This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1201
8 mai 2015
SOMMAIRE
3A Alternative Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57616
Aberdeen Infrastructure Capital Holdings
(France) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57604
Air Newco 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57618
Banco Popolare Luxembourg S.A. . . . . . . . 57603
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV -
SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57604
Cellmedia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57608
DPI S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57605
Edinburgh Car Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . 57605
Eurocash-Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57617
Fermat 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57626
Fiduciaire Bovy Luxembourg S.à.r.l. . . . . . 57604
Frasia Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57604
I-Invest Management S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . 57641
II PM Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57612
ING International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57606
IRK Secure Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57602
ITACA Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57603
LB-Re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57603
LBREM NW Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . 57608
Managed Funds Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . 57609
Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57629
MariTeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57648
Nordea Life & Pensions S.A. . . . . . . . . . . . . 57646
Nouvel Horizon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . 57605
Partners Group Real Estate Secondary
2009 (Euro) S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . 57645
PC EU Feeder V SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57647
Pharaoh Corporation S.A. . . . . . . . . . . . . . . 57630
Piscadera Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . 57602
Pyramus S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57613
Reload Master S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57621
Rigond Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57617
Sankaty European Holdings S.à r.l. . . . . . . 57644
Sogeho International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . 57603
Storm Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57613
Tanin Export S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57643
Tannenberg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57647
Timbercreek Real Estate Fund . . . . . . . . . . 57619
Transports Neves S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . 57602
Treveria Seven S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57609
Vauban Management S.C. . . . . . . . . . . . . . . 57602
VDC Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57615
Venusia Real Estate Investment S.A. . . . . . 57605
57601
Vauban Management S.C., Société Civile.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 48, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg E 3.228.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015046151/9.
(150052062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
IRK Secure Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 156.405.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 5 mars 2015 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10, Antoine Jans à L-1820 Luxembourg
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015046489/11.
(150053277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Transports Neves S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3313 Bergem, 95, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 179.533.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015046121/14.
(150052680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Piscadera Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 75.904.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
de la société qui se tiendra extraordinairement le mardi <i>19 mai 2015i> à 16.00 hrs au siège de la société à L-9053
Ettelbruck, 45, avenue J.F. Kennedy, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et discussion des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice
clôturé au 31.12.2013;
2. Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 31.12.2013;
3. Affectation du résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Décision à prendre sur base de l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915;
6. Elections statutaires;
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015063534/561/20.
57602
Banco Popolare Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 47.796.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015046887/9.
(150054335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
LB-Re, Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 24.011.
Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société LB-Re
i>Aon Insurance Managers (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2015046523/11.
(150052956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
ITACA Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 161.507.
Il résulte d'un acte sous seing privé du 24 mars 2015 que:
- IMI INVESTIMENTI S.p.a., une société constituée sous les lois italiennes, ayant son siège social au 2 Via Zamboni,
40126 Bologne, Italie; a cédé 11.556 parts sociales de classe D et 11.640.579 parts sociales de classe D2 à la société
MANZONI S.R.L., ayant son siège social au 12, Via Monte Di Pieta, 20121 Milan, Italie.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
<i>Pour: ITACA FINANCE S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015046492/14.
(150052913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Sogeho International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 69.904.
Messieurs les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>19 mai 2015i> à 11.00 heures au siège social 23, rue Aldringen - L-1118 Luxembourg, avec l'ordre du
jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du conseil d'administration pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.
2. Rapport du réviseur pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.
3. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.
4. Affectation du résultat de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.
5. Décharge à accorder aux membres du conseil d'administration et au réviseur pour leur mandat relatif de l'exercice
clôturé au 31 décembre 2014.
6. Démissions et nomination d'un nouveau administrateur.
7. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015058701/20.
57603
Fiduciaire Bovy Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1128 Luxembourg, 37, Val Saint André.
R.C.S. Luxembourg B 40.327.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015045778/9.
(150052139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Aberdeen Infrastructure Capital Holdings (France) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 123.078.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 mars 2015.
Référence de publication: 2015046209/10.
(150053335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Frasia Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 21, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 175.327.
Les statuts coordonnés au 10/03/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/03/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015045766/12.
(150052214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'In-
vestissement Spécialisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 132.403.
The board of directors is pleased to convene the shareholders of BOURNE PARK CAPITAL (LUX) S.A., SICAV-SIF
to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the SICAV-SIF on <i>19 May 2015i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the board of directors and of the approved statutory auditor
2. Approval of the financial statements as at 31 December 2014
3. Allocation of results
4. Discharge to the directors
5. Renewal of the mandate of the approved statutory auditor
6. Statutory elections
7. Remuneration of the directors
The shareholders are advised that no quorum for the statutory general meeting is required and that decisions will be
taken by simple majority of the votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV-SIF. Shareholders,
who wish to attend the annual general meeting, are requested to inform the Board of Directors (Fax nr: +352 49 924
2501 - ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days prior to the annual general meeting.
Référence de publication: 2015062668/755/23.
57604
DPI S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.266.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044371/9.
(150050521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Nouvel Horizon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1475 Luxembourg, 11, rue du Saint Esprit.
R.C.S. Luxembourg B 33.995.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015044604/10.
(150050825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Edinburgh Car Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.688.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015044373/12.
(150050988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
VRE, Venusia Real Estate Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.585.
Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être
exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre,
le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour
le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.
Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Qui se tiendra au siège social en date du <i>18 mai 2015i> à 10 heures avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte des résultats.
2. Discussion du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions
exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C., le cas échéant.
6. Modification au sein du Conseil d'Administration.
7. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015062679/1004/23.
57605
ING International, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 47.586.
Since the quorum required by the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended, was not reached
at the previous Extraordinary General Meeting of the Company held on 17 April 2015 at 11 a.m., notice is hereby given
that a
SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
will be held before notary at the registered office of the Company on <i>27 May 2015i> at 3 p.m. Luxembourg time (the
“Meeting”) with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. As from 1 June 2015 (hereinafter the “Effective Date”), change of the name of the Company from “ING Interna-
tional” to “NN (L) International” in order to align with the rebranding of the other ING investment entities.
2. As from the Effective Date, subsequent amendment to Article 1 - “Name and Form” of the articles of association
of the Company (hereinafter the “Articles”) so as to reflect the new name of the Company. Article 1 shall therefore
read as follows:
“There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a public
limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital (“société
d'investissement à capital variable”) under the name of NN (L) International (hereinafter the “Company”). The
Company shall be governed by the Law of seventeenth of December two thousand and ten relating to undertakings
for collective investments, and by these articles of association.”
3. As from the Effective Date, amendment to Article 3 - “Purpose”, Article 5 - “Share capital”, Article 20 - “Powers
of the Board of Directors”, Article 26 - “termination or amalgamation of sub-funds or share classes” and Article
31 - “Applicable law”, with the updated references to the Luxembourg law of 17 December 2010.
4. As from the Effective Date, amendment to Article 5 - “Share Capital” so as to update it with provisions of Lux-
embourg Law of 10 December 2010 regarding the cross-investments between sub-funds of the same Company.
5. As from the Effective Date, Article 8 - “Form of Shares” of the Articles shall be entirely reworded so as to comply
with Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of shares and units
in bearer form (the “Law”). Consequently, Article 8 shall read as follows:
“Article 8: Form of Shares. The board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer and/
or registered shares, to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents of
the Company.
The board of directors may decide, at its entire discretion, whether or not to issue certificates in respect of
registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected
to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.
The share certificates, if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share
certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.
All registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders, which shall be kept in
compliance with applicable laws.
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares.
Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested
under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will
also be entered into the register of shareholders.
At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or
immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.
All bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept by the bearer
shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of the Company.
Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer share register. Upon written request
by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares regis-
tered for such shareholder in the bearer share register.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney
to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the
exercise of all rights attached to such shares.
57606
The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata
basis.”
6. As from the Effective Date, amendment to Article 9 - “Classes of Shares” of the Articles so as to replace the third
paragraph by the following:
“Within each class, there may be
- one or more capitalization share-types; and
- one or more distribution share-types.”
7. As from the Effective Date, to Article 11 - “Redemption” shall be updated with regards to the wording on the
suspension of orders as well as to re-arrange the allocation of costs in case of redemptions in kind. Consequently,
the last sentence of Article 11 will be replaced as follows:
“Any costs resulting from such a redemption in kind are supported by the redeeming shareholders.”
8. As from the Effective Date, amendment to Article 12 - “Conversion” so as to rephrase the wording on the sus-
pension of orders.
9. As from the Effective Date, amendment to Article 13 - “Limitations on the Ownership of Shares” so as to delete
reference to physical bearer shares under first indent of letter b), to replace third indent of letter b) and letter c)
as follows:
b) 3. “payment of the purchase price will be made to the owner of such shares and will be deposited by the Company
with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon
surrender, where applicable, of the share certificate or certificates) representing the shares specified in such notice
together with the unmatured coupons. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares
specified in such purchase notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the owners thereof
to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender, where applicable, of
the share certificate(s) and the unmatured coupons as aforesaid;
c) “refuse, during any Shareholders' Meeting, the right to vote of any person who is not authorised to hold shares
in the Company.
In particular, the Shares of the Company may not be offered or sold within the United States or to or for the
account of any US Person as defined in Rule 902 of Regulation S under the Securities Act.
Applicants may be required to declare that they are not US Persons and that they are neither acquiring Shares on
behalf of US Persons nor acquiring Shares with the intent to sell to US Persons.
The Shares of the Company may, however, be offered to investors that qualify as US Persons as defined under the
Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), under the condition that such investors do not qualify as US
Persons according to Rule 902 of Regulation S under the Securities Act”.
10. As from the Effective Date, amendment to Article 16 - “Suspension of calculation of the net asset value” so as to
update the wording and to include new indents 8 and 9 as additional cases for the suspension of the calculation, as
follows:
8. “In case of a merger of a Sub-Funds with another Sub-Fund of the Company or another UCITS (or a Sub-Fund
thereof), provided such suspension is in the interest of the shareholders;
9. In case of a feeder Sub-Fund of the Company, if the net asset calculation of the master Sub-Fund or the master
UCITS is suspended”.
11. As from the Effective Date, amendment to article 20 - “Powers of the Board of Directors” so as to to update the
wording and to include new indents 10 and 11 as additional investment possibilities and in accordance with the
provisions of UCITS IV Directive:
10. “A Sub-Fund which can, under the conditions provided for in the law of seventeenth December two thousand
and ten, invest in the shares issued by one or several Sub-Funds of the Company.
11. A Sub-Fund which can be constituted as a feeder Sub-Fund in a master UCITS or a master Sub-Fund of such
UCITS”.
12. As from the Effective Date, amendment of last paragraph of Article 23 - “Conflicts of interest” so as to align it with
the conflicts of interest policy applicable to the Company and as follows:
“If any director, executive or authorised representative has a personal interest in some part of the Company's
business, or is in a situation which leads or may lead to a conflict of interest entailing a material risk of damage to
the interests of the Company and/or its clients, he shall inform the board of directors thereof. He shall not deliberate
or take part in voting on this matter. The matter shall be reported to the next shareholders' meeting.”
13. As from the Effective Date, removal of Article 24 - “Indemnification” from the Articles.
14. As from the Effective Date, subsequent renumbering of articles 25 to 33 of the Articles and update of the relevant
cross-references in the Articles.
15. As from the Effective Date, amendment of /newly numbered) Article 24 - “General Meeting of the Company” and
Article 26 - “Termination and amalgamation of sub-funds or classes of shares” so as to rephrase the Articles.
16. As from the Effective Date, amendment to the former Article 29 - “Distributions” (to be renumbered 28) of the
Articles so as to comply with the Law. The third paragraph shall now read as follows:
57607
“Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses
in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of immobilised bearer shares shall be made to
the bearer shares depositary for the benefit of the shareholder, as further specified in the sales documents of the
Company.”
The Meeting will validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the Com-
pany present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the
votes cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked
to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department
of ING Investment Management Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 20 May 2015
5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.
<i>The Board of Directors of the Company.i>
Référence de publication: 2015058717/755/132.
Cellmedia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 75.417.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2014 que le professionnel du
secteur financier, la société INTERCORP S.A., 23, rue Beaumont, -1219 Luxembourg, a été nommée dépositaire des
titres au porteur émis par la société.
Luxembourg, le 31 décembre 2014.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2015044326/15.
(150050978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
LBREM NW Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 119.744.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises en date du 12 mars 2015i>
<i>(«l'Associé Unique»)i>
L'associé unique accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant que gérant de catégorie A de la Société
avec effet au 1.4 décembre 2014.
Le Conseil, de Gérance de la Société se compose désormais de la façon suivante:
<i>Gérants de catégorie A:i>
- Hinnerk Koch, avec adresse professionnelle au, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Laurent Belik, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
<i>Gérants de catégorie B:i>
- Yon Ku Cho, avec adresse professionnelle au 27, Beekman Terrace, USA-07901 Summit, New jersey;
- Ronald Bonneau, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245
El Segundo, Californie;
- Aaron Giovara, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245 El
Segundo, Californie.
A Luxembourg, le 13 Mars 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015042442/26.
(150048620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
57608
Treveria Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.322.525,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 125.033.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises pas l'associé unique de la Société du 20 mars 2015 que:
- La démission de M. Jérôme TIBESAR, gérant de la Société, avec effet immédiat, a été acceptée;
- La personne suivante a été nommée gérant de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée:
* Mme Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Référence de publication: 2015046679/16.
(150053148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 81.144.
The shareholders of the Company are invited to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(hereinafter “the Meeting”) to be held on <i>19 May 2015i> at 11:30 CET at the registered office of the Company with the
following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Approval of the common draft terms of Merger drawn up in accordance with Article 261 (1) and (2) of the 1915
Law and to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 18 April 2015, in accordance
with Article 262 (1) of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”).
2. Approval of the explanatory memorandum to the proposal for the Merger of the Company into NN (L) drawn up
in accordance with Article 265 of the 1915 Law explaining the common draft terms of Merger and setting out the
legal and economic grounds for them.
3. Acknowledgement of the accomplishment of all then applicable formalities prescribed in Article 267 (1) a), b) and
e) of the 1915 Law in relation to the right of each shareholder to inspect the Merger documentation at the registered
office of the Company at least one month before the date of the extraordinary general meeting of the shareholders
of the Company.
4. Approval of the examination carried out and the report drawn up by the independent auditor in accordance with
Article 266 (1) of the 1915 Law.
5. Approval of the merger by absorption between Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 5, a sub-fund of the
Company (the “Contributing Sub-Fund”) into NN (L) First Class Multi Asset (the “Receiving Sub-Fund”), a sub-
fund of NN (L), a Société d'Investissement à Capital Variable, with registered office at 3, rue Jean Piret, L-2350
Luxembourg, and registered with the Luxembourg register of companies and commerce under number B 44.873
(“NN (L)”) as the absorbing company, and allocation of the merger costs to the Alternative Investment Manager.
6. Approval of the merger by absorption between Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 10 a sub-fund of the
Company (the “Contributing Sub-Fund”) into NN (L) First Class Multi Asset (the “Receiving Sub-Fund”), a sub-
fund of NN (L), and allocation of the merger costs to the Alternative Investment Manager.
The absorption of the Company's Sub-Funds into the Receiving Sub-Fund shall be done as described below:
Contributing Sub-Funds and share classes
Receiving Sub-Fund and share classes
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 5
NN (L) First Class Multi Asset
A CAP EUR
LU0290137057
P CAP EUR
LU0809674541
A CAP USD (Hedged)
LU0290136240
P CAP USD (Hedged)
LU1175220752
I CAP EUR
LU0290136083
I CAP EUR
LU0809674202
I CAP USD (Hedged)
LU0290135788
I CAP USD (Hedged)
LU1175220679
57609
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 10
NN (L) First Class Multi Asset
A CAP EUR
LU0290137560
P CAP EUR
LU0809674541
A CAP USD (Hedged)
LU0290136836
P CAP USD (Hedged)
LU1175220752
I CAP EUR
LU0290137305
I CAP EUR
LU0809674202
I CAP USD (Hedged)
LU0290136596
I CAP USD (Hedged)
LU1175220679
With effect on 19 May, 2015 or as soon as possible thereafter, the applicable exchange ratio between the shares
of the Contributing Sub-Funds and the new shares of the Receiving Sub-Fund shall be determined on the basis of
the Net Asset Value of the Contributing Sub-Funds/share classes and the Receiving Sub-Fund, as outlined in the
merger documentation.
7. Dissolution without liquidation of the Contributing Sub-Funds and the Company and subsequent cancellation of all
the outstanding shares inscribed in the books of Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. at the date of the
Merger which will be replaced by shares of the respective sub-fund of NN (L) First Class Multi Asset in accordance
with Article 274 (1) of the 1915 Law.
8. Discharge of the members of the Board of Directors of the Company and determination of the place where the
books and records of the Company will be kept for a period of five years.
9. Effectiveness of the merger as at 19 May 2015 or at any other date thereafter (hereinafter the “Effective Date”).
The cost associated with the Merger will be supported by the Alternative Investment Fund Manager.
The reason for Merger is that the overall product streamlining of NN Investment Partners Group pertaining its
worldwide distribution of investment funds and the higher assets resulting from a merger would (a) optimize the product
offering and generate economy of scale and (b) lower the costs borne by the shareholders with more efficient usage of
fund management resources; therefore the merger of the Contributing Sub-Funds with the Receiving Sub-Fund would
benefit to the shareholders of the Contributing Sub-Funds.
On 19 May, 2015, the Effective Date, the shareholders of the Contributing Sub-Funds not wishing to redeem their
shares will receive new shares, free of charge, in the respective Receiving Sub-Fund. Exchange ratio will be calculated on
basis of the net asset value per share of the Contributing Sub-Fund set in relation to the net asset value of the Receiving
Sub-Fund on the Effective Date, upon validation of an independent auditor.
Following the contribution of all assets and liabilities and the share exchange mentioned above on the Effective Date,
the Contributing Sub-Funds and the Company will be dissolved without liquidation as of the Effective Date.
Shareholders of the Contributing Sub-Funds should note that the investment policies of the Contributing Sub-Funds
differ from the investment policy of the Receiving Sub-Fund:
<i>Objective and Investment Policy Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 5 and Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 10:i>
The objective of the Contributing Sub-Funds is to obtain long-term absolute performance by investing in a diversified
portfolio composed primarily of any type of fixed-income securities and/or money market instruments and/or equities
and/or any type of traditional or alternative funds or funds of funds, and on an ancillary basis in cash.
Fixed-income securities primarily include (but are not limited to) bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds,
mortgage pass-through securities, collateralised mortgage obligations, mortgage-backed securities, variable-rate bonds
and asset-backed securities.
If it invests in other target investment funds or funds of funds, the Sub-Funds must ensure that the securities portfolios
of those target investment funds or funds of funds have the appropriate liquidity features to enable the Sub-Funds to meet
their redemption obligations to their investors.
Investors' attention is drawn to the fact that if it invests in other target investment funds, additional fees may be charged
because fees applicable to those target investment funds may be added to the usual fees applicable to the Sub-Funds.
<i>Objective and Investment Policy of NN (L) First Class Multi Asset:i>
The Receiving Sub-Fund aims to deliver attractive returns under all market circumstances by investing in assets classes
as defined in the prospectus. At all times the sub-fund will mainly invest in a combination of investment grade debt, cash
equivalent, and short term debt. The Sub-Fund may also invest, on an ancillary basis, in other asset classes as defined
below (with maximum 20% of the sub-fund's net assets in Asset-Backed and mortgage backed securities).
Eligible investments
The Sub-Fund may invest in transferable securities (including warrants on transferable securities up to a maximum of
10% of the Sub-Fund's net assets), bonds, equities, money market instruments, 144A securities, units of UCITS and other
UCIs and deposits, as described in the full prospectus in Part III, Chapter III “Investment Restrictions”, Section A “Eligible
investments”. Investments in asset-back securities will however be limited to 20% and investments in UCITS and UCIs
may not exceed a total of 10% of the net assets.
57610
Where the Sub-Fund invests in warrants on transferable securities, the Net Asset Value may fluctuate more than if
the Sub-Fund were invested in the underlying assets because of the higher volatility of the value of the warrant.
The Sub-Fund may be exposed to various exchange risks linked to investments in securities denominated in currencies
other than that of the Sub-Fund or in derivative instruments with underlying exchange rates or currencies.
With a view to achieving the investment objectives, the Sub-Fund may also use derivative financial instruments including,
but not limited to, the following:
- options and futures on transferable securities or money market instruments
- index futures and options
- interest rate swaps, futures and options
- performance swaps
- credit default swaps
- forward currency contracts and currency options.
The risks linked to this use of derivative financial instruments for purposes other than hedging are described in the full
prospectus in Part III, Chapter II “Risks linked to the investment universe: detailed description”.
The table below is a comparison of keys features of the merging sub-funds:
Contributing Sub-Funds
Receiving Sub-Fund
Reference Currency
EUR
EUR
Subscription Charge
Class A: Maximum 5%
Class I: Maximum 5%
Class I: Maximum 2%
Class P: Maximum 3%
Redemption Charge
Nil
Nil
Conversion Charge
Nil
Class I: Nil
Class P: 3% in Belgium
and 1% elsewhere
Management Fee
Class A: Maximum 1%
Class I: Maximum 1%
Class I: Maximum 0.60%
Class P: Maximum 1%
Ongoing Charges
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX
5:
Class A CAP EUR: 1.62%
Class A CAP USD (Hedged): 1.56%
Class I CAP EUR: 1.61%
Class I CAP USD (Hedged): 1.61%
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX
10:
Class A CAP EUR: 1.74%
Class A CAP USD (Hedged): 1.75%
Class I CAP EUR: 1.71 %
Class I CAP USD (Hedged): inactive
Class I CAP EUR: 0.81 %
Class I CAP USD (Hedged): 0.76%
Class P CAP EUR: 1.35%
Class P CAP USD: (Hedged): 1.30%
Fixed Service Fee
Nil
Class I: 0.15%
Class P: 0.25%
Performance Fee
Class A: 10%
Class I: 10%
10% of the outperformance.
The hurdle rates are the US 3-month
treasury bill for shares denominated in
USD and the German 3-month treasury
bill for shares denominated in EUR.
Nil
Minimum Investment Amount
Class A: Nil
Class I: 250,000
Class I: EUR 250,000, which may be
spread over all the ING (L) sub-funds
Class P: Nil
Minimum Holding Amount
Class A: Nil
Class I: 250,000
Class I: EUR 250,000, which may be
spread over all the ING (L) sub-funds
Class P: Nil
Management Company
NN Investment Partners Luxembourg
S.A.
NN Investment Partners Luxembourg
S.A.
Investment Manager
NNIP Asset Management B.V
NNIP Asset Management B.V
Central Administration
NN Investment Partners Luxembourg
S.A.
NN Investment Partners Luxembourg
S.A.
57611
Custodian
Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A.
Brown Brothers Harriman (Luxem-
bourg) S.C.A.
Auditor
Ernst & Young S.A.
Ernst & Young S.A.
Shareholders of the Contributing Sub-Funds should note that there may be a possible dilution in performance caused
by the merger.
Additionally, shareholders of the Contributing Sub-Funds/Share-Classes should note that the financial year and the
date of the ordinary general meeting of NN (L), the absorbing Fund differ from the financial year and the date of the
ordinary general meeting of the Company. The date of the ordinary general meeting financial year of the absorbing Fund
is the fourth Thursday of January at 14:00 CET and its financial year is from 1st October to 30 September of the following
year.
The annual and semi-annual reports including the Receiving Sub-Fund are available to shareholders, respectively four
months and two months after the end of the preceding financial period, respectively, on www.nnip.com website or at
the registered office of the Company. Copies of the auditor's merger report and of the depositary's statement, can be
obtained free of charge upon request.
The “Key Investor Information Documents” for the share classes of the Receiving Sub-Fund are available on
www.nnip.com website or at the registered office of the Company.
Shareholders are encouraged to seek advice of a tax expert in their respective countries regarding the potential
taxation impact resulting from the Merger.
The issue of Shares in the Contributing Sub-Funds will be suspended with effect as of 12 May, 2015. Accordingly,
subscription and conversion applications in the Contributing Sub-Funds can be submitted up to the last cut-off at 3.30
p.m. Luxembourg time on 1 May, 2015.
Shareholders will be able to redeem their shares free of charges in the Contributing Sub-Funds until 12 May, 2015, i.e.
redemption applications can be submitted up to the last cut-off at 3.30 p.m. Luxembourg time on 1 May 2015. Any
redemption applications in the Contributing Sub-Funds received after 3.30 p.m. Luxembourg time on 1 May 2015 will not
be processed and any such redemption requests should be submitted to the Receiving Sub-Fund on or after 20 May 2015.
The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is
present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes
cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.
If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened on/or around 30 June 2015.
The second Extraordinary General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the
issued share capital of the Company present or represented.
Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case shareholders cannot attend the Meeting, they are
kindly asked to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal
Department of NN Investment Partners Luxembourg S.A., at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, not later than 18
May 2015 at 05.00 p.m. Luxembourg time by fax (fax number: (+352) 26 19 68 40), followed by the original by regular
mail.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015053370/755/203.
II PM Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 659, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 143.539.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 juin 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue en date du 19 juin 2014 que:
Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance, l'Assemblée a décidé d'appeler aux fonctions de réviseur
d'entreprises et de réélire la personne suivante:
- La société de droit luxembourgeois ERNST & YOUNG, établie et ayant son siège social à L-5365 MUNSBACH, 7,
Parc s'Activité Sydrall, et immatriculée auprès du R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 47771.
Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25.03.2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015046475/18.
(150053192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57612
Pyramus S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 44.769.999,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 137.398.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers que Monsieur Magnus Mattsson a démissionné de son mandat de Gérant de
Classe B de la Société avec effet au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015046603/13.
(150052900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
Storm Fund, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 173.699.
The board of directors herewith invites shareholders, in accordance with the Company's Articles of Association (the
“Articles”), to the
2
nd
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to take place on <i> 27 i>
<i>thi>
<i> May 2015 i> at 14:00 a.m. CET, at the offices of Oppenheim Asset Management
Services S.à r.l. in Luxembourg.
Capitalised terms not defined herein have the meaning assigned to them in the Prospectus of the Company.
The agenda is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendments of Articles of the Company
A. FORMALITIES
The term “Custodian” was replaced by the term “Depositary”
B. In Title II - SHARE CAPITAL - SHARES - NET ASSET VALUE
Art. 11. - Calculation of the Net Asset Value per Share
- sub-para 1 has to be read as follows
“The Net Asset Value per Share of each Class and/or Sub-Fund shall be calculated by the Central Administrative
Agent under the ultimate responsibility of the Board of Directors and the AIFM upon the frequency set forth in
the Appendices and at least once a year (each a “Valuation Day”) in accordance with Luxembourg law and Lux-
embourg General Accepted Accounting Principles (Lux GAAP).”
- In Article 11, the section titled “The value of such assets shall be determined as follows” was changed as follows:
No (1) has to be read as follows:
“The value of any cash in hand or on deposit, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses,
cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received shall be deemed to be the full
amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof
shall be arrived at after making such discount as the Board in cooperation with the AIFM may consider appropriate
in such case to reflect the true value thereof.”
No (3) has to be read as follows:
“If a security is not traded or admitted on any official stock exchange or any Regulated Market, or in the case of
securities so traded or admitted the last available settlement price or the last available closing price of which does
not reflect their true value, the Board in cooperation with the AIFM is required to proceed on the basis of their
expected sales price, which shall be valued with prudence and in good faith.”
No (4) has to be read as follows:
“The liquidating value of futures, forward or options contracts not dealt in on a stock exchange or another regulated
market shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the Board of
Directors and the AIFM, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value
of futures, forward or options contracts dealt in on a stock exchange or another regulated markets shall be based
upon the last available settlement prices of these contracts on such regulated markets on which the particular
futures, forward or options contracts are dealt in by the SICAV; provided that if a futures, forward or options
contract could not be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for
determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors and the AIFM may
deem fair and reasonable;”
57613
No (5) has to be read as follows:
“Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates
curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference
to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap
agreement shall be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to
procedures established by the Board of Directors and the AIFM;”
No (8) has to be read as follows:
“All other securities and other assets, including debt securities and securities for which no market quotation is
available, are valued on the basis of dealer-supplied quotations or by a pricing service approved by the Board of
Directors and the AIFM or, to the extent such prices are not deemed to be representative of market values, such
securities and other assets shall be valued at fair value as determined in good faith pursuant to procedures estab-
lished by the Board of Directors and the AIFM. Money market instruments held by the SICAV will be valued using
an amortised cost method for all investments with a known short-term maturity date. This involves valuing an
investment at its cost and thereafter assuming a constant amortisation to maturity of any discount or premium,
regardless of the impact of fluctuating interest rates on the market value of the investments. While this method
provides certainty in valuation, it may result in periods during which value, as determined by amortised cost, is
higher or lower than the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The Board of Directors
and the AIFM will continually assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure
that the SICAV's investments will be valued at their fair value as determined in good faith by the Board of Directors
and the AIFM. If the Board of Directors and the AIFM believe that a deviation from the amortised cost method
may result in material dilution or other unfair results to Shareholders, the Board of Directors in cooperation with
the AIFM shall take such corrective action, if any, as it deems appropriate to eliminate or reduce, to the extent
reasonably practicable, the dilution or unfair results.”
- The sub para that follows No (8) has to be read as follows:
“The Board of Directors, in cooperation with the AIFM, may permit some other method of valuation to be used
if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset or liability of the SICAV and/or its Sub-
Funds in compliance with Luxembourg laws. This method will then be applied in a consistent way. The Central
Administrative Agent can rely on such deviations as approved by the SICAV and the AIFM for the purpose of the
Net Asset Value calculation.”
Art. 12. - Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of the Issue,
the Redemption and the Conversion of Shares
- Sub para 2 1
st
sentence has to be read as follows:
“The Company in cooperation with the AIFM may suspend the determination of the Net Asset Value per Share of
any particular Sub-Fund and/or Class and the issue, redemption and conversion of its Shares to and from its Share-
holders in the following cases: ...”
Art. 19. - Alternative Investment Fund Manager
Article 19 was added and has to be read as follows:
“The Board appoints an external AIFM within the meaning of the 2013 Law.
The AIFM may delegate certain administrative, distribution and investment management functions to specialised
service providers in consideration of the provisions of the 2013 Law.”
Art. 20. - Investment Manager and Investment Advisers
Article 20 has to be read as follows:
“With the consent of the Board of Directors the AIFM may appoint an Investment Manager to manage, under its
overall control and responsibility, the securities portfolio of the various Sub-Funds of the Company.
With the consent of the Board of Directors, the AIFM may furthermore appoint an Investment Advisor with the
responsibility to prepare the purchase and sale of any eligible investments for the Company and otherwise advise
the Company with respect to asset management.
The powers and duties of the Investment Manager and the Investment Advisor as well as their remuneration will
be described in an investment management agreement and/or investment advisory agreement to be entered into
by the AIFM and the Investment Manager and/or Investment Advisor (as the case may be).”
Art. 21. - Conflict of Interest
“Any kind of conflict of interest is to be fully disclosed to the Board of Directors. The Company will enter into all
transactions on an arm's length basis.
The Directors of the Company, the directors of the AIFM, the Directors of the Investment Manager and any affiliate
thereof, its members and staff may engage in various business activities other than the Company's, the AIFM's and/
or the Investment Manager's business, including providing consulting and other services (including, without limita-
tion, serving as director) to a variety of partnerships, corporations and other entities, not excluding those in which
the Company invests. However, the Directors of the Company, the directors of the AIFM, the directors of the
Investment Manager and its members will devote the time and effort necessary and appropriate to the business of
the Company. The Directors of the Company, the directors of the AIFM, the directors of the Investment Manager
and any affiliate thereof, its members and staff may also invest and trade for their own accounts. Because the
Directors of the Company, the directors of the AIFM and the directors of the Investment Manager, the members
57614
and affiliates of the Investment Manager can have other accounts managed by them, the interests of the Company
and other accounts, in the selection, negotiation and administration of investments, may conflict. Although it is
aimed to avoid such conflicts of interest, the Directors, the AIFM, the Investment Manager and its members will
attempt to resolve all nonetheless arising conflicts in a manner that is deemed equitable to all parties under the
given circumstances.
No contract or other transaction between the Company and any other company or firm, including the AIFM, shall
be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of, such other company or firm. Any Director or officer of the
Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall
contract or otherwise engage in business, including the AIFM, shall not, by reason of such affiliation with such other
company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
Any Director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with
that of the Company shall advise the Board of Directors thereof and cause a record of his statement to be included
in the minutes of the meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting,
before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the
Directors may have had an interest conflicting with that of the company.
The provisions of the preceding paragraph are not applicable when the decisions of the Board of Directors of the
Company or of the Director concern day-to-day operations engaged in normal conditions.”
Art. 23. - Auditors
The 2
nd
sentence shall be read as follows:
“The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2007 Law and the 2013 Law.”
C. In Title V - FINAL PROVISIONS
Art. 29. - Depositary
Sub para 2 shall be read as follows:
“The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law and the 2013 Law.”
Sub para 3 shall be read as follows:
“Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity
and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in the 2013 Law, the Depositary
may discharge itself of liability, provided the conditions of such discharge as set out in the 2013 Law are fulfilled.”
Quorum and Majority
Resolutions on the agenda of the extraordinary general meeting of Shareholders will require a quorum of fifty percent
(50%) of the shares issued and outstanding. Should the quorum of fifty percent (50%) of the shares issued and outstanding
not be met at the extraordinary general meeting of Shareholders, a second meeting, which will validly deliberate irre-
spective of the number of shares represented, will be reconvened in due course with the same agenda.
The changes will only enter into force, and the documents, notably the Prospectus, will be available, only if all the
resolutions have been validly taken, either at the initial extraordinary general meeting or the second extraordinary general
meeting of Shareholders.
Representation of the Shareholders:
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them.
A proxy need not be a member of the Company. If you do not wish to attend the Extraordinary General Meeting of
Shareholders would you please sign the special proxy form and return it to us until the 25
th
May 2015. Otherwise, the
votes will not be taken into account by the company. Please fax the forms beforehand to (00352) 22 15 22 - 500 or send
it by e-mail: d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu.
By order of the Board,
<i>Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015057165/755/153.
VDC Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.685.
Statuts coordonnes déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 25 mars 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015046719/11.
(150053410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57615
3A Alternative Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 88.843.
NOTICE OF MEETING OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
Notice is hereby given to the Shareholders of 3A ALTERNATIVE FUNDS (the "Company") that the
ANNUAL GENERAL MEETING
(the "Annual Meeting") which will be held at its registered office set above at 2.00 p.m. on Monday <i>18 May 2015i> , or
at any adjournment thereof, to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the Report of the Alternative Investment Fund Manager for the accounting year ended 31 December
2014
2. Presentation of the Report of the Auditors for the accounting year ended 31 December 2014
3. Approval of the Audited Annual Report for the accounting year ended 31 December 2014
4. Discharge of the Board of Directors in respect of their duties carried out for the accounting year ended 31 De-
cember 2014
5. Election of Monsieur Alexandre Pierron as Director, to serve as such until the Annual General Meeting to approve
the Audited Annual Report for the accounting year ending on 31 December 2015
6. Re-election of Messrs Massimo Paolo Gentili, Xavier Guillon, Jean Keller and Jérôme Wigny as Directors, to serve
as such until the Annual General Meeting to approve the Audited Annual Report for the accounting year ending
on 31 December 2015
7. Re-election of PricewaterhouseCoopers, Société coopérative as Auditor of the Company until the Annual General
Meeting to approve the Audited Annual Report for the accounting year ending on 31 December 2015
8. Allocation of the results for the accounting year ended 31 December 2014
9. Approval of Directors' fees
10. Consideration of such other business as may properly come before the meeting
***
Notice is also hereby given to the Shareholders of the Company that the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the "Extraordinary Meeting") which will follow the Annual Meeting on <i>18 May 2015i> , or any adjournment thereof, at
3.45 p.m. to deliberate and vote on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Amendment of the name of the Company from "3A ALTERNATIVE FUNDS" into "OYSTER ALTERNATIVE"
2. General restatement of the articles of Incorporation of the Company to (i) bring the Articles in line with the
requirements of the 2013 Law, (ii) proceed with a replacement throughout the Articles of the reference to the
Luxembourg law of 20 December 2002 on undertakings for collective investment by the Luxembourg law of 17
December 2010 on undertakings for collective investment, and (iii) to proceed with a general update of the Articles
in order for them to reflect the currently admitted standards.
Voting
General Meeting: No quorum will be required in relation to the Annual Meeting and the resolutions will be adopted
if approved by a majority of the votes cast.
Extraordinary Meeting: A quorum of 50% of the outstanding shares of the Company at the date of the Extraordinary
Meeting will be required and the resolutions will be adopted if approved by a two thirds majority of the votes cast.
Voting Arrangements
Shareholders may vote in person or by proxy who need not be another shareholder in the Company. Proxy Cards
can be obtained from the registered office of the Company. To be valid, a Proxy Card must be deposited at the registered
office of 3A ALTERNATIVE FUNDS at HSBC Bank plc, Luxembourg branch, Attention: Registration Team, 16 Boulevard
d'Avranches, L-1160 Luxembourg, Fax No: (352) 27025 380 no later than 15 May 2015.
A copy of the Audited Annual Report for the accounting year ended 31 December 2014, the draft prospectus and
consolidated Articles, including among others the changes described above are available free of charge at the registered
office of the Company.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015062667/41/54.
57616
Rigond Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 146.558.
En date du 22 mars 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
- Démission de Nazem Fawwaz Nazem Al Kudsi de son poste de gérant de classe A avec effet au 13 mars 2015;
- Election de Nada Najem Aldeen Abdulla Hamoudi, née le 17 décembre 1967 à Baghdad, Irak, et résidant profes-
sionnellement au 1506, Al Siri Tower, Hamdan Street, étage 15, Abu Dhabi, Emirats Arabes Unis au poste gérant de classe
A avec effet au 13 mars 2015, et pour une période indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015047329/17.
(150054184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.
Eurocash-Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 45.631.
Gemäß Art. 22 ff. der Satzung ergeht hiermit die Einladung zur
ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>28. Mai 2015 ui> m 14:30 Uhr am Gesellschaftssitz in der 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115
Luxemburg mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung i> :
I. Änderungen der Satzung
Insbesondere werden die folgenden relevanten Änderungen der Satzung vorgenommen. Die vollständige Neufassung
der Satzung ist am Sitz der Gesellschaft erhältlich.
1. Formalia:
Die Referenzen zum Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen sowie Recht-
schreibung werden aktualisiert.
2. Artikel 4, Abs. 2 wird um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:
„Die Gesellschaft kann im weitesten Sinne und im Rahmen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 und des Gesetzes
vom 12. Juli 2013 über Verwalter alternativer Investmentfonds („Gesetz vom 12. Juli 2013“) alle Maßnahmen er-
greifen und alle Geschäfte durchführen, die sie im Rahmen der Erfüllung und Entwicklung ihres Gesellschaftszweckes
für angebracht erachtet.“
3. In Artikel 11 Abschnitt II (Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft beinhalten) wird Unterabsatz 6 Satz 2 um folgenden
Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:
„Bei der Bestimmung des Betrages solcher Verbindlichkeiten wird die Gesellschaft sämtliche von der Gesellschaft
zu zahlenden Kosten berücksichtigen, einschließlich Gründungskosten, Gebühren an den alternativen Investment-
fonds Manager („AIFM“), den Investment Manager und Anlageberater, Gebühren für die Buchführung, Gebühren
an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken sowie....“
4. Artikel 17 werden Satz 2 und Satz 3 um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt gefasst:
„Der Verwaltungsrat kann auch Einzelvollmachten durch notarielle oder privatschriftliche Urkunde übertragen.
Der Verwaltungsrat ernennt einen externen AIFM im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013. Der AIFM ist berechtigt,
die Erfüllung seiner Aufgaben an Dritte zu übertragen, solange diese Übertragung den Voraussetzungen des Ge-
setzes vom 12. Juli 2013 entsprechen.“
5. Artikel 18 Abs. 8 wird um folgenden Wortlaut ergänzt und wie folgt neu gefasst:
„Die Gesellschaft kann zudem (i) Derivate, Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente und sonstige zulässige Vermögenswerte verwenden, insofern dies zu einer effizienten Verwaltung des
Portfolios geschieht und (ii) Derivate, Techniken und Instrumente im Zusammenhang mit der Verwaltung der
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu Absicherungszwecken nutzen.“
6. Artikel 27 wird wie folgt geändert:
„In dem gesetzlich erforderlichen Umfang wird die Gesellschaft zusammen mit dem AIFM einen Depotbankvertrag
mit einer Bank im Sinne des Gesetzes vom 5. April 1993 über den Finanzsektor („Depotbank“) abschließen.
57617
Die Depotbank wird die Pflichten erfüllen und die Verantwortung übernehmen, wie dies im Gesetz vom 17. De-
zember 2010 und im Gesetz vom 12. Juli 2013 vorgesehen ist.
Wenn laut den Rechtsbestimmungen eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von
einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen und es keine ortsansässige Einrichtung gibt, die den
Anforderungen des Gesetzes von 2013 genügen, kann die Depotbank sich von ihrer gesetzlichen Verantwortung
befreien, sofern die im Gesetz von 2013 aufgeführten weiteren Bedingungen für eine solche Befreiung gegeben sind.
Sofern die Depotbank sich aus ihrer Stellung zurückziehen möchte, wird der Verwaltungsrat sich nach Kräften
bemühen, eine Nachfolgedepotbank innerhalb von zwei Monaten nach Wirksamwerden der Beendigung der De-
potbankbestellung zu finden.“
7. Artikel 31 wird wie folgt geändert:
„Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Fragen werden durch die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften, das Gesetz vom 17. Dezember 2010 und das Gesetz vom 12. Juli 2013 ein-
schließlich nachfolgender Änderungen und Ergänzungen der jeweiligen Gesetze geregelt.“
II. Verschiedenes
Telegramm und Telex werden als Kommunikationsmittel gestrichen.
Beschlüsse der außerordentlichen Generalversammlung in Bezug auf die Satzungsänderung werden mit Zweidrittel-
Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst, sofern mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals
vertreten ist. Sofern das erforderliche Quorum zur ordnungsgemäßen Einberufung der Generalversammlung nicht er-
reicht werden konnte, wird eine zweite außerordentliche Generalversammlung nach den in Luxemburg anwendbaren
Vorschriften einberufen, wobei diese dann ohne die Einhaltung eines Anwesenheitsquorums über die Tagesordnung mit
einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre abstimmen kann.
Zur Teilnahme an der außerordentlichen Generalversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen
Aktionäre berechtigt, die bis spätestens 3 Tage vor der Versammlung die Depotbestätigung eines Kreditinstitutes bei der
Gesellschaft einreichen, aus der hervorgeht, daß die Aktien bis zur Beendigung der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden. Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die
Vollmachten müssen wenigstens fünf Tage vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden.
Die Neufassung der Satzung der Gesellschaft ist ab sofort bei der Gesellschaft, der Depotbank sowie den Zahlstellen
kostenlos erhältlich.
Bitte übermitteln Sie uns die Vollmacht vorab per Telefax-Nr. (00352) 22 15 22 - 500 oder Email:
d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015057162/755/72.
Air Newco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 194.917.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 17 mars 2015i>
En date du 17 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Madame Antonella GRAZIANO, née le 20 janvier 1966 à Orvieto, Italie, résidant professionnellement
à l'adresse suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société
avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Adrian Robert ALONSO, gérant de catégorie A
- Monsieur Maneet Singh SAROYA, gérant de catégorie A
- Monsieur Olivier HAMOU, gérant de catégorie B
- Madame Laetitia ANTOINE, gérant de catégorie B
- Madame Antonella GRAZIANO, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2015.
Air Newco 3 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015043323/23.
(150050021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
57618
Timbercreek Real Estate Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement
Spécialisé.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 144.640.
The board of directors herewith invites shareholders, in accordance with the Company's Articles of Association (the
“Articles”), to the
2
nd
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of shareholders to take place on <i>28 May 2015i> at 2:30 p.m. CET, at 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.
Capitalised terms not defined herein have the meaning assigned to them in the Prospectus of the Company.
The agenda is as follows:
<i>Agenda:i>
1. Amendments of Articles of the Company
A. In Title II - SHARE CAPITAL - SHARES - NET ASSET VALUE
Art. 11.- Calculation of the Net Asset Value per Share:
a) sub-para 1 has to be read as follows
“The Net Asset Value per Share of each Class, Category and/or Sub-Fund shall be calculated by the Central Ad-
ministrative Agent under the responsibility of the Board of Directors and the AIFM upon the frequency set forth
in article 12 of these Articles of Incorporation and the Offering document and at least once a year (each a “Valuation
Day”) in accordance with Luxembourg law and the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (Lux
GAAP).”
b) In section The value of such assets shall be determined as follows, lit. b) 1
st
sentence and 5
th
sentence have to
be read as follows
1
st
sentence “Securities which are not listed on a stock exchange nor dealt in on another regulated market will
be valued on the basis of the probable net realisation value (excluding any deferred taxation) estimated with pru-
dence and in good faith by the AIFM in cooperation with the Board of Directors.”
5
th
sentence “In case of the occurrence of an evaluation event that is not reflected in the latest available Net Asset
Value of such shares or units issued by such Investment Structures, the valuation of the shares or units issued by
such Investment Structures may be estimated with prudence and in good faith by the AIFM in cooperation with
the Board to take into account this evaluation event.”
c) In section The value of such assets shall be determined as follows, lit. d) has to be read as follows
“The liquidating value of futures, forward or options contracts not dealt in on a stock exchange or another regulated
markets shall mean their net liquidating value determined, pursuant to the policies established by the AIFM and the
board, on a basis consistently applied for each different variety of contracts. The liquidating value of futures, forward
or options contracts dealt in on a stock exchange or another regulated markets shall be based upon the last available
settlement prices of these contracts on such regulated markets on which the particular futures, forward or options
contracts are dealt in by the relevant Sub-Fund; provided that if a futures, forward or options contract could not
be liquidated on the day with respect to which net assets are being determined, the basis for determining the
liquidating value of such contract shall be such value as the AIFM and the Board of Directors may deem fair and
reasonable;”
d) In section The value of such assets shall be determined as follows, lit. e) has to be read as follows
“Interest rate swaps will be valued at their market value established by reference to the applicable interest rates
curve. Index and financial instruments related swaps will be valued at their market value established by reference
to the applicable index or financial instrument. The valuation of the index or financial instrument related swap
agreement shall be based upon the market value of such swap transaction established in good faith pursuant to
procedures established by the AIFM and the Board of Directors;”
e) In section The value of such assets shall be determined as follows, lit. g) has to be read as follows
“Real estate or rights equivalent to real estate property, held directly or indirectly by the Fund will be valued at
fair market value at least once per year according to international standards being performed by an independent
expert. The hence determined annual value as monitored by the independent expert can be taken up to the next
monitored valuation determination within one year. There exists the possibility to perform single valuations within
the financial year as instructed by the AIFM and the Board of Directors in order to confirm the market value of a
specific real estate or right equivalent to real estate property. Additionally, in case of sale or purchase of real estate
or of the right equivalent to real estate property by or from the Fund there will be a value determination performed
by two independent experts.”
f) In section The value of such assets shall be determined as follows, the last sub para has to be read as follows
“The AIFM in close cooperation with the Board of Directors, at its discretion, may permit some other method of
valuation to be used if it considers that such valuation better reflects the fair value of any asset or liability of the
57619
Company and/or its Sub-Funds in compliance with Luxembourg law and Lux GAAP. This method will then be applied
in a consistent way. The Central Administrative Agent can rely on such deviations as approved by the Company
and the AIFM for the purpose of the Net Asset Value calculation.”
Art. 12. - Frequency and Temporary Suspension of the Calculation of the Net Asset Value per Share, of the Issue,
the Redemption and the Conversion of Shares
a) sub-para 2 has to be read as follows
“The Company with the agreement of the AIFM may suspend the determination of the Net Asset Value per Share
of any particular Sub-Fund, Class and/or Category and the issue, redemption and conversion of its Shares to and
from its Shareholders in the following cases: ...”
B. In the Title III - ADMINISTRATION AND SUPERVISION
Art. 19. - Alternative Investment Fund Managers
The Article was added and has to be read as follows:
“The Board appoints an external AIFM within the meaning of the 2013 Law.
The AIFM may delegate certain administrative, distribution and investment management functions to specialised
service providers in consideration of the provisions of the 2013 Law.”
Art. 20. - Investment Manager and Investment Advisers
The Article has to be read as follows:
“The AIFM in cooperation with the Company may appoint an Investment Manager to manage, under its overall
control and responsibility, the securities portfolio of the various Sub-Funds of the Company.
The AIFM in cooperation with the Company may furthermore appoint an investment advisor with the responsibility
to prepare the purchase and sale of any eligible investments for the Company and otherwise advise the Company
with respect to asset management.
The powers and duties of the Investment Manager and the investment advisor as well as their remuneration will
be described in an investment management agreement and/or investment advisory agreement to be entered into
by the AIFM and the Investment Manager and/or investment advisor (as the case may be).”
Art. 23. - Auditors
Sub para 2 has to be read as follows:
“The auditor shall fulfil all duties prescribed by the 2007 Law and the 2013 Law.”
C. In the Title V - FINAL PROVISIONS
Art. 29. - Depositary
The Article has to be read as follows:
“To the extent required by law, the Company shall enter into a custody agreement with a banking or saving
institution as defined by the law of April 5, 1993 on the financial sector.
The Depositary shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2007 Law and the 2013 Law.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity
and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in the 2013 Law, the Depositary
may discharge itself of liability, provided the conditions of such discharge as set out in the 2013 Law are fulfilled.”
Art. 33. - Transitory Dispositions
The Article was erased.
2. Miscellaneous
- The term “Custodian” was replaced by the term “Depositary”
- The term “Prospectus” was replaced by the term “Offering document”
- Spelling corrections
Quorum and Majority
Resolutions on the agenda of the extraordinary general meeting of Shareholders will require a quorum of fifty percent
(50%) of the shares issued and outstanding. Should the quorum of fifty percent (50%) of the shares issued and outstanding
not be met at the extraordinary general meeting of Shareholders, a second meeting, which will validly deliberate irre-
spective of the number of shares represented, will be reconvened in due course with the same agenda.
The changes will only enter into force, and the documents, notably the Prospectus, will be available, only if all the
resolutions have been validly taken, either at the initial extraordinary general meeting or the second extraordinary general
meeting of Shareholders.
Representation of the Shareholders:
All shareholders are entitled to attend and vote and are entitled to appoint proxies to attend and vote instead of them.
A proxy need not be a member of the Company. If you do not wish to attend the Extraordinary General Meeting of
Shareholders would you please sign the special proxy form and return it to us until the 26 May 2015. Otherwise, the
votes will not be taken into account by the company. Please fax the forms beforehand to (00352) 22 15 22 - 500 or send
it by e-mail: d_FundSetUpOPAM@oppenheim.lu.
By order of the Board,
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015057166/755/118.
57620
Reload Master S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 192.363.
In the year two thousand and fifteen on the thirteenth day of March.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
- Cavendish-Peakside CEE Holding S.à. r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) esta-
blished and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-)
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192313,
- Mr. Tomas JOKL, born on 25 September 1974, residing at Terronská 742/55, Bubenee, 160 00 Praha 6, Czech
Republic,
both here represented by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, having his professional address at 10 avenue Guillaume, L-1650
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of two (2) proxies given on March 13, 2015.
The said proxies, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated hereabove, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons, represented as mentioned above, are the shareholders of the private limited liability company
(société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name “Reload
Master S.a. r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 192363,
established pursuant to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg dated November 14, 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of December 19,
2014, number 3943, and whose articles have not been amended since then.
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each (the Existing Shares).
III. The Existing Shares are currently held as follows:
- twelve thousand three hundred thirty (12.330) shares by Cavendish-Peakside CEE Holding S.a. r.l., prenamed; and
- one hundred seventy (170) shares by Mr. Tomas Jokl, prenamed.
IV. The agenda of the meeting is the following:
1. Creation of class A shares and class B shares;
2. Conversion of the twelve thousand three hundred thirty (12.330) Existing Shares held by Cavendish-Peakside CEE
Holding S.à. r.l., prenamed into twelve thousand three hundred thirty (12.330) class A shares and one hundred seventy
(170) Existing Shares held by Mr. Tomas Jokl, prenamed into one hundred seventy (170) class B shares;
3. Subsequent amendment of article 5, first paragraph of the articles of association of the Company;
4. Insertion of new articles 9 and 10 in the article of association of the Company;
5. Insertion of a new article 17 in the article of association of the Company;
6. Change the numbering of the articles of association of the Company accordingly.
7. Amendment of articles 20 and 21 of the article of association of the Company.
V. The shareholders, after deliberation, unanimously take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders resolve to create class A shares and class B shares.
<i>Second resolutioni>
The shareholders resolve to convert the twelve thousand three hundred thirty (12.330) Existing Shares held by Ca-
vendish-Peakside CEE Holding S.a. r.l., prenamed, into twelve thousand three hundred thirty (12.330) class A shares and
one hundred seventy (170) Existing Shares held by Mr. Tomas Jokl, prenamed, into one hundred seventy (170) class B
shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each and an aggregate value of twelve thousand five hundred Euro
(EUR 12.500,-).
<i>Third resolutioni>
Following the above, the shareholders resolve to amend article 5, first paragraph of the Company's articles of asso-
ciation to give it henceforth the following content:
57621
“ Art. 5. The subscribed share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,-) represented by:
- twelve thousand three hundred thirty (12.330) class A shares (the Class A Shares); and
- one hundred seventy (170) class B shares (the Class B Shares), all with a nominal value of one Euro (EUR 1,-) each.”
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to insert new articles 9 and 10 into the article of association of the Company and to give
them the following content:
“ Art. 9. In case the holder of the Class A Shares intends to sell and transfer 50 % or more of the shares it holds in
the share capital of the Company to a third party, the holder of the Class A Shares shall be entitled to require from the
holder of Class B Shares to sell and transfer the shares it holds in the Company by option of the holder of the Class A
Shares on a pro rata basis or in full to the same third party (or another party designated by the respective third party or
the holder of the Class A Shares) (the Buyer) on the same terms and conditions as agreed between the holder of the
Class A Shares and the Buyer (the Drag-Along-Right). If the purchase price for the Class B Shares is lower than the value
of the Class B Shares determined by an independent expert appointed collectively by the shareholders of the Company
subject to any shareholders ' agreement which may be entered into from time to time between the Company's share-
holders (the Exit Price), the holder of Class B Shares shall be entitled to receive the difference between the purchase
price and the Exit Price for the Class B Shares from the holder of Class A Shares plus any accrued but unpaid portion of
any payments or distribution allocated to the holder of Class B Shares according to clause 17.3 and 17.4 (the Promote).
The shareholders of the Company shall cooperate in good faith to achieve an efficient transaction structure when
exercising the Drag-Along-Right.
Art. 10. In case the holder of the Class A Shares intends to sell and transfer 50 % or more of the shares it holds in the
share capital of the Company to a third party and does not exercise the Drag-Along-Right, the holder of Class B shares
shall be entitled to require from the holder of the Class A Shares to sell and transfer all the Class B Shares to the Buyer
on the same terms and conditions as agreed between the holder of the Class A Shares and the Buyer (the Tag-Along-
Right). In case of exercising the Tag-Along-Right, any accrued but unpaid Promote shall forfeit.
The shareholders of the Company shall cooperate in good faith to achieve an efficient transaction structure when
exercising the Tag-Along-Right.”
<i>Fifth resolutioni>
The shareholders resolve to insert a new article 17 and to give it henceforth the following content:
“ Art. 17. Any distribution to be made by the Company (being by virtue of return of capital, dividend distribution or
by virtue of the Company's liquidation) out of the distributable cash received by and available to the Company in the
respective financial year from operating activities, less any disbursements by the Company for costs, interest payments
and capital expenditures (the Free Cash Flow), subject always to the provisions of the Law, shall be made to the share-
holders pro rata in proportion to their respective shareholding in the Company unless article 17 expressly provides for
another allocation of the payments and in the following order of priority until exhaustion of the distributable sums and
as soon as reasonably practicable:
17.1 firstly, and in the following priority, any such amount required to repay any principal outstanding under any loan
made by the holder of Class A Shares or Class B Shares to the Company to eliminate any shortfall of the Company;
17.2 secondly, any principal outstanding under any other loan granted by the holder of Class A Shares or Class B Shares
to the Company which is due for repayment;
17.3 thirdly, to all shareholders of the Company pro rata of the respective shareholding in the Company, such amount
required until the holder of Class A Shares has received a total amount which would constitute an internal return rate
of fifteen percent (15 %) on the capital contributions made by the holder of Class A Shares;
17.4 fourthly, following the payments above, fifteen percent (15 %) of all then Free Cash Flow to the holder of Class
B Shares and the remainder to the holder of Class A Shares.
The funds to be paid under the Promote, if any, shall be assessed twice a year by the holder of Class A Shares on 30
June and by the end of the calendar year. The Company shall pay the Promote to the holder of Class B Shares within
forty-five (45) business days from such date on.
Immediately following the distribution of the Free Cash Flow to the shareholders of the Company in accordance with
clauses 17.1 through 17.4, the holder of Class A Shares shall measure its internal return rate on its capital contributions
(composed of the share capital, the shareholder loans and special equity reserve account contributed/paid by the holder
of Class A Shares to the Company); the holder of Class A Shares may do so also on an ongoing basis. In case the holder
of Class A Shares' return for the preceding financial year does not constitute an internal return rate of fifteen percent
(15%) on the capital contributions made by the holder of Class A Shares, then the holder of Class B Shares shall, on
demand by the holder of Class A Shares, return to the holder of Class A Shares the payment or distributions allocated
to the holder of Class B Shares according to the clauses 17.3 and 17.4 up to the amount that is required to constitute an
internal return rate of fifteen percent (15%) on the capital contributions (as described above) made by the holder of Class
57622
A Shares (the Clawback). For the avoidance of doubt, the Clawback shall not exceed the total amount of all distributions
made to the holder of Class B Shares in accordance with clauses 17.3 and 17.4."
<i>Sixth resolutioni>
Following the above, the shareholders resolve to change the numbering of the articles of association of the Company
from article 9 to article 22.
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders resolve to amend articles 20 and 21 of the article of association of the Company and to give them
henceforth the following content:
“ Art. 20. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortization,
charges and provisions represents the net profit of the Company.
Every year, five percent (5%) of the net profit shall be allocated to the legal reserve.
This allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share
capital but shall be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever,
the ten percent (10%) threshold is no longer met.
Art. 21. At the time of winding up the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
shareholders or not, appointed by the shareholder(s) who shall determine their powers and remuneration.”
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be as a result of the present reso-
lutions are estimated at approximately one thousand five hundred Euro (EUR 1,500,-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the attorney of the persons appearing, who is known to the notary by his name,
civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de mars.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1. Cavendish-Peakside CEE Holding S.à. r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante selon le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
avec un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), et immatriculée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 192313;
2. Monsieur Tomas JOKL, né le 25 septembre 1974, ayant son adresse personnelle au Terronská 742/55, Bubenec,
160 00 Praha 6, République Tchèque;
ici représentés par Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, avec adresse professionnelle au 10 avenue Guillaume, L-1650
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de deux (2) procurations données sous seing privé le 13 mars 2015.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des personnes comparantes
et le notaire instrumentaire, annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Lesquels comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les personnes comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Lu-
xembourg sous la dénomination «Reload Master S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 46A, Avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192363, constituée par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 14 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 3943 en date du 19 décembre 2014, et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par douze mille cinq
cents (12.500) parts sociales ayant toutes une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,-) chacune (les Parts Sociales Existantes).
III. Les Parts Sociales Existantes sont actuellement détenues comme suit:
- douze mille trois cent trente (12.330) parts sociales par Cavendish-Peakside CEE Holding S.à r.l., prénommée, et
- cent soixante-dix (170) parts sociales par M. Tomas Jokl, prénommé.
57623
IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Création des parts sociales de classe A et des parts sociales de classe B;
2. Conversion des douze mille trois cent trente (12.330) Parts Sociales Existantes détenues par Cavendish-Peakside
CEE Holding S.à r.l., prénommée, en douze mille trois cent trente (12.330) parts sociales de classe A et des cent soixante-
dix (170) Parts Sociales Existantes détenues par M. Tomas Jokl, prénommé, en cent soixante-dix (170) parts sociales de
classe B;
3. Modification subséquente de l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société;
4. Insertion de nouveaux articles 9 et 10 dans les statuts de la Société;
5. Insertion d'un nouvel article 17 dans les statuts de la Société;
6. Changement de la numérotation des articles des statuts de la Société en conséquence;
7. Modification des articles 20 et 21 des statuts de la Société.
V. Les associés, après avoir délibéré, prennent à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de créer des parts sociales de classe A et des parts sociales de classe B.
<i>Seconde résolutioni>
Les associés décident de convertir les douze mille trois cent trente (12.330) Parts Sociales Existantes détenues par
Cavendish-Peakside CEE Holding S.à r.l., prénommée, en douze mille trois cent trente (12.330) parts sociales de classe
A et les cent soixante-dix (170) Parts Sociales Existantes détenues par M. Tomas Jokl, prénommé, en cent soixante-dix
(170) parts sociales de classe B.
<i>Troisième résolutioni>
Suite aux résolutions ci-dessus, les associés décident de modifier l'article 5, premier paragraphe des statuts de la Société
pour lui donner désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital souscrit est fixé à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) représenté par:
- douze mille trois cent trente (12.330) parts sociales de classe A (les Parts Sociales de Classe A); et
- cent soixante-dix (170) parts sociales de classe B (les Parts Sociales de Classe B), ayant toutes une valeur nominale
d'un Euro (EUR 1,-) chacune.»
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d'insérer de nouveaux articles 9 et 10 dans les statuts de la Société et de leur donner la teneur
suivante:
« Art. 9. Dans le cas où le titulaire des Parts Sociales de Classe A a l'intention de vendre et de transférer 50% ou plus
des parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société à un tiers, le titulaire des Parts Sociales de Classe A a le
droit d'exiger de la part du détenteur des Parts Sociales de Classe B de vendre et de transférer les parts sociales qu'il
détient dans la Société sur option du titulaire des Parts Sociales de Classe A, sur une base proportionnelle ou en totalité,
à la même tierce partie (ou une autre personne désignée cette tierce personne ou par le titulaire des Parts Sociales de
Classe A) (l'Acheteur) selon les mêmes termes et conditions que ceux convenus entre le titulaire des Parts Sociales de
Classe A et l'Acheteur (le Droit de Cession Forcée).Si le prix d'achat des Parts Sociales de Classe B est inférieure à la
valeur des Parts Sociales de Classe B déterminée par un expert indépendant nommé collectivement par les associés de
la Société, sous réserve de tout pacte d'associés qui serait en vigueur entre les associés de la Société le cas échéant, (le
Prix de Cession) le détenteur des Parts Sociales de Classe B doit être autorisé à recevoir la différence entre le prix d'achat
et le Prix de Cession de la part du détenteur des Parts Sociales de Classe A pour ses Parts Sociales de Classe B ensemble
avec tous les paiements ou distributions échus mais non payés, alloués au détenteur de Parts Sociales de Classe B en
conformité avec les articles 17.3 et 17.4 (le Promote).
Les associés de la Société doivent coopérer de bonne foi pour mettre en oeuvre une structure efficace dans le cadre
de l'exercice du Droit de Cession Forcée.
Art. 10. Dans le cas où le titulaire des Parts Sociales de Classe A a l'intention de vendre et de transférer 50% ou plus
des parts sociales qu'il détient dans le capital social de la Société à un tiers et qu'il n'exerce pas le Droit de Cession Forcée,
le titulaire des Parts Sociales de Classe B a le droit d'exiger du titulaire des Parts Sociales de Classe A de vendre et de
transférer toutes les Parts Sociales de Classe B à l'Acheteur dans les mêmes termes et conditions que ceux convenus
entre le titulaire des Parts Sociales de Classe A et l'Acheteur (le Droit de Suite). En cas d'exercice du Droit de Suite, tout
Promote échu et non payé est perdu.
Les associés de la Société doivent coopérer de bonne foi pour mettre en oeuvre une structure efficace dans le cadre
de l'exercice du Droit de Suite.»
57624
<i>Cinquième résolutioni>
Les associés décident d'insérer un nouvel article 17 dans les statuts de la Société et de lui donner désormais la teneur
suivante:
« Art. 17. Toute distribution devant être effectuée par la Société (en vertu d'un remboursement de capital, de distri-
bution de dividendes ou en vertu de la liquidation de la Société) des liquidités distribuables reçues par et disponibles pour
la Société sur l'exercice financier de l'année et résultant des activités d'exploitation, déduction faite de tous décaissements
par la Société sur les coûts, les paiements d'intérêts et les dépenses d'investissements (les Flux de Trésorerie), toujours
sous réserve des dispositions de la Loi, doit être effectuée au bénéfice des associés au prorata et en proportion de leur
participation respective dans la Société, sauf si l'article 17 prévoit expressément une autre répartition des paiements et
dans l'ordre de priorité suivant jusqu'à épuisement des sommes distribuables et si cela est raisonnablement possible:
17.1 en premier lieu, selon l'ordre de priorité suivant, tout montant nécessaire pour rembourser le montant du
principal impayé de tout prêt effectué par le titulaire de Parts Sociales de Classe A et de Classe B à la Société afin d'éliminer
tout déficit de la Société;
17.2 en deuxième lieu, tout principal impayé de chaque prêt effectué par le titulaire de Parts Sociales de Classe A et
de Classe B à la Société qui est dû pour repaiement;
17.3 en troisième lieu, à tous les associés de la Société au prorata de leur participation respective dans la Société,
jusqu'à ce que le titulaire de Parts Sociales de Classe A ait reçu un montant total qui constituerait un taux de rendement
interne de quinze pour cent (15%) sur les apports en capital effectués par le titulaire de Parts Sociales de Classe A;
17.3 quatrièmement, à la suite des paiements susmentionnés, quinze pour cent (15%) des Flux de Trésorerie restant,
au détenteur de Parts Sociales de Classe B et le montant restant au détenteur de Parts Sociales de Classe A.
Les sommes devant être payées en vertu du Promote, le cas échéant, doivent être évaluées deux fois par an par le
détenteur de Part Sociales de Classe A le 30 juin et à la fin de chaque année calendaire. La Société doit payer le Promote
au détenteur des Parts Sociales de Classe B endéans les quarante-cinq (45) jours ouvrés suivant ces dates.
Immédiatement après la distribution des Flux de Trésoreries aux associés de la Société conformément aux articles
17.1 à 17.4, le titulaire de Parts Sociales de Catégorie A doit mesurer le taux de rendement interne de ses apports
(composés du capital social, des prêts des associés et des contributions/paiements au compte de capital spécial fait par
le détenteur des parts Sociales des Classe A à la Société); le détenteur de Parts Sociales de Classe A peut également le
faire de façon continue. Si le rendement de l'exercice précédent du titulaire de Parts Sociales de Catégorie A ne constitue
pas un taux de rendement interne de quinze pour cent (15%) sur les apports en capital effectués par le(s) titulaire(s) de
Parts Sociales de Catégorie A, alors le(s) titulaire(s) de Parts Sociales de Catégorie B doit, à la demande du(des) titulaire
(s) de Parts Sociales de Catégorie A, retourner au(x) titulaire(s) de Parts Sociales de Catégorie A le paiement ou les
distributions alloué au(x) titulaire(s) de Parts Sociales de Catégorie B en vertu des clauses 17.3 et 17.4 pour l'année
financière précédente à hauteur du montant nécessaire pour constituer un taux de rendement interne de quinze pour
cent (15%) sur les apports en capital (décrit ci-dessus) effectués par le(s) titulaire(s) de Parts Sociales de Catégorie A (la
Récupération). Par souci de clarté, la Récupération ne doit pas dépasser le montant total de toutes les distributions
effectuées au(x) titulaire(s) de Parts Sociales de Catégorie B conformément aux clauses 17.3 et 17.4 sur toutes les années
précédentes.».
<i>Sixième résolutioni>
Suite à ce qui précède, les associés décident de changer la numérotation des statuts de la Société.
<i>Septième résolutioni>
Les associés décident de modifier les articles 20 et 21 des statuts de la Société et de leur donner désormais la teneur
suivante:
« Art. 20. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et
provisions, constitue le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net sont affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cessent d'être obligatoires lorsque la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social,
mais doivent être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds
de réserve se trouve entamé.
Art. 21. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation est assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l'(es) associé(s) qui détermine(nt) leurs pouvoirs et rémunération.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de mille cinq cents Euro (EUR 1.500,-).
57625
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, il a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Nezar, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 16 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8138. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015046041/282.
(150052415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Fermat 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 17.829.281,00.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 168.721.
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
There appeared the following:
Fermat 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) organised and established under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirty million eight hundred twenty-two thousand two hundred
thirty-nine US Dollars (USD 30,822,239.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 169330 (the "Sole Shareholder"),
represented by Mr Michael Mosser, jurist, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), by
virtue of a proxy given in Munsbach on 17 March 2015 which, after having been initialled and signed "ne varietur" by the
proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated before, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The appearing party declares that it currently holds all the seventeen million two hundred seventy nine thousand
two hundred eighty-one (17,279,281) shares of Fermat 2 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) organised and established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 6C, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of seventeen million two hundred
seventy nine thousand two hundred eighty-one US Dollars (USD 17,279,281.-) and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 168721, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary
residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 30
th
, 2011, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1520 dated June 18
th
, 2012 (the "Company"). The Company's articles of association
have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on January 28
th
, 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 693 dated March 13
rd
2015.
II. That the agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. To increase the Company's share capital with an amount of five hundred fifty thousand US Dollars (USD 550,000.-),
in order to raise it from its current amount of seventeen million two hundred seventy nine thousand two hundred and
eighty-one US Dollars (USD 17,279,281.-), divided into seventeen million two hundred seventy nine thousand two hun-
dred and eighty-one (17,279,281) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, to an amount of seventeen
million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one US Dollars (USD 17,829,281.-), divided into
seventeen million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one (17,829,281) shares with a nominal
value of one US Dollar (USD 1.-).
2. To issue five hundred fifty thousand (550,000) shares so as to raise the total number of shares to seventeen million
eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one (17,829,281) shares with a nominal value of one US
Dollar (USD 1.-) each, with a share premium of fifty four million four hundred fifty thousand US Dollars (USD
57626
54,450,000.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitled to dividends as
from the day of such extraordinary general shareholder meeting.
3. To subscribe five hundred fifty thousand (550,000) shares of the Company with a nominal value of one US Dollar
(USD 1.-) each with a share premium of fifty four million four hundred fifty thousand US Dollars (USD 54,450,000.-).
4. To amend article 6.1 of the articles of association of the Company so as to reflect the resolutions to be adopted
under items 1) to 3).
5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to increase the Company's share capital with an amount of five hundred fifty thou-
sand US Dollars (USD 550,000.-), in order to raise it from its current amount of seventeen million two hundred seventy
nine thousand two hundred and eighty-one US Dollars (USD 17,279,281.-) divided into seventeen million two hundred
seventy nine thousand two hundred and eighty-one (17,279,281) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-)
each, to an amount of seventeen million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one US Dollars
(USD 17,829,281.-), divided into seventeen million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one
(17,829,281) shares with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-).
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to issue five hundred fifty thousand (550,000) shares so as to raise the total number
of shares to seventeen million eight hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one (17,829,281) shares with
a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, with a share premium of fifty four million four hundred fifty thousand
US Dollars (USD 54,450,000.-), having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitled
to dividends as from the day of such extraordinary general shareholder meeting.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to accept the subscription of five hundred fifty thousand (550,000) shares of the
Company with a nominal value of one US Dollar (USD 1.-) each, with a share premium of fifty four million four hundred
fifty thousand US Dollars (USD 54,450,000.-), by the Sole Shareholder.
<i>Contributor's Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon, now appeared Mr Michael Mosser, prenamed, acting in his capacity as duly authorised agent and attorney
in fact of the Sole Shareholder.
The person appearing declared to subscribe in the name and on behalf of the Sole Shareholder, prenamed, to the
increase of capital.
<i>Evidence of the contribution's existencei>
Proof of the contribution's existence has been given to the undersigned notary.
The capital increase has been fully paid up by a contribution of cash (including the payment of the share premium) for
a total amount of fifty five million US Dollars (USD 55,000,000.-).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder RESOLVED to amend article 6.1 of the articles of association of the Company which shall
forthwith read as follows:
" 6.1. Subscribed share capital. The issued share capital of the Company amounts to seventeen million eight hundred
twenty-nine thousand two hundred and eighty-one US Dollars (USD 17,829,281.-) represented by seventeen million eight
hundred twenty-nine thousand two hundred and eighty-one (17, 829,281) shares of one US Dollar (USD 1.-) each, all
fully subscribed and entirely paid up.”.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately six thousand seven hundred Euro (EUR 6,700.-).
The undersigned notary, who understands English, states that on request of the appearing party, the present deed is
worded in English, followed by a French version, and in case of discrepancies between the English and the French text,
the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the appearing party's proxyholder, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the appearing party's proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.
57627
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour de mars.
Par devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
Fermat 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée dûment constituée et valablement existante selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de
Luxembourg, avec un capital social de trente millions huit cent vingt-deux mille deux cent trente-neuf Dollars Américains
(USD 30.822.239,-) et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
169330 (l'"Associé Unique"),
représentée par Monsieur Michael Mosser, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), en vertu d'une procuration donnée à Munsbach le 17 mars 2015.
La procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné devra être
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
L'Associé Unique a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La comparante déclare détenir l'intégralité des dix-sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-
vingt-une (17.279.281) parts sociales de Fermat 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée incorporée et existante selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-
Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
168721 et constituée aux termes d'un acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 30 décembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 1520 du 18 juin 2012 (la "Société"). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire instrumentant en date du 28 Janvier 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 693 du 13 mars 2015.
II. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinquante mille Dollars Américains (USD
550.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix-sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille deux cent quatre-
vingt-un Dollars Américains (USD 17.279.281,-) représenté par dix-sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille deux
cent quatre-vingt-une (17.279.281) parts sociales avec une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, au
montant de dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-un Dollars Américains (USD 17.829.281,-),
représenté par dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (17.829.281) parts sociales avec
une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune.
2. Emission de cinq cent cinquante mille (550.000) parts sociales afin d'élever le nombre total des parts sociales à dix-
sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (17.829.281) parts sociales ayant une valeur nominale
d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions quatre cent cinquante
mille Dollars Américains (USD 54.450.000,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales
existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date d'une telle assemblée générale extraordinaire.
3. Acceptation de la souscription de cinq cent cinquante mille (550.000) parts sociales de la Société avec une valeur
nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions quatre cent
cinquante mille Dollars Américains (USD 54.450.000,-).
4. Modification de l'article 6.1 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions devant être adoptées sous les
points 1) à 3).
5. Divers.
III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq cent cinquante mille Dollars
Américains (USD 550.000,-) pour le porter de son montant actuel de dix-sept millions deux cent soixante-dix-neuf mille
deux cent quatre-vingt-un Dollars Américains (USD 17.279.281,-) représenté par dix-sept millions deux cent soixante-
dix-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (17.279.281) parts sociales avec une valeur nominale d'un Dollar Américain
(USD 1,-) chacune, au montant de dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-un Dollars Américains
(USD 17.829.281,-), représenté par dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (17.829.281)
parts sociales avec une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'émettre cinq cent cinquante mille (550.000) parts sociales afin d'élever le nombre total des
parts sociales à dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent quatre-vingt-une (17.829.281) parts sociales ayant
une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, avec une prime d'émission de cinquante-quatre millions
57628
quatre cent cinquante mille Dollars Américains (USD 54.450.000,-), ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés
aux parts sociales existantes et donnant droit aux dividendes à partir de la date d'une telle assemblée générale extraor-
dinaire.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'accepter la souscription de cinq cent cinquante mille (550.000) parts sociales de la Société
avec une valeur nominale d'un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, avec une prime d'émission de cinquante-quatre
millions quatre cent cinquante mille Dollars Américains (USD 54.450.000,-) par l'Associé Unique.
<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Paiementi>
Comparait ensuite aux présentes Monsieur Michael MOSSER, préqualifié, agissant en sa qualité de mandataire de
l'Associé Unique, susmentionné, dûment autorisé.
La partie comparante a déclaré souscrire au nom et pour le compte de l'Associé Unique l'augmentation de capital.
<i>Preuve de l'existence de l'apporti>
Preuve de l'existence de cet apport a été donnée au notaire soussigné.
L'augmentation de capital a été payée en intégralité au moyen d'un apport en numéraire (incluant le paiement de la
prime d'émission) pour un montant total de cinquante-cinq millions de Dollars Américains (USD 55.000.000,-).
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 des statuts de la Société qui est remplacé par le texte qui suit:
« 6.1. Capital souscrit et libéré. Le capital social émis est fixé à dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux cent
quatre-vingt-un Dollars Américains (USD 17.829.281,-) représenté par dix-sept millions huit cent vingt-neuf mille deux
cent quatre-vingt-une (17.829.281) parts sociales d'une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1,-) chacune, toutes
entièrement souscrites et libérées.».
<i>Estimation des coûtsi>
Les frais, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui devront être supportés par la Société à la suite de cet acte
notarié sont estimés approximativement à six mille sept cents euros (EUR 6.700,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur la demande de la partie contractante, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la partie contractante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom,
usuel, état civil et demeure, cette personne a signé avec nous, le notaire, le présent acte.
Signé: Mosser, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 19 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8620. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015045756/185.
(150052360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une
Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 178.903.
Les statuts coordonnés au 03/02/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25/03/2015.
Me Cosita Delvaux
Notaire
Référence de publication: 2015046551/13.
(150053274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2015.
57629
Pharaoh Corporation S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 195.537.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the twenty-sixth day of February
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
ABINGDON S.A., a public company with limited liability (Société anonyme) organized and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 9B, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg (the
“Company”), RCS Luxembourg B191.450, duly represented by Mr Fons MANGEN, Réviseur d’entreprises, residing in
Ettelbruck (Grand Duchy of Luxembourg), by virtue of a proxy given under private seal in Luxembourg on February 25,
2015.
The forenamed power of attorney given, signed "ne varietur" by the appearing person and the undersigning notary
shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party, in the capacity in which he acts, has requested the notary to record the following:
ABINGDON S.A. is the sole shareholder of PHARAOH CORPORATION N.V., a company established in the Ne-
therlands Antilles, registered at the Chamber of Commerce in Curaçao with registration number 100.493 and having its
registered office in Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O. Box 837, Willemstad Curaçao, Netherlands Antilles,
hereinafter referred to as the «Company», incorporated under the Netherlands Antilles Laws pursuant to a deed executed
before Maître Rudolf Johannes Anthony Palm, civil law notary, residing in Curaçao, on 20 April 1990
The sole shareholder ABINGDON S.A., holding all the 26.000 shares in the company, is duly represented at the present
meeting which is duly constituted and may validly take the resolutions on the following agenda, without prior convening
notice.
The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Ratification of the shareholders’ resolutions adopted on February 25, 2015, to approve, among others, the transfer
of the registered office from Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O. Box 837, Willemstad Curaçao, Nether-
lands Antilles to L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri and to adopt the Luxembourg nationality.
2. To acknowledge the transfer of the registered office and of the administrative management seat of the Company
from Curaçao to the Grand-Duchy of Luxembourg for strategic reasons and following changes in the legislation in Cu-
raçao, without the Company being dissolved and with corporate continuance as of the date of the present deed.
3. Adoption of the patrimonial statement of the Company as at February 10, 2015 as the closing balance sheet of the
operations of the company in the Netherlands Antilles and as the opening balance of the company in Luxembourg
4. To approve the valuation report of the Company as of February 18, 2015, issued by FIDEWA-CLAR S.A.
5. To adopt in Luxembourg the legal form of public company with limited liability (société anonyme).
6. Cancellation of the nominal value of each share and conversion of the corporate capital and bookkeeping currency
from USD into EUR at the rate fixed by the Foreign Exchange Rates on February 18, 2015 at 1 USD= 0,8789 EUR, to
EUR 22.851.-, represented by 26,000 shares without nominal value. Allocation of any difference resulting from an eventual
variation of the currency rate to a positive or negative reserve, if needed.
7. Increase of the corporate capital of an amount of EUR 8.149,-, so as to raise it from its present amount of EUR
22.851,- to EUR 31.000.-, without issue of new shares, but by increase of the par value of each share, to be subscribed
by the sole shareholder, by contribution in cash
8. Replacement of the 26.000 shares without nominal value by 31.000 shares with a nominal value of EUR 1.- each
9. To adopt the corporate name of "Pharaoh Corporation S.A.".
10. Complete up-dating of the by-laws, in order to adapt them to the Luxembourg company law.
11. To fix the registered office of the Company at L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.
12. Resignation of United International Trust NV. from its mandate of director and discharge for the execution of its
mandate
13. Appointment of the following persons as Directors of the Company until the annual general meeting of shareholders
to be held in 2020:
Mr Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, residing at Ettelbruck.
Mr Jean-Hugues ANTOINE, accountant, with professional address at 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg.
Mrs Carine REUTER-BONERT, employee, residing at Fennange.
57630
14. Appointment for the same period of a statutory auditor, RAMLUX S.A., having its registered office in L-1724
Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri. Its mandate will expire at the ordinary general meeting which will be held in
2020.
15. Miscellaneous.
After approval of the foregoing, the sole shareholder represented as stated above, has adopted the following resolu-
tions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder approves and, ratifies the resolution taken by the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of PHARAOH CORPORATION N.V., at its meeting held in Curaçao on February 25, 2015, to transfer the registered
office and the administrative management seat of the Company from Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O.
Box 837, Willemstad Curaçao (Netherlands Antilles) to L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, as from the
date of the present deed and without discontinuance in its legal personality.
A copy of the said meeting, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary,
will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
It is resolved to adopt the Luxembourg nationality and to submit the Company to the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg as from the date of the present deed.
the Company, being an N.V., which is equivalent to an S.A., the sole shareholder resolves, for the purposes of the law
dated 10
th
August, 1915 on commercial companies, as amended, to adopt the legal form of public company with limited
liability (société anonyme).
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder decides to adopt the patrimonial statement of the Company as at February 10, 2015 as the closing
balance sheet of the operations of the company in the Netherlands Antilles and as the opening balance of the company
in Luxembourg, the said balance sheet showing a net equity of USD 705.862,-
Said closing balance and opening balance, after having been signed ne varietur, by the appearing party and the under-
signed notary, will remain attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration
authorities.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder decides to adopt the auditor’s report drawn up in view of the transfer of the Company and
according to articles 26-1 and 32-1 of the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies.by FIDEWA-CLAR,
Réviseur d’entreprises, with address in Luxembourg, on February 18, 2015. Based on generally accepted accountancy
principles, it appears from this report that, as of this date, the net asset value of the Company amounts to at least USD
705.862,-
The said report contains the following conclusion:
«Sans remettre en cause notre conclusion, nous attirons votre attention sur le fait qu’un montant minimal de EUR
8.149 devra être versé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire devant statuer sur la transformation de PHARAOH
CORPORATION S.A. pour atteindre le minimum de capital requis pour la constitution d’une société anonyme.
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention hormis le point énoncé ci-dessus, qui nous laisse
à penser que la valeur globale de l’actif net au 10 février 2015 de la société PHARAOH CORPORATION S.A. ne cor-
respond pas au moins au capital minimum requis pour la constitution d’une société anonyme.»
Said report, after having been signed ne varietur, by the appearing party and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed in order to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder decides to cancel the nominal value of each share.
According to the valuation report issued by the réviseur d’entreprises, the net value of the Company is USD 705.862
and the issued share capital of the Company currently amounts to USD 26.000,-
It is decided to convert the corporate capital and bookkeeping currency from USD into Euro at the exchange rate,
fixed by the Foreign Exchange Rates on February 18, 2015 at USD 1 = 0,8789.- EUR, Based on this conversion, the capital
of the Company is fixed at EUR 22.851, (twenty-two thousand eight hundred fifty-one Euro), represented by 26.000
(twenty-six thousand) shares without nominal value.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder decides to increase the corporate capital by an amount of EUR 8.149- (eight thousand one
hundred forty-nine Euro), so as to raise it from its present amount of EUR 22.851,- (twenty-two thousand eight hundred
fifty-one Euro) to EUR 31.000.- (thirty-one thousand Euro), without issue of new shares, but by increase of the par value
of each share, to be subscribed by the sole shareholder, by contribution in cash.
57631
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon the sole shareholder, represented by Mr Fons MANGEN, pre-named, by virtue of the aforementioned
proxy;
declared to subscribe to the capital increase and to have it fully paid up by payment in cash, so that from now on the
company has at its free and entire disposal the amount of EUR 8.149,- eight thousand one hundred forty-nine Euro), as
it is certified to the undersigned notary.
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder decides to fix a new nominal value of EUR 1,- (one Euro) per share and to replace the 26,000
shares without nominal value by 31,000 shares with a nominal value of EUR 1.- each.
<i>Seventh resolutioni>
It is further resolved that the Company adopts the corporate name of "Pharaoh Corporation S.A.".
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder resolves to adapt the Articles of Association to Luxembourg Law and to the foregoing resolutions
The Articles of Association of the company are drafted in French language and have henceforth the following wording:
STATUTS
1. Nom.
1. Le nom ou dénomination de la Société est: «PHARAOH CORPORATION S.A.».
2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'adminis-
tration. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
des actionnaires modifiant les statuts de l'association.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration.
2.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3. Objet social.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres
et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de
toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opé-
rations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement. La société peut dans ce cadre consentir
des emprunts, le cas échéant, représentés par des obligations ou autres titres de créance.
4. Durée.
4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital et actions.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000.- (trente et un mille Euros), divisé en 31.000 (trente et un mille)
actions d'une valeur nominale de EUR 1.- (un Euro) chacune.
5.2. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
5.3. La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.
5.4. Usufruit et Nue-Propriété: Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital
social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier»
et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire». Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et
conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l’assemblée se prononçant sur la
mise en liquidation de la société.
57632
- droit aux dividendes.
5.5. Nature des actions: Les actions sont et resteront nominatives.
5.6. Versements: Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront
se faire aux dates et aux conditions que le conseil d’administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
6. Conseil d’administration.
6.1. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. Toutefois, dans le cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, s'il est constaté
lors d'une assemblée générale des actionnaires que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en reconnaissant
que la Société a plus d'un actionnaire. Les personnes morales peuvent également être nommées en tant qu’administrateur,
mais dans ce cas, conformément à la loi luxembourgeoise, ils doivent désigner un représentant permanent qui doit être
une personne physique.
6.2 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
7. Réunions du conseil d’administration.
7.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être
nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
7.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
7.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée par procuration.
7.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration par un
autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter. Cette désignation devra être confirmée
par une lettre écrite.
7.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
7.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant
soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
7.7 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut
résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et
la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué. La date de
ces résolutions doit être la date de la dernière signature.
7.8 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou
par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
7.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
8. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique est investi
des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous
pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
9. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs
relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière
des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou
non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.
57633
Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux
à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et em-
ployés, et fixer leurs émoluments.
10. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-
trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.
11. Surveillance - Commissaire aux comptes. La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique. Ils sont nommés pour une période n'excédant pas six ans et
ils seront rééligibles; ils peuvent être révoqués à tout moment.
12. Assemblée générale des actionnaires.
12.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires
représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
12.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
12.3 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax
ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
autorisé à voter par procuration. Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires
par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme
présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
12.4 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
12.5 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des
Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.
12.6 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
13. Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville
de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième jeudi du mois de mai à 16.00 heures.
14. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée
générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
15. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale
des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
16. Année sociale.
16.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
16.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
17. Répartition des bénéfices.
17.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
17.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
17.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
18. Dissolution - Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires,
délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
57634
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale des actionnaires.
A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Adminis-
trateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
19. Référence à la loi. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Ninth resolutioni>
The sole shareholder resolves to fix the address of the Company at L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince
Henri, Grand-Duchy of Luxembourg.
<i>Tenth resolutioni>
The sole shareholder accepts the resignation of United International Trust NV as sole director, discharge is granted
to it for the execution of its mandate.
The sole shareholder resolves to fix the number of directors at three and to appoint the following persons as directors
of the Company until the annual general meeting of shareholders to be held in 2020:
1. Mr Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, residing at Ettelbruck.
2. Mr Jean-Hugues ANTOINE, accountant, with professional address at 9b, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxem-
bourg.
3. Mrs Carine REUTER-BONERT, employee, residing at Fennange.
<i>Eleventh resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint the following person as statutory auditor of the Company until the annual
general meeting of shareholders to be held in 2020:
RAMLUX S.A. having its registered office in L- 1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri and registered at the
Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under the number B 53.438
<i>Transitory provisioni>
1. By way of derogation of article 16 of the present articles of association, the Company’s current accounting year is
to run from the date of the present deed to December 31, 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders under Luxembourg Law shall be held in 2016.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10
th
1915 on commercial companies have been observed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR 2,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by its surname, Christian name, civil
status and residence, it have signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'AN DEUX MILLE QUINZE
LE VINGT-SIXIEME JOUR DU MOIS DE FEVRIER
Devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
A comparu:
ABINGDON S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 9B, Boulevard du Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, RCS Luxembourg B 191.450, ici dûment représentée par Monsieur Fons MANGEN, Réviseur
d’entreprises, résidant à Ettelbruck (Grand-Duché de Luxembourg), en vertu d'une procuration sous seing privé donnée
à Luxembourg le 25 février 2015
Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
pour être enregistrée en même temps.
Le comparant, représenté comme dit ci-dessus, a demandé au Notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
57635
ABINGDON S.A. est l’associé unique de PHARAOH CORPORATION N.V., une société de droit des Antilles Néer-
landaises, enregistrée à la Chambre de Commerce à Curaçao sous le numéro 100.493 et ayant son siège social à Landhuis
Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O. Box 837, Willemstad Curaçao, Antilles Néerlandaises, ci-après dénommée «La
société», constituée sous le droit des Antilles néerlandaises, suivant un acte passé devant Maître Rudolf Johannes Antony
Palm, notaire à Curaçao, le 20 avril 1990.
L’actionnaire unique ABINGDON S.A. détenant la totalité des 26.000 actions de la société, est dûment représentée
à la présente assemblée qui est régulièrement constituée et peut décider valablement sur les points de l'ordre du jour
suivant, sans convocation préalable:
<i>Ordre du jouri>
1. Ratification des résolutions des actionnaires adoptées le 25 février 2015 qui ont décidé entre autres de transférer
le siège social de la Société de Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O. Box 837, Willemstad Curaçao, Antilles
Néerlandaises à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri et d’adopter la nationalité luxembourgeoise.
2. Reconnaitre le transfert du siège social et du siège de gestion administrative de la Société de Curaçao au Grand-
Duché de Luxembourg pour des raisons stratégiques et suite à des changements dans la législation en Curaçao, sans
dissolution de la Société et avec continuité de sa personnalité juridique à compter de la date du présent acte.
3. Approbation de la situation financière de la Société au 10 février 2015 en tant que bilan de clôture de la Société aux
Antilles Néerlandaises et bilan d’ouverture à Luxembourg
4. Approbation du rapport d'évaluation de la Société à la date du 18 février 2015, émis par FIDEWA-CLAR S.A.
5. Adopter à Luxembourg la forme juridique de société anonyme.
6. Suppression de la valeur nominale des actions et conversion de le devise d’expression du capital social de USD en
Euros au taux de change fixé par les «Foreign Exchange Rate» au 18 février 2015 à 1 USD= 0,8789.- EUR, à EUR 22.851,-
représenté par 26.000 actions sans désignation de valeur nominale. Allocation, en cas de besoin, de toute différence
résultant d’une variation éventuelle du cours de change à une réserve positive ou négative
7. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 8.149,- afin de le porter de son montant actuel de EUR 22.851,-
à EUR 31.000.-, sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable de chaque action, à souscrire
par l’actionnaire unique, par apport en numéraire.
8. Echange des 26.000 actions sans désignation de valeur nominale contre 31.000 actions d’une valeur nominale de
EUR 1.- chacune.
9. Adopter la dénomination sociale "Pharaoh Corporation SA".
10. Refonte complète des statuts pour les adapter à la loi luxembourgeoise.
11. Fixer le siège social de la Société à L - 1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.
12. Démission de United International Trust NV de son mandat d’administrateur unique et décharge pour l’exécution
de son mandat
13. Nomination des personnes suivantes comme administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui se tiendra en 2020:
Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Monsieur Jean-Hugues ANTOINE, comptable, demeurant professionnellement au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
Madame Carine REUTER-BONERT, employée privée, demeurant à Fennange.
14. Nomination pour la même période du commissaire aux comptes: RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724
Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri. Son mandat expirera à l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020.
15. Divers.
Après que ce qui précède ait été approuvé par l'actionnaire unique, représenté comme pré-mentionné, a pris les
résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique approuve et ratifie la résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
PHARAOH CORPORATION N.V. tenue à Curaçao le 25 février 2015, pour transférer le siège social et le siège de
gestion administrative de la Société de Landhuis Joonchi Kaya Richard J. Beaujon z/n, P.O. Box 837, Willemstad Curaçao,
Antilles Néerlandaises à L- 1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri à la date du présent acte et sans interruption
de la personnalité juridique
Une copie dudit procès-verbal restera, après avoir été signée ne varietur par le comparant et le notaire, annexée aux
présentes pour être formalisée avec elles.
Il est décidé d'adopter la nationalité luxembourgeoise et de soumettre la Société aux lois du Grand -Duché de Lu-
xembourg à partir de la date du présent acte.
La Société étant une N.V., ce qui est équivalent à une S.A., l’actionnaire unique décide, pour l'application de la loi du
10 Août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, d’adopter la forme juridique d’une société anonyme.
57636
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique décide d’approuver la situation financière de la Société au 10 février 2015 en tant que bilan de
clôture de la Société aux Antilles Néerlandaises et bilan d’ouverture à Luxembourg, ledit bilan montrant un actif net de
USD 705.862,-
Ledit bilan d’ouverture et de clôture, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de l’actionnaire unique et le
notaire instrumentant, restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
<i>Troisième résolutioni>
L’actionnaire unique décide d’adopter le rapport établi en vue du transfert de la Société et conformément aux articles
26-1 et 32-1 de la loi du 10 Août 1915 sur les sociétés commerciales par FIDEWA-CLAR, Réviseur d’entreprises, ayant
son siège social à Luxembourg, en date du 18 février 2015.Sur base des principes comptables généralement reconnus, il
ressort de ce rapport qu’ à cette date, la valeur de l'actif net de la Société s'élève à au moins USD 705.862,-.
Ledit rapport contient la conclusion suivante:
«Sans remettre en cause notre conclusion, nous attirons votre attention sur le fait qu’un montant minimal de EUR
8.149 devra être versé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire devant statuer sur la transformation de PHARAOH
CORPORATION S.A. pour atteindre le minimum de capital requis pour la constitution d’une société anonyme.
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention hormis le point énoncé ci-dessus, qui nous laisse
à penser que la valeur globale de l’actif net au 10 février 2015 de la société PHARAOH CORPORATION S.A. ne cor-
respond pas au moins au capital minimum requis pour la constitution d’une société anonyme.»
Ledit rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire de l’actionnaire unique et le notaire instrumentant,
restera annexé aux présentes pour être enregistré avec elles.
<i>Quatrième résolutioni>
L’assemblée générale décide de supprimer la valeur nominale des actions.
Il résulte du rapport du réviseur d’entreprises que la valeur nette de la Société est de USD 705.862,-et que le capital
actuel de la société est de USD 26.000,-.
Il est décidé de convertir le capital social de USD en EUR, au taux de change fixé par «Foreign Exchange Rates» du 18
février 2015 à 1 USD= 0,8789 EUR. Sur base de cette conversion, le montant du capital est fixé à EUR 22.851,- (vingt-
deux mille huit cent cinquante et un Euros) représenté par 26.000 (vingt-six mille) actions sans désignation de valeur
nominale.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 8.149,- (huit mille cent quarante-neuf
euros), pour le porter de son montant actuel de EUR 22.851,- (vingt-deux mille huit cent cinquante et un Euros) à EUR
31.000.- (trente et un mille euros), sans émission d’actions nouvelles, mais par augmentation du pair comptable de chaque
action, à souscrire par l’actionnaire unique, par apport en numéraire.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Ensuite l’actionnaire unique, représenté par Monsieur Fons MANGEN, prénommé, en vertu de d’une procuration dont
mention ci-avant;
a déclaré souscrire à l’augmentation de capital et la libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès
maintenant à sa libre et entière disposition la somme de EUR 8.149,- (huit mille cent quarante-neuf euros), ainsi qu'il en
a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Sixième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de fixer une nouvelle valeur nominale de EUR 1,- (un Euro) par action et d’échanger les
26.000 actions sans désignation de valeur nominale contre 31.000 actions d’une valeur nominale de EUR 1.- (un euro)
chacune.
<i>Septième résolutioni>
Il est décidé par ailleurs que la Société adopte la dénomination sociale «Pharaoh Corporation S.A.».
<i>Huitième résolutioni>
L’actionnaire unique décide d’adapter les statuts de la société à la législation luxembourgeoise et aux résolutions ci-
dessus.
Les statuts sont rédigés en langue française et auront désormais la teneur suivante.
STATUTS
1. Nom.
1. Le nom ou dénomination de la Société est: «PHARAOH CORPORATION S.A.».
57637
2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg- Ville, Grand-Duché de Luxembourg.
2.2. Le siège social pourra être transféré dans la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'adminis-
tration. Le siège social pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
des actionnaires modifiant les statuts de l'association.
2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre
l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert,
conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera prise par le Conseil d’Ad-
ministration.
2.4. La Société peut avoir des bureaux et des succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3. Objet social.
3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises com-
merciales, industrielles, financières, immobilières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres
et droits par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de
toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux
entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opé-
rations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte
avec tous les secteurs pré-décrits, de manière à en faciliter l'accomplissement. La société peut dans ce cadre consentir
des emprunts, le cas échéant, représentés par des obligations ou autres titres de créance.
4. Durée.
4. La Société est constituée pour une durée illimitée.
5. Capital et actions.
5.1. Le capital social souscrit est fixé à EUR 31.000.- (trente et un mille Euros), divisé en 31.000 (trente et un mille)
actions d'une valeur nominale de EUR 1.- (un Euro) chacune.
5.2. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.
5.3. La société pourra racheter ses propres actions en observant les conditions prévues par la loi.
5.4. Usufruit et Nue-Propriété: Il est expressément prévu que la titularité de chaque action représentative du capital
social souscrit pourra être exercée soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier»
et en nue-propriété par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».Les droits attachés à la qualité d’usufruitier et
conférés pour chaque action sont les suivants:
- droits de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, sauf pour l’assemblée se prononçant sur la
mise en liquidation de la société.
- droit aux dividendes.
5.5. Nature des actions: Les actions sont et resteront nominatives.
5.6. Versements: Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription pourront
se faire aux dates et aux conditions que le conseil d’administration déterminera de temps à autres. Tout versement appelé
s’impute à parts égales sur l’ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.
6. Conseil d’administration.
6.1. La Société est gérée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, qui n'ont pas besoin
d'être actionnaires. Toutefois, dans le cas où la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, s'il est constaté
lors d'une assemblée générale des actionnaires que la Société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à un (1) membre jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire en reconnaissant
que la Société a plus d'un actionnaire. Les personnes morales peuvent également être nommées en tant qu’administrateur,
mais dans ce cas, conformément à la loi luxembourgeoise, ils doivent désigner un représentant permanent qui doit être
une personne physique.
6.2 Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une
période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu’à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.
En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs
restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.
57638
7. Réunions du conseil d’administration.
7.1 Le Conseil d’Administration élira parmi ses membres un président (le «Président»). Le premier Président peut être
nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du Président, il sera remplacé par
l'Administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.
7.2 Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président ou d’un Administrateur. Lorsque tous les
Administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux formalités de convocation.
7.3 Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente
ou représentée par procuration.
7.4 Tout Administrateur est autorisé à se faire représenter lors d’une réunion du Conseil d’Administration par un
autre Administrateur, pour autant que ce dernier soit en possession d’une procuration écrite. Un Administrateur peut
également désigner par téléphone un autre Administrateur pour le représenter.
Cette désignation devra être confirmée par une lettre écrite.
7.5 Toute décision du Conseil d’Administration est prise à la majorité simple des votes émis. En cas de partage, la voix
du Président est prépondérante.
7.6 L’utilisation de la vidéo conférence et de conférence téléphonique est autorisée pour autant que chaque participant
soit en mesure de prendre activement part à la réunion, c’est à dire notamment d’entendre et d’être entendu par tous
les autres Administrateurs participant et utilisant ce type de technologie, seront réputés présents à la réunion et seront
habilités à prendre part au vote via le téléphone ou la vidéo.
7.7 Des résolutions du Conseil d’Administration peuvent être prises valablement par voie circulaire si elles sont signées
et approuvées par écrit par tous les Administrateurs personnellement (résolution circulaire). Cette approbation peut
résulter d’un seul ou de plusieurs documents séparés transmis par fax ou e-mail. Ces décisions auront le même effet et
la même validité que des décisions votées lors d’une réunion du Conseil d’Administration, dûment convoqué. La date de
ces résolutions doit être la date de la dernière signature.
7.8 Les votes pourront également s’exprimer par tout autre moyen généralement quelconque tel que fax, e-mail ou
par téléphone, dans cette dernière hypothèse, le vote devra être confirmé par écrit.
7.9 Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’Administration sont signés par tous les membres présents aux
séances. Des extraits seront certifiés par le président du Conseil d’Administration ou par deux Administrateurs.
8. Pouvoirs généraux du conseil d’administration. Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique est investi
des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d’administration et de disposition dans l’intérêt de la Société. Tous
pouvoirs que la loi ne réserve pas expressément à l’assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil
d’Administration.
9. Délégation de pouvoirs. Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra déléguer ses pouvoirs
relatifs à la gestion journalière des affaires de la Société et à la représentation de la Société pour la conduite journalière
des affaires, à un ou plusieurs membres du Conseil d’Administration, directeurs, gérants et autres agents, associés ou
non, agissant à telles conditions et avec tels pouvoirs que le Conseil déterminera.
Le Conseil d’Administration ou l'Administrateur Unique pourra également conférer tous pouvoirs et mandats spéciaux
à toutes personnes qui n’ont pas besoin d’être Administrateurs, nommer et révoquer tous fondés de pouvoirs et em-
ployés, et fixer leurs émoluments.
10. Représentation de la société. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Adminis-
trateur Unique, par la signature unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature unique de toute personne à qui le pouvoir de signature
aura été délégué par deux Administrateurs ou par l'Administrateur Unique de la Société, mais seulement dans les limites
de ce pouvoir.
11. Surveillance - Commissaire aux comptes. La Société est contrôlée par un ou plusieurs commissaires aux comptes
nommés par l’assemblée générale ou l’actionnaire unique. Ils sont nommés pour une période n'excédant pas six ans et
ils seront rééligibles; ils peuvent être révoqués à tout moment.
12. Assemblée générale des actionnaires.
12.1 S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale
des actionnaires et prend les décisions par écrit. En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires
représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier
tous les actes relatifs à l’activité de la Société.
12.2 Toute assemblée générale sera convoquée par voie de lettres recommandées envoyées à chaque actionnaire
nominatif au moins quinze jours avant l’assemblée. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s’ils
déclarent avoir pris connaissance de l’agenda de l’assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convo-
cation ou de publication.
12.3 Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax
ou par e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent
57639
autorisé à voter par procuration. Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires
par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme
présent, pour les conditions de quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques
garantissant une participation effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
12.4 Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l’assemblée ordinaire des actionnaires
sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.
12.5 Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des
Statuts ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l’ordre
du jour indique les modifications statutaires proposées.
12.6 Cependant, la nationalité de la Société peut être changée et l’augmentation ou la réduction des engagements des
actionnaires ne peuvent être décidés qu’avec l’accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute autre
disposition légale.
13. Assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit chaque année dans la Ville
de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations le deuxième jeudi du mois de mai à 16.00 heures.
14. Autres assemblées générales. Tout Administrateur peut convoquer d'autres assemblées générales. Une assemblée
générale doit être convoquée sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.
15. Votes. Chaque action donne droit à une voix. Un actionnaire peut se faire représenter à toute assemblée générale
des actionnaires, y compris l’assemblée générale annuelle des actionnaires, par une autre personne désignée par écrit.
16. Année sociale.
16.1 L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de la même année.
16.2 Le Conseil d’Administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport
sur les opérations de la Société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, aux réviseurs
d’entreprises qui commenteront ces documents dans leur rapport.
17. Répartition des bénéfices.
17.1 Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital
social.
17.2 Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale des actionnaires décide de la répartition et de la distri-
bution du solde des bénéfices nets.
17.3 Le Conseil d’Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions
prescrites par la loi.
18. Dissolution - Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l'assemblée générale des actionnaires,
délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des Statuts.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés
par l'assemblée générale des actionnaires.
A défaut de nomination de liquidateurs par l'assemblée générale des actionnaires, les Administrateurs ou l'Adminis-
trateur Unique seront considérés comme liquidateurs à l'égard des tiers.
19. Référence à la loi. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où
il n'y a pas été dérogé par les présents Statuts.
<i>Neuvième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de fixer le siège de la Société à L-1724 Luxembourg, 9B, Boulevard du Prince Henri.
<i>Dixième résolutioni>
L’actionnaire unique accepte la démission de United International Trust N.V. en tant qu’administrateur unique, dé-
charge lui est donnée pour l’exécution de son mandat:
L’actionnaire unique décide de fixer le nombre des administrateurs à trois et de nommer les personnes suivantes
comme administrateurs de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020:
- Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d'entreprises, demeurant à Ettelbruck.
Monsieur Jean-Hugues ANTOINE, comptable, demeurant professionnellement au 9b, boulevard Prince Henri, L-1724
Luxembourg.
Madame Carine REUTER-BONERT, employée privée, demeurant à Fennange.
<i>Onzième résolutioni>
L'assemblée générale décide de nommer la personne suivante comme auditeur de la Société jusqu'à l'assemblée gé-
nérale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2020:
57640
RAMLUX S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B 53.438.
Son mandat expirera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra en l’année 2020.
<i>Disposition transitoirei>
1. Par dérogation à l'article 16 des présents statuts, l'année comptable actuelle de la Société débute le jour du présent
acte et se termine le 31 décembre 2015
2. La première assemblée générale annuelle des actionnaires selon la Loi luxembourgeois se tiendra en 2016.
<i>Constatationi>
Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur
les sociétés commerciales ont été accomplies.
<i>Coûtsi>
Le montant global des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
société ou pour lesquels il est responsable en raison du présent acte, à environ EUR 2.000,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle français et qu'à l'anglais et sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en anglais suivi par une traduction française. et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. MANGEN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6282. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015046024/623.
(150051416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
I-Invest Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 5, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 195.553.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le deux mars.
Par-devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Luxembourg
A comparu:
La société anonyme I-INVEST GROUP S.A., avec siège social à L-1637 Luxembourg, 5 rue Goethe, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186.991,
représentée par Monsieur Kevin Grégory DEMONTE, demeurant à B-4607 Dalhem (Belgique), 5 rue sur le Bois,
agissant en sa qualité d'administrateur-délégué, nommé à ces fonctions lors de l'assemblée générale extraordinaire con-
sécutive au prédit acte de constitution du 26 juin 2014 et habilité à engager ladite société par sa seule signature.
La partie comparante, a prié le notaire instrumentant d'acter de la façon suivante les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qui est ainsi constituée:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes sortes de prestations dans le domaine du
management, de consultance, de gestion administrative, ressources humaines, ventes de produits divers, vente de produits
publicitaires, vente de produits liés au net.
D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures et faire toutes opérations commerciales, industrielles
et financières, tant mobilières qu'immobilières dans tous secteurs, qui peuvent lui paraître utiles à l'accomplissement et
au développement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de «I-INVEST MANAGEMENT», société à responsabilité limitée.
57641
Art. 4. Le siège social est établi dans la Commune de Luxembourg-Ville.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500,00) représenté par cent (100) parts sociales
d'une valeur nominale de cent-vingt-cinq euros (EUR 125.-) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mil quinze.
<i>Souscription et libérationi>
Les cent parts sociales sont souscrites par la société anonyme I-INVEST GROUP SA, avec siège social à L-1637 Lu-
xembourg, 5 rue Goethe, et inscrite au registre des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186991.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents euros (EUR 12.500,00.-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ce que les associés
reconnaissent expressément.
<i>Déclaration en matière de blanchimenti>
Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par
la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l'objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
57642
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l'article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de mille cent cinquante euros (1.150.-
euros). A l'égard du notaire instrumentant toutefois, toutes les parties comparantes sont tenues solidairement quant au
paiement des dits frais, ce qui est expressément reconnu par toutes les parties comparantes.
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l'instant les parties comparantes pré qualifiées, représentées comme dit ci-avant, et représentant l'intégralité du
capital social, se considérant comme dûment convoquées, se sont constituées en assemblée générale extraordinaire et,
après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. Le nombre des gérants est fixé à un.
2. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
La société anonyme I-INVEST GROUP SA, avec siège social à L-1637 Luxembourg, 5 rue Goethe, et inscrite au registre
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B186991
La société est engagée, en toutes circonstances y compris toutes opérations bancaires, par la signature individuelle du
gérant.
3. L'adresse de la société est fixée à L-1637 Luxembourg, 5 rue Goethe.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant a encore rendu les comparants attentifs au fait que l'exercice d'une activité commerciale
peut nécessiter une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social, et qu'il y a lieu de
se renseigner en ce sens auprès des autorités administratives compétentes avant de débuter l'activité de la société pré-
sentement constituée.
Après lecture faite et interprétation donnée à la partie comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état
et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signés: K. DEMONTE, K. REUTER.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4740. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): P. MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME
LUXEMBOURG, le 24 mars 2015.
Référence de publication: 2015045842/107.
(150052232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.
Tanin Export S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 75.722.
L'an deux mille quinze, le onze mars.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-
mination de "TANIN EXPORT S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 75722, ayant son siège social au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 12 mai 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
640 du 7 septembre 2000.
Les statuts de la société ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois par acte du même notaire en date du
23 novembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2450 du 30 décembre 2006.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au
18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée profession-
nellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74,
avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.
Monsieur le Président expose ensuite:
57643
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les quatre cents (400)
actions d'une valeur nominale de cinq cents euros (EUR 500,-) chacune, représentant l’intégralité du capital social de deux
cent mille euros (EUR 200.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l’ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l’enregistrement.
II.- Que l’ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l’exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l’ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l.,
inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à
l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales. En conséquence, il est mis fin au mandat
des administrateurs.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour et personne ne demandant la parole, l’Assemblée s'est terminée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Zianveni, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 mars 2015. 2LAC/2015/5390. Reçu douze euros (12.- €)
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Référence de publication: 2015042613/54.
(150048887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Sankaty European Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.541,20.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 173.880.
<i>Extrait de la résolution prise par l’associé unique de la Société En date du 20 mars 2015i>
En date du 20 mars 2015, l’associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d’accepter la démission de Grindale Gamboa de son mandat de Gérant de classe B de la Société avec effet au 20
mars 2015;
- de nommer Dimitri Nys, né le 12 octobre 1984 à Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant comme adresse professionnelle:
4 rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de classe B de la Société avec effet au 20 mars 2015
et ce pour une durée indéterminée.
Depuis cette date, le Conseil de Gérance de la Société se compose des personnes suivantes:
- Ranesh Ramanathan, gérant de classe A
- Sally Fassler, gérant de classe A
- Myleen Tapawan Basilio, gérant de classe B
- Dimitri Nys, gérant de classe B
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044679/21.
(150050995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
57644
Partners Group Real Estate Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions
sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 2, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 146.205.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den elften März.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
IST ERSCHIENEN:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Partners Group Management II S.à r.l., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 2,
rue Jean Monnet, H.G.R. Luxemburg Nummer B 140257,
hier ordnungsgemäß vertreten durch Frau Arlette Siebenaler, Privatangestellte, geschäftsansässig in Luxemburg,
auf Grund eines Zirkularbeschluss der Partners Group Management II S.à r.l., welcher gegenwärtiger Urkunde als
Anlage beigefügt bleibt.
Die Komparentin handelt in ihrer Eigenschaft als Manager der Kommanditaktiengesellschaft Partners Group Real Estate
Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR, mit Sitz in L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet.
Die Komparentin, handelnd wie vorerwähnt, hat den amtierenden Notar ersucht folgende Feststellungen zu beur-
kunden:
I.- Die Gesellschaft Partners Group Real Estate Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR (hiernach "Gesellschaft"), mit
Sitz in L-2180 Luxemburg, 2, rue Jean Monnet, RCS Luxemburg Nummer B 146205, wurde gegründet gemäß Urkunde
aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit dem Amtssitz in Luxemburg, am 8. Mai 2009, veröffentlicht im Mé-
morial C Nummer 1095 vom 3. Juni 2009. Die Satzung wurde zuletzt abgeändert gemäß notarieller Urkunde vom 26. Juni
2014, veröffentlicht im Mémorial C, Nummer 2586 vom 24. September 2014.
II.- Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 6.671.902,358 (sechs Millionen sechshunderteinundsiebzigtausend
neunhundertzwei Komma dreihundertachtundfünfzig Euro) eingeteilt in 6.070.882,970 (sechs Millionen siebzigtausend
achthundertzweiundachtzig Komma neunhundertsiebzig) Manager-Aktien und 601.019,388 (sechshunderteintausend
neunzehn Komma dreihundertachtundachtzig) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-EUR) pro Aktie,
ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Euro (999,- EUR) pro Aktie.
III.- Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Aktienkapital von zehn Millionen Euro (10.000.000,- EUR) und ist aufgeteilt
in:
- fünf Millionen (5.000.000) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie; und
- fünf Millionen (5.000.000) Manager-Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,- EUR) pro Aktie.
IV.- Artikel 5 der Satzung, welcher die Voraussetzungen für ein genehmigtes Kapital schafft, beinhaltet folgende sach-
dienliche Angaben:
Der Manager ist berechtigt, im Rahmen der betraglichen Begrenzung des genehmigten Aktienkapitals Aktien wie folgt
auszugeben:
- jede Stammaktie wird zu einem Zeichnungspreis von insgesamt ein tausend Euro (1.000,- EUR) ausgegeben (d.h.
Nominalwert von 1,- EUR zuzüglich Emissionsagio von 999,- EUR); und
- jede Manager-Aktie wird zu einem Zeichnungsbetrag von einem Euro (1,- EUR) zuzüglich Emissionsagio von null (0)
bis einem (1,-) Euro ausgegeben.
Die Gesamtsumme der von einem Gesellschaftsinvestor an die Gesellschaft getätigten Zahlungen (d.h. Nominalwert
und Emissionsagio) werden als "Kapitaleinlagen" bezeichnet.
Der Manager kann im Rahmen des genehmigten Kapitals bis zum 26. Juni 2019 Aktien ausgeben. Diese Periode kann
jedoch durch Aktionärsbeschluss, der gemäß den Regeln für die Änderung dieser Satzungen gefasst wurde, verlängert
werden.
Der im Namen der Gesellschaft handelnde Manager verfügt über eine umfassende Kompetenz, das Vorgehen bei der
Aufnahme von Investoren, bei Kapitalabrufen und bei Zahlungen, die auf Kapitalabrufe folgen, zu regeln.
V.- Gemäß Beschluss vom 11. Dezember 2014 hat der Manager entschieden, im Rahmen des genehmigten Kapitals,
das Gesellschaftskapital um EUR 153.143,100 (einhundertdreiundfünfzigtausend einhundertdreiundvierzig Komma ein-
hundert Euro) zu erhöhen, durch die Ausgabe von:
- 13.795,420 (dreizehntausend siebenhundertfünfundneunzig Komma vierhundertzwanzig) neuen Stammaktien mit ei-
nem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben mit einem Emissionsagio von EUR 999.- (neunhundertneu-
nundneunzig Euro),
- 139.347,680 (einhundertneununddreißigtausend dreihundertsiebenundvierzig Komma sechshundertachtzig) Mana-
ger-Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (1,- EUR), ausgegeben ohne Emissionsagio.
Die Zeichnung und die Einzahlung der neuen Aktien ergeben sich aus den Zeichnungs- und Einzahlungsbelegen über-
mittelt durch die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, und der Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar erbracht,
57645
dass die Gesellschaft von den Zeichnern im Verhältnis ihrer Zeichnung, den Gesamtbetrag von EUR 13.934.767,68 (drei-
zehn Millionen neunhundertvierunddreissigtausend siebenhundersiebenundsechzig Euro und achtundsechzig Cent) erhal-
ten hat.
VI.- Dass aufgrund des oben genannten Beschlusses, der Manager beschließt Paragraph (b) von Artikel 5 der Satzung
abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:
Art. 5. Aktienkapital (Paragraph b).
(b) Die Gesellschaft hat ein Aktienkapital von EUR 6.825.045,458 (sechs Millionen achthundertfünfundzwanzigtausend
fünfundvierzig Komma vierhundertachtundfünfzig Euro) eingeteilt in 6.210.230,650 (sechs Millionen zweihundertzehn-
tausend zweihundertdreißig Komma sechshundertfünfzig) Manager-Aktien und 614.814,808 (sechshundertvierzehntau-
send achthundertvierzehn Komma achthundertacht) Stammaktien mit einem Nominalwert von einem Euro (1,-EUR) pro
Aktie, ausgegeben mit einem Emissionsagio von neunhundertneunundneunzig Euro (999,- EUR) pro Aktie.
Englische Version von Artikel, Paragraph b)
Art. 5. Share capital (paragraph b).
(b) The Corporation has a capital of EUR 6,825,045.458 (six million eight hundred and twenty-five thousand forty-five
point four hundred and fifty-eight) represented by 6,210,230.650 (six million two hundred and ten thousand two hundred
and thirty point six hundred and fifty Manager Shares and 614,814.808 (six hundred and fourteen thousand eight hundred
fourteen point eight hundred and eight) Ordinary Shares of a par value of EUR 1.- (one Euro) per Share and a share
premium of EUR 999.- (nine hundred ninety-nine Euro).
<i>Kosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr EUR
5.500.- abgeschätzt.
WORÜBER URKUNDE, errichtet wurde in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen,
Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.
Gezeichnet: A. SIEBENALER, und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8425. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 20. März 2015.
Référence de publication: 2015044639/89.
(150050878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Nordea Life & Pensions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 562, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 35.996.
<i>Extrait rectificatif concernant la modification déposée le 19 mars 2015 sous la référence L150050067i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 19 mars 2015 sous la
référence L150050067.
Les mandats des nouveaux administrateurs de la Société:
- Monsieur Lars KORNMOD (administrateur);
- Monsieur Johan NYSTEDT (administrateur) et
- Monsieur Leif RAANES (administrateur et président du conseil d'administration)
prendront fin lors de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'année 2014 et pas 2015.
Toutes autres mentions de la publication demeurent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
NORDEA LIFE & PENSIONS S.A.
Signature
Référence de publication: 2015044603/21.
(150050488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
57646
Tannenberg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.
R.C.S. Luxembourg B 124.826.
Der Alleinige Anteilsinhaber der Gesellschaft, Mars Holdco 1 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (so-
ciété à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce
et des Sociétés) unter Nummer B122122 hielt alle Anteile an der Gesellschaft (500 Gesellschaftsanteile mit je einem
Nominalwert von 25,- EUR).
Mars Holdco 1 S.à r.l. hat mit Urkunde vom 11. und 12. Februar 2015, geändert durch Urkunde vom 11. März 2015
(der Übertragungs-und Veräußerungsvertrag), (i) 421 Anteile an der Gesellschaft an Patrizia Basket LuxHoldCo S.à r.l.,
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz
in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesell-
schaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter Nummer B192964, veräußert und übertragen und (ii) 79
Anteile an der Gesellschaft an PATRIZIA Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) luxemburgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce
et des Sociétés) unter Nummer B181332, veräußert und übertragen.
Demnach resultiert aus dem Vollzug des Übertragungs- und Veräußerungsvertrag am 11. März 2015, dass (i) Patrizia
Basket LuxHoldCo S.à r.l. 421 Anteile an der Gesellschaft (mit je einem Nominalwert von 25,-EUR) und (ii) PATRIZIA
Res Publica Hessen I HoldCo S.à r.l. 79 Anteile an der Gesellschaft (mit je einem Nominalwert von 25,- EUR) halten.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
TANNENBERG S.À R.L.
<i>VERTRETERi>
Référence de publication: 2015044750/28.
(150050282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
PC EU Feeder V SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 195.422.
STATUTES
<i>Extrait de l'acte constitutif conformément à l'article 6 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiéei>
Name of the Partnership
PC EU Feeder V SCSp
Form of the Partnership
Special Limited Partnership (société en commandite spéciale)
Registered office
296-298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Name of the shareholders
with joint and several liability
PATRON CAPITAL EU FEEDER GP V S.à r.l., a private limited liability company (société
à responsabilité limitée), whose registered office is at 296-298, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500 and registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg) under number B 194783.
Purpose of the Partnership
The object of the Partnership is to carry on the business of an investor and, in particular
but without limitation, of identifying, negotiating, making, monitoring and realising
investments, and to carry out all the functions and acts in connection therewith.
Name of the general partner PATRON CAPITAL EU FEEDER GP V S.à r.l.
Management power and
representative capacity
of the general partner
The Partnership and its asset will be managed exclusively by the general partner.
Commencement date
5 March 2015
Terminate Date
The Partnership shall terminate on the 10 year anniversary of its commencement which
will occur on 5 March 2025.
The PC EU Feeder V SCSp partnership agreement extract has been drawn up in English and is followed by a French
translation, in case of discrepancies between the English and French version, the English version will prevail.
57647
Suit la traduction française du texte qui précède
Dénomination sociale
PC EU Feeder V SCSp
Forme légale
société en commandite spéciale
Siège social
296-298, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Nom des associés
solidaires (associé gérant
commandité)
PATRON CAPITAL EU FEEDER GP V S.à r.l, une société à responsabilité limitée, dont le
siège social est au 298 route de Longwy, L-1940 Luxembourg, ayant un capital social de
12.500 EUR et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 194783.
Objet social
L’objet de la Société est d’exercer les activités d’un investisseur et, particulièrement, mais
sans s’y limiter, d’identifier, négocier, effectuer et surveiller le progrès des investissements,
et d’exercer toutes les fonctions et actes y afférant.
Nom du gérant
PATRON CAPITAL EU FEEDER GP V S.à r.l
Pouvoir de signature du
gérant
La Société et ses actifs seront exclusivement gérer par l'associé gérant commandité.
Date de commencement 5 mars 2015
Date de fin
La Société prendra fin au 10
ème
anniversaire de son commencement, soit le 5 mars 2025.
L'extrait de l'acte constitutif de PC EU Feeder V SCSp a été dressé en langue anglaise et suivi d'une traduction en
langue française, en cas de différence entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
Référence de publication: 2015043134/48.
(150049587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.
MariTeam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 353, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.832.
Suite à une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 mars 2015 il a été convenu ce qui suit:
- La démission de Inter-Haus-Luxembourg S.A., en sa qualité d'administrateur est acceptée, avec effet immédiat.
- La démission de Mme Claudine Jander, en sa qualité d'administrateur est acceptée, avec effet immédiat.
- Election des nouveaux administrateurs:
Fiduciaire de Trèves S.C., 70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
- M. Jann Driebold, 353, route de Longwy, L - 1941 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
- Le mandat d'administrateur:
Mme Andrea Thielenhaus
est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
<i>Délégué à la gestion journalière:i>
- Le mandat de l'administrateur-délégué:
Mme Andrea Thielenhaus
est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
- Election d’un nouvel administrateur-délégué
M. Jann Driebold, 353, route de Longwy, L - 1941 Luxembourg
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
- le mandat du commissaire:
AUTONOME DE REVISION
est renouvelé jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017
L’adresse du commissaire Autonome de Révision a été transféré au 70, Grand-Rue, L - 1660 Luxembourg en date du
1
er
mars 2012.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
MARITEAM S.A.
Référence de publication: 2015045229/32.
(150051269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
57648
3A Alternative Funds
Aberdeen Infrastructure Capital Holdings (France) S.à r.l.
Air Newco 3 S.à r.l.
Banco Popolare Luxembourg S.A.
Bourne Park Capital (Lux) S.A. SICAV - SIF
Cellmedia S.A.
DPI S.A.
Edinburgh Car Park S.à r.l.
Eurocash-Fund
Fermat 2 S.à r.l.
Fiduciaire Bovy Luxembourg S.à.r.l.
Frasia Holdings S.A.
I-Invest Management S.à.r.l.
II PM Luxembourg S.A.
ING International
IRK Secure Capital S.A.
ITACA Finance S.à r.l.
LB-Re
LBREM NW Holdings S.à r.l.
Managed Funds Portfolio
Mandarin Capital Partners II S.C.A. SICAR
MariTeam S.A.
Nordea Life & Pensions S.A.
Nouvel Horizon S.à r.l.
Partners Group Real Estate Secondary 2009 (Euro) S.C.A., SICAR
PC EU Feeder V SCSp
Pharaoh Corporation S.A.
Piscadera Investments S.A.
Pyramus S. à r.l.
Reload Master S.à r.l.
Rigond Finance S.à r.l.
Sankaty European Holdings S.à r.l.
Sogeho International S.A.
Storm Fund
Tanin Export S.A.
Tannenberg S.à r.l.
Timbercreek Real Estate Fund
Transports Neves S.à r.l.
Treveria Seven S.à r.l.
Vauban Management S.C.
VDC Invest S.A.
Venusia Real Estate Investment S.A.