This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1163
5 mai 2015
SOMMAIRE
2002-Propriété s.c.i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55823
AD Corporate Services S.à.r.l. . . . . . . . . . .
55824
Adrion Immobilière SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
55785
AMT Capital Holdings III - Société de Ti-
trisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55785
Assar Universum Architects S.A. . . . . . . . .
55823
Athena Private Equity 2 S.A. . . . . . . . . . . . .
55785
Atlantic Coast Company S.A. . . . . . . . . . . .
55785
Atoga S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55784
AWL Properties I S.C.S. SICAV-SIF . . . . .
55785
Becton Dickinson Management S.à r.l. . . .
55779
Bicafé Luxembourg s.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55780
Brunel Properties S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
55779
BtoBe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55780
CP Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55780
Dahlia Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55781
DBL Products S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55782
Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l. . . . . .
55786
Edinburgh Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55782
Elevate (BC) Manager S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
55808
Entreprise de Façades SECAR S.à r.l. . . . .
55778
European Property Lux FinCo 1 S.à r.l. . .
55780
Fondation Home Saint Jean . . . . . . . . . . . . .
55819
Fragil S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55817
Garavan S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55821
Hipoteca XII Lux S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55783
Hipoteca XI Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55782
Hipoteca XIV Lux S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
55783
Intersaco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55781
Jefna S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55780
Juky S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55781
Kiowatt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55781
Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Lu-
xembourg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55781
Lombard Odier Gateway . . . . . . . . . . . . . . .
55782
LYXOR Selection Fund . . . . . . . . . . . . . . . . .
55783
MariTeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55783
MariTeam S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55784
Mastercroft S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55784
Matterhorn Financing & Cy S.C.A. . . . . . . .
55784
SALT Generics S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55778
Samsonite International S.A. . . . . . . . . . . . .
55778
Sarqua S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55778
SDTP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55822
Trinseo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55824
Wire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55819
Worrus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55779
Zeus Recovery Fund SA . . . . . . . . . . . . . . . .
55779
55777
L
U X E M B O U R G
SALT Generics S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 132.367.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015042578/14.
(150048838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Sarqua S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 154.218.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 16 mars 2015 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10 rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.
En outre, il est à noter que Monsieur Vincent WILLEMS, Madame Laurence BARDELLI et Monsieur Andrea DE MARIA
(actuels gérants), sont désormais domiciliés au 10, rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015042581/15.
(150048636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Samsonite International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 159.469.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Référence de publication: 2015042580/10.
(150048572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Entreprise de Façades SECAR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3311 Abweiler, 40, rue du Village.
R.C.S. Luxembourg B 9.966.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement du 8 janvier 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière
commerciale, a déclaré closes par liquidation les opérations de liquidation de la société:
ENTREPRISE DE FACADES SECAR S.à r.l., avec siège social à L-3311 Abweiler, 40, rue du Village, de fait inconnue à
cette adresse, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 9966.
Pour extrait conforme
Me Aziza GOMRI
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2015043446/15.
(150050050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
55778
L
U X E M B O U R G
Zeus Recovery Fund SA, Société Anonyme de Titrisation.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 140.679.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la Société en date du 17 mars 2015i>
<i>(«l’Assemblée»)i>
L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de catégorie B de la Société,
avec effet au 17 mars 2015 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2017:
- Daniel Geyer, né le 29 juillet 1971 à Lauchhammer, Allemagne, avec adresse professionnelle au Kurfürstendamm 57,
D-10707 Berlin, Allemagne.
A Luxembourg, le 17 mars 2015.
Pour extrait conforme
La Société
Signatures
Référence de publication: 2015043287/18.
(150049065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.
Worrus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 26, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 112.194.
<i>Extrait des décisions prises lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 12 mars 2015i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée accepte la démission du gérant de Catégorie A Madame Ferryal DABON, ayant son adresse profession-
nelle au 12, Place de la Défense, F-92400 Courbevoie, France. Son mandat a pris fin le 6 mars 2015.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer comme gérant de Catégorie A Monsieur Dmitry ERMAKOV, ayant son adresse privée
au 37, Basseynaya street, Apt. 70, RU196070 St-Petersburg, Russie, avec effet au 6 mars 2015. Son mandat est de durée
déterminée et prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2015.
Pour extrait
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015043280/17.
(150049637) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.
Brunel Properties S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 151.252.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015043384/10.
(150049748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Becton Dickinson Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 163.006.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015043377/9.
(150049966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
55779
L
U X E M B O U R G
BtoBe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8008 Strassen, 130, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 163.383.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange.
Carlo GOEDERT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015043385/12.
(150050333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Bicafé Luxembourg s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4480 Belvaux, 1-3, Chemin Rouge.
R.C.S. Luxembourg B 48.797.
Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015043390/10.
(150050210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
CP Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 47.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 180.963.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015043429/10.
(150050107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
European Property Lux FinCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 138.988.
Der Name der Teilhaberin der European Property Lux FinCo 1 S.à r.l. wurde geändert von iii European Property
SICAV-FIS in European Property SICAV-FIS.
Luxembourg, den 19.03.2015.
Référence de publication: 2015043469/10.
(150049790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Jefna S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 19, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 177.569.
Par la présente, je vous notifie ma démission en qualité de commissaire aux comptes de votre société à dater de ce
jour.
Weiswampach, le 16 mars 2015.
Verelst Luc
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015044511/12.
(150050490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55780
L
U X E M B O U R G
Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg), Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 47, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 155.462.
Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
KREDYT INKASO PORTFOLIO INVESTMENTS (LUXEMBOURG)
Signature
Référence de publication: 2015044517/12.
(150050632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Kiowatt S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7795 Bissen, 6, Op der Poukewiss.
R.C.S. Luxembourg B 143.047.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui s'est tenue au siège social à Bissen le 1
er
avril 2014
que:
L'Assemblée Générale nomme Messieurs Daniel Christnach, Pierre-Emile Kieffer et Paul Weis, les sociétés Interna-
tional Finance Services S.A., UCXA Management S.A. et Sogecondroz S.A. administrateurs de la société pour une durée
de 6 ans, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.
Référence de publication: 2015044519/12.
(150050581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Juky S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 94.261.
L'adresse professionnelle de l'administrateur et Président, Madame Ginevra ELKANN est dorénavant la suivante:
3, Via Corelli, I-00198 Rome
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044513/11.
(150050520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Intersaco S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 9.531.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044506/9.
(150050940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Dahlia Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.201.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Hesperange, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044352/10.
(150050944) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55781
L
U X E M B O U R G
DBL Products S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 156, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 36.066.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>Pour compte de DBL Products S.A.
i>Fiduplan S.A.
Référence de publication: 2015044362/12.
(150050423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Edinburgh Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 149.277.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015044374/12.
(150050987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Hipoteca XI Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 192.275.
EXTRAIT
En date du 20 février 2015, les associés de la Société ont décidé de transférer le siège social du 5C, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet au 20 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015044480/14.
(150050431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Lombard Odier Gateway, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 163.745.
Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Olivia TOURNIER
<i>Responsable juridique / Head of legali>
Référence de publication: 2015044528/16.
(150050693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55782
L
U X E M B O U R G
LYXOR Selection Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1616 Luxembourg, 28-32, place de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 118.801.
<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 13 mars 2015:i>
I. Démission de Monsieur Eric TALLEUX en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale des actionnaires prend note de la démission de Monsieur Eric TALLEUX, résidant profession-
nellement au 17 Cours Valmy, F-92987 Paris, France de sa fonction d'Administrateur, avec effet au 30 Octobre 2014.
II. Nomination de Monsieur Olivier GERMAIN en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration
L'Assemblée Générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Olivier GERMAIN, résidant professionnellement
au 17 Cours Valmy, F-92987 Paris, France de sa fonction d'Administrateur et ce jusqu'à la prochaine Assemblée Générale
Annuelle des Actionnaires.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044531/16.
(150050881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Hipoteca XIV Lux S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 194.889.
EXTRAIT
En date du 20 février 2015, les associés de la Société ont décidé de transférer le siège social du 5C, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet au 20 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015044483/14.
(150050428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Hipoteca XII Lux S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 193.586.
EXTRAIT
En date du 20 février 2015, les associés de la Société ont décidé de transférer le siège social du 5C, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg au 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet au 20 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015044481/14.
(150050430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
MariTeam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 353, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.832.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044556/10.
(150050753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55783
L
U X E M B O U R G
Mastercroft S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 186.304.
Il résulte des résolutions circulaires prises par le conseil de gérance de la Société en date du 18 mars 2015 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 18 mars 2015 au 1, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015044558/15.
(150050619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Matterhorn Financing & Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 171.751.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision des associés la Société en date du 20 février 2015, de:
- accepter la démission de Monsieur Alain STEICHEN en tant que commissaire de la Société avec effet 20 février 2015;
et
- nommer Madame Emilie BORDANEIL, née le 30 janvier 1981 à Perpignan, France, résidant professionnellement au
1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que commissaire de la Société
avec effet au 23 février 2015 et ce pour une durée déterminée de 6 ans.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044559/16.
(150051044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
MariTeam S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 353, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 107.832.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044557/10.
(150050754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Atoga S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.
R.C.S. Luxembourg B 178.263.
EXTRAIT
Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social en date du 19 mars 2015 que le siège social
de la société a été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.
En outre, il est à noter que Monsieur Vincent WILLEMS et Madame Laurence BARDELLI, actuels administrateurs, sont
désormais domicilié au 10, rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044890/13.
(150051122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
55784
L
U X E M B O U R G
Atlantic Coast Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 106.032.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23/03/2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015044889/12.
(150051634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Athena Private Equity 2 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 136.914.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
<i>Pour Athena Private Equity 2 S.A.
i>Fideco Luxembourg S.A.
Référence de publication: 2015044888/12.
(150051305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
AWL Properties I S.C.S. SICAV-SIF, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAV - Fonds
d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 187.497.
Les comptes annuels au 30 Septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 19 mars 2015.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015044895/12.
(150051577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
AMT Capital Holdings III - Société de Titrisation, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 181.843.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044870/9.
(150051325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Adrion Immobilière SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 169.400.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044857/9.
(150051867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
55785
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.956,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.430.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of March,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Digital Services XXXVI S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 194399,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter "Digital
Services XXXVI"),
being the holder of eleven thousand eight hundred two (11,802) shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its re-
gistered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter "Bambino 53. V V"),
being the holder of six hundred ninety-eight (698) shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015;
3. Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its sta-
tutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under
no. HRB 211601, having its business address at Adelgundenstrafte 23, 80538 Munich, Germany (hereinafter "Pallua UG"),
becoming the holder of three hundred forty-nine (349) Common Shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015;
4. Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its statutory
seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB
211832, having its business address at Herzog-Heinrich-Str. 40, 80336 Munich, Germany (hereinafter "Mehl UG"),
becoming the holder of three hundred forty-nine (349) Common Shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015;
5. Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its
statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under
no. HRB 214472, having its business address at Winzererstr. 29, 80797 Munich, Germany (hereinafter "Rothlehner UG"),
becoming the holder of three hundred forty-nine (349) Common Shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015;
6. Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its
statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under
no. HRB 216096, having its business address at Winzererstr. 29, 80797 Munich, Germany (hereinafter "Thurner UG"),
becoming the holder of three hundred forty-nine (349) Common Shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 12 March 2015; and
7. Florian Huber Beteiligungen GmbH, a limited liability company under the laws of Germany with its statutory seat
in Pocking, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich under number HRB 177215,
having its business address at Feldafinger Str. 5, 82343 Pocking, Germany (hereinafter "Huber GmbH"),
becoming the holder of sixty (60) Common Shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 13 March 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
55786
L
U X E M B O U R G
The parties under 1. and 2. (the "Existing Shareholders") are all the current shareholders of Digital Services XXXVI
(GP) S.à r.l. (the "Company"), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 194.430 and incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, on 7 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations. The articles of association have not been amended since.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Pallua UG,
Mehl UG, Rothlehner UG, Thurner UG and Huber GmbH participate and vote for the purpose of agenda point 9 et seqq.
only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) class of shares, referred to as the common shares (hereinafter the "Common Shares").
2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR
1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each,
without cancellation of shares.
3. Acceptance of Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany
with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany,
under no. HRB 211601, having its business address at Adelgundenstraße 23, 80538 Munich, Germany, as new shareholder
of the Company.
4. Acceptance of Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany
with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany,
under no. HRB 211832, having its business address at Herzog-Heinrich-Str. 40, 80336 Munich, Germany, as new share-
holder of the Company.
5. Acceptance of Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of
Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich,
Germany, under no. HRB 214472, having its business address at Winzererstr. 29, 80797 Munich, Germany, as new
shareholder of the Company.
6. Acceptance of Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschrànkt), a limited liability company under the laws of Ger-
many with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich,
Germany, under no. HRB 216096, having its business address at Winzererstr. 29, 80797 Munich, Germany, as new
shareholder of the Company.
7. Acceptance of Florian Huber Beteiligungen GmbH, a limited liability company under the laws of Germany with its
statutory seat in Pöcking, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich under number
HRB 177215, having its business address at Feldafinger Str. 5, 82343 Pocking, Germany, as new shareholder of the Com-
pany.
8. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand four hundred fifty-six (EUR 1,456) so as to
raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to thirteen thousand nine hundred
fifty-six euro (EUR 13,956) by issuing one thousand four hundred fifty-six (1,456) Common Shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1)each.
9. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand nine hundred fifty six Euros (EUR 13,956.00), represented
by thirteen thousand nine hundred fifty six (13,956) common shares (hereinafter "Common Shares"), with a nominal value
of one Euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association. "
10. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
XXXVI (GP) S.à r.l. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
55787
L
U X E M B O U R G
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand nine hundred fifty six Euros (EUR 13,956.00), represented
by thirteen thousand nine hundred fifty six (13,956) common shares (hereinafter "Common Shares"), with a nominal value
of one Euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
55788
L
U X E M B O U R G
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a "Super Majority") and subject to the provisions
of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Digital Services XXXVI
S.à r.l. ("Volo Holding") to a company affiliated to Volo Holding within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock
Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by Volo Holding to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) Volo Holding or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of Volo Holding (each a "Controlled Company"), whereas "Control" or "Controlled" or
"Controlling" shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (y) in which Volo Holding or one or more shareholders of Volo Holding has a direct or indirect
majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any of the shareholders pursuant to a call-option under a vesting
scheme.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.3 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
55789
L
U X E M B O U R G
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
55790
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-
holders (ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG))\
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term "sole manager" is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of managers" used in these articles of
association is to be construed as a reference to the "sole manager".
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance ²with the applicable legal provisions.
55791
L
U X E M B O U R G
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
21.8 The managers shall require the consent of Volo Holding for the legal transactions and measures specified below.
No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance been
approved by an adopted budget with the consent of Volo Holding:
21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros
(EUR 200,000.00) in aggregate;
21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,
however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;
21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such
shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
55792
L
U X E M B O U R G
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;
21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.
21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of Volo Holding. Volo Holding may give its consent also in advance for
certain groups and kinds of transactions and measures.
21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply at least in the
same manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present
or in the future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 24. Auditor(s).
24.1 In case and as long as the Company has more than twenty- five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
24.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
24.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (reviseur(s) d'entreprises agree
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
24.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
26.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
55793
L
U X E M B O U R G
26.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
26.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 29. Governing law.
29.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
29.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail."
11. Subsequently, decision to grant power to any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr
Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the shareholders'
register of the Company.
12. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) class of shares, referred to as the common shares
(hereinafter the "Common Shares").
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a
nominal value of one euro (EUR 1.00) each, without cancellation of shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability
company under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register
at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 211601, having its business address at Adelgundenstraße 23, 80538
Munich, Germany, as new shareholder of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited liability
company under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register
at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 211832, having its business address at Herzog-Heinrich-Str. 40,
80336 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.
55794
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited
liability company under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 214472, having its business address at Winzererstr. 29,
80797 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), a limited
liability company under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 216096, having its business address at Winzererstr. 29,
80797 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to accept Florian Huber Beteiligungen GmbH, a limited liability company
under the laws of Germany with its statutory seat in Pocking, Germany, registered with the commercial register at the
local court of Munich under number HRB 177215, having its business address at Feldafinger Str. 5, 82343 Pocking, Ger-
many, as new shareholder of the Company.
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of one thousand
four hundred fifty-six (EUR 1,456) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) up to thirteen thousand nine hundred fifty-six euro (EUR 13,956) by issuing one thousand four hundred fifty-six
(1,456) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand four hundred fifty-six (1,456) Common Shares have been subscribed as follows:
- three hundred forty-nine (349) Common Shares have been subscribed by Pallua UG, aforementioned, for the price
of nine hundred forty-nine euro (EUR 949);
- three hundred forty-nine (349) Common Shares have been subscribed by Mehl UG, aforementioned, for the price
of nine hundred forty-nine euro (EUR 949);
- three hundred forty-nine (349) Common Shares have been subscribed by Rothlehner UG, aforementioned, for the
price of nine hundred forty-nine euro (EUR 949);
- three hundred forty-nine (349) Common Shares have been subscribed by Thurner UG, aforementioned, for the price
of nine hundred forty-nine euro (EUR 949);
- sixty (60) Common Shares have been subscribed by Huber GmbH, aforementioned, for the price of one hundred
sixty-three euro (EUR 163).
<i>Paymenti>
The three hundred forty-nine (349) Common Shares subscribed by Pallua UG, aforementioned, have been entirely
paid up through:
(i) a contribution in cash in the amount of three hundred forty-nine euro (EUR 349); and
(ii) a contribution in kind in the amount of six hundred euro (EUR 600) consisting of one (1) share of Volo Logistics
UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Ger-
many, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 211947, having its
business address at Adelgundenstraße 23, 80538 München, Germany ("Volo Logistics") with a nominal value of six hundred
euro (EUR 600);
The three hundred forty-nine (349) Common Shares subscribed by Mehl UG, aforementioned, have been entirely paid
up through:
(i) a contribution in cash in the amount of three hundred forty-nine euro (EUR 349); and
(ii) a contribution in kind in the amount of six hundred euro (EUR 600) consisting of one (1) share of Volo Logistics
with a nominal value of six hundred euro (EUR 600);
The three hundred forty-nine (349) Common Shares subscribed by Rothlehner UG, aforementioned, have been en-
tirely paid up through:
(i) a contribution in cash in the amount of three hundred forty-nine euro (EUR 349); and
(ii) a contribution in kind in the amount of six hundred euro (EUR 600) consisting of one (1) share of Volo Logistics
with a nominal value of six hundred euro (EUR 600);
The three hundred forty-nine (349) Common Shares subscribed by Thurner UG, aforementioned, have been entirely
paid up through:
(i) a contribution in cash in the amount of three hundred forty-nine euro (EUR 349); and
55795
L
U X E M B O U R G
(ii) a contribution in kind in the amount of six hundred euro (EUR 600) consisting of one (1) share of Volo Logistics
with a nominal value of six hundred euro (EUR 600), with a nominal value of six hundred euro (EUR 600);
The sixty (60) Common Shares subscribed by Huber GmbH, aforementioned, have been entirely paid up through:
(i) a contribution in cash in the amount of sixty euro (EUR 60); and
(ii) a contribution in kind in the amount of one hundred three euro (EUR 103) consisting of one (1) share of Volo
Logistics with a nominal value of one hundred three euro (EUR 103).
The proofs of the existence and of the value of the above contributions have been produced to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of three thousand nine hundred fifty-nine euro (EUR 3,959) consists of
(i) one thousand four hundred fifty-six euro (EUR 1,456) paid in cash allocated to the share capital of the Company,
and
(ii) two thousand five hundred three euro (EUR 2,503) paid in kind allocated to the share premium account of the
Company.
<i>Ninth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to amend article five (5) of the articles of association of the Company
so that it shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand nine hundred fifty six Euros (EUR 13,956.00), represented
by thirteen thousand nine hundred fifty six (13,956) common shares (hereinafter "Common Shares"), with a nominal value
of one Euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association. "
<i>Tenth resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Eleventh resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby grants power to any manager of the Company, regardless of his category,
as well as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to update and sign solely, the
shareholders' register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 1,900.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten März,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Digital Services XXXVI S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit satzungsmäßigem Sitz in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 194399, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg (im Folgenden „Digital
Services XXXVI"),
Inhaberin von elftausendachthundertzwei (11.802) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015;
55796
L
U X E M B O U R G
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland (im Folgenden „Bambino 53. V V"),
Inhaberin von sechshundertachtundneunzig (698) Anteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015;
3. Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungs-
mäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter
der Nummer HRB 211601, mit Geschäftssitz in Adelgundenstraße 23, 80538 München, Deutschland (im Folgenden „Pallua
UG"),
zukünftige Inhaberin von dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015;
4. Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungs-
mäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter
der Nummer HRB 211832, mit Geschäftssitz in Herzog-Heinrich-Str. 40, 80336 München, Deutschland (im Folgenden
„Mehl UG"),
zukünftige Inhaberin von dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015;
5. Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht, mit sat-
zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRB 214472, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797 München, Deutschland (im Folgenden
„Rothlehner UG"),
zukünftige Inhaberin von dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015;
6. Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht, mit sat-
zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRB 216096, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797 München, Deutschland (im Folgenden
„Thurner UG"),
zukünftige Inhaberin von dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015; und
7. Florian Huber Beteiligungen GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht, mit sat-
zungsmäßigem Sitz in Pöcking, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter der
Nummer HRB 177215, mit Geschäftssitz in Feldafinger Str. 5, 82343 Pöcking, Deutschland (im Folgenden „Huber GmbH"),
zukünftige Inhaberin von sechzig (60) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 13. März 2015.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-
raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter") sind alle derzeitigen Gesellschafter der Digital Services
XXXVI (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft"), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der
Nummer B 194.430, gegründet am 7. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin, welche noch
nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde
seitdem nicht geändert.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei Pallua UG, Mehl UG, Rothlehner UG, Thurner UG und Huber GmbH ausschließlich für
die Punkte 9 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1 ) Klasse von Anteilen, die als Stammanteile (im Folgenden die „Stamm-
anteile") bezeichnet werden.
55797
L
U X E M B O U R G
2. Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von
je einem Euro.
3. Aufnahme von Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht,
mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 211601, mit Geschäftssitz in Adelgundenstraße 23, 80538 München, Deutschland, als neue
Gesellschafterin der Gesellschaft.
4. Aufnahme von Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht,
mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 211832, mit Geschäftssitz in Herzog-Heinrich-Str. 40, 80336 München, Deutschland, als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
5. Aufnahme von Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft nach deutschem
Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München,
Deutschland, unter der Nummer HRB 214472, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797 München, Deutschland, als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
6. Aufnahme von Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft nach deutschem
Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München,
Deutschland, unter der Nummer HRB 216096, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797 München, Deutschland, als
neue Gesellschafterin der Gesellschaft.
7. Aufnahme von Florian Huber Beteiligungen GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem
Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Pöcking, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München
unter der Nummer HRB 177215, mit Geschäftssitz in Feldafinger Str. 5, 82343 Pöcking, Deutschland, als neue Gesell-
schafterin der Gesellschaft.
8. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendvierhundertsechsundfünfzig Euro (EUR 1.456) auf einen Betrag von
dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig Euro (EUR 13.956) durch die Ausgabe von eintausendvierhundertsechsund-
fünfzig (1.456) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
9. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig Euro (EUR
13.956,00), bestehend aus dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig (13.956) Stammanteilen (im Folgenden die
„Stammanteile") mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden."
10. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l. (die „Gesellschaft"), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915") und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
55798
L
U X E M B O U R G
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig Euro (EUR
13.956,00), bestehend aus dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig (13.956) Stammanteilen (im Folgenden die
„Stammanteile") mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit") und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:
55799
L
U X E M B O U R G
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Digital Services XXXVI S.à r.l. („Volo Holding") an eine mit Volo Holding verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
Volo Holding an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) Volo Holding oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter von Volo Holding (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft") Kontrolliert, von diesem Kon-
trolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle" oder „Kontrolliert
Wird" oder „Kontrolliert" die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a) die Leitung
der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher Volo Holding oder
einer oder mehrere Gesellschafter von Volo Holding eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten,
welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen der
Gesellschafter gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung.
7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.3 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen
werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
55800
L
U X E M B O U R G
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-
zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung" in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in
der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
55801
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer" nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer"
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer" auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
55802
L
U X E M B O U R G
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung von Volo Holding für die unten genannten Rechtsgeschäfte und
Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und
im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung von Volo Holding genehmigt wurden:
21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-
hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;
21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-
wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
55803
L
U X E M B O U R G
21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft
an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;
21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.
Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß diesem Artikel 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;
21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Anteils-oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
von Volo Holding erfordern. Volo Holding kann ihre Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen
und Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
zumindest auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesell-
schaft direkt oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft
Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
24.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
24.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
24.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
55804
L
U X E M B O U R G
24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.
26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
26.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
26.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.
26.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
27.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht
Art. 29. Anwendbares Recht.
29.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
29.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend."
11. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie
Herrn Rüdiger Trox zu bevollmächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit unein-
geschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
12. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) Klasse von Anteilen zu schaffen, die als Stammanteile (die „Stamm-
anteile") bezeichnet werden.
55805
L
U X E M B O U R G
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Pallua Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesell-
schaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 211601, mit Geschäftssitz in Adelgundenstraße 23, 80538
München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Mehl Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesell-
schaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 211832, mit Geschäftssitz in Herzog-Heinrich-Str. 40,
80336 München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Rothlehner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmerge-
sellschaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 214472, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797
München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Thurner Beteiligungen UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesell-
schaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 216096, mit Geschäftssitz in Winzererstr. 29, 80797
München, Deutschland, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Florian Huber Beteiligungen GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Pöcking, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 177215, mit Geschäftssitz in Feldafinger Str. 5, 82343 Pöcking, Deutsch-
land, als neue Gesellschafterin der Gesellschaft aufzunehmen.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendvierhundertsechsundfünfzig Euro (EUR
1.456) auf einen Betrag von dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig Euro (EUR 13.956) durch die Ausgabe von
eintausendvierhundertsechsundfünfzig (1.456) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu
erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die eintausendvierhundertsechsundfünfzig (1.456) Stammanteile wurden wie folgt gezeichnet:
- dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden von Pallua UG, vorbenannt, zum Preis von neunhundert-
neunundvierzig Euro (EUR 949) gezeichnet;
- dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden von Mehl UG, vorbenannt, zum Preis von neunhundertneu-
nundvierzig Euro (EUR 949) gezeichnet;
- dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden von Rothlehner UG, vorbenannt, zum Preis von neunhun-
dertneunundvierzig Euro (EUR 949) gezeichnet;
- dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden von Thurner UG, vorbenannt, zum Preis von neunhundert-
neunundvierzig Euro (EUR 949) gezeichnet;
- sechzig (60) Stammanteile wurden von Huber GmbH, vorbenannt, zum Preis von einhundertdreiundsechzig Euro
(EUR 163) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Pallua UG, vorbenannt, gezeichneten dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden vollständig ein-
gezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe von dreihundertneunundvierzig Euro (EUR 349); und
55806
L
U X E M B O U R G
(ii) eine Sacheinlage im Wert von sechshundert Euro (EUR 600) bestehend aus einem (1) Anteil der Volo Logistics UG
(haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in München,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 211947,
mit Geschäftssitz in Adelgundenstraße 23, 80538 München, Deutschland („Volo Logistics") mit einem Nominalwert von
sechshundert Euro (EUR 600);
Die von Mehl UG, vorbenannt, gezeichneten dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden vollständig ein-
gezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe von dreihundertneunundvierzig Euro (EUR 349); und
(ii) eine Sacheinlage im Wert von sechshundert Euro (EUR 600) bestehend aus einem (1) Anteil der Volo Logistics mit
einem Nominalwert von sechshundert Euro (EUR 600);
Die von Rothlehner UG, vorbenannt, gezeichneten dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden vollständig
eingezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe von dreihundertneunundvierzig Euro (EUR 349); und
(ii) eine Sacheinlage im Wert von sechshundert Euro (EUR 600) bestehend aus einem (1) Anteil der Volo Logistics mit
einem Nominalwert von sechshundert Euro (EUR 600);
Die von Thurner UG, vorbenannt, gezeichneten dreihundertneunundvierzig (349) Stammanteile wurden vollständig
eingezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe von dreihundertneunundvierzig Euro (EUR 349); und
(ii) eine Sacheinlage im Wert von sechshundert Euro (EUR 600) bestehend aus einem (1) Anteil der Volo Logistics mit
einem Nominalwert von sechshundert Euro (EUR 600);
Die von Huber GmbH, vorbenannt, gezeichneten sechzig (60) Stammanteile wurden vollständig eingezahlt durch:
(i) eine Bareinlage in Höhe von sechzig Euro (EUR 60); und
(ii) eine Sacheinlage im Wert von einhundertdrei Euro (EUR 103) bestehend aus einem (1) Anteil der Volo Logistics
mit einem Nominalwert von einhundertdrei Euro (EUR 103).
Die Nachweise über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlagen wurden der unterzeichnenden Notarin
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von dreitausendneunhundertneunundfünfzig Euro (EUR 3.959) besteht aus
(i) eintausendvierhundertsechsundfünfzig Euro (EUR 1.456), die durch eine Bareinlage eingezahlt und dem Gesell-
schaftskapital der Gesellschaft zugeführt werden, und
(ii) zweitausendfünfhundertdrei Euro (EUR 2.503), die durch eine Sacheinlage eingezahlt und dem Agio der Gesellschaft
zugeführt werden.
<i>Neunter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig Euro (EUR
13.956,00), bestehend aus dreizehntausendneunhundertsechsundfünfzig (13.956) Stammanteilen (im Folgenden die
„Stammanteile") mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden."
<i>Zehnter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Elfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bevollmächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Ka-
tegorie, sowie Herrn Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung zu aktualisieren und alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 1.900,-. geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
55807
L
U X E M B O U R G
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/8237. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 19. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015044358/1233.
(150050309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Elevate (BC) Manager S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 195.446.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the third day of February.
Before us Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bain Capital Europe Fund IV, L.P., an exempted limited partnership, incorporated and existing under the laws of the
Cayman Islands, having its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street,
PO Box 309, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Part-
nerships in the Cayman Islands under number MC 73219,
here represented by Fanny Kindler, lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy.
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Elevate (BC) Manager S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 con-
cerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development
of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may also act as a partner/shareholder with unlimited or limited liability for the debts and obligations
of any Luxembourg or foreign entity.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
55808
L
U X E M B O U R G
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve
thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
55809
L
U X E M B O U R G
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager. In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal
incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time
not exceeding the initial mandate of the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of share-
holders which shall resolve on the permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
55810
L
U X E M B O U R G
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall have a casting vote.
17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signature of any two managers or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been
delegated by the board of managers within the limits of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
55811
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Bain Capital Europe Fund IV, L.P.,
aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five
hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company.
The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the
share capital.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,500.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, have passed the following resolutions:
1. The address of the registered office of the Company is set at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand
Duchy of Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:
(i) Ruth Springham, born in Johnstone, United Kingdom on 25 May 1961, professionally residing at 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg;
(ii) Michael Siefke, born in Damme, Germany on 1
st
July 1967, professionally residing at 4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, and
(iii) Aurélien Vasseur, born in Secun, France on 8 January 1976, professionally residing at 4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
55812
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française de ce qui précède.
L'an deux mille quinze, le trois février.
Par-devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Bain Capital Europe Fund IV, L.P., un exempted limited partnership constitué et existant sous les lois des Îles Caïmanes,
ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO Box 309, George
Town, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Caïmanes, enregistrée auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships des
Îles Caïmanes sous le numéro d'enregistrement MC 73219,
dûment représenté(e) par Fanny Kindler, avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une pro-
curation.
Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, resterait annexée au présent
acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée
qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:
A. Nom - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Nom - Forme. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Elevate (BC) Manager
S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que
modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-
bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.
2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière
des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.
2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute
forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.
2.4 La Société a également la possibilité d'agir en tant qu'associé ou actionnaire à responsabilité illimitée ou limitée
pour les dettes et les obligations de n'importe quelle entité luxembourgeoise ou étrangère.
2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété
intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.
Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée
selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être
transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.
4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision
du conseil de gérance.
4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-
nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
B. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cent euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq
cent (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
55813
L
U X E M B O U R G
5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés
de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.
5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.
Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre
événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé
pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.
7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant
unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.
7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle
cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.
7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après
l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.
7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé
sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant.
C. Décisions des associés
Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par
les présents statuts.
8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il
détient.
8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui
relèveraient d'ordinaire de la compétence de l'assemblée générale, pourront être valablement adoptées par voie de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.
8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des
dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.
Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une
assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations aux assemblées générales correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.
Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés
de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même ordre du jour et les
décisions sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-
ment unanime des associés.
55814
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)
représentant au moins les trois quarts du capital social.
D. Gérance
Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un
conseil de gérance.
13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas
expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».
13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre
toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération
et la durée de son (leur) mandat.
14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,
par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.
Art. 15. Vacance d'un poste de gérant. Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à
l'incapacité juridique, la faillite, la démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière
temporaire et pour une période ne pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants
jusqu'à la prochaine assemblée des associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispo-
sitions légales applicables.
Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues
au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.
16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)
heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.
16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés
à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.
Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner
un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.
17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son
absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.
17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme
son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des
membres du conseil de gérance.
17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par
tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.
17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est
présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.
17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil
de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.
55815
L
U X E M B O U R G
17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation
par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.
Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,
ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.
18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.
Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la
signature conjointe de deux gérants ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de
signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.
E. Audit et surveillance
Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société
seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.
20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des
associés.
20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69
de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.
20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif
ou avec son accord.
F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes
Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente-et-un décembre de la même année.
Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de
l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.
22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette
affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.
22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve
légale, si cet associé consent à cette affectation.
22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle
n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.
22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des
bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.
Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable
intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.
23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés
conformément à la Loi et aux présents statuts.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation. En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation
sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette
55816
L
U X E M B O U R G
dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs
disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.
H. Disposition finale - Loi applicable
Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.
<i>Dispositions transitoiresi>
1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.
<i>Souscription et paiementi>
Les douze mille cinq cent parts sociales émises ont été souscrites par Bain Capital Europe Fund IV, L.P., susmentionnée,
pour un prix de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500).
Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que
le montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société.
L'apport global d'un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.
<i>Fraisi>
Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ 1.500,- euros.
<i>Résolutions des associési>
Les associés fondateurs, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de
convocation, ont adopté les résolutions suivantes:
1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché
de Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:
(i) Ruth Springham, née à Johnstone, Royaume-Uni le 25 mai 1961, résidant professionnellement à 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg;
(ii) Michael Siefke, né à Damme, Germany le 1
er
juillet 1967, résidant professionnellement à 4, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg; et
(iii) Aurélien Vasseur, née à Secun, France le 8 janvier 1976, résidant professionnellement à 4, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg.
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande de la comparante que le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la même comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,
ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Kindler, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05 février 2015. Relation: EAC/2015/3031. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015044376/511.
(150050471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fragil S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 154.400.
L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme, qualifiée comme société
de gestion de patrimoine familial, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “FRAGIL S.A., SPF”, établie et ayant
son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
55817
L
U X E M B O U R G
section B, sous le numéro 154400, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du
16 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1788 du 1
er
septembre 2010,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 91, rue Cents.
Le Président désigne Madame Maria FIGUEIREDO, salariée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,
91, rue Cents, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Piu Lan LIU, salariée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue
Cents, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs
mandats respectifs;
3. Nomination de la société “NOXX s.à r.l.” en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société;
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “NOXX s.à r.l.”, établie et ayant son siège social à
L-3822 Schifflange, 29, rue de l'Eglise, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 158452, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
55818
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. VOGEL, M. FIGUEIREDO, P. L. LIU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5700. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Référence de publication: 2015044435/83.
(150050321) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Wire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.748.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société en date du 19 mars 2015i>
Les actionnaires de la Société ont décidé en date du 19 mars 2015:
1) de prononcer la clôture de la liquidation de la Société, et
2) que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans au 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2015.
<i>Pour la Société
i>Signes S.A.
Représentée par Vincent Goy
<i>Liquidateuri>
Référence de publication: 2015044791/19.
(150050467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fondation Home Saint Jean, Fondation.
Siège social: L-3503 Dudelange, 13, Um Kräitzbierg.
R.C.S. Luxembourg G 87.
<i>Bilan au 31 décembre 2014 2014i>
Actif
2014
2013
Caisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
590,09 €
30,00 €
CCP et comptes-courants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 325,96 €
2 828,54 €
Livret d'épargne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 000,63 €
2 499,51 €
Terrains y compris frais d'acte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 978,97 €
48 978,97€
Matériel et Immeuble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
923 030,95 €
922 785,99 €
Installation photo-voltaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 996,96 €
Locations chalet à recevoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
806,90 €
1 322,36 €
Autres actifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 749,92€
Total Actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 042 480,38 €
978 445,37 €
55819
L
U X E M B O U R G
Passif
Acomptes reçus locations chalets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 250,00 €
1 300,00 €
Financement installation photo-voltaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43 000,00 €
Réductions de valeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
503 904,43 €
479 570,64€
Apport guides et scouts St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
284 758,98 €
284 758,98 €
Fonds Home St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135 934,12 €
158 456,37 €
Réserve pour investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 100,00 €
Autres passifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175,09 €
Avoirs propres au 1
er
janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 359,37 €
65 693,50 €
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 998,40€
-11 334,13 €
Total Passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 042 480,39 €
978 445,36 €
<i>Pertes et Profits au 31 décembre 2014i>
Produits
2014
2013
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 608,47 €
687,07 €
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,75 €
30,18 €
Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 543,61 €
12 994,84 €
Recettes diverses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,65 €
10,14 €
Reprise du fonds Home St Jean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 522,25 €
20 665,41 €
Production électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 411,37 €
Total Produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 108,10 €
34 387,64 €
Charges
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 655,12 €
1 628,62 €
Frais d'exploitation chalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 495,19 €
5 399,29€
Réductions de valeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 767,21 €
38 605,06€
Frais et réductions de valeur inst. photo-voltaique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 582,64€
Dotation à la réserve pour investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 100,00 €
Autres frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
509,54 €
88,80 €
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 109,70 €
45 721,77€
Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 998,40 € -11 334,13 €
<i>Budget de fonctionnement 2015i>
Réalisé
2012
Réalisé
2013
Budget
2014
Réalisé
2014
Budget
2015
Dons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 707,37
687,07
700,00
13 608,47
500,00
Locations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 202,29
12 994,84
13 000,00
14 543,61
13 000,00
Intérêts créditeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8,75
Production électricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 411,37
5 000,00
Autres revenus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,65
Autres produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
422,52
40,32
300.00
2 433,77
5 000,00
Total Recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 332,18
13 722,23
14 000,00
30 585,85 18 500, 00
Frais courants chalet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 105,95
5 399,29
6 000,00
6 495,19
7 000,00
Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 589,19
1 628,62
1 675,00
1 655,12
1 700,00
Frais de bureau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00
192,60
100,00
Frais de banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71,50
82,80
80,00
77,70
100,00
Financement inst. Photovoltaique . . . . . . . . . . . . .
697,34
860,00
Frais inst. photov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318,73
500,00
Autres frais divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140,62
245,00
239,24
240,00
Autres frais généraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212,12
88,80
325,00
1 525,61
1 800,00
Total Charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 907,26
7 116,71
8 000,00
9 676,92
10 500,00
Résultat de fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 424,92
6 605,52
6 000,00
20 909,93
8 000,00
<i>Budget d'investissement 2015i>
Réalisé
2012
Réalisé
2013
Budget
2014
Réalisé
2014
Budget
2015
55820
L
U X E M B O U R G
Mise en sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 200,00
Equipement de cuisine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80,31
7 368,22
2 000,00
13100,00
Panneaux solaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 000,00
47241,92
Equipement chalet autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 859,21
10 571,43
3 000,00
244,96
7 000,00
Total Investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 939,52
17 939,65
60 000,00
47 486,88
26 300,00
Utilisation moyens propres . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 334,13
4 000,00
18 300,00
Solde budget de fonctionnement . . . . . . . . . . . . .
6 939,52
6 605,52
6 000,00
4 486,88
8 000,00
Excédent budget de fonctionnement . . . . . . . . . . .
485,40
16 423,05
Financement LGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 000,00
43 000,00
Financement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 424,92
17 939,65
60 000,00
63 909,93
26 300,00
Référence de publication: 2015044428/80.
(150051037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Garavan S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 156.123.
L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de mars;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme, qualifiée comme société
de gestion de patrimoine familial, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg “GARAVAN S.A., SPF”, établie et
ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 156123, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant,
en date du 12 octobre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2498 du 18 novembre
2010,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319
Luxembourg, 91, rue Cents.
Le Président désigne Madame Maria FIGUEIREDO, salariée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg,
91, rue Cents, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Piu Lan LIU, salariée, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 91, rue
Cents, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour l'exercice de leurs
mandats respectifs;
3. Nomination de la société “NOXX s.à r.l.” en tant que liquidateur en vue de la liquidation volontaire de la Société;
4. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et détermination de la procédure de mise en liquidation de la Société;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
55821
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l'exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L'Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d'exercer tout recours à l'encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société à responsabilité limitée “NOXX s.à r.l.”, établie et ayant son siège social à
L-3822 Schifflange, 29, rue de l'Eglise, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous
le numéro 158452, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l'ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l'article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l'assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l'article 148 de la Loi.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: G. VOGEL, M. FIGUEIREDO, P. L. LIU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 mars 2015. 2LAC/2015/5699. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Référence de publication: 2015044447/84.
(150050311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
SDTP, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2441 Luxembourg, 330, route de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 150.457.
Le bilan au 31/12/2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015042583/10.
(150048454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
55822
L
U X E M B O U R G
2002-Propriété s.c.i., Société Civile.
Siège social: L-3428 Dudelange, 105, rue de Boudersberg.
R.C.S. Luxembourg E 819.
DISSOLUTION
<i>Procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30.12.2013i>
Sont présent ou représentés:
a) Frank TRIERWEILER, associé gérant détenant 99 parts sociales
b) Chantai RISCH, associée gérant détenant 1 part sociale
Les associés présents ou représentés disposent ensemble de 75 sur les 75 parts formant le capital de la société.
Monsieur Frank Trierweiler préside la séance en qualité de gérant associé.
Le Président constate que les associés présents ou représentés possèdent ensemble au moins le quart des parts
sociales.
L'assemblée lui donne acte de ses déclarations et reconnaît la validité de la convocation.
<i>Ordre du jouri>
Les associés se sont réunis à la date du 30.12.13 en assemblée générale extraordinaire pour procéder à la liquidation
volontaire de la société civile immobilière 2002 Propriété s.c.i., selon l'ordre du jour suivant.
1. Nomination d'un liquidateur (Art 14.)
2. Dissolution/Liquidation volontaire de la société civile (Art 14.)
3. Publication des résolutions (Art 15.)
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale nomme Monsieur TRIERWEILER Frank comme liquidateur, conformément à l'art 14 des statuts
de la société civile.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
<i>Deuxième résolutioni>
La société civile immobilière sera définitivement dissolue avec effet à la date du 31.12.2013.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
<i>Troisième résolutioni>
Les frais de dissolution seront réglés par l'associé Frank Trierweiler
Cette résolution est approuvée à l'unanimité.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin
d'accomplir toutes les formalités consécutives aux décisions prises et de publier les résolutions prises ci-devant
De tout ceci, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la gérance, les associés présents
et les mandataires des associés représentés.
Cette résolution est approuvée à l'unanimité
Fait à Dudelange, le 30.12.2013.
Frank TRIERWEILER / Chantal RISCH
<i>Associé Gérant / Associée Géranti>
Référence de publication: 2015042096/42.
(150047860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Assar Universum Architects S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 79.287.
Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 20/03/2015.
Référence de publication: 2015044223/10.
(150050810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55823
L
U X E M B O U R G
AD Corporate Services S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 79.361.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société AD Corporate Services Sàrl tenue au siège de la sociétéi>
<i>en date du 2 février 2015i>
Tous les associés étant présents.
Les associés confirment:
- La cession des 63 parts sociales de Monsieur Jeffrey DAVIES, né le 15 mai 1950 à Swansea (Royaume-Uni) et de-
meurant au 77, rue Charlemagne à L - 1328 LUXEMBOURG
à
la société BVZ Luxembourg S.A., dont le siège social se situe au 165A, route de Longwy à L - 4751 PETANGE,
immatriculée au RCSL sous le numéro B181507
- La démission de Monsieur Jeffrey DAVIES du mandat de Gérant Technique et Administratif
- La nomination en tant que Gérant Technique de Monsieur Louis LIBART, né le 8 août 1982 à Bastogne (Belgique) et
demeurant professionnellement au 165A, Route de Longwy à L - 4751 PETANGE
- La nomination en tant que Gérant Administratif de Monsieur Thierry BECKRICH, né le 1
er
mai 1961 à Ixelles
(Belgique) et demeurant au 50, rue Baillet à B - 6761 LATOUR
La décision a été prise à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
AD CORPORATE SERVICES SARL
Louis LIBART / Jeffrey DAVIES
<i>Gérant Technique / -i>
Référence de publication: 2015044227/26.
(150050680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Trinseo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 153.549.
<i>Extrait des décisions de procès-verbal du conseil d'administration de la société pris en date du 19 février 2015i>
En date du 19 Février 2015, le conseil d'administration a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Monsieur Stephen Thomas de son mandat d'administrateur de la Société avec effet im-
médiat;
- de nommer Monsieur Donald Thomas Misheff, né le 11 Mai 1956 à Ohio, ayant comme adresse professionnelle 2960
Silver Lake Boulevard, Silver Lake, OH 44224, Etats-Unis en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet
immédiat en accordance d'art. 7.1.5 jusqu'à l'assemblée générale des associés qui se tiendra dans l'année 2015.
Depuis cette date, le Conseil d'administration de la Société se compose des personnes suivantes:
- Mr. Michel Plantevin
- Mr. Aurelien Vasseur
- Mr. Brian Chu
- Mr. Christopher Pappas
- Mr. Seth Meisel
- Mr. Stephen Zide
- Mr. Jeff Cote
- Mr Pierre-Marie De Leener
- Mr. Donald Thomas Misheff
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 Mars 2015.
Référence de publication: 2015043756/26.
(150049571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
55824
2002-Propriété s.c.i.
AD Corporate Services S.à.r.l.
Adrion Immobilière SA
AMT Capital Holdings III - Société de Titrisation
Assar Universum Architects S.A.
Athena Private Equity 2 S.A.
Atlantic Coast Company S.A.
Atoga S.A.
AWL Properties I S.C.S. SICAV-SIF
Becton Dickinson Management S.à r.l.
Bicafé Luxembourg s.à.r.l.
Brunel Properties S.àr.l.
BtoBe S.A.
CP Holdings S.à r.l.
Dahlia Gestion S.A.
DBL Products S.A.
Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l.
Edinburgh Office S.à r.l.
Elevate (BC) Manager S.à r.l.
Entreprise de Façades SECAR S.à r.l.
European Property Lux FinCo 1 S.à r.l.
Fondation Home Saint Jean
Fragil S.A., SPF
Garavan S.A., SPF
Hipoteca XII Lux S.àr.l.
Hipoteca XI Lux S.à r.l.
Hipoteca XIV Lux S.à.r.l.
Intersaco S.A.
Jefna S.A.
Juky S.A.
Kiowatt S.A.
Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg)
Lombard Odier Gateway
LYXOR Selection Fund
MariTeam S.A.
MariTeam S.A.
Mastercroft S.à r.l.
Matterhorn Financing & Cy S.C.A.
SALT Generics S.à r.l.
Samsonite International S.A.
Sarqua S.à r.l.
SDTP
Trinseo S.A.
Wire S.A.
Worrus Holding S.à r.l.
Zeus Recovery Fund SA