This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1148
4 mai 2015
SOMMAIRE
Alpinist S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55088
AmTrust Holdings Luxembourg . . . . . . . . .
55068
BEL Financial Services S.à r.l. . . . . . . . . . . .
55058
Celanese International Holdings Luxem-
bourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55083
Edmond de Rothschild Fund . . . . . . . . . . . .
55061
Eurodat-Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55062
Eurofins Scientific SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Euroinfo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Europ Continents Holding . . . . . . . . . . . . . .
55062
Evolve S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
EVRAZ Greenfield Development S.A. . . . .
55062
Evraz Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
Fassile Saint-Germain S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
55063
FBConsulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55058
FEV S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Fiduciaire Cabexco s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Fidupar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55062
Financière Saint Merri Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55061
Fleet Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
Flexible Five SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
Fontainbleu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55058
Fontainbleu S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Franklin Templeton Strategic Allocation
Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55058
FRI Managers Fund S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
55078
Fuelsco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55058
Fuelsco 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55059
Gase International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55060
GB WFC GP S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
Global Project Investment . . . . . . . . . . . . . .
55065
Global Project Investment S.C.A. . . . . . . .
55063
Global Technologies and Investments S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55064
GROUPE OPEN PSF Luxembourg . . . . . .
55065
Grupo Celeste Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
55075
Grupo Leon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55063
HDB Competences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Hess Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l. . . .
55065
Rontal Holding Two S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
55066
Rontal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55066
Service Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55088
SoWiTec Luxembourg 3 S.à r.l. . . . . . . . . .
55071
Toitures Antoniotti S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
55074
55057
L
U X E M B O U R G
Fuelsco, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 183.947.
Les comptes annuels au Décembre 31, 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044420/9.
(150050865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
FBConsulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 21, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 143.731.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015044422/10.
(150050617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fontainbleu S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 65.232.
Par la présente, je suis au regret de vous annoncer ma décision de démissionner de mes fonctions d'administrateur de
votre société avec effet immédiat.
Luxembourg, le 17 mars 2015.
Alexandre TASKIRAN.
Référence de publication: 2015044429/10.
(150050974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
BEL Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 154.612.
Les Comptes Annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015044923/11.
(150051448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 113.696.
EXTRAIT
Lors d'une assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 12 janvier 2015, ces derniers ont voté
en faveur de la fusion de la Société au sein de la Franklin Templeton Investment Funds (la «Fusion»).
Il résulte de ce qui précède que la Société a cessé d'exister depuis le 20 mars 2015, minuit, heure de Luxembourg,
date d'effectivité de la Fusion.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION FUNDS
Référence de publication: 2015044437/14.
(150050951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55058
L
U X E M B O U R G
Fuelsco 2, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8069 Bertrange, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 187.836.
Les comptes annuels au Décembre 31, 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044421/9.
(150050867) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fiduciaire Cabexco s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 139.890.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Windhof, le 20/03/2015.
Référence de publication: 2015044413/10.
(150050820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Eurofins Scientific SE, Société Européenne.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 167.775.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
Référence de publication: 2015044407/10.
(150050802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Euroinfo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 56.038.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 18 mars 2015.
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signature
Référence de publication: 2015044408/12.
(150050486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fontainbleu S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 65.232.
La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127 rue de Mühlenbach, L-2168
Luxembourg, et la société FONTAINBLEU S.A., société anonyme, enregistrée au registre de commerce de Luxembourg
sous le numéro RCS B 65232, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 17 mars 2015; le siège
de la société est ainsi dénoncé.
Trustconsult Luxembourg S.A.
Signature
<i>Le Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015044433/13.
(150051043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55059
L
U X E M B O U R G
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 83, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 168.793.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession signé en date du 4 septembre 2014 que:
Monsieur Gabriele CICCHITTI a transféré 125 parts sociales à Monsieur Marco VINEIS et 125 parts sociale à Monsieur
Massimo MONZINI.
Monsieur Marco VINEIS détient désormais 2.500 parts sociales de la société Gastronomica Luxembourg Sàrl.
Monsieur Massimo MONZINI détient désormais 2.500 parts sociales de la société Gastronomica Luxembourg Sàrl.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015044448/14.
(150050898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Evraz Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 105.615.
Il résulte des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 18 mars 2015 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 18 mars 2015 au 1, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015044384/15.
(150050613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fleet Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 148.815.
Par résolutions prises en date du 19 mars 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Renouvellement du mandat des administrateurs suivants:
- Christophe Laguerre, administrateur de catégorie B, avec adresse au 115, rue du Kriem, L-8030 Strassen;
- Pawel Gierynski, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 5a, Grzybowska, 00-132 Varsovie,
Pologne;
- Wojciech Lukawski, administrateur de catégorie A, avec adresse professionnelle au 5a, Grzybowska, 00-1 32 Varsovie,
Pologne;
- Grzegorz Antoni Waluszewski, administrateur de catégorie A, avec adresse au 19, Polanki, 80-308 Gdansk, Pologne;
- Tomasz Kwiecien, administrateur de catégorie A, avec adresse au 39, Sienna, Warsaw Towers Building, 00-121
Varsovie, Pologne;
- Evelyn Maher, administrateur de catégorie B, avec adresse au 22-24, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg;
pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2017 et qui se tiendra en 2018.
2. Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes d'Alter Domus Luxembourg S.à r.l., avec siège social au
5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle
qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 201 4 et qui se tiendra en 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Référence de publication: 2015044416/25.
(150050452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55060
L
U X E M B O U R G
Evolve S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9938 Pommerloch, 19, route de Bastogne.
R.C.S. Luxembourg B 170.243.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015044411/10.
(150050849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Edmond de Rothschild Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 76.441.
- Il est noté que:
* Mme Alessandra GAUDIO a démissionné de sa fonction d'Administrateur de la Sicav Edmond de Rothschild Fund,
avec effet au 20 février 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044386/11.
(150050280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
FEV S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 134.381.
<i>Extrait des résolutions écrites de l’actionnaire unique prises en date du 23 janvier 2015i>
- L’Actionnaire Unique prend acte de la démission de Monsieur Nicolas MILLE de son mandat d’administrateur unique,
avec effet au 17 octobre 2014.
- L’Actionnaire Unique décide de nommer la personne suivante en qualité d’administrateur unique de la Société, avec
effet immédiat et ce jusqu'à l’issue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra en l’an 2021: M. Jens Michael MAUCH-
NIK, avocat, né le 30 août 1977 à Freiburg (Allemagne), résidant au 10, Ratsfreischulstraße, D-04109 Leipzig (Allemagne).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FEV S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015044423/16.
(150050390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Financière Saint Merri Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 122.926.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la Société FINANCIERE SAINT MERRI IN-i>
<i>VESTMENTS S.A., qui s'est tenue en date du 11 décembre 2014i>
Il a été décidé ce qui suit:
- L'Assemblée Générale décide de nommer GRANT THORNTON LUX AUDIT, Société Anonyme, RCS Luxembourg
B 183652, ayant son siège social à L-8308 Capellen, 89A Pafebruch, comme nouveau Commissaire aux Comptes de la
Société en remplacement de PREMIER TAX S.A., Commissaire aux Comptes en fonction; son mandat viendra à échéance
à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle de 2015.
Pour extrait certifié conforme
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015044415/17.
(150050748) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55061
L
U X E M B O U R G
Europ Continents Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-2546 Luxembourg, 5, rue C.M. Spoo.
R.C.S. Luxembourg B 16.913.
<i>Dépôt rectificatif du dépôt L140221271 du 12.12.2014i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015044409/10.
(150051024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Fidupar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 74.296.
<i>Extrait de la résolution du conseil d'administration en date du 20 mars 2015i>
Le Conseil d'Administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société au 44, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg avec effet au 20 mars 2015.
Copie certifiée conforme
Nicolas MONTAGNE / Noël DIDIER
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015045075/13.
(150051751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
EVRAZ Greenfield Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1946 Luxembourg, 1, rue Louvigny.
R.C.S. Luxembourg B 168.803.
Il résulte des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration de la Société en date du 18 mars 2015 que:
- le siège social de la Société est transféré à partir du 18 mars 2015 au 1, rue de Louvigny, L-1946 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autoriséi>
Référence de publication: 2015044412/15.
(150050616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Eurodat-Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 183.272.
EXTRAIT
DATA GRAPHIC S.A., société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège est établi L-2330 Luxembourg, Bou-
levard de la Pétrusse, 128, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B
42.166 informe le Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg de sa démission en date du 20 mars 2015 de
son mandat de Commissaire de la société EURODAT-LIFE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée
au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183 272 et dont le siège est établi L-2330
Luxembourg, 128 Boulevard de la Pétrusse.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015044405/16.
(150050698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
55062
L
U X E M B O U R G
Fassile Saint-Germain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.835.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire des associés tenue extraordinairement le mardi 10 mars 2015, que les
décisions suivantes ont été adoptées:
- Nomination d'un cogérant:
* Monsieur William Kohn, demeurant au 19 A chemin du Fort Benoit,25000 BESANCON, est nommé cogérant de la
société avec effet immédiat et ce, pour une durée illimitée.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015045068/14.
(150051560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Grupo Leon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 7.838.728,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 178.879.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Sociétéi>
Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 04/12/2014 qui ont été acceptées:
- la nomination de Mme. Miranda Lansdowne, née le 3 octobre 1974 à Rugby, Royaume-Uni, résidant professionnel-
lement à 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg en tant que gérant de catégorie B de la Société avec effet au
04/12/2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 mars 2015.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015045091/16.
(150051192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Global Project Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions de Titrisation.
Capital social: EUR 100.000,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 162.513.
<i>Résolutions écrites du gérant associé commanditéi>
L'an deux mille quinze le 20 mars, la société Global Project Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.973 en sa qualité de gérant associé commandité
représentée par son gérant unique Monsieur Pascal ROBINET, demeurant au 5, rue d'Arlon, L-7412, Bour, a pris les
résolutions suivantes:
1. Décision de transférer le siège social de la Société.
2. Divers.
Le gérant associé commandité en sa qualité de représentant légal de la Société reconnaît que ces résolutions sont
prises dans le meilleur intérêt de la Société.
<i>Résolution uniquei>
Le gérant unique décide transférer le siège social de la Société de L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe au L-2146
Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Global Project Investment S.à r.l.
Représentée par M. Pascal ROBINET
Référence de publication: 2015045089/24.
(150051708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
55063
L
U X E M B O U R G
GB WFC GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 194.222.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
Référence de publication: 2015045094/10.
(150051327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Gase International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 103.286.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour GASE INTERNATIONAL S.A.i>
Référence de publication: 2015045092/10.
(150051258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Flexible Five SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-
lisé.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 164.727.
Le Rapport annuel révisé au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 mars 2015.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015045081/12.
(150051483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Global Technologies and Investments S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 175.300.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 27 janvier 2015i>
Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
annuels au 31 décembre 2019:
<i>Administrateur catégorie A:i>
- Monsieur Vladimir TCHIJEVSKI, ingénieur, demeurant au 11, rue du Parc, L - 8031 Strassen, Président.
<i>Administrateurs catégorie B:i>
- Monsieur Pierre LENTZ, licencié en sciences économiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de
Gaulle, L - 1653 Luxembourg;
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue
Charles de Gaulle, L - 1653 Luxembourg.
Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les
comptes annuels au 31 décembre 2019:
- AUDIEX S.A., Société Anonyme, 9, rue du Laboratoire, L - 1911 Luxembourg.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Référence de publication: 2015045096/22.
(150051971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
55064
L
U X E M B O U R G
ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.769,36.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 159.210.
<i>Extrait des résolutions prises en date du 12 mars 2015i>
- Il est pris acte de la démission de Monsieur Diogo ALVES de son mandat de gérant avec effet au 4 mars 2015.
- Madame Delphine BIRCKER, employée privée, née le 30 mai 1981 à La Fère (France) demeurant professionnellement
au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée en tant que gérant en remplacement de Monsieur Diogo ALVES,
démissionnaire, avec effet au 4 mars 2015, et ce pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Référence de publication: 2015045118/14.
(150051548) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
GROUPE OPEN PSF Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 69.399.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal du Conseil d'administration du 22 janvier 2015 que:
- Le Conseil décide de déléguer la gestion journalière de la Société à Monsieur Marc MATHIS avec adresse à 41, Rue
de l'étang, F-57645 Montoy-Flanville, France, pour une durée illimitée, conformément aux dispositions de l'article 11 des
statuts (le «Délégué à la gestion journalière») et autorise ainsi ce dernier à réaliser, seul, toute opération, conclure tout
contrat ou signer tout document dans le cadre de la gestion journalière d'un opérateur de systèmes informatiques du
secteur financier.
- Le Conseil acte la démission de Monsieur Laurent DESOMER de son mandat de délégué la gestion journalière de la
Société avec effet à l'issue du présent conseil d'administration.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015045100/17.
(150051392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
Global Project Investment, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 62.500,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 127.973.
<i>Résolutions écrites du gérant uniquei>
L'an deux mille quinze le 20 mars, Monsieur Pascal ROBINET, demeurant au 5, rue d'Arlon, L-7412, Bour, en sa qualité
de gérant unique de la société Global Project Investment S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois, ayant son siège social au 40, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 127.973 a pris les résolutions suivantes:
1. Décision de transférer le siège social de la Société.
2. Divers.
Le gérant unique, Monsieur Pascal Robinet, en sa qualité de représentant légal de la Société reconnaît que ces réso-
lutions sont prises dans le meilleur intérêt de la Société.
<i>Résolution uniquei>
Le gérant unique décide transférer le siège social de la Société de L-2163 Luxembourg, 40, Avenue Monterey au L-2146
Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pascal ROBINET
<i>Gérant uniquei>
Référence de publication: 2015045088/23.
(150051157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mars 2015.
55065
L
U X E M B O U R G
Hess Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 193.235.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Référence de publication: 2015041632/10.
(150047523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
HDB Competences, Société Anonyme.
Siège social: L-4210 Esch-sur-Alzette, 69, rue de la Libération.
R.C.S. Luxembourg B 168.712.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015041641/13.
(150047917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Rontal S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Rontal Holding Two S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 182.702.
In the year two thousand and fifteen, on the fifth of March.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rontal Holding S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, registrated with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B. 182.705,
in its capacity as sole shareholder of Rontal Holding Two S.à r.l., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6D, Route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 182.702
and with a share capital of twelve thousand six hundred euro (EUR 12,600), which has been incorporated on pursuant
to a deed of Maître Joseph ELVINGER, then notary residing in Luxembourg on 10
th
December 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 248 on January 28
th
, 2014, (the Company), whose
articles have not been amended since,
here represented by Mister Gianpiero SADDI, employee, with professional address in L-1750 Luxembourg, 74, avenue
Victor Hugo, by virtue of a proxy given in Senningerberg on 27
th
February, 2015.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. Rontal Holding S.à r.l. is the sole shareholder (the sole shareholder) of the Company and represents the entire share
capital of the Company;
II. the sole shareholder takes the following resolution:
55066
L
U X E M B O U R G
<i>Resolutioni>
The Sole Shareholder of the Company resolves to change the name of the Company from "Rontal Holding Two S.à
r.l." into "Rontal S.à r.l." and to subsequently amend article 1 of the articles of association of the Company which shall
henceforth read as follows:
“ Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
Rontal S.à r.l. (the Company), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10
th
August, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), as well as by the present articles of incorporation (the
Articles).”
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Declarationi>
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a German version and in case of discrepancies between the English and the German
text, the English version will be binding.
The document having been read to the person appearing, said person appearing, signed together with the notary the
present original deed.
Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am fünften März,
Vor uns, Maître Martine SCHAEFFER, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Rontal Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 6D, Route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen
im Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter der Nummer B. 182.705,
in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der Rontal Holding Two S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 6 D,
route de Trèves, L-2633 Senningerberg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Num-
mer B 182.702 und mit einem Stammkapital von zwölftausendsechshundert Euro (EUR 12.600), welche durch die Urkunde
vom Notar Joseph ELVINGER, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, am 10. Dezember 2013 gegründet wurde (die
Gesellschaft), eingetragen im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 248 am 28. Januar
2014, welche Urkunde nicht abgeändert wurde,
hier vertreten durch Herrn Gianpiero SADDI, Angestellter, mit Berufsadresse in L-1750 Luxemburg, 74, avenue Victor
Hugo, aufgrund von einer Vollmacht die in Senningerberg, am 27. Februar 2015 ausgestellt wurde.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird
der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beur-
kunden:
I. Rontal Holding S.à r.l. ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesellschafterin) und vertritt das gesamte
Gesellschaftskapital;
II. Die Alleingesellschafterin fasst folgenden Beschluss:
<i>Beschlussi>
Die Alleingesellschafterin beschließt die Bezeichnung der Gesellschaft von „Rontal Holding Two S.à r.l." in „Rontal S.à
r.l." zu ändern, sowie Artikel 1 der Satzung dementsprechend zu ändern, sodass dieser von nun an wie folgt lautet:
„ Art. 1. Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
dem Namen Rontal S.à r.l. (die Gesellschaft) gegründet, welche der Luxemburger Gesetzgebung, insbesondere dem Ge-
setz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das Gesetz), sowie der gegenwärtigen Satzung
(die Satzung) unterliegt.“
<i>Voraussichtliche Kosteni>
Die voraussichtlichen Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf-
grund der vorliegenden Urkunde entstehen, werden ungefähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400.-) betragen.
55067
L
U X E M B O U R G
<i>Erklärungi>
Um dieses zu beurkunden wurde diese notarielle Urkunde am vorgenannten Tag in Luxemburg aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache im Verständnis und im Sprachgebrauch mächtig ist, erklärt
hiermit, dass auf Anfrage der erschienenen Partei die Urkunde in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Über-
setzung, verfasst wurde, und im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und deutschen Text, die englische
Fassung maßgeblich sein soll.
Nachdem das Dokument der erschienenen Partei vorgelesen wurde, wurde dieses von dieser erschienenen Person
und dem unterzeichnenden Notar unterschrieben.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 mars 2015. 2LAC/2015/5057. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015041919/96.
(150047728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
AmTrust Holdings Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 900.000.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 142.739.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of January,
Before Us Me Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned,
THERE APPEARED:
AmTrust International Insurance Ltd, a company duly incorporated and organized under the laws of Bermuda, having
its principal offices at Suite 400, 7 Reid Street, BER - HM 11 Hamilton, Bermuda (hereinafter referred to as AmTrust
International Insurance Ltd. (or the Sole Member),
duly represented by Mrs. Valérie COQUILLE, Legal Manager, residing professionally in L-2220 Luxembourg, 534, rue
de Neudorf, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder representing the appearing person and by the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing person, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that:
I. AmTrust International Insurance Ltd. is the sole member of AmTrust Holdings Luxembourg, a private limited liability
company (société à responsabilité limitée) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, with registered
offices at 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 142.739 (“the Company”);
II. The Company was incorporated under the name of Imagine Captive Holdings Limited pursuant to a deed received
by Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on 24 October 2008, published on
18 November 2008 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2785;
III. The articles of association of the Company have been amended most recently by a deed of the undersigned notary,
on 23 December 2014, not yet published;
IV. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1) Increase of the corporate capital of the Company by an amount of USD 20,000,000.- (twenty million United States
Dollars) so as to bring it from its current amount of USD 880,000,000.- (eight hundred eighty million United States
Dollars) represented by 8,800,000 (eight million eight hundred thousand) corporate units with a nominal value of USD
100.- (one hundred United States Dollars) each, to the new amount of USD 900,000,000.- (nine hundred million United
States Dollars) represented by 9,000,000 (nine million) corporate units with a nominal value of USD 100.- (one hundred
United States Dollars) each;
2) Issue of 200,000 (two hundred thousand) corporate units with a par value of USD 100.- (one hundred United States
Dollars) each, having the same rights and obligations as the existing corporate units of the Company;
3) Subscription and payment of 200,000 (two hundred thousand) corporate units with a par value of USD 100.- (one
hundred United States Dollars) each, by a contribution in cash of USD 20,000,000.- (twenty million United States Dollars).
55068
L
U X E M B O U R G
4) Subsequent amendment of article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to reflect the
increase of the corporate capital of the Company;
5) Authorization granted to any one manager of the Company, acting individually under his sole signature, in the name
and on behalf of the Company, to amend, sign and execute the members’ register of the Company to reflect the present
capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful actions in relation to the present resolutions;
and
6) Miscellaneous.
After due consideration, the Sole Member took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 20,000,000.-
(twenty million United States Dollars) so as to bring it from its current amount of USD 880,000,000.- (eight hundred
eighty million United States Dollars) represented by 8,800,000 (eight million eight hundred thousand) corporate units
with a nominal value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each, to the new amount of USD 900,000,000.-
(nine hundred million United States Dollars) represented by 9,000,000 (nine million) corporate units with a nominal value
of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each;
<i>Second resolutioni>
The Sole Member resolved that the Company issues 200,000 (two hundred thousand) new corporate units with a par
value of USD 100.- (one hundred United States Dollars) each, having the same rights and obligations as the existing
corporate units of the Company (the “New Corporate Units”).
<i>Subscription and paymenti>
The prenamed AmTrust International Insurance Ltd., represented as hereabove stated, declared to: (i) subscribe to
the New Corporate Units and (ii) make payment in full for such New Corporate Units by a contribution in cash, for an
amount of USD 20,000,000.- (twenty million United States Dollars).
The proof of the existence and the value of the contribution in cash has been produced to the undersigned notary.
<i>Third resolutioni>
The Sole Member subsequently resolved to amend the first paragraph of article 5 of the articles of association of the
Company so as to reflect the Capital Increase, as follows:
Art. 5. Corporate Capital. The subscribed corporate capital is set at USD 900,000,000.- (nine hundred million United
States Dollars) represented by 9,000,000 (nine million) corporate units with a nominal value of USD 100.- (one hundred
United States Dollars) each."
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Member resolved to grant authorization to any one manager of the Company, acting individually under his
sole signature, in the name and on behalf of the Company, to amend, sign and execute the members’ register of the
Company to reflect the present capital increase, and more generally to carry out any necessary or useful actions in relation
to the present resolutions.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven thousand Euros (EUR
7,000.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huitième jour du mois de janvier,
Par devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-duché de Luxembourg), soussigné,
A COMPARU:
55069
L
U X E M B O U R G
AmTrust International Insurance Ltd., une société constituée et régie selon le droit des Bermudes, ayant son siège
principal à Suite 400, 7 Reid Street, BER - HM 11 Hamilton, Bermudes (ci-après «AmTrust International Insurance Ltd.»
ou l’«Associé Unique»),
dûment représentée par Mme Valérie COQUILLE, Legal Manager, demeurant professionnellement à L-2220 Luxem-
bourg, 534, rue de Neudorf, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d’acter que:
I. AmTrust International Insurance Ltd. est l’associé unique de AmTrust Holdings Luxembourg, une société à respon-
sabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2220 Luxembourg, 534, rue de Neudorf, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142.739 (la «Société»);
II. La Société a été constituée sous la dénomination sociale de Imagine Captive Holdings Limited suivant un acte reçu
par Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-duché de Luxembourg, le 24 octobre 2008, publié le 18
novembre 2008 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2785;
III. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 23 décembre 2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à ce jour;
IV. Que l’ordre du jour de l’assemblée était le suivant:
1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 20.000.000,- (vingt millions de Dollars des Etats-
Unis d'Amérique) pour le porter de son montant actuel de USD 880.000.000,- (huit cent quatre-vingts millions de Dollars
des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 8.800.000 (huit millions huit cent mille) parts sociales d'une valeur nominale
de USD 100,- (cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, au nouveau montant de USD 900.000.000,- (neuf cent
millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 9.000.000 (neuf millions) de parts sociales d'une valeur
nominale de USD 100,- (cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune;
2) Emission de 200.000 (deux cent mille) parts sociales ayant une valeur de USD 100,- (cent Dollars des Etats-Unis
d'Amérique) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société;
3) Souscription et paiement des 200.000 (deux cent mille) parts sociales ayant une valeur de USD 100,- (cent Dollars
des Etats-Unis d'Amérique) chacune, par le biais d’un apport en numéraire d’un montant de USD 20.000.000,- (vingt
millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique);
4) Amendement subséquent de l’article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société pour refléter l’augmentation de capital
de la Société;
5) Autorisation accordée à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement sous sa seule signature au nom
et pour le compte de la Société, afin de modifier, signer et exécuter le registre des associés de la Société pour refléter
la présente augmentation de capital et, plus généralement, de prendre toute mesure nécessaire ou utile en relation avec
les présentes résolutions; et
6) Divers.
Après analyse, l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 20.000.000,- (vingt millions
de Dollars des Etats-Unis d'Amérique) pour le porter de son montant actuel de USD 880.000.000,- (huit cent quatre-
vingts millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 8.800.000 (huit millions huit cent mille) parts sociales
d'une valeur nominale de USD 100,- (cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, au nouveau montant de USD
900.000.000,- (neuf cent millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 9.000.000 (neuf millions) parts
sociales d'une valeur nominale de USD 100,-(cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé que la Société émette 200.000 (deux cent mille) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de USD 100,-(cent Dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les
parts sociales existantes de la Société (les «Nouvelles Parts Sociales»).
<i>Souscription et libérationi>
Amtrust International Insurance Ltd., prénommée, représentée comme indiqué précédemment, a déclaré: (i) souscrire
aux Nouvelles Parts Sociales et (ii) libérer intégralement ces Nouvelles Parts Sociales par un apport en numéraire d’un
montant de USD 20.000.000,- (vingt millions de Dollars des Etats-Unis d'Amérique).
La preuve de l’existence et de la valeur de l’apport en numéraire a été donnée au notaire soussigné.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique a subséquemment décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société
afin de refléter l’Augmentation de Capital comme suit:
55070
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. Capital social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 900.000.000,- (neuf cent millions de Dollars
des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 9.000.000 (neuf millions) de parts sociales d'une valeur nominale de USD 100,-
(cent Dollars des Etats Unis d’Amérique) chacune."
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique a décidé d’autoriser tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement sous sa seule signature
au nom et pour le compte de la Société, afin de modifier, signer et exécuter le registre des associés de la Société pour
refléter la présente Augmentation de Capital et plus généralement, de prendre toute mesure nécessaire ou utile en
relation avec les présentes résolutions.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s’élève approximativement à la somme de sept mille Euros
(7.000.-EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu'à la requête de la partie comparante, le présent acte a
été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la même partie comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: V. COQUILLE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3440. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015042133/170.
(150048483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
SoWiTec Luxembourg 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 165.347.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth day of February,
Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder (the “General Meeting”) of SoWiTec Luxembourg 3 S.à r.l.
(the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B165.347,
with registered office at 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg, with a corporate capital of twelve thousand and five hundred
euros (EUR 12,500) divided into one thousand (1000) fully paid up shares having par value of twelve euros and fifty cents
(EUR 12.50) and incorporated following a notarial deed enacted on December 2, 2011 before Maître Joëlle Baden, notary
residing in Luxembourg, published in the Luxembourg Official Gazette, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
number 211 of January 26, 2012.
The General Meeting is declared open at 12.00 p.m. and is chaired by Kai Buntrock, private employee, residing pro-
fessionally in Luxembourg.
The chairman appoints Zhana Genova, private employee, residing professionally in Luxembourg as secretary of the
General Meeting.
Jean-Claude Wolff, lawyer, residing professionally in Luxembourg, is elected as scrutineer.
The bureau of the General Meeting being thus constituted, the chairman declares and requests the notary to record
that:
(i) The agenda of the General Meeting is as follows:
55071
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation;
2. Appointment of the liquidator;
3. Determination of the powers to be given to the liquidator and of the liquidator’s remuneration; and
4. Miscellaneous.
(ii) The sole shareholder of the Company being represented, the proxy of the represented sole shareholder, and the
number of shares held by the sole shareholder are shown on an attendance list which, signed by the sole shareholder’s
proxy, by the bureau of the General Meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
(iii) The proxy of the represented sole shareholder, signed ne varietur by the appearing party and the undersigned
notary, will also remain annexed to the present deed.
(iv) It appears from the said attendance list that all of the one thousand (1000) shares representing one hundred percent
(100%) of the Company’s subscribed capital are represented at the General Meeting, which consequently is regularly
constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
(v) The represented sole shareholder declares that it considers itself as having been duly convened to the General
Meeting and that it has been duly informed of the agenda of the General Meeting.
(vi) The General Meeting, having been regularly constituted, may validly deliberate on the agenda items.
Thereupon, the General Meeting, each time unanimously, passes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The General Meeting resolves to dissolve the Company and to put it into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The General Meeting resolves to appoint SoWiTec operation GmbH, a German laws governed company, registered
with the Amtsgericht Stuttgart under the number HRB 728468 with registered address at 24, Löherstraße, D-72820
Sonnenbühl, Germany, as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
Following a discussion of the liquidator’s responsibilities, the General Meeting resolves to grant the liquidator the
broadest powers as provided for by Article 144 to 148 bis of the Law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended from time to time (the “Law”).
The liquidator shall have corporate signature authority and shall be empowered to represent the Company towards
third parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.
The liquidator may accomplish all the acts provided for by Article 144 to 147 of the Law without requesting authori-
zation from the general General Meeting of shareholders of the Company in cases where it is otherwise required.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or
without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.
The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
The liquidator may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such
part of its powers it determines and for the period he will fix.
The Company is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the liquidator for
all deeds and acts including those involving any public official or notary.
The General Meeting further resolves to approve the liquidator’s remuneration as agreed among the parties concerned.
No further items being on the agenda of the General Meeting and none of the shareholders present or represented
asking to speak, the chairman then adjourns the General Meeting.
Whereas the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary on the day first stated
in this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English, followed by a French version; and further states, on request of the same
appearing persons, that in case of any divergence between the English and the French texts, the English version shall
prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
55072
L
U X E M B O U R G
une assemblée générale extraordinaire des associés (l’«Assemblée Générale») de SoWiTec Luxembourg 3 S.à r.l. (la
«Société»), une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 165.347 et avec siège social au 4, rue Dicks, L-1417 Lu-
xembourg, avec un capital social de douze mille euros (EUR 12.500) divisé en mille parts sociales entièrement libérées
d’une valeur nominale de douze euros et cinquante cents (EUR 12.50) chacune et constituée par acte notarié du 2
décembre 2011 par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, publié au Journal Officiel de Lu-
xembourg, Mémorial C, numéro 211 du 26 janvier 2012.
L’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 12.00 heures et est présidée par Kai Buntrock, employé privé, avec
adresse professionnelle à Luxembourg.
Le président désigne Zhana Genova, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, comme secrétaire
de l’Assemblée Générale.
Jean-Claude Wolff, avocat, avec adresse professionnelle à Luxembourg, est élu comme scrutateur.
Le bureau de l’Assemblée Générale étant ainsi constitué, le président déclare et prie le notaire instrumentant d’acter:
(i) Que l’Assemblée Générale a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre en liquidation la Société;
2. Désignation d’un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur; et
4. Divers.
(ii) L’associé unique présent ou représenté, le mandataire de l’associé unique représenté, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'il détient, sont indiqués sur une liste de présence, laquelle, signée par l’associé unique présent ou son man-
dataire, par les membres du bureau et par le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être soumise
avec lui aux formalités de l’enregistrement.
(iii) La procuration de l’associé unique représenté, après avoir été paraphée ne varietur par la parties comparante et
le notaire instrumentaire, restera pareillement annexées au présente acte.
(iv) Il ressort de ladite liste de présence que l’intégralité des 1000 (mille) parts sociales représentant 100% (cent pour
cent) du capital social souscrit de la Société est présente ou représentée à l’Assemblée Générale, laquelle est, par con-
séquent, régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous les points inscrits à l’ordre du jour.
(v) L’associé unique présent ou représenté déclare se considérer comme ayant été valablement convoqué à l’Assemblée
Générale et qu'il a été dûment informé de l’ordre du jour de l’Assemblée Générale.
(vi) L’Assemblée Générale, étant valablement constituée, peut délibérer sur les points de l’ordre du jour.
Ensuite, l’Assemblée Générale adopte, chaque fois à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée Générale décide de nommer SoWiTec operation GmbH, une société régie par les lois de l’Allemagne,
immatriculée auprès du Amtsgericht Stuttgart sous le numéro HRB 728468 et avec siège social au 24, Löherstraße,
D-72820 Sonnenbühl, Allemagne, comme liquidateur de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Après une discussion sur les responsabilités du liquidateur, l’Assemblée Générale décide d’accorder au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus conformément aux articles 144 à 148 bis de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»).
Le liquidateur disposera du pouvoir de signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers,
notamment en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut accomplir tous les actes conformément aux articles 144 à 147 de la Loi sans devoir recourir à
l’autorisation de l’Assemblée Générale des associés de la Société le cas échéant.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété et à des droits similaires, à des gages, actions en rescision; il
peut accorder des mainlevées, avec ou sans quittance, l’inscription de tout gage, saisie, ordonnance ou autre opposition.
Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixera, déléguer à un ou plusieurs mandataires
ses pouvoirs pour l’accomplissement d’actes spéciaux ou spécifiques.
La Société est valablement engagée envers des tiers et sans limite par la seule signature du liquidateur pour tous les
actes et faits y compris ceux impliquant un fonctionnaire public ou un notaire.
55073
L
U X E M B O U R G
L’Assemblée Générale décide également d’approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les
parties concernées.
L’ordre du jour étant épuisé et l’associé unique présent ou représenté ne demandant la parole, le président ensuite
clôture l’Assemblée Générale.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare, à la demande des parties comparantes, que le présent
acte est rédigé en anglais suivi d’une version française; et déclare également, à la demande des parties comparantes, qu'en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Kai Buntrock, Zhana Genova, Jean-Claude Wolff, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: DAC/2015/3828. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 13 mars 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015041945/146.
(150047213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Toitures Antoniotti S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 161.141.
L'an deux mille quinze, le vingt-six février.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "TOITURES ANTONIOTTI S.A.", établie et ayant
son siège à L-3980 Wickrange, 7, rue des trois cantons, constituée suivant acte du notaire Paul DECKER de Luxembourg,
en date du 19 mai 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 1793 du 5 août 2011,
modifiée pour la dernière fois suivant acte du notaire Roger ARRENSDORFF de Luxembourg, en date du 8 février 2013,
publié au dit Mémorial C, Numéro 922 du 18 avril 2013, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 161.141.
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Gilbert ANTONIOTTI, artisan couvreur ferblantier, demeurant à
F-54400 Longwy (France), 58, rue des Religieuses,
qui désigne comme secrétaire Stephen ANTONIOTTI, artisan couvreur ferblantier, demeurant à F-54870 Villers-la-
Chèvre, 1, rue Jacques Brel.
L'assemblée choisit comme scrutateur Stephen ANTONIOTTI, artisan couvreur ferblantier, demeurant à F-54870
Villers-la-Chèvre, 1, rue Jacques Brel.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Transfert du siège social de la société de la commune de Reckange-sur-Mess à la commune de Pétange et modifi-
cation subséquente du premier alinéa de l'article 2 des statuts de la société;
2.- Fixation de l'adresse à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents et représentés, ainsi que le nombre d'actions
qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée ne varietur par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du bureau sera annexée au présent acte pour être soumis à la formalité de l'enregistrement.
Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés ne varietur par les comparants et par le notaire instrumentant,
resteront également annexés au présent acte.
III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les actions représentant l'intégralité du capital social sont présentes
ou représentées à cette assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son
ordre du jour. Tous les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir renoncé à toutes les formalités de convo-
cation.
Après délibération, l'assemblée prend, chaque fois à l'unanimité, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de la commune de Reckange-sur-Mess à la commune de
Pétange et par conséquent de modifier le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit:
55074
L
U X E M B O U R G
" Art. 2. Premier alinéa. Le siège social est établi dans la commune de Pétange. Il pourra être transféré dans les limites
de la commune par simple décision du Conseil d'administration."
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée fixe l'adresse à L-4751 Pétange, 165A, route de Longwy.
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: G. ANTONIOTTI, S. ANTONIOTTI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 février 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 6123. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Référence de publication: 2015041295/54.
(150046626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
Grupo Celeste Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Joseph Kieffer.
R.C.S. Luxembourg B 175.136.
In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of March.
Before Me Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Mrs Virginie PIERRU, notary clerk, residing professionally in L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand Rue (Grand-Duchy
of Luxembourg), acting as proxy-holder of:
1) Mrs. Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, manager, born on October 15
th
, 1977 in Azurém-Guimaraes (Portugal),
with professional address in L-4176 Esch-sur-Alzette, 30 Rue Joseph Kieffer,
2) Mrs Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, manager, born on December 30
th
, 1973 in Guimaraes, S. Paio (Portugal),
residing in Rua Casa do Rio Poveiros, No. 78-3 ° Norte - 4490-499 Povoa de Varzim,
3) Mrs Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, manager, born on June 19
th
, 1966 to Polvoreira (Portugal), residing
in Estrada Nacional 105, No. 991 - Polvoreira. - 4810-294 Guimaraes,
by three (3) proxies given under private seal.
Such proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing persons and the undersigned
notary, will remain attached to this deed for the purpose of registration.
The appearing persons, represented as aforesaid, declared to the undersigned notary the following:
1. the company "GRUPO CELESTE LUX S.à rl", a private limited company (société à responsabilité limitée), having its
registered office in 30, rue Joseph Kieffer, L-4176 Esch-sur-Alzette, incorporated by deed of Maître Marc LOESCH, notary
residing in Mondorf-les-Bains, dated January 22
th
, 2013, published in the Mémorial C, Receuil des Associations et des
Sociétés de Luxembourg n° 803 of April 4
th
, 2013, registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg,
section B, under the number 175.136, (the “Company”),
2. The Company's share capital is set at twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred
and twenty-six (126) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each.
3. the one hundred and twenty-six (126) shares are allocated as follows:
a) Mrs Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
b) Mrs Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
c) Mrs Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
The shareholders, represented as aforesaid and representing the entire share capital, have required the undersigned
notary to act the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The shareholders resolved to increase the share capital by an amount of twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) in order
to raise it from its present amount of twelve thousand six hundred Euro (EUR 12,600.-) represented by one hundred
55075
L
U X E M B O U R G
twenty-six (126) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100.-) each, to an amount of thirty-two thousand
six hundred Euro (EUR 32.600.-) by the issue of two hundred (200) new shares with a nominal value of one hundred
(EUR 100.-) each, having the same rights and obligations as the existing shares of the company (the "New Shares").
<i>Subscription and paymenti>
The shareholders acknowledge that the current shareholder Mrs. Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, pren-
amed, does not wish to subscribe to the New Shares.
Then, the two hundred (200) newly issued shares have been subscribed as follows:
- one hundred (100) new shares subscribed by Mrs. Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, prenamed;
- one hundred (100) new shares subscribed by Mrs Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, prenamed.
All the New Shares have been fully paid-up by the subscribers aforesaid by contribution in cash so that the amount of
twenty thousand Euro (EUR 20,000.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary
who states it.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the shareholders decide to amend the first paragraph of Article 6 of
the articles of association, as follows:
" Art. 6. (first paragraph). The share capital is set at thirty-two thousand six hundred Euro (EUR 32,600.-) represented
by three hundred and twenty-six (326) shares with a par value of one hundred Euro (EUR 100.-) each."
<i>Third resolution:i>
The shareholders resolve to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
empowers and authorizes any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with
the registration of the newly issued shares.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
WHEREOF, the present deed was drawn up in Redange-sur-Attert, at the date indicated at the beginning of the
document.
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing persons, acting as said before, known to the
notary by name, first name, civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present
deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
L'an deux mil quinze, le dix mars.
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg)
soussigné.
A COMPARU:
Madame Virginie PIERRU, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-8510 Redange-sur-Attert, 66, Grand
Rue, agissant en tant que mandataire:
1) Madame Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, gérante, née le 15 octobre 1977, à Azurém-Guimaraes (Portugal),
avec adresse professionnelle à L-4176 Esch-sur-Alzette, 30, rue Joseph Kieffer,
2) Madame Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, gérante, née le 30 décembre 1973, à Guimaraes, S. Paio (Portugal),
demeurant à rua Casa Poveiros do Rio, n° 78 - 3° Norte - 4490-499 Povoa de Varzim,
3) Madame Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, gérante, née le 19 juin 1966, à Polvoreira (Portugal), demeurant
à Estrada Nacional 105, n° 991 -Polvoreira - 4810-294 Guimarâes,
en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
Lesquelles comparantes, représentées comme ci-avant, ont déclaré au notaire instrumentant ce qui suit:
1. la société "GRUPO CELESTE LUX S.à r.l.", une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 30, rue
Joseph Kieffer, L-4176 Esch-sur-Alzette, a été constituée suivant acte reçu par le notaire Maître Marc LOESCH, notaire
de résidence à Mondorf-les-Bains, en date du 22 janvier 2013, publié au Mémorial C n° 803 du 4 avril 2013, immatriculée
au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 175.136 (la «Société»).
55076
L
U X E M B O U R G
2. le capital social est fixé à douze mille six cents euros (EUR 12.600,-) représenté par cent vingt-six (126) parts sociales,
d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.
3. les cent vingt-six (126) parts sociales sont réparties comme suit:
a. Mme Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
b. Mme Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
c. Mme Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Les associés, représentés comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, ont requis le notaire instru-
mentant d’acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Les associés décident d’augmenter le capital social d’un montant de vingt mille euros (20.000,- EUR) pour le porter
de son montant actuel de douze mille six cents euros (12.600,- EUR), représenté par cent vingt-six (126) parts sociales
d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, à un montant de trente-deux mille six cents euros (32.600,-
EUR) par l’émission de deux cents (200) parts sociales nouvelles d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune,
jouissant des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de la Société (les «Nouvelles Parts Sociales»).
<i>Souscription et libérationi>
Les associés prennent acte et constatent que l’associé actuel Mme Maria DO SAMEIRO LEITE DA SILVA VAZ, prén-
ommée, ne souhaite pas souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
Ainsi, les deux cents (200) parts sociales nouvellement émises ont toutes été souscrites, comme suit:
- cent (100) parts sociales nouvelles souscrites par Madame Maria Teresa LEITE DA SILVA VAZ, prénommée;
- cent (100) parts sociales nouvelles souscrites par Madame Maria Celeste LEITE DA SILVA VAZ, prénommée.
Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont été libérées par les prédites souscriptrices moyennant apport en numéraire
de sorte que le montant de vingt mille euros (20.000,- EUR) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu’il en a été
justifié au notaire instrumentant qui le constate.
<i>Deuxième résolution:i>
Suite à la résolution qui précède, les associés décident de modifier le premier alinéa de l’article 6 des statuts de la
Société, pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. (premier paragraphe). Le capital social est fixé à trente-deux mille six cents euros (32.600,- EUR) représenté
par trois cent vingt-six (326) parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune.»
<i>Troisième résolution:i>
Les associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et
donne pouvoir à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à l’enregistrement
des parts sociales nouvellement émises.
<i>Fraisi>
Tous les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de mille cent euros
(1.100,- EUR).
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Redange-sur-Attert, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des
comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Après lecture du présent acte au mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par nom,
prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: V. PIERRU, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils le 12 mars 2015. Relation: DAC/2015/4185. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): J. THOLL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.
Redange-sur-Attert, le 17 mars 2015.
Référence de publication: 2015042333/139.
(150048699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
55077
L
U X E M B O U R G
FRI Managers Fund S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.923,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 138.925.
In the year two thousand and fifteen on the fifth day of February,
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of FRI Managers Fund S.à r.l., a private limited liability company
(société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,600
and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 138.925.
The Company was incorporated on May 19, 2008 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1515 of June 19, 2008. The articles of association of the
Company have been amended for the last time on February [3], 2015 pursuant to a deed of the undersigned notary, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
There appeared:
1. Fernando Martinez Aguirre, born on May 1, 1966 in Madrid, Spain, having his professional address at Paseo de la
Castellana, 136, 28046 Madrid, Spain; and
2. Ignacio Izuzquiza Fernández, born on May 6, 1970 in Madrid, Spain, having his professional address at Paseo de la
Castellana, 136, 28046 Madrid, Spain,
both represented by Regis Galiotto, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg, by virtue of two powers
of attorney given under private seal, which, after having been signed ne varietur by the authorised representative of the
appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for registration purposes.
The appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That they hold all the shares in the share capital of the Company (the Shareholders).
II. That the agenda of the meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of seventeen thousand three hundred twenty-three Euro
(EUR 17,323.-) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand six hundred Euro (EUR
12,600.-), represented by (i) ten thousand one hundred (10,100) class A “tracker” shares and (ii) two thousand five
hundred (2,500) class B “tracker” shares, all in registered form and having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each,
to twenty-nine thousand nine hundred twenty-three Euro (EUR 29,923.-), by way of the issuance of seventeen thousand
three hundred twenty-three (17,323) new class A “tracker” shares of the Company, having a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) each;
3. Subscription and payment of the share capital increase by contributions in kind;
4. Subsequent amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the increase
of the share capital adopted under item 2. above;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any
employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the newly issued
shares in the register of shareholders of the Company; and
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present meeting, the Shareholders waive the convening
notices, the Shareholders represented considering themselves as duly convened and declaring having a perfect knowledge
of the agenda of this meeting which has been provided to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the Company’s share capital by an amount of seventeen thousand three hundred
twenty-three Euro (EUR 17,323.-) in order to bring the share capital from its present amount of twelve thousand six
hundred Euro (EUR 12,600.-), represented by (i) ten thousand one hundred (10,100) class A “tracker” shares (the Class
A Shares) and (ii) two thousand five hundred (2,500) class B “tracker” shares (the Class B Shares), all in registered form
and having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to twenty-nine thousand nine hundred twenty-three Euro (EUR
55078
L
U X E M B O U R G
29,923.-), by way of the issuance of seventeen thousand three hundred twenty-three (17,323) new class A “tracker”
shares of the Company, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payment of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription and paymenti>
MC Corporate & Foods, S.L., limited liability company incorporated and existing under Spanish law, having its registered
office in Madrid, calle Agastia nº 51, 5ºA, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet number
M-280186 and with Spanish Tax Identification Number B-82975236 (MC Corporate), represented by Regis Galiotto,
notary’s clerk, by way of a power of attorney given under private seal, subscribes for ten thousand one hundred five
(10,105) newly issued Class A Shares of the Company, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and fully pays
them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable amounting to six hundred thirty-one thousand seven
hundred eighty-five Euro (EUR 631,785.-) (the Receivable 1) that it holds against Britania Investments S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 15, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136.383
and having a share capital of EUR 20,050.- (Britania) to be allocated as follows:
(i) ten thousand one hundred five Euro (EUR 10,105.-) to the share capital account of the Company; and
(ii) six hundred twenty-one thousand six hundred eighty Euro (EUR 621,680.-) to the Class A share premium reserve
account of the Company.
The value of the Receivable 1 is evidenced by a management certificate issued by the management of MC Corporate
and acknowledged and approved by the management of the Company, stating that:
“
1. MC Corporate is the owner of the Receivable 1, is solely entitled to the Receivable 1 and possesses the power to
dispose of the Receivable 1;
2. the Receivable 1 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. based on generally accepted accountancy principles the aggregate value of the Receivable 1 is at least equal to six
hundred thirty-one thousand seven hundred eighty-five Euro (EUR 631,785) and since such valuation no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
4. the Receivable 1 contributed to the Company is freely transferable by MC Corporate to the Company and is not
subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
5. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 1 contributed to the Company have been or will be
accomplished by MC Corporate and upon the contribution of the Receivable 1 by MC Corporate to the Company, the
Company will become the full owner of the Receivable 1.”
Inverbaita S.L., a limited liability company incorporated and existing under Spanish law, having its registered office at
Calle Doctor Fleming, 30, 28036 Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under sheet number
M-241032 and with Spanish Tax Identification Number B-82397969 (Inverbaita), represented by Regis Galiotto, notary’s
clerk, by way of a power of attorney given under private seal, subscribes for seven thousand two hundred eighteen (7,218)
newly issued Class A Share of the Company, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and fully pays them up
by way of a contribution in kind consisting of a receivable amounting to four hundred fifty-one thousand two hundred
seventy-five Euro (EUR 451,275.-) (the Receivable 2) that it holds against Britania to be allocated as follows:
(i) seven thousand two hundred eighteen Euro (EUR 7,218.-) to the share capital account of the Company; and
(ii) four hundred forty-four thousand fifty-seven Euro (EUR 444,057.-) to the Class A share premium reserve account
of the Company.
The value of the Receivable 2 is evidenced by a management certificate issued by the management of Inverbaita and
acknowledged and approved by the management of the Company, stating that:
“
1. Inverbaita is the owner of the Receivable 2, is solely entitled to the Receivable 2 and possesses the power to dispose
of the Receivable 2;
2. the Receivable 2 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
3. based on generally accepted accountancy principles the aggregate value of the Receivable 2 is at least equal to four
hundred fifty-one thousand two hundred seventy-five Euro (EUR 451,275) and since such valuation no material changes
have occurred which would have depreciated the contribution made to the Company;
4. the Receivable 2 contributed to the Company is freely transferable by Inverbaita to the Company and is not subject
to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and
5. all formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 2 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Inverbaita and upon the contribution of the Receivable 2 by Inverbaita to the Company, the Company
will become the full owner of the Receivable 2.”
55079
L
U X E M B O U R G
Such certificates and the powers of attorney, after signature ne varietur by the authorised representative acting on
behalf of MC Corporate and Inverbaita and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for regis-
tration purposes.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles which will
have henceforth the following wording:
“ 5.1. The corporate capital of the Company is fixed at twenty-nine thousand nine hundred twenty-three Euro (EUR
29,923) represented by (i) twenty-seven thousand four hundred twenty-three (27,423) class A “tracker” shares (in case
of plurality, the Class A Shares and individually a Class A Share) and (ii) two thousand five hundred (2,500) class B “tracker”
shares (in case of plurality, the Class B Shares and individually a Class B Share), having a nominal value of one euro (EUR
1) each (collectively, the Tracker Shares, and individually, a Tracker Share) that will track the performance and returns
of a particular asset or assets of the Company (the Designated Assets) which term shall be deemed to include not only
the Designated Assets identified as such but also (i) the proceeds of sale of all or any part of such Designated Assets (ii)
any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such Designated
Assets including, for the avoidance of doubt, any proceeds of sale (whether in cash or otherwise) received in respect of
any such Designated Assets (iii) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such Designated
Assets and (iv) any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence
of, owning such Designated Assets.
[...]”
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens & Loeff Luxembourg
S.à r.l. and any employee of Vistra (Luxembourg) S.à r.l. to proceed on behalf of the Company to the registration of the
newly issued shares in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be
borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately
two thousand four hundred Euros (EUR 2,400.-).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. In case of discrepancies between the English
version and the French version, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing parties, the proxyholder signed
together with the notary the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le cinquième jour de février,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés de FRI Managers Fund S.à r.l., une société à responsabilité limitée
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 15, rue Edward Steichen, L-2540
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d’un capital social de EUR 12.600 et immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.925 (la Société).
La Société a été constituée le 19 mai 2008 suivant un acte du notaire instrumentant, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations numéro 1515 du 19 juin 2008. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois le 3 février 2015 suivant un acte du notaire instrumentant, qui n’est pas encore publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
Ont comparu:
1. Fernando Martinez Aguirre, né le 1
er
mai 1966 à Madrid, Espagne, dont l’adresse professionnelle se situe à Paseo
de la Castellana, 136, 28046 Madrid, Espagne; et
2. Ignacio Izuzquiza Fernández, né le 6 mai 1970 à Madrid, Espagne et dont l’adresse professionnelle se situe à Paseo
de la Castellana, 136, 28046 Madrid, Espagne,
tous deux représentés par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, en vertu de
deux procurations données sous seing privé, qui, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le
55080
L
U X E M B O U R G
compte des parties comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités
d’enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui
suit:
I. qu’elles détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société (les Associés).
II. que l’ordre du jour de l’assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux avis de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille trois cent vingt-trois euros (EUR 17.323,-)
afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600) représenté par (i) dix
mille cent (10.100) parts sociales «traçantes» de classe A et (ii) deux mille cinq cents (2.500) parts sociales «traçantes»
de classe B, toutes sous forme nominative et ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à vingt-neuf mille
neuf cent vingt-trois euros (EUR 29.923,-) par l’émission de dix-sept mille trois cent vingt-trois (17.323) parts sociales
«traçantes» de classe A, ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune;
3. Souscription et libération de l’augmentation de capital social par apports en nature;
4. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société (les Statuts) afin de refléter l’augmentation du
capital social adoptée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, avec pouvoir et autorité
donnés au gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. et tout employé de Vistra
(Luxembourg) S.à r.l., pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises
dans le registre des associés de la Société; et
6. Divers.
III. que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social étant représenté à la présente assemblée, les Associés renoncent aux formalités de
convocation, les Associés représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite con-
naissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de dix-sept mille trois cent vingt-trois
euros (EUR 17.323,-) afin de porter le capital social de son montant actuel de douze mille six cents euros (EUR 12.600)
représenté par (i) dix mille cent (10.100) parts sociales «traçantes» de classe A (les Parts Sociales de Classe A) et (ii)
deux mille cinq cents (2.500) parts sociales «traçantes» de classe B (les Parts Sociales de Classe B), toutes sous forme
nominative et ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, à vingt-neuf mille neuf cent vingt-trois euros (EUR
29.923,-) par l’émission de dix-sept mille trois cent vingt-trois (17.323) Parts Sociales de Classe A, ayant une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes et libérations intégrales de l’augmentation
de capital social comme suit:
<i>Souscription et libérationi>
MC Corporate & Foods, S.L., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon le droit espagnol, dont
le siège social se situe à Madrid, calle Agastia n° 51, 5°A, immatriculée au Registre Commercial de Madrid sous le feuillet
numéro M-280186 et dont le numéro d’Indentification Fiscal espagnole est B-82975236 (MC Corporate), représentée
par Régis Galiotto, clerc de notaire en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, souscrit à dix mille cent cinq
(10.105) Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégralement
par un apport en nature qui se compose d’une créance s’élevant à six cent trente-et-un mille sept cent quatre-vingt-cinq
euros (EUR 631.785,-) (la Créance 1) qu'elle détient envers Britania Investments S.à.r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, immatri-
culée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.383 et disposant d’un capital social
de EUR 20.050 (Britania), qui sera affectée de la manière suivante:
- dix mille cent cinq euros (EUR 10.105,-) au compte de capital social de la Société; et
- six cent vingt-et-un mille six cent quatre-vingts euros (EUR 621.680,-) au compte de réserve de prime d’émission de
Classe A de la Société.
La valeur de la Créance 1 est documentée par un certificat de gestion émis par la gérance de MC Corporate et reconnu
et approuvé par la gérance de la Société, qui indique que:
«
55081
L
U X E M B O U R G
1. MC Corporate est le propriétaire de la Créance 1, le seul titulaire de la Créance 1, et peut librement disposer de
la Créance 1;
2. la Créance 1 est certaine, liquide et exigible en date due sans pénalité aucune;
3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur totale de la Créance 1 est au moins égale à six
cent trente-et-un mille sept cent quatre-vingt-cinq euros (EUR 631.785,-) et, depuis cette évaluation, aucun changement
matériel qui aurait déprécié l’apport à la Société n’a eu lieu;
4. la Créance 1 apportée à la Société est librement cessible par MC Corporate à la Société et n’est grevée d’aucune
restriction, nantissement ou sûreté limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
5. toutes les formalités requises pour le transfert de propriété de la Créance 1 apportée à la Société ont été ou seront
effectuées par MC Corporate et, suite à l’apport de la Créance 1 par MC Corporate à la Société, la Société deviendra le
propriétaire de plein droit de la Créance 1.»
Inverbaita S.L., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon le droit espagnol, dont le siège social
se situe à Calle Doctor Fleming, 30, 28036 Madrid, Espagne, immatriculée au Registre Commercial de Madrid sous le
feuillet numéro M-241032 et dont le numéro d’Indentification Fiscal espagnole est B-82397969 (Inverbaita), représentée
par Régis Galiotto, clerc de notaire en vertu d’une procuration donnée sous seing privé, souscrit à sept mille deux cent
dix-huit (7.218) Parts Sociales de Classe A ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et les libère intégra-
lement par un apport en nature qui se compose d’une créance s’élevant à quatre cent cinquante-et-un mille deux cent
soixante-quinze euros (EUR 451.275,-) (la Créance 2) qu'elle détient envers Britania, qui sera affectée de la manière
suivante:
- sept mille cent deux cent dix-huit euros (EUR 7.218,-) au compte de capital social de la Société; et
- quatre cent quarante-quatre mille cinquante-sept euros (EUR 444.057,-) au compte de réserve de prime d’émission
de Classe A de la Société.
La valeur de la Créance 2 est documentée par un certificat de gestion émis par la gérance de Inverbaita et reconnu et
approuvé par la gérance de la Société, qui indique que:
«
1. Inverbaita est le propriétaire de la Créance 2, le seul titulaire de la Créance 2, et peut librement disposer de la
Créance 2;
2. la Créance 2 est certaine, liquide et exigible en date due sans pénalité aucune;
3. sur base de principes comptables généralement acceptés, la valeur totale de la Créance 2 est au moins égale à quatre
cent cinquante-et-un mille deux cent soixante-quinze euros (EUR 451.275,-) et, depuis cette évaluation, aucun changement
matériel qui aurait déprécié l’apport à la Société n’a eu lieu;
4. la Créance 2 apportée à la Société est librement cessible par Inverbaita à la Société et n’est grevée d’aucune res-
triction, nantissement ou sûreté limitant sa cessibilité ou réduisant sa valeur; et
5. toutes les formalités requises pour le transfert de propriété de la Créance 2 apportée à la Société ont été ou seront
effectuées par Inverbaita et, suite à l’apport de la Créance 2 par Inverbaita à la Société, la Société deviendra le propriétaire
de plein droit de la Créance 2.»
Lesdits certificats et les procurations, après avoir été signés ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de
MC Corporate et Inverbaita et le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour les formalités de l’en-
registrement.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l’article 5.1 des Statuts, qui aura
désormais la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à vingt-neuf mille neuf cent vingt-trois euros (EUR 29.923), représenté par (i) vingt-sept
mille quatre cent vingt-trois (27.423) parts sociales "traçantes" de classe A (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe
A et individuellement une Part Sociale de Classe A), et (ii) deux mille cinq cents (2.500) parts sociales "traçantes" de classe
B (en cas de pluralité, les Parts Sociales de Classe B et individuellement une Part Sociale de Classe B), ayant une valeur
nominale d'un euro (EUR 1) chacune (collectivement les Parts Sociales Traçantes, et individuellement une Part Sociale
Traçante), qui traceront la performance et les rendements d'un actif particulier ou d'actifs de la Société (les Actifs Dési-
gnés), ce terme sera censé inclure non seulement les Actifs Désignés identifiés comme tels mais également (i) le produit
de la vente de tout ou partie de ces Actifs Désignés (ii) tout actif qui pourra de temps à autre être considéré raisonna-
blement comme ayant remplacé en totalité ou partiellement ces Actifs Désignés y compris, en tout état de cause, tout
produit de vente (que ce soit en numéraire ou autre) reçu en relation avec ces Actifs Désignés (iii) tout actif acquis en
relation avec, ou en conséquence de la détention, de ces Actifs Désignés et (iv) toute distribution de revenu ou de capital
perçue par la Société en relation avec, ou en conséquence de, la détention de ces Actifs Désignés.
(...)»
55082
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés au gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. et tout
employé de Vistra (Luxembourg) S.à r.l., pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales
nouvellement émises dans le registre des associés de la Société
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses coûts, honoraires et charges de toute sorte qui incombent à la Société ou qui seront
à sa charge du fait du présent acte s'élève à environ deux mille quatre cents Euros (EUR 2.400.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise et la version française,
la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant le
présent acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 6 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3884. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015042309/297.
(150048597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.922.899.200,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 118.247.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of November.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-
placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Eschsur- Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.
There appeared
Ticona LLC, a limited liability company organized under the laws of the state of Delaware, United States of America,
having its registered office located at 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, United States of America and
registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 2795049, and Celanese US Holdings LLC,
a limited liability company organized under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its regis-
tered office located at 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, United States of America and registered with
the Secretary of State of the State of Delaware under number 3780476 (the “Shareholders”),
here represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of proxies given under private seal.
Such proxies having been signed “ne varietur' by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The parties hereby represented as described above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I. The appearers constitute all of the shareholders of “Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.1.”, a Lu-
xembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 4A, rue Henri
Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 118.247, incorporated by a deed enacted by Maître Henri Hellinckx, notary public established
in Luxembourg, on 18 July 2006, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" (the “Mémorial C”)
number 1788, dated 25 September 2006 (the “Company”).
The articles of association of the Company have been amended for the last time by a deed enacted on 20 November
2014, by the undersigned notary.
II. That the 15,493,106 (fifteen million, four hundred ninety-three thousand, one hundred six) shares having a nominal
value of EUR 100 (one hundred Euros) each and representing the whole share capital of the Company, are represented
55083
L
U X E M B O U R G
so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Shareholders expressly state having
been duly informed beforehand.
III. The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 373,588,600 (three hundred seventy-three million,
five hundred eighty-eight thousand, six hundred Euros), so as to increase it from its current amount of EUR 1,549,310,600
(one billion, five hundred forty-nine million, three hundred ten thousand, six hundred forty-one Euros) to EUR
1,922,899,200 (one billion, nine hundred twenty-two million, eight hundred ninety-nine thousand, two hundred Euros)
by the issuance of 3,735,886 (three million, seven hundred thirty-five thousand, eight hundred eighty six) shares with a
nominal value of EUR l00 (one hundred Euros) each;
3. Subscription and payment by Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l. of the new shares by the contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Shareholders waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders
acknowledge being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deli-
berate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow the Shareholders to examine
carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company with effect as of the date of these resolutions by an amount
of EUR 373,588,600 (three hundred seventy-three million, five hundred eighty-eight thousand, six hundred Euros), so as
to increase it from its current amount of EUR 1,549,310,600 (one billion, five hundred forty-nine million, three hundred
ten thousand, six hundred Euros) to EUR 1,922,899,200 (one billion, nine hundred twenty-two million, eight hundred
ninety-nine thousand, two hundred Euros), by the issuance of 3,735,886 (three million, seven hundred thirty-five thousand,
eight hundred eighty six) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros) each (the “New Shares”) in
favor of Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”)
organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office located at 4A, rue Henri Schnadt,
L-2530 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 143.875 (the “Contributor”).
The subscription price for the New Shares to be fully paid up through a contribution in kind consisting of a receivable
held by the Contributor against the Company (the “Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares referred to above by
a contribution in kind with effect as of the date of these resolutions.
<i>Intervention of the contributor - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor, represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, pre-named. The Contri-
butor declares to subscribe the New Shares in the Company and to pay them entirely by a contribution in kind hereafter
described.
The subscription price for the New Shares has been fully paid up by the Contributor through the Contribution.
<i>Description of the contributioni>
A receivable against the Company having a principal amount of EUR 720,000,000 (seven hundred twenty million Euros)
dated 24 November 2014.
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution is EUR 720,000,000 (seven hundred twenty million Euros).
Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution dated
24 November 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it with it to the formality of registration.
<i>Managers’ interventioni>
Thereupon intervene:
55084
L
U X E M B O U R G
- Mr. Jean-François Findling, with professional address at 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, manager of
category A;
- Mr. John Sutherland, with a professional address at 4a, rue Henri Schnadt. L-2530 Luxembourg, manager of category
A;
- Mr. Hicham Maâtoug, Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, Germany, manager of category A;
- Mr. Ronnie D. Berry, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,
manager of category B; and
- Mr. Jiong (Thomas) Liu, with a professional address at 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,
manager of category B.
all here represented by Mrs. Sofia Da Chao Conde, pre-named, in accordance with the provisions of the statement of
contribution value established 24 November 2014;
acting in their capacity as managers of the Company, require the notary to act as follows:
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the contribution in kind described above, expressly agree with the description of the Contribution,
with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.
The balance of EUR 346,411,400 (three hundred forty-six million, four hundred eleven thousand, four hundred Euros)
of the value of the Contribution exceeding the nominal value of the New Shares shall be allocated to the share premium
account of the Company.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the
shareholding of the Company now composed of:
- Ticona LLC: 13,954,259 (thirteen million, nine hundred fifty four thousand, two hundred fifty-nine) shares; Celanese
US Holdings LLC: 1,538,847 (one million, five hundred thirty-eight thousand, eight hundred forty-seven) shares; and
Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.: 3,735,886 (three million, seven hundred thirty-five thousand, eight hundred eighty-
six) shares.
The notary acts that the 19,228,992 (nineteen million, two hundred twenty-eight thousand, nine hundred ninety-two)
shares, representing the whole share capital of the Company are presented so that the meeting can validly decide on the
resolution taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, it is resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles
of association of the Company to read as follows:
“ Art. 6. The company's corporate capital is fixed at EUR 1,922,899,200 (one billion, nine hundred twenty-two million,
eight hundred ninety-nine thousand, two hundred forty one Euros) represented by 19,228,992 (nineteen million, two
hundred twenty-eight thousand, nine hundred ninety-two) shares having a nominal value of EUR 100 (one hundred Euros)
each.”
No other amendment shall be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about 7,000.- Euros.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-
sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.
Ont comparu:
55085
L
U X E M B O U R G
Ticona LLC, société à responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique,
ayant son siège social sis au 1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, et enregistrée
auprès du Secrétaire d'Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 2795049, et Celanese US Holdings LLC, une société à
responsabilité limitée constituée selon le droit de l’état du Delaware, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social sis au
1209, Orange Street, 19801 New Castle, Delaware, Etats-Unis d’Amérique, et enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat
de l’Etat du Delaware sous le numéro 3780476 (les “Associés”),
ici représentées par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations ayant été paraphée "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte de les parties com-
parantes et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités
de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées telles que décrit ci-dessus,ont requis du notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I - Les parties comparantes sont les associés de «Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.», une société à
responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 4A, rue Henri M. Schnadt,
L-2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 118.247, constituée par acte pris par Maître Henri Hellinkx, notaire résidant à Luxembourg,
Grand Duché de Luxembourg, en date du 18 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Memorial C») numéro 1788, en date du 25 septembre 2006 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 20 novembre
2014.
II - Que les 15.493.106 (quinze million quatre cent quatre-vingt-treize mille cent six) parts sociales ayant une valeur
nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées
de sorte que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont les Associés recon-
naissent avoir été dûment préalablement informé.
III - L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 373.588.600 EUR (trois cent soixante-treize million
cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent Euros) afin de le porter de son montant actuel de 1.549.310.600 EUR (un milliard
cinq cent quarante-neuf million trois cent dix mille six cent Euros) à 1.922.899.200 EUR (un milliard neuf cent vingt-deux
million huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent Euros) par l’émission de 3.735.886 (trois million sept cent trente-
cinq mille huit cent quatre-vingt-six) nouvelles parts sociales d’une valeur nominale de 100 Euros (cent Euros) chacune;
3. Souscription et paiement par Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l. des nouvelles parts sociales par un apport en
nature;
4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 6 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que les Associés renoncent à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente
assemblée; les Associés reconnaissent avoir été suffisamment informés de l’ordre du jour et considèrent avoir été vala-
blement convoqué et en conséquence acceptent de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un délai suffisant
afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société avec effet à compter de la date de ces résolutions d’un montant
de 373.588.600 EUR (trois cent soixante-treize million cinq cent quatre-vingt-huit mille six cent Euros), afin de le porter
de son montant actuel de 1.549.310.600 EUR (un milliard cinq cent quarante-neuf million trois cent dix mille six cent
Euros) à 1.922.899.200 EUR (un milliard neuf cent vingt-deux million huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent
Euros), par l’émission de 3.735.886 (trois million sept cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six) nouvelles parts
sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales») en faveur de Celanese
Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon le droit luxembourgeois, ayant son
siège social sis au 4A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.875 (l'"Apporteur").
Le prix de souscription pour les Nouvelles Parts Sociales devant être entièrement payé par un apport en nature
constant en des créances détenues par l'Apporteur contre la Société (l'«Apport»).
55086
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur des Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un
apport en nature avec effet à compter de la date de ces résolutions.
<i>Intervention du contributeur - Souscription - Paiementi>
Intervient alors l'Apporteur précité. L'Apporteur, représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, prénommée.
L'Apporteur déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les payer entièrement au moyen de l'Apport.
La souscription des Nouvelles Parts Sociales a été entièrement payée par l'Apporteur au moyen de l'Apport.
<i>Description de l'apporti>
Une créance d'un montant principal de 720.000.000 EUR (sept cent vingt million d'Euros) daté du 24 novembre 2014.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l'Apport s’élève à 720.000.000 EUR (sept cent vingt million d'Euros).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l'Apport datée du 24 novembre 2014, qui devra rester annexée à cet acte pour être soumis avec celui-ci aux formalités
de l’enregistrement.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent alors:
(a) Mr. Jean-Francois Findling, avec adresse professionnelle au 10-12 Boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand
Duché de Luxembourg, gérant de catégorie A;
(b) Mr. John Sutherland, avec adresse professionnelle au 4A, rue Henri M. Schnadt, L- 2530 Luxembourg, Grand Duché
de Luxembourg, gérant de catégorie A;
(c) Mr. Hicham Maâtoug, avec adresse professionnelle au Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach, Allemagne, gérant de
catégorie A;
(d) Mr. Ronnie D. Berry, avec adresse professionnelle au 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas 75039,
gérant de catégorie B; and
(e) Mr. Jiong (Thomas) Liu, avec adresse professionnelle au 222 West Las Colinas Blvd., Suite 900N, Irving, Texas
75039, gérant de catégorie B;
tous représentés par Mme Sofia Da Chao Conde, précitée, en vertu des provisions de la déclaration sur la valeur de
l'apport datée du 24 novembre 2014;
agissant en leur qualité des gérants de la Société, requièrent le notaire d'acter comme suit:
Reconnaissant avoir été préalablement informés de l’étendue de leur responsabilité, légalement responsables en tant
que gérants de la Société en raison de l'apport en nature tel que décrit ci-dessus, s’accordent expressément avec la
description de l'Apport, avec leur évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.
Le solde de 346.411.400 EUR (trois cent quarante-six million quatre cent onze mille quatre cent Euros) de la valeur
de l'Apport qui dépasse la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales est alloué au compte de prime d'émission de la
Société.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport qui a été entièrement réalisé, l’actionnariat
de la Société est maintenant composée de:
- Ticona LLC: 13.954.259 (treize million neuf cent cinquante-quatre mille deux cent cinquante-neuf) parts sociales;
Celanese US Holdings LLC: 1.538.847 (un million cinq cent trente-huit mille huit cent quarante-sept) parts sociales; et
Celanese Holdings Luxembourg S.à r.l.: 3.735.886 (trois million sept cent trente-cinq mille huit cent quatre-vingt-six) parts
sociales.
Le notaire constate que les 19.228.992 (dix-neuf million deux cent vingt-huit mille neuf cent quatre-vingt-douze) parts
sociales, représentant la totalité du capital social de la Société sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement
se prononcer sur la résolution à prendre ci-dessus.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des résolutions précédentes, il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 6 des statuts
de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 6. Le capital de la Société est fixé à 1.922.899.200 EUR (un milliard neuf cent vingt-deux million huit cent quatre-
vingt-dix-neuf mille deux cent Euros), représentés par 19.228.992 (dix-neuf million deux cent vingt-huit mille neuf cent
quatre-vingt-douze) parts sociales d’une valeur nominale de 100 EUR (cent Euros) chacune.»
Aucune autre modification doit être faite à cet article.
55087
L
U X E M B O U R G
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cette augmentation de capital, ont été estimés à environ 7.000 euros.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document au comparant, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent acte notarié.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent acte qu'à la requête de la personne
comparante les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Signé: Conde, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16425. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015042193/261.
(150048718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
Alpinist S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6670 Mertert, 2C, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 53.863.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2015044246/11.
(150051055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mars 2015.
Service Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 195.341.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of March.
Before Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains (Grand Duchy of Luxembourg).
There appeared:
1) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its regis-
tered office at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with
the Register of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1695, acting through its general partner
DBG Fund VI GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at
First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of
Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1680, acting through its general partner DBG Management
GP (Guernsey) Limited, a limited company having its registered office at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie,
St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Companies of the Island of Guernsey under
number 55086,
here represented by Me Stephan Weling, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on March 4, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration;
2) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office
at First Floor, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register
of Limited Partnerships of the Island of Guernsey under number 1692, acting through its general partner DBG Fund VI
GP (Guernsey) L.P., a limited partnership governed by the laws of Guernsey, having its registered office at First Floor, La
Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Limited Part-
nerships of the Island of Guernsey under number 1680, acting through its general partner DBG Management GP
(Guernsey) Limited, a limited company governed by the laws of Guernsey, having its registered office at First Floor, La
Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG and registered with the Register of Companies of
the Island of Guernsey under number 55086,
55088
L
U X E M B O U R G
here represented by Me Stephan Weling, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on March 4, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration; and
3) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, a company governed by the laws of Germany, having its registered office at
Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the Frankfurt trade register under number HRA
46856, acting through its general partner DBG Service Provider Verwaltungs GmbH, a company governed by the laws of
Germany, having its registered office at Börsenstraße 1, 60313 Frankfurt am Main, Germany, and registered with the
commercial register of the local court of Frankfurt am Main under number HRB 90813,
here represented by Me Stephan Weling, lawyer, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal, given on March 4, 2015; such proxy, signed by the proxyholder and the
undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration;
The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:
Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration
Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the “Company”) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the “Articles of
Incorporation”).
The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not
exceeding forty (40) shareholders.
The Company will exist under the name of “Service Holding S.à r.l.”.
Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in the Municipality of Niederanven.
The registered office may be transferred to any other place within the Municipality of Niederanven by a resolution of
the Manager(s).
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Manager(s).
In the event that, in the view of the Manager(s), extraordinary political, economic or social developments occur or
are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communications with such office or between such office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the
registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such temporary measures will
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office,
will remain a company governed by the Laws. Such temporary measures will be taken and notified to any interested
parties by the Manager(s).
Art. 3. Object. The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or
in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.
The Company may provide loans and financing in any other kind or form or grant guarantees or security in any other
kind or form, in favour of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.
The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets
in any kind or form.
The Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes or any other debt instruments as well
as warrants or other share subscription rights.
In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem
useful in the accomplishment and development of its purposes.
Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set
by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.
Chapter II. Capital, Shares
Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-)
divided into:
- One million two hundred and forty-one thousand (1,241,000) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a nominal
value of one euro cent (EUR 0,01) each, all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class A shares (the “Class A Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class B shares (the “Class B Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class C shares (the “Class C Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
55089
L
U X E M B O U R G
- One thousand (1,000) class D shares (the “Class D Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class E shares (the “Class E Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class F shares (the “Class F Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class G shares (the “Class G Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up;
- One thousand (1,000) class H shares (the “Class H Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up; and
- One thousand (1,000) class I shares (the “Class I Shares”) with a nominal value of one euro cent (EUR 0,01) each,
all subscribed and fully paid up.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.
The issued capital of the Company may be reduced through the repurchase and cancellation of one or more entire
classes of Shares provided however that the Company may not at any time repurchase and cancel the Ordinary Shares.
In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares such cancellations and repurchases of Shares shall be
made in the following order:
i. Class I Shares;
ii. Class H Shares;
iii. Class G Shares;
iv. Class F Shares;
v. Class E Shares;
vi. Class D Shares;
vii. Class C Shares;
viii. Class B Shares; and
ix. Class A Shares.
The cancellation value per share (the “Cancellation Value Per Share”) shall be calculated by dividing the Total Can-
cellation Amount by the number of Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
The total cancellation amount (the “Total Cancellation Amount”) shall be an amount determined by the general meeting
of shareholders or the Manager or the Board of Managers, as the case may be, on the basis of the relevant interim accounts
of the Company at a date not older than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant
calls of shares and approved by the general meeting of shareholders. The Total Cancellation Amount for each of the
Classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of
the relevant class unless otherwise decided by the general meeting of shareholders, provided however that the Total
Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.
Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become
due and payable by the Company.
Available Amount (the “Available Amount”) means the total amount of net profits of the Company (including carried
forward profits) to the extend the shareholder would have been entitled to dividend distributions according to article
28 of the Articles of Incorporation, increased by:
i. any freely distributable reserves,
ii. the amount of the share capital reduction and of the share premium relating to the Class of Shares to be cancelled,
and
iii. as the case may be, the legal reserve reduction relating to the Class of Shares to be cancelled,
but reduced by:
i. any losses (included carried forward losses), and
ii. any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles.
Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
Co-owners of shares must be represented towards the Company by a common representative, whether appointed
amongst them or not.
55090
L
U X E M B O U R G
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.
When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders
but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.
The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding
upon the Company or upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, pursuant to
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company may acquire its own shares with a view to their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted
by the shareholder(s).
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or
several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.
Art. 8. Incapacity, Death, Suspension of civil rights, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, death,
suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency or any other similar event affecting the shareholder(s) does not put the
Company into liquidation.
Chapter III. Managers, Auditors
Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves
(the “Manager(s)”).
If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the “Board of Managers”).
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their
mandate. The Managers are eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause, by a
resolution of the shareholder(s).
The shareholder(s) may decide to qualify the appointed Managers as class A Managers (the “Class A Managers”) or
class B Managers (the “Class B Managers”).
The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.
Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary
or useful for accomplishing the Company’s object.
All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder
(s) or to the auditor(s) shall be within the competence of the Managers.
Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) may delegate special powers or
proxies, or entrust determined permanent or temporary functions to persons or committees chosen by them.
The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint
signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.
However, if the shareholder(s) have qualified the Managers as Class A Managers or Class B Managers, the Company
will only be bound towards third parties by the joint signatures of one Class A Manager and one Class B Manager.
The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to
whom special power has been delegated by the Manager(s), but only within the limits of such special power.
Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the “Chairman”). It may also appoint a
secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).
The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened
if any two (2) of its members so require.
The Chairman will preside over all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers
may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.
Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’
written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.
55091
L
U X E M B O U R G
The meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Managers
may from time to time determine.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy. Any Manager may represent
one or several members of the Board of Managers.
A quorum of the Board of Managers shall be the presence or representation of at least half (1/2) of the Managers
holding office, provided that in the event that the Managers have been qualified as Class A Managers or Class B Managers,
such quorum shall only be met if at least one (1) Class A Manager and one (1) Class B Manager are present or represented.
Decisions will be taken by a majority of the votes of the Managers present or represented at such meeting.
One or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means
of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other.
Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.
A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the
Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.
Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the
secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.
Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be
signed by the sole Manager or by any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a
management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation to such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.
Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any
transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Managers and shall not
consider or vote on any such transaction.
To the extent that only one Manager has been appointed, the said Manager will vote and the minutes of the meeting
of the Board of Managers will specify such conflict of interest.
To the extent that only one (1) A Manager and one (1) B Manager have been appointed, the Manager having a personal
interest will disclose such personal interest and will be authorized to vote. The minutes of the meeting of the Board of
Managers will specify such conflict of interest and a special report will be made to the shareholders in that respect at the
following general meeting of the shareholders
Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal
obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.
Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any Manager, officer or employee of the Company and, if applicable, their successors,
heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any
action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Manager(s), officer or
employee of the Company, or, at the request of the Company, any other company of which the Company is a shareholder
or creditor and by which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally
adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement,
indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Com-
pany is advised by its legal counsel that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The
foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the
Articles of Incorporation may be entitled.
Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws, the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts
must be audited by an approved statutory auditor, the business of the Company and its financial situation, including in
particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more statutory
auditors who need not be shareholders themselves.
The statutory or approved statutory auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine the
number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be removed
at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved statutory
auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.
55092
L
U X E M B O U R G
Chapter IV. Shareholders
Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested in them pursuant to the
Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general meeting
of shareholders.
Any properly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.
Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held where the
Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the first day of the month of June.
If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on
the next following business day.
Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five
(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.
General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered
office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the
judgement of the Manager(s), which is final, circumstances of force majeure so require.
Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in
a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.
The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda
and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have
been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of
shareholders.
A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of
communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.
Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided over by the Chairman or by a person
designated by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.
The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general
meeting of shareholders.
The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.
Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of
amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, resolutions shall be adopted by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting (or consultation in
writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be adopted, irrespective
of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.
At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for
the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the majority requirements
shall be a majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.
Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and
may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.
The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
55093
L
U X E M B O U R G
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general
meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
any two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.
Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits
Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of
December of each year.
Art. 27. Adoption of Financial Statements. At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager
(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.
The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.
If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.
Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year
be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be
required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.
After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits
will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).
In respect of each distribution of dividend, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order
of priority:
- each Ordinary Share shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty-five per cent
(0.65%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class A Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixty per
cent (0.60%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class B Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty-five per
cent (0.55%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class C Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fifty per
cent (0.50%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class D Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty-five
per cent (0.45%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class E Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point forty per
cent (0.40%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class F Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty-five
per cent (0.35%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class G Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point thirty per
cent (0.30%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class H Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than twenty-five per cent
(0.25%) per annum of the nominal value of such share, then,
- each Class I Share (if any) shall entitle to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twenty per
cent (0.20%) per annum of the nominal value of such share, (together the “Profit Entitlement”); and
any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement shall be allocated in whole to all the shares
forming the then last outstanding class of shares in reverse alphabetical order (starting from the Class I Shares until the
Class A Shares).
Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)
may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.
Chapter VI. Dissolution, Liquidation
Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by half
of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.
Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who
may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.
In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
55094
L
U X E M B O U R G
(i) first, to the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the
Company’s debts and liabilities;
(ii) second, to the shareholders for the repayment of the nominal value of their shares in the Company;
(iii) third, to the holders of all classes of shares in such order of priority and in such amount as is necessary to achieve
on an aggregate basis the same economic result as the distribution rules set out for dividend distributions.
Chapter VII. Applicable law
Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance
with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have
been subscribed and the nominal value of these shares, has been one hundred per cent (100%) paid in cash as follows:
Shareholders
subscribed
capital
number of shares amount paid-in
DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P. . . . . . . . . . . EUR 2,345.31.-
232,839 Ordinary Shares
188 Class A Shares
188 Class B Shares
188 Class C Shares
188 Class D Shares
188 Class E Shares
188 Class F Shares
188 Class G Shares
188 Class H Shares
188 Class I Shares
EUR 2,345.31.-
DBAG Fund VI (Guernsey) L.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9,998.44.-
992,644 Ordinary Shares
800 Class A Shares
800 Class B Shares
800 Class C Shares
800 Class D Shares
800 Class E Shares
800 Class F Shares
800 Class G Shares
800 Class H Shares
800 Class I Shares
EUR 9,998.44.-
DBG Advisors VI GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . .
EUR 156.25.-
15,517 Ordinary Shares
12 Class A Shares
12 Class B Shares
12 Class C Shares
12 Class D Shares
12 Class E Shares
12 Class F Shares
12 Class G Shares
12 Class H Shares
12 Class I Shares
EUR 156.25.-
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 12,500.- 1,241,000 Ordinary Shares
1,000 Class A Shares
1,000 Class B Shares
1,000 Class C Shares
1,000 Class D Shares
1,000 Class E Shares
1,000 Class F Shares
1,000 Class G Shares
1,000 Class H Shares
1,000 Class I Shares
EUR 12,500.-
The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) was thus as from that moment at the disposal of
the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions provided
for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.
55095
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or
charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200.-).
<i>Transitory Provisioni>
The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last
day of December of 2015.
<i>Shareholders’ resolutionsi>
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to establish the registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Lu-
xembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders resolved to set at two (2) the number of Managers and further resolved to appoint
the following for an unlimited duration:
- Mr. James Bermingham, company manager, born on 19 December 1972 in Sheffield, United Kingdom, residing pro-
fessionally at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Ms. Anke Jager, company manager, born on 22 April 1968 in Salzgitter, Germany, residing professionally at 7, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the proxyholder of the appearing
parties, the present deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same proxyholder
and in case of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day referred to at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary
by his surname, first name, civil status and residence, such proxyholder signed together with the undersigned notary, this
original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, am fünften März.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit dem Amtssitz in Bad Mondorf, Großherzogtum Luxem-
burg.
Sind erschienen:
1) DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft geregelt nach dem Recht von Guernsey, mit
Sitz im 1. Stock, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG und eingetragen beim Guernsey
Registry unter der Nummer 1695, handelnd durch ihren Komanditisten DBG Fund VI GP (Guernsey) LP, eine Komman-
ditgesellschaft geregelt nach dem Recht von Guernsey, mit Sitz im 1. Stock, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter
Port, Guernsey GY1 1WG und eingetragen beim Guernsey Registry unter der Nummer 1680, handelnd durch ihren
Komanditisten DBG Management GP (Guernsey) Limited, eine limited company mit Sitz im 1. Stock, La Plaiderie Cham-
bers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG und eingetragen im Guernsey Registry unter der Nummer 55086,
hier vertreten durch Me Stephan Weling, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg,
kraft der am 4. März 2015 privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt;
2) DBAG Fund VI (Guernsey) L.P., eine Kommanditgesellschaft geregelt nach dem Recht von Guernsey, mit Sitz im 1.
Stock, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG und eingetragen beim Guernsey Registry
unter der Nummer 1692, handelnd durch ihren Komanditisten DBG Fund VI GP (Guernsey) LP, eine Kommanditgesell-
schaft geregelt nach dem Recht von Guernsey, mit Sitz im 1. Stock, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port,
Guernsey GY1 1WG und eingetragen beim Guernsey Registry unter der Nummer 1680, handelnd durch ihren Koman-
ditisten DBG Management GP (Guernsey) Limited, eine limited company geregelt nach dem Recht von Guernsey, mit
Sitz in 1. Stock, La Plaiderie Chambers, La Plaiderie, St Peter Port, Guernsey GY1 1WG nd eingetragen beim Guernsey
Registry unter der Nummer 55086,
hier vertreten durch Me Stephan Weling, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg,
kraft der am 4. März 2015 privatschriftlich erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt; und
3) DBG Advisors VI GmbH & Co. KG, eine Gesellschaft geregelt nach deutschem Recht, mit Sitz Börsenstraße 1,
60313 Frankfurt am Main, Deutschland, und eingetragen beim Frankfurter Handelsregister unter der Nummer HRA
55096
L
U X E M B O U R G
46856, handelnd durch ihren Komanditisten DBG Service Provider Verwaltungs GmbH, eine nach dem deutschen Recht
gegründete Gesellschaft, mit Sitz in der Börsenstraße 1, D-60313 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 90813,
hier vertreten durch Me Stephan Weling, Rechtsanwalt, mit beruflichem Wohnsitz in Luxemburg,
kraft der am 4. März 2015 privatschriftich erteilten Vollmacht.
Die oben genannte Vollmacht, welche von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet
wurde, bleibt der vorliegenden notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt.
Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:
Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer
Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die
den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.
Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren
Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.
Die Gesellschaft wird unter dem Namen „Service Holding S.à r.l.“ firmieren.
Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Gemeinde Niederanven haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der
Gemeinde Niederanven verlegt werden.
Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) ent-
weder im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
Sollte(n) die (der) Geschäftsführer oder die Geschäftsführung der Auffassung sein, dass außergewöhnliche Ereignisse
politischer, wirtschaftlicher oder gesellschaftlicher Art aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, die die normale
Geschäftsführung der Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den Austausch mit der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz
beziehungsweise zwischen der Geschäftsstelle am Gesellschaftssitz und im Ausland befindlichen Personen beeinträchtigen
könnten, so kann die Gesellschaft den Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Beilegung der außergewöhnlichen
Ereignisse ins Ausland zu verlegen. Diese vorübergehenden Maßnahmen haben keinerlei Auswirkungen auf das Statut der
Gesellschaft, welche trotz der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin den luxemburgischen Gesetzen unter-
liegt. Die genannten vorübergehenden Maßnahmen sind von der Geschäftsführung zu beschließen und den hiervon
betroffenen Dritten mitzuteilen.
Art. 3. Gesellschaftszweck. Der Zweck der Gesellschaft umfasst die Akquisition, das Halten und die Veräußerung von
Beteiligungen in luxemburgischen und/oder ausländischen Unternehmen, sowie die Verwaltung, Entwicklung und Betreu-
ung solcher Beteiligungen.
Die Gesellschaft kann zugunsten von Unternehmen, welche der Unternehmensgruppe angehören, jede finanzielle Un-
terstützung gewähren, wie zum Beispiel die Gewährung von Darlehen, Garantien und Sicherheiten jeglicher Art und Form.
Die Gesellschaft kann auch in Immobilien, geistiges Eigentum oder jegliche andere bewegliche oder unbewegliche
Vermögensgüter investieren.
Die Gesellschaft kann in jeder Art und Form Darlehen aufnehmen und private Emissionen von Schuldscheinen oder
ähnlichen Schuldtiteln oder Warrants oder ähnliche Anteile, die Recht auf Aktien geben, ausgeben.
Generell kann die Gesellschaft jede kommerzielle, industrielle oder finanzielle Tätigkeit ausführen, welche für die
Ausführung und Entwicklung ihres Zweckes dienlich ist.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit dem
nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.
Kapitel II. Kapital, Anteile
Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500,-), und ist wie folgt aufgeteilt:
- eine Million zweihunderteinundvierzigtausend (1.241.000) Stammanteile (die „Stammanteile“) mit einem Nennwert
von je einem Eurocent (EUR 0,01), welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse A Anteile (die „Klasse A Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse B Anteile (die „Klasse B Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse C Anteile (die „Klasse C Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
55097
L
U X E M B O U R G
- eintausend (1.000) Klasse D Anteile (die „Klasse D Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse E Anteile (die „Klasse E Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse F Anteile (die „Klasse F Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse G Anteile (die „Klasse G Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse H Anteile (die „Klasse H Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind;
- eintausend (1.000) Klasse I Anteile (die „Klasse I Anteile“) mit einem Nennwert von je einem Eurocent (EUR 0,01),
welche vollständig eingezahlt sind.
Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und
Pflichten ausgestattet.
Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf das alle Emissions-
aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung
von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten, zur Auszahlung an den/die Gesellschafter in Form von Dividenden oder um Mittel zur gesetzlichen Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.
Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft kann durch Rückkauf und Annullierung von einer oder mehrerer Anteilsk-
lassen zurückgesetzt werden, wobei die Gesellschaft jedoch nicht zu jeder Zeit die Stammanteile zurückkaufen und
annullieren darf. Falls Rückkäufe und Annullierungen von Anteilsklassen vorgesehen sind, sind diese in folgender Reihen-
folge durchzuführen:
i) Klasse I Anteile
ii) Klasse H Anteile
iii) Klasse G Anteile
iv) Klasse F Anteile
v) Klasse E Anteile
vi) Klasse D Anteile
vii) Klasse C Anteile
viii) Klasse B Anteile
ix) Klasse A Anteile
Der Annullierungsbetrag pro Anteil (der „Annullierungswert pro Anteil“) wird errechnet, indem der Gesamte An-
nullierungsbetrag durch die Anzahl der betroffenen Anteile in der zurückzukaufenden und zu annullierenden Anteilsklasse
geteilt wird.
Der Gesamte Annullierungsbetrag (der „Gesamte Annullierungsbetrag“) ist ein Wert welcher gegebenenfalls durch
die Generalversammlung oder den oder die Geschäftsführer, auf Basis der relevanten Zwischenbilanzen der Gesellschaft,
nicht früher als acht (8) Tage vor Rückkauf und Annullierung der betroffenen Anteilsklassen ermittelt und durch die
Generalversammlung bestätigt worden ist. Der Gesamte Annullierungsbetrag für jede der Anteilklassen I, H, G, H, E, D,
C, B und A entspricht dem Verfügbaren Betrag der betroffenen Anteilsklasse zum Zeitpunkt der Annullierung dieser
betroffenen Klasse, vorausgesetzt die Generalversammlung trifft keine andere Entscheidung, wobei der Gesamte Annul-
lierungsbetrag niemals höher als ein solcher Verfügbarer Betrag sein darf.
Im Moment des Rückkaufs und der Annullierung der Anteile einer bestimmten Anteilsklasse wird die Gesellschaft den
Annullierungsbetrag pro Aktie schuldig.
Verfügbarer Betrag (der „Verfügbare Betrag“) bedeutet der Gesamtbetrag des Reingewinns der Gesellschaft (ein-
schließlich des Gewinnvortrags) bis zu der Summe auf die der Gesellschafter, aufgrund von Artikel 28 der Statute, Anrecht
auf Gewinnausschüttung gehabt hätte, zuzüglich:
i) jeglicher frei auszuschüttender Rücklagen,
ii) den Betrag der Kapitalreduzierung und des Aufgeldes welches sich auf die zu annullierende Anteilsklasse bezieht,
und
iii) gegebenenfalls, die Reduzierung der gesetzlichen Rücklage welche sich auf die zu annullierende Anteilsklasse bezieht,
jedoch abzüglich
i) jegliche Verluste (einschließlich Verlustvorträge), und
ii) jegliche Summen welche aufgrund gesetzlicher oder satzungsgemäßer Bestimmungen als Rücklage eingebracht wer-
den müssen.
Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
55098
L
U X E M B O U R G
Gemeinschaftliche Eigentümer von Anteilen müssen sich gegenüber der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Be-
vollmächtigten, der auch ein Dritter sein kann, vertreten lassen.
Der Alleingesellschafter kann seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile
können nur dann an Nicht- Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.
Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.
Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft oder Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser an-
genommen worden ist.
Die Gesellschaft ist berechtigt ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuerwerben.
Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-
fenen Beschlüsse mit sich.
Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-
sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Tod, Aussetzung von Bürgerrechten, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die
Handlungsunfähigkeit, der Tod, die Aussetzung von Bürgerrechten, der Konkurs oder die Insolvenz oder ein vergleich-
barer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der Gesellschaft zur Folge.
Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer
Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-
ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).
Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)
gegründet.
Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats
festlegt. Die (der) Geschäftsführer können wiederernannt werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.
Die (der) Gesellschafter können (kann) beschließen, die gewählten Geschäftsführer als Geschäftsführer A (der (die)
„Geschäftsführer A“)) oder als Geschäftsführer B (die (der) „Geschäftsführer B“)) zu qualifizieren.
Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen noch sich in diese einmischen.
Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,
um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.
Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-
prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der (des) Geschäftsführer(s).
Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer können (kann) spezielle
Befugnisse oder Vollmachten an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit
bestimmten ständigen oder zeitweiligen Funktionen ausstatten.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern, gebun-
den.
Falls die (der) Gesellschafter die Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäftsführer B qualifiziert haben
(hat), ist die Gesellschaft Dritten gegenüber nur gebunden, wenn ein Geschäftsführer A und ein Geschäftsführer B ge-
meinsam unterzeichnen.
Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen
gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) übertragen worden ist, jedoch nicht über
die Grenzen dieser speziellen Vollmacht hinaus.
Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende
Regeln:
Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen
Schriftführer benennen, welcher selbst kein Geschäftsführer sein muss und für die Protokollführung der Sitzung der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).
Der Geschäftsführungsrat tritt nach Aufruf durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäftsfüh-
rungsrates muss einberufen werden, wenn zwei (2) seiner Mitglieder dies verlangen.
55099
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass in seiner Abwesenheit
der Geschäftsführungsrat ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als zeitweisen Vorsitzenden ernennt.
Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des
Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes Kommunikationsmittel einberufen. Jede dieser Benachrichtigungen soll Ort und Zeit der Sitzung sowie
die Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Mitteilung kann durch ordnungs-
gemäß dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort
in einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrich-
tigung erforderlich.
Die Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg oder an einem anderen Ort statt, den die Geschäfts-
führung von Zeit zu Zeit bestimmen kann.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-
schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt; die Bevollmächtigung kann durch jedes
die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmedium übertragen werden. Jeder Geschäftsführer kann einen oder
mehrere Geschäftsführer vertreten.
Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit von mindestens der Hälfte (1/2) seiner
amtierenden Mitglieder, wobei im Falle der Qualifizierung der Geschäftsführer als Geschäftsführer A oder als Geschäfts-
führer B, außerdem mindestens ein (1) Geschäftsführer A und ein (1) Geschäftsführer B anwesend oder vertreten sein
muss.
Entschlüsse werden per Mehrheitsbescheid aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mitglieder des Ge-
schäftsführungsrates gefasst.
Ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates können an Sitzungen durch eine Telefonkonferenzschaltung
oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen, teilnehmen.
Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.
Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß
einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Ein solcher Beschluss kann
festgehalten werden in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.
Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführung. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls es einen solchen gibt) unterzeichnet.
Alle Vollmachten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.
Kopien oder Auszüge der schriftlichen Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder ander-
weitig übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn
mehr als ein Geschäftsführer ernannt wurde, unterzeichnet werden.
Art. 14. Vergütung und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter, können (kann) die
(der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten. Darüber hinaus
können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur Verfolgung des
Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.
Art. 15. Interessenkonflikte. Wenn einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem
Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse den anderen Geschäfts-
führern anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.
Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, wird dieser Geschäftsführer abstimmen, und das Sitzungsprotokoll des Ge-
schäftsführungsrates wird den Interessenskonflikt darlegen.
Falls es nur einen (1) A Geschäftsführer und einen (B) Geschäftsführer gibt, wird der Geschäftsführer mit persönlichem
Interesse an einem Rechtsgeschäft dieses Interesse kundtun und darf abstimmen. Das Sitzungsprotokoll des Geschäfts-
führungsrates wird den Interessenskonflikt darlegen und ein Sonderbericht wird diesbezüglich bei der nächsten Gene-
ralversammlung an die Gesellschafter adressiert.
Art. 16. Haftung der Geschäftsführung - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung
hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.
Geschäftsführer sind für die Ausführung ihrer Aufgaben verantwortlich.
Die Gesellschaft stellt jeden Geschäftsführer, Angestellten oder Mitarbeiter und, gegebenenfalls, dessen Erben, Nach-
lassverwalter und Vermögensverwalter, von Schäden und Ausgaben frei, die ihm im Zusammenhang eines Rechtsstreits
oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder früherer Geschäftsführer, Angestellter
oder Mitarbeiter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf Anfrage der Gesellschaft für eine andere
Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist, Ausgaben tätigt und der gegenüber er
nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich endgültig wegen grober Fahrlässigkeit
oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung nur für vom Vergleich umfasste Fragen
55100
L
U X E M B O U R G
gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten worden ist, dass der freizustellenden
Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das vorgenannte Recht zur Freistellung
schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.
Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-
schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen Wirtschaftsprüfer vorsehen, wird das Geschäft
der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, einschließlich insbesondere der Bücher und Konten durch Wirtschafts-
prüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen, geprüft.
Die statutorischen oder zugelassenen Wirtschaftsprüfer, falls es solche gibt, werden durch die (den) Gesellschafter
ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt werden und
können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden außer in
Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der zugelassene Wirtschaftsprüfer nur aufgrund schwerwiegendem Grund
oder in gegenseitigem Einverständnis abberufen werden kann.
Kapitel IV. Gesellschafter
Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter. Die Gesellschafter haben die Rechte, die ihnen nach der Satzung und dem Gesetz
zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz der
Gesellschafterversammlung übertragen hat.
Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung repräsentiert alle Gesellschafter.
Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden
muss wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am ersten Juni abgehalten.
Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-
genden Werktag abgehalten.
Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-
zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.
Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-
halten oder an jedem anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg; sie können im Ausland abgehalten werden, wenn
Umstände höherer Gewalt, deren Einschätzung im alleinigen Interesse des (der) Geschäftsführer(s) liegt, dies erforderlich
machen.
Art. 21. Mitteilung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich die
Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-
schafterversammlung an sowie die Eigenart der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls
eine vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck
oder die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.
Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über
die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.
Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-
und Rederecht.
Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes
Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.
Art. 23. Verfahren. Den Vorsitz der Gesellschafterversammlung führt der Vorsitzende oder eine Person, die hierzu
von den Geschäftsführern oder andernfalls durch die Gesellschafterversammlung ernannt wird.
Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.
Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-
versammlung anwesend sind, gewählt wird.
55101
L
U X E M B O U R G
Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-
lung.
Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht einberufen wurde zur Änderung der Satzung
oder zur Fassung von Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind,
unterliegen, werden Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals reprä-
sentieren.
Wenn eine solche Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Be-
schlussfassung erreicht wird, werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden
dann unabhängig von der Anzahl der vertretenen Aktien, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der
Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen wird, entsprechen die Mehrheitsverhältnisse der Mehrheit der Anzahl
der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals repräsentieren.
Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-
zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.
Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und von dem Alleingesellschafter
unterzeichnet.
Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls
der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder durch zwei (2) Geschäftsführer gemeinsam, wenn mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden
ist, unterzeichnet werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen
Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die
Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.
Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr
als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.
Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der
gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reinge-
winn verteilt werden soll indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-
jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten.
Im Falle einer Gewinnausschüttung, wird die diesbezüglich vorgesehene Summe nach folgendem Kollokationsplan zu-
geteilt:
- jeder Stammanteil gibt Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr mindestens Null Komma fünfund-
sechzig Prozent (0,65%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse A Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma sechzig Prozent (0,60%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse B Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma fünfundfünfzig Prozent (0,55%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse C Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma fünfzig Prozent (0,50%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse D Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma fünfundvierzig Prozent (0,45%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse E Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma vierzig Prozent (0,40%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse F Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma fünfunddreißig Prozent (0,35%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse G Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma dreißig Prozent (0,30%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
55102
L
U X E M B O U R G
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse H Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma fünfundzwanzig Prozent (0,25%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, dann
- gibt jeder (gegebenenfalls existierende) Klasse I Anteil Anrecht auf eine kumulative Dividende, welche pro Jahr
mindestens Null Komma zwanzig Prozent (0,20%) des Nennwertes eines solchen Anteils beträgt, (zusammen die „Ge-
winnbeteiligung“); und
alle nach der Ausschüttung der Gewinnbeteiligung übrigen Dividenden werden an die zuletzt ausstehende Anteilsklasse
ausgegeben, und zwar in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge (d.h. ausgehend von Klasse I Anteilen, und zurückgehend
bis zu Klasse A Anteilen).
Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-
henden Bestimmungen, können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die
Geschäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.
Kapitel VI. Auflösung, Liquidation
Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst
werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.
Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-
liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.
Im Falle einer Auflösung, werden die Aktiva und das Bargeld der Gesellschaft in folgender Reihenfolge verteilt:
(i) zuerst an alle Gläubiger (durch Rückzahlung oder vernünftige Rückstellung für eine Rückzahlung), für alle Schulden
und Passiva der Gesellschaft;
(ii) dann an die Gesellschafter, in Höhe des Nennwertes ihrer Anteile an der Gesellschaft;
(iii) dann an die Inhaber aller Klassenanteile in einer Reihenfolge, welche zur Folge hat, dass das gesamtheitliche wirt-
schaftliche Resultat identisch mit dem im Falle einer Gewinnausschüttung ist
Kapitel VII. Anwendbares recht
Art. 30. Anwendbares Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, be-
stimmen sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der
zuletzt geltenden Fassung.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert zu einhundert
Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:
Gesellschafter
gezeichnetes
Kapital
Anzahl der Anteile
eingezahlter
Betrag
DBAG Fund VI Konzern (Guernsey) LP . . . . . . . . . . . . . . EUR 2.345,31
232.839 Stamanteile
188 Klasse A Anteile
188 Klasse B Anteile
188 Klasse C Anteile
188 Klasse D Anteile
188 Klasse E Anteile
188 Klasse F Anteile
188 Klasse G Anteile
188 Klasse H Anteile
188 Klasse I Anteile
EUR 2.345,31
DBAG Fund VI (Guernsey) LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 9.998,44
992.644 Stamanteile
800 Klasse A Anteile
800 Klasse B Anteile
800 Klasse C Anteile
800 Klasse D Anteile
800 Klasse E Anteile
800 Klasse F Anteile
800 Klasse G Anteile
800 Klasse H Anteile
800 Klasse I Anteile
EUR 9.998,44
DBG Advisors VI GmbH & Co. KG . . . . . . . . . . . . . . . . .
EUR 156,25
15.517 Stammanteile
12 Klasse A Anteile
12 Klasse B Anteile
12 Klasse C Anteile
EUR 156,25
55103
L
U X E M B O U R G
12 Klasse D Anteile
12 Klasse E Anteile
12 Klasse F Anteile
12 Klasse G Anteile
12 Klasse H Anteile
12 Klasse I Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 12.500,-
1.241.000 Stammanteile
1.000 Klasse A Anteile
1.000 Klasse B Anteile
1.000 Klasse C Anteile
1.000 Klasse D Anteile
1.000 Klasse E Anteile
1.000 Klasse F Anteile
1.000 Klasse G Anteile
1.000 Klasse H Anteile
1.000 Klasse I Anteile
EUR 12.500,-
Die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Zeitpunkt an
zur Verfügung. Nachweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar erbracht, welcher erklärt, dass die Maßgaben
von Artikel 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der zuletzt geltenden Fassung,
erfüllt wurden.
<i>Kosteni>
Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung
entstehen, werden auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-) geschätzt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember
2015.
<i>Gesellschafterbeschlüssei>
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel, Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Anzahl der Geschäftsführer wird auf zwei (2) festgelegt und die folgenden Personen werden auf unbegrenzte Zeit
als Geschäftsführer ernannt:
- Herr James Bermingham, geboren am 19. Dezember 1972 in Sheffield, Vereinigtes Königreich, mit beruflicher An-
schrift in 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg; und
- Frau Anke Jager, geboren am 22. April 1968 in Salzgitter, Deutschland, mit beruflicher Anschrift in 7, rue Lou Hemmer,
L-1748 Luxembourg-Findel, Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag des Bevollmächtigten
der oben genannten Parteien in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag desselben
Bevollmächtigten und im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische
Text.
Worüber Urkunde, Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten, Datum in Luxemburg aufgenommen
wurde.
Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, Bevoll-
mächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen worden ist, hat derselbe vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem
unterzeichnenden Notar, unterzeichnet.
Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 10 mars 2015. GAC/2015/1965. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015041937/913.
(150047891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
55104
Alpinist S.A.
AmTrust Holdings Luxembourg
BEL Financial Services S.à r.l.
Celanese International Holdings Luxembourg S.à r.l.
Edmond de Rothschild Fund
Eurodat-Life S.A.
Eurofins Scientific SE
Euroinfo S.A.
Europ Continents Holding
Evolve S.A.
EVRAZ Greenfield Development S.A.
Evraz Group S.A.
Fassile Saint-Germain S.à r.l.
FBConsulting S.à r.l.
FEV S.A.
Fiduciaire Cabexco s.à r.l.
Fidupar S.A.
Financière Saint Merri Investments S.A.
Fleet Holdings S.A.
Flexible Five SICAV-SIF
Fontainbleu S.A.
Fontainbleu S.A.
Franklin Templeton Strategic Allocation Funds
FRI Managers Fund S.àr.l.
Fuelsco
Fuelsco 2
Gase International S.A.
GASTRONOMICA LUXEMBOURG S.à r.l.
GB WFC GP S.à r.l.
Global Project Investment
Global Project Investment S.C.A.
Global Technologies and Investments S.A.
GROUPE OPEN PSF Luxembourg
Grupo Celeste Lux S.à r.l.
Grupo Leon S.à r.l.
HDB Competences
Hess Holdings S.à r.l.
ICG European Fund 2006, No 3 S.à r.l.
Rontal Holding Two S.à r.l.
Rontal S.à r.l.
Service Holding S.à r.l.
SoWiTec Luxembourg 3 S.à r.l.
Toitures Antoniotti S.A.