logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1109

28 avril 2015

SOMMAIRE

4Ma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53203

APS Consult S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53203

Bacur S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53188

Bonte s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53187

Car Avenue S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Cerved VDC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

Framalux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53191

France Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53191

Galileo Global Education Luxco S.à r.l.  . . .

53192

Georgia-Pacific S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53192

Greencap Trading International S.A.  . . . .

53192

Immo Sharp S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53195

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53200

Leopoldstrasse Aviation Finance  . . . . . . . .

53213

Longan Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

53231

LSREF3 Lion Investments S.à r.l.  . . . . . . . .

53197

Matterhorn Financing & Cy S.C.A. . . . . . . .

53225

M.F.M. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

MGE Hellenic Investments S.à r.l.  . . . . . . .

53228

MGE Vancouver S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53228

Montebello S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53203

Neo Liquidation S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

53193

Npew North S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53229

Phal s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53190

Primeur Invest II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53191

Promo Rio Immobilier S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

53191

Red Earth Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53190

Starling Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Süd-Ost Finanz S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53188

Technolia International S.A.  . . . . . . . . . . . .

53187

Tercade S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

Tevorina Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

Top Patrimoine S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .

53187

Triumph Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

53188

Um Gringert S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53232

Urka S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53187

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53188

Value Portfolio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53190

Vancentio Holdings Limited . . . . . . . . . . . . .

53187

Vence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

Waters Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

53189

WE Luxembourg SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53186

Xperedon Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53189

53185

L

U X E M B O U R G

Tevorina Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 31.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042620/9.
(150048392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

M.F.M. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1532 Luxembourg, 24, rue Ignace de la Fontaine.

R.C.S. Luxembourg B 42.015.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015041770/10.
(150047503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Cerved VDC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 176.004.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 Février 2015.

Référence de publication: 2015041440/10.
(150048124) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Tercade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 114.532.

Les comptes annuels au 30.09.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TERCADE S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015042617/11.
(150048514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

WE Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 23, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 47.361.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires du 15 janvier 2015.

Il résulte de la décision de l'Assemblée Générale des actionnaires du 15 janvier 2015 que:
- Monsieur George Aperghis, né le 19/05/1966 à Middlesborough, la Grande-Bretagne et résidant aux Pays-Bas, Me-

rellaan 15, 2111 GJ Aerdenhout est nommé administrateur de la société. La durée du mandat est indéterminée.

- Monsieur Anders Mikael Andersson, né le 10/04/1970 à Nikolai, Suède et résidant aux Pays-Bas, Sweelincklaan 11,

5242 HE Rosmalen est nommé administrateur de la société. La durée du mandat est indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042652/14.
(150048502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53186

L

U X E M B O U R G

Vancentio Holdings Limited, Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.600,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 106.664.

Les comptes annuels au 31 mai 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042638/9.
(150048809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Urka S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5639 Mondorf-les-Bains, 21, rue des Prunelles.

R.C.S. Luxembourg B 87.977.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015042633/10.
(150048383) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Top Patrimoine S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 155.978.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Référence de publication: 2015042622/10.
(150048711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Technolia International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 115.551.

Je soussigné, Monsieur Claude ZANDONA, demeurant 1, rue des Hêtres à Bridel L-8137, informe le Conseil d'Ad-

ministration de la société TECHNOLIA International, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 115.551, qu'à compter de ce jour, je donne ma démission de mon mandat d'Administrateur Délégué de la
société TECHNOLIA International.

Fait à Pétange, le 3 novembre 2014.

Claude ZANDONA.

Référence de publication: 2015042615/12.
(150048298) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Bonte s.a., Société Anonyme.

Siège social: L-9674 Nocher, 20, Welscheedgen.

R.C.S. Luxembourg B 103.845.

Date  de  clôture  des  comptes  annuels  au  31/12/2014  a  été  déposée  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Derenbach, le 18/03/2015.

FRL SA
Signature

Référence de publication: 2015042755/13.
(150049710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

53187

L

U X E M B O U R G

Bacur S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 90.230.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042741/9.
(150049043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Triumph Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-1417 Luxembourg, 8, rue Dicks.

R.C.S. Luxembourg B 159.828.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015042611/11.
(150048659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.007.875,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 115.926.

<i>Extrait rectificatif sur dépôt numéro L080117807 du 11 août 2008

Le dépôt L080117807 du 11 août 2008 mentionne entre autre que M. Elliot Merrill est nommé en tant que gérant de

catégorie B de la Société.

Or, cette information est erronée et il convient donc de lire que M. Eliot Merrill est nommé en tant que gérant de

catégorie B de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042634/15.
(150048773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Süd-Ost Finanz S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 58.984.

Par décision du Conseil d'administration tenu le 12 mars 2015 au siège social de la société, il a été décidé:
- d'accepter la démission de Monsieur Dominique Audia de sa fonction d'administrateur avec effet immédiat.
- de coopter comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, CL Management S.A., ayant son siège social au 20

rue de la Poste L-2346 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.

- d'appeler à la fonction de Président du Conseil d'Administration Monsieur Giovanni Spasiano, demeurant profes-

sionnellement 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

Le Conseil d'administration constate en outre qu'il résulte des acte de la société que le Prénom de l'administrateur et

l'administrateur-délégué Monsieur Caligaris est Giovanni Guido et non Gianguido.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

SÜD-OST FINANZ S.A.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015042602/19.
(150048538) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53188

L

U X E M B O U R G

Xperedon Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 150.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042657/10.
(150048735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Car Avenue S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Starling Capital S.à r.l.).

Siège social: L-3396 Roeser, 10A, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 155.477.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
CAR AVENUE S.à r.l.
Anc. Starling Capital S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015042770/13.
(150049203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Vence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 97.703.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire Statutaire du 24 juin 2014:

L'Assemblée Générale décide de renouveler les mandats des administrateurs de Catégorie B Madame Luisella MO-

RESCHI  et  Mr  Fabrice  JOURQUIN  et  l'Administrateur  de  Catégorie  A  Mme  Patricia  OSIEKA  ainsi  que  celui  du
commissaire aux comptes Gordale Marketing Limited ayant son siège social à Strovolou, 77, Strovolos center, Office 204
Strovolos, P.C. 2018 Nicosia, Chypre jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 2020.

Luxembourg, le 22 septembre 2014.

<i>Pour VENCE S.A.
Signature

Référence de publication: 2015042645/15.
(150048510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Waters Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 93.818.

<i>Décisions prises par le conseil de gérance en date du 9 mai 2014

Veuillez noter que l’adresse professionnelle de l’associé, MM EUROPEAN HOLDINGS LLP, sous forme juridique

étrangère ‘Limited liability partnership’ et sous le numéro d’immatriculation OC 304702, enregistré par le Registre des
Sociétés d’Angleterre et du Pays de Galles, se situe désormais au Royaume-Uni, à SK9 4AX Cheshire, Altrincham Road,
Waters Wilmslow Stamford, avec effet au 9 mai 2014.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour WATERS LUXEMBOURG S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015042651/16.
(150048520) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53189

L

U X E M B O U R G

Red Earth Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 121.250.

<i>Extrait de la réunion de l'Assemblée Générale Annuelle du 09 mars 2015

L'assemblée accepte la démission de Monsieur Richard Perris de ses fonctions de gérant en date du 17 octobre 2014.
L'assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant, en remplacement du gérant démissionnaire, Monsieur Manuel

MOUGET, né le 06 janvier 1977 à Messancy, Belgique et demeurant professionnellement à L-2163 Luxembourg, 20,
Avenue Monterey, avec effet au 10 novembre 2014.

MAZARS ATO

Référence de publication: 2015041915/13.
(150047244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Phal s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller.

R.C.S. Luxembourg B 154.850.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement n°1011/14 rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième

chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes, pour insuffisance d'actif, les opérations de liquidation de la
société à responsabilité limitée PHAL S.àr.l. avec siège social à L-3562 Dudelange, 21, rue Schiller, de fait inconnue à cette
adresse.

Pour extrait conforme
Maître Admir PUCURICA
<i>Avocat / Le Liquidateur

Référence de publication: 2015041889/15.
(150047573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Value Portfolio, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-8009 Strassen, 23, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 132.415.

<i>Auszug aus dem Protokoll Ordentliche Generalversammlung der Value Portfolio

Die Ordentliche Generalversammlung der Value Portfolio vom 11. März 2015 hat folgende Beschlüsse gefasst:
Zur Wiederwahl des Verwaltungsrates stellen sich
Herr Kurt von Storch (Vorsitzender)
Herr Wendelin Schmitt (Mitglied)
Herr Ulrich Juchem (Mitglied)
Herr Nikolaus Rummler stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl und scheidet somit zum 11. März 2015 aus dem Ver-

waltungsrat aus.

Herr von Storch mit Berufsadresse 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg und Herren Schmitt und Juchem

mit Berufsadresse 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.

Die genannten Herren werden einstimmig von den Aktionären, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung

im Jahr 2016, als Verwaltungsrat gewählt.

Die Aktionäre beschließen einstimmig, bis zur nächsten Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2016, Pricewate-

rhouseCoopers Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, als Wirtschaftsprüfer wieder zu
wählen.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 11. März 2015.

<i>Für Value Portfolio
DZ PRIVATBANK S.A.

Référence de publication: 2015042637/26.
(150048782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53190

L

U X E M B O U R G

Framalux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 144.530.

Le Bilan au 26 janvier 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042308/9.
(150048876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

France Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 108.500.

La version abrégée des comptes au 31 décembre 2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015042293/11.
(150048679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Primeur Invest II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.157.800,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 164.563.

EXTRAIT

Depuis le 24 février 2014, l'associé unique de la société, Vrucht Invest S.A., a établi son siège social au 45, avenue de

la Liberté, L-1931 Luxembourg au lieu du 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg.

Référence de publication: 2015041905/14.
(150047484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Promo Rio Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2664 Luxembourg, 4, rue Verdi.

R.C.S. Luxembourg B 181.649.

<i>Extrait de la décision des associés du 10 mars 2015

- Les associés décident à l'unanimité d'accepter la démission de M. Alexandre MATIAS DOS SANTOS, né à Luxem-

bourg, le 13 janvier 1982, demeurant à L-7423 Dondelange, 15B, rue de la Montée, de son poste de gérant technique de
la société.

- Les associés décident à l'unanimité de nommer Mme Teresa CARVALHO SANCHES, née le 28 avril 1978 à Oeiras

E S Juliao Da Barra Oeiras (Portugal), demeurant L-3314 Bergem, 10, Cité Raedelsbesch au poste de gérante technique
de la société en remplacement du gérant technique démissionnaire pour une durée indéterminée.

- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant administratif par

délégation permanente des pouvoirs de la gérante technique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015041909/20.
(150047442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

53191

L

U X E M B O U R G

Galileo Global Education Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 112.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 149.466.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 3 février 2015 que Galileo Global Education Finance S.à

r.l., l'associé unique de la Société, a transféré l'intégralité des 112 500 parts sociales détenues dans la Société à Galileo
Global Education UK Limited, une limited company constituée en vertu des lois du Royaume-Uni, dont le siège social se
situe au 13 Bramley Road, London W10 6SZ, Royaume-Uni, et qui est immatriculée auprès du Companies House sous
le numéro 08100095.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042313/16.
(150048714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Greencap Trading International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1450 Luxembourg, 36, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 154.007.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 19 septembre 2014

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 septembre 2014, que Mess. Xavier Laloux,

Marc Saverys et Paul-Emmanuel de Becker Rémy se sont démis de leurs postes d'administrateurs, M. Xavier Laloux s'est
également démis de son poste d'administrateur-délégué.

M. Luc Corluy, résidant à Sionkloosterlaan 20, B-2930 Brasschaat, a été appelé à la fonction d'administrateur et ad-

ministrateur-délégué de la société. Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle de l'an 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 septembre 2014.

Pour avis et extrait conforme
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015042319/17.
(150048423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Georgia-Pacific S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 114.101.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 67.134.

EXTRAIT

Il résulte que le mandat de la société suivante n'a pas été renouvelé en tant que réviseur d'entreprises agréé:
- Ernst &amp; Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Münsbach, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, sous le numéro B 47771.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 17 mars 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015042325/21.
(150048507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53192

L

U X E M B O U R G

Neo Liquidation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 163.609.

In the year two thousand and fifteen, on twenty-first day of January,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

there appeared:

Neo Liquidation (Jersey) Limited, a company governed by the laws of Jersey, with registered office at 22, Grenville

Street, JE-JE4 8PX St Helier and registered with the Companies Registry of the Jersey Financial Services Commission
under number 108928 (the “Shareholder”),

hereby represented by Maître Catherine Kremer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on 16 December 2014,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of Neo

Liquidation S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), with registered office at 2C, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary
residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, of 9 September 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations number 2755 of 11 November 2011 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and
Companies under number B 163609 (the "Company"). The articles of incorporation of the Company have not yet been
amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To dissolve the Company and to put the Company into liquidation.
2 To appoint the liquidator.
3 To determine the powers to be given to the liquidator and the remuneration of the liquidator.
4 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to dissolve the Company and to put the Company into liquidation with immediate effect.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to appoint Triton II Luxco 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-one thousand and ninety euro (EUR 31,090.-), with
registered office at 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171261, as liquidator.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved that, in performing his duties, the liquidator shall have the broadest powers to carry out

any act of administration, management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.

The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third

parties, including in court either as a plaintiff or as a defendant.

The liquidator may waive all property and similar rights, charges, actions for rescission; grant any release, with or

without payment, of the registration of any charge, seizure, attachment or other opposition.

The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued

by the Company.

The liquidator may under his own responsibility, pay advances on the liquidation profits to the shareholders.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders

such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.

The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the

liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.

The Shareholder resolved to approve the remuneration of the liquidator as agreed among the parties concerned.

53193

L

U X E M B O U R G

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt et unième jour du mois de janvier,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Neo Liquidation (Jersey) Limited, une société régie par les lois de Jersey, ayant son siège social au 22, Grenville Street,

JE-JE4 8PX St Helier et immatriculée au registre des société de la Commission des services financiers de Jersey sous le
numéro 108928 (l'«Associé»),

représentée aux fins des présentes par Maître Catherine Kremer, demeurant professionnellement à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 16 décembre 2014.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé de Neo Liquidation S.à

r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 9 septembre 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
2755 du 11 novembre 2011 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro
B 163609 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Dissolution de la Société et mise en liquidation de la Société.
2 Nomination d'un liquidateur.
3 Détermination des pouvoirs conférés au liquidateur et de la rémunération du liquidateur.
4 Divers.
a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé a décidé la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.

<i>Deuxième résolution

L'Associé a décidé de nommer Triton II Luxco 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant un capital social de

trente-et-un mille quatre-vingt-dix euros (EUR 31.090,-), avec siège social au 2C, rue Albert Borschette, L-1246 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous
le numéro B 171261, comme liquidateur.

<i>Troisième résolution

L'Associé a décidé que, dans l'exercice de ses fonctions, le liquidateur disposera des pouvoirs les plus étendus pour

effectuer tous les actes d'administration, de gestion et de disposition intéressant la Société, quelle que soit la nature ou
l'importance des opérations en question.

Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment

en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.

Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou actions en rescision,

il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l'inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.

Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des parts sociales

émises par la Société.

53194

L

U X E M B O U R G

Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité, payer aux associés des avances sur le boni de liquidation.
Le liquidateur peut, sous sa propre responsabilité et pour une durée qu'il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires

des pouvoirs qu'il croit appropriés pour l'accomplissement de certains actes particuliers.

La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur pour

tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.

L' Associé a décidé d'approuver la rémunération du liquidateur telle que convenue entre les parties concernées.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: C. Kremer, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 22 janvier 2015. GAC/2015/667. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040564/128.
(150046340) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Immo Sharp S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel.

R.C.S. Luxembourg B 49.770.

L'an deux mil quinze, le vingt-septième jour du mois de février.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme “IMMO SHARP S.A.”, ayant son siège

social à L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, sous le numéro 49770, constituée suivant acte reçu par le Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bet-
tembourg, en date du 15 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 157 en
l'an 1995. «la Société»

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 17

mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1272 du 19 mai 2014.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Guy Weimerskirch, agent immobilier, demeurant profes-

sionnellement à L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sonja Weimerskirch-Schmitz, employée privée, demeurant profes-

sionnellement à L-7395 Hunsdorf, 50, rue de Steinsel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Guy Weimerskirch, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Adaptation des statuts de la Société à la loi du 25 août 2006 en vue de refléter la possibilité pour la Société d'être

une société anonyme unipersonnelle.

2. Modification subséquente des articles 1, 6, 8, 9, 10 et 11.
3. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Resteront annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées „ne va-

rietur“ par les comparants.

III.- Que tous les actionnaires étant présents, les convocations d'usage n'ont pas été adressées aux actionnaires
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'entièreté du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

53195

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la Société aux dispositions de la loi du 25 août 2006 relatives à la

société anonyme unipersonnelle.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée générale décide de modifier les articles 1, 6, 8, 9, 10 et 11 comme suit:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de IMMO SHARP S.A.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la société n'a qu'un actionnaire unique, la

société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
société.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la

société a un associé unique) tant que la société a un associé unique.

Art. 6. Si la société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des action-

naires, il est établi que la société a un actionnaire unique, la société peut être administrée par un administrateur, appelé
«administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus
d'un actionnaire.

Si la société a plus d'un actionnaire, la société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'assemblée générale qui déterminera également le nombre d'administrateurs,

leur rémunération et la durée de leur mandat. Ils sont toujours révocables par elle.

En cas de vacance au sein du conseil d'administration, les administrateurs restants ont le droit provisoirement d'y

pourvoir, et, la décision prise sera ratifiée à la prochaine assemblée».

Art. 8. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour faire tous actes d'administration et de disposition qui rentrent dans l'objet social conformément à l'article 4 ci-
dessus. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les statuts à l'assemblée
générale. Il est autorisé, avec l'approbation du commissaire, à verser des acomptes sur dividendes, aux conditions prévues
par la loi.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès-verbaux, qui seront signés par l'administrateur unique, et dont les
copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

Art. 9. Lorsque la composition du conseil d'administration est limitée à un membre, la société se trouve engagée, vis-

à-vis  des  tiers,  en  toutes  circonstances,  par  la  signature  individuelle  de  l'administrateur  unique.  En  cas  de  pluralité
d'administrateurs, la société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs
dont celle de l'administrateur délégué, ou par la signature d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le conseil d'administration
ou l'administrateur unique en vertu de l'article 10 des statuts.

Art. 10. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le Conseil d‘Administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique peut déléguer ses pouvoirs relatifs à la gestion

journalière et à l‘exécution d'opérations en vue de l‘accomplissement de son objet à des personnes physiques ou morales
qui n‘ont pas besoin d‘être des membres du Conseil d‘Administration.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoir,
choisis dans ou hors de son sein, associés ou non.

Art. 11. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins ou lorsque la com-
position du conseil d'administration est limitée à un membre, par l'administrateur unique.

53196

L

U X E M B O U R G

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de

l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe
(s)) au présent acte.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Guy Weimerskirch, Sonja Weimerskirch-Schmitz, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 2 mars 2015. 1LAC / 2015 / 6347. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015040430/101.
(150045668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

LSREF3 Lion Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 947.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.681.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of February,
Before Us Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Lone Star Capial Investments S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-
Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 36,987,625.-
(thirty-six million nine hundred eighty-seven thousand six hundred twenty-five euro) and registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number
B 91796 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Valérie Fagnant, employee, with professional address in Bertrange, by virtue of a power of

attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 25 February 2015,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned

notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Lion Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 942,500.- (nine hundred forty-
two thousand five hundred euro), registered with the RCS under number B 188681 and incorporated under its initial
name LSREF3 Lux Investments IX S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 11 July 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) dated 24 July 2014 number 1929 and amended for
the last time by a deed of the undersigned notary dated 28 January 2015, not yet published in the Mémorial C (the
Company).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
A. The entire issued share capital represented by 7,540 (seven thousand forty) shares is held by the Sole Shareholder.
B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this

extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.

C. The agenda of the meeting is as follows:
(1) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 5,000.- (five thousand euro) in order to bring

the share capital of the Company from its present amount of EUR 942,500.- (nine hundred forty-two thousand five
hundred euro) to an amount of EUR 947,500.- (nine hundred forty-seven thousand five hundred euro) by way of the

53197

L

U X E M B O U R G

issuance of 40 (forty) new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each
(collectively, the New Shares);

(2) Subscription to and payment in cash of the New Shares by the Sole Shareholder by way of an aggregate contribution

in cash of EUR 5,000.- (five thousand euro);

(3) Subsequent amendment of article 6.1 of the Articles in order to reflect the changes proposed above; and
(4) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and

authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the name change of the Company, (ii) to the registration of
the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (iii) to the performance of any
formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as

follows

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 5,000.- (five thousand

euro)

in order to bring the share capital of the Company from its present amount of 942,500.- (nine hundred forty-two

thousand five hundred euro) to an amount of EUR 947,500.- (nine hundred forty-seven thousand five hundred euro)

by way of the issuance of 40 (forty) New Shares.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder, duly represented as stated above, hereby accepts the subscription of the New Shares and their

full payment as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to 40 (forty) New Shares, having

a nominal value of EUR 125.-(one hundred twenty-five euro) and (ii) fully pay up such New Shares by way of a contribution
in cash of EUR 5,000.- (five thousand euro), which is entirely allocated to the share capital of the Company.

All the New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the

aggregate subscription amount of EUR 5,000.- (five thousand euro) is at the free disposal of the Company as it has been
proved to the undersigned notary who expressly bears witness to it.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to subsequently amend the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect

the above resolutions, so that it reads henceforth as follows in its English version:

Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 947,500.- (nine hundred forty-

seven thousand five hundred euro) represented by 7,580 (seven thousand five hundred eighty) ordinary shares having a
nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) each."

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and

hereby empowers and authorizes any manager of the Company and/or any employee of LSCI, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company (i) to the name change of the Company, (ii) to the registration of the New
Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (iii) to the performance of any formalities in
connection therewith.

<i>Estimate of costs

The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the

Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1100.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of

the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the proxy-
holder of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties which is known by the undersigned notary

by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the
notary, the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-sept février.

53198

L

U X E M B O U R G

Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Lone Star Capital Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège

social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant
un capital social de EUR 36.987.625,- (trente-six millions neuf cent quatre-vingt-sept mille six cent vingt-cinq euros) et
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 91796 (l'Associé
Unique),

ici représentée par Valérie Fagnant, employé(e), ayant son adresse professionnelle à Bertrange, en vertu d'une pro-

curation donnée à Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, le 25 février 2015.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de LSREF3 Lion Investments

S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-
Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 942.500,-
(neuf cent quarante-deux mille cinq cents euros) et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188681

constituée sous son nom initial LSREF3 Lux Investments IX S.à r.l. suivant un acte du notaire instrumentaire en date

du 11 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (Mémorial C) du 24 juillet 2014, numéro
1929 et modifié pour la dernière fois par un acte du notaire instrumentaire en date du 28 janvier 2015, non-encore publié
au Mémorial C (la Société).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
A. La totalité du capital social, représentée par 7.540 (sept mille cinq cent quarante) parts sociales, est détenu par

l'Associé Unique.

B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la

Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être vala-
blement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

C. L'ordre du jour est le suivant:
(1) Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 5.000,- (cinq mille euros) afin d'augmenter le

capital social de son montant actuel de EUR 942.500,- (neuf cent quarante-deux mille cinq cents euros) à un montant de
EUR 947.500,- (neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros) par voie de création et d'émission de 40 (quarante)
nouvelles parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (collective-
ment, les Nouvelles Parts Sociales);

(2) Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un

montant total de souscription de EUR 5.000,- (cinq mille euros);

(3) Par conséquent, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de

refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus; et

(4) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l.
(LSCI), afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du changement de dénomi-
nation de la Société, (ii) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (iii) la réalisation de toute formalité en relation avec
ce point.

Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre

acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de EUR 5.000,- (cinq mille euros)
afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de EUR 942.500,- (neuf cent quarante-deux mille

cinq cents euros) à un montant de EUR 947.500,- (neuf cent quarante-sept mille cinq cents euros)

par voie de création et d'émission de 40 (quarante) Nouvelles Parts Sociales.

<i>Quatrième résolution

L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-avant, approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales

et leur libération intégrale de la manière suivante:

<i>Souscription - Libération

L'Associé Unique, susmentionné, représenté telle que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 40 (quarante) Nouvelles

Parts Sociales, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) et (ii) libérer entièrement ces Nouvelles
Parts Sociales au moyen d'un apport en numéraire total de EUR 5.000,- (cinq mille euros), qui est intégralement alloué
au capital social de la Société.

53199

L

U X E M B O U R G

L'ensemble  des  Nouvelles  Parts  Sociales  émises  sont  donc  intégralement  souscrites  et  libérées  en  numéraire  par

l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 5.000,- (cinq mille euros) est à la libre disposition de la Société, ainsi
qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Cinquième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de façon à y refléter les résolutions

prises ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante dans la version française des statuts:

« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 947.500,- (neuf cent quarante-

sept mille cinq cents euros), représenté par 7,580 (sept mille cinq cent quatre-vingts) parts sociales ordinaires d'une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Sixième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements repris

ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de LSCI, afin d'effectuer, par
sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du changement de dénomination de la Société, (ii) l'in-
scription des Nouvelles Parts Sociales et (iii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

<i>Estimation des coûts

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1100.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire de la parties comparante,

le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire de la partie
comparante, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire de la parties comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 5 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4841. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015040508/177.
(150045741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 770.651,00.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 192.509.

In the year two thousand and fifteen, on the fifth day of March;
Before Us Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Karlin Real Estate Europe, LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the State of Delaware, the

United States of America, having its registered office at the Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilming-
ton, New Castle County, Delaware, 19801, the United States of America, registered with the Secretary of State of the
Delaware, Division of Corporations, under number 5340522 (the “Sole Shareholder”), here represented by Peggy Simon,
employee, with professional address at 9, Rabatt, L-6475 Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
established on March 4, 2015.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxy holder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)

established in Luxembourg under the name of “Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l.”, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 192509 (he-
reafter the “Company”), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, notary in Echternach, on December

53200

L

U X E M B O U R G

rd

 , 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 4007 on December 29 

th

 , 2014.

The Company's articles of association have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on
February 27 

th

 , 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. The Company's share capital is set at seven hundred and twenty-three thousand seven hundred and ninety-nine U.S.

Dollars  (USD  723,799.-)  represented  by  seven  hundred  and  twenty-three  thousand  seven  hundred  and  ninety-nine
(723,799) shares with a nominal value of one U.S. Dollar each (USD 1.-) each.

III. The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of forty-six thousand

eight hundred and fifty-two U.S. Dollars (USD 46,852.-) to raise it from its present amount of seven hundred and twenty-
three thousand seven hundred and ninety-nine U.S. Dollars (USD 723,799.-) to seven hundred and seventy thousand six
hundred and fifty-one U.S. Dollars (USD 770,651.-) by the creation and issue of forty-six thousand eight hundred and
fifty-two (46,852) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each vested with the same rights and
obligations as the existing shares, to be fully paid up by the Sole Shareholder by way of a contribution in kind.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares to subscribe to the forty-six thousand eight hundred and

fifty-two (46,852) new shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each, and fully pay them up by way of a
contribution in kind consisting of 1% of a receivable held by the Sole Shareholder on the company Magnus Properties
Holdings A Limited, a company incorporated under the laws of Jersey, having its registered office at 26, New Street, St.
Helier, Jersey, Channel Islands, JE2 3 RA, with registration number 117196, for an amount of thirty thousand five hundred
British Pounds (GBP 30,500.-) corresponding to forty-six thousand eight hundred and fifty-two U.S. Dollars (USD 46,852.-)
(hereafter the “Contributed Asset”).

<i>Evidence of the contribution's existence

The value of the Contributed Asset is set at forty-six thousand eight hundred and fifty-two U.S. Dollars (USD 46,852.-)

and results from a statement of contribution value of the managers of the Company as well as a declaration of value from
the contributor. A copy of the aforementioned documentation will remain annexed to the present deed.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole owner of the Contributed Asset;
- the Contributed Asset is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
- the Contributed Asset is not the object of a dispute or claim;
- the Contributed Asset is freely transferable with all the rights attached thereto;
- all formalities subsequent to the transfer of the Contributed Asset required under any applicable law have or will be

carried out in order for the contribution to be valid anywhere and towards any third party.

IV. Pursuant to the above resolutions, the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association is amended

and shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Subscribed Capital. The share capital is set at seven hundred and seventy thousand six hundred and fifty-one

U.S. Dollars (USD 770,651.-) represented by seven hundred and seventy thousand six hundred and fifty-one (770,651)
shares with a nominal value of one U.S. Dollar (USD 1.-) each.”

<i>Costs

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result

of the presently stated increase of capital are estimated at nine hundred fifty Euro (EUR 950.-).

The amount of the capital increase is valued at EUR 42.531,75
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French translation.

On request of the same appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English

version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the party appearing, who is known to the notary by her Surname,

Christian name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L'an deux mille quinze, le cinq mars;
Par-devant Maître Henri BECK, notaire, résidant à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

53201

L

U X E M B O U R G

Karlin Real Estate Europe, LLC, une «limited liability company» constituée selon les lois de l'état du Delaware, Etats-

Unis d'Amérique, ayant son siège social au Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware, 19801, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée auprès du «Secretary of State of the Delaware, Division
of Corporations», sous le numéro 5340522 (l'«Associé Unique»), représenté par Peggy Simon, employée, ayant son
adresse  professionnelle  au  9,  Rabatt,  L-6475  Echternach,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  en  vertu  d'une  procuration
donnée le 4 mars 2015.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-

mentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.

Laquelle comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination

de «Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l.», immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 192509 (ci-après la «Société»), constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné,
notaire à Echternach, en date du 3 décembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
4007 le 29 décembre 2014. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné
en date du 27 février 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

II. Le capital social de la Société est de sept cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains

(723.799,- USD) représenté par sept cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf (723.799) parts sociales ayant
une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune.

III. L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de quarante-six mille huit cent

cinquante-deux Dollars américains (46.852,- USD) pour le porter de son montant actuel de sept cent vingt-trois mille
sept cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars américains (723.799,- USD) à sept cent soixante-dix mille six cent cinquante-et-
un Dollars américains (770.651,- USD) par la création et l'émission de quarante-six mille huit cent cinquante-deux (46.852)
nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales existantes, intégralement libérées par l'Associé Unique par apport en nature.

<i>Souscription - Libération

L'Associé Unique, agissant par son mandataire, déclare souscrire à l'intégralité des quarante-six mille huit cent cin-

quante-deux (46.852) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune et les payer
intégralement par apport en nature consistant en 1% d'une créance détenue par l'Associé Unique sur la société Magnus
Properties Holdings A Limited, une société constituée selon les lois de Jersey, ayant son siège social au 26, New Street,
St. Helier, Jersey, Ìles Anglo-Normandes, JE2 3 RA, enregistrée sous le numéro 117196, évaluée à trente mille cinq cent
Livres Sterling (30.500,- GBP) correspondant à quarante-six mille huit cent cinquante-deux Dollars américains (46.852,-
USD) (l'«Actif Apporté»).

<i>Preuve de l'existence de l'apport

La valeur de l'Actif Apporté est établie à quarante-six mille huit cent cinquante-deux Dollars américains (46.852,- USD),

et résulte d'un état sur la valeur des gérants de la Société ainsi que d'une déclaration de l'apporteur. Une copie desdits
documents demeurera annexée au présent acte.

<i>Réalisation effective de l'apport

L'Associé Unique, par son mandataire, déclare que:
- il est seul propriétaire de l'Actif Apporté;
- l'Actif Apporté est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
- l'Actif Apporté ne fait l'objet d'aucune contestation ou action en justice;
- l'Actif Apporté est librement transférable, avec tous les droits qui y sont attachés; et
- l'ensemble des formalités, subséquentes au transfert de l'Actif Apporté, requises en vertu de toute loi applicable a

été accompli ou sera accompli afin que l'apport soit valable en tout lieu et à l'égard de tout tiers.

IV. Suite aux résolutions susmentionnées, le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société est modifié pour

avoir désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Souscrit. Le capital social est fixé à sept cent soixante-dix mille six cent cinquante-et-un Dollars

américains (770.651 USD) représenté par sept cent soixante-dix mille six cent cinquante-et-une (770.651) parts sociales
ayant une valeur nominale d'un Dollar américain (1,- USD) chacune.».

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge

à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de neuf cent cinquante Euros (EUR 950.-).

Le montant de l'augmentation du capital social est évalué à EUR 42.531,75.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

53202

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le

présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française.

A la requête de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version

anglaise fera foi.

Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 mars 2015. Relation: GAC/2015/1911. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040454/144.
(150046482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

4Ma S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 140, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 138.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042664/9.
(150048821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

APS Consult S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7447 Lintgen, 11, Bei de Fëschweieren.

R.C.S. Luxembourg B 114.818.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Monsieur Alfred PETERS
<i>Le gérant technique

Référence de publication: 2015042713/11.
(150049680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

Montebello S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 195.244.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the fourth day of March,
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

AIM  Services  S.à  r.l.,  a  société  à  responsabilité  limitée  incorporated  and  existing  under  the  laws  of  Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B74676, having its registered office at
14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg,

here represented by Mrs. Mélanie Muller, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg, on March 2, 2015.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

53203

L

U X E M B O U R G

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Montebello S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning com-
mercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

53204

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
13.2 The manager(s) is (are) appointed by the general meeting of the shareholders which sets the term of their office.

The managers may be dismissed freely at any time, without there having to exist any legitimate reason (“causes légitimes”).

13.3 In the case of several managers, the Company is managed by a board of managers which may be composed of

several classes, i.e. A manager(s) and B manager(s).

13.4 The sole manager or the board of managers may grant special powers by authentic proxy or power of attorney

by private instrument.

13.5 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.6 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

53205

L

U X E M B O U R G

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers is and, in case

several classes of managers have been appointed, at least one (1) class A manager and one (1) class B manager are present
or represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall have a casting vote.

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Should several classes of managers
exist, the minutes shall be signed by a class A and a class B manager. Copies or excerpts of such minutes, which may be
produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) managers or by
a class A and a class B manager should several classes of managers exist.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signatures of any two (2) managers
and by the joint signatures of a class A and a class B manager should several classes of managers exist, or (ii) by the joint
signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board
of managers within the limits of such delegation.

53206

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on the 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

53207

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The 12,500 (twelve thousand five hundred) shares issued have been subscribed as follows:
- Twelve thousand five hundred (12,500) shares have been subscribed by AIM Services S.à r.l., aforementioned, for the

price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred Euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Olivier Hamou, born in Levallois-Perret, France, on 19 December 1973, professionally residing at 19, rue de Bitbourg,

L-1273 Luxembourg, is appointed as manager of the Company for an unlimited term.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède

L'an deux mille quinze, le quatre mars.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

A COMPARU:

AIM Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand Duché de

Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74676, ayant
son siège social à 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg,

dûment représentée par Madame Mélanie Muller, employée, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu

d'une procuration donnée à Luxembourg, le 2 mars 2015.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire des comparant(e)s et le notaire, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société à responsabilité limitée

qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Montebello S.à r.l.» (ci-

après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»),
ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxem-

bourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre
manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi
que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 Excepté par voie d'appel publique à l'épargne, la Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non
garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

53208

L

U X E M B O U R G

2.4 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée.
3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
3.2 Elle peut être dissoute à tout moment sans cause par une décision de l'assemblée générale des associés, adoptée

selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Le siège social peut être transféré au sein de la même commune par décision du conseil de gérance. Il peut être

transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des associés,
adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision

du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec
l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à
la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur
la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500), représenté par douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4  Le  décès,  la  suspension  des  droits  civils,  la  dissolution,  la  liquidation,  la  faillite  ou  l'insolvabilité  ou  tout  autre

événement similaire d'un des associés n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats d'inscription peuvent
être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants à une majorité des trois quarts du capital
social. Un tel agrément n'est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux as-
cendants, descendants ou au conjoint survivant.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

53209

L

U X E M B O U R G

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n'a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d'ordinaire  de  la  compétence  de  l'assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d'associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation à cette assemblée
générale. D'autres assemblées générales d'associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d'un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d'une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants, qui ne sont pas nécessairement associés.
13.2 Le ou les gérants sont nommés par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés, fixant la durée de leur

mandat. Il(s) est/sont librement et à tout moment révocable(s) par l'associé unique ou, selon le cas, les associés.

13.3 En cas de pluralité de gérants, la société est administrée par un conseil de gérance qui pourra être composé de

différentes classes de gérants: c'est-à-dire gérant(s) A et gérant(s) B.

13.4 Le gérant unique ou le conseil de gérance peut accorder un pouvoir spécial par le biais d'un acte authentique ou

sous seing privé.

13.5 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n'est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

13.6 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération

et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d'un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

53210

L

U X E M B O U R G

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs
d'une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d'accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d'un tel
document signé constituera une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d'un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où les tous les gérants seront présents ou re-

présentés à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites
et approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du mandat
en constituant une preuve suffisante. Un gérant peut représenter un ou plusieurs, mais non l'intégralité des membres du
conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s'être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée et, dans le cas où différentes classes de gérants ont été nommées, si au moins un (1) gérant de
classe A et un (1) gérant de classe B sont présents ou représentés à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, dispose d'une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Si plusieurs
classes de gérants ont été nommées, les procès-verbaux seront signés par un gérant de classe A et un gérant de classe
B. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant,
signés par le président ou par deux (2) gérants, ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes
de gérants ont été nommées.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, et par
un gérant de classe A et un gérant de classe B, si plusieurs classes de gérants ont été nommées, ou (ii) par la signature
conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué
par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire - réviseur d'entreprises agréé.
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des

associés.

53211

L

U X E M B O U R G

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans

la Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d'un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

24.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du

nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été souscrites comme suit:
- Douze mille cinq cents(12.500) parts sociales ont été souscrites par AIM Services S.à r.l., susmentionnée, pour un

prix de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire, de sorte que

le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

L'apport global d'un montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est entièrement affecté au capital social.

53212

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ EUR 1.800.-.

<i>Résolutions de l'associé unique

L'associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de con-

vocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L- 1273 Luxembourg.
2. Olivier Hamou, né à Levallois-Perret, France, le 19 décembre 1973, résidant professionnellement au 19, rue de

Bitbourg, L-1273 Luxembourg, est nommé gérant pour une durée indéterminée.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MULLER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7063. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015040528/525.
(150045838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Leopoldstrasse Aviation Finance, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 195.266.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of February.
Before Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Leopoldstrasse Stichting, a foundation (Stichting) established under the laws of Netherlands, having its statutory office

in  Netherlands  at  Claude Debussylaan  24,  1082MD  Amsterdam,  registered with the Dutch  Chamber of  Commerce
(Kamer van Koophandel) under number 854913439,

here duly represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, with professional address at Esch/

Alzette.

by virtue of a proxy given under private seal.
The above named proxy, after been signed "ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), which it declared to
establish:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate name. There is hereby formed a private limited liability company (“société à responsabilité

limitée”) under the name “Leopoldstrasse Aviation Finance” which will be governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg (the "Company"), in particular by the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the "1915 Law") as well as by the present articles of incorporation (the "Articles"). The Company shall be
further subject to the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended (the "2004 Law").

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established on the territory of the commune of the city of Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

53213

L

U X E M B O U R G

2.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised to

transfer the registered office of the Company within the territory of the commune of the city of Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.

2.3 The registered office may be transferred to any other commune in the Grand Duchy of Luxembourg by means of

a resolution of an extraordinary general meeting of its Shareholders deliberating in the manner provided for amendments
of the Articles.

2.4 Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have
any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will
remain a Luxembourg Company. The decision to transfer the registered office abroad will be made by the Sole Manager,
or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

Art. 3. Object.
3.1 The exclusive purpose of the Company is to enter into one or more securitisation transactions within the meaning

of the 2004 Law. The Company may, in this context, assume risks, existing or future, relating to the holding of assets,
whether movable or immovable, tangible or intangible, as well as risks resulting from the obligations assumed by third
parties or relating to all or part of the activities of third parties, in one or more transactions or on a continuous basis.
The Company may assume those risks by acquiring the assets, guaranteeing the obligations or by committing itself in any
other way. It may also transfer, to the extent permitted by law and these Articles, dispose of the claims and other assets
it holds, whether existing or future, in one or more transactions or on a continuous basis.

3.2 The Company may, in this context, acquire, dispose and invest in loans (including, for the avoidance of doubt

aviation loans in their broadest sense), stocks, bonds, debentures, obligations, notes, advances, shares, warrants and other
securities. The Company may grant pledges, other guarantees or security interests of any kind to Luxembourg or foreign
entities and enter into securities lending activity on an ancillary basis.

3.3 The Company may take any measure to safeguard its rights and make any transactions whatsoever which are

directly or indirectly connected with or useful for its purposes and which are able to promote their accomplishment or
development of its corporate object to the largest extent permitted under the 2004 Law.

Art. 4. Compartments.
4.1 In accordance with the 2004 Law, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers is

entitled to create one or more compartments corresponding each to a separate part of the Company's estate.

4.2 Subject to article 4.4 below, all assets allocated to a compartment are exclusively available to investors thereunder

and the creditors whose claims have arisen in connection with the creation, operation or liquidation of that compartment.

4.3 Notwithstanding the foregoing, if, following the redemption or repayment in full of the borrowings of the Company

attributable to a compartment and the satisfaction in full and termination of all obligations of the Company to other
creditors whose claims have arisen in connection with such borrowings or the creation, operation or liquidation of that
compartment, there remain assets under such compartment, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the
Board of Managers may allocate such assets to one (1) or several other compartment or to the general estate of the
Company.

4.4 Claims which are not incurred in relation to the creation, operation or liquidation of a specific compartment may

be paid out of the general estate of the Company or may be apportioned by the Sole Manager or, in case of plurality of
managers, by the Board of Managers between the Company's compartments on a pro rata basis of the assets of those
compartments or on such other basis as it may deem more appropriate.

4.5 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers or his/her/its/their delegates shall

establish and maintain separate accounting records for each compartment of the Company.

4.6 The liquidation of a compartment is decided by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board

of Managers.

Art. 5. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 6. Share capital.
6.1 The share capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by two hundred and

fifty (250) Shares with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each (the "Shares"). The holders of the Shares are together
referred to as the "Shareholders".

6.2 All Shares have equal rights.
6.3 The Company can proceed to the repurchase of its own Shares within the limits set by the 1915 Law.

Art. 7. Shares indivisibility. Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one (1) owner is admitted per

Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their joint representative towards the Company.

53214

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Transfer of Shares.
8.1 In case of a single Shareholder, the Company's Shares held by the single Shareholder are freely transferable.
8.2 In case of plurality of Shareholders, some or all of the Shares held by each Shareholder may be transferred by

application of the requirements of articles 189 and 190 of the 1915 Law.

Chapter III. - Bonds, notes and other debt instruments

Art. 9. Registered or bearer form. The Company may issue bonds, notes or any other debt instruments under regis-

tered or bearer form, it being understood that such bonds, notes or debt instruments shall not be offered nor subscribed
by any US person(s) or Specified US Person(s) as such terms are defined in the United States Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) and the Agreement between the government of the Grand Duchy of Luxembourg and the
government of the United States of America to improve International Tax Compliance and with respect to the United
States information reporting provisions commonly known as FATCA. Bonds, notes or other debt instruments under
registered form may not be exchanged or converted into bearer form. The Company being a private limited liability
company may issue such instruments on a private basis only. The Company is not able to make public offerings, as provided
for by article 188 of the 1915 Law.

Chapter IV. - Management

Art. 10. Management.
10.1 The Company is managed by one (1) or more manager(s) appointed by a resolution of the Shareholder(s). In case

of one (1) manager, he/she/it will be referred to as the "Sole Manager". In case of plurality of managers, they will constitute
a board of managers (“conseil de gérance”) (the "Board of Managers").

10.2 The managers need not to be Shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause,

by a resolution of the Shareholder(s).

Art. 11. Powers of the Sole Manager or of the Board of Managers.
11.1 In dealing with third parties, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers, without

prejudice to articles 10 and 12 of the Articles, will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object, provided the terms of this
article have been complied with.

11.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers is authorised to transfer, assign and

dispose of the assets of the Company in such manner as the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board
of Managers deems appropriate.

11.3 All powers not expressly reserved by the 1915 Law or the Articles to the general meeting of Shareholders fall

within the competence of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 12. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two (2)
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two (2) managers.

Art. 13. Delegation and agent of the Sole Manager or of the Board of Managers.
13.1 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two (2) managers may delegate his/her/its/their powers

for specific tasks to one (1) or more “ad hoc” agents.

13.2 The Sole Manager or, in case of plurality of managers, any two (2) managers will determine such agent's respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant condition of its
agency.

Art. 14. Meeting of the Board of Managers.
14.1 In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers are convened by any manager.
Notice of any meeting of the Board of Managers shall be given to all managers at least two (2) days in advance of the

time set for such meeting.

All pertaining documents regarding each of the items mentioned on the agenda of such meeting shall be attached to

the convening notice: In urgent cases, the meetings may be held within a shorter notice.

The Board of Managers may appoint a chairman.
14.2 The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present

or represented and have waived the convening requirements and formalities.

14.3 Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax

or email or letter another manager as his/her/its proxy. A manager may also appoint another manager to represent him/
her/it by phone to be confirmed subsequently in writing.

14.4 The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or

represented. Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority of the votes cast.

53215

L

U X E M B O U R G

14.5 The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating

manager is able to hear and to be heard by all other participating managers, and each participating manager shall be deemed
to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

14.6 A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of

the Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or
in several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

14.7 The minutes of a meeting of the Board of Managers shall be signed by all managers present or represented at the

meeting. Extracts shall be certified by any manager or by any person nominated by any manager during a meeting of the
Board of Managers. Each manager will receive a copy of the minutes of the meeting of the Board of Managers within one
(1) month after the meeting has been held.

Art. 15. Advisory Committee.
15.1 Setting up and powers An advisory committee (the “Advisory Committee”) shall be set up by the Sole Manager

or, as the case may be, by the Board of Managers, with the following powers:

- discussing any matter in connection with the business activity of the Company; and
- issuing non-binding recommendations and/or advices to the Sole Manager or, as the case may be, the Board of

Managers with respect to the business activity of the Company.

15.2 Composition
The Advisory Committee is composed of at least one (1) executive member of (i) Allianz Versicherungs-AG, a cor-

porate entity with its registered office in Munich (Germany) or (ii) Allianz Global Corporate &amp; Specialty SE, a corporate
entity with its registered office in Munich (Germany) (“Allianz”) (the “Members of the Advisory Committee”).

The Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers appoint the members of the Advisory Committee.

Those members shall only be chosen among the Allianz executive members.

The chairman of the Advisory Committee (the "Chairman") shall be appointed by the Members of the Advisory Com-

mittee.

The Chairman shall chair the meetings and, if he/she is prevented from doing so, a deputy chairman, appointed by the

Members of the Advisory Committee shall chair the meeting.

15.3 Convening
The meetings of the Advisory Committee shall be convened by the Chairman or, if he/she is prevented from doing so,

by any other Member of the Advisory Committee, as often as the circumstances require.

Notice of any meeting of the Advisory Committee shall be given to all Members of the Advisory Committee at least

two (2) days in advance of the time set for such meeting.

All pertaining documents regarding each of the items mentioned on the agenda shall be attached to the convening

notice: In urgent cases, the meetings may be held within a shorter notice.

The Advisory Committee may validly debate and take decisions without prior notice if all the Members of the Advisory

Committee are present or represented and have waived the convening requirements and formalities.

15.4 Meeting of the Advisory Committee
Each Member of the Advisory Committee may act at any meeting of the Advisory Committee by appointing in writing,

by telefax or email or letter another Member of the Advisory Committee as his/her proxy. A Member of the Advisory
Committee may also appoint another Member of the Advisory Committee to represent him/her/ by phone, to be con-
firmed subsequently in writing.

The Advisory Committee can only validly deliberate and take decisions if a majority of its Members is present or

represented. Decisions of the Advisory Committee shall be adopted by a simple majority of the votes cast. Each Member
has one vote.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Member

of the Advisory Committee is able to hear and to be heard by all other participating Members of the Advisory Committee
and each participating Member of the Advisory Committee shall be deemed to be present and shall be authorised to vote
by video or by telephone.

15.5 Recommendations
The Advisory Committee may only issue non-binding recommendations and advice to the sole Manager or, as the case

may be, the Board of Managers regarding the items listed in Article 15.1.

15.6 Minutes
The Advisory Committee shall keep minutes of its meetings, recommendations and/or advice.
The minutes shall mention the presence and the names of the attending Members and of any third party, as the case

may be, invited to attend.

The minutes of any meeting of the Advisory Committee shall be signed by all Members of the Advisory Committee

present or represented at the meeting. Extracts shall be certified by any Member of the Advisory Committee or by any
person nominated by any Member of the Advisory Committee during a meeting of the Advisory Committee. Each Ad-

53216

L

U X E M B O U R G

visory Committee Member will receive a copy of each of the minutes no later than three (3) business days after such
meeting has been held.

A written decision, signed by all the Members of the Advisory Committee, is proper and valid as though it was adopted

at a meeting of the Advisory Committee, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a
single document or in several separate documents having the same content signed by all the Members of the Advisory
Committee.

The minutes of any meeting shall be remitted to the Sole Manager or, as the case may be, the Board of Managers not

later than three (3) business days following each meeting.

Art. 16. External and independent auditor(s).
16.1 The accounts of the Company are audited by one or more external and independent auditor(s) (“reviseur(s)

d'entreprises agréé(s)”) appointed by the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the Board of Managers.

16.2 They are re-eligible.

Chapter V. - General meeting of Shareholders

Art. 17. Powers of the general meeting of Shareholder(s) - Votes.
17.1 If there is only one (1) Shareholder, that sole Shareholder assumes all the powers conferred to the general meeting

of Shareholders and takes each decision in writing.

17.2 In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in decisions irrespectively of the number

of Shares, which he/she/it owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his/her/its shareholding. All Shares
have equal voting rights.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to Shareholders to their address appearing

in the register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days prior to the date of the meeting. If
the entire share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice. In
the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the Shareholders at their addresses in the
register of Shareholders held by the Company at least eight (8) calendar days before the proposed effective date of the
resolutions. Unanimous written resolutions may be passed at any time without prior notice. If all the Shareholders are
present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

The quorum requirements, if any, are those provided for by the Luxembourg law.
17.3 If there are more than twenty-five (25) Shareholders, the Shareholders' decisions have to be taken at meetings

to be convened in accordance with the applicable legal provisions.

17.4 If there are less than twenty-five (25) Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be

taken and cast its vote in writing.

17.5 At a Shareholders' meeting a Shareholder may be represented by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) a representative who does not need to be a Shareholder.

17.6 Decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the Company's share capital

adopt them. However, resolutions to amend the Articles may only be adopted by the majority of the Shareholders owning
at least three-quarters of the Company's share capital, subject to any other provision of the 1915 Law.

Chapter VI. - Business year

Art. 18. Business year.
18.1 The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty first of December of each year,

except for the Company's first financial year which starts on the day of incorporation of the Company and ends on the
thirty first of December 2015.

18.2 At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Sole Manager or, in case of

plurality of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of
Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

18.3 Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 19. Distribution right of Shares.
19.1 The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating expenses, charges and depre-

ciations shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.

19.2 From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions, five per cent (5%) shall be

deducted and allocated to a legal reserve. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve
reaches ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

19.3 To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by the Articles, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose
that cash available for remittance be distributed.

19.4 The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by a

majority vote of the share capital.

53217

L

U X E M B O U R G

19.5 Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of

Managers may decide to pay interim dividends to the Shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of
a statement of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount
to be distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by
carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to
a reserve to be established according to the 1915 Law or the Articles and that (ii) any such distributed sums which do
not correspond to profits actually earned shall be reimbursed by the Shareholder(s).

Chapter VII. - Liquidation

Art. 20. Dissolution and liquidation.
20.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy

of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

20.2 The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders' meeting in accordance with the applicable

legal provisions.

20.3 The liquidation will be carried out by one or several liquidator(s), Shareholder(s) or not, appointed by the Sha-

reholders who shall determine their powers and remuneration.

20.4 The balance remaining after payment of the debts of the dissolved Company shall be transferred to the Share-

holders in proportion to the aggregate nominal value of the Shares held by each.

Chapter VIII. - Applicable law

Art. 21. Applicable law. Reference is made to the provisions of the laws of Grand Duchy of Luxembourg for all matters

for which no specific provision is provided for in the Articles.

<i>Subscription - Payment

The capital has been subscribed as follows:

Shares:
Leopoldstrasse Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Shares
Total: two hundred and fifty Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Shares

All these Shares, each with a nominal value of fifty Euro (50.- EUR), have been fully paid up, so that the sum of twelve

thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500.-) is forthwith at the free disposal of the Company.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about 1,500.- euro.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named party, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers of the Company for an undetermined period:
(a) KOSSMANN Christoph B.N., manager, with professional address at 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, born

in Homburg on 21 June 1957;

(b) BOULHAÏS El Ahcène, manager, with professional address at 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg, born in

Thionville on 12 December 1977;

(c) GERARD Nicolas André, manager, with professional address at 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxembourg born in

Libramont-Chevigny on 20 April 1981.

In accordance with article 12 of the Articles, the Company shall be bound by the joint signature of any two (2) Managers

or by the signature of any person to whom such power shall be delegated jointly by any two (2) Managers.

2) The Company shall have its registered office at 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he/she/it signed together with the notary the present deed.

53218

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Übersetzung:

Im Jahr zweitausendfünfzehn, am neunzehnten Tag des Monats Februar.
Vor dem unterzeichnenden Notar Francis KESSELER, mit Amtssitz in Esch/Alzette, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Leopoldstrasse  Stichting,  eine  Stiftung  (Stichting)  gegründet  nach  niederländischem  Recht,  mit  Gesellschaftssitz  in

Claude Debussylaan 24, 1082MD Amsterdam, eingetragen im niederländischen Handelsregister (Kamer van Koophandel)
unter der Nummer 854913439,

hier vertreten durch Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, Privatbeamtin, geschäftsansässig in Esch/Alzette,
aufgrund einer Private ausgestellten Vollmacht.
Die vorerwähnte Vollmacht bleibt, nach Paraphierung „ne varietur“ durch die erschienene Partei und die beurkundende

Notarin, vorliegender Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.

Die Erschienene, vertreten wie oben erwähnt, ersucht die unterzeichnende Notarin, die Satzung einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung nach luxemburgischem Recht („société à responsabilité limitée“) wie folgt zu beurkunden:

SATZUNG

Kapitel I. - Form. Name, Gesellschaftssitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Form und Name.
1.1 Dieses Dokument stellt die Satzung der „Leopoldstrasse Aviation Finance“ (die "Gesellschaft") dar, eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung („société à responsabilité limitée“), welche den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg,
insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften, wie abgeändert (das "Gesetz von 1915"),
und der vorliegenden Satzung (die "Satzung") unterliegt. Die Gesellschaft unterliegt ferner dem luxemburgischen Gesetz
vom 22. März 2004 über die Verbriefung in seiner aktuellen Fassung (das "Gesetz von 2004").

Art. 2. Gesellschaftssitz.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft liegt im Bezirk der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
2.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführer, der Rat der Geschäftsführer darf den

Gesellschaftssitz innerhalb der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, verlegen.

2.3 Durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, der im Einklang mit den Vorschriften über die Satzungs-

änderung gefasst wurde, kann der Gesellschaftssitz in eine andere Gemeinde im Großherzogtum Luxemburg verlegt
werden.

2.4 Sollte eine Situation eintreten oder als voraussehbar betrachtet werden, die die normale Geschäftstätigkeit der

Gesellschaft am Gesellschaftssitz oder den ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zwischen diesem Sitz und dem Ausland
durch außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder sonstiger Art ge-
fährdet werden, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse
ins Ausland verlegt werden; diese Maßnahmen betreffen jedoch in keiner Weise die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft,
welche ungeachtet der vorübergehenden Sitzverlegung, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss über die
vorübergehende Sitzverlegung der Gesellschaft wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren
Geschäftsführern, durch den Rat der Geschäftsführer getroffen.

Art. 3. Zweck.
3.1. Der ausschließliche Zweck der Gesellschaft liegt in der Eingehung von einer oder mehreren Verbriefungstransak-

tionen.  In  diesem  Zusammenhang  darf  die  Gesellschaft  in  einer  oder  mehreren  Transaktionen  beziehungsweise  auf
kontinuierlicher Basis bestehende oder zukünftige Risiken, die im Zusammenhang mit der Verwahrung des Vermögens
stehen, unabhängig davon, ob beweglich oder unbeweglich, materiell oder immateriell, sowie Risiken übernehmen, die
aus den von Dritten übernommenen Verpflichtungen resultieren oder sich auf alle beziehungsweise einen Teil der von
Dritten ausgeführten Tätigkeiten beziehen. Die Übernahme solcher Risiken kann durch den Erwerb der Vermögenswerte,
Gewährung von Garantien bezüglich der Verpflichtungen oder durch eine Verpflichtung in sonstiger Weise erfolgen.
Innerhalb  des  vom  Gesetz  und  von  der  Satzung  bestimmten  Rahmens  darf  die  Gesellschaft  in  einer  oder  mehreren
Transaktionen beziehungsweise auf kontinuierlicher Basis über bestehende oder zukünftige Forderungen und andere
Vermögenswerte verfügen und sie übertragen.

3.2 In diesem Zusammenhang darf die Gesellschaft Darlehen (einschließlich Luftfahrtdarlehen im weitetesten Sinne),

Aktien, Anleihen, Schuldverschreibungen, Obligationen, Schuldscheine, Fortschritte, Optionsscheine und andere Wert-
papiere erwerben, veräußern, darin investieren und sonst darüber verfügen. Die Gesellschaft darf Pfandrechte, sonstige
Garantien oder Sicherungsrechte aller Art luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen gewähren, und auf er-
gänzender Basis in Wertpapierleihegeschäfte eintreten.

3.3 Die Gesellschaft kann Maßnahmen zum Schutz ihrer Rechte treffen und Transaktionen jeglicher Art vornehmen,

die unmittelbar oder mittelbar mit dem Gesellschaftszweck in Verbindung stehen, oder dem Gesellschaftszweck nützen
und geeignet sind, seine Erreichung oder Förderung voranzubringen.

53219

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Teilvermögen.
4.1 Gemäß dem Gesetz von 2004 ist der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der

Rat der Geschäftsführer berechtigt, ein oder mehrere Teilvermögen zu bilden, die jeweils einem gesonderten Teil des
Gesamtvermögens der Gesellschaft entsprechen.

4.2 Unter Vorbehalt des untenstehenden Artikels 4.4, stehen sämtliche Vermögenswerte, die einem Teilvermögen

zugeordnet sind, ausschließlich den diesbezüglichen Investoren und denjenigen Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprü-
che im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung dieses Teilvermögens entstanden sind.

4.3 Unbeschadet dessen gilt, dass, falls nach vollständiger Tilgung oder Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten der

Gesellschaft, die einem Teilvermögen zuzuordnen sind und nach vollständiger Erfüllung und vollständigem Erlöschen aller
Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  gegenüber  sonstigen  Gläubigern,  deren  Ansprüche  in  Zusammenhang  mit  solchen
Kreditverbindlichkeiten oder Gründung, Verwaltung oder Auflösung des betreffenden Teilvermögens entstanden sind,
noch Vermögenswerte des betreffenden Teilvermögens übrig bleiben, der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von
mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer diese überschüssigen Vermögenswerte auf ein beziehungsweise
mehrere andere Teilvermögen oder die allgemeine Vermögensmasse der Gesellschaft umverteilen darf.

4.4 Ansprüche die nicht im Zusammenhang mit der Gründung, der Verwaltung oder der Auflösung eines bestimmten

Teilvermögens entstanden sind, können aus der allgemeinen Vermögensmasse der Gesellschaft gezahlt werden oder von
dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern dem Rat der Geschäftsführer auf die Aktiva
der einzelnen Teilvermögen auf pro rata Basis oder auf jede andere Weise aufgeteilt werden, die als geeignet erscheint.

4.5 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer bezie-

hungsweise  deren  Bevollmächtigte  sollen  einzelne  Kontenführungsberichte  für  jedes  Teilvermögen  der  Gesellschaft
erstellen und führen.

4.6 Die Auflösung von Teilvermögen kann von dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäfts-

führern, dem Rat der Geschäftsführer beschlossen werden.

5. Art. 5. Dauer. Die Gesellschaft wird für eine unbegrenzte Zeitdauer errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 6. Gesellschaftskapital.
6.1  Das  Gesellschaftskapital  beträgt  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  12.500,-)  eingeteilt  in  zweihundertfünfzig

(250) Gesellschaftsanteile zu je fünfzig Euro (EUR 50,-) (die "Gesellschaftsanteile"). Die Inhaber der Gesellschaftsanteile
werden als "Gesellschafter" bezeichnet.

6.2 Alle Gesellschaftsanteile haben gleiche Rechte.
6.3 Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes von 1915 ihre eigenen Gesellschaftsanteile zurückkaufen.

Art. 7. Unteilbarkeit der Gesellschaftsanteile. Gegenüber der Gesellschaft ist jeder Gesellschaftsanteil unteilbar, da

lediglich ein (1) Inhaber per Geschäftsanteil zulässig ist. Gemeinsame Inhaber eines Gesellschaftsanteils haben der Ge-
sellschaft mitzuteilen, welche Einzelperson von ihnen als ihr gemeinsamer Vertreter angesehen werden soll.

Art. 8. Übertragung der Gesellschaftsanteile.
8.1 Falls die Gesellschaft einen Alleingesellschafter hat, sind die Gesellschaftsanteile frei übertragbar.
8.2 Im Falle einer Mehrzahl von Gesellschaftern, unterliegt die Übertragung der Gesellschaftsanteile den Bestimmungen

der Artikel 189 und 190 des Gesetzes von 1915.

Kapitel III. - Anleihen, Schuldverschreibungen und andere Schuldtitel

Art. 9. Namens- oder Inhaberpapiere. Die Gesellschaft kann Anleihen, Schuldverschreibungen oder andere Schuldtitel

als Namens- oder Inhaberpapiere begeben. Vertrieb von diesen an oder Zeichnung dieser Anleihen, Schuldverschreibun-
gen oder Schuldtitel durch US-Personen oder spezifizierte US-Personen, wie im United States Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA) und im Abkommen zwischen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg und der Regie-
rung von Vereinigten Staaten von Amerika zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und
hinsichtlich der als Gesetz über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten bekannten US-amerikanischen Informa-
tions- und Meldebestimmungen, allgemein als FATCA bekannt, definiert, findet nicht statt. Anleihen, Schuldverschrei-
bungen oder andere Schuldtitel, die als Namenspapiere begeben wurden, können nicht in Inhaberpapiere umgetauscht
oder umgewandelt werden. Da es sich bei der Gesellschaft um eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung handelt, kann
sie solche Instrumente lediglich auf privater Grundlage begeben. Gemäß Artikel 188 des Gesetzes von 1915, ist der
Gesellschaft nicht gestattet öffentliche Emissionen vorzunehmen.

Kapitel IV. - Geschäftsführung

Art. 10. Geschäftsführung.
10.1 Die Gesellschaft wird von einem (1) oder mehreren Geschäftsführern geführt, welche durch Beschluss der Ge-

sellschafterversammlung bestellt werden. Für den Fall, dass die Gesellschaft nur über einen (1) Geschäftsführer verfügt,

53220

L

U X E M B O U R G

wird dieser als "alleiniger Geschäftsführer" bezeichnet. Für den Fall, dass die Gesellschaft über mehrere Geschäftsführer
verfügt, bilden die Geschäftsführer den Rat der Geschäftsführer („conseil de gérance“) (der "Rat der Geschäftsführer").

10.2 Es ist nicht erforderlich, dass die Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft sind. Ein Geschäftsführer kann

jederzeit aus jedem Grund oder grundlos durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung abberufen werden.

Art. 11. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers oder des Rates der Geschäftsführer.
11.1 Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 10 und 12 dieser Satzung, kann der alleinige Geschäftsführer oder,

im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, im Namen der Gesellschaft alle Rechtsgeschäfte
und Tätigkeiten, die mit dem Gesellschaftszweck konform sind, vornehmen, vorausgesetzt, dass dieser Artikel beachtet
worden ist.

11.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer ist

befugt, Vermögenswerte der Gesellschaft zu verkaufen, zu übertragen, zu belasten, abzutreten oder anderweitig darüber
zu verfügen, wie es der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäfts-
führer für angemessen erachtet.

11.3 Sämtliche Befugnisse, die nicht durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich der Gesell-

schafterversammlung vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle
von mehreren Geschäftsführern, des Rates der Geschäftsführer.

Art. 12. Rechtmäßige Vertretung. Eine Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten erfolgt, für den Fall des allei-

nigen Geschäftsführers, durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, im Falle von mehreren Geschäfts-
führern, durch die gemeinsame Unterschrift zwei beliebiger (2) Geschäftsführer oder durch die alleinige Unterschrift der
Person, auf die im Falle des alleinigen Geschäftsführers durch ihn oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, durch
zwei beliebige (2) Geschäftsführer, eine solche Unterschriftsbefugnis übertragen wurde.

Art. 13. Bevollmächtigter des alleinigen Geschäftsführers oder des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei (2) beliebige Geschäftsführer,

kann/können einem zu diesem Zweck berufenen Vertreter für spezifische Aufgaben Untervollmacht erteilen.

13.2 Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, zwei (2) beliebige Geschäftsführer

bestimmt/bestimmen den Verantwortungsbereich und (gegebenenfalls) die Bezahlung, die Dauer und alle anderen we-
sentlichen Bedingungen der Vertretung.

Art. 14. Geschäftsführerversammlung.
14.1 Im Falle der Mehrheit von Geschäftsführern kann die Versammlung des Rates der Geschäftsführer (die "Ge-

schäftsführerversammlung") von jedem Geschäftsführer einberufen werden.

Zu jeder Geschäftsführerversammlung werden alle Geschäftsführer durch eine Mitteilung einberufen, die mindestens

zwei (2) Tage vor dem Zeitpunkt, der für eine solche Versammlung festgelegt wurde, erfolgen muss.

Alle dazugehörigen Unterlagen, die im Zusammenhang mit den in der Versammlungstagesordnung erwähnten Punkten

stehen, sind dem Einberufungsschreiben beizufügen: In dringenden Fällen kann die Versammlung auch innerhalb einer
kürzeren Einberufungsfrist stattfinden.

Der Rat der Geschäftsführer kann einen Vorsitzenden wählen.
14.2 Ohne vorherige Einberufungsmitteilung kann der Rat der Geschäftsführer wirksam beraten und Beschlüsse fassen,

wenn alle Geschäftsführer an der Geschäftsführerversammlung persönlich teilnehmen oder vertreten sind und auf die
Einberufungserfordernisse und -formalitäten verzichtet haben.

14.3  Jeder  Geschäftsführer  kann  bei  jeder  Geschäftsführerversammlung  einen  anderen  Geschäftsführer  schriftlich,

mittels eines Telegramms, eines Telefaxes, einer Email oder eines Briefes zu seinem Vertreter ernennen. Ein Geschäfts-
führer ist auch befugt, einen anderen Geschäftsführer telefonisch zu seinem Vertreter zu bestimmen, wobei dies später
schriftlich zu bestätigen ist.

14.4 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn die Mehrheit der

Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen des Rates der Geschäftsführer werden durch einfache
Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

14.5 Die Verwendung von Videokonferenz- und Telefonkonferenzeinrichtungen ist zulässig, wenn alle teilnehmenden

Geschäftsführer während der gesamten Versammlung in der Lage sind, sich gegenseitig zu hören und zu sprechen. Ein in
dieser Weise teilnehmender Geschäftsführer gilt als persönlich in der Versammlung anwesend und ist befugt, mittels
Video oder Telefon seine Stimme abzugeben.

14.6 Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurde, ist ordnungsgemäß und rechts-

kräftig, wenn er in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführerversammlung gefasst wurde. Er
kann aus einem einzigen Dokument oder aus verschiedenen, den gleichen Inhalt enthaltenden Dokumenten bestehen, die
von oder im Namen eines oder allen betreffenden Mitgliedern des Rates der Geschäftsführer unterschrieben wurden.

14.7 Die Protokolle der Geschäftsführerversammlung werden von allen anwesenden oder vertretenen Geschäftsfüh-

rern  unterschreiben.  Auszüge  werden  von  einem  beliebigen  Geschäftsführer  oder  einer  Person,  die  durch  einen

53221

L

U X E M B O U R G

Geschäftsführer während der Geschäftsführerversammlung ernannt worden ist, zertifiziert. Jeder Geschäftsführer be-
kommt eine Kopie des Protokolls innerhalb eines (1) Monats, nachdem die Versammlung abgehalten wurde.

Art. 15. Beratungsausschuss.
15.1 Einrichtung und Zuständigkeiten
Ein Beratungsausschuss (der „Beratungsausschuss“) wird durch den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von meh-

reren Geschäftsführern vom Rat der Geschäftsführer eingerichtet. Dem Beratungsausschuss werden folgende Zustän-
digkeiten zugewiesen:

- Besprechung aller Fragen, die im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft stehen; und
- Erteilung von unverbindlichen Empfehlungen und / oder Ratschlägen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit der Gesell-

schaft an den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, an den Rat der Geschäftsführer.

15.2 Zusammensetzung
Der Beratungsausschuss setzt sich aus mindestens einem (1) Mitglied des Leitungsorgans/der Leitungsorgane der (i)

Allianz Versicherungs-AG, einer Gesellschaft mit Sitz in München (Deutschland) oder (ii) Allianz Global Corporate &amp;
Specialty SE, einer Gesellschaft mit Sitz München (Deutschland)(„Allianz“) zusammen (die „Mitglieder des Beratungsaus-
schusses“).

Der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer ernennt die

Mitglieder des Beratungsausschusses. Mitglieder des Beratungsausschusses dürfen nur aus dem Kreis der Mitglieder des
Leitungsorgans/der Leitungsorgane von Allianz gewählt werden.

Mitglieder des Beratungsausschusses wählen den Vorsitzenden des Beratungsausschusses (der "Vorsitzende").
Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden geleitet. Sollte er daran gehindert sein, werden die Sitzungen vom stellver-

tretenden Vorsitzenden, der von den Mitgliedern des Beratungsausschusses ernannt wird, geleitet.

15.3 Einberufung
Die Sitzungen des Beratungsausschusses werden vom Vorsitzenden oder, falls er daran gehindert ist, von jedem an-

deren Mitglied des Beratungsausschusses so oft, wie die Umstände dies erfordern.

Zu jeder Sitzung des Beratungsausschusses werden alle seine Mitglieder durch eine Mitteilung einberufen, die mindes-

tens zwei (2) Tage vor dem Zeitpunkt, der für eine solche Sitzung festgelegt wurde, erfolgen muss.

Alle dazugehörigen Unterlagen, die im Zusammenhang mit den in der Sitzungstagesordnung erwähnten Punkten stehen,

sind dem Einberufungsschreiben beizufügen: In dringenden Fällen kann die Sitzung auch innerhalb einer kürzeren Einbe-
rufungsfrist stattfinden.

Ohne vorherige Einberufungsmitteilung kann der Beratungsausschuss wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn

alle seine Mitglieder persönlich anwesend oder vertreten sind und auf die Einberufungserfordernisse und -formalitäten
verzichtet haben.

15.4 Sitzung des Beratungsausschusses
Jedes Mitglied des Beratungsausschusses kann bei jeder Sitzung des Beratungsausschusses ein anderes Mitglied des

Beratungsausschusses schriftlich, mittels eines Telegramms, eines Telefaxes, einer Email oder eines Briefes zu seinem
Vertreter ernennen. Ein Mitglied des Beratungsausschusses ist auch befugt, ein anderes Mitglied des Beratungsausschusses
telefonisch zu seinem Vertreter zu bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Beratungsausschuss kann nur dann wirksam beraten und Beschlüsse fassen, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Entscheidungen des Beratungsausschusses werden durch einfache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen getroffen. Jedes Mitglied hat eine Stimme.

Die Verwendung von Videokonferenz- und Telefonkonferenzeinrichtungen ist zulässig, wenn alle teilnehmenden Mit-

glieder  des  Beratungsausschusses  während  der  gesamten  Sitzung  in  der  Lage  sind,  sich  gegenseitig  zu  hören  und  zu
sprechen. Ein in dieser Weise teilnehmendes Mitglied des Beratungsausschusses gilt als persönlich in der Sitzung anwesend
und ist befugt, mittels Video oder Telefon seine Stimme abzugeben.

15.5 Empfehlungen
Der Beratungsausschuss erteilt an den alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern an

den Rat der Geschäftsführer, lediglich unverbindliche Empfehlungen und Ratschläge in Bezug auf die in Artikel 15.1 auf-
geführten Punkte.

15.6 Sitzungsprotokolle
Der Beratungsausschuss verwahrt Protokolle seiner Sitzungen, seine Empfehlungen und / oder Ratschläge.
Das Protokoll enthält Information zur Anwesenheit sowie die Namen der anwesenden Mitglieder und Dritter, die zur

Sitzung eingeladen wurden.

Die Protokolle zu jeder Beratungsausschusssitzung werden von allen anwesenden oder vertretenen Mitgliedern des

Beratungsausschusses unterschreiben. Auszüge werden von einem beliebigen Mitglied des Beratungsausschusses oder
einer Person, die durch ein Mitglied des Beratungsausschusses während der Beratungsausschusssitzung ernannt worden
ist, zertifiziert. Jedes Mitglied des Beratungsausschusses bekommt eine Kopie des Sitzungsprotokolls innerhalb von drei
(3) Arbeitstagen, nachdem die Sitzung abgehalten wurde.

53222

L

U X E M B O U R G

Ein schriftlicher Beschluss, der von allen Mitgliedern des Beratungsausschusses unterzeichnet wurde, ist ordnungsge-

mäß und rechtskräftig, wenn er in einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Beratungsausschusssitzung gefasst
wurde. Er kann aus einem einzigen Dokument oder aus verschiedenen, den gleichen Inhalt enthaltenden Dokumenten
bestehen, die von allen Mitgliedern des Beratungsausschusses unterschrieben wurden.

Das Protokoll zu jeder Sitzung des Beratungsausschusses wird dem alleinigen Geschäftsführer oder, im Falle von meh-

reren  Geschäftsführern  dem  Rat  der  Geschäftsführer  spätestens  am  dritten  (3.)  Arbeitstag,  nachdem  die  Sitzung
abgehalten wurde, zur Verfügung gestellt.

Art. 16. Zugelassene(r) Wirtschaftsprüfer.
16.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft werden von einem oder mehreren externen unabhängigen Wirtschafts-

prüfern  („réviseur(s)  d'entreprises  agréé(s)“)  geprüft,  welche(r)  vom  alleinigen  Geschäftsführer  oder,  im  Falle  von
mehreren Geschäftsführern vom Rat der Geschäftsführer gewählt wird.

16.2 Der oder die zugelassene(n) Wirtschaftsprüfer kann/können wiedergewählt werden.

Kapitel V. - Gesellschafterversammlung

Art. 17. Beschlüsse der Gesellschafterversammlung.
17.1 Hat die Gesellschaft einen Gesellschafter, soll dieser Alleingesellschafter sämtliche Befugnisse erhalten, die der

Hauptversammlung zustehen. Die Beschlussfassungen sollen in diesem Fall schriftlich durch den Alleingesellschafter er-
folgen.

17.2 Im Falle von mehreren Gesellschaftern kann jeder Gesellschafter unabhängig von der Anzahl der von ihm gehalt-

enen  Anteile  an  Entscheidungsfindungen  teilnehmen.  Jedem  Gesellschafter  stehen  Stimmrechte  entsprechend  seiner
Beteiligung an der Gesellschaft zu. Alle Anteile haben gleiche Stimmrechte.

Die Einberufung der Gesellschafterversammlung soll mindestens acht (8) Kalendertage vor der Versammlung an jeden

Gesellschafter durch schriftliche Einberufungsmitteilung per Einschreiben an die Adresse, welche im Anteilsregister ver-
zeichnet ist, erfolgen. Sofern das gesamte gezeichnete Kapital in der Gesellschafterversammlung vertreten ist, kann die
Gesellschafterversammlung ohne vorherige schriftliche Einberufungsmitteilung abgehalten werden. Bei Vorliegen eines
Umlaufbeschlusses muss der Text eines solchen Umlaufbeschlusses den Gesellschaftern an die jeweiligen Adressen, aus
dem Anteilsregister, welches von der Gesellschaft geführt wird, mindestens acht (8) Kalendertage vor Wirksamwerden
des Umlaufbeschlusses, zugesandt werden. Ein einstimmiger Umlaufbeschluss kann zu jeder Zeit ohne vorherige Mitteilung
ergehen. Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, kann auf die Einhaltung der Einberufungserfordernisse
verzichtet werden und die Gesellschafterversammlung kann ohne vorherige Mitteilung durchgeführt werden.

Die Regeln über die Beschlussfähigkeit, falls anwendbar, sind den luxemburgischen Gesetzen zu entnehmen.
17.3 Bei Vorliegen von mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern müssen die Gesellschafterbeschlüsse in einer

Gesellschafterversammlung, die gemäß den anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen einberufen worden ist, gefasst wer-
den.

17.4 Bei Vorliegen von weniger als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern darf jeder Gesellschafter den Text der zu

fassenden Beschlüsse erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

17.5 Ein Gesellschafter kann sich bei einer Gesellschafterversammlung durch einen schriftlich (oder per Fax oder E-

Mail oder durch ein anderes entsprechendes elektronisches Mittel) bestellten Stellvertreter vertreten lassen, der kein
Gesellschafter sein muss, und ist dementsprechend berechtigt, sich bei der Abstimmung durch einen Stimmrechtsbevoll-
mächtigten vertreten zu lassen.

17.6 Beschlüsse werden nur dann wirksam, sofern sie von Gesellschaftern, denen mehr als die Hälfte der Anteile der

Gesellschaft gehören, gefasst wurden. Beschlüsse, die die Satzung abändern sollen, werden vorbehaltlich anderer Vor-
schriften des Gesetzes von 1915 nur dann wirksam, wenn diese durch die Mehrheit der Gesellschafter, die zusammen
mindestens drei Viertel der Anteile der Gesellschaft halten, angenommen wurden.

Kapitel VI. - Geschäftsjahr

Art. 18. Geschäftsjahr.
18.1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember jedes

Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft beginnt und am ein-
unddreißigsten Dezember 2015 endet.

18.2 Am Ende jedes Geschäftsjahres hat der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern,

der  Rat  der  Geschäftsführer  die  Bilanz-  und  die  Gewinn-  und  Verlustrechnung  zu  erstellen.  Ferner  hat  der  alleinige
Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern der Rat der Geschäftsführer einen Geschäftsbericht unter
Angabe der Vermögenswerte und der Verpflichtungen der Gesellschaft zu erstellen.

18.3  Jeder  Gesellschafter  kann  in  den  oben  genannten  Geschäftsbericht  und  die  Jahresabschlussbilanz  am  Gesell-

schaftssitz Einsicht nehmen.

53223

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Ausschüttungen.
19.1 Die Gewinne eines Geschäftsjahres nach Abzug der generellen und operativen Kosten, Belastungen und Ab-

schreibungen stellen den Nettogewinn der Gesellschaft für diesen Zeitraum dar.

19.2 Vom Nettogewinn der Gesellschaft, welcher in Übereinstimmung mit den anwendbaren rechtlichen Bestimmun-

gen  ermittelt  wurde,  werden  fünf  Prozent  (5%)  zur  Bildung  der  gesetzlichen  Rücklage  verwendet.  Diese  zwingende
Verpflichtung zur Bildung der Rücklage erlischt, wenn diese Rücklage einen Betrag erreicht hat, der zehn Prozent (10%)
des Gesellschaftskapitals entspricht.

19.3 Für den Fall, dass auf der Ebene der Gesellschaft Geldmittel für die Ausschüttung zur Verfügung stehen und falls

diese durch das Gesetz von 1915 und diese Satzung vorgesehen ist, kann der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von
mehreren Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer anregen, dass Barmittel, welche für eine Remission zur Verfü-
gung stehen, ausgeschüttet werden.

19.4 Die Entscheidung über die Ausschüttung von Geldmitteln und die Bestimmung der Höhe einer solchen Aus-

schüttung wird durch einen Gesellschafterbeschluss getroffen, der von den Gesellschaftern angenommen wurde, die die
Mehrheit des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

19.5 Ungeachtet der vorangegangenen Bestimmungen kann der alleinige Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren

Geschäftsführern, der Rat der Geschäftsführer, vor Ablauf des Geschäftsjahres auf Grundlage einer Zwischenbilanz, die
zeigt, dass genügend Mittel zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, die Zahlung einer Interimsdividende an den/die Ge-
sellschafter beschließen, wobei zu beachten ist, dass (i) der auszuschüttende Betrag (wenn anwendbar) den seit Ende des
letzten Geschäftsjahres realisierten Gewinn - erhöht um den Gewinnvortrag und die ausschüttungsfähige Reserve und
reduziert um den Verlustvortrag und den Betrag, der im Einklang mit dem Gesetz von 1915 bzw. mit dieser Satzung in
die Rücklage einfließen muss - nicht übersteigen darf und dass (ii) solche ausgeschütteten Beträge, die nicht dem wirklichen
Gewinn entsprechen, von den Gesellschaftern zurückzuerstatten sind.

Kapitel VII. - Liquidation

Art. 20. Auflösung und Liquidation.
20.1 Die Gesellschaft wird nicht durch einen Todesfall, die Aussetzung der bürgerlichen Rechte, die Zahlungsunfähigkeit

oder die Insolvenz des alleinigen Gesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

20.2 Die Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft wird von der Gesellschafterversammlung in Übereinstim-

mung mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften getroffen.

20.3 Die Liquidation wird durch einen oder mehrere Liquidatoren, die nicht notwendigerweise Gesellschafter sein

müssen, durchgeführt. Die Liquidatoren werden von den Gesellschaftern ernannt, welche deren Befugnisse und Vergütung
festlegen.

20.4 Der Überschuss nach Zahlung aller Verbindlichkeiten der aufgelösten Gesellschaft wird an die Gesellschafter in

Höhe des Gesamtnennwertes der jeweils gehaltenen Anteile überwiesen.

Kapitel VIII. - Anwendbares Recht

Art. 21. Anwendbares Recht. Sämtliche, nicht in dieser Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Recht

des Großherzogtums Luxemburg.

<i>Zeichnung - Zahlung

Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft wurde wie folgt gezeichnet:

Anteile:
Leopoldstrasse Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Anteile
Gesamt: zweihundertfünfzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 Anteile

Alle Gesellschaftsanteile, jede mit einem Nennwert von fünfzig Euro (50,- EUR), wurden vollständig eingezahlt, so dass

die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), welche einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500,-) entspricht, ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht.

<i>Kostenschätzung

Die der Gesellschaft für diese Gründung entstandenen oder von ihr zu tragenden Kosten, Ausgaben, Entgelte und

Gebühren jeglicher Art, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.500.-

<i>Generalversammlung

Unmittelbar nach der Gesellschaftsgründung fasst die oben benannte Erschienene, welche das gesamte gezeichnete

Gesellschaftskapital repräsentiert und die der Gesellschafterversammlung übertragenen Rechte ausübt, durch ihren Ver-
treter, folgende Beschlüsse:

1) Die folgenden Personen werden auf unbestimmte Dauer und mit sofortiger Wirkung als Geschäftsführer der Ge-

sellschaft benannt:

53224

L

U X E M B O U R G

(a) KOSSMANN Christoph B.N., Geschäftsführer, geschäftsansässig in 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxemburg, geboren

in Homburg am 21. Juni 1957,

(b) BOULHAÏS El Ahcène, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxemburg, geboren in

Thionville am 12 Dezember 1977,

(c) GERARD Nicolas André, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 412 F Route d'Esch, L-2086 Luxemburg, geboren in

Libramont-Chevigny am 20 April 1981.

In Einklang mit Artikel 12 der Satzung, soll die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) Ge-

schäftsführern oder durch die Unterschrift einer Person, auf die die Unterschriftsbefugnis durch zwei (2) Geschäftsführer
wirksam übertragen wurde, verpflichtet werden.

2) Der Gesellschaftssitz ist in 412 F, route d'Esch, L-2086 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Die unterzeichnende Notarin, welche die englische Sprache versteht und spricht, bestätigt, dass vorliegende Urkunde

in Englisch  gefasst  ist,  gefolgt von  einer  deutschen  Übersetzung und dass im Falle  von  Widersprüchen  zwischen  der
englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.

WORÜBER URKUNDE in Esch/Alzette, mit Datum wie eingangs erwähnt, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung und Erklärung des Vorstehenden dem erschienenen Bevollmächtigten, hat Letzterer mit Uns, der

unterzeichnenden Notarin, die gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 26 février 2015. Relation: EAC/2015/4627. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015040480/659.
(150046263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Matterhorn Financing &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 171.751.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of February;
Before Maître Francis Kesseler, notary residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of

Luxembourg, undersigned.

Is held

an extraordinary general meeting of Matterhorn Financing &amp; Cy S.C.A., a Luxembourg société en commandite par

actions having its registered office at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 171.751 (“Company”), incorporated
by a deed enacted by Maître Jean-Joseph WAGNER, on 25 September 2012, published in the “Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations” number 2639 of 25 October 2012, and lastly amended by a deed enacted by Maître Jean-Joseph
WAGNER,  prenamed,  on  28  November  2012,  published  in  the  “Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations”
number 248 of 1 February 2013.

The meeting is presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch/

Alzette.

The chairman appoints as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette

and the meeting elects as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.

The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders of the Company (the “Shareholders”) present or represented and the number of shares held by

them are shown on an attendance list.

II. The Shareholders are duly represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue of proxies

given under private seal.

III. The above-mentioned proxies, being initialed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary,

and the attendance list, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

IV. As it appears from the attendance list, the 96,686,405 (ninety-six million six hundred and eighty-six thousand four

hundred and five) shares of the Company with a nominal value of 1 CHF (one Swiss Franc) each, representing the whole
share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of
which the Shareholders state having been duly informed beforehand.

53225

L

U X E M B O U R G

V. The agenda of the meeting is the following (the “Agenda”):

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Amendment of the article 5.1 (A) and (B) and the first paragraph of article 7 of the articles of association of the

Company in order to reflect the new management of the Company following the acquisition of the management share
of the Company by OCH AT Management; and

3. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Shareholders resolved to waive their right to a prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge

being sufficiently informed on the Agenda and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the Agenda.
It is further resolved that all documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Shareholders
within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

It is explained that following the acquisition of the management share in the Company, OCH AT Management, a

Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered office at 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registration with the Luxembourg Trade and Companies Register pending (“AT Manage-
ment”), has become the manager and unlimited partner of the Company.

It is therefore resolved to amend the article 5.1 (A) and (B) and the first paragraph of article 7 of the articles of

association of the Company in order to reflect the new management of the Company, so as to read as follows, the rest
of these articles remaining unchanged:

“ 5. Share capital.
"5.1. The capital is fixed at ninety-six million six hundred and eighty-six thousand four hundred and five Swiss Franc

(CHF  96,686,405.00)  represented  by  ninety-six  million  six  hundred  and  eighty-six  thousand  four  hundred  and  five
(96,686,405) shares of one Swiss Franc (CHF 1.00) each, divided into

(A) ninety-six million six hundred and eighty-six thousand four hundred and four (96,686,404) shares (the "Shares" or

actions de commanditaires), each having such rights and obligations as set out in these Articles, owned by a sole limited
shareholder; and

(B) one (1) management share (the "Management Share" or actions de commandité) owned by OCH AT Management.
In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be

construed accordingly."

“ 7. Management.
7.1 The Company shall be managed by OCH AT Management prenamed (herein referred to as the “Manager”).”

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing
persons and in case of discrepancy between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, at the date indicated at the beginning of the docu-

ment.

After reading the present deed to the proxy-holder of the appearing persons, known to the notary by their name, first

name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing persons has signed together with Us, the notary,
the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de février;
Before Maître Francis Kesseler, notaire ayant son adresse professionnelle au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire de Matterhorn Financing &amp; Cy S.C.A., une société en commandite par actions

luxembourgeoise ayant son siège social au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 171.751 (“Company”), constituée par acte
notarié de Maître Jean-Joseph WAGNER, daté du 25 septembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 2639 en date du 25 octobre 2012, et modifié pour la dernière fois par acte du Maître Jean-Joseph

53226

L

U X E M B O U R G

WAGNER, précité, en date du 28 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
248 en date du 1 

er

 février 2013.

La réunion est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profes-

sionnelle à Esch/Alzette.

Le président désigne Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette

secrétaire et l'assemblée élit Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle à Esch/Alzette
comme scrutateur.

Le président prie le notaire d'acter ce qui suit:
I. Les actionnaires de la Société (les «Actionnaires») présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par eux

figurent sur la liste de présence.

II. Les Actionnaires sont dûment représentés par Madame Sofia AFONSODA CHAO CONDE, prénommée, en vertu

des procurations données sous seing privé.

III. Les procurations susmentionnées, après avoir été signées «ne varietur» par les partie comparantes et le notaire

instrumentant, et la liste de présence, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités
d'enregistrement.

IV. Il apparaît sur la liste de présence que les 96.686.405 (quatre-vingt-seize millions six cent quatre-vingt-six mille

quatre cent cinq) actions de la Société ayant une valeur nominale de CHF 1 (un Franc Suisse) chacune, représentant la
totalité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer
sur tous les points de l'ordre du jour, dont les Actionnaires indiquent avoir été dûment informés par avance.

VI. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant (l'«Ordre du jour»):

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Modification de l'article 5.1 (A) et (B) et du premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société afin de refléter

la nouvelle gérance de la Société suite à l'acquisition de l'action de commandité de la Société par OCH AT Management;
et

3. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Actionnaires, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

Les Actionnaires ont décidé de renoncer à leur droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée;

les Actionnaires reconnaissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et acceptent en conséquence de déli-
bérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de
cette assemblée a été mise à la disposition des Actionnaires dans un laps de temps suffisant afin de leur permettre un
examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution:

Il est expliqué que suite à l'acquisition de l'action de commandité dans la Société, par OCH AT Management, une

société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, dont l'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg en cours
(“AT Management”), est devenue le gérant et actionnaire commandité de la Société.

Il est ainsi décidé de modifier l'article 5.1 (A) et (B) et le premier paragraphe de l'article 7 des statuts de la Société afin

de refléter la nouvelle gérance de la Société, et afin d'être lus comme suit, le reste des statuts restant inchangé:

« 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est de quatre-vingt-seize millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent cinq

Francs Suisses (CHF 96.686.405) représenté par quatre-vingt-seize millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent
cinq (96.686.405) actions d'un Franc Suisse (CHF 1,00) chacune, réparties en:

(A) quatre-vingt-seize millions six cent quatre-vingt-six mille quatre cent quatre (96.686.404) actions ordinaires (les

«Actions» ou actions de commanditaires), chacune conférant les mêmes droits et obligations tels que prévus dans les
présentes Statuts, détenues par un seul actionnaire commanditaire; et

(B) une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité») détenue par OCH AT Management.
Dans les présents Statuts, «Actionnaires» signifie les détenteurs au moment opportun de Actions et «Actionnaire»

devra être interprété conformément.»

« 7. Gérance.
7.1 La Société sera administrée par OCH AT Management, prénommée (dans cet acte le «Gérant»).»

53227

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, le présent acte a été rédigé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte au mandataire des parties comparantes, agissant comme décrit ci-dessus, dont le nom,

prénom, statut civil et lieu de résidence sont connus du notaire, le mandataire des parties comparantes a signé avec Nous,
notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 février 2015. Relation: EAC/2015/4722. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015040521/151.
(150046398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

MGE Vancouver S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.550,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 169.013.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 1 

<i>er

<i> février 2015

1. Monsieur Robert Hessing a démissionné de son mandat de gérant B.
2. Madame Roisin Lynch, administrateur de sociétés, née le 28 octobre 1984 à Cork (Irlande), demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante B pour une durée indéterminée.

Veuillez prendre note que Monsieur Brian McDade, gérant A, réside désormais à IN 46033 Carmel (Etats-Unis d'Amé-

rique), 3849, Birkdale Dr.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour MGE Vancouver S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015041807/18.
(150047650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

MGE Hellenic Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 62.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 99.856.

<i>Extrait des résolutions prises par les associées avec effet au 13 mars 2015

1. Monsieur John RALSTON a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Marc BAUWENS a démissionné de son mandat d'administrateur.
3. Monsieur Christophe YEREMIAN, administrateur de sociétés, né le 13 juin 1967 à Paris (France), demeurant au 5,

rue du General Delestraint, 75016 Paris (France), a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale statutaire de 2019.

4. Monsieur Olivier NOTTEAU, administrateur de sociétés, né le 29 janvier 1974 à Armentières (France), demeurant

au  15,  rue  du  11  Novembre 1918,  59420  Mouvaux  (France),  a  été nommé comme administrateur jusqu'à  l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2019.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour MGE Hellenic Investments S.à r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015041806/21.
(150047895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

53228

L

U X E M B O U R G

Npew North S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 846.500,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 189.886.

In the year two thousand and fifteen, on twelfth day of March.
Before Maître Henri BECK, notary, residing in Echternach (Grand-Duchy of Luxembourg),
were taken the resolutions of the sole shareholder of NPEW North S.à r.l., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 208, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 189.886 (the Company).

The Company has been incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary resident in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, on 18 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
number 3059 of 22 October, 2014. The articles of association of the Company (the Articles) have been amended the last
time by a notarial deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),
acting as replacement of Maître Francis KESSELER, notary, residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg),
on 30 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

There appeared,

Northland Power Euro Wind S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), organised

under the laws of Luxembourg, having its registered office at 208, Val des Bons Malades, L - 2121 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183.889
(the Sole Shareholder),

hereby represented by Peggy Simon, employee, residing professionally at L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand Duchy

of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal,

which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record that it holds all the shares in the share capital

of the Company, and has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred seventy

thousand Euro (EUR 770,000.-) so as to raise it from its present amount of seventy-six thousand five hundred Euro (EUR
76,500.-) to eight hundred forty-six thousand five hundred Euro (EUR 846,500.-) by the creation and issue of seven
hundred seventy thousand (770,000) shares with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to subscribe to seven hundred seventy

thousand (770,000) shares, all in registered form, having a par value of one Euro (EUR 1.-) each, and fully pays them up
by way of a contribution in cash in the aggregate amount of seventy-seven million Euro (EUR 77,000,000.-), which shall
be allocated as follows:

- an amount of seven hundred seventy thousand Euro (EUR 770,000.-) to the share capital account allocated to the

shares; and

- an amount of seventy-six million two hundred thirty thousand Euro (EUR 76,230,000.-) to the share premium account

allocated to the shares.

The amount of seventy-seven million Euro (EUR 77,000,000.-) is at the Company’s disposal and evidence of such

amount has been given to the undersigned notary.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder further resolves to amend article 5 of the Articles so that it reads henceforth as follows:

“ 5.1. The share capital is set at eight hundred forty-six thousand five hundred Euro (EUR 846,500.-), represented by

eight hundred forty-six thousand five hundred (846,500) shares in registered form, having a nominal value of one Euro
(EUR 1.-) each.”

<i>Third Resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and to authorise and empower any manager of the Company, any lawyer or employee of Loyens &amp; Loeff Lu-
xembourg S.à r.l., each acting individually, to proceed on behalf of the Company, to the registration of the newly issued
shares in the register of shareholders of the Company.

53229

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately six thousand six hundred Euro (EUR 6.600.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Echternach, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le douzième jour de mars.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, (Grand-Duché de Luxembourg),
ont été prises les résolutions de l’associé unique de NPEW North S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée

selon et régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe au 208, Val des Bons Malades,
L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 189.886 (la Société).

La Société a été constituée le 18 août 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), numéro
3059 du 22 octobre 2014. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 30 janvier 2015
suivant un acte de Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Luxembourg),
agissant en remplacement de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, (Grand-Duché de Lu-
xembourg), et dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours.

A comparu,

Northland Power Euro Wind S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Lu-

xembourg, dont le siège social est établi au 208 Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.889 (l’Associé Unique),

ici représentée par Peggy Simon, employée, dont l’adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9, Rabatt,

Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

ladite procuration, après signature ne varietur par la mandataire agissant pour le compte de la partie comparante et

le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé Unique a demandé au notaire instrumentant d’acter qu’il détient l’intégralité des parts sociales dans le capital

social et a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé  Unique  décide  d’augmenter  le  capital  social  d’un  montant  de  sept  cent  soixante-dix  mille  Euros  (EUR

770.000,-) afin de le porter de son montant actuel de soixante-seize mille cinq cents Euros (EUR 76.500,-) à huit cent
quarante-six mille cinq cent Euros (EUR 846.500,-) par la création et l’émission de sept cent soixante-dix mille (770,000)
parts sociales ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Souscription - Libération

Sur ce, l’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, décide par les présentes de souscrire aux sept cent

soixante-dix mille (770.000) parts sociales, toutes sous forme nominative, d’une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-)
chacune, et les libère intégralement par un apport en numéraire d’un montant total de soixante-dix-sept millions d’Euros
(EUR 77.000.000,-), qui est affecté de la manière suivante:

- un montant de sept cent soixante-dix mille Euros (EUR 770.000,-) qui est affecté au compte de capital social affecté

aux parts sociales; et

- un montant de soixante-seize millions deux cent trente mille Euros (EUR 76.230.000,-) qui est affecté au compte de

prime d’émission affecté aux parts sociales.

Le montant de soixante-dix-sept millions d’Euros (EUR 77.000.000,-) est à la disposition de la Société, et la preuve

dudit montant a été remis au notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts de sorte qu’il ait désormais la teneur suivante:

« Art. 5.1. Le capital social est fixé à huit cent quarante-six mille cinq cent Euros (EUR 846.500,-), représenté par huit

cent quarante-six mille cinq cent (846.500) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un Euro
(EUR 1,-) chacune.».

53230

L

U X E M B O U R G

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société à l’effet de refléter les changements ci-dessus

et d’autoriser et donner pouvoir à tout gérant de la Société, tout avocat ou employé de Loyens &amp; Loeff Luxembourg S.à
r.l., chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nou-
vellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les dépenses, frais, honoraires et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés à environ six mille six cents Euros (EUR 6.600.-).

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande de la partie comparante ci-

dessus, que le présent acte est rédigé en Anglais et en Français et qu’en cas de divergences, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Echternach, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture à haute voix faite par le notaire à la mandataire de la partie comparante, celle-ci signe le présent acte

en original, avec nous, notaire.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 mars 2015. Relation: GAC/2015/2121. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041842/129.
(150047675) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Longan Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 170.677.

L’an deux mille quinze, le vingt-trois janvier,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

S’est tenue

une assemblée générale extraordinaire de la société
LONGAN PROPERTIES S.à r.l.
une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare,

constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 1 

er

 août

2012,

publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 11 septembre 2012, numéro 2248,

page 107.889

A comparu à cet effet:

Laurentia Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit de luxembourgeois, ayant son siège social à

L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 166.195

ici représentée par Madame Priscillia Clechet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1610 Luxem-

bourg, 4-6, avenue de la Gare, agissant en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante est l’associée unique de la dite société, et en sa qualité d’associée unique, la dite partie

comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L’associée unique décide de changer le régime de signature sous lequel la société sera valablement engagée. Ainsi,

l’associée unique décide que dorénavant la société sera valablement engagée, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.

53231

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

En exécution de ce qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 10 alinéa 6 des statuts pour lui conférer

dorénavant la teneur suivante:

dans la version anglaise des statuts:

“ Art. 10. Sixth paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of

plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.”

dans la version française des statuts:

« Art. 10. sixième alinéa. La Société est valablement engagée par la signature individuelle du gérant unique et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du conseil de gérance.»

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte

avec le notaire.

Signés: P. CLECHET, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03 février 2015. Relation: EAC/2015/2741. Reçu soixante-quinze euros 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME

PETANGE, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015039830/49.
(150045573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Um Gringert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.

R.C.S. Luxembourg B 103.630.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège de la société, en date du 15 Janvier 2015 à 10:00

<i>heures

Les mandats des administrateurs et de l'administrateur-délégué étant venus à échéance à l'assemblée générale de 2012,

sont renouvelés rétroactivement du 11 avril 2012 à l'assemblée générale de l'an 2018:

- Monsieur John Dondlinger, administrateur-délégué, né à Schieren (L), le 30 avril 1947 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Marguerite Theis, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 20 juillet 1950 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Francoise Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 14 août 1976 et demeurant à L-9171 Michelau

8, Beim Donati;

L'assemblée générale nomme comme nouveaux administrateurs additionnels jusqu'à l'assemblée générale de l' an 2018:
- Monsieur Georges Dondlinger, administrateur, né à Ettelbruck (L), le 30 avril 1979 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Laurie Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 4 juillet 1982 et demeurant à L-9151 Eschdorf,

1, op der Heelt;

- Madame Béatrice Dondlinger, administrateur, née à Ettelbruck (L), le 15 septembre 1952 et demeurant à L-9151

Eschdorf, 1D, op der Heelt;

L'assemblée générale accepte la démission de la société EWA REVISION S.A. ayant son siège social à L-8080 Bertrange,

36, route de Longwy de son poste de commissaire aux comptes de la société.

- L'assemblée générale décide de nommer en remplacement Monsieur Victor Collé, demeurant à L-8838 Wahl, 41 ,

rue Kinnikshaff. Le mandat du nouveau commissaire aux comptes se terminera à l'issue de l'assemblée générale annuelle
devant se tenir en 2018.

Eschdorf, le 5 MARS 2015.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015040072/33.
(150045111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53232


Document Outline

4Ma S.A.

APS Consult S. à r.l.

Bacur S.A.

Bonte s.a.

Car Avenue S.à r.l.

Cerved VDC S.à r.l.

Framalux

France Investment S.A.

Galileo Global Education Luxco S.à r.l.

Georgia-Pacific S.à.r.l.

Greencap Trading International S.A.

Immo Sharp S.A.

Karlin Real Estate Europe Holdings (Lux) S.à r.l.

Leopoldstrasse Aviation Finance

Longan Properties S.à r.l.

LSREF3 Lion Investments S.à r.l.

Matterhorn Financing &amp; Cy S.C.A.

M.F.M. S.A.

MGE Hellenic Investments S.à r.l.

MGE Vancouver S.à r.l.

Montebello S.à.r.l.

Neo Liquidation S.à r.l.

Npew North S.à r.l.

Phal s.à r.l.

Primeur Invest II S.à r.l.

Promo Rio Immobilier S.à r.l.

Red Earth Holdings S.à r.l.

Starling Capital S.à r.l.

Süd-Ost Finanz S.A.

Technolia International S.A.

Tercade S.A.

Tevorina Finance S.A.

Top Patrimoine S.A., SPF

Triumph Holdings S.à r.l.

Um Gringert S.A.

Urka S.A.

Valcon Acquisition Holding (Luxembourg) S.à r.l.

Value Portfolio

Vancentio Holdings Limited

Vence S.A.

Waters Luxembourg S.à r.l.

WE Luxembourg SA

Xperedon Group S.A.