logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1107

28 avril 2015

SOMMAIRE

Agripartes S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53135

CeDerLux-Services S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53121

Fluxinvest International S.A.  . . . . . . . . . . . .

53136

Heavyland S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

HGHI Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

Horest, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

Horest, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt

Benelux A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

ING Investment Management Luxem-

bourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53132

Kandira S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53094

Kemon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53094

KG Far East (Luxembourg) Sàrl  . . . . . . . . .

53094

KG Participações S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

K.M.K. Agroinvestment S.A.  . . . . . . . . . . . .

53094

Korero SCI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53098

Lazada Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53104

LBREM Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

LBREM Luxco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53095

Leisure Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53100

Le Regent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Luna Management  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

Luxembourg Investment Company 41 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Luxembourg Investment Company 8 S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

Marge S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53091

MC Seahome S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53096

Metano Capital S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

Mika S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53097

Mirotech S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53097

Modim International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

53097

Morning Bay S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53093

Nemesia Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

53095

Nimulux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53092

NN Investment Partners Luxembourg S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53132

OCM Luxembourg EPF III Railpool Topco

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53124

Orsay-Re  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

Palvord Financing S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53097

Parabau S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53122

Park Luxco 3 S.C.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

Procastora Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

53103

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

Simauchan Development S.A. SPF  . . . . . .

53095

Um Gringert III S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53090

WOF III Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

53124

53089

L

U X E M B O U R G

HGHI Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 62, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 186.354.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042356/9.
(150048563) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Orsay-Re, Société Anonyme.

Siège social: L-4801 Rodange, Zone Industrielle du P.E.D..

R.C.S. Luxembourg B 90.130.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041857/10.
(150047657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Park Luxco 3 S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.288.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015041862/10.
(150047236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Um Gringert III S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9151 Eschdorf, 1, Op der Heelt.

R.C.S. Luxembourg B 135.290.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

John Dondlinger
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015042048/11.
(150047547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 1, rue de la Poudrerie.

R.C.S. Luxembourg B 132.838.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2014, il convient de modifier l'adresse de l'associé Reckitt

Benckiser Investments (No 5) SARL

La nouvelle adresse de cet associé est, avec effet au 10 juillet 2014:
1 rue de la Poudrerie à L-3364 Leudelange.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015041924/14.
(150047757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

53090

L

U X E M B O U R G

Horest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8355 Garnich, 26, rue Nic Arend.

R.C.S. Luxembourg B 26.475.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042360/9.
(150048646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5531 Remich, 35, route de l'Europe.

R.C.S. Luxembourg B 64.834.

Le bilan arrêté au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Ehnen, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042339/10.
(150048779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Heavyland S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1112 Luxembourg, 76, rue de l'Aciérie.

R.C.S. Luxembourg B 151.137.

Le bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042344/10.
(150048950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Luna Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 10, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 158.904.

Les comptes annuels au 31-12-14 ont été déposés dans leur version abrégée au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16-03-15.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015042450/12.
(150048243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Marge S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 81.422.

J'ai le regret de vous informer que je renonce par la présente à mes fonctions de commissaire aux comptes dans votre

société, avec effet immédiat.

Luxembourg, le 02 février 2015.

HAMERVATE LIMITED
GORDALE MARKETING LIMITED
Signatures

Référence de publication: 2015042473/13.
(150048258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53091

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Investment Company 8 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.984.

Changement suivant le contrat de cession de parts sociales du 2 janvier 2015:
- Ancienne situation associés

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500 parts sociales

- Nouvelle situation associés

Mr Kristof Mark Guy De Spiegeleer, né le 29 juin 1971 à Gent (Belgique) et résidant
professionnellement au 22, Korenlei, B-9000 Gent (Belgique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ,500 parts sociales

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Luxembourg Investment Company 8 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015042431/17.
(150048542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Luxembourg Investment Company 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 195.067.

<i>Extrait du contrat de cession de parts de la Société daté du 9 mars 2015

En vertu de l'acte de transfert de parts daté du 9 mars 2015, Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., a transféré la totalité de

ses parts détenues dans la Société de la manière suivante:

- 12.500 parts sociales d'une valeur de 1 Euro chacune, à Partners Group Access 737 L.P., une «Limited Partnership»

enregistrée auprès du Registre de Commerce d'Ecosse sous le numéro SL17792, ayant son siège social au 50, Lothian
Road, EH3 9WJ Edinburgh, Royaume-Uni.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015042430/18.
(150048391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Nimulux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9980 Wilwerdange, 39, Hauptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 93.192.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Versammlung des Verwaltungsrates vom 6. November 2014

Folgendes wurde einstimmig beschlossen:

<i>Erster und einziger Beschluss

Es wurde festgestellt, dass die Privatadresse von
- Herrn Jürgen NIESSEN, Präsident des Verwaltungsrats und Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, nunmehr

wie folgt lautet: B - 4770 Amel, Auf Eichenhardt 5;

- Frau Iris NIESSEN-PAASCH, Verwaltungsratsmitglied, nunmehr wie folgt lautet: B - 4770 Amel, Auf Eichenhardt 5;
- Herrn Hubert NIESSEN, Verwaltungsratsmitglied, nunmehr wie folgt lautet: B- 4770 Amel, Au Eichenhardt 13.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, den 17. März 2015.

<i>Für NIMULUX S.A.
FIDUNORD S.à r.l.

Référence de publication: 2015042503/19.
(150048445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53092

L

U X E M B O U R G

Metano Capital S.A, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 63, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 187.386.

Par lettre datée du 12 mars 2015, l'administrateur Monsieur Marco FUMAGALLI né le 27 juin 1970 à Mariano Comense

(Italie), demeurant au 17, Via Giovanni Molignoni, I-22020 Dizzasco (CO), Italie, a informé la Société de sa démission de
son mandat d'administrateur avec effet au 12 mars 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

METANO CAPITAL S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2015042480/13.
(150048308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Morning Bay S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.

R.C.S. Luxembourg B 144.149.

- Constituée suivant acte reçu par Me Karine REUTER, en date du 19 janvier 2009, publié au Mémorial, Recueil Spécial

C n° 297 en date du 11 février 2009.

Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois

«REVILUX S.A.», ayant son siège social à L-1371 Luxembourg, Val Ste Croix, 223, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 25.549, tenue en date du 25 janvier 2011 que son siège a été
transféré vers L-2450 Luxembourg, boulevard Roosevelt, 17.

Luxembourg, le 20 février 2015.

Fiduciaire Fernand Faber

Référence de publication: 2015042489/15.
(150048768) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

LBREM Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 110.486.

<i>Extrait des minutes de l'assemblée générale annuelle de la société tenue en date du 12 mars 2015

<i>(«l'Assemblée»)

L'assemblée acception la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant que gérant de catégorie À de la Société avec

effet au 14 décembre 2014.

Le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais de la façon suivante:

<i>Gérants de catégorie A:

- Hinnerk Koch, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Laurent Belik, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

<i>Gérants de catégorie B:

- Yon Ku Cho, avec adresse professionnelle au 27, Beekman Terrace, USA-07901 Summit, New Jersey;
- Ronald Bormeau, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245

El Segundo, Californie;

- Aaron Giovara, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245 El

Segundo, Californie.

A Luxembourg, le 12 mars 2015.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015042437/26.
(150048616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53093

L

U X E M B O U R G

K.M.K. Agroinvestment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 70.715.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042404/9.
(150048389) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Kandira S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 53.301.

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 février 2015 que la convention de

domiciliation conclue entre SG AUDIT S.àr.l., 231, Val des Bons Malades, L-2121 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 75
908 et la société KANDIRA SA, R.C.S. Luxembourg B 53 301, en date du 18 octobre 2004 a été résiliée.

Pour extrait conforme
SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015042411/11.
(150048598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Kemon S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 49.488.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 09 février 2015

Monsieur Martin STEIN, né le 31.07.1936 à DUBLIN (Irlande), domicilié professionnellement au Suite 112, 23 King

Street, SW1Y 6QY LONDON (Royaume-Uni), est nommé administrateur-délégué de la société, avec pouvoir de signa-
ture individuelle, pour une période d'un an. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de
l'an 2016.

Pour extrait sincère et conforme
KEMON S.A.

Référence de publication: 2015042413/14.
(150048567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 320.077.350,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 149.409.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 mars 2015 que:
1. La démission de Monsieur Nicholas J. Hayduk, gérant de la Société, avec effet au 13 mars 2015, a été acceptée;
2. Ont été nommés gérants, avec effet au 13 mars 2015 et pour une durée indéterminée:
- Mr Mikhail Ugodnikov, né le 23 septembre 1976 en URSS, demeurant professionnellement à Van Kinsbergenstraat

90A, 2518 HA, Den Haag, Pays-Bas;

- Mr Scott McKinlay, né le 11 avril 1983 à Dunfermline, Ecosse, demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg;

- Mr Mauro Ostwald, né le 27 juillet 1971 à Rio de Janeiro, Brésil, demeurant professionnellement à Noordeinde 157,

2514 GG, Den Haag, Pays-Bas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042414/20.
(150048853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53094

L

U X E M B O U R G

Nemesia Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 210.000,00.

Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 147.444.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Carsten Söns
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015042493/12.
(150048940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Simauchan Development S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 45.961.

Le bilan au 31.12.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015041938/14.
(150047781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

LBREM Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 118.733.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la société prises en date du 12 mars 2015

<i>(«l'Associé Unique»)

L'associé unique accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant que gérant de catégorie A de la Société

avec effet au 14 décembre 2014.

Le Conseil de Gérance de la Société se compose désormais de la façon suivante:

<i>Gérants de catégorie A:

- Hinnerk Koch, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;
- Laurent Belik, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg;

<i>Gérants de catégorie B:

- Yon Ku Cho, avec adresse professionnelle au 27, Beekman Terrace, USA-07901 Summit, New Jersey;
- Ronald Bonneau, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245

El Segundo, Californie;

- Aaron Giovara, avec adresse professionnelle au 222, N. Sepulveda Boulevard, étage Suite 2222, USA - CA 90245 El

Segundo, Californie.

A Luxembourg, le 13 Mars 2015.

Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliataire

Référence de publication: 2015042441/26.
(150048619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53095

L

U X E M B O U R G

Horest, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8355 Garnich, 26, rue Nic Arend.

R.C.S. Luxembourg B 26.475.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042361/9.
(150048647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Le Regent, Société Anonyme.

Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 161.738.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire reportée tenue en date du 05 mars 2015

L'assemblée prend note du changement d'adresse du Commissaire aux Comptes:
CHESTER &amp; JONES Sàrl, RCS Luxembourg B 120.602, 14 rue Bernard Haal, L-1711 Luxembourg.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015042444/11.
(150048728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

KG Participações S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 50.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 183.710.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 13 mars 2015 que:
1. La démission de Monsieur Nicholas J. Hayduk, gérant de la Société, avec effet au 13 mars 2015, a été acceptée;
2. A été nommé gérant, avec effet au 13 mars 2015 et pour une durée indéterminée:
- Mr Mauro Ostwald, né le 27 juillet 1971 à Rio de Janeiro, Brésil, demeurant professionnellement à Noordeinde 157,

2514 GG, Den Haag, Pays-Bas.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 mars 2015.

Référence de publication: 2015042415/16.
(150048899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

MC Seahome S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2713 Luxembourg, 1, place du Théâtre.

R.C.S. Luxembourg B 178.118.

EXTRAIT

La société GLH SHIPPING S.A., administrateur de la société MC SEAHOME A.G., a changé la dénomination en YACHT

REGISTRATION ASSOCIATES S.A. en date du 15/12/2014.

La société anonyme YACHT REGISTRATION ASSOCIATES S.A. est représentée par Madame Nina MEYER, employée

privée, née le 23.11.1984 à Ettelbruck (L) demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre,
avec signature individuelle et jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2017.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
André HARPES
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2015041789/18.
(150048083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

53096

L

U X E M B O U R G

Mika S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3316 Bergem, 3, rue de Schifflange.

R.C.S. Luxembourg B 105.569.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015042483/10.
(150048425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Modim International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 56A, avenue François Clément.

R.C.S. Luxembourg B 37.719.

<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration du 16 mars 2015

Le conseil d'administration de la Société a, à l'occasion de ses délibérations du 16 mars 2015 décidé de nommer, Maître

Morgane IMGRUND, avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 11, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg en
qualité de dépositaire des actions au porteur émises par la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015042486/13.
(150048297) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Palvord Financing S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 142.743.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 13 mars 2015

L'Assemblée accepte les démissions de Messieurs Samba Kane et Jean-Pascal Caruso, de leurs mandats d'Administra-

teurs de la Société avec effet au 13 mars 2015.

L'Assemblée décide de nommer Monsieur Laurent Kind, résidant professionnellement à 121, Avenue de la Faïencerie;

L - 1511 Luxembourg et Monsieur Serge Pira, résidant à L - 1628 Luxembourg, 69, rue des Glacis, en tant qu'Adminis-
trateurs de la Société avec effet au 13 mars 2015 pour une durée de six ans.

Pour extrait
<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015042527/15.
(150048217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

Mirotech S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4571 Oberkorn, 84, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 189.107.

<i>Extrait des Résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 février 2015

L'associé unique de la société a pris les décisions suivantes:

<i>Résolution 1:

Le siège social est transféré à l'intérieur de la commune de DIFFERDANGE

<i>Résolution 2:

La nouvelle adresse est fixée à: 84, rue de la Gare, L-4571 OBERKORN

Luxembourg, le 28 février 2015.

Pour extrait conforme
La société

Référence de publication: 2015042485/16.
(150048503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.

53097

L

U X E M B O U R G

Korero SCI, Société Civile.

Siège social: L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel.

R.C.S. Luxembourg E 5.581.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le treize mars.

Ont comparu;

1. - Madame Marga Reuter-Kohl, pensionnée, né à Ettelbruck le 04 mai 1952,
matricule n° 1952050418720,
demeurant à L-9183 Schlindermanderscheid, 17, Haaptstrooss,
2. - Monsieur Joseph Reuter, pensionné, né à Ettelbruck, le 03 mars 1948,
matricule no 1948030327222,
demeurant à L-9183 Schlindermanderscheid, 17, Haaptstrooss,
3. - Madame Edith Reuter-Roilgen, fonctionnaire, né à Luxembourg, le 21 mai 1978,
matricule n° 1978052116653,
demeurant à L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel,
4. - Monsieur Joël REUTER, employé privé, né à Ettelbruck le 20 mars 1974,
matricule n° 1974032019283,
demeurant à L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel,
Lesquels comparants ont déclaré constituer entre eux une société civile immobilière, dont ils ont arrêté les statuts

comme suit:

Titre I 

er

 . - Dénomination, Objet, Durée, Siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les parties ci-devant désignées et toutes personnes, physiques ou morales,

qui pourront devenir associés dans la suite, une société civile immobilière qui sera régie par les lois y relatives ainsi que
par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de "KORERO SCI"

Art. 3. La société a pour objet la gestion, l'administration, l'exploitation, la mise en valeur par achat, vente, échange,

location,  construction  ou  de  toute  autre  manière  de  tous  biens  immobiliers  ou  mobiliers  tant  au  Luxembourg  qu'à
l'étranger.

Elle pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirec-

tement à cet objet, de nature à en faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne soient pas susceptibles de porter atteinte au
caractère exclusivement civil de l'activité sociale.

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le siège social est établi à BISSEN.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés prise

en assemblée générale,

Titre II. - Apports, Capital social, Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à MILLE EUROS (1.000,00 €), représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation

de valeur nominale, réparties comme suit:

1. - Madame Marga REUTER-KOHL, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2. - Monsieur Joseph REUTER, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

3. - Madame Edith REUTER-ROILGEN, prénommée, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4. - Monsieur Joël REUTER, prénommé, vingt-cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

TOTAL: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts ont été entièrement libérées par des apports en numéraire, de sorte que la somme de mille euros

(1.000,00 €) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par la loi.

Art. 8. La cession des parts s'opérera par acte authentique ou par acte sous seing privé en observant l'article 1690 du

Code Civil.

Les parts sont librement cessibles entre associés.
Elles ne pourront être cédées à des tiers non-associés qu'avec l'agrément des associés décidant à l'unanimité.

53098

L

U X E M B O U R G

Les associés fondateurs ont un droit de préemption pour l'acquisition de parts:
a) Si un associé se propose de céder tant à titre gratuit qu'à titre onéreux tout ou partie de ses parts sociales, il doit

d'abord les offrir à ses coassociés proportionnellement à leur participation dans la société au moins six (6) mois avant la
date prévue pour la cession; si un ou plusieurs associés ne souhaitent pas acquérir les parts offertes, les autres associés
peuvent se porter acquéreur au prorata des parts détenues.

b) Si aucun des associés ne se porte acquéreur des parts qui ont été offertes aux associés, ou si une partie des parts

à céder n'est pas reprise par des associés» l'associé cédant peut offrir ses parts à des non-associés.

L'associé cédant ses parts doit informer tous les associés du prix de cession convenu avec le ou les non-associé(s) et

dévoiler l'identité du ou des acheteurs.

Tous les associés peuvent ensuite faire valoir un droit de préemption pendant le mois qui suit la communication du

prix convenu et de l'identité du ou des acheteurs non-associé^), et se porter acquéreur au même prix des parts à céder,
Si plusieurs associés exercent le droit de préemption, les parts à céder sont réparties entre eux proportionnellement
aux parts détenues par chaque intéressé.

Si aucun associé n'a exercé son droit de préemption dans le délai d'un mois après la communication du prix convenu

et de l'identité du ou des repreneur(s) non-associé(s), l'associé cédant peut transmettre les parts à ces acheteurs qui
deviennent alors associés de la société.

Les droits et obligations attachés à chaque part suivent dans quelques mains qu'elle passe. La propriété d'une part

sociale emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Art. 9. La société ne sera pas dissoute par le décès d'un ou de plusieurs associés, mais continuera entre le ou les

survivants et les héritiers de l'associé ou des associés décédés.

L'interdiction, la faillite, la liquidation judiciaire ou la déconfiture d'un ou de plusieurs des associés ne mettra pas fin à

la société qui continuera entre les autres associés, à l'exclusion du ou des associés en état d'interdiction» de faillite, de
liquidation judiciaire ou de déconfiture.

Art. 10. Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction

proportionnelle au nombre des parts existantes,

Art. 11. Les associés sont tenus des dettes de la société, chacun dans la proportion du nombre des parts qu'il détient.

Art. 12. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul titulaire par part. Les

copropriétaires individus ainsi que le nu-propriétaire et usufruitiers de parts sociales sont tenus de se faire représenter
par un seul d'entre eux. Faute d'accord sur ce point, l'exercice des droits attachés à ces parts pourra être suspendu.

Titre III. - Administration de la Société

Art. 13. La société est gérée et administrée par les associés. Pour tout acte de disposition la société est valablement

engagée par la signature conjointe de deux associés et pour tout acte de gestion courante la société est valablement
engagée par la signature individuelle de chaque associé.

Les associés peuvent emprunter au nom de la société ou faire consentir à celle-ci des ouvertures de crédit avec ou

sans garantie et signer valablement tous actes de prêt, d'ouverture de crédit ou autres, et hypothéquer les biens immo-
biliers de la société en garantie de ces prêts ou ouvertures de crédit.

Art. 14. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède.

Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 15. Chaque associé a un droit illimité de surveillance et de contrôle sur les affaires de la société et il pourra en

particulier prendre inspection des livres et comptes au siège social.

Titre IV. - Assemblée générale

Art. 16. L'assemblée des associés se réunira aussi souvent que les affaires de la société l'exigent sur convocation du

ou des associés. Pareille convocation doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée.

Art. 17. Le vote des délibérations de l'assemblée des associés, sur tous les points y compris les modifications statutaires,

est déterminé par la majorité des trois quarts des votes des associés présent ou représentés, chaque part donnant droit
à une voix.

Art. 18. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Le premier exercice commence le jour de la constitution de la société et se termine le trente et un décembre deux

mille quinze.

Art. 19. L'assemblée entend le rapport du ou des administrateurs sur les affaires sociales, approuve les comptes,

délibère sur les points portés à l'ordre du jour,

53099

L

U X E M B O U R G

Titre V. - Dissolution et Liquidation

Art. 20. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins des associés, à moins qu'ils ne décident

de nommer un liquidateur dont les pouvoirs seront fixés dans l'acte de nomination.

Titre VI. - Divers

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Fait à Bissen, le 13 mars 2015 en trois exemplaires.

REUTER-KOHL Marga / REUTER Joseph /

REUTER-ROILGEN Edith / REUTER Joël.

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les prédits associés se considérant comme réunis en assemblée générale ont pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

1- Le nombre d'administrateurs est fixé à quatre.
Sont nommés administrateurs de catégorie «A» pour une durée indéterminée, Madame Marga Reuter-Kohl et Mon-

sieur Joseph Reuter.

Sont nommés administrateurs de catégorie «B» pour une durée indéterminée, Madame Edith Reuter-Roilgen et Mon-

sieur Joël Reuter.

Pour tout acte de disposition la société est valablement engagée par la signature conjointe d'un administrateur de

catégorie «A» et d'un administrateur de catégorie «B».

Pour tout acte de gestion courante la société est valablement engagée par la signature individuelle d'un administrateur

de catégorie «A» ou bien par la signature individuelle d'un administrateur de catégorie «B».

2- Le siège de la société est fixé à L-7793 Bissen, 25, rue Michel Stoffel.

<i>Frais

Le montant des irais qui incombent à la société à raison de sa constitution sont à charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Bissen le 13 mars 2015.

REUTER-KOHL Marga / REUTER Joseph / REUTER-ROILGEN Edith / REUTER Joël.

Référence de publication: 2015041723/131.
(150048101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Leisure Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 68.901.

In the year two thousand fifteen, on the fourth of March.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem (Grand-Duchy of Luxembourg),

was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “LEISURE HOLDING S.A.”, a “société anonyme”, established

and having its registered office at 21 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,

filed with the Trade and Companies Register in Luxembourg, section B under number 68 901 (here after: the “Com-

pany”).

The Company has been incorporated pursuant to a deed enacted through the undersigned notary, on 17 February

1999, published in the Mémorial C, number 402 of 2 June 1999.

The Articles of Incorporation of the Company were for the last amended pursuant to a deed of the undersigned notary,

on 29 November 2010, which deed was published in the Mémorial C number 481 of 14 March 2011.

The Extraordinary General Meeting is declared open with Mrs Danielle SCHROEDER, company director, residing

professionally in Luxembourg, in the chair.

The Chairman appoints as secretary of the meeting Mr. Alain SCHREURS, attorney-at-law, residing professionally in

Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mr. Alain SCHREURS, prenammed.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) To increase the share capital by ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTEEN EUROS

AND THIRTY-FOUR CENTS (115,215.34 EUR) in order to raise it from its actual amount of TWENTY-THREE MILLION

53100

L

U X E M B O U R G

EIGHT HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY-FIVE EUROS (23,825,645.- EUR) to
TWENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED FORTY THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY EUROS AND
THIRTY-FOUR CENTS (23,940,860.34 EUR) by the creation and the issue of ONE THOUSAND TWO HUNDRED
AND FOUR (1,204) new shares without nominal value, having the same rights and advantages as the existing shares
entirely paid up in cash;

2) Subscription and payment.
3) Subsequent amendment of the first paragraph of article 3.- of the articles of incorporation to read as follows:
“The subscribed share capital is set at TWENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED FORTY THOUSAND EIGHT

HUNDRED AND SIXTY EUROS AND THIRTY-FOUR CENTS (23,940,860.34.- EUR) divided into two hundred fifty
thousand one hundred and eighty-two (250,182) shares without a par value.”

II.- The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, and the number of their

shares held by each of them are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their proxies and by
the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary,

will also remain annexed to the present deed.

III.-  It  appears  from  the  said  attendance  list  that  all  the  shares  representing  the  total  subscribed  share  capital  of

TWENTY-THREE MILLION EIGHT HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY-FIVE EU-
ROS (23,825,645.- EUR) are present or represented at the meeting. All the shareholders present or represented declare
that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were
necessary.

IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate

on all the items on the agenda.

After deliberation, the Extraordinary General Meeting of shareholders adopts each time unanimously the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Extraordinary General Meeting of shareholders RESOLVES to increase the issued subscribed share capital of the

Company by an amount of ONE HUNDRED FIFTEEN THOUSAND TWO HUNDRED AND FIFTEEN EUROS AND
THIRTY-FOUR CENTS (115,215.34 EUR) in order to raise it from its actual amount of TWENTY-THREE MILLION
EIGHT HUNDRED TWENTY-FIVE THOUSAND SIX HUNDRED AND FORTY-FIVE EUROS (23,825,645.- EUR) to
TWENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED FORTY THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY EUROS AND
THIRTY-FOUR CENTS (23,940,860.34 EUR) by the creation and the issue of ONE THOUSAND TWO HUNDRED
AND FOUR (1,204) new additional shares with no par value and having the same rights and advantages as the existing
shares.

<i>Second resolution:

<i>Subscription - Payment

The Extraordinary General Meeting of shareholders acknowledged that the ONE THOUSAND TWO HUNDRED

AND FOUR (1,204) new shares issued by the Company were all subscribed by the existing shareholders of the Company
in the proportions indicated in a list attached hereto, the other existing shareholders waiving their preferential subscrip-
tion right.

All these ONE THOUSAND TWO HUNDRED AND FOUR (1,204) new shares thus subscribed by the same current

subscribers, were then totally paid up by contribution in cash to a bank account of the Company, so that the amount of
ONE  HUNDRED  FIFTEEN  THOUSAND  TWO  HUNDRED  AND  FIFTEEN  EUROS  AND  THIRTY-FOUR  CENTS
(115,215.34 EUR) is now at the free disposal of the Company, as was certified to the attesting notary, who expressly
states this.

<i>Third resolution:

In order to reflect such stated capital increase, the Extraordinary General Meeting of shareholders RESOLVES to

amend the First Paragraph of Article THREE (3) of the Company’s Articles of Incorporation. The Extraordinary General
Meeting of shareholders resolves to give Article THREE (3), First Paragraph of the Company’s Articles of Incorporation,
the following wording:

Art. 3. First Paragraph. “The subscribed share capital is set at TWENTY-THREE MILLION NINE HUNDRED FORTY

THOUSAND EIGHT HUNDRED AND SIXTY EUROS AND THIRTY-FOUR CENTS (23,940,860.34 EUR) divided into
two hundred fifty thousand one hundred and eighty-two (250,182) shares without a par value.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which shall be born by the company as a result

of the present notarial deed are estimated at approximately two thousand Euros.

53101

L

U X E M B O U R G

There being no further business, the meeting is thereupon closed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who has personal knowledge of the English language, states herewith that the present deed

is worded in English, followed by a German version; upon request of the appearing persons and in case of divergence
between the English and the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing all known to the notary by their names, first names, civil

status and residence, the members of the board signed together with the notary the present deed.

Folgt die deutsche Übersetzung vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten März.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu Sassenheim (Großherzogtum Luxemburg),
versammelten sich in Außerordentlicher Generalversammlung die Gesellschafter der Gesellschaft „LEISURE HOL-

DING S.A.“, eine Aktiengesellschaft, mit Sitz in 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxemburg,

welche eingetragen ist im Handels- und Gesellschaftsregister in Luxemburg, Sektion B unter der Nummer 68 901,

(hiernach: die „Gesellschaft“).

Die Gesellschaft wurde gegründet gemäß Urkunde, aufgenommen durch den amtierenden Notar, am 17. Februar 1999,

veröffentlicht im Mémorial C Nummer 402 vom 2. Juni 1999.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch Urkunde des amtierenden Notars, aufgenommen am 29.

November 2010, welche Urkunde im Mémorial C Nummer 481 am 14. März 2011, veröffentlicht wurde.

Die Versammlung ist eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Danielle SCHROEDER, Gesellschaftsdirektorin, beruflich

wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende ernennt zur Schriftführerin Herr Alain SCHREURS, Jurist, beruflich wohnhaft in Luxemburg.
Die Generalversammlung wählt zum Stimmenzähler Herr Alain SCHREURS.
Der Versammlungsvorstand ist hiermit gebildet. Der Vorsitzende erklärt und ersucht den beurkundenden Notar ak-

tenmäßig die nachfolgenden Beschlüsse festzuhalten:

I.- Daß die Tagesordnung für die Generalversammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1)  Aufstockung  des  Gesellschaftskapitals  in  Höhe  von  EINHUNDERT  UND  FÜNFZEHNTAUSEND  ZWEIHUN-

DERTFÜNFZEHN EURO UND VIERUNDDREISSIG CENT (115.215,34 EUR) um es von seinem jetzigen Betrag von
DREIUNDZWANZIG  MILLIONEN  ACHTHUNDERT  UND  FÜNFUNDZWANZIG  TAUSEND  SECHS  HUNDERT
FÜNFUNDVIERZIG EURO (23.825.645,- EUR) auf einen Betrag von DREIUNDZWANZIG MILLIONEN NEUN HUN-
DERTVIERZIGTAUSEND ACHTHUNDERTSECHZIG EURO UND VIERUNDDREISSIG CENT (23.940.860,34 EUR) zu
erhöhen durch die Schaffung und Ausgabe von EINTAUSENDZWEIHUNDERT UND VIER (1.204) neuen Aktien ohne
Nennwert, welche die gleichen Rechte und Vorteile verbriefen wie die bereits bestehenden Aktien und welche alle voll
in bar einzuzahlen sind.

2) Zeichnung und Zahlung der neuen Aktien der bestehenden Gesellschafter im Verhältnis ihrer derzeitigen Beteili-

gungen.

3) Dementsprechende Abänderung von Artikel 3.- erster Absatz der Gesellschaftssatzung um diesem folgenden Wort-

laut zu geben:

„Das  gezeichnete  Aktienkapital  beträgt  DREIUNDZWANZIG  MILLIONEN  NEUNHUNDERTVIERZIGTAUSEND

ACHTHUNDERTSECHZIG EURO UND VIERUNDDREISSIG CENT (23.940.860,34 EUR) und ist eingeteilt in zweihun-
dertfünfzigtausend einhundertzweiundachtzig (250.182) Aktien, ohne Nennwert.“.

II.- Die anwesenden oder vertretenen Gesellschafter, die Vollmachtträger der vertretenen Gesellschafter, sowie die

Anzahl ihrer Aktien sind in einer Anwesenheitsliste eingetragen; diese Anwesenheitsliste, von den anwesenden Gesell-
schafter,  den  Bevollmächtigten  der  vertretenen  Gesellschafter  und  dem  Versammlungsvorstand  unterzeichnet,  bleibt
gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter werden nach Unterzeichnung "ne varietur" durch die Erschienenen

und durch den unterzeichneten Notar, ebenfalls gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

III.- Aus besagter Anwesenheitsliste ergibt sich, daß sämtliche Aktien, die das gesamte Gesellschaftskapital von DREI-

UNDZWANZIG MILLIONEN ACHTHUNDERT UND FÜNFUNDZWANZIG TAUSEND SECHS HUNDERT FÜNF-
UNDVIERZIG EURO (23.825.645,- EUR) darstellen, auf gegenwärtiger Versammlung anwesend oder vertreten sind; die
anwesenden oder vertretenen Gesellschafter bekennen sich als ordnungsgemäß einberufen und erklären vorweg, Kennt-
nis der Tagesordnung gehabt zu haben, so daß auf eine förmliche Einberufung verzichtet werden konnte.

IV.- Die gegenwärtige Generalversammlung, bei der das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist, ist somit ordnungs-

gemäß zusammengesetzt und kann rechtsgültig über sämtliche Punkte der Tagesordnung beraten.

Nach Beratung faßt die Generalversammlung einstimmig folgende Beschlüsse:

53102

L

U X E M B O U R G

<i>Erster Beschluß:

Die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter beschließt, das Gesellschaftskapital aufzustocken um

einen Betrag von EINHUNDERT UND FÜNFZEHNTAUSEND ZWEIHUNDERTFÜNFZEHN EURO UND VIERUNDD-
REISSIG CENT (115.215,34 EUR) um es von seinem jetzigen Betrag von DREIUNDZWANZIG MILLIONEN ACHT-
HUNDERT UND FÜNFUNDZWANZIG TAUSEND SECHS HUNDERT FÜNFUNDVIERZIG EURO (23.825.645,- EUR)
auf  einen  Betrag  von  DREIUNDZWANZIG  MILLIONEN  NEUN  HUNDERTVIERZIGTAUSEND  ACHTHUNDERT-
SECHZIG EURO UND VIERUNDDREISSIG CENT (23.940.860,34 EUR) zu erhöhen, durch die Schaffung und Ausgabe
von EINTAUSENDZWEIHUNDERT UND VIER (1.204) neuen zusätzlichen Aktien ohne Nennwert, welche die gleichen
Rechte und Vorteile verbriefen sollen, wie die bereits bestehenden Aktien.

<i>Zweiter Beschluß:

<i>Zeichnung - Einzahlung

Die Außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter stellt fest, dass die, durch die Gesellschaft soeben aus-

gegebenen EINTAUSENDZWEIHUNDERT UND VIER (1.204) neuen Aktien, durch bestehende Aktionäre im in einer
dieser Urkunde beigefügten Liste angeführten Verhältnis gezeichnet wurden, unter Verzicht der übrigen bestehenden
Aktionäre auf ihr Vorzugsrecht.

Alle diese EINTAUSENDZWEIHUNDERT UND VIER (1.204) neuen Aktien, die soeben durch die gegenwärtigen

Gesellschafter gezeichnet wurden, wurden von denselben vollständig auf ein Bankkonto der Gesellschaft in bar eingezahlt,
so dass die Summe von EINHUNDERT UND FÜNFZEHNTAUSEND ZWEIHUNDERTFÜNFZEHN EURO UND VIER-
UNDDREISSIG  CENT  (115.215,34  EUR)  der  Gesellschaft  ab  sofort  zur  freien  Verfügung  steht,  so  wie  dies  dem
amtierenden Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.

<i>Dritter Beschluß:

Um die Satzung der Gesellschaft an die vorerwähnte Kapitalerhöhung anzupassen, beschließt die Außerordentliche

Generalversammlung der Gesellschafter den ersten Absatz des Artikels DREI (3) der Gesellschaftssatzung abzuändern.
Die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter beschließt demselben Artikel DREI (3) erster Absatz, fol-
genden Wortlaut zu geben:

Art. 3. Erster Absatz. „Das gezeichnete Aktienkapital beträgt DREIUNDZWANZIG MILLIONEN NEUN HUNDERT-

VIERZIGTAUSEND ACHTHUNDERTSECHZIG EURO UND VIERUNDDREISSIG CENT (23.940.860,34 EUR) und ist
eingeteilt in zweihundertfünfzigtausend einhundertzweiundachtzig (250.182) Aktien, ohne Nennwert.“.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft aus Anlaß dieser Urkunde anerfallen, werden auf zirka zweitausend Euro geschätzt.
Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt die Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Worüber Urkunde aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, daß auf Ersuchen der vorgenannten Parteien

diese Urkunde in englischer Sprache verfaßt ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.

Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, dem beurkundenden Notar nach Namen,

gebräuchlichen Vornamen, sowie Stand und Wohnort bekannt, haben die Erschienenen mit dem Versammlungsvorstand
und dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: D. SCHROEDER, A. SCHREURS, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 10. März 2015. Relation: EAC/2015/5615. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer ff. (gezeichnet): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015041749/181.
(150047229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

Procastora Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 37C, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 181.173.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041871/10.
(150047714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

53103

L

U X E M B O U R G

Lazada Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 195.318.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of March.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany, registered with

the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 159634 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

duly represented by Mr. Julien De Mayer, private employee, professionally residing in 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-

berg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

2. Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden, with its statutory

seat in Stockholm, Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under number 556815-4958
with registered address in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

3. Summit Partners RKT S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 169548, having its registered office in 5, rue de Plébiscite, L-2341 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

4. Saturn 2 S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des
Sociétés) under number B 180356, having its registered office in 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

5. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany with its

statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under
no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

6. Aismare Limited, a limited company incorporated in England and Wales, registered with the Companies House of

the United Kingdom under number 07634146, with registered address in 11/12 Lennox Gardens Mews London England,
SW1X 0DP, United Kingdom,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

7. E-commerce Holdings LP, a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands with registered address

in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

8. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, a limited company existing under the laws of Ireland, registered with

the Companies Registration Office Ireland under number 223184, in its capacity as trustee of Eureka Fund, a sub-trust
of Marshall Wace Investment Strategies, with registered address in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

9. Mercura Capital GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws

of Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB 200948,
having its business address at Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

10. Tetral S.A., a stock corporation (société anonyme) existing under the laws of Switzerland, with its statutory seat

in Pully, Switzerland, registered with the Federal Commercial Registry office (at the Canton of Vaud) under number
CH-550.1.000.845-3 with registered address in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland,

53104

L

U X E M B O U R G

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

11. JaToPa GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Ger-

many with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich,
Germany, under number HRB 198609, with registered address in Maximilianstraße 21, 80539 Munich, Germany,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

12. Kaltroco Limited, a limited company existing under the laws of Jersey, registered with the JFSC Companies Registry

under number 60595 with registered address in Third Floor, South Tower, 29/31 Esplanade, St. Helier, Jersey JE2 3QA,
Jersey, Channel Islands,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal;

13. E-Fashion S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) existing under the laws of Luxembourg,

registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B 177.487 having its registered office in 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

duly represented by Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal; and

14. TEC Global Invest II GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the

laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under no. HRB 24964
with registered address in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,

duly represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited

company (société anonyme) which they wish to incorporate with the following articles of association:

“Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Lazada Group

S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial com-
panies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1. The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2. The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or

of any entity in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same group
of entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist any such entity in any other manner.

2.3. The Company may further provide any and all financial management services, including, but not limited to treasury

management services, currencies management services, interest rate and foreign exchange risk management to any entity
in which it holds a direct or indirect controlling interest.

2.4. The Company may raise funds, especially through borrowing in any form, and may issue any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of any
type.

2.5. A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, registration or in any other manner as well

as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.6. The Company shall not act as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative

Investment  Fund  Managers  and  shall  not  carry  out  any  other  activity  which  would  be  subject  to  supervision  by  the
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

2.7. The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, technical, intellectual property or

other activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

53105

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's

registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors. It may be
transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders.

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

A. Share capital - Shares - Register of shares - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.
5.1. The Company has an issued share capital of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000), represented by thirty-one

thousand (31,000) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2. The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association in accordance with the Law or as set
out in article 6 hereof.

5.3. Subject to article 6.2 of these articles of association, any new shares to be paid for in cash will be offered by

preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company's issued
share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right
may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of the opening of the subscription as
published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(the "Mémorial") and two (2) Luxembourg newspapers in accordance with the Law or, in case all the shares are in
registered form, from the date of notification of the shareholders by registered letter. However, subject to the provisions
of the Law, the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the Company's issued share
capital or (ii) on the occasion of an authorization granted to the board of directors to increase the Company's issued
share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize the
board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment to these articles
of association.

Art. 6. Authorized Capital.
6.1 The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at one million six hundred thirty-nine

thousand  ninety-two  Euro  (EUR  1,639,092),  consisting  of  one  million  six  hundred  thirty-nine  thousand  ninety-two
(1,639,092) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1).

6.2 The board of directors is hereby authorized to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue

any other instruments convertible into shares for the purpose of delivery of shares upon exercise or conversion, as
applicable, of the Company's stock options or other equity-based awards granted under any management incentive plan
of the Company or issues of shares to certain managers or other employees of the group of companies of which the
Company is the parent company, within the limit of the authorized capital, to such persons and on such terms as it shall
see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing sha-
reholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general
meeting of shareholders in the Mémorial. This authorization may be renewed once or several times by a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association,
each time for a period not exceeding five (5) years.

6.3 The authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 7. Shares.
7.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value. The shares of the

Company are in registered form. No fractional shares shall be issued.

7.2 The shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law and these articles of association. The

Company may repurchase its shares and hold them in treasury subject to the conditions of the Law.

7.3 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

7.5 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law and ownership of shares is esta-
blished by registration in said share register, without prejudice to the conditions for transfer by book-entries provided
for in article 7.6 of these articles of association. Certificates of such registration shall be issued by the Company upon
request and at the expense of the relevant shareholder and, in the situation described by article 7.6 of these articles of
association, to the Depositary (as defined below). All communications and notices to be given to a registered shareholder

53106

L

U X E M B O U R G

shall be deemed validly made to the latest address communicated by the shareholder to the Company. The board of
directors may decide that no entry shall be made in the share register and no notice of a transfer shall be recognized by
the Company during the period starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of the relevant
general meeting.

7.6 Where shares are in registered form and are recorded in the Company’s register of shares in the name of or on

behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry interests in the
accounts of a financial institution or a professional depositary or sub-depositary (any such institution, depositary and sub-
depositary being referred to hereinafter as a “Depositary”), the Company, subject to having received from the Depositary
a proper certification of such record position, will permit the Depositary of such book-entry interests to exercise the
rights attached to the shares corresponding to the book-entry interests of the relevant shareholder, including receiving
notices of general meetings, admission to and voting at general meetings (the “Certificates”). The board of directors may
determine formal requirements with which such Certificates must comply.

B. General meeting of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general

meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 9. Convening general meetings of shareholders.
9.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Thursday
of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following business day. Other general meeting of shareholders of the Company may at any time be
convened by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meetings.

9.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance with the provisions of the Law and these articles

of association and in the event the shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance with the
publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. If all shareholders are present or
represented, the meeting may be held without prior notice or publication.

9.3 In the event the shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders recorded

in the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted to the
general meeting of shareholders. If the shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, the board of
directors may determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission
to the general meeting of shareholders (the “Record Date”). In such case, any shareholder who wishes to attend the
general meeting must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be determined by
the board of directors in the convening notice. In case of shares held through a Depositary, a shareholder wishing to
attend a general meeting of shareholders should receive from such Depositary one or more Certificates regarding the
number of shares recorded in his name on the Record Date. No entry shall be made in the share register and no notice
of transfer shall be recognized by the Company or a registrar acting for the Company in the period between the Record
Date and the date of a general meeting ending at the closing of such general meeting if so decided by the board of directors.
In the event of a transfer of shares held in book-entry form in the period between the Record Date and the date of the
general meeting, the transferor is authorized and empowered by the transferee to participate in such general meeting
and, in particular, exercise the voting rights attached to such shares. The Certificates should be submitted to the Company
(or its agent appointed in the convening notice) no later than five (5) business days prior to the date of the relevant
general meeting. Proxies and voting forms relating to such general meeting must be remitted at the same time. The board
of directors may set a shorter period for the submission of the Certificate, proxies or voting forms.

9.4 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy.
9.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company or its agent specified

in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and the board of directors
shall determine their content.

9.6 The board of directors may determine other terms or set conditions that must be respected by a shareholder to

participate in any meeting of shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.
10.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of

shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

10.3 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
10.4 Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding at least

two-thirds of the aggregate number of shares issued in the Company:

53107

L

U X E M B O U R G

(i) any amendment of these articles of association;
(ii) the winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;
(iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares (other than realized through the

authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association); and

(iv) any reduction of the share capital or any redemption or repurchase by the Company of any shares.
In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the consent of shareholders holding at least two-

thirds of the shares of the relevant class at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding
sentence.

The creation, allotment or issue of securities in the Company other than shares, or the grant of any option or rights

to subscribe for or to convert any instrument into shares or other securities in the Company (other than realized through
the authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association) shall require the consent of the sha-
reholders with majority set out in the first sentence of this article 10.4.

Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding more than

fifty per cent (50%) of the aggregate number of shares issued in the Company:

(i) the adoption of statutory accounts of the Company and any consolidated group accounts;
(ii) the payment or declaration of any dividend or other distribution by the Company; and
(iii) the appointment or change of the Company’s auditor.
The conclusion, termination or amendment of (a) silent partnerships and sub-participations in the Company or (b)

enterprise agreements of the Company within the meaning of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation
Act shall require the consent of the shareholders with majority set out in the fourth sentence of this article 10.4.

C. Management

Art. 11. Board of directors.
11.1 The Company shall be managed by a board of directors. The board of directors is vested with the broadest

powers to take any actions necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the
actions reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

11.2 In accordance with article 60 of the Law, the Company’s daily management and the Company’s representation in

connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any
other person(s) appointed by the board of directors, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers
shall be determined by a resolution of the board of directors.

11.3 The board of directors may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.
11.4 The board of directors is composed of at least three (3) directors. The board of directors must choose from

among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a vice-chairman and it may choose a secretary,
who does not need to be a shareholder or a member of the board of directors.

Art. 12. Election and removal of directors and term of the office.
12.1 Directors may be re-elected for successive terms. The directors are elected by a simple majority vote of the

shares represented in a general meeting. Any director may be removed at any time without cause and prior notice by
the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares represented.

12.2 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement, dismissal or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by a person designated by the
remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appoint-
ment.

Art. 13. Rules of procedure of the board of directors and board committees.
13.1 The board of directors determines its rules of conduct in a resolution and establishes such rules in writing.
13.2 The board of directors shall establish an audit committee (the “Audit Committee”), a nominating committee (the

“Nominating Committee”) and a compensation committee (the “Compensation Committee”). The board may further
(but shall not be obliged to unless required by law), establish one or more additional committees. The board shall de-
termine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable for all
committees which are established.

13.3 In particular, the responsibilities and organisation of the Audit Committee, the Nomination Committee and the

Compensation Committee shall be determined in a charter for each such committee by the board of directors. The board
of directors may also issue general principles and codes of conduct for the Company and its group.

13.4 Audit Committee: the Audit Committee shall be composed of at least three (3) members and the board of

directors shall appoint the members of the Audit Committee and shall designate one (1) of such members as the chair-
person of the Audit Committee. The purpose of the Audit Committee is (i) to oversee the accounting and financial
reporting processes of the Company, the audits of the financial statements of the Company, the Company's internal
control and recommending to the board of directors the choice of the Company’s approved independent auditor (réviseur

53108

L

U X E M B O U R G

d’entreprises agréé); and (ii) to perform such other duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the
regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed, as well as any other duties entrusted
to it by the board of directors. The board of directors shall allocate to the Audit Committee the necessary resources
and authority to fulfill its functions. The members of the Audit Committee may receive remuneration from the Company
in consideration of their services as members of the Audit Committee.

13.5 Nominating Committee: the Nominating Committee shall be composed of at least three (3) members and the

board of directors shall appoint the members of the Nominating Committee and shall designate one (1) of such members
as the chairperson of the Nominating Committee. The purpose of the Nominating Committee is to (i) assist the board
of directors in discharging the board of directors' responsibilities regarding (a) the identification of qualified candidates
to become directors of the Company, (b) the selection or recommendation to the board of directors regarding the
selection of nominees for election as directors at the next annual meeting of shareholders (or extraordinary meeting of
shareholders at which directors are to be elected), (c) the selection or recommendation of selection to the board of
directors regarding the selection of candidates to fill any vacancies on the board of directors and board committees, (d)
the assignment and rotation of directors of the board to various board committees, (e) oversight of the evaluation of the
board of directors and its various committees, and (f) assistance with the selection of candidates for future executive
officers as well as the promotion and changes in position of incumbent executive officers; and (ii) to perform such other
duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the shares
of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors
shall allocate to the Nominating Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members
of the Nominating Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as members
of the Nominating Committee.

13.6 Compensation Committee: the Compensation Committee shall be composed of at least three (3) members and

the board of directors shall appoint the members of the Compensation Committee and shall designate one (1) of such
members as the chairperson of the Compensation Committee. The purpose of the Compensation Committee is (i) to
discharge or assist the board of directors in discharging the board of directors' responsibilities relating to review and
approval of the Company’s compensation programs and the compensation of the Company’s executive officers (including
the Company's subsidiaries), including by designing (in consultation with management and the board of directors), eva-
luating and approving the compensation plans, policies and programs of the Company and (ii) to perform such other
duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the shares
of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors
shall allocate to the Compensation Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members
of the Compensation Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as
members of the Compensation Committee.

13.7 The Board may in particular pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile,

electronic mail or any other similar means of communication, provided that each of the directors participates in such
resolution by circular means. The directors may express their consent separately on one or several documents. The date
of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 14. Dealing with third parties.
14.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2)

directors or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such power may have been delegated by the
board of directors.

14.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signatures

of any person to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly and within the limits of such
delegation.

Art. 15. Indemnification.
15.1 The members of the board of directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations

of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to mandatory
provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors or officer of the Company shall
be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably
incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party
or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him
in the settlement thereof. The words “claim”, “action”, “suit” or “proceeding” shall apply to all claims, actions, suits or
proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words “liability” and “expenses”
shall include without limitation attorneys’ fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

15.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) against any liability to the Company or its

shareholders by reason of willful misconduct, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in
the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted
in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been
approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.

53109

L

U X E M B O U R G

15.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any

director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director
or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained
herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers,
may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual
indemnification to any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide
upon from time to time.

15.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or pro-

ceeding of the character described in this article 15 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately deter-
mined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 16. Conflicts of interest.
16.1 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a personal interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interests, such director must
inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the
board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction.
Such conflict of interest shall be reported to the next general meeting.

16.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that a director has a personal interest in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or
employee of such other company or firm.

D. Auditors

Art. 17. Independent auditor(s).
17.1 The Company’s annual accounts shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs

d’entreprises agréés), appointed by the general meeting of shareholders at the board of directors’ recommendation (itself
acting upon recommendation of the Audit Committee). The general meeting of shareholders shall determine the number
of auditor(s) and the term of their office.

17.2 An approved independent auditor may be dismissed at any time with cause (or with his approval) by the general

meeting of shareholders. An approved independent auditor (réviseur d’entreprises agréé) may be reappointed.

E. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 18. Financial year. The Company’s financial year shall begin on the first of January of each year and shall end on

the thirty-first of December of the same year.

Art. 19. Profits.
19.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors shall draw up or shall cause

to be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with
the Law.

19.2 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s issued share capital.

19.3 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how

the remainder of the annual net profits will be allocated. Each share shall be entitled to receive the same amount.

19.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation. In the case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be
reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

19.5 If the shares are held through a Depositary, the Company will make dividend payments and any other payments

in cash, shares or other securities only to the Depositary recorded in the register or in accordance with its instructions,
and such payment will fully discharge of the Company’s obligations in this respect.

19.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable

revert back to the Company.

Art. 20. Interim dividends - Share premium and additional premiums.
20.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
20.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

53110

L

U X E M B O U R G

F. Liquidation

Art. 21. Liquidation.
21.1 In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s dissolution
which shall determine the liquidators’ powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have
the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

21.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realization of assets and

the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the
Company held by them.

G. Governing law

Art. 22. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.”

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 

st

 December

2015.

2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2016.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The thirty-one thousand (31,000) shares issued, which shall be numbered 1 to 31,000, have been subscribed as follows:
- fifteen thousand nine hundred ninety-five (15,995) shares, which shall be numbered 1 to 15,995, have been subscribed

by Rocket Internet AG, aforementioned, for the price of fifteen thousand nine hundred ninety-five Euro (EUR 15,995);

- four thousand three hundred thirty-seven (4,337) shares, which shall be numbered 15,996 to 20,332, have been

subscribed by Kinnevik Online AB, aforementioned, for the price of four thousand three hundred thirty-seven Euro (EUR
4,337);

- two thousand six hundred nineteen (2,619) shares, which shall be numbered 20,333 to 22,951, have been subscribed

by Summit Partners RKT S.à r.l., aforementioned, for the price of two thousand six hundred nineteen Euro (EUR 2,619);

- nine hundred fifty-one (951) shares, which shall be numbered 22,952 to 23,902, have been subscribed by Saturn 2

S.à r.l., aforementioned, for the price of nine hundred fifty-one Euro (EUR 951);

- one thousand five hundred twenty-five (1,525) shares, which shall be numbered 23,903 to 25,427, have been sub-

scribed by HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, aforementioned, for the price of one thousand five hundred
twenty-five Euro (EUR 1,525);

- eight hundred seventy-three (873) shares, which shall be numbered 25,428 to 26,300, have been subscribed by TEC

Global Invest II GmbH, aforementioned, for the price of eight hundred seventy- three Euro (EUR 873);

- eight hundred seventy-three (873) shares, which shall be numbered 26,301 to 27,173, have been subscribed by

Aismare Limited, aforementioned, for the price of eight hundred seventy-three Euro (EUR 873);

- one thousand three hundred nine (1,309) shares, which shall be numbered 27,174 to 28,482, have been subscribed

by E-commerce Holdings LP, aforementioned, for the price of one thousand three hundred nine Euro (EUR 1,309);

- two hundred eighteen (218) shares, which shall be numbered 28,483 to 28,700, have been subscribed by BNY Mellon

Trust Company (Ireland) Limited, aforementioned, for the price of two hundred eighteen Euro (EUR 218);

- one hundred seventy-five (175) shares, which shall be numbered 28,701 to 28,875, have been subscribed by MER-

CURA CAPITAL GmbH, aforementioned, for the price of one hundred seventy-five Euro (EUR 175);

- eight hundred seventy-three (873) shares, which shall be numbered 28,876 to 29,748, have been subscribed by Tetral

S.A., aforementioned, for the price of eight hundred seventy-three Euro (EUR 873);

- four hundred thirty-seven (437) shares, which shall be numbered 29,749 to 30,185, have been subscribed by JaToPa

GmbH, aforementioned, for the price of four hundred thirty-seven Euro (EUR 437);

- two hundred ninety-one (291) shares, which shall be numbered 30,186 to 30,476, have been subscribed by Kaltroco

Limited, aforementioned, for the price of two hundred ninety-one Euro (EUR 291); and

- five hundred twenty-four (524) shares, which shall be numbered 30,477 to 31,000, have been subscribed by E-Fashion

S.à r.l., aforementioned, for the price of five hundred twenty-four Euro (EUR 524).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand

Euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned

notary.

The total contribution in the amount of thirty-one thousand Euro (EUR 31,000) is entirely allocated to the share capital.

53111

L

U X E M B O U R G

<i>Declaration

The undersigned notary herewith declares that he has verified the existence of the conditions provided for or referred

to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 2,500.

<i>Resolutions of the shareholders

The incorporating shareholders, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, have passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened

to approve the Company’s annual accounts for the first financial year:

- Mr. Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin;

- Mr. Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg; and

- Mr. Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium, on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Ernst &amp; Young, a société anonyme existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the

Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann,
L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg is appointed as independent auditor until the general meeting of share-
holders convened to approve the Company’s annual accounts for the first financial year.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified in the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing parties and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholders of the appearing parties, known to the notary by name, first

name and residence, the said proxyholders of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am sechsten März.

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Großherzogtum Luxemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

2. Kinnevik Online AB, eine Gesellschaft (aktiebolag) bestehend unter schwedischem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz

in Stockholm, Schweden, eingetragen im Handelsregister in Schweden (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958,
mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

3. Summit Partners RKT S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Re-
gistre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 169548, mit Sitz in 5, rue de Plébiscite, L-2341 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

4. Saturn 2 S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de
Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 180356, mit Sitz in 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

53112

L

U X E M B O U R G

5. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

6. Aismare Limited, eine Gesellschaft (limited company) gegründet in England und Wales, eingetragen im Companies

House of the United Kingdom unter der Nummer 07634146, mit Sitz in 11/12 Lennox Gardens Mews London England,
SW1X 0DP, Vereinigtes Königreich,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

7. E-commerce Holdings LP, eine Gesellschaft (limited partnership) bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln

(Cayman Islands), mit Sitz in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

8. BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited, eine Gesellschaft (limited company) bestehend unter dem Recht

Irlands, eingetragen im Companies Registration Office Ireland unter der Nummer 223184, in ihrer Eigenschaft als Treu-
händerin der Eureka Fund, einer Untertreuhandgesellschaft der Marshall Wace Investment Strategies, mit Sitz in Guild
House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Irland,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

9. Mercura Capital GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen

im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  München,  Deutschland,  unter  der  Nummer  HRB  200948,  mit  Geschäftssitz  in
Schießstättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

10. Tetral S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht der Schweiz, mit satzungsmä-

ßigem Sitz in Pully, Schweiz, eingetragen im Handelsregister (Federal Commercial Registry office) des Kantons Waadt
unter der Nummer CH-550.1.000.845-3, mit Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Schweiz,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

11. JaToPa GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, mit satzungsmäßigem

Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Num-
mer HRB 198609, mit Sitz in Maximilianstraße 21, 80539 München, Deutschland,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

12. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft (limited company) bestehend unter dem Recht von Jersey, eingetragen im JFSC

Companies Registry unter der Nummer 60595, mit Sitz in Third Floor, South Tower, 29/31 Esplanade, St. Helier, Jersey
JE2 3QA, Jersey, Kanalinseln (Channel Islands),

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht;

13. E-Fashion S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre
de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 177.487, mit Sitz in 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxemburg,

hier vertreten durch Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht; und

14. TEC Global Invest II GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, ein-

getragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Duisburg,  Deutschland,  unter  der  Nummer  HRB  24964,  mit  Sitz  in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,

hier vertreten durch Frau Alina Rymalova, Rechtsanwältin, geschäftsansässig in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg, gemäß einer privatschriftlich ausgestellten Vollmacht.

Besagte Vollmachten, welche von den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die besagten erschienenen Parteien haben die amtierende Notarin ersucht, die Gründung einer Aktiengesellschaft

(sociéte anonyme) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen wollen:

53113

L

U X E M B O U R G

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Lazada Group S.A.

(die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner
aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren jegliche Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Ge-

sellschaft sowie für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält,
oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, einräumen und Kredite gewähren, Leistungen
erbringen oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für jede Gesellschaft, an welcher sie eine direkte oder indirekte Kontroll-

mehrheit hält, Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermö-
gensverwaltung (treasury management), Währungsmanagement (currencies management services), Zins- (interest rate)
und Devisenkursrisikomanagement (foreign exchange risk management).

2.4 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.5 Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten

durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art,
(ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich dieses geistigen Eigentums und dieser gewerblichen Schutzrechte, und (iii) das
Halten und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.6 Die Gesellschaft wird nicht als alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die

Verwalter  alternativer  Investmentfonds  handeln  und  wird  keine  anderen  Tätigkeit  durchführen,  die  der  Aufsicht  der
Commission de Surveillance du Secteur Financier unterliegen würde.

2.7 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller, finanzieller und technischer Na-

tur, sowie solche, welches geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann

der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversamm-
lung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede
andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.2 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Aktien - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000), bestehend aus einunddrei-

ßigtausend (31.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine

Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Vorbehaltlich des Artikels 6.2 dieser Satzung werden alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu zahlen sind,

bevorzugt den bestehenden Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am ausgegebenen Gesellschaftskapital
jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt
werden kann. Dieser Zeitraum beträgt nicht weniger als dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Zeich-
nungszeitraums,  welcher  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums  Luxemburg,  dem  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations (das „Mémorial“) und in zwei (2) Luxemburger Tageszeitungen im Einklang mit dem Gesetz von 1915 ver-
öffentlicht wird, oder, falls alle Aktien Namensaktien sind, ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung der Aktionäre durch
Einschreiben. Jedoch kann, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, die Hauptversammlung der Aktionäre (i)

53114

L

U X E M B O U R G

im Rahmen eines Beschlusses über die Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder (ii) anlässlich einer dem
Verwaltungsrat eingeräumten Berechtigung zur Erhöhung des von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftskapitals
das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss begrenzen oder aufheben, oder den Verwaltungsrat
hierzu ermächtigen. Ein solcher Beschluss ist im Einklang mit den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung zu fassen.

Art. 6. Genehmigtes Kapital.
6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, eine Million

sechshundertneununddreißigtausendzweiundneunzig Euro (EUR 1.639.092), aufgeteilt in eine Million sechshundertneu-
nunddreißigtausendzweiundneunzig (1.639.092) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

6.2 Der Verwaltungsrat ist hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung

des betreffenden Gesellschafterbeschlusses im Mémorial im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien aus-
zugeben, Aktienbezugsoptionen für Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszu-
geben, um die Zuteilung von Aktien, folgend auf die Ausübung oder Umwandlung der Aktienoptionen oder anderer
aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Ge-
sellschaft vorzunehmen, oder Aktien an bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe,
von welcher die Gesellschaft das Mutterunternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter
solchen Bedingungen erfolgt, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären
ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder
mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf
(5) Jahre beträgt.

6.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, wel-

cher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Aktien.
7.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien aufgeteilt, die alle den gleichen Nominalwert haben. Die

Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben.

7.2 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung frei übertragbar.

Die Gesellschaft kann entsprechend den Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Aktien zurückerwerben und als eigene
Aktien halten.

7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Stammaktie von mehreren Personen

gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie solange auszusetzen, bis
eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz,

noch ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

7.5 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Register enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum an
Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden, unbeschadet der Bedingungen für
Übertragungen im Wege der Umbuchung von Bucheffekten, wie in Artikel 7.6 dieser Satzung vorgesehen. Zertifikate
über die Eintragung werden auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs an diesen und, in dem in Artikel 7.6
dieser Satzung vorgesehenen Fall, an die Verwahrstelle (wie unten definiert) ausgegeben. Alle einem eingetragenen Ak-
tionär zuzustellenden Mitteilungen und Bescheide gelten als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie an die letzte von diesem
Aktionär an die Gesellschaft kommunizierte Adresse geschickt wurden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, weder
einen Eintrag im Aktienregister vorzunehmen, noch eine Übertragungsmitteilung während eines Zeitraums ab dem Stich-
tag (wie unten definiert) bis zum Ablauf der betreffenden Hauptversammlung von der Gesellschaft anzuerkennen.

7.6 Handelt es sich bei den Aktien um Namensaktien und sind diese im Aktienregister der Gesellschaft im Namen oder

für Rechnung eines Wertpapierabwicklungssystems oder des Betreibers eines solchen Systems eingetragen und als Buch-
effekte in den Geschäftsbüchern eines Kreditinstituts oder einer professionellen Verwahrstelle oder Unterverwahrstelle
verzeichnet (wobei solche Kreditinstitute, Verwahrstellen und Unterverwahrstellen im Folgenden als „Verwahrstelle“
bezeichnet werden), räumt die Gesellschaft der betreffenden Verwahrstelle, nach Vorlage eines Nachweises durch die
Verwahrstelle über die Eintragung der Bucheffekte, die Ausübung der mit den Aktien verbundenen Rechte entsprechend
der Bucheffekte des betreffenden Aktionärs, einschließlich des Erhalts von Einberufungen zu Hauptversammlungen, die
Zulassung zu Hauptversammlungen und ein Stimmrecht bei Hauptversammlungen ein (die „Zertifikate“). Der Verwal-
tungsrat kann Formvorschriften festlegen, denen diese Zertifikate entsprechen müssen.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Haupt-

versammlung  der  Aktionäre  aus.  Jede  regelmäßig  einberufene  Hauptversammlung  der  Aktionäre  repräsentiert  die
Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915
oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

53115

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Einberufung der Hauptversammlung.
9.1 Die Jahreshauptversammlung wird am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an einem anderen in der Einberufung

bestimmten Ort in Luxemburg am letzten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Ist
dieser Tag kein Werktag in Luxemburg, so ist die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können zu jeder Zeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden und an
dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

9.2 Hauptversammlungen der Aktionäre müssen im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser

Satzung und, falls die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, in Übereinstimmung mit den die Gesellschaft
betreffenden Publizitätspflichten dieser ausländischen Börse, einberufen werden. Falls alle Aktionäre anwesend sind, ist
keine Einberufung oder vorherige Mitteilung notwendig.

9.3 Falls die Aktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse zum Handel zugelassen sind, sind alle am Tag

der Hauptversammlung der Aktionäre im Aktienregister geführten Aktionäre dazu berechtigt, zur Hauptversammlung
der Aktionäre zugelassen zu werden. Sind die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert, so kann der
Verwaltungsrat ein/e dem der Hauptversammlung vorangehende/s Datum und Uhrzeit als Stichtag zur Zulassung zur
Hauptversammlung der Aktionäre bestimmen (der „Stichtag“). In einem solchen Fall muss jeder Aktionär, der an der
Hauptversammlung teilnehmen möchte, die Gesellschaft spätestens am Stichtag auf die vom Verwaltungsrat im Einberu-
fungsbescheid festgelegte Weise darüber in Kenntnis setzen. Werden Aktien durch eine Verwahrstelle gehalten, muss
ein Aktionär, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, von dieser Verwahrstelle ein oder meh-
rere Zertifikate erhalten, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen registrierten Aktien am Stichtag ausweist. In der
Zeit zwischen dem Stichtag und dem Ablauf der Hauptversammlung darf weder ein Eintrag im Aktienregister vorgenom-
men  werden,  noch  darf  eine  Mitteilung  einer  Aktienübertragung  von  der  Gesellschaft  oder  einem  im  Auftrag  der
Gesellschaft handelnden Registerführer anerkannt werden, wenn dies vom Verwaltungsrat entschieden wird. Bei einer
Übertragung von Aktien in Form von Bucheffekten in der Zeit zwischen dem Stichtag und dem Datum der Hauptver-
sammlung ist der Veräußerer vom Erwerber ermächtigt, an einer solchen Hauptversammlung teilzunehmen und insbe-
sondere die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die Zertifikate sollten bei der Gesellschaft (oder dem
in der Einberufung ernannten Vertreter) nicht später als fünf (5) Werktage vor dem Tag der betreffenden Hauptver-
sammlung eingereicht werden. Vollmachten und Stimmzettel bezüglich solcher Hauptversammlungen müssen zur gleichen
Zeit übermittelt werden. Der Verwaltungsrat kann einen kürzeren Zeitraum für die Übermittlung der Zertifikate sowie
der Vollmachten oder Stimmzetteln festlegen.

9.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person bevoll-

mächtigt.

9.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme durch eine Stimmkarte abgeben, welche per Post oder Fax an den Sitz der

Gesellschaft  oder  an  den  in  der  Einberufung  genannten  Vertreter  gesendet  wird.  Die  Aktionäre  können  nur  solche
Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, deren Inhalt durch den Verwaltungsrat
bestimmt wird.

9.6 Der Verwaltungsrat kann in der Einberufung weitere Bedingungen festlegen, die ein Aktionär zur Teilnahme an

einer Versammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht begrenzt auf längere Mitteilungsfristen).

Art. 10. Quorum und Stimmrecht.
10.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
10.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

10.3 Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
10.4 Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die

mindestens zwei Drittel (2/3) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) eine Änderung dieser Satzung;
(ii) die Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
(iii) eine Änderung des Gesellschaftskapitals oder die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von Aktien (sofern nicht

über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen); und

(iv) eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals oder die Einziehung oder der Rückkauf von Aktien durch die Gesell-

schaft.

Für die Änderung von Rechten einer Aktienklasse bedarf es zusätzlich zu den Voraussetzungen des vorhergehenden

Satzes der Zustimmung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel (2/3) aller Aktien der betreffenden Klasse halten.

Die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von anderen Wertpapieren als Aktien in der Gesellschaft oder die Bewilligung

von Optionen oder Bezugsrechten oder die Umwandlung jeglicher Instrumente in Aktien oder andere Sicherheiten der
Gesellschaft (sofern nicht über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen),
erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz dieses Artikels 10.4 festgelegten Mehrheit.

53116

L

U X E M B O U R G

Beschlüsse der Hauptversammlung hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktio-

nären, die mehr als fünfzig Prozent (50%) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) die Genehmigung von gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüssen der Gesellschaft und konsolidierten Konzernab-

schlüssen;

(ii) die Auszahlung oder die Festsetzung von Dividenden oder anderen Ausschüttungen durch die Gesellschaft; und
(iii) die Ernennung oder die Neubesetzung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft.
Der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung von (a) stillen Beteiligungen und Unterbeteiligungen an der Gesell-

schaft oder (b) Unternehmensverträgen der Gesellschaft im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)
erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz des Artikels 10.4 dieser Satzung festgelegten Mehrheit.

D. Geschäftsführung

Art. 11. Verwaltungsrat.
11.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden

Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschafts-
zwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung
der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

11.2 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, oder einer oder mehreren durch den Verwaltungsrat
dazu befugten Personen mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberu-
fung und ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

11.3 Der Verwaltungsrat kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
11.4 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat

wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen stellvertretenden Vorsit-
zenden und einen Schriftführer ernennen, der weder Aktionär, noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 12. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
12.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der in einer Hauptversammlung vertretenen Aktien ernannt. Ein Verwaltungsrats-
mitglied kann jederzeit und ohne Grund und vorherige Mitteilung von der Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher
Mehrheit der vertretenen Aktien abberufen werden.

12.2 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch eine von den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern ernannte
Person bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die endgültige Neubesetzung entscheidet, vo-
rübergehend ausgefüllt werden.

Art. 13. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse.
13.1 Der Verwaltungsrat beschließt seine Geschäftsordnung in einem Beschluss und stellt diese in schriftlicher Form

auf.

13.2 Der Verwaltungsrat richtet einen Prüfungsausschuss (der „Prüfungsausschuss“), einen Nominierungsausschuss

(der „Nominierungsausschuss“) und einen Vergütungsausschuss (der „Vergütungsausschuss“) ein. Der Verwaltungsrat
kann des Weiteren einen oder mehrere weitere Ausschüsse einrichten (ist aber nicht dazu verpflichtet, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben). Der Verwaltungsrat bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zuständigkeiten sowie
die Verfahrensweisen und andere Regeln, die für alle eingerichteten Ausschüsse gelten, soweit anwendbar.

13.3 Die Zuständigkeiten und die Organisation des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Ver-

gütungsausschusses  werden  durch  den  Verwaltungsrat  ausdrücklich  in  einer  Charter  für  jeden  dieser  Ausschüsse
festgelegt. Der Verwaltungsrat kann zudem allgemeine Grundsätze und einen Verhaltenskodex für die Gesellschaft und
ihre Unternehmensgruppe festlegen.

13.4 Prüfungsausschuss: der Prüfungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der Ver-

waltungsrat ernennt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses. Der Zweck des Prüfungsausschusses ist (i) die Überwachung der Rechnungslegungs- und Fi-
nanzberichterstattung  (reporting)  der  Gesellschaft,  der  Abschlussprüfung  der  Gesellschaft,  die  interne  Kontrolle  der
Gesellschaft und Empfehlung des Wirtschaftsprüfers (réviseur d’entreprises agréé) der Gesellschaft an den Verwaltungs-
rat;  und  (ii)  die  Einhaltung  anderer  Verpflichtungen,  welche  ihm  nach  anwendbarem  Recht  zukommen  und  ggf.  die
Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln,
sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem
Prüfungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder
des Prüfungsausschusses können von der Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses erhalten.

13.5 Nominierungsausschuss: der Nominierungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen

und der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Nominierungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder

53117

L

U X E M B O U R G

als Vorsitzenden des Nominierungsausschusses. Der Zweck des Nominierungsausschusses ist (i) die Unterstützung des
Verwaltungsrats bei der Erfüllung der Verpflichtungen des Verwaltungsrats hinsichtlich (a) der Identifizierung qualifizierter
Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, (b) der Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat
zur Auswahl von Kandidaten für die Wahl als Verwaltungsratsmitglied bei der nächsten jährlichen Hauptversammlung
(oder  außerordentlichen  Hauptversammlung,  bei  welcher  Verwaltungsratsmitglieder  ernannt  werden  sollen),  (c)  der
Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat zur Auswahl von Kandidaten zur Besetzung von freien Stellen beim
Verwaltungsrat und den Ausschüssen, (d) der Zuweisung und dem turnusgemäßen Wechsel von Verwaltungsratsmitglie-
dern in verschiedene Ausschüsse, (e) der Überwachung der Beurteilung des Verwaltungsrats und seiner verschiedenen
Ausschüsse, und (f) der Unterstützung bei der Auswahl von Kandidaten als künftige Führungskräfte sowie bei der Beför-
derung und dem Positionswechsel von Führungskräften; und (ii) die Einhaltung anderer Verpflichtungen, welche ihm nach
anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der
Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat
betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Nominierungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung
seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses können von der Gesellschaft eine Ver-
gütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten.

13.6 Vergütungsausschuss: der Vergütungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der

Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Vergütungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsit-
zenden des Vergütungsausschusses. Der Zweck des Vergütungsausschusses ist (i) die Entlastung oder Unterstützung des
Verwaltungsrats bei der Erfüllung seiner Pflichten hinsichtlich der Überprüfung und Genehmigung der Bonusprogramme
und der Vergütung der Führungskräfte der Gesellschaft (einschließlich der Tochtergesellschaften der Gesellschaft), ein-
schließlich der Erstellung (in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat), Beurteilung und Geneh-
migung der Vergütungspläne, der Vergütungspolitik und Bonusprogramme der Gesellschaft und (ii) die Einhaltung anderer
Verpflichtungen, welche ihm nach anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an
welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit
denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Vergütungsausschuss die notwendigen Mittel
und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses können von der
Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Vergütungsausschusses erhalten.

13.7 Der Verwaltungsrat kann insbesondere Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen, vorausgesetzt, dass alle Verwaltungsratsmitglieder an
diesem Beschluss teilnehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustimmung auf einem oder mehreren Doku-
menten getrennt erteilen. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 14. Geschäfte mit Dritten.
14.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)

beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der
(denen) eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

14.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der(denen) diese Vollmacht übertragen wurde.

Art. 15. Entschädigung.
15.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nicht persönlich für die Schulden oder sonstigen Verpflichtungen der

Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie für die Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich. Vorbehaltlich zwing-
ender gesetzlicher Vorschriften soll jede Person, die Mitglied des Verwaltungsrats oder sonstiger Mandatsträger der
Gesellschaft ist oder war, im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Maße durch die Gesellschaft von jeglicher Haftung
oder von angemessenen Kosten freigestellt werden, die im Zusammenhang mit Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder
sonstigen Verfahren, in die die betreffende Person als Partei oder in sonstiger Weise aufgrund ihres bestehenden oder
ehemaligen Mandatsverhältnisses mit der Gesellschaft involviert ist oder war, oder im Zusammenhang mit der Begleichung
oder Beseitigung derselben, eintreten. Die Begriffe „Anspruch“, „Rechtsmittel“, „Klage“ oder sonstigen „Verfahren“ er-
fassen sämtliche bestehenden oder drohende Ansprüche, Rechtsmittel, Klagen oder sonstige Verfahren (ob zivilrechtli-
cher, strafrechtlicher oder sonstiger Natur, einschließlich in weiteren Instanzen), und die Worte „Haftung“ und „Kosten“
sollen ohne Einschränkung Anwaltskosten, Unkosten, Urteile, zu Begleichungs- oder Vergleichszwecken gezahlte Beträge
und sonstige Verbindlichkeiten umfassen.

15.2 Ein Verwaltungsratsmitglied soll nicht entschädigt werden, wenn (i) die Haftung des Verwaltungsratsmitglieds

gegenüber  der  Gesellschaft  oder  den  Aktionären  aus  vorsätzlicher,  arglistiger,  grob  fahrlässiger  oder  rücksichtsloser
Verletzung der Mandatspflichten entstand, (ii) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, bezüglich welcher das be-
treffende Verwaltungsratsmitglied wegen arglistigem und nicht im Interesse der Gesellschaft liegenden Handeln rechts-
kräftig verurteilt wurde, oder (iii) es sich um Zahlungen aus einem Vergleich handelt, sofern nicht durch ein zuständiges
Gericht oder durch den Verwaltungsrat bestätigt.

15.3 Das Recht auf Entschädigung ist individuell, es berührt in keiner Weise sonstige gegenwärtige oder zukünftige

Rechte eines Verwaltungsratsmitglieds und besteht einmal entstanden fort, auch wenn die betreffende Person in der Folge
nicht länger Verwaltungsratsmitglied ist, und kommt seinen Erben, dem Testamentsvollstrecker und dem Verwalter zu-
gute.  Keine  der  hierin  enthaltenen  Bestimmungen  soll  etwaige  vertragliche  oder  sonstige  gesetzlich  vorgesehene

53118

L

U X E M B O U R G

Entschädigungsrechte von Angestellten, Verwaltungsratsmitgliedern oder Mandatsträgern beschränken oder berühren.
Die Gesellschaft ist ausdrücklich befugt, vertragliche Entschädigungen anAngestellte, einschließlich Verwaltungsratsmit-
glieder oder Mandatsträger der Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu gewähren.

15.4 Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung von Ansprüchen, Rechtsmitteln,

Klagen oder sonstigen Verfahren im Sinne dieses Artikels 15 sollen, vor der endgültigen Entscheidung über ihre Erstat-
tungsfähigkeit,  von  der  Gesellschaft  vorgestreckt  werden,  sofern  sich  der  betreffende  leitende  Angestellte  oder  das
Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese an die Gesellschaft zurück zu erstatten, sollte sich
im Nachhinein herausstellen, dass dem betreffenden Mandatsträger oder dem Verwaltungsratsmitglied kein Entschädi-
gungsanspruch gemäß dieses Artikels zusteht.

Art. 16. Interessenkonflikt.
16.1 Soweit gesetzlich erforderlich hat jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einer Transaktion, die dem Verwal-

tungsrat  zur  Entscheidung  vorliegt,  direkt  oder  indirekt  ein  persönliches  Interesse  hat,  welches  den  Interessen  der
Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt zu informieren und dafür zu sorgen, dass
die Erklärung im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen wird. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf
weder an der Beratung über die in Frage stehend Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Über einen solchen
Interessenkonflikt ist auf der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten.

16.2 Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

durch die Tatsache, dass ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einer solchen Gesellschaft oder Firma
hat oder durch die Tatsache, dass er Verwaltungsratsmitglied, Partner, leitender Angestellter, Vertreter, Berater oder
Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist, beeinflusst oder ungültig.

E. Wirtschaftsprüfer

Art. 17. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.
17.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sind von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschafts-

prüfern (réviseurs d’entreprises agréés), die von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats (welcher
selbst auf Vorschlag des Prüfungsausschusses handelt) ernannt werden, zu prüfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre
bestimmt die Anzahl des/der Wirtschaftsprüfer/s und ihre Amtszeit.

17.2 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann jederzeit mit Grund (oder mit seiner Zustimmung) durch die Haupt-

versammlung der Aktionäre abberufen werden. Ein zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises
agréé) kann wiederernannt werden.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 19. Gewinne.
19.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung.

19.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals beträgt.

19.3 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wie der verbleibende

jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll. Jede Aktie erhält den gleichen Betrag.

19.4 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rück-
lage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals nicht
übersteigt.

19.5 Werden Aktien von einer Verwahrstelle gehalten, so tätigt die Gesellschaft Dividendenzahlungen oder andere

Barzahlungen, durch Aktien oder andere Wertpapiere nur an die im Aktienregister benannte Verwahrstelle im Einklang
mit ihren Anweisungen, und eine solche Zahlung befreit die Gesellschaft von jeglichen Verpflichtungen in dieser Angele-
genheit.

19.6 Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht wurden, fallen an die Gesell-

schaft zurück.

Art. 20. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
20.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-

zahlen.

20.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

53119

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 21. Liquidation.
21.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt
und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquida-
toren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft.

21.2 Sofern nicht anders in dieser Satzung festgelegt, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung

der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft
gehaltenen Aktien verteilt.

H. Anwendbares recht

Art. 22. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.“

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Die erste Jahreshauptversammlung der Aktionäre soll im Jahr 2016 abgehalten werden.
3. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die einunddreißigtausend (31.000) ausgegebenen Aktien, welche von 1 bis 31.000 nummeriert sind, wurden wie folgt

gezeichnet:

- fünfzehntausendneunhundertfünfundneunzig (15.995) Aktien, welche von 1 bis 15.995 nummeriert sind, wurden von

Rocket  Internet  AG,  vorbenannt,  zum  Preis  von  fünfzehntausendneunhundertfünfundneunzig  Euro  (EUR  15.995)  ge-
zeichnet;

- viertausenddreihundertsiebenunddreißig (4.337) Aktien, welche von 15.996 bis 20.332 nummeriert sind, wurden von

Kinnevik Online AB, vorbenannt, zum Preis von viertausenddreihundertsiebenunddreißig Euro (EUR 4.337) gezeichnet;

-  zweitausendsechshundertneunzehn  (2.619)  Aktien,  welche  von  20.333  bis  22.951  nummeriert  sind,  wurden  von

Summit Partners RKT S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zweitausendsechshundertneunzehn Euro (EUR 2.619) gezeichnet;

- neunhunderteinundfünfzig (951) Aktien, welche von 22.952 bis 23.902 nummeriert sind, wurden von Saturn 2 S.à r.l.,

vorbenannt, zum Preis von neunhunderteinundfünfzig Euro (EUR 951) gezeichnet;

- eintausendfünfhundertfünfundzwanzig (1.525) Aktien, welche von 23.903 bis 25.427 nummeriert sind, wurden von

HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, vorbenannt, zum Preis von eintausendfünfhundertfünfundzwanzig
Euro (EUR 1.525) gezeichnet;

- achthundertdreiundsiebzig (873) Aktien, welche von 25.428 bis 26.300 nummeriert sind, wurden von TEC Global

Invest II GmbH, vorbenannt, zum Preis von achthundertdreiundsiebzig Euro (EUR 873) gezeichnet;

- achthundertdreiundsiebzig (873) Aktien, welche von 26.301 bis 27.173 nummeriert sind, wurden von Aismare Limi-

ted, vorbenannt, zum Preis von achthundertdreiundsiebzig Euro (EUR 873) gezeichnet;

- eintausenddreihundertneun (1.309) Aktien, welche von 27.174 bis 28.482 nummeriert sind, wurden von E-commerce

Holdings LP, vorbenannt, zum Preis von eintausenddreihundertneun Euro (EUR 1.309) gezeichnet;

- zweihundertachtzehn (218) Aktien, welche von 28.483 bis 28.700 nummeriert sind, wurden von BNY Mellon Trust

Company (Ireland) Limited, vorbenannt, zum Preis von zweihundertachtzehn Euro (EUR 218) gezeichnet;

- einhundertfünfundsiebzig  (175)  Aktien,  welche  von  28.701  bis 28.875 nummeriert  sind, wurden von MERCURA

CAPITAL GmbH, vorbenannt, zum Preis von einhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 175) gezeichnet;

- achthundertdreiundsiebzig (873) Aktien, welche von 28.876 bis 29.748 nummeriert sind, wurden von Tetral S.A.,

vorbenannt, zum Preis von achthundertdreiundsiebzig Euro (EUR 873) gezeichnet;

-  vierhundertsiebenunddreißig  (437)  Aktien,  welche  von  29.749  bis  30.185  nummeriert  sind,  wurden  von  JaToPa

GmbH, vorbenannt, zum Preis von vierhundertsiebenunddreißig Euro (EUR 437) gezeichnet;

- zweihunderteinundneunzig (291) Aktien, welche von 30.186 bis 30.476 nummeriert sind, wurden von Kaltroco Li-

mited, vorbenannt, zum Preis von zweihunderteinundneunzig Euro (EUR 291) gezeichnet; und

- fünfhundertvierundzwanzig (524) Aktien, welche von 30.477 bis 31.000 nummeriert sind, wurden von E-Fashion S.à

r.l., vorbenannt, zum Preis von fünfhundertvierundzwanzig Euro (EUR 524) gezeichnet.

Die Einlage für die so gezeichneten Aktien wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in

Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) zur Verfügung steht, was der unterzeichnenden Notarin nachgewiesen
wurde.

53120

L

U X E M B O U R G

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin

erbracht.

Die gesamte Einlage in Höhe von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Erklärung

Die unterzeichnende Notarin erklärt hiermit, dass sie die Einhaltung der Vorschriften, die in Artikel 26 des Gesetzes

von 1915 aufgeführt sind und auf die verwiesen wird, geprüft hat und erklärt, dass diese erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit der Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

oder Auslagen werden auf EUR 2.500,- geschätzt.

<i>Beschlüsse der Aktionäre

Die Gründungsaktionäre, welche das gesamte Gesellschaftskapital repräsentieren und auf eine formelle Einberufung

verzichtet haben, haben die folgenden Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgenden Personen werden als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ernannt, bis zur Hauptversammlung

der Aktionäre, die den Jahresabschluss der Gesellschaft für das erste Geschäftsjahr verabschiedet:

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin;

- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg; und

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9. April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Ernst &amp; Young, eine Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Lu-

xemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 47771, mit Sitz in 7, rue
Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, wird als unabhängiger Wirtschaftsprüfer der Gesell-
schaft  ernannt,  bis  zur  Hauptversammlung  der  Aktionäre,  die  den  Jahresabschluss  der  Gesellschaft  für  das  erste
Geschäftsjahr verabschiedet.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Die beurkundende Notarin, welche die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass diese Urkunde

auf Ersuchen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Ersu-
chen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text,
soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien vorgelesen wurde, welche der Notarin mit

Namen,  Vornamen  und  Wohnsitz  bekannt  sind,  haben  die  besagten  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien  die
Urkunde zusammen mit der Notarin unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, A. OLLIGES, A. RYMALOVA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7579. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 13. März 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015041732/1003.
(150047498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

CeDerLux-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 79.327.

Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015042776/10.
(150049567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.

53121

L

U X E M B O U R G

Parabau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5720 Aspelt, 13, um Goldbierchen.

R.C.S. Luxembourg B 195.340.

STATUTEN

Im Jahre zwei tausend fünfzehn.
Den zehnten März.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN:

Herr Stanislaw CHMURA, Trockenbauer, wohnhaft in D-66663 Merzig-Wellingen, Hofgut Hocksfels, 1A.
Welcher Komparent den instrumentierenden Notar ersuchte, folgende Gesellschaftsgründung zu beurkunden:

Titel I. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet, welche durch gegenwärtige Satzung

sowie durch die zutreffenden gesetzlichen Bestimmungen geregelt ist.

Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben.

Art. 2. Die Gesellschaft trägt die Bezeichnung "PARABAU S.à r.l.".

Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Aspelt.
Er kann durch eine Entscheidung des oder der Gesellschafter in eine andere Ortschaft des Grossherzogtums Luxem-

burg verlegt werden.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist das Betreiben eines Bauunternehmens für Hoch- und Tiefbau sowie Trockenbau.
Die Gesellschaft ist des Weiteren ermächtigt alle Arten von industriellen, kommerziellen, finanziellen oder Immobilien-

Transaktionen  zu  tätigen,  welche  mit  dem  Gesellschaftszweck  verbunden  werden  können  und  der  Entwicklung  der
Gesellschaft förderlich sind.

Art. 5. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.

Titel II. Gesellschaftskapital, Anteile

Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt ZWÖLF TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 12.500.-), aufgeteilt in EIN

HUNDERT (100) Anteile von je EIN HUNDERT FÜNFUNDZWANZIG EURO (€ 125.-), alle zugeteilt Herrn Stanislaw
CHMURA, Trockenbauer, wohnhaft in D-66663 Merzig-Wellingen, Hofgut Hocksfels, 1A.

Art. 7. Im Falle von mehreren Gesellschaftern sind die Anteile zwischen ihnen frei übertragbar.
Das Abtreten von Gesellschaftsanteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter bedarf der Genehmigung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Die Übertragungen sind der Gesellschaft und Dritten gegenüber erst rechtswirksam, nachdem sie gemäss Artikel 1690

des Zivilgesetzbuches der Gesellschaft zugestellt, oder von ihr in einer notariellen Urkunde angenommen worden sind.

Titel III. Verwaltung und Vertretung

Art. 8. Die Beschlüsse werden durch den alleinigen Gesellschafter gemäss Artikel 200-2 des Gesetzes vom 18. Sep-

tember 1933 sowie dasselbe abgeändert worden ist, gefasst.

Die Verträge zwischen der Gesellschaft und dem alleinigen Gesellschafter unterliegen ebenfalls den Bestimmungen

dieses Artikels.

Art. 9. Solange die Zahl der Gesellschafter fünfundzwanzig (25) nicht übersteigt, steht es dem Geschäftsführer frei, die

Gesellschafter in Generalversammlungen zu vereinigen. Falls keine Versammlung abgehalten wird, erhält jeder Gesell-
schafter den genau festgelegten Text der zu treffenden Beschlüsse und gibt seine Stimme schriftlich ab.

Eine Entscheidung wird nur dann gültig getroffen, wenn sie von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Kapitals

vertreten, angenommen wird. Ist diese Zahl in einer ersten Versammlung oder schriftlichen Befragung nicht erreicht
worden, so werden die Gesellschafter ein zweites Mal durch Einschreibebrief zusammengerufen oder befragt und die
Entscheidungen werden nach der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen, welches auch der Teil des vertretenen
Kapitals sein mag.

Jeder Gesellschafter ist stimmberechtigt ganz gleich wie viele Anteile er hat. Er kann so viele Stimmen abgeben wie er

Anteile hat. Jeder Gesellschafter kann sich rechtmässig bei der Gesellschafterversammlung auf Grund einer Sondervoll-
macht vertreten lassen.

Art. 10. Die Gesellschaft wird verwaltet durch einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Teilhaber der Ge-

sellschaft sein müssen.

53122

L

U X E M B O U R G

Die Ernennung der Geschäftsführer erfolgt durch den alleinigen Gesellschafter beziehungsweise durch die Gesell-

schafterversammlung, welche die Befugnisse und die Dauer der Mandate des oder der Geschäftsführer festlegt.

Als einfache Mandatare gehen der oder die Geschäftsführer durch ihre Funktion(en) keine persönlichen Verpflichtun-

gen  bezüglich  der  Verbindlichkeiten  der  Gesellschaft  ein.  Sie  sind  jedoch  für  die  ordnungsgemässe  Ausführung  ihres
Mandates verantwortlich.

Art. 11. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember eines jeden Jahres.

Art. 12. Über die Geschäfte der Gesellschaft wird nach handelsüblichem Brauch Buch geführt.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden durch die Geschäftsführung ein Inventar, eine Bilanz und eine Gewinn-

und Verlustrechnung aufgestellt, gemäss den diesbezüglichen gesetzlichen Bestimmungen.

Ein Geschäftsbericht muss gleichzeitig abgegeben werden. Am Gesellschaftssitz kann jeder Gesellschafter während der

Geschäftszeit Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung werden dem oder den Gesellschaftern zur Genehmigung vorgelegt.

Diese äussern sich durch besondere Abstimmung über die Entlastung der Geschäftsführung.

Der Kreditsaldo der Bilanz wird nach Abzug aller Unkosten sowie des Beitrages zur gesetzlichen Reserve der Gene-

ralversammlung der Gesellschafter beziehungsweise dem alleinigen Gesellschafter zur Verfügung gestellt.

Art. 13. Beim Ableben des alleinigen Gesellschafters oder einem der Gesellschafter erlischt die Gesellschaft nicht,

sondern wird durch oder mit den Erben des Verstorbenen weitergeführt.

Titel IV. Auflösung und Liquidation

Art. 14. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere von dem alleinigen

Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannten Liquidatoren, die keine Gesellschafter sein müssen, durch-
geführt.

Der alleinige Gesellschafter beziehungsweise die Gesellschafterversammlung legt deren Befugnisse und Bezüge fest.

Art. 15. Für sämtliche nicht vorgesehenen Punkte gilt das Gesetz vom 18. September 1933 über die Gesellschaften

mit beschränkter Haftung, sowie das Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften und deren Abände-
rungen.

<i>Einzahlung des gesellschaftskapitals

Die ein hundert (100) Gesellschaftsanteile werden wie folgt eingezahlt:
- bis zum Belaufe des Betrages von ZWEI TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 2.500.-) mittels Bareinzahlung, so

dass der Betrag von ZWEI TAUSEND FÜNF HUNDERT EURO (€ 2.500.-) der Gesellschaft von heute an zur Verfügung
steht, wie dies dem unterzeichneten Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde;

- bis zum Belaufe des Betrages von ZEHN TAUSEND EURO (€ 10.000.-) mittels einer Sacheinlage bestehend in dem

Einbringen einer Rüttelmaschine Revers Dynapac der Marke Atals Copco lg500, Nummer 1d 81z sowie zwei Doppelboden
Sägemaschinen.

Der Wert dieser Sacheinlage geht aus einer Rechnung ausgestellt von der Gesellschaft BRUD-MONTAGE mit Sitz in

D-66663 Merzig, Hofgut Hockfels 1, vom 30. Mai 2014 hervor, welche Rechnung nachdem sie durch den Komparenten
und  dem  amtierenden  Notar  "ne  varietur"  paraphiert  worden  ist,  gegenwärtiger  Urkunde  beigebogen  bleibt  um  mit
derselben einregistriert zu werden.

Der Komparent bestätigt die Existenz sowie den Wert dieser Sacheinlage, und entbindet den amtierenden Notar

diesbezüglich jeder Verantwortung.

<i>Übergangsbestimmung

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gründung der Gesellschaft und endigt am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten, welche der Gesellschaft zum Anlass ihrer Gründung entstehen, werden abgeschätzt auf den Betrag von

ungefähr ein tausend Euro (€ 1.000.-).

<i>Erklärung

Der Komparent erklärt, dass der unterfertigte Notar ihm Kenntnis gegeben hat davon, dass die Gesellschaft erst nach

Erhalt der Handelsermächtigung ihre Aktivitäten aufnehmen kann.

<i>Generalversammlung

Sofort nach der Gründung, hat der alleinige Gesellschafter, folgende Beschlüsse gefasst:
a) Zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Stanislaw CHMURA, Trockenbauer, geboren in Gniewczyna Tryniecka (Polen), am 16. Januar 1977, wohnhaft in

D-66663 Merzig-Wellingen, Hofgut Hocksfels, 1A.

53123

L

U X E M B O U R G

b) Zum administrativen Geschäftsführer der Gesellschaft wird für eine unbestimmte Dauer ernannt:
Herr Jan RYBAK, Maurermeister, geboren in Otwock (Polen), am 27. Januar 1961 wohnhaft in L-5720 Aspelt, 13, um

Goldbierchen.

c) Die Gesellschaft wird wie folgt vertreten und verpflichtet:
- durch die alleinige Unterschrift des technischen Geschäftsführers;
- durch die alleinige Unterschrift des administrativen Geschäftsführers bis zu dem Betrag von zwei tausend fünf hundert

Euro (€ 2.500.-); darüber hinaus bedarf es der zusätzlichen Unterschrift des technischen Geschäftsführers.

d) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-5720 Aspelt, 13, um Goldbierchen.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat derselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: S. CHMURA, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 mars 2015. Relation: GAC/2015/2007. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 16. März 2015.

Référence de publication: 2015041877/124.
(150047863) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

WOF III Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 22.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.007.

EXTRAIT

En date du 13 March 2015, les associés de la Société ont approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de John D.McEvoy, en tant que gérant B de la Société, est constatée avec effet au 13 March 2015.
- Patrick J. Halloran, avec adresse professionnelle au 701 East Lake Street, Suite 300, Wayzata MN 55391, USA, est

élue nouveau gérant B de la Société avec effet au 13 March 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 13 March 2015.

Référence de publication: 2015042081/15.
(150047524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

OCM Luxembourg EPF III Railpool Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 195.339.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the tenth day of March.
Before us, Maître Danielle KOLBACH, notary in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée),

having its registered office at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and a share capital
of one million one hundred and twenty-seven thousand three hundred euro (EUR 1,127,300.-), registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 159.343;

here represented by Mr. Michael WIETZOREK, Lawyer, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

The appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to state as follows the

articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:

53124

L

U X E M B O U R G

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

“OCM Luxembourg EPF III Railpool Topco S.à r.l.” (hereafter the Company), which will be governed by the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies, as amended
(hereafter the Law), as well as by the present articles of association (hereafter the Articles).

Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It

may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the board of managers of the Company.
The registered office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a
resolution of the sole shareholder or the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad

by a resolution of the board of managers of the Company. Where the board of managers of the Company determines
that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these develop-
ments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may temporarily be transferred abroad
until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Company, which notwithstanding the temporary transfer of its registered office will remain a Luxem-
bourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire
by subscription, purchase, and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever. It may participate in the creation, development, manage-
ment and control of any company or enterprise. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

3.2. The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies  and/or  any  other  companies.  The  Company  may  also  give  guarantees  and  pledge,  transfer,  encumber  or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person.

3.3. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect

to real estate or movable property, which directly or indirectly favour or relate to its object.

Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, all
subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole

shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

53125

L

U X E M B O U R G

6.3. Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.
If the Company has more than one shareholder, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior

approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4. A shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions

of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5. The Company may redeem its own shares within the limits set forth by the Law.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1. The Company is managed by a board of managers of at least two members, appointed by a resolution of the sole

shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. The manager(s) need not be
shareholder(s).

7.2. The managers may be dismissed at any time ad nutum (without any reason).

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall

within the competence of the board of managers, which has all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.

8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders

or not, by the board of managers of the Company or by two managers acting jointly.

Art. 9. Procedure.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon request of any manager

at the place indicated in the convening notice.

9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the time set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3. No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present

or represented at the meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by a consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-
mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5. The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a sole document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

Art. 10. Representation. The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two

managers of the Company, or by the joint or sole signature(s) of any person(s) to whom such signatory power has been
validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of shareholders

Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1. The sole shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.
12.2. Each shareholder may participate in the collective decisions irrespective of the numbers of shares which he owns.

Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

53126

L

U X E M B O U R G

12.3. Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter,

telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

Art. 13. Form - Quorum - Majority.
13.1. If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by

circular resolution, the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram,
telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the
shareholders may appear on a sole document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by
letter or facsimile.

13.2. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of

the share capital.

13.3. However, resolutions to amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by

the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14. Accounting Year.
14.1. The accounting year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall end on the

thirty-first day of December

14.2. Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the board of managers must prepare

the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the
value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts
of the managers, the statutory auditor(s) (if any) and shareholders towards the Company.

14.3. Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15. Allocation of Profits.
15.1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses, represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is
allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share
capital.

15.2. The general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus. It may in particular

allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

15.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers of the Company;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being

understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year,
increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be
allocated to the statutory reserve;

(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders of

the Company;

(iv) assurance has been obtained that the rights of the creditors of the Company are not threatened.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who  do  not  need  to  be  shareholders,  appointed  by  a  resolution  of  the  sole  shareholder  or  the  general  meeting  of
shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of
the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be vested with the broadest powers for the realisation of the assets
and payments of the liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the shareholder or, in case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by
each shareholder in the Company.

VI. General provision

17. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these

Articles.

<i>Transitory provision:

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31 

st

 , 2015.

53127

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription - Payment:

Thereupon, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prenamed and represented as stated above, declared to subscribe to

twelve thousand five hundred (12,500) shares in registered form with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and
to fully pay them up by way of a contribution in cash amounting to twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-).

The amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) is at the disposal of the Company, as has been

proven to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

<i>Resolutions of the sole shareholder

The sole shareholder, represented as aforesaid and representing the entirety of the subscribed share capital, has passed

the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr Jabir CHAKIB, born on November 5, 1967 in Casablanca, Morocco, residing professionally at 26A, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Hugo NEUMAN, born on October 21, 1960 in Amsterdam, the Netherlands, residing at 16, rue J.B. Fresez, L-1724

Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and

- Mr Justin BICKLE, born on January 11, 1971 in Plymouth, United Kingdom, residing professionally at 27 Knightsbridge,

London SW1X 7LY, United Kingdom.

2. The registered office of the Company is set at 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French version, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the notary the present

deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix mars,
Par-devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social d’un million cent vingt-
sept mille trois cents euros (EUR 1.127.300,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 159.343;

ici représentée par Monsieur Michael WIETZOREK, Avocat, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire

instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d’une

société à responsabilité limitée dont il a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «OCM Luxembourg

EPF III Railpool Topco S.à r.l.» (ci-après la Société), qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en
particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la Loi) et par les
présents statuts (ci-après les Statuts).

Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Il peut être transféré en tout autre
endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés
délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé par décision du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de

Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique

53128

L

U X E M B O U R G

ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre l'activité
normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra
être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures
provisoires n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La Société a pour objet la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou

entreprises sous quelque forme que ce soit et la gestion de ces sociétés ou entreprises ou participations. La Société
pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres
valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette et en général toutes
valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle pourra participer dans la création, le
développement, la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise. Elle pourra en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit.

3.2 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres représentatifs
d'emprunts et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des
emprunts et/ou des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société. La
Société pourra aussi donner des garanties et nantir, transférer, grever, ou créer de toute autre manière et accorder des
sûretés sur toutes ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et
engagements de toute autre société, et, de manière générale, en sa faveur et/ou en faveur de toute autre société ou
personne.

3.3 La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les créanciers, fluctua-
tions monétaires, fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

3.4 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, financières ou industrielles, ainsi que toutes trans-

actions  se  rapportant  à  la  propriété  immobilière  ou  mobilière,  qui  directement  ou  indirectement  favorisent  ou  se
rapportent à la réalisation de son objet social.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500 EUR), représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) chacune, toutes
souscrites et entièrement libérées.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale

est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3. Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il

pourra être consulté par chaque associé.

6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales dans les limites et aux conditions prévues par la

Loi.

53129

L

U X E M B O U R G

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'au moins deux membres qui seront nommés par réso-

lution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés, lequel/laquelle fixera la durée de leur mandat. Le(s)
gérant(s) ne sont pas nécessairement associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables n'importe quand ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opé-
rations conformes à l'objet social de la Société.

8.2. Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents,

associés ou non, par le conseil de gérance de la Société ou par deux gérants agissant conjointement.

Art. 9. Procédure.
9.1. Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des

gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2. Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3. La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du conseil de gérance de

la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de
son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque membre du conseil de gérance de
la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4. Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5. Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou

représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu'à la majorité des voix. Les procès-verbaux
des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6. Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7. Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

Art. 10. Représentation. La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la signature conjointe

de deux gérants de la Société, ou, le cas échéant, par la/les signature(s) individuelle(s) ou conjointe(s) de toutes personnes
à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11. Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée générale des associés

Art. 12. Pouvoirs - Droits de vote.
12.1. L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartient.

Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

12.3. Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1. Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être

prises par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme,
télex, téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signa-
tures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par
lettre ou téléfax.

13.2. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

53130

L

U X E M B O U R G

13.3. Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1. L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre.
14.2. Chaque année, à la fin de l'exercice social de la Société, le conseil de gérance doit préparer le bilan et les comptes

de profits et pertes de la Société, ainsi qu'un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société,
avec une annexe résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérants, commissaire(s) aux comptes (si
tel est le cas), et associés envers la Société.

14.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2. L'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net

annuel. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

15.3. Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
(i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le conseil de gérance de la Société;
(ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution,

étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer
à la réserve légale;

(iii) la décision de payer les dividendes intérimaires est prise par l'associé unique ou l'assemblée générale des associés

de la Société;

(iv) le paiement est fait dès lors qu'il est établi que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés.

VI. Dissolution - Liquidation

16.1. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

16.2. Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VI. Disposition générale

17. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire:

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération:

Ces faits exposés, OCM Luxembourg EPF III S.à r.l., prénommée et représentée comme décrit ci-dessus, déclare

souscrire à douze mille cinq cents (12.500) parts sociales sous forme nominative avec une valeur nominale d’un euro (1
EUR) chacune, et les libérer entièrement par versement en espèces de douze mille cinq cents euros (12.500 EUR).

La somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au

notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille deux cents euros (1.200,-
EUR).

<i>Résolutions de l’associé unique:

L’associé unique, représenté comme ci-avant et représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions sui-

vantes:

1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:

53131

L

U X E M B O U R G

- M. Jabir CHAKIB, né le 5 novembre 1967 à Casablanca, Maroc, ayant son adresse professionnelle au 26A, boulevard

Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. Hugo NEUMAN, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam, Pays-Bas, demeurant au 16, rue J.B. Fresez, L-1724 Lu-

xembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et

- M. Justin BICKLE, né le 11 janvier 1971 à Plymouth, Royaume-Uni, résidant professionnellement au 27 Knightsbridge,

Londres SW1X 7LY, Royaume-Uni.

2. Le siège social de la Société est établi au 26A, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. WIETZOREK, D. KOLBACH.
Enregistré à Diekirch A.C., le 12 mars 2015. Relation: DAC/2015/4194. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Jeannot THOLL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 16 mars 2015.

Référence de publication: 2015041853/415.
(150047839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.

NN Investment Partners Luxembourg S.A., Société Anonyme,

(anc. ING Investment Management Luxembourg S.A.).

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 98.977.

In the year two thousand fifteen, on the thirteenth day of February,
Before Maître Marc Lecuit, notary residing in Mersch, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître

Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, to whom the present deed will remain,

was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “ING Investment Management Luxembourg S.A.”, a société

anonyme with registered office in L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, (the "Company"),

incorporated following a deed of the undersigned notary on 4 February 2004, published in the Mémorial C number

224 on 25 February 2004, registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg, section B number 98977,
and whose articles of incorporation have been amended pursuant to a notarial deed on May 26 

th

 , 2014, published in

the Mémorial C number 1541 on June 16 

th

 , 2014.

The meeting is presided by Mr Federico D'Ascanio, private employee, with professional address in Luxembourg, who

appointed as secretary Mrs Elise Valentine, private employee, with professional address in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Mathieu Thiry, private employee, with professional address in Luxembourg.
The Board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record

the following statements and declarations:

(i) That the agenda of the Meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Change of the Company's name from “ING Investment Management Luxembourg S.A.” to “NN Investment Partners

Luxembourg S.A.” with effect from 7 April 2015;

2. Amendment to article 1 of the articles of association of the Company (the “Articles”) to reflect its new name with

effect from 7 April 2015;

3. Amendment to article 3 of the Articles with effect from 7 April 2015 so as to clarify that, within the scope of the

activity consisting in UCITS administration, in addition to the pricing of units and the maintenance of the unitholder
register, also the pricing of shares and the maintenance of the shareholder register shall be included;

4. Miscellaneous.
(ii) That the sole shareholder represented, the proxy holder of the represented sole shareholder and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxy holder of the represented sole
shareholder, the proxy of the represented sole shareholder and by the Board of the Meeting, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

53132

L

U X E M B O U R G

(iii) That the proxy of the represented sole shareholder, initialled "ne varietur" by the proxy holder of the represented

sole shareholder, the Board of the Meeting and by the notary, will also remain annexed to the present deed.

(iv) It results from the attendance list that the whole corporate capital is represented at the present Meeting.
(v) That the present Meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the General Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions

<i>First resolution:

The General Meeting resolves to change the name of the Company from “ING Investment Management Luxembourg

S.A.” to “NN Investment Partners Luxembourg S.A.”, with effect from 7 April 2015.

<i>Second resolution:

Further to the foregoing resolution, the General Meeting resolves to amend, with effect from 7 April 2015, article 1

of the Articles in order to read as follows:

“There is hereby incorporated by the parties appearing and all those who might later become shareholders a company

(the “Company”) in the form of a public limited company organised in accordance with the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and the present articles of association. The Company bears the name of NN Investment Partners Luxem-
bourg S.A.”

<i>Third resolution:

The General Meeting resolves to amend, with effect from 7 April 2015, article 3 of the Articles as follows:
“The corporate object of the Company shall be the collective management of a portfolio of Luxembourg and/or foreign

Undertakings  for  Collective  Investment  in  Transferable  Securities  (UCITS)  approved  in  accordance  with  Directive
2009/65/EC as amended, the administration of its own assets only being of an ancillary nature.

In particular, the activities of collective management of a portfolio of UCITS shall include:
- portfolio management: in this regard, the Company may, on behalf of the UCITS under management, give any opinion

or recommendations as to the investments to be made, conclude contracts, purchase, sell, exchange and deliver any
transferable securities and any other assets, on behalf of the UCITS under management, exercise any voting rights attached
to the transferable securities constituting the assets of the UCITS, this list not being exhaustive but indicative;

- UCITS administration: this consists of all the tasks listed in Appendix II of the Law of 17 December 2010 relating to

Undertakings for Collective Investment, in particular including the legal and fund management accounting services, cus-
tomer enquiries, valuation of the portfolio and pricing of the units/shares (including tax returns), regulatory compliance
monitoring, maintenance of unit-/shareholder register, distribution of income, unit/share issue and repurchase, contract
settlements (including certificate dispatch) and record keeping;

- the marketing in Luxembourg and/or abroad of the shares and/or units of the UCITS.
The corporate object of the Company shall also be the management of other Luxembourg and/or foreign Alternative

Investment Funds (AIFs) approved in accordance with Directive 2011/61/EU as amended.

In particular, it must perform the following activities when managing an AIF, listed in Annex I of the Law of 12 July

2013:

- At least investment management functions which include portfolio management and risk management;
- Additionally, other functions in the course of the collective management of an AIF as follows:
* Administration: this consists in legal and fund management accounting services, customer enquiries, valuation and

pricing (including tax returns), regulatory compliance monitoring, maintenance of unit-/shareholder register, distribution
of income, unit/ share issues and redemptions, contract settlements (including certificate dispatch) and record keeping;

* Marketing;
* Activities related to the assets of the AIFs: namely services necessary to meet the fiduciary duties of the AIFM,

facilities management, real estate administration activities, advice to undertakings on capital structure, industrial strategy
and related matters, advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings and other services con-
nected to the management of the AIF and the companies and other assets in which it has invested.

The Company may carry on all the activities considered useful to accomplishing its corporate objects nonetheless

observing the provisions of the Law of 10 August 1915 relating to commercial companies as amended and Chapter 15 of
the Law of 17 December 2010 relating to Undertakings for Collective Investment and Chapter 2 the Law of 12 July 2013
relating to Alternative Investment Fund Managers.”

Whereas, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English.

The deed having been read to the appearing persons, who are known by the notary by their surname, first name, civil

status and residence, the said persons signed together with the notary, this original deed.

53133

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le treize février,
Par devant Maître Marc Lecuit, notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement

de Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, qui restera dépositaire de
la présente minute.

A été tenue

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de «ING Investment Management Luxembourg S.A.», une so-

ciété anonyme ayant son siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret (la «Société»),

Constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 4 février 2004, publié au Mémorial C sous le

numéro 224 du 25 février 2004, inscrite au Registre de commerce et des Sociétés à Luxembourg sous la section B, numéro
98977, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte notarié en date du 26 mai 2014, publié au Mémorial C sous le
numéro 1541 du 16 juin 2014.

L'Assemblée Générale Extraordinaire est ouverte sous la présidence de, Monsieur Federico D'Ascanio, employé privé,

demeurant professionnellement au Luxembourg, qui désigne Madame Elise Valentin, employée privée, demeurant pro-
fessionnellement au Luxembourg comme secrétaire.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Mathieu Thiry, employé privé, demeurant professionnellement au

Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
i. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Changement du nom de la Société de «ING Investment Management Luxembourg S.A.» en «NN Investment Partners

Luxembourg S.A.» à compter du 7 avril 2015;

2. Modification en conséquence de l'article 1 des statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter le nouveau nom

à compter du 7 avril 2015;

3. Modification de l'article 3 des Statuts, à compter du 7 avril 2015, afin de clarifier que l'activité d'administration des

UCITS, outre à la détermination des prix des parts et la tenue du registre des porteurs de parts, devrait inclure également
la détermination des prix des actions et la tenue du registre des actionnaires

4. Divers.
ii. L'actionnaire unique représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté et le nombre d'actions qu'il détient,

sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée "ne varietur" par l'actionnaire unique représenté et la mandataire
de l'actionnaire unique représenté, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire, restera an-
nexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

iii. La procuration de l'actionnaire unique représenté, signée "ne varietur" par le mandataire de l'actionnaire unique

représenté, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera aussi annexée au présent acte.

iv. Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est représentée à la présente assemblée générale

extraordinaire.

v. La présente Assemblée est constituée régulièrement et peut valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée Générale, après délibération, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de changer le nom de la Société de «ING Investment Management Luxembourg S.A.»

en «NN Investment Partners Luxembourg S.A.» à compter du 7 avril 2015.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution précédente, L'Assemblée Générale décide de modifier, à compter du 7 avril 2015, l'article 1 des

Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

«Il est formé par les présentes par les comparants et tous ceux qui pourraient devenir actionnaires par la suite une

société (la «Société») ayant la forme d'une société anonyme organisée d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg
et les présents statuts. La Société porte le nom de «NN Investment Partners Luxembourg S.A.».

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de modifier, à compter du 7 avril 2015, l'article 3 des Statuts afin de lui donner la teneur

suivante:

«L'objet social de la Société de gestion concerne la gestion collective d'un portefeuille de UCITS luxembourgeois et/

ou étrangers agréés conformément à la Directive 2009/65/CE, telle que modifiée, l'administration de ses propres actifs
n'ayant qu'un caractère accessoire. Les activités de gestion collective d'un portefeuille de UCITS incluent notamment:

53134

L

U X E M B O U R G

- gestion de portefeuille: à ce titre, la Société de gestion peut, pour le compte des UCITS sous gestion, donner tout

avis  ou  recommandation  quant  aux  investissements  à  effectuer,  conclure  des  contrats,  acheter,  vendre,  échanger  et
délivrer  toutes  valeurs  mobilières  et  tous  autres  actifs,  exercer  tous  droits  de  vote  attachés  aux  valeurs  mobilières
constituant les avoirs des UCITS (liste indicative non exhaustive);

- administration des UCITS: toutes les tâches énumérées à l'Annexe II de la Loi du 17 décembre 2010 relative aux

organismes de placement collectif, y compris les services juridiques et comptables liés à la gestion de fonds, les questions
des clients, l'évaluation du portefeuille et la détermination des prix des parts/d'actions (y compris la déclaration de re-
venus), le contrôle de la conformité, la tenue du registre des porteurs de parts/actionnaires, la distribution des revenus,
l'émission et le rachat de parts/d'actions, le règlement des contrats (y compris l'envoi de certificats) et la tenue des livres
comptables;

- commercialisation au Luxembourg et/ou à l'étranger des actions et/ou parts des «UCITS.»
L'objet social de la Société concerne la gestion d'autres Fonds d'investissement alternatifs (FIAs) luxembourgeois et/

ou étrangers agréés conformément à la Directive 2011/61/CE, telle que modifiée.

Il doit notamment exercer les activités suivantes dans le cadre de la gestion d'un FIA, figurant à l'Annexe I de la Loi du

12 juillet 2013:

- fonctions de gestion d'investissement, qui incluent la gestion de portefeuille et du risque;
- autres fonctions dans le cadre de la gestion collective d'un FIA:
* administration: services juridiques et comptables liés à la gestion du fonds, questions des clients, évaluation et prix

(y compris déclaration de revenus), contrôle de conformité, tenue du registre des porteurs de parts/actionnaires, distri-
bution des revenus, émission et rachat de parts/d'actions, règlement des contrats (y compris envoi de certificats) et tenue
des livres comptables;

* commercialisation;
* activités liées aux actifs des FIA: services nécessaires pour remplir les obligations fiduciaires de l'AIFM, gestion des

installations, administration des biens immobiliers, conseils aux organismes en matière de structure du capital, stratégie
sectorielle et thèmes connexes, conseils et services liés aux fusions et à l'achat d'organismes, et autres services relatifs à
la gestion du FIA et des sociétés et autres actifs dans lesquels il a investi.

La Société pourra exercer toutes les activités estimées utiles à l'accomplissement de son objet social en respectant

toutefois les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, du Chapitre
15 de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organismes de Placement Collectif et du Chapitre 2 de la loi du 12 juillet
2013 relative aux Gérants de fonds d'investissement alternatifs.»

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le comparant l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms, états

et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: F. D'ASCANIO, E. VALENTIN, M. THIRY, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 18 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5195. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015041059/187.
(150046801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.

Agripartes S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 67.994.

Les statuts coordonnés au 29 janvier 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015040146/11.
(150046103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

53135

L

U X E M B O U R G

Fluxinvest International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 125.467.

L'an deux mille quinze, le vingt-sept février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-

mination de "FLUXINVEST INTERNATIONAL S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 125467, ayant son
siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence
à Junglinster, en date du 7 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 967 du 24 mai
2007.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michaël ZIANVENI, juriste, domicilié professionnellement au

18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, domiciliée profession-

nellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, domicilié professionnellement au 74,

avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les trois cent dix (310)

actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.

Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-

verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.

II.- Que l'ordre du jour de la présente Assemblée est conçu comme suit:
1. Dissolution de la société et mise en liquidation.
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
3. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Monsieur le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-

tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation.

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale nomme aux fonctions de liquidateur, pour la durée de la liquidation, la société LISOLUX S.à r.l.,

inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 117503, ayant son siège social au 18, rue de l’Eau, L-1449 Luxembourg,
qui aura les pouvoirs les plus étendus pour réaliser la liquidation, y compris ceux de réaliser les opérations prévues à
l’article 145 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'Assemblée s'est terminée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Zianveni, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 mars 2015. 2LAC/2015/4730. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur (signé): Paul Molling.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015039723/51.
(150045550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

53136


Document Outline

Agripartes S.A.

CeDerLux-Services S.à r.l.

Fluxinvest International S.A.

Heavyland S. à r.l.

HGHI Luxembourg S.A.

Horest, S.à r.l.

Horest, S.à r.l.

H.T.S.B., Handel-Transport und Schiffahrt Benelux A.G.

ING Investment Management Luxembourg S.A.

Kandira S.A.

Kemon S.A.

KG Far East (Luxembourg) Sàrl

KG Participações S.à r.l.

K.M.K. Agroinvestment S.A.

Korero SCI

Lazada Group S.A.

LBREM Europe S.à r.l.

LBREM Luxco S.à r.l.

Leisure Holding S.A.

Le Regent

Luna Management

Luxembourg Investment Company 41 S.à r.l.

Luxembourg Investment Company 8 S.à r.l.

Marge S.A.

MC Seahome S.A.

Metano Capital S.A

Mika S.à.r.l.

Mirotech S.à.r.l.

Modim International S.A.

Morning Bay S.A.

Nemesia Luxembourg S.à r.l.

Nimulux S.A.

NN Investment Partners Luxembourg S.A.

OCM Luxembourg EPF III Railpool Topco S.à r.l.

Orsay-Re

Palvord Financing S.A.

Parabau S.à r.l.

Park Luxco 3 S.C.A.

Procastora Holding S.à r.l.

Reckitt Benckiser Investments (N°6), S.à r.l.

Simauchan Development S.A. SPF

Um Gringert III S.A.

WOF III Holding S.à r.l.