This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1093
27 avril 2015
SOMMAIRE
Acres Financial, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52436
Advent Energy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52450
AGS Invest S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52426
Altaïr Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52418
Aquila Capital European Hydropower
Fund S.A., SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . .
52451
Arm Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52418
Banyal Aragorn Investments S.A. . . . . . . . .
52418
Brico Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52418
CaCh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52428
Capula ESS Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52438
Esso Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52441
Key Note S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52429
La Cité Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
Le Cigare S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
Malake S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52464
Managua Holdings S.A. SPF . . . . . . . . . . . . .
52419
MCI Prop Co. B S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
MCI Prop Co. C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
Melga Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52428
MH Germany Property VI S.à r.l. . . . . . . . .
52419
Monterey Capital I Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
52418
Naudin S.A. Spf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52419
Phebus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52423
Pizzeria El Barbaro S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52422
Radwan Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
52429
RCSL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52423
Romanico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
R.P. Real Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
52420
Savin Hill Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
52421
SE Investmentfund-FIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
52421
Skandia Life S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52422
Société Européenne pour la Restructura-
tion et l'Ingénierie de l'Entreprise S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52428
SPUERKEESS Ré S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52422
STAEDEL HANSEATIC Luxembourg S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
Stratego Managing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
52425
Strateteq International S.A. . . . . . . . . . . . . .
52424
SWM South . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
TCN Holding (Luxembourg) S.à.r.l. . . . . . .
52425
Tech-It PSF SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52424
Tevennec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52421
Top Patrimoine S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . .
52425
Treveria G S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52425
TriCap Administration (Luxembourg) S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52423
52417
L
U X E M B O U R G
Monterey Capital I Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 75.050,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 90.246.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041779/9.
(150047939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Banyal Aragorn Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 102.341.
Le Bilan au 31.12.2013 (à titre informatif) a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015041410/10.
(150047669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Brico Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9964 Huldange, 3, Op d'Schmëtt.
R.C.S. Luxembourg B 116.085.
Les comptes annuels au 31 janvier 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015041397/10.
(150047409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Altaïr Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 169.795.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Domiciliatairei>
Référence de publication: 2015041376/11.
(150047239) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Arm Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 142.978.
EXTRAIT
La Société prend acte du changement d'adresse de Monsieur Nicolas TODT, administrateur A et président du conseil
d'administration comme suit:
- 9, rue des Alpes CH-1201 Genève.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 mars 2015.
Référence de publication: 2015041383/14.
(150047212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52418
L
U X E M B O U R G
MH Germany Property VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 118.849.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041808/9.
(150047285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
MCI Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 162.990.
<i>Rectificatif du dépôt L140126586 déposé le 21 juillet 2014i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041796/10.
(150047902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
MCI Prop Co. B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 163.468.
<i>Rectificatif du dépôt L120135240 déposé le 1 i>
<i>eri>
<i> août 2012i>
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041795/10.
(150047907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Naudin S.A. Spf, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 161.854.
Par la présente, il est signalé que Luxfiducia S.à r.l., établie au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg et inscrite au
R.C.S. sous le numéro B 71529, a été nommée dépositaire des actions au porteur et du registre des actions au porteur
de la société Naudin S.A. Spf, inscrite au R.C.S. sous le numéro B 161854 et dont le siège social est au 20 avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041825/12.
(150048176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Managua Holdings S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 183.524.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015041786/13.
(150047764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52419
L
U X E M B O U R G
R.P. Real Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 72.511.
Par la présente, il est signalé que Luxfiducia S.à r.l., établie au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg et inscrite au
R.C.S. sous le numéro B 71529, a été nommée dépositaire des actions au porteur et du registre des actions au porteur
de la société R.P. REAL PROPERTIES S.A., inscrite au R.C.S. sous le numéro B 72511 et dont le siège social est au 20
avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041913/12.
(150048175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Romanico, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1122 Luxembourg, 2, rue d'Alsace.
R.C.S. Luxembourg B 158.359.
Veuillez prendre note de ma démission du conseil de gérance de Romanico Sàrl comme gérant avec effet au 13 février
2015.
Alberto Vivanti
Steinbockstrasse 8
CH7000 Chur
Switzerland
Référence de publication: 2015041918/13.
(150047455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
La Cité Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2561 Luxembourg, 97, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 76.421.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Franck BADEN, notaire de résidence à L-LUXEMBOURG, en date du 13
juin 2000, acte publié au Mémorial, Recueil Spécial C n° 767 du 19 octobre 2000.
Il résulte d'une lettre émise en date du 1
er
mars 2015 que Madame Mariette KNAUFLANGSAM démissionne de son
mandat de gérant de la société à compter du 31 mars 2015.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
<i>Pour la société LA CITE Sàrl
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015041746/14.
(150047636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Le Cigare S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3730 Rumelange, 34, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 25.737.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement n°1030/14 rendu en date du 2 octobre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième
chambre, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes, pour absence d'actif, les opérations de liquidation de la
société à responsabilité limitée LE CIGARE S.àr.l. avec siège social à L-3730 Rumelange, 34, Grand-Rue, de fait inconnue
à cette adresse.
Pour extrait conforme
Maître Admir PUCURICA
<i>Avocat / Le Liquidateuri>
Référence de publication: 2015041747/15.
(150047574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52420
L
U X E M B O U R G
Savin Hill Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 20, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 134.228.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Manacor (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2015041964/14.
(150048077) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Tevennec, Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 132.413.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 mars 2015i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée a décidé de révoquer avec effet immédiat M. Claude Zimmer de son mandat d'administrateur.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouvel administrateur:
- M. Alexander Villaverde Zweegers, demeurant à Hoeven 1, B-2275 Lille-Poederlee.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015041291/16.
(150046532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
SE Investmentfund-FIS, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investisse-
ment Spécialisé.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 133.298.
<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung die am 12. März 2015 stattfand:i>
1. Die Generalversammlung beschließt, die folgenden Personen bis zur nächsten Generalversammlung, die über den
Jahresabschluss der SE Investmentfund - FIS für das am 30. September 2015 endende Geschäftsjahr abstimmt, wieder zum
Verwaltungsrat zu ernennen:
- Stefan Schneider (Verwaltungsratsvorsitzender), geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
- Achim Welschoff (Verwaltungsratsmitglied), geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
- Jean-Marie Schomer (Verwaltungsratsmitglied), geschäftsansässig in 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
2. Die Generalversammlung beschließt, den Abschlussprüfer, KPMG Luxembourg, Société coopérative, 39, Avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, wieder zum Abschlussprüfer der SE Investmentfund - FIS bis zur nächsten Gene-
ralversammlung, die über den Jahresabschluss der SE Investmentfund - FIS für das am 30. September 2015 endende
Geschäftsjahr abstimmt, zu bestellen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 13. März 2015.
<i>Für SE Investmentfund - FIS
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2015041969/24.
(150047402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52421
L
U X E M B O U R G
Pizzeria El Barbaro S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 151.489.
Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
i>Signature
Référence de publication: 2015041897/13.
(150048071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
SPUERKEESS Ré S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2954 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 164.465.
Le bilan au 31 DECEMBRE 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015041998/10.
(150047374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Skandia Life S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 18-20, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 160.699.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 2 février 2015i>
L'actionnaire unique de la Société décide:
- d'accepter la démission de Monsieur Vincent VERCOUSTRE de son mandat d'administrateur de la Société avec effet
au 2 février 2015;
- d'accepter la démission de Monsieur Thierry MADINIER de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au
2 février 2015;
- d'accepter la démission de Monsieur Steven LEVIN de son mandat d'administrateur de la Société avec effet au 2
février 2015;
- de nommer Monsieur Philippe Olivier BARRET, administrateur, né le 9 janvier 1965 à Rive-de-Gier, demeurant à 23,
avenue du Maréchal Foch, 69006 Lyon, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat
viendra à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2021,
- de nommer Monsieur Renaud Jean-Michel CELIE, administrateur, né le 8 octobre 1967 à Besançon, demeurant à 12,
rue de l'Echiquier, 75010 Paris, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat viendra
à échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2021;
- de nommer Monsieur Alain Pierre Joseph ESQUIROL, administrateur, né le 24 novembre 1956 à Lyon, demeurant
à 15, rue Louise, 69003 Lyon, France, en tant qu'administrateur de la Société avec effet immédiat, son mandat viendra à
échéance lors de l'assemblée générale de l'an 2021;
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Philippe Olivier BARRET, administrateur;
- Monsieur Renaud Jean-Michel CELIE, administrateur; et
- Monsieur Alain Pierre Joseph ESQUIROL, administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Skandia Life S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015041940/31.
(150047508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52422
L
U X E M B O U R G
TriCap Administration (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 130.096.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 28 janvier 2015i>
- L'assemblée générale décide de révoquer le commissaire Monsieur Jérôme Domange
- L'assemblée générale nomme en tant que commissaire la société FOP Conseil S.A., avec siège social à L-8080 Ber-
trange, 1, rue Pletzer, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 186.074.
Le mandat du commissaire prend fin le 30 septembre 2015.
Extrait sincère et conforme
TRICAP ADMINISTRATION (Luxembourg) S.A.
5, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
<i>Le mandatairei>
Référence de publication: 2015042016/17.
(150048029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
RCSL, Groupement d'Intérêt Economique.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 13, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg C 24.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des membres tenue à Luxembourg le 5 mars 2015i>
<i>Résolution uniquei>
L'assemblée nomme Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller économique, avec adresse professionnelle au 13, rue
Erasme, L-1468 Luxembourg, comme membre du conseil de gérance en remplacement de M. Nicolas WEYDERT, dé-
missionnaire, dont elle terminera le mandat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 mars 2015.
Pour extrait conforme
RCSL g.i.e.
Steve BREIER
<i>Vice-Président du Conseil de Gérancei>
Référence de publication: 2015041923/18.
(150048120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Phebus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5612 Mondorf-les-Bains, 145, avenue François Clément.
R.C.S. Luxembourg B 185.574.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Phebus S.A. tenue au siège de la société en date dui>
<i>18 février 2015i>
Tous les actionnaires étant présents.
Les administrateurs décident:
- de nommer en qualité de dépositaire professionnel en charge de la tenue du registre des actions, la société AD
CORPORATE SERVICES SARL, immatriculée au RCSL sous le numéro B 79361, dont le siège social se situe au 165A,
Route de Longwy à L-4751 PETANGE.
La décision a été prise à l'unanimité.
Après cela, l'assemblée générale extraordinaire est déclarée comme terminée.
Signé en nom de PHEBUS S.A.
Thierry MACHOLT
<i>Administrateur Déléguéi>
Référence de publication: 2015041890/19.
(150047816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52423
L
U X E M B O U R G
Strateteq International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 44.030.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015042005/9.
(150047789) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
STAEDEL HANSEATIC Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 150.730.
Par la présente, la société TONUS & CUNHA ASSOCIES SARL, 61 route de Longwy L-8080 Bertrange (ancienne
adresse: 38 Arelerstrooss, L-8552 Oberpallen), immatriculé au RCSL B139158, démissionne en date du 21/01/2015 de
son poste de commissaire aux comptes de la Société.
Fait à Senningerberg, le 21/01/2015.
Référence de publication: 2015042001/11.
(150048076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Tech-It PSF SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1524 Luxembourg, 14, rue Michel Flammang.
R.C.S. Luxembourg B 125.205.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 25 février 2015, que:
Suivant arrêt de la cour d'appel de Metz du 17 décembre 2013, à compter de cette date, Monsieur Freddy KADDOUR,
se prénomme désormais Hamid.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015042025/13.
(150047153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
SWM South, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.543.250,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 191.852.
Il résulte de la résolution écrite de l'associé unique de la Société en date du 12 mars 2015 que Monsieur Patrick Moinet
a démissionné son poste de gérant de type B de la Société avec effet au 6 février 2015.
Il est décidé de nommer Madame Caroline Goergen, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique et résidant profession-
nellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg comme nouvelle gérante de type B de la Société avec effet au 6
février 2015 pour une durée indéterminée.
Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Ashish Advani, comme gérant de type A de la Société;
- John Blasko, comme gérant de type A de la Société;
- Roberta Masson, comme gérante de type B de la Société; et
- Caroline Goergen, comme gérante de type B de la Société.
Le 13 mars 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015042007/21.
(150047238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52424
L
U X E M B O U R G
Treveria G S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 250.000,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 116.356.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015042014/10.
(150047353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Stratego Managing S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12D, Impasse Drosbach.
R.C.S. Luxembourg B 165.077.
Le Bilan au 31 DECEMBRE 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015042004/10.
(150047586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
TCN Holding (Luxembourg) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.000,00.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 17, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 75.099.
Il est à noter que l'adresse de l'associé unique de la Société, Tyco Global Networks Ltd. est désormais la suivante: 7
Church Street, Dorchester House, Hamilton, HM 11, Bermudes.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
TCN Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015042023/14.
(150047806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Top Patrimoine S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 155.978.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle, tenue de manière extraordinaire à la date du 06.03.2015
à 10 heures, que les actionnaires ont:
1. Décidé de révoquer la société à responsabilité limitée "Capital Immo Luxembourg", établie et ayant son siège social
à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 93635, de ses fonctions de commissaire aux comptes.
2. Décidé de nommer comme nouveau commissaire aux comptes la société Fiduciaire Comptable Vogel & Monteiro
S.àr.l., RCSL 112.699, avec siège social au 91, rue Cents, L-1319 Luxembourg. Le nouveau Commissaire aux Comptes
terminera le mandat de son prédécesseur et ceci jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06.03.2015.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015042035/20.
(150047973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52425
L
U X E M B O U R G
AGS Invest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 193.828.
IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN, ON THE THIRD DAY OF THE MONTH OF FEBRUARY,
Before Us Me Cosita DELVAUX, duly appointed notary in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
Mr Xavier MANGIULLO, employee in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
acting as special proxyholder of the board of directors of the company AGS INVEST S.A. SPF, a société de gestion de
patrimoine familial organized in a form of a société anonyme, having its registered office in L- 1420 Luxemburg, 5, avenue
Gaston Diderich, in process of registration with the Luxembourg Trade and Companies Register, (the “Company”),
by virtue of a resolution of the board of directors adopted on 2 February 2015, a copy of which, signed "ne varietur"
by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed.
Said appearing person, acting in the above stated capacity, asked the notary to document the following of his statements:
I.- That the Company was incorporated on 22 December 2014 by deed of the undersigned notary, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, with an entirely paid up share capital of CHF 40,000.00 (forty
thousand Swiss franc) divided into 40,000 (forty thousand) shares with a nominal value of CHF 1.00 (one Swiss franc)
each;
II.- That article 5 (five), paragraphs 8 (eight) to 13 (thirteen) of the Articles of Incorporation, state that:
"For the period foreseen here below, the authorized capital is fixed at CHF 2,000,000.00 (two million Swiss franc) to
be divided into 2,000,000 (two million) shares with a nominal value of CHF 1.00 (one Swiss franc) each.
The authorized and the subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general
meeting of shareholders voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.
Furthermore, the board of directors is authorized, from the date of incorporation and during a period ending on 22
December 2019, to increase in one or several times the subscribed capital, within the limits of the authorized capital.
Such increased amount of capital may be subscribed for and issued in the form of shares with or without an issue premium,
to be paid-up in cash, by contribution in kind, by compensation with uncontested, current and immediately exercisable
claims against the company, or even by incorporation of profits brought forward, of available reserves or issue premiums,
or by conversion of bonds as mentioned below.
The board of directors is especially authorized to proceed to such issues without reserving to the then existing
shareholders a preferential right to subscribe to the shares to be issued.
The board of directors may delegate to any duly authorized director or officer of the company, or to any other duly
authorized person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for shares representing part or all of such
increased amounts of capital.
After each increase of the subscribed capital performed in the legally required form by the board of directors, the
present article is, as a consequence, to be adjusted to this amendment.”;
III.- That the board of directors, in its meeting of 2
nd
February 2015, has decided to proceed to an increase of the
share capital by CHF 460,000.00 (four hundred sixty thousand Swiss franc) in order to bring it from its current amount
of 40,000.00 (forty thousand Swiss franc) to 500,000.00 (five hundred thousand Swiss franc) by the issue of 460,000 (four
hundred sixty thousand) new shares with a nominal value of CHF 1.00 (one Swiss franc), vested with the same rights and
advantages as the existing shares;
IV.- That the board of directors has admitted to the subscription of the 460,000 (four hundred sixty thousand) new
shares the existing sole shareholder of the Company;
V.- That the capital increase has been entirely paid up by the above named subscriber by contribution in cash wired
to the bank account open in the name of the Company, so that the amount of CHF 460,000.00 (four hundred sixty
thousand Swiss franc) was at the free disposal of the Company and the proof of the subscription and payment have been
submitted to the undersigned notary;
VI.- That as a consequence of this capital increase, the first paragraph of article 5 (five) of the Articles of Incorporation
of the Company is amended and will henceforth read as follows:
“ Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at CHF 500,000.00 (five hundred thousand Swiss franc) divided
into 500,000 (five hundred thousand) shares with a nominal value of CHF 1.00 (one Swiss franc) each.”.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are
estimated at two thousand four hundred Euro (EUR 2,400.-).
52426
L
U X E M B O U R G
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date named at the beginning of this
document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by her surname, first name, civil status
and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'AN DEUX MIL QUINZE, LE TROIS FEVRIER,
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A COMPARU:
Monsieur Xavier MANGIULLO, employé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire spécial du conseil d'administration de la société AGS INVEST S.A. SPF, une société
de gestion de patrimoine familial organisée sous forme d'une société anonyme, ayant son siège social à L-1420 Luxemburg,
5, avenue Gaston Diderich, en cours d'immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
(la “Société”),
en vertu d'une résolution du conseil d'administration adoptée en date du 2 février 2015, dont une copie, signée «ne
varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.
Lequel comparant, ès-qualités qu'il agît, a requis le notaire d'acter ses déclarations comme suit:
I.- Que la Société a été constituée en date du 22 décembre 2014 suivant un acte reçu par le notaire instrumentaire,
acte non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, avec un capital social intégralement libéré
de CHF 40.000,00 (quarante mille francs suisses) représenté par 40.000 (quarante mille) actions d'une valeur nominale
de CHF 1,00 (un franc suisse) chacune;
II.- Que l'article 5 (cinq), alinéas 8 (huit) à 13 (treize) des statuts stipule que:
«Le capital autorisé est, pendant la durée telle que prévue ci-après, de CHF 2.000.000,00 (deux millions francs suisses)
qui sera représenté par 2.000.000 (deux millions) actions d'une valeur nominale de CHF 1,00 (un franc suisse) chacune.
Le capital autorisé et le capital souscrit de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l'assemblée
générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.
En outre, le conseil d'administration est autorisé, dès la constitution et pendant une période prenant fin le 22 décembre
2019, à augmenter en une ou plusieurs fois le capital souscrit à l'intérieur des limites du capital autorisé avec émission
d'actions nouvelles. Ces augmentations de capital peuvent être souscrites avec ou sans prime d'émission, à libérer en
espèces, en nature ou par compensation avec des créances certaines, liquides et immédiatement exigibles vis-à-vis de la
société, ou même par incorporation de bénéfices reportés, de réserves disponibles ou de primes d'émission, ou par
conversion d'obligations comme dit ci-après.
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à de telles émissions sans réserver aux actionnaires
antérieurs un droit préférentiel de souscription des actions à émettre.
Le conseil d'administration peut déléguer tout administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou toute autre personne
dûment autorisée, pour recueillir les souscriptions et recevoir paiement du prix des actions représentant tout ou partie
de cette augmentation de capital.
Chaque fois que le conseil d'administration aura fait constater authentiquement une augmentation du capital souscrit,
il fera adapter le présent article.»;
III.- Que le conseil d'administration, en sa réunion du 2 février 2015 a décidé de procéder à la réalisation d'une partie
du capital autorisé à concurrence de CHF 460.000,00 (quatre cent soixante mille francs suisses) pour le porter de son
montant actuel de CHF 40.000,00 (quarante mille francs suisses) à CHF 500.000,00 (cinq cent mille francs suisses), par
l'émission de 460.000 (quatre cent soixante mille) actions nouvelles d'une valeur nominale de CHF 1,00 (un franc suisse)
chacune, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes;
IV.- Que le conseil d'administration a admis à la souscription des 460.000 (quatre cent soixante mille) actions nouvelles
l'actionnaire unique de la Société;
V.- Que l'augmentation de capital a été intégralement libérée par le souscripteur prénommé moyennant apport en
numéraire à un compte bancaire ouvert au nom de la Société, de sorte que la somme de CHF 460.000,00 (quatre cent
soixante mille francs suisses) a été mise à la libre disposition de cette dernière, ce dont il a été justifié au notaire instru-
mentant par la présentation des pièces justificatives des souscription et libération;
VI.- Qu'à la suite de cette augmentation de capital, le premier alinéa de l'article 5 (cinq) des statuts de la Société est
modifié et aura dorénavant la teneur suivante:
52427
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à CHF 500.000,00 (cinq cent mille francs suisses) représenté par
500.000 (cinq cent mille) actions d'une valeur nominale de CHF 1,00 (un franc suisse) chacune.».
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société à la suite des présentes
s'élèvent approximativement à deux mille quatre cents euros (EUR 2.400,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une traduction en français. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite de tout ce qui précède au comparant, connu du notaire instrumentaire par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: X. MANGIULLO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3769. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015040148/131.
(150045958) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.
SERIE S.A., Société Européenne pour la Restructuration et l'Ingénierie de l'Entreprise S.A., Société Ano-
nyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 31.696.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015041991/9.
(150047940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
Melga Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 176.391.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015042461/10.
(150048338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
CaCh, Société Anonyme.
Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 56.170.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 13 février 2015i>
<i>Résolution uniquei>
Les actionnaires décident de transférer le siège social de la Société du 8 Rue des Bruyères L-1274 Howald au 65 Rue
des Bruyères L-1274 Howald.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015041434/12.
(150048127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 mars 2015.
52428
L
U X E M B O U R G
Radwan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Key Note S.à r.l.).
Capital social: EUR 40.000,00.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 1, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 131.219.
ln the year two thousand fifteen, on the thirteenth of April.
Before us Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg.
THERE APPEARED:
Radwan Investments GmbH, a company incorporated under the laws of Austria, having its registered office at 6,
Führichgasse, A-1010 Vienna, registered with the Trade Register (Firmenbuch) of the Republic of Austria under the
registration number 336042f (“Radwan Investments GmbH” or the “Sole Shareholder") here represented by Mr Laurent
FISCH, lawyer, residing professionally at 36, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 10 April 2015 (“Proxyholder”).
The said proxy, signed ne varietur by the Proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party has requested the undersigned notary to note and record that Radwan Investments GmbH is
the sole shareholder of Key Note S.à r.l. (the “Company”) and has requested the undersigned notary to record the
following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder, after stating that he had knowledge of the documents mentioned in Article 267 of the law on
commercial companies, hereby approves the cross-border merger between Radwan Investments GmbH and Key Note
S.à r.l. according to the Merger Plan enacted by a deed of the undersigned notary of the 10
th
of November 2014 and
published in the Mémorial, Recueil Spécial C, number 3446 of November 26, 2011.
The said Merger has been approved by Radwan Investments GmbH by a notarial deed of Dr. Michael Mauler on the
11
th
February 2015.
A certificate confirming that all the formalities have been accomplished according to Austrian law will remain attached
to the present deed.
According to Luxembourg law the Merger will become effective between parties after the approval by the general
meetings of the merging companies and vis-à-vis third parties on the day of the publication of the present Meeting in the
Mémorial, Recueil Spécial C.
<i>Second resolutioni>
The name of the Company shall be changed to Radwan Investments S.à r.l.
<i>Third resolutioni>
Article 4 of the articles of incorporation of the Company shall be amended as follows so as to reflect the name change
pf the Company:
“ Art. 4. The name of the company is “Radwan Investments S.à r.l.”
<i>Fourth resolutioni>
The nominal value of the Shares of the Company shall be EUR 1.00 and the number of Shares increased accordingly.
The share capital of the Company shall also be divided in several classes of shares.
<i>Fifth resolutioni>
Articles 6 and 19 of the articles of incorporation of the Company shall be amended as follows so as to reflect the
above changes, and a new article 23 shall be added:
Art. 6. Share capital. The issued share capital of the Company is set at forty thousand euros (EUR 40,000.00), divided
into forty thousand (40,000) shares, each with a par value of one EURO (EUR 1), and further divided into the following
classes of shares:
- four thousand (4,000) Class A Shares,
- four thousand (4,000) Class B Shares,
- four thousand (4,000) Class C Shares,
- four thousand (4,000) Class D Shares,
- four thousand (4,000) Class E Shares,
52429
L
U X E M B O U R G
- four thousand (4,000) Class F Shares,
- four thousand (4,000) Class G Shares,
- four thousand (4,000) Class H Shares,
- four thousand (4,000) Class I Shares,
- four thousand (4,000) Class J Shares.
The capital of the Company may be increased by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association.
The capital of the Company may be reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association including by the cancellation of one or more entire Classes of Shares through
the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations
of Classes of Shares by the Company, such purchases and cancellations of Shares shall be made in the reverse alphabetical
order (starting with the Class J Shares and, if no Class J Shares are in existence, by the last Class of Shares in issue in the
Company in the alphabetical order).
In the event of a reduction of the issued share capital of the Company through the purchase and the cancellation of a
Class of Shares by the Company (in the order provided for in the preceding paragraph), such Class of Shares gives the
holders thereof the right, pro rata to their holding in such Class, to the Total Cancellation Amount as determined by the
general meeting of shareholders and the holders of Shares of the repurchased and cancelled Class of Shares shall receive
from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant Class held by
them and repurchased and cancelled.
The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of
Shares in issue in the Class of Shares to be repurchased and cancelled.
The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the sole manager or the board of managers and
approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation
Amount for each of Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount at the time of cancellation of the
relevant Class of Shares unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner required for
amendment of these articles of association, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher
than such Available Amount.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law, acquire its own shares.
Any available share premium or other available reserves shall be distributable.
Art. 19. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits and from available
reserves derived from retained earnings, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distri-
buted in the following order of priority:
- First, the holders of Class A Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an
amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of the Class A Shares held by them, then,
- the holders of Class B Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of the Class B Shares held by them, then,
- the holders of Class C Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point thirty-fifty per cent (0.35%) of the nominal value of the Class C Shares held by them, then,
- the holders of Class D Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty per cent (0.40%) of the nominal value of the Class D Shares held by them, then,
- the holders of Class E Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point forty-five per cent (0.45%) of the nominal value of the Class E Shares held by them, then,
- the holders of Class F Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty per cent (0.50%) of the nominal value of the Class F Shares held by them, then
- the holders of Class G Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point fifty-five per cent (0.55%) of the nominal value of the Class G Shares held by them, then
- the holders of Class H Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty per cent (0.60%) of the nominal value of the Class H Shares held by them, then
- the holders of Class I Shares shall be entitled to receive dividend distributions with respect to such year in an amount
of zero point sixty-five per cent (0.65%) of the nominal value of the Class I Shares, and then,
- the holders of Class J Shares shall be entitled to receive the remainder of any dividend distribution (and, if no Class
J Shares are in existence in the Company, the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to
the shareholders starting with the last Class of Shares in existence in the alphabetical order (i.e if first Class I Shares, then
if no Class I Shares are in existence, Class H Shares, and in such continuation until only Class A Shares are in existence).
52430
L
U X E M B O U R G
The share premium or other available reserves accounts may be distributed to the shareholders upon decision of a
general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share
premium account to the legal reserve account.
The shareholders may decide to pay interim dividends in accordance with the distribution priority rules set forth in
this Article 16 on the basis of statements of accounts prepared by the manager, or, as the case may be, the board of
managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed
may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distri-
butable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be
established by law.
Art. 23. Definitions.
"Available Amount" means, at any time, the amount determined by the board of managers in its sole discretion as being
the total amount lawfully distributable by the Company, consisting of net profits of the Company (including the profits
carried forward from the previous financial years) as increased by (i) any freely distributable share premium and other
freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be cancelled less the aggregate of (i) any losses (included carried forward
losses), (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or the articles of association, each
time as set out in the relevant Interim Accounts, and (iii) any amount as determined by the sole manager or the board
of managers (as applicable) he/she or it determines as being prudent to deduct (without for the avoidance of doubt, any
double counting) so that:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR + AM)
Where:
AA = Available Amount
NP = net profits (including profits carried forward from the previous financial years)
P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the articles of association
AM = any amount as determined by the sole manager or the board of managers (as applicable (he/she or it determines
as being prudent to deduct (without, for the avoidance of doubt, any double counting).
"Cancellation Value Per Share” means, with respect to the purchase by the Company of Shares of any class or classes,
the amount resulting from the division of the relevant Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the
Class(es) to be purchased and cancelled by the Company.
"Class or Classes" means a class or classes of Shares in issue in the Company.
"Class A Shares" means the Shares of Class A in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class B Shares" means the Shares of Class B in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class C Shares" means the Shares of Class C in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class D Shares" means the Shares of Class D in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class E Shares" means the Shares of Class E in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class F Shares" means the Shares of Class F in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class G Shares" means the Shares of Class G in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class H Shares" means the Shares of Class H in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class I Shares" means the Shares of Class I in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Class J Shares" means the Shares of Class J in the Company with a par value of EUR 1 each.
"Interim Accounts" means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
"Interim Account Date" means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation
of the relevant Class of Shares.
"Share" and "Shares" means a share or shares in the Company.
"Total Cancellation Amount" means the amount determined by the general meeting of shareholders of the Company
as total cancellation amount at the time of a repurchase and cancellation of one or more Classes of Shares within the
limit of the Available Amount.
<i>Sixth resolutioni>
The hour hundred (400) Shares of the Company with a nominal value of one hundred euros (EUR 100.00) each
belonging to Radwan Investments GmbH before this meeting are cancelled and exchanged, for the benefit of Radwan
Privatstiftung, “Privatstiftung”, having its registered office in A-1010 Wien, Führichgasse 6, Austria, registered with the
“Firmenbuch des Handelsgerichts Wien” under number FN 330876, being the new Shareholder after merger, by:
- four thousand (4,000) Class A Shares,
52431
L
U X E M B O U R G
- four thousand (4,000) Class B Shares,
- four thousand (4,000) Class C Shares,
- four thousand (4,000) Class D Shares,
- four thousand (4,000) Class E Shares,
- four thousand (4,000) Class F Shares,
- four thousand (4,000) Class G Shares,
- four thousand (4,000) Class H Shares,
- four thousand (4,000) Class I Shares and
- four thousand (4,000) Class J Shares.
<i>Seventh resolutioni>
Radwan Investments GmbH resolves to authorise and empower the Proxyholder and any manager of the Company,
each acting individually, with full power of substitution, to execute and deliver, under his/her/its sole signature, on behalf
of the Company, any documents necessary or useful in connection with the filing and registration required by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg regarding the above resolutions and, in particular, to register the newly created
Shares and Classes in the register of the Company.
<i>Expensesi>
The expenses incurred in connection with the present deed are estimated to be approximately EUR 2,500.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary states in accordance with article 271 (2) of the Companies Law having verified and certifies
the existence and legality of all the acts and formalities incumbent upon the Company and the Merger Project.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg-City, on the day named at the beginning.
The document having been read to the appearing parties, the latter signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the French version of the text above:
L'an deux mille quinze, le treize avril.
Par-devant Nous, Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Radwan Investments GmbH, une société dûment constituée sous le droit Autrichien, ayant son siège social à 6, Füh-
richgasse, A-1010 Vienne, immatriculée au registre de commerce («Firmenbuch») de la République d’Autriche sous le
numéro 336042f («Radwan Investments GmbH» ou l’«Associé Unique»), ici représentée par M. Laurent Fisch, juriste,
résidant professionnellement à 36, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg-Ville, Grand Duché de Luxembourg, en vertu
d'une procuration donnée sous seing privé daté du 10 avril 2015 (le «Mandataire»).
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par le Mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui auprès des autorités compétentes.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de noter et d'acter que
Radwan Investments GmbH est l’associé unique de Key Note S.à r.l. (ci-après la «Société») et a déclaré et requis le notaire
instrumentant de noter, d’enregistrer et d'acter les résolutions qui suivent:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique, après avoir déclaré avoir eu connaissance des documents mentionnés à l’article 267 de la loi sur le
sociétés commerciales, approuve la fusion transfrontalière entre Radwan Investments GmbH and Key Note S.à r.l., con-
formément au projet de fusion acté par le notaire soussigné, en date du 10 novembre 2014, publié au Mémorial, Recueil
Spécial C, numéro 3446 du 26 novembre 2011.
Ladite fusion a été approuvée par Radwan Investments GmbH par acte notarié de Dr. Michael Mauler le 11 février
2015.
Un certificat confirmant que toutes les formalités ont été accomplies conformément à la loi autrichienne restera annexé
aux présentes.
Conformément à la loi luxembourgeoise la fusion deviendra effective entre parties lorsque les décisions concordantes
sont intervenues au sein des sociétés et vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial de la présente Assemblée.
52432
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
La société sera désormais dénommée «Radwan Investments S.à r.l.»
<i>Troisième résolutioni>
L’article 4 des statuts de la Société est modifié comme suit pour tenir compte du changement de dénomination:
« Art. 4. La société prend la dénomination de «Radwan Investment S.à r.l.».
<i>Quatrième résolutioni>
Le capital de la Société sera désormais divisé en Parts Sociales d’une valeur nominale d’un euro chacune, le nombre
de Parts Sociales augmentera à raison de ceci plusieurs Classes de Parts Sociales sont créées.
<i>Cinquième résolutioni>
Les articles 6 et 19 des statuts de la Société sont modifiés comme suit pour tenir compte des modifications qui
précèdent, et un nouvel article 23 est ajouté:
Art. 6. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à quarante mille euros (40.000,- EUR) divisé en quarante
mille (40.000) Parts Sociales avec une valeur nominale d’un EURO (1,- EUR) chacune et en outre divisé dans les Classes
de Parts Sociales suivantes:
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe A,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe B,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe C,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe D,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe E,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe F,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe G,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe H,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe I,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe J.
Le capital de la Société peut être augmenté par une résolution adoptée par les associés selon les modalités requises
pour la modification des présents statuts.
Le capital de la Société peut être réduit par une résolution adoptée par les associés selon les modalités requises pour
la modification des présents statuts y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Classes de Parts Sociales par le rachat
et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette/ces Classe(s). Dans le cas de rachats et annulations de Classes
de Parts Sociales par la Société, ces rachats et annulations de Parts Sociales doivent être faits dans l'ordre alphabétique
inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe J et, si aucune Part Sociale de Classe J n'existe, par la dernière
Classe de Parts Sociales émises dans la Société dans l'ordre alphabétique).
Dans le cas d'une réduction du capital social émis de la Société par le rachat et l'annulation d'une Classe de Parts
Sociales par la Société (dans l'ordre prévu au paragraphe précédent), cette Classe de Parts Sociales donnera à ses dé-
tenteurs le droit, proportionnellement à leur détention dans cette Classe, au Montant Total d'Annulation tel que
déterminé par l'assemblée générale des associés et les détenteurs de Parts Sociales de la Classe rachetée et annulée
devront recevoir de la Société une somme égale à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque Part Sociale
rachetée et annulée qu'ils détiennent dans la Classe concernée.
La Valeur d'Annulation par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts
Sociales émises dans la Classe de Parts Sociales devant être rachetée et annulée.
Le Montant Total d'Annulation devra être un montant déterminé par le gérant unique ou le conseil de gérance et
approuvé par l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'An-
nulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A devra être le Montant Disponible au moment de l'annulation
de la Classe de Parts Sociales concernée à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée générale des associés
selon les modalités requises pour la modification des présents statuts, sous réserve toutefois que le Montant Total
d'Annulation ne soit jamais plus élevé que le Montant Disponible.
La Société peut, dans la mesure où la loi le permet, procéder au rachat de ses propres parts sociales.
Toute prime d'émission disponible ou autre réserve disponible sera distribuable.
Art. 19. Distributions. Il est prélevé, sur les bénéfices nets, cinq pour cent (5%) affecté à la constitution d'une réserve
légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis
de la Société.
Le solde peut être distribué aux associés sur décision de l'assemblée générale des associés.
52433
L
U X E M B O U R G
Pour toute année où la Société décide de procéder à des distributions de dividende, tiré des bénéfices nets et des
réserves disponibles provenant de bénéfices reportées, y compris les primes d'émission, le montant alloué à cet effet
devra être distribué selon l'ordre de priorité suivant:
- Tout d'abord, les détenteurs de Parts Sociales de Classe A seront en droit de recevoir des distributions de dividende
relatives à cette année pour un montant égal à zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale des Parts
Sociales de Classe A qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe B seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Classe B qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe C seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe C qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe D seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Classe D qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe E seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe E qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe F seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Classe F qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe G seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule cinquante-cinq pourcent (0,55%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe G qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe H seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule soixante pourcent (0,60%) de la valeur nominale des Parts Sociales de
Classe H qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe I seront en droit de recevoir des distributions de dividende relatives à
cette année pour un montant égal à zéro virgule soixante-cinq pourcent (0,65%) de la valeur nominale des Parts Sociales
de Classe I qu'ils détiennent, puis
- les détenteurs de Parts Sociales de Classe J seront en droit de recevoir le solde des distributions de dividende (et,
si aucune Part Sociale de Classe J n'existe dans la Société, le solde du montant total distribué sera alloué en son intégralité
aux associés en commençant par la dernière Classe de Parts Sociales existante dans l'ordre alphabétique (i.e. en premier
les Parts Sociales de Classe I, puis si aucune Part Sociale de Classe I n'existe, les Parts Sociales de Classe H et ainsi de
suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des Parts Sociales de Classe A).
La prime d'émission ou d'autres réserves disponibles peuvent être distribuées aux associés sur décision de l'assemblée
générale des associés. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la
réserve légale.
Les associés peuvent décider de verser des acomptes sur dividendes en conformité avec les règles de priorité de
distribution établies dans le présent Article 16 sur la base d'un état comptable préparé par le gérant ou, le cas échéant,
le conseil de gérance, duquel il apparaît que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution, étant entendu que
le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable
augmenté des bénéfices reportés ainsi que des réserves et primes distribuables mais diminué des pertes reportées et des
sommes à allouer à une réserve en vertu de la loi.
Art. 23. Définitions.
«Montant Disponible» signifie, à tout moment, le montant déterminé de manière discrétionnaire par le conseil de
gérance comme étant le montant total légalement distribuable par la Société, constitué des bénéfices nets de la Société
(incluant les bénéfices reportés des années précédentes) augmentés de (i) toute prime d'émission librement distribuable
et autres réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction du capital social et de la
réduction de la réserve légale en lien avec la classe de parts sociales devant être annulée moins la somme de (i) toutes
pertes (incluant les pertes reportées) et (ii) toutes sommes qui devront être placées en réserve(s) suivant les dispositions
légales ou les Statuts, déterminées chaque fois sur base des Comptes Intérimaires pertinents, et (iii) toute somme dé-
terminée par le gérant unique ou le conseil de gérance (le cas échéant) tel qu'il/elle estime prudent de déduire (par soins
de clarté sans double calcul) de sorte que:
MD = (BN + P+ RC) - (Pe + RL + TS)
où:
MD = Montant Disponible
BN = Bénéfices Nets (incluant les bénéfices reportés des années précédentes)
52434
L
U X E M B O U R G
P = toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables
RC= montant de la réduction de capital social et de la réduction de la réserve légale en lien avec la classe de parts
sociales devant être annulée
Pe = pertes (incluant les pertes reportées)
RL = toutes sommes devant être placées en réserve(s) suivant les dispositions légales ou les Statuts
TS = toute somme telle que déterminée par le gérant unique ou le conseil de gérance (le cas échéant) qu'il/elle estime
prudent de déduire (par soins de clarté sans double calcul).
«Valeur d'Annulation par Part Sociale» signifie, concernant le rachat par la Société de Parts Sociales d'une ou de
quelconque(s) classe(s), le montant résultant de la division du Montant Total d'Annulation concerné par le nombre de
Parts Sociales émises dans la/les Classe(s) devant être rachetée(s) et annulée(s).
«Classe ou Classes» signifie une classe ou des classes de Parts Sociales émises dans la Société «Parts Sociales de Classe
A» signifie les Parts Sociales de Classe A dans la Société ayant une valeur nominale de EUR 1 chacune.
«Parts Sociales de Classe B» signifie les Parts Sociales de Classe B dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe B» signifie les Parts Sociales de Classe B dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe C» signifie les Parts Sociales de Classe C dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe D» signifie les Parts Sociales de Classe D dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe E» signifie les Parts Sociales de Classe E dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe F» signifie les Parts Sociales de Classe F dans la Société ayant une valeur nominale de EUR 1
chacune.
«Parts Sociales de Classe G» signifie les Parts Sociales de Classe G dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe H» signifie les Parts Sociales de Classe H dans la Société ayant une valeur nominale de EUR
1 chacune.
«Parts Sociales de Classe I» signifie les Parts Sociales de Classe I dans la Société ayant une valeur nominale de EUR 1
chacune.
«Parts Sociales de Classe J» signifie les Parts Sociales de Classe J dans la Société ayant une valeur nominale de EUR 1
chacune.
«Comptes Intérimaires» sont les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernés.
«Date des Comptes Intérimaires» est la date ne devant être inférieure à huit (8) jours avant la date de rachat et
d'annulation de la Classe de Parts Sociales concernée.
«Part Sociale» et «Parts Sociales» signifie une part sociale ou des parts sociales de la Société.
«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par l'assemblée générale des associés de la Société comme
étant le montant total d'annulation au moment d'un rachat et d'une annulation de l'une ou plusieurs Classe(s) de Parts
Sociales dans les limites du Montant Disponible.
<i>Sixième résolutioni>
Les quatre cents (400) Parts Sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,00) chacune appartenant à l’Associé
Unique avant cette assemblée sont annulées et échangées, au profit de Radwan Privatstiftung, “Privatstiftung”, ayant son
siège social A-1010 Wien, Führichgasse 6, Autriche, inscrite au “Firmenbuch des Handelsgerichts Wien” sous le numéro
FN 330876, qui sera le nouvel associé après fusion, par
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe A,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe B,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe C,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe D,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe E,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe F,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe G,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe H,
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe I et
- quatre mille (4.000) Parts Sociales de Classe J.
52435
L
U X E M B O U R G
<i>Septième résolutioni>
Radwan Investments GmbH décide d'autoriser et de charger le Mandataire et tous gérants de la Société, agissant
individuellement, avec plein pouvoir de substitution à signer et émettre par sa seule signature au nom de la Société tout
document nécessaire ou utile en relation avec le dépôt et l'inscription requise par la loi du Grand-Duché de Luxembourg
au sujet des résolutions ci-dessus et, plus particulièrement, d'inscrire les nouvelles Parts Sociales et leurs Classes dans le
registre de la Société.
<i>Coûtsi>
Les frais, occasionnés par le présent acte sont estimés à la somme de EUR 2.500.-.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, déclare en conformité avec l’article 271 (2) de la Loi sur les Sociétés, avoir vérifié et certifie
l’existence et la légalité de tous les actes et formalités incombant à la Société et le Projet de Fusion.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes, qu'à la requête de la comparante, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante et en cas de divergences
entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous, notaire, le présent acte
original.
Signé: L. FISCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/11673. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 avril 2015.
Référence de publication: 2015059123/404.
(150067521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 avril 2015.
Acres Financial, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 43.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 138.376.
In the year two thousand and fifteen, on the fourth of March.
Before Me Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of ACRES FINANCIAL, S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2449 Luxembourg, 5,
Boulevard Royal, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 138.376
(NIN 2008 2416 855) (the Company),
incorporated by deed of the notary Joseph ELVINGER, then residing in Luxembourg, on the 18
th
of April 2008,
published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1339 of May 31, 2008, and which articles of
incorporation have been amended by deed of the same notary Joseph ELVINGER on the 2
nd
of August 2013, published
in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 2454 of October 3, 2013.
THERE APPEARED:
1.- GRUPO TINEL S.A., a corporation organized under the laws of Panama, having its address at Panama City, PA -
Panama and registered with the Public Registry of Panama under number 803340, and holding eight hundred seventy (870)
shares of the Company.
2.- MAUZO INTERNATIONAL S.A., a corporation organized under the laws of Panama, having its address at Panama
City, PA - Panama and registered with the Public Registry of Panama under number 803564, and holding eight hundred
seventy (870) shares of the Company;
all together referred to as the Shareholders,
all hereby represented by Mrs. Colette WOHL, employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard
Royal, by virtue of two proxies given under private seal.
Said powers of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing
parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the regis-
tration authorities.
52436
L
U X E M B O U R G
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. that the Shareholders wish to proceed with the dissolution of the Company and to put it into liquidation;
III. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1.- Decision to put the company ACRES FINANCIAL, S.à r.l. into liquidation.
2.- Nomination of a liquidator and determination of his powers.
3.- Miscellaneous.
IV. After having carefully considered the above, the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to dissolve the company ACRES FINANCIAL, S.à r.l. and to put it into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Mrs. Colette WOHL, employee, residing professionally at L-2449 Luxembourg,
5, Boulevard Royal, as liquidator of the company.
The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by
article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le quatre mars.
Par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de ACRES FINANCIAL, S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe à L-2449 Luxembourg, 5, Boulevard Royal,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 138.376 (NIN 2008 2416 855),
(la Société)
constituée suivant acte reçu par le notaire Joseph ELVINGER, alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 avril
2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1339 du 31 mai 2007, et dont les statuts ont
été modifiés suivant acte reçu par le même notaire Joseph ELVINGER en date du 2 août 2013, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 2454 du 3 octobre 2013.
ONT COMPARU
1.- GRUPO TINEL S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Panama, ayant son siège social à Panama
City, PA - Panama, enregistrée auprès du Registre Public du Panama sous le numéro 803340, et détenant huit cent
soixante-dix (870) parts sociales de la Société;
2.- MAUZO INTERNATIONAL S.A., une société anonyme constituée selon les lois du Panama, ayant son siège social
à Panama City, PA - Panama, enregistrée auprès du Registre Public du Panama sous le numéro 803564, et détenant huit
cent soixante-dix (870) parts sociales de la Société;
collectivement désignées les Associés,
tous représentés par Madame Colette WOHL, employée, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 5,
Boulevard Royal, en vertu de deux procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire agissant pour le compte des parties
comparantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d’être soumises avec celui-ci aux for-
malités de l’enregistrement.
Les Associés représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que les Associés souhaitent procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation;
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé de la manière suivante:
1.- Décision de mettre la société ACRES FINANCIAL, S.à r.l. en liquidation.
2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
52437
L
U X E M B O U R G
3.- Divers
IV. Après avoir soigneusement examiné ce qui précède les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de dissoudre la société ACRES FINANCIAL, S.à r.l. et de la mettre en liquidation.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de nommer Madame Colette WOHL, employée, demeurant professionnellement à L-2449
Luxembourg, 5, Boulevard Royal, comme liquidateur de la société.
Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants
de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: C. WOHL, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 mars 2015. Relation: GAC/2015/1902. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 12 mars 2015.
Référence de publication: 2015040142/107.
(150046127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.
Capula ESS Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 177.365.
In the year two thousand and fifteen, on the third day of March,
Before Maître Joëlle Baden, notary, residing in Luxembourg,
There appeared:
Capula European Special Situations Fund L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the
laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman
Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number MC-70819,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P., an exempted limited partnership
incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Exempted Limited Partnerships under number
MC-70808,
represented by its general partner, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, a limited company incor-
porated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands, registered with the Registrar of Companies under number MC-274461,
duly represented by Mr Kristof De Wael, having his professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 13
th
February 2015 in Potsdam (Germany).
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole member of Capula ESS Lux 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 177.365, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 2 May 2013,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 1620 on 6 July 2013 (hereafter the "Company").
The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 January
2015 and not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party, representing the entire share capital, requested the undersigned notary to act that the agenda of
the meeting is as follows:
52438
L
U X E M B O U R G
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its current amount of three million nine hundred twenty thousand
one hundred twenty-five euro (EUR 3,920,125.-), represented by three hundred fifty-six thousand three hundred seventy-
five (356,375) class A shares and three million five hundred sixty-three thousand seven hundred fifty (3,563,750) class B
shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, up to four million six hundred thousand one hundred twenty-five
euro (EUR 4,600,125.-), through the issue of sixty-one thousand eight hundred eighteen (61,818) new class A shares and
six hundred eighteen thousand one hundred eighty-two (618,182) new class B shares, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each, against a payment in cash;
2. Subsequent amendment of Article 5.1 of the articles of association of the Company.
The appearing party, representing the entire share capital, took the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The sole member resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of three million nine
hundred twenty thousand one hundred twenty-five euro (EUR 3,920,125.-), represented by three hundred fifty-six thou-
sand three hundred seventy-five (356,375) class A shares and three million five hundred sixty-three thousand seven
hundred fifty (3,563,750) class B shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, up to four million six hundred
thousand one hundred twenty-five euro (EUR 4,600,125.-), through the issue of sixty-one thousand eight hundred eighteen
(61,818) new class A shares and six hundred eighteen thousand one hundred eighty-two (618,182) new class B shares,
having a par value of one euro (EUR 1.-) each.
<i>Subscription and payment:i>
The sixty-one thousand eight hundred eighteen (61,818) new class A shares and six hundred eighteen thousand one
hundred eighty-two (618,182) new class B shares have been subscribed by Capula European Special Situations Fund L.P.,
aforementioned, at a total price of six hundred eighty thousand euro (EUR 680,000.-) entirely allocated to the share
capital.
The sixty-one thousand eight hundred eighteen (61,818) new class A shares and six hundred eighteen thousand one
hundred eighty-two (618,182) new class B shares have been fully paid up in cash by Capula European Special Situations
Fund L.P., aforementioned so that the total amount of six hundred eighty thousand euro (EUR 680,000.-) is at the free
disposal of the Company, as it has been shown to the undersigned notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolution, the sole member resolves to amend article 5.1 of the articles of association
of the Company which shall henceforth be read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at four million six hundred thousand one hundred twenty-five euro (EUR
4,600,125.-), consisting of:
- four hundred eighteen thousand one hundred ninety-three (418,193) class A shares, having a par value of one euro
(EUR 1.-) each (the “Class A Shares”); and
- four million one hundred eighty-one thousand nine hundred thirty-two (4,181,932) class B shares, having a par value
of one euro (EUR 1.-) each (the “Class B Shares”, and together with the Class A Shares, the “Shares”).”
There being no further business, the meeting is closed.
WHEREOF, this deed is drawn up in Luxembourg on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the proxyholder
of the appearing person, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder of the appearing person and in case of divergences between the English and the French texts, the English
version will be prevailing.
The document having been read to the proxyholder of the above appearing party known to the notary, such person
signed together with the notary this deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le troisième jour du mois de mars,
Par devant Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg,
A comparu:
Capula European Special Situations Fund L.P., un exempted limited partnership, constitué et existant sous les lois des
Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé
auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro MC-70819,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) L.P, un exempted limited part-
nership, constitué et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box 309, Ugland House, Grand
52439
L
U X E M B O U R G
Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Exempted Limited Partnerships sous le numéro
MC-70808,
représenté par son gérant commandité, Capula European Special Situations Fund (GP) Limited, une société à respon-
sabilité limitée (limited company), constituée et existant sous les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social à PO Box
309, Ugland House, Grand Caïman, KY1-1104, Iles Caïmans, immatriculé auprès du Registrar of Companies sous le
numéro MC-274461,
dûment représenté par Monsieur Kristof DeWael, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 13 février 2015 à Potsdam (Allemagne).
Ladite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le comparant est l’associé unique de Capula ESS Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège
social au 7, Avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 177.365, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 2 mai 2013, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1620 du 6 juillet 2013 (ci-après la "Société").
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 21 janvier 2015, non
encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire soussigné de prendre acte que l’ordre du
jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de trois millions neuf cent vingt mille cent vingt-
cinq euros (EUR 3.920.125,-) représenté par trois cent cinquante-six mille trois cent soixante-quinze (356.375) parts
sociales de catégorie A et trois millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante (3.563.750) parts sociales de
catégorie B, d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de quatre millions six cent mille cent vingt-
cinq euros (EUR 4.600.125,-) par l’émission de soixante-et-un mille huit cent dix-huit (61.818) nouvelles parts sociales de
catégorie A et six cent dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (618.182) nouvelles parts sociales de catégorie B d’une valeur
nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, en échange d’un paiement en numéraire;
2. Modification subséquente de l’article 5.1 des statuts de la Société.
Le comparant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’associé unique décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de trois millions neuf cent
vingt mille cent vingt-cinq euros (EUR 3.920.125,-) représenté par trois cent cinquante-six mille trois cent soixante-quinze
(356.375) parts sociales de catégorie A et trois millions cinq cent soixante-trois mille sept cent cinquante (3.563.750)
parts sociales de catégorie B, d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, au montant de quatre millions six cent
mille cent vingt-cinq euros (EUR 4.600.125,-) par l’émission de soixante-et-un mille huit cent dix-huit (61.818) nouvelles
parts sociales de catégorie A et six cent dix-huit mille cent quatre-vingt-deux (618.182) nouvelles parts sociales de caté-
gorie B d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.
<i>Souscription et libération:i>
Les soixante-et-un mille huit cent dix-huit (61.818) nouvelles parts sociales de catégorie A ainsi que les six cent dix-
huit mille cent quatre-vingt-deux (618.182) nouvelles parts sociales de catégorie B ont été souscrites par Capula European
Special Situations Fund L.P., susmentionné, pour un prix total de six cent quatre-vingt mille euros (EUR 680.000,-) inté-
gralement alloué au capital social.
Les soixante-et-un mille huit cent dix-huit (61.818) nouvelles parts sociales de catégorie A ainsi que les six cent dix-
huit mille cent quatre-vingt-deux (618.182) nouvelles parts sociales de catégorie B ainsi souscrites ont été entièrement
libérées en numéraire par Capula European Special Situations Fund L.P., susmentionné, si bien que le montant total de
six cent quatre-vingt mille euros (EUR 680.000,-) est à la libre disposition de la Société tel qu'il a été démontré au notaire
soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
A la suite de la résolution précédente, l’associé unique décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société, qui
aura désormais la teneur suivante:
« 5.1. La Société a un capital social de quatre millions six cent mille cent vingt-cinq euros (EUR 4.600.125,-) représenté
par:
- quatre cent dix-huit mille cent quatre-vingt-treize (418.193) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales A»); et par
- quatre millions cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent trente-deux (4.181.932) parts sociales de catégorie B ayant
une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (les «Parts Sociales B» et ensemble avec les Parts Sociales A, les «Parts
Sociales»).»
52440
L
U X E M B O U R G
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du mandataire du comparant, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du mandataire de ce même comparant et en
cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant, ledit
comparant a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: K. DE WAEL et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 6 mars 2015. 1LAC/2015/6984. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Référence de publication: 2015040218/153.
(150046088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.
Esso Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.223.130,98.
Siège social: L-8069 Luxembourg, 20, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 7.310.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fourth day of March,
Before us Maître Gérard Lecuit, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
ExxonMobil Luxembourg et Cie, a société en commandite par actions governed by the laws of Luxembourg, with
registered office at 20, rue de l'Industrie, L-8069 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B 72560 (the "Shareholder"),
hereby represented by Maître Jean-Paul Spang, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
under private seal given on 24 March 2015,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of ESSO
LUXEMBOURG, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, having a share capital of sixteen
million seven hundred seventy-five thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 16,775,588.-), with registered office at
20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated on 23 January 1920, pursuant to a
deed of Maître Jules Hamélius, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil Spécial, No. 8 of 13
February 1920 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 7310 (the
“Company”). The articles of incorporation have for the last time been amended following a deed of the undersigned
notary, dated 11 May 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 12 July 2007 under
number 1428.
The Shareholder, represented as above mentioned, has recognised to be duly and fully informed of the resolutions to
be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To acknowledge the waiver by the holders of securities of the Company to be Divided (as defined below) and the
Recipient Company (as defined below) regarding the division report of the board of directors of the Company, as company
to be divided, (the “Company to be Divided”) and the board of managers of Fuelsco, a société à responsabilité limitée
governed by the laws of Luxembourg, with registered office at 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange, Grand Duchy of
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 183947, as
recipient company (the “Recipient Company”), regarding the division of part of the retail petrol business (the “Division”)
from the Company to be Divided to the Recipient Company.
2. To acknowledge the waiver by the holders of securities of the Company to be Divided and the Recipient Company
regarding the expert report on the draft terms of division (projet de scission partielle).
3. To approve the draft terms of division (projet de scission partielle) and, as a result, the Division, as further described
in the draft terms of division (projet de scission partielle), between the Company to be Divided and the Recipient Com-
pany, by way of transfer of all assets and liabilities of part of the retail petrol business of the Company to be Divided,
without any restriction or limitation, to the Recipient Company, without liquidation of the Company to be Divided.
4. To reduce the share capital of the Company to be Divided by an amount of six million five hundred fifty-two thousand
four hundred fifty-seven euro and two cents (EUR 6,552,457.02) so as to reduce it from its current amount of sixteen
52441
L
U X E M B O U R G
million seven hundred seventy-five thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 16,775,588.-) to ten million two hundred
twenty-three thousand one hundred thirty euro and ninety-eight cents (EUR 10,223,130.98) without cancellation of any
shares.
5. To amend the first paragraph of article 6, of the articles of incorporation of the Company to be Divided to reflect
the reduction of the share capital of the Company to be Divided.
6. To set the effective date of the Division.
7. To grant all necessary powers to the board of directors of the Company to be Divided to implement the resolutions
adopted on the basis of the above agenda items.
The undersigned notary confirms that:
a) draft terms of division (projet de scission partielle) have been drawn up and adopted by the board of directors of
the Company to be Divided and by the board of managers of the Recipient Company on 18 February 2015 (the “Draft
Terms of Division”);
b) the present resolutions of the sole shareholder of the Company to be Divided are adopted at least one (1) month
after the publication of such Draft Terms of Division in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 23
February 2015 under number 490;
c) a waiver statement has been adopted by the holders of securities of the Company to be Divided and of the Recipient
Company on 17 February 2015, in accordance with article 296 (2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies,
as amended (the “Law”) regarding the division report of the board of directors of the Company to be Divided and by
the board of managers of the Recipient Company (the “Division Report Waiver”);
d) a waiver statement has been adopted by the holders of securities of the Company to be Divided and the Recipient
Company on 17 February 2015, in accordance with article 296 (1) of the Law regarding the expert report on the Draft
Terms of Division (the “Expert Report Waiver”);
e) the documents required pursuant to article 295 of the Law have been deposited at the registered office of the
Company to be Divided and the Recipient Company, for inspection by the shareholders and those persons having special
rights against any of the Company to be Divided or the Recipient Company, at least one (1) month prior to the date of
the present resolutions; and
f) in accordance with article 302 of the Law, the Division will become effective vis-à-vis third parties as at the date of
publication of the resolutions of the sole shareholder of the Company to be Divided and of the sole shareholder of the
Recipient Company approving the Division in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
After having acknowledged the Division Report Waiver and the Expert Report Waiver, the Shareholder resolved to
approve the Draft Terms of Division and the Division, as further described in the Draft Terms of Division, pursuant to
which all the assets and liabilities of part of the retail petrol business of the Company to be Divided shall be transferred,
without any restriction or limitation, to the Recipient Company, without liquidation of the Company to be Divided.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to reduce the share capital of the Company to be Divided by an amount of six million five
hundred fifty-two thousand four hundred fifty-seven euro and two cents (EUR 6,552,457.02) so as to reduce it from its
current amount of sixteen million seven hundred seventy-five thousand five hundred eighty-eight euro (EUR 16,775,588.-)
to ten million two hundred twenty-three thousand one hundred thirty euro and ninety-eight cents (EUR 10,223,130.98)
without cancellation of any shares.
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 6 of the articles of incorporation of the Company to
be Divided to reflect the reduction of the share capital of the Company to be Divided.
Said paragraph will from now on read as follows:
"The capital is set at ten million two hundred twenty-three thousand one hundred thirty euro and ninety-eight cents
(EUR 10,223,130.98) divided in sixty thousand (60,000) shares without nominal value.".
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved that the Division will be effective between the Recipient Company and the Company to be
Divided on 25 March 2015 at 8.00 a.m.
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholder resolved to appoint any director of the Company to be Divided, each acting individually, with power
of substitution, as its attorney-in-fact to implement the foregoing resolutions and to accomplish all acts of whatever kind
which are necessary or useful to fully implement the Division, such as, notably but not exclusively, to file with the Lu-
52442
L
U X E M B O U R G
xembourg Register of Commerce and Companies all declarations and formalities with regards to the Company to be
Divided pursuant to the Division being effective.
<i>Declarationi>
In accordance with article 300 (2) of the Law, the undersigned notary declares and certifies having verified the existence
and validity, under Luxembourg law, of the Draft Terms of Division and of the legal acts and formalities imposed in order
to render the Division effective between the Company to be Divided and the Recipient Company.
In accordance with article 303 (2) of the Law, the following real estate properties are transferred to the Recipient
Company (in the French language):
<i>«Remarquei>
Il résulte d’une lettre émanant de la Commune de Schengen datée du 02 mars 2015 que le collège des bourgmestre
et échevins de ladite commune a décidé d’autoriser la société ESSO Luxembourg de céder le contrat de concession d’un
droit de superficie pour la station d’essence de Remerschen relatée sub. 7.- qu'elle a acquis aux termes d’un acte de
concession d’un droit de superficie reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, le 10 octobre
2005, ci-après relaté.
1.- La station d’essence ESSO DUDELANGE sise au 132, route de Luxembourg à L-3515 Dudelange, inscrite au
cadastre comme suit:
Commune de Dudelange, section B de Burange:
- numéro 20/4654, lieu-dit «route de Luxembourg», place, d’une contenance de 04 ares 92 centiares.
- numéro 19/5608, même lieu-dit, place, d’une contenance de 13 ares 71 centiares.
- numéro 20/4478, même lieu-dit, place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 10 ares 42 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 20/4654 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur la dame Joséphine SCHNEIDER et le sieur Marc HOFERLIN aux termes d’un acte de vente reçu par le
notaire soussigné, alors de résidence à Hesperange, en date du 19 juin 2002, transcrit au deuxième bureau des Hypo-
thèques à Luxembourg, le 11 juillet 2002, volume 1335, numéro 45.
- Le numéro cadastral prédésigné 19/5608 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
* partiellement sur les consorts PAULY aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André Schwachtgen, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1987, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 21 décembre 1987, volume 715, numéro 106.
* partiellement sur la dame Berthe SCHNEIDER aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire André Schwacht-
gen, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Francis KESSELER, alors de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 27 novembre 1987, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 21 décembre
1987, volume 715, numéro 107.
- Le numéro cadastral prédésigné 20/4478 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur les époux Camille REITER-SCHNEIDER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles
FUNCK, alors de résidence à Luxembourg, en date du 09 septembre 1965, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 16 septembre 1965, volume 202, numéro 36.
2.- La station d’essence ESSO CHARLES DE GAULLE sise au 306, boulevard Charles de Gaulle à L-4083 Esch-sur-
Alzette, inscrite au cadastre comme suit:
Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord:
- numéro 2347/13801, lieu-dit «Boulevard Charles de Gaulle», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance
de 15 ares.
- numéro 2347/15835, même lieu-dit, place (occupée), station d’épuration, d’une contenance de 07 ares 26 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 2347/13801 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur les époux Jean-Claude VENANZI-ARMENZANI aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire
soussigné, alors de résidence à Hesperange, en date du 1
er
août 2001, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 10 septembre 2001, volume 1293, numéro 102.
- Le numéro cadastral prédésigné 2347/15835 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur le sieur Nico GOUBER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André SCHWACHTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 07 janvier 1993, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxem-
bourg, le 22 janvier 1993, volume 916, numéro 96.
3.- La station d’essence ESSO FRISANGE sise au 24, rue Robert Schuman à L-5751 Frisange, inscrite au cadastre comme
suit:
52443
L
U X E M B O U R G
Commune de Frisange, section B de Frisange:
- numéro 1070/2637, lieu-dit «Robert Schuman Strooss», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de
30 ares 90 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 1070/2637 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg):
- partiellement sur les époux Jean AREND-FRANZEN aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles
MICHELS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1960, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à
Luxembourg, le 31 mai 1960, volume 117, numéro 162.
- partiellement sur la dame Doris BINTENER aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire André SCHWACHT-
GEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1984, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à
Luxembourg, le 29 novembre 1984, volume 634, numéro 114.
4.- La station d’essence ESSO SANDWEILER sise au 1, route de Remich à L-5250 Sandweiler, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Sandweiler, section A de Sandweiler:
- numéro 984/3923, lieu-dit «rue de Remich», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 06 ares 61
centiares.
- numéro 987/3097, lieu-dit «rue d’Oetrange», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de 07 ares
17 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 984/3923 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg):
- partiellement sur le sieur Joseph GAASCH aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Marie-Joseph KINTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1955, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Lu-
xembourg, le 10 décembre 1955, volume 57, numéro 118.
- partiellement sur les époux Jean-Pierre HOFFMANN aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Marie-Joseph
Kintgen, alors de résidence à Luxembourg, en date du 05 septembre 1956, transcrit au premier bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 19 septembre 1956, volume 80, numéro 110.
- partiellement sur le sieur Pierre MALLER-BAUER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Jacques Faber,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 03 mai 1960, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 25 mai 1960, volume 187, numéro 116.
- partiellement sur l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d’un acte d’échange sous seing-privé, en date
du 24 octobre 1980, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 25 novembre 1980, volume 864,
numéro 65.
- Le numéro cadastral prédésigné 987/3097 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur la dame Alice THOSS aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André SCHWACHTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 1986, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 06 mars 1986, volume 1042, numéro 126.
5.- La station d’essence ESSO STEINFORT sise au 105, rue de Luxembourg à L-8440 Steinfort, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Steinfort, section A de Steinfort:
- numéro 572/2733, lieu-dit «rue de Luxembourg», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 12
ares 82 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 572/2733 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur le sieur Jean CLEMENT aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 1967, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 22 septembre 1967, volume 237, numéro 43.
6.- La station d’essence ESSO SENNINGERBERG sise au 40, route de Trèves à L-2633 Senningerberg, inscrite au
cadastre comme suit:
Commune de Niederanven, section B de Senningen:
- numéro 1190/4163, lieu-dit «route de Trèves», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 34 ares
98 centiares.
52444
L
U X E M B O U R G
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 1190/4163 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
- partiellement sur les consorts KILL aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Christine DOERNER, de
résidence à Bettembourg, et le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Bascharage, en date du 1
er
octobre
1987, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 27 octobre 1987, volume 1100, numéro 156.
- partiellement sur le sieur Nico FELLER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire soussigné, alors de résidence
à Hesperange, en date du 09 avril 2001, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 10 mai 2001,
volume 1683, numéro 13.
7.- Un droit de superficie dans un terrain ci-après désigné sur lequel la station d’essence ESSO REMERSCHEN sise au
3, Schengerwis à L-5439 Remerschen est exploitée, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Schengen, ancienne commune de Remerschen, section RC de Flouer:
- numéro 1940/4930, lieu-dit «Schengerwis», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 1 hectare
05 ares 71 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le prédit droit de superficie du prédit numéro cadastral prédésigné 1940/4930 a été acquis par la société ESSO
Luxembourg S.A. (actuellement ESSO Luxembourg) sur l’Administration Communale de Remerschen aux termes d’un
acte de concession d’un droit de superficie reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date
du 10 octobre 2005, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 27 janvier 2006, volume 1970,
numéro 88.
8.- La station d’essence ESSO DIFFERDANGE sise au 70, avenue de la Liberté à L-4601 Differdange, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Differdange, section A de Niedercorn:
- numéro 2567/7773, lieu-dit «avenue de la Liberté», place (occupée), bâtiment non défini, d’une contenance de 17
ares 53 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 2567/7773 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
- partiellement sur le sieur Charles HAUSEMER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK,
alors de résidence à Luxembourg, et le notaire Jean-Pierre BOURG, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25
septembre 1968, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 18 octobre 1968, volume 253, numéro
79.
- partiellement sur les consorts HESSE aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1969, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le
20 août 1969, volume 268, numéro 55.
- partiellement sur la société GENERAL ELECTRONICS S.A. aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André
SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 05 juin 1989, transcrit au deuxième bureau des Hypo-
thèques à Luxembourg, le 03 juillet 1989, volume 767, numéro 145.
9.- La station d’essence ESSO REMICH sise au 9, route de l’Europe à L-5531 Remich, inscrite au cadastre comme suit:
Commune de Remich, section A des Bois:
- numéro 425/1913, lieu-dit «route de l’Europe», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 07 ares
41 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 425/1913 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg) sur les consorts WOLTZ aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire Charles MICHELS, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 09 novembre 1962, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 28 novembre 1962, volume 263, numéro 130.»
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at two thousand euros (2,000.-EUR).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
52445
L
U X E M B O U R G
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-quatre mars,
Par-devant Nous Maître Gérard Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
ExxonMobil Luxembourg et Cie, une société en commandite par actions de droit luxembourgeois, avec siège social
au 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 72560 (l' «Associé»),
représentée aux fins des présentes par Maître Jean-Paul Spang, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 24 mars 2015.
La prédite procuration restera annexée aux présentes.
L'Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l'Associé est le seul et unique associé d’ESSO LUXEMBOURG,
une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant un capital social de seize millions sept cent soixante-
quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 16.775.588,-), dont le siège social est au 20, rue de l’Industrie, L-8069
Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en date du 23 janvier 1920 suivant acte de Maître Jules Hamélius,
notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial, Recueil Spécial, No. 8 du 13 février 1920 et immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 7310 (la «Société»). Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant en date du 11 mai 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations en date du 12 juillet 2007 sous le numéro 1428.
L'Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaît avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
1. Constatation de la renonciation des détenteurs de titres de la Société Scindée (telle que définie ci-dessous) et de
la Société Bénéficiaire (telle que définie ci-dessous) concernant le rapport de scission du conseil de gérance de la Société,
comme société scindée (la «Société Scindée») et du conseil de gérance de Fuelsco, une société à responsabilité limitée
de droit luxembourgeois, dont le siège social est au 20, rue de l’Industrie, L-8069 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg,
et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183947, comme société
bénéficiaire (la «Société Bénéficiaire») relatif à la scission d’une partie du commerce de pétrole (la «Scission») de la Société
Scindée à la Société Bénéficiaire.
2. Constatation de la renonciation des détenteurs de titres de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire concernant
le rapport d’expert sur le projet de scission partielle.
3. Approbation du projet de scission partielle et, en conséquence, de la Scission telle que plus amplement décrite dans
le projet de scission partielle, entre la Société Scindée et la Société Bénéficiaire, par transfert de l’ensemble de l’actif et
du passif d’une partie du commerce de pétrole de la Société Scindée, sans restriction ou limitation aucune, à la Société
Bénéficiaire, sans liquidation de la Société Scindée.
4. Réduction du capital social émis de la Société Scindée d’un montant de six millions cinq cent cinquante-deux mille
quatre cent cinquante-sept euros et deux centimes (EUR 6.552.457,02) afin de le réduire de son montant actuel de seize
millions sept cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 16.775.588,-) à dix millions deux cent
vingt-trois mille cent trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 10.223.130,98), sans annulation de parts sociales.
5. Modification du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société Scindée, afin de refléter la réduction du capital
social de la Société Scindée.
6. Fixation de la date d’effet de la Scission.
7. Délégation de tous pouvoirs nécessaires au conseil de gérance de la Société Scindée afin de mettre en oeuvre les
résolutions adoptées sur la base des points de l’ordre du jour ci-dessus.
Le notaire soussigné confirme que:
a) un projet de scission partielle a été rédigé conjointement par le conseil de gérance de la Société Scindée et par le
conseil de gérance de la Société Bénéficiaire en date du 18 février 2015 (le «Projet de Scission»);
b) les présentes résolutions de l'associé unique de la Société Scindée sont prises au moins un (1) mois après la publi-
cation du Projet de Scission au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 490 du 23 février 2015;
c) la renonciation des détenteurs de titres de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire du 17 février 2015,
conformément à l’article 296 (2) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la
«Loi») concernant le rapport de scission du conseil de gérance de la Société Scindée et du conseil de gérance de la Société
Bénéficiaire (la «Renonciation au Rapport de Scission»);
52446
L
U X E M B O U R G
d) la renonciation des détenteurs de titres de la Société Scindée et de la Société Bénéficiaire du 17 février 2015,
conformément à l’article 296 (1) de la Loi concernant le rapport d’expert sur le Projet de Scission (la «Renonciation au
Rapport d’Expert»);
e) les documents requis par l'article 295 de la Loi ont été déposés au siège social de la Société Scindée et de la Société
Bénéficiaire, pour inspection par les associés et personnes titulaires de droits spéciaux contre la Société Scindée ou la
Société Bénéficiaire et ce, un (1) mois au moins avant la date des présentes résolutions; et
f) conformément à l’article 302 de la Loi, la Scission deviendra effective vis-à-vis des tiers à la date de la publication
des résolutions de l'associé unique de la Société Scindée et de l’associé unique de la Société Bénéficiaire approuvant la
Scission au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'Associé a requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Après avoir pris connaissance de la Renonciation au Rapport de Scission et à la Renonciation au Rapport d’Expert,
l'Associé décide d'approuver le Projet de Scission et la Scission telle que plus amplement décrite dans le Projet de Scission,
au terme de laquelle l’ensemble de l’actif et du passif d’une partie du commerce de pétrole de la Société Scindée sera
transféré, sans restriction ou limitation aucune, à la Société Bénéficiaire, sans liquidation de la Société Scindée.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé décide de réduire le capital social émis de la Société Scindée d’un montant de six millions cinq cent cinquante-
deux mille quatre cent cinquante-sept euros et deux centimes (EUR 6.552.457,02) afin de le réduire de son montant
actuel de seize millions sept cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-huit euros (EUR 16.775.588,-) à dix millions
deux cent vingt-trois mille cent trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes (EUR 10.223.130,98), sans annulation de
parts sociales.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé décide de modifier le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société Scindée, afin de refléter la réduction
du capital social de la Société Scindée.
Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:
«Le capital social est fixé à dix millions deux cent vingt-trois mille cent trente euros et quatre-vingt-dix-huit centimes
(EUR 10.223.130,98) divisé en soixante mille (60.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.».
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé décide que la Scission sera effective entre la Société Scindée et la Société Bénéficiaire le 25 mars 2015 à 8:00
heures.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé décide de nommer tout gérant de la Société Scindée, chacun agissant individuellement, avec pouvoir de
substitution, comme son mandataire afin de mettre en oeuvre les résolutions ci-avant adoptées, et accomplir tous les
actes de quelque nature qu'ils soient nécessaires ou utiles afin que la Scission soit intégralement réalisée et, en particulier
mais non exclusivement, afin de déposer et d'accomplir auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
toutes les déclarations et formalités relatives à la Société Scindée afin de rendre la Scission effective.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'article 300 (2) de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité,
en droit luxembourgeois, du Projet de Scission ainsi que des actes juridiques et formalités imposés afin de rendre la
Scission effective entre la Société Scindée et la Société Bénéficiaire.
Conformément à l’article 303 (2) de la Loi, sont transférés à la Société Bénéficiaire les immeubles suivants:
<i>Remarquei>
Il résulte d’une lettre émanant de la Commune de Schengen datée du 02 mars 2015 que le collège des bourgmestre
et échevins de ladite commune a décidé d’autoriser la société ESSO Luxembourg de céder le contrat de concession d’un
droit de superficie pour la station d’essence de Remerschen relatée sub. 7.- qu'elle a acquis aux termes d’un acte de
concession d’un droit de superficie reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, le 10 octobre
2005, ci-après relaté.
1.- La station d’essence ESSO DUDELANGE sise au 132, route de Luxembourg à L-3515 Dudelange, inscrite au
cadastre comme suit:
Commune de Dudelange, section B de Burange:
- numéro 20/4654, lieu-dit «route de Luxembourg», place, d’une contenance de 04 ares 92 centiares.
- numéro 19/5608, même lieu-dit, place, d’une contenance de 13 ares 71 centiares.
- numéro 20/4478, même lieu-dit, place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 10 ares 42 centiares.
52447
L
U X E M B O U R G
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 20/4654 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur la dame Joséphine SCHNEIDER et le sieur Marc HOFERLIN aux termes d’un acte de vente reçu par le
notaire soussigné, alors de résidence à Hesperange, en date du 19 juin 2002, transcrit au deuxième bureau des Hypo-
thèques à Luxembourg, le 11 juillet 2002, volume 1335, numéro 45.
- Le numéro cadastral prédésigné 19/5608 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
* partiellement sur les consorts PAULY aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André Schwachtgen, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 27 novembre 1987, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 21 décembre 1987, volume 715, numéro 106.
* partiellement sur la dame Berthe SCHNEIDER aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire André Schwacht-
gen, alors de résidence à Luxembourg, en remplacement du notaire Francis KESSELER, alors de résidence à Esch-sur-
Alzette, en date du 27 novembre 1987, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 21 décembre
1987, volume 715, numéro 107.
- Le numéro cadastral prédésigné 20/4478 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur les époux Camille REITER-SCHNEIDER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles
FUNCK, alors de résidence à Luxembourg, en date du 09 septembre 1965, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 16 septembre 1965, volume 202, numéro 36.
2.- La station d’essence ESSO CHARLES DE GAULLE sise au 306, boulevard Charles de Gaulle à L-4083 Esch-sur-
Alzette, inscrite au cadastre comme suit:
Commune d’Esch-sur-Alzette, section A d’Esch-Nord:
- numéro 2347/13801, lieu-dit «Boulevard Charles de Gaulle», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance
de 15 ares.
- numéro 2347/15835, même lieu-dit, place (occupée), station d’épuration, d’une contenance de 07 ares 26 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 2347/13801 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur les époux Jean-Claude VENANZI-ARMENZANI aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire
soussigné, alors de résidence à Hesperange, en date du 1
er
août 2001, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 10 septembre 2001, volume 1293, numéro 102.
- Le numéro cadastral prédésigné 2347/15835 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur le sieur Nico GOUBER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André SCHWACHTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 07 janvier 1993, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxem-
bourg, le 22 janvier 1993, volume 916, numéro 96.
3.- La station d’essence ESSO FRISANGE sise au 24, rue Robert Schuman à L-5751 Frisange, inscrite au cadastre comme
suit:
Commune de Frisange, section B de Frisange:
- numéro 1070/2637, lieu-dit «Robert Schuman Strooss», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de
30 ares 90 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 1070/2637 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg):
- partiellement sur les époux Jean AREND-FRANZEN aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles
MICHELS, alors de résidence à Luxembourg, en date du 20 mai 1960, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à
Luxembourg, le 31 mai 1960, volume 117, numéro 162.
- partiellement sur la dame Doris BINTENER aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire André SCHWACHT-
GEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 5 novembre 1984, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à
Luxembourg, le 29 novembre 1984, volume 634, numéro 114.
4.- La station d’essence ESSO SANDWEILER sise au 1, route de Remich à L-5250 Sandweiler, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Sandweiler, section A de Sandweiler:
- numéro 984/3923, lieu-dit «rue de Remich», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 06 ares 61
centiares.
- numéro 987/3097, lieu-dit «rue d’Oetrange», place (occupée), bâtiment à habitation, d’une contenance de 07 ares
17 centiares.
52448
L
U X E M B O U R G
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 984/3923 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg):
- partiellement sur le sieur Joseph GAASCH aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Marie-Joseph KINTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 10 décembre 1955, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Lu-
xembourg, le 10 décembre 1955, volume 57, numéro 118.
- partiellement sur les époux Jean-Pierre HOFFMANN aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Marie-Joseph
Kintgen, alors de résidence à Luxembourg, en date du 05 septembre 1956, transcrit au premier bureau des Hypothèques
à Luxembourg, le 19 septembre 1956, volume 80, numéro 110.
- partiellement sur le sieur Pierre MALLER-BAUER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Jacques Faber,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 03 mai 1960, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 25 mai 1960, volume 187, numéro 116.
- partiellement sur l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d’un acte d’échange sous seing-privé, en date
du 24 octobre 1980, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 25 novembre 1980, volume 864,
numéro 65.
- Le numéro cadastral prédésigné 987/3097 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur la dame Alice THOSS aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André SCHWACHTGEN,
alors de résidence à Luxembourg, en date du 25 février 1986, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 06 mars 1986, volume 1042, numéro 126.
5.- La station d’essence ESSO STEINFORT sise au 105, rue de Luxembourg à L-8440 Steinfort, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Steinfort, section A de Steinfort:
- numéro 572/2733, lieu-dit «rue de Luxembourg», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 12
ares 82 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 572/2733 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg) sur le sieur Jean CLEMENT aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 20 septembre 1967, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 22 septembre 1967, volume 237, numéro 43.
6.- La station d’essence ESSO SENNINGERBERG sise au 40, route de Trèves à L-2633 Senningerberg, inscrite au
cadastre comme suit:
Commune de Niederanven, section B de Senningen:
- numéro 1190/4163, lieu-dit «route de Trèves», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 34 ares
98 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 1190/4163 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
- partiellement sur les consorts KILL aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Christine DOERNER, de
résidence à Bettembourg, et le notaire Reginald NEUMAN, alors de résidence à Bascharage, en date du 1
er
octobre
1987, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 27 octobre 1987, volume 1100, numéro 156.
- partiellement sur le sieur Nico FELLER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire soussigné, alors de résidence
à Hesperange, en date du 09 avril 2001, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 10 mai 2001,
volume 1683, numéro 13.
7.- Un droit de superficie dans un terrain ci-après désigné sur lequel la station d’essence ESSO REMERSCHEN sise au
3, Schengerwis à L-5439 Remerschen est exploitée, inscrit au cadastre comme suit:
Commune de Schengen, ancienne commune de Remerschen, section RC de Flouer:
- numéro 1940/4930, lieu-dit «Schengerwis», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 1 hectare
05 ares 71 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le prédit droit de superficie du prédit numéro cadastral prédésigné 1940/4930 a été acquis par la société ESSO
Luxembourg S.A. (actuellement ESSO Luxembourg) sur l’Administration Communale de Remerschen aux termes d’un
acte de concession d’un droit de superficie reçu par le notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg, en date
du 10 octobre 2005, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 27 janvier 2006, volume 1970,
numéro 88.
52449
L
U X E M B O U R G
8.- La station d’essence ESSO DIFFERDANGE sise au 70, avenue de la Liberté à L-4601 Differdange, inscrite au cadastre
comme suit:
Commune de Differdange, section A de Niedercorn:
- numéro 2567/7773, lieu-dit «avenue de la Liberté», place (occupée), bâtiment non défini, d’une contenance de 17
ares 53 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
Le numéro cadastral prédésigné 2567/7773 a été acquis par la société ESSO Luxembourg S.A. (actuellement ESSO
Luxembourg):
- partiellement sur le sieur Charles HAUSEMER aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK,
alors de résidence à Luxembourg, et le notaire Jean-Pierre BOURG, alors de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 25
septembre 1968, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le 18 octobre 1968, volume 253, numéro
79.
- partiellement sur les consorts HESSE aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Charles FUNCK, alors de
résidence à Luxembourg, en date du 21 juillet 1969, transcrit au deuxième bureau des Hypothèques à Luxembourg, le
20 août 1969, volume 268, numéro 55.
- partiellement sur la société GENERAL ELECTRONICS S.A. aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire André
SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 05 juin 1989, transcrit au deuxième bureau des Hypo-
thèques à Luxembourg, le 03 juillet 1989, volume 767, numéro 145.
9.- La station d’essence ESSO REMICH sise au 9, route de l’Europe à L-5531 Remich, inscrite au cadastre comme suit:
Commune de Remich, section A des Bois:
- numéro 425/1913, lieu-dit «route de l’Europe», place (occupée), bâtiment commercial, d’une contenance de 07 ares
41 centiares.
<i>Titre de propriétéi>
- Le numéro cadastral prédésigné 425/1913 a été acquis par la société ESSO Standard (Luxembourg) S.A. (actuellement
ESSO Luxembourg) sur les consorts WOLTZ aux termes d’un acte d’échange reçu par le notaire Charles MICHELS, alors
de résidence à Luxembourg, en date du 09 novembre 1962, transcrit au premier bureau des Hypothèques à Luxembourg,
le 28 novembre 1962, volume 263, numéro 130.
<i>Dépensesi>
Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués
à deux mille euros (2.000.-EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du mandataire de la
comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande au même
mandataire, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire instrumen-
taire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: J.-P. SPANG, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 25 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9205. Reçu soixante-quinze euros
75,00 EUR.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 avril 2015.
Référence de publication: 2015058088/517.
(150066755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 avril 2015.
Advent Energy, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 112.512.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 mars 2015.
Référence de publication: 2015042125/10.
(150048309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 mars 2015.
52450
L
U X E M B O U R G
Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SI-
CAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 196.165.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second day of April,
Before Maitre Pierre PROBST, notary residing in Ettelbruck (Grand Duchy of Luxembourg)
There appeared:
“Alceda Fund Management S.A.“ incorporated in Luxembourg on January 1, 2007 as a public limited company; regis-
tered at the Registrar of Companies of Luxembourg under registration number B 123356 with registered office at 5,
Heienhaff L-1736 Senningerberg
here represented by
Ms. Nadine Closter, professional address in L-9087 ETTELBRUCK, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy
given dated 25
th
March 2015;
The proxy given, signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary shall remain annexed to the
present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to enact these Articles of Association
of a societe d' investissement a capital variable, which it declares to incorporate between themselves:
Title I. Name - Registered office - Duration - Purpose
Art. 1. Definitions. "Accounting Principles" means the Lux GAAP;
"Affiliate" means, with respect to an entity, any other entity that, directly or indirectly, controls, is under common
control with, or is controlled by such entity. For the purposes of this definition, control (including, with its correlative
meanings, the terms “controlled by” and “under common control with”), as used with respect to any entity, shall mean
the possession, directly or indirectly, of the power to direct or cause the direction of the management and policies of
such entity, whether through the ownership of voting securities or by contract or otherwise;
"AIFM" means the alternative investment fund manager appointed by the Company, initially Alceda Fund Management
S.A.;
"AIFM Directive" means Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council on Alternative Invest-
ment Fund Managers, amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU)
No 1095/2010;
"Articles" means these articles of incorporation of the Company as amended from time to time;
"Auditor" means a firm of international accountants appointed by the general assembly of Shareholders as shall serve
as auditor of the Company from time to time;
"Benefit Plan Investor" means the investors defined in the Plan Assets Regulation as (a) any employee benefit plan (as
defined in Section 3(3) of ERISA) that is subject to the provisions of Title of ERISA, (b) any plan that is subject to Section
4975 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended., and (c) any entity whose underlying assets include plan
assets by reason of a plan's investment in the entity (to the extent of such plan's investment in the entity);
"Board of Directors" means the management board of the Company;
"Business Day" means a weekday on which banks are normally open for business in Germany and Luxembourg;
"Capital Contribution" means, in respect of each Shareholder, the part of each Shareholder's Commitment which has
been drawn down and paid to the Company, and which has not been refunded and again added to the undrawn Com-
mitment;
"Central Administration Agent" means the central administration agent appointed by the Company, initially Warburg
Invest Luxembourg S.A.;
"Commitment" means the amount as set out in the relevant Subscription Agreement and accepted by the Board of
Directors in the relevant Subscription Agreement as the maximum amount the Shareholder will provide for the issuance
of Shares to the Shareholder;
"Company" means Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-SIF;
"Company Law" means the Luxembourg law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended and restated
from time to time;
"Depositary" means the depositary appointed from time to time by the Company in compliance with the Law of 2007;
"Eligible Investors" means Institutional Investors, Professional Investors and/or other Well-informed Investors who
are not a Prohibited Persons or a FATCA Relevant Person;
"ERISA" means the U.S. Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended from time to time;
52451
L
U X E M B O U R G
"Euro" or "EUR" means Euro the legal currency of the European Monetary Union;
"FATCA" means: (a) sections 1471 to 1474 of the U.S. Internal Revenue Code of 1986 or any associated regulations
or official guidance; (b) any treaty, law, regulation or other official guidance enacted in any other jurisdiction, or relating
to an intergovernmental agreement between the U.S. and any other jurisdiction, which (in either case) facilitates the
implementation of paragraph (a) above, it being understood that if a multipartite agreement involving the U.S. also contains
rules relating to the on tracting states other than the U.S. such parts of the agreement are not falling under the FATCA
definition; or (c) any agreement pursuant to implementation of paragraphs (a) or (b) above with the U.S. Internal Revenue
Service, the U.S. government or any governmental or taxation authority in any other jurisdiction.
"FATCA Relevant Person" means any person falling under: (a) sections 1471 to 1474 of the U.S. Internal Revenue
Code of 1986 or any associated regulations or official guidance; (b) any treaty, law, regulation or other official guidance
enacted in any other jurisdiction, or relating to an intergovernmental agreement between the U.S. and any other juris-
diction, which (in either case) facilitates the implementation of paragraph (a) above, it being under-stood that if a multi-
partite agreement involving the U.S. also contains rules relating to the contracting states other than the U.S. such parts
of the agreement are not falling under the FATCA definition; or (c) any agreement pursuant to implementation of para-
graphs (a) or (b) above with the U.S. Internal Revenue Service, the U.S. government or any governmental or taxation
authority in any other jurisdiction.
"Final Closing" means the earlier of (i) the Board of Directors having accepted aggregate Commitments equaling the
EUR 250 million or (ii) 31 December 2016;
"Fiscal Year" means the calendar year, commencing on 1 January and ending on 31 December;
"First Closing" means the date of the first closing of the Company once the Company has received and accepted
aggregate Commitments of at least EUR 25 million;
"Hydropower Company" means any of the Hydropower Investment intermediate vehicles, whether or not having legal
personality or being a special purpose vehicle, which directly or indirectly holds primarily Hydropower Facilities and/or
licenses to develop or construct such facilities and which may also hold other assets, if such assets are ancillary to the
main investment strategy and investment objective of the Fund;
"Hydropower Facilities" mean hydroelectric power plants generating electricity through the gravity force of falling or
flowing water, transforming the kinetic energy into electricity by using a water turbine and generator as well as any
installation to store, transform or transmit such energy or electricity.
Hydroelectricity can be produced trough dam and reservoir as well as runof- the-river hydroelectric power plants;
"Hydropower Investment" means any investment made by the Company in one or more Hydropower Facilities directly
or indirectly through one or more Hydropower Companies;
"Indemnified Parties" means the members of the Board of Directors, members of the AdvisoryBoard, each of the
managers, authorised officers, employees, executors and administrators, as well as each member of Service Provider of
the Company and the AIFM, to the extent directly involved in the business of the Company (and individually an "Indem-
nified Party");
"Independent Appraiser" means the person appointed by the AIFM from time to time;
"Institutional Investor" means any Shareholder who qualifies as institutional investor according to the Luxembourg
laws and regulation and, within those laws and regulations, Semi-Professional Investors;
"Investment Period" means the period from the Final Closing until the third anniversary of the Final Closing date;
"Investment Policies" means the investment strategy and policy of the Company as set out in the Issuing Document;
"Investor" means any Shareholder of the Company;
"Issuing Document" means the issuing document for the offering of the Shares of the Company dated of today, as may
be amended from time to time;
"Law of 1915" means the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to
time;
"Law of 2007" means the Luxembourg law of 13 February 2007 relating to specialized investment funds, as amended
from time to time;
"Law of 2013" means the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers as amended from
time to time;
"Lux GAAP" means the generally accepted accounting principles under the laws of Luxembourg.
"Management Agreement" means the management agreement between the Company and the AIFM;
"Net Asset Value" means the value of the net assets in EUR of the Company on a Valuation Date determined in
accordance with the Accounting Principles and in accordance with Article 12;
"Paying Agent" means the paying agent appointed by the Company, initially M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.;
"Person" means any natural or legal person which is not a Shareholder;
"Plan Assets Regulation" means the regulation issued by the U.S. Department of Labor (29 CFR Section 2510.3-101),
as modified by Section 3(42) of ERISA;
52452
L
U X E M B O U R G
"Professional Investor" means any Investor who qualifies as professional investors under annex II of Directive 2004/39/
EC, as amended;
"Prohibited Persons" mean a person who is not authorized to hold Shares in the Company as further described in
Article 10;
"Registrar and Transfer Agent" means the registrar and transfer agent appointed by the Company, initially M.M.War-
burg & CO Luxembourg S.A.;
"Semi-Professional Investor" means any (prospective) Shareholder residing in Germany and meeting the criteria as set
out in section 1, para. 19, No.33 of the German Capital Investment Code (Kapitalanlagegesetzbuch, KAGB), as amended
from time to time;
"Service Providers" mean collectively the Depository, Paying Agent, Registrar and Transfer Agent and Central Admi-
nistration Agent;
"Shareholders" means any person who has signed a Subscription Agreement and subsequently acquires and holds the
Shares, as the context may require, and "Shareholder" means any one of them;
"Shares" mean the ordinary shares of no nominal value issued by the Company in compliance with the provisions of
the Issuing Document;
"Subscription Agreement" means each of the subscription agreements entered into between the Company and any
Shareholder in relation to the subscription for Shares issued by the Company setting forth, among other things, (i) the
amount of money that the Shareholder has committed, (ii) the rights and obligations of the Shareholder in relation to the
subscription of Shares;
"Subscription Request" means with respect to an Investor, a request to subscribe for a portion of Shares issued in
accordance with the terms and conditions of a Subscription Agreement.
"Transfer" means, with respect to Shares, to transfer, sell, donate, exchange, convey, assign, pledge, hypothecate, create
a security interest in or lien on (other than in connection with a borrowing for the Company), place in trust (voting or
otherwise), transfer by operation of law or in any other way subject to encumbrance, or dispose of, whether or not
voluntarily;
"U.S. Person" has the meaning ascribed to that term in the Regulation S of the United States Security Act of 1933, as
amended from time to time, including for the avoidance of doubt, any Benefit Plan Investor;
"Valuation Date" has the meaning given to such term in Article 12;
"Well-informed Investor" means any Investor who (i) adheres in writing to the status of well-informed investors and
(ii) either (x) invests a minimum one hundred and twenty-five thousand Euros (EUR 125,000.-) in the Company or (y)
benefits from a certificate delivered by a credit institution within the meaning of Directive 2006/48/EC or an investment
firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or a management company within the meaning of Directive 2001/107/
EC stating that it has experience enough to appreciate in adequate manner an investment in the Company.
All references herein to time are to Central European Time (CET) unless otherwise indicated.
Words importing the singular shall, where the context permits, include the plural and vice versa.
Art. 2. Name and form. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of
Shares hereafter issued, a public limited company ("societe anonyme") qualifying as an investment company with variable
share capital ("societe d'investissement à capital variable-fonds d'investissement specialise") subject to the Law of 2007
and the Law of 2013 and the Law of 1915 under the name of Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-
SIF.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand
Duchy of Luxembourg.
Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
decision of the Board of Directors. Within the same municipality, the registered office may be transferred through simple
resolution of the Board of Directors.
Art. 4. Duration. The Company is established for a limited period which expires on the twentieth anniversary of the
Final Closing. The term of the Company may be extended for two (2) successive periods of three (3) years by decision
of the Board of Directors, provided that the Board of Directors may only prolong the term of the Company if it determines
in its discretion, within the two Fiscal Years immediately preceeding the Fiscal Year in which the then regular term of the
Company expires, that such prolongation would be in the best interest of the Shareholders, with the view to achieve a
more favorable exit from Hydropower Investments, or for the Company as a whole.
The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in the manner described
hereof and if the Management Agreement is terminated in accordance with the provisions of the Issuing Document and
no new AIFM has been appointed.
Art. 5. Purpose. The exclusive purpose of the Company is to invest the funds available to it, in securities and other
assets permitted by the Law of 2007, with the purpose of spreading investment risks and affording its Shareholders the
52453
L
U X E M B O U R G
results of the management of its assets. The Company may take any measures and carry out any transaction which it may
deem useful for the fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the Law of 2007.
Title II. Share capital - Shares - Net Asset Value
Art. 6. Share Capital. The capital of the Company shall be represented by Shares of no nominal value and shall at any
time be equal to the total net assets of the Company pursuant to Article 12 hereof.
The minimum capital shall be as provided by law i.e. one million two hundred and fifty thousand Euros (EUR 1,250,000.-).
The minimum capital of the Company must be reached within twelve (12) months after the date on which the Company
has been authorized as a specialized investment fund under the Law of 2007.
The Reference Currency of the Company is the Euro.
The Shares are to be issued pursuant to Article 8 hereof.
The Shares entitle the Shareholders thereof to distribution rights as further described under Article 27 "Distributions".
The Shares shall have voting rights at the general meetings of Shareholders.
Upon incorporation of the Company, the initial capital was thirty-one thousand Euros (EUR 31,000.-) of no nominal
value. The Company's share capital shall vary, without any amendment of the Articles, as a result of the Company issuing
new Shares or redeeming its Shares.
The proceeds of the issue of the Shares shall be invested in Hydropower Investments pursuant to the investment
strategy, policy and criteria established in the Issuing Document, subject to the diversification requirement set forth by
law or otherwise agreed among the Shareholders.
The Board of Directors will adopt such provisions as are necessary to ensure that any preferential treatment accorded
to a Shareholder by the Company, or by the AIFM with respect to the Company will not result in an overall material
disadvantage to other Shareholders, as further disclosed in the Issuing Document.
Shares will be exclusively restricted to Investors who qualify as Eligible Investors. The Company will not issue or give
effect to any transfer of Shares to any person which does not comply with this provision.
Art. 7. Form of Shares. Shares shall only be issued in registered form.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders which shall be kept by the Registrar
and Transfer Agent or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the
name of each owner of record of registered Shares, its residence or elected domicile as indicated to the Company, the
number of registered Shares held by the owner of record and the amount paid-up on each fractional share.
The inscription of the Shareholder's name in the register of Shares evidences the Shareholder's right of ownership on
such registered shares.
The Shareholder shall receive a written confirmation of his shareholding.
Shareholders entitled to receive registered Shares shall provide the Company with an address to which all notices and
announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of Shareholders.
In the event that a Shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of
the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time, until another
address shall be provided to the Company by such Shareholder. A Shareholder may, at any time, change the address as
entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or
at such other address as may be set by the Company from time to time.
The Board of Directors may impose restrictions on the frequency at which Shares shall be issued; the Board of
Directors may, in particular, decide that Shares shall only be issued during one or more offering periods or at such other
periodicity as provided for in the Issuing Document.
Shares will be issued to Shareholders only on a fully paid basis and up to an amount equivalent to each Shareholder's
aggregate Commitment.
During the Initial Subscription Period, Shares will be issued for an amount of EUR 1,000 per Share. After the end of
the Initial Subscription Period, or such earlier date as determined by the AIFM, the issue price per Share shall be the latest
Net Asset Value per Share.
The Board of Directors may determine any other subscription conditions such as minimum subscriptions, default
interests or restrictions on ownership. Such other conditions shall be disclosed
and detailed in the Issuing Document, the Subscription Agreement. The Board of Directors may delegate to any
director, manager, officer or other duly authorised agent the power to accept subscriptions, to receive payment of the
price of the new Shares to be issued and to allot them and record the subscription in the register of Shareholders.
The Company recognizes only one (1) single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the
ownership of Shares is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one (1) single attorney to
represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the exercise
of all rights attached to such Share(s).
52454
L
U X E M B O U R G
Moreover, in the case of joint Shareholders, the Company reserves the right to pay any redemption proceeds, distri-
butions or other payments to the first registered holder only, whom the Company may consider to be the representative
of all joint holders, or to all joint Shareholders together, at its absolute discretion.
Each Share grants the right to one (1) vote at the general meetings of Shareholders.
The Company may decide to issue fractional Shares rounded up by two decimal places. Such fractional Shares shall
not be entitled to vote, except to the extent their number is so that they represent a whole Share, but shall be entitled
to participate in the net assets attributable to the Shares on a pro rata basis.
Art. 8. Issue of Shares. The Board of Directors may with the prior approval of a seventy-five percent (75%) majority
vote of the extraordinary general meeting of Shareholders and without reserving the existing Shareholders a pre-emptive
or a preferential right to subscribe, (i) issue or create new shares other than the Shares,or (ii) alter the rights attaching
to the Shares, or (iii) increase, consolidate, sub-divide or convert any of the Shares.
Art. 9. Redemption, Transfer and Conversion of Shares. The Company is a closed-ended investment fund. Conse-
quently, Shares in the Company shall not be redeemable at the request of a Shareholder.
Shares may be compulsorily redeemed (i) in accordance with Article 10 in the event that any Shares are held directly
or indirectly by any person who no longer qualifies as an Eligible Investor (either alone or in connection with any other
person) or (ii) in case a Shareholder is declared a "Defaulting Shareholder" as defined in the Issuing Document and the
relevant default is not cured within 30 calendar days after the date on which the relevant amount became due and payable.
In such case,
the redemption price shall be determined in accordance with the provisions set out in the Issuing Document.
All redeemed Shares may be cancelled.
Shares may only be transferred under the conditions described in the Issuing Document.
Art. 10. Restrictions on Ownership of Shares. Shares are exclusively available to the Eligible Investors.
The Company may restrict or reject any application for Shares in the Company by any person and may cause any
Shares to be subject to compulsory redemption (i) in accordance with the provisions set out the Issuing Document or
(ii) if the Company considers that this ownership involves a violation of the law of the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad, or may involve the Company in being subject to taxation in a country other than the Grand Duchy of Luxembourg
or may in some other manner be detrimental to the Company ("Prohibited Person").
For such purposes the Company may:
A.- refuse the issuance of Shares or the registration of a disposal of Shares if there are any indications that this
registration or this disposal lead to a legal or economic ownership of Shares of any person who no longer qualifies as
Eligible Investor;
B.- request from any person whose name is registered in the share register or any person which tries to register its
Shares in the share register to provide the Company with the relevant information and make an affirmation, which the
Board of Directors considers necessary to decide whether any person who no longer qualifies as Eligible Investor is the
economic owner of Shares, or the relevant registration of Shares shows an economic ownership of any person who no
longer qualifies as Eligible Investor; and/or
C.- redeem the Shares compulsorily with a 15-day period of notice. In the event of the redemption of Shares, the
person who no longer qualifies as Eligible Investor is no longer owner of the Shares. The costs and expenses of the
compulsory redemption of Shares shall be borne by the redeeming Shareholder. Shares shall be redeemed at their Net
Asset Value as determined at time of redemption subject to a discount of 20%. Payment of the redemption price can be
made in intervals at the Board of Directors' discretion, at the latest in the event of the liquidation of the Company.
In compliance with the Issuing Document, U.S. Persons as defined in these Articles may constitute a specific category
of Prohibited Persons except in the case where the Company receives evidence satisfactory to it that the acquisition of
Shares by such a Shareholder is exempt from registration under the securities laws of the United States including, but
not limited to, the United States Securities Act of 1933, as amended and that, in all events there will be no adverse tax
consequences to the Company or to Investors as a result of such an acquisition.
Art. 11. Right of First Refusal.
(a) In the event that (i) a Shareholder (the "Transferor") wishes or proposes to Transfer any of its Shares to any party
(the "Transferee") except for a Transfer falling under the scope of Section 7.3.2 of the Issuing Document, or (ii) a Defaulting
Shareholder is requested by the Company to sell its Shares (a "Default Sale") in the event that the default is not cured
within 30 calendar days of the date on which the relevant amount became due and payable, the other Shareholders, except
for any Defaulting Shareholder (each, an "Offeree"), shall have a right of first refusal (the "First Refusal Right") with respect
to such Transfer or Default Sale in accordance with this Article 11.
(b) Transfer Notice or Default Sales Notice
(i) Before entering into any transfer agreement with any potential Transferee, the Transferor shall first send a written
notice (the "Transfer Notice") to the Company which notice shall state (i) the name of the Transferor, (ii) the number
of Shares to be transferred (the "Offered Shares"), (iii) the name and address of the Transferee, (iv) the total value of the
52455
L
U X E M B O U R G
consideration for the proposed Transfer (the "Offer Price") and (v) the other terms and conditions of the proposed
Transfer by submission of the execution version of the relevant transfer agreement. The Company shall without undue
delay forward the Transfer Notice to the Offerees by way of registered mail, facsimile or email.
(ii) In the event of a Default Sale, the Company shall send a written notice by way of registered mail, facsimile or email
(the "Default Sales Notice") to the Offerees which notice shall state (i) the name of the Defaulting Shareholder, (ii) the
number of Shares to be sold (the "Default Shares"),
(iii) the total purchase price for the Default Shares, which shall be equal to the Net Asset Value as determined by the
last valuation available upon declaration of the status of the Defaulting Shareholder and subject to a discount of 20% (the
"Sale Price") and (v) the other key terms and conditions of the Default Sale.
(c) Acceptance Notice
(i) For a period of ten (10) Business Days after receipt of a Transfer Notice or a Default Sales Notice, as the case may
be (the "Offer Period"), the Offerees shall have the right, exercisable by each Offeree through the delivery of an Accep-
tance Notice as provided in Article 11(c)(ii), to purchase in aggregate all of the Offered Shares, or the Default Shares, as
the case may be, at a purchase price equal to the Offer Price, or Sale Price, as the case may be, and upon the other terms
and conditions set forth in the Transfer Notice or the Default Sales Notice, as the cas may be. For the avoidance of doubt,
each Offeree shall have the right to purchase a minimum number of Offered Shares, or the Default Shares (such Offeree's
"First Refusal Allocation") that is equal to the total number of the Offered Shares, or the Default Shares, each multiplied
by a fraction, the numerator of which is the number of Shares held by such Offeree and the denominator of which is the
total number of Shares held by all Offerees.
(ii) The First Refusal Right of each Offeree shall be exercisable by each Offeree delivering written notice of exercise
(an "Acceptance Notice") within the Offer Period to the Company, with a copy to each of the other Offerees. Each
Acceptance Notice shall indicate (i) such Offeree's intention to exercise its First Refusal Right and (ii) the maximum
number of Offered Shares or Default Shares, as the case may be, that such Offeree is willing to purchase. An Acceptance
Notice shall be irrevocable and shall constitute a binding agreement by such Offeree to purchase the relevant number of
Offered Shares, or Default Shares, as the case may be, as determined in accordance with Articles 11(b)(ii) and 11(d). The
failure of an Offeree to give an Acceptance Notice within the Offer Period shall be deemed to be a waiver of such Offeree's
First Refusal Right.
(d) Non-Electing Offerees
In the event that one or more Offerees ("Non-Electing Offerees") declines or is deemed pursuant to Article 11(c)(ii)
to have waived its First Refusal Right, each Offeree electing to exercise its First Refusal Right (an "Electing Offeree") shall
have the right as provided in Article 11(c)(ii) to purchase all or a portion of the Offered Shares or the Default Shares,
constituting the aggregate First Refusal Allocations of the Non-Electing Offerees (the "Excess Offered Shares").
(e) Allocation of Excess Offered Shares
Each Electing Offeree shall have the right to purchase the number of Excess Offered Shares calculated based on the
Electing Offeree's Acceptance Notice; provided that, if the number of Excess Offered Shares is less than the aggregate
number of Excess Offered Shares that the Electing Offerees have indicated to purchase, the Excess Offered Shares shall
be allocated in a manner that each Electing Offeree shall have a right to purchase (i) not less than the total number of
Excess Offered Shares multiplied by a fraction, the numerator of which is the number of Shares held by such Electing
Offeree and the denominator of which is the total number of Shares held by all Electing Offerees, and (ii) not more than
the maximum number of Offered Shares or Default Shares, as the case may be, specified in such Electing Offeree's
Acceptance Notice. The Company shall calculate and determine the amount of Offered Shares or the Default Shares, as
the case may be, to be allocated to each Electing Offeree within five (5) Business Days upon the expiration of the Offer
Period.
(f) Consequences of Exercise of First Refusal Right
(i) Transfer to third party
The Transferor shall, without undue delay, enter into a transfer agreement with each Electing Offeree based on the
Offer Price and the other terms and conditions set forth in the Transfer Notice.
If not all of the Offered Shares have been elected to be purchased by the Electing Offerees, the Transferor may Transfer
all of the Offered Shares not sellable to the Offerees, to the Transferee identified in the Transfer Notice based on the
Offer Price and the other terms and conditions as set forth in the Transfer Notice; provided, however, that if the Company
determines that the terms and conditions in the transfer agreement have materially deviated from those in the Transfer
Notice, the restrictions provided for herein shall again become effective, and no Transfer of Shares may be made by the
Transferor thereafter without again making an offer to the other Shareholders in accordance with this Article 11.
(ii) Default Sale
The Defaulting Shareholder shall, without undue delay, enter into a transfer agreement with each Electing Offeree
based on the Sale Price and the other terms and conditions set forth in the Default Sales Notice. If not all of the Default
Shares have been elected to be purchased by the Electing Offerees, the remaining Default Shares shall be sold by the
Company at the highest price a third party is willing to pay after a period of having approached such parties within two
(2) months following the offer of the Default Shares to the Offerees.
52456
L
U X E M B O U R G
(iii) Any stamp duty or transfer taxes or fees payable on the Transfer of any Offered Shares or sale of any Default
Shares, as the case may be, shall in principle be borne and paid by the Transferor or Defaulting Shareholder, if not agreed
otherwise in the transfer documentation, whereby the Company is under no obligation to agree on such provision in
case of a Default Sale.
Art. 12. Calculation of Net Asset Value per Share.
(a) The Net Asset Value shall be calculated by the Central Administration Agent, under the responsibility of the AIFM,
at least once a year on 31 December of each calendar year (the "Valuation Date"), in accordance with Lux GAAP and
the valuation rules set forth below. The Net Asset Value will be expressed in Euro.
The Annual Report shall include the basis of the calculation, e.g. all relevant parameters used. All valuation policies are
subject to the laws of Luxembourg and to be interpreted accordingly. The Net Asset Value is calculated by subtracting
liabilities and provisions from the fair asset value on each Valuation Date.
(b) The valuation should take into account the following guidelines:
(i) Assets that are admitted to trading on a stock exchange or traded on an organized market Assets that are traded
on a stock exchange or included in another organized market are valued at their respective listed prices, unless (i) the
"Valuation methodology for assets" in Article 12(b)(iii) below provides otherwise; or (ii) the listed price is not represen-
tative; in such cases, the value of these assets is determined on the basis of the probable realisation value as estimated in
good faith.
(ii) Assets that are not listed on a stock exchange or traded on an organised market and assets with no available trading
price. Assets that are neither traded on a stock exchange nor included in another organized market and assets for which
no trading price is available are valued on the basis of their current market value as determined by suitable valuation
models having regard to the current market situation, unless the "Valuation methodology for assets" in Article 12(b)(iii)
below provides otherwise.
(iii) Valuation methodology for assets
(aa) Assets admitted to a stock exchange or traded in an organised market (in particular, securities (including company
participations, shares and other company interest) are valued at their respective (latest available) market prices, subject
to special valuation rules for the individual assets listed, if applicable, below or in the Issuing Document. If these prices
are not representative, the value of these assets shall be determined on the basis of the probable realisable value, as
estimated in good faith by the Company.
(bb) Assets (in particular, securities (including company participations, shares and other company interest) that are
neither traded on stock exchanges nor included in another organised market, or for which no negotiable price is available,
shall be valued at the fair market value based on suitable valuation models and taking into account current market cir-
cumstances, subject to special valuation rules for the individual assets listed, if applicable, in the Issuing Document. The
methodology used shall be in accordance with the latest IPEV (International Private Equity and Venture Capital Valuation
as published by the IPEV board) guidelines.
(cc) In general, debt securities are valued at nominal value plus accrued interest, subject to special valuation rules which
are listed, if applicable, below or in the Issuing Document.
(dd) In general, to value unlisted debt securities, historical costs (less amortisation, where applicable) and impairment
tests are used that are based on the business plans of the underlying companies and show the payment streams that are
available for servicing the debt securities; likewise, if the issuing companies have a positive shareholders' equity position,
this may serve as an indicator that the debt securities are sound. If necessary, accrued interest may be considered if the
respective interest is owed unconditionally by the issuer. Otherwise (i.e., in the event of liquidity-based and/or earnings-
based interest. interest owed on a conditional basis), accrued interest and interest receivables shall be considered by the
Company on the date of the inflow.
(ee) Shares and/or units of UCIs, specialised investment funds, UCITS and comparable investment funds are valued at
the most recently determined Net Asset Value available on the respective Valuation Date.
(ff) The value of cash and cash equivalents or cash deposits, bills of exchange and demands for payment, as well as
trade receivables, prepaid expenses, cash dividends and interest income that have been decided or accrued, as described
above, but not yet received, are taken into account in their entirety, unless it is improbable that such amounts will be
paid or received, in which case their value shall be set at a discount that reflects their actual value; In the case of money
market instruments, starting with the net acquisition price and maintaining the resulting return, the valuation price is
gradually adjusted to the redemption price.
(gg) If there are significant changes in market conditions, the valuation basis for the individual investments shall be
adjusted to the new market returns; The value of futures, forwards or options that are traded on stock exchanges or
other regulated markets is calculated on the basis of the latest available prices of such contracts on the Valuation Date
on the exchanges or regulated markets on which these futures, forwards or options are traded; if a future, a forward or
an option cannot be liquidated on a day for which the Net Asset Value is determined, the valuation basis for such a
contract shall be determined by the Board of Directors in an appropriate, reasonable manner.
(hh) The value of the forwards or options that are not traded on stock exchanges or other regulated markets (over-
the-counter derivatives) is equal to the net liquidation value on the respective Valuation Date, as determined in accordance
52457
L
U X E M B O U R G
with the guidelines from the Board of Directors on a basis that is applied consistently for all different types of contracts.
Swaps are valued at their market value, in the case of interest-rate swaps, with reference to the underlying interest-rate
trend.
(ii) Assets and liabilities denominated in currencies other than Euro are converted into Euro at the applicable exchange
rate in Luxembourg on the respective Valuation Date (in general, the reference rate published by the ECB). If no exchange
rate is available, it shall be determined in good faith by the Board of Directors or in accordance with the method it has
specified.
(jj) Special valuation rules for individual assets may, if appropriate, be stipulated in the Issuing Document.
(iv) Valuation methodology for liabilities
(aa) any and all expenses and fees incurred or payable;
(bb) any and all currently known and future liabilities, including any and all due contractual obligations for payments of
monies or assets, including distributions shown but not yet paid;
(cc) appropriate provisions for future taxes based on assets and income of the Company up to the Valuation Date
(e.g. deferred taxes) and, if applicable, other provisions approved and sanctioned by the Board of Directors, as well as
any amount, if applicable, considered by the Board of Directors to be an appropriate provision for potential liabilities;
and
(dd) any and all other liabilities reported under Luxembourg law.
(ee) When determining the amount of these liabilities, any and all expenses that must be paid by the Company must
be taken into account. The Company may estimate regularly recurring costs in advance based on estimated figures for
annual and other periods.
(v) Additional valuation methodology for shares
(aa) Shares that, where applicable, are intended to be redeemed or withdrawn in accordance with these Articles shall
be listed on the books as Shares outstanding until they are redeemed and/or until the withdrawal date. From that date
until the redemption price is paid, this shall be deemed to be a liability of the Company.
(bb) Shares to be issued by the Company shall be treated as Shares outstanding from the date of issue on.
(cc) The market price or exchange rate on the Valuation Date shall be taken into account when valuing investments,
time deposits and other assets denominated in a currency other than Euro.
(vi) Additional valuation methodology for prospective investments
If the Company has undertaken, on a Valuation Date:
(aa) to buy assets, the amount to be paid for such assets shall be reported as a liability of the Company. The value of
the asset to be purchased shall be reported as an asset of the Company;
(bb) to sell assets, the amount received for such assets by the Company shall be reported as an asset of the Company.
The asset to be delivered shall not be reported as an asset of the Company. If the exact value of the consideration on
the Valuation Date is unknown, it shall be estimated by the AIFM.
(cc) Both for purchases and for sales of assets on a regulated market, the principles referred to in this Article 12(b)
(vi) shall apply from the Business Day following the closing for the respective purchase or sale. If the transaction is executed
by a broker, the date on which the respective broker executes the order for the purchase or sale shall be authoritative.
(vii) Calculation of the Net Asset Value
The Net Asset Value per Share will be expressed in Euro and shall be determined by the Depositary under the
supervision of the AIFM on each Valuation Day, and on each other Business Day as the AIFM may determine from time
to time. The Net Asset Value is calculated in accordance with this Article 12 and Lux GAAP by dividing (i) the net assets
of the Company being the value of the gross assets less the portion of liabilities on such Quarter Day by (ii) the number
of Shares issued on the relevant Quarter Day
(viii) Special Valuation Rules
(a) Valuation of Hydropower Investments Hydropower Investments held by the Company shall be valued on each
Valuation Date at the then current market value based on suitable valuation models and taking into account the then
current market circumstances. The valuation process and methodology shall be audited once a year by a reputable
accounting firm, including the model and all sources of information used.
(b) Internal or external appraiser
The valuation can be conducted by either (i) an Independent Appraiser or
(ii) by the valuation department of the AIFM. This decision shall be made by the AIFM for every asset acquired.
(1) The Independent Appraiser shall be appointed in compliance with the regulations of the CSSF and the Management
Agreement. The Independent Appraiser must be registered as such, subject to professional rules and with guarantees.
Independent Appraiser must have relevant experience regarding the types of assets to be valued and the relevant market.
A plausibility check of the results shall be conducted by AIFM, taking into account all relevant parameters used in the
calculation.
52458
L
U X E M B O U R G
(2) Internal valuation shall be conducted by the independent valuation department of the AIFM according to the
processes implemented and documented in the organization manual.
Art. 13. Suspension of Valuation of the Net Asset Value. The suspension of the determination of the Net Asset Value
may occur in accordance with the provisions of and under the conditions outlined in the Articles and pursuant to this
Article 13.
The Board of Directors may temporarily suspend the valuation of the Net Asset Value, as well as the issue and
redemption of Shares in the following cases:
(a) During any period when any market or stock exchange which is in the principal market or stock exchange on which
a substantial portion of the investments of the Company is listed is closed, other than for ordinary holidays, or during
which dealings are considerably restricted or suspended.
(b) When for any other exceptional circumstance the prices of any investments owned by the Company cannot
promptly or accurately be ascertained
(c) When the means of communication normally used to calculate the value of assets in the Company are suspended
or when, for any reason whatsoever, the value of an investment in the Company cannot be calculated with the desired
speed and precision.
(d) When restrictions on exchange or the transfer of capital prevent the execution of dealings for the Company or
when buying and selling transactions on their behalf cannot be executed at the normal exchange rates.
(e) When factors which depend, among other things, on the political, economic, military and monetary situation and
which evade the control, responsibility and means of action of the Company, prevent the Company from having access
to its assets and from calculating their Net Asset Value in normal or reasonable manner.
(f) When the Board of Directors so decide, provided all Shareholders are treated on an equal footing and all relevant
laws and regulations are applied as soon as an extraordinary general meeting of Shareholders of the Company has been
convened for the purpose of deciding on the liquidation or dissolution of the Company.
Any such suspension of the valuation of the Net Asset Value shall be published by the Board of Directors and shall be
notified to the Shareholders. In addition to this Article 13, the related provisions of the Articles shall apply.
Title III. Administration
Art. 14. Board of Directors. The Company shall be managed by the Board of Directors composed of at least three
members. The members of the Board of Directors need not be Shareholders of the Company.
Any director shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be re-eligible.
Whenever a legal entity is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent
representative to perform such director's mandate in its name and on its behalf. The representative is subject to the same
conditions and obligations, and incurs the same liability, as if he was performing such director's mandate in his own name,
without prejudice to the joint liability of the legal entity. The legal entity may only revoke the representative provided
that it simultaneously appoints a new representative.
The members of the Board of Directors shall be elected by the Shareholders of the Company at the general meeting.
The Shareholders of the Company shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their
office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the
general meeting of Shareholders of the Company.
In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next general meeting of Shareholders of the Company.
Art. 15. Board meetings. The Board of Directors of the Company must appoint a chairman among its members and
it may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the
meetings of the board of directors of the Company and the minutes of the general meetings of the Shareholders of the
Company.
The Board of Directors of the Company shall meet upon call by the chairman or any two directors, at the place
indicated in the notice of meeting which shall, in principle, be in Luxembourg.
Written notice of any meeting of the Board of Directors of the Company shall be given to all directors at least 24
(twenty-four) hours in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case
the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board of Directors
of the Company.
No such written notice is required if all the members of the Board of Directors of the Company are present or
represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda,
of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax or cable, of
each member of the Board of Directors of the Company. Separate written notice shall not be required for meetings that
are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors of the
Company.
52459
L
U X E M B O U R G
Any member of the Board of Directors of the Company may act at any meeting of the Board of Directors of the
Company by appointing, in writing whether in original, by telefax or cable, another director as his or her proxy.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors of the Company by conference call or similar
means of communications equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other
and properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board of Directors of the Company can deliberate and/or act validly only if at least the majority of the Company's
directors is present or represented at a meeting of the Board of Directors of the Company.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
event that at any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the chairman of the meeting shall have
a casting vote.
Resolutions signed by all directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened
and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be
evidenced by letter, telefax or telex.
Art. 16. Minutes of the Board of Directors meetings. The minutes of any meeting of the Board of Directors of the
Company shall be signed by the chairman of the Board of Directors of the Company who presided at such meeting or
by any two directors of the Company.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
secretary (if any) or by any director of the Company.
Art. 17. Decisions of the Board of Directors. The Board of Directors of the Company is vested with the broadest
powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All
powers not expressly reserved by the Law of 2007, or by these Articles to the general meeting of Shareholders of the
Company fall within the competence of the Board of Directors.
Art. 18. Delegation of powers. The Board of Directors of the Company is authorised to appoint a person, either
director or not, without the prior authorisation of the general meeting of the shareholder(s) of the Company, for the
purposes of performing specific functions at every level within the Company. The Board of Directors may thus delegate
its powers for the conduct of the daily management of the Company, to one or more directors, who will be called
managing directors.
Art. 19. Binding signatures. The Company shall be bound towards third parties by the joint signature of any two
directors of the Company in all matters or the joint signatures or single signature of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with these Articles.
Insofar as daily management is concerned, the Company shall be legally bound towards third parties by the sole
signature of any managing director of the Company.
Art. 20. Indemnity. In accordance with Luxembourg law, none of the Indemnified Parties will be liable to the Company
or to the Shareholders for any act or omission by it or them and the Company will indemnify each
Indemnified Party for any loss or damage incurred by such Indemnified Party in connection with the Company's acti-
vities, howsoever arising in respect of functions performed as a member of such Board of Directors, except for any
liability, loss or damage primarily attributable to such Indemnified Party's gross negligence ("faute lourde") or wilful mis-
conduct.
Art. 21. Investment Policies and Restrictions. The Board of Directors, based upon the principle of risk spreading, has
the power to decide on investment in accordance with the investment policies and strategies as set out in the Issuing
Document determined from time to time and/or to be applied in respect of the Company and the course of conduct of
the management and business affairs of the Company, all within the restrictions as shall be set forth by the Board of
Directors in compliance with applicable laws and regulations.
The Company is authorized (i) to employ techniques and instruments relating to transferable securities provided that
such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management and (ii) to employ techniques
and instruments intended to provide protection against exchange risks in the context of the management of its assets
and liabilities.
Art. 22. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that the Company or any one or more of the members of its Board of Directors
or officers is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any members of the Board of Directors or officer who serves as a manager, officer or employee of any company or
firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with
such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
Art. 23. Alternative Investment Fund Manager. The Company may, under the conditions and within the limits laid down
by Luxembourg laws and regulations, and in particular the Law of 2007 and the Law of 2013, either appoint an external
52460
L
U X E M B O U R G
alternative investment fund manager in order to carry out the functions described in annex I of the AIFM Directive, or
remain self-managed.
The Company has appointed the AIFM as its alternative investment fund manager. Details regarding the appointment
of the AIFM are set out in the Issuing Document.
Art. 24 Auditor. The accounting data related in the annual report of the Company shall be examined by an auditor
("reviseur d'entreprises agree") appointed by the general meeting of Shareholders and remunerated by the Company.
The Auditor shall fulfill all duties prescribed by the Law of 2007.
Title IV. General meetings - Accounting year - Distributions
Art. 25. General Meetings of Shareholders of the Company.
(a) The general meeting of Shareholders shall represent all the Shareholders of the Company. Its resolutions shall be
binding upon all the Shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts
relating to the operations of the Company. General meetings of Shareholders shall be convened by the Board of Directors.
It may also be called upon the request of Shareholders representing at least ten percent (10%) of the Share capital.
The annual general meeting of the shareholder(s) of the Company shall be held, in accordance with the Law of 1915
in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the
convening notice of such meeting, on the third Monday of June of each year. If such day is not a business day for banks
in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following Business Day.
Other meetings of Shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of
meeting.
General meetings of Shareholders shall be convened pursuant to a notice setting forth the agenda and sent by registered
letter at least eight (8) days prior to the meeting to each Shareholder at the Shareholder's address recorded in the register
of registered Shares. The giving of such notice to registered Shareholders needs not to be justified to the meeting. The
agenda shall be prepared by Board of Directors except in the instance where the meeting is called on the written demand
of the Shareholders in which instance the Board of Directors may prepare a supplementary agenda.
If all Shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of the
agenda, general meetings may take place without notice of meeting. Any Shareholder may act at any meeting of the
Shareholders by appointing another person as his proxy in writing whether in original, by telefax or cable.
Any Shareholder may participate in a meeting of the Shareholders by conference call or similar means of communi-
cations equipment whereby all persons participating in the meeting can hear and speak to each other and properly
deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.
The business transacted at any meeting of the Shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda
(which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.
Each Share is entitled to one (1) vote, in compliance with Luxembourg law and these Articles. Only full Shares are
entitled to vote.
A Shareholder may act at any general meeting by giving a written proxy to another person, who need not be a
Shareholder and who may be a director of the Company.
Shareholders can vote using mail poll by fulfilling a form which shall indicate their identity, and their choice concerning
the vote or their abstention. Forms which do not indicate the vote or the abstention are void.
In order to be taken into account for the calculation of quorum, such forms shall have been received by the Company
at the latest two (2) days before the Shareholders' meeting. Unless otherwise provided by law or herein, general meetings
of Shareholders shall not validly deliberate unless Shareholders representing the majority of the capital are present or
duly represented.
If this condition is not satisfied, a second meeting may be convened, by means of registered mails sent at least eight
(8) calendar days before the meeting. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and results
of the previous meeting.
Unless required otherwise by (i) law; or (ii) these Articles resolutions of the general meeting are passed by a simple
majority vote of the validly cast votes.
A resolution to change these Articles for the Company shall require a supermajority of ninety per cent (90 %) vote
of the general meeting of Shareholders. Such amount shall be calculated on the number of Shares entitled to vote irres-
pective of present or represented Shareholders at the relevant shareholder meeting.
A resolution to terminate the Management Agreement with the AIFM by termination for cause in cases of (i) fraud,
gross negligence, bad faith, wilful misconduct or reckless disregard by the AIFM in respect of its obligations in relation to
the Company, in each case as determined by a court of competent jurisdiction; or (ii) having been declared bankrupt,
granted suspension of payments or being dissolved requires an approval of Shareholders representing more than two-
thirds (.) of the Shares held by Shareholders entitled to vote. The Board of Directors are not bound by the result of such
voting in their decision on the termination of the Management Agreement.
(b) The Management Agreement can be terminated by the Company in cases of:
52461
L
U X E M B O U R G
(i) fraud, gross negligence, bad faith, wilful misconduct or reckless disregard by the AIFM in respect of its obligations
in relation to the Company, in each case as determined by a court of competent jurisdiction; or
(ii) the AIFM having been declared bankrupt, granted suspension of payments or being dissolved;
and in both cases prior to terminating the Management Agreement, the Board of Directors will convene a Shareholders'
meeting to inform the Shareholders about such occurrence and will ask Shareholders for their view as to whether or not
to terminate the Management Agreement, such vote requiring majority of Shareholders representing more than two-
thirds (.) of the Shares held by Shareholders entitled to vote. The Board of Directors are not bound by the result of such
voting in their decision on the termination of the Management Agreement.
(c) The Company may terminate the Management Agreement without cause by giving 12-month prior written notice
to the AIFM. Prior to sending such notice and terminating the Management Agreement without cause, the Board of
Directors will convene a Shareholders' meeting to inform the Shareholders about such intention and will ask the Share-
holders for their view as to whether or not to terminate the Management Agreement, and such vote requires the majority
of the Shareholders representing 90% of the Shares held by Shareholders entitled to vote. Such a vote to remove the
AIFM may only be adopted after the eighth (8
th
) anniversary of the First Closing Date. The Board of Directors are not
bound by the result of such voting in their decision on the termination of the Management Agreement.
Art. 26. Termination of Shares. In the event that for any reason the value of the net assets of the Shares within the
Company has decreased to, or has not reached, an amount which, in the opinion of the Board of Directors, is the minimum
level for the Company, or such Shares, to be operated in an economically efficient manner or in case of a modification
in the political, economic or monetary situation or as a matter of economic rationalisation, the Board of Directors with
the prior approval given by a ninety per cent (90 %) majority vote of the extraordinary general meeting of Shareholders
may decide to redeem all the Shares at the Net Asset Value per Share (taking into account actual realisation prices of
investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Date at which such decision shall take effect. The
Company shall serve a written notice to the holders of the relevant Shares prior to the effective date for the compulsory
redemption, which will indicate the reasons and the procedure for the redemption operations.
Notwithstanding the powers conferred to the Board of Directors by the preceding paragraph, the general meeting of
Shareholders will, by a resolution adopted by a ninety per cent (90 %) majority vote of the general meeting of Shareholders,
in any other circumstances, have the power, upon proposal from the Board of Directors, to redeem all the Shares and
refund to the Shareholders the Net Asset Value per Share for their Shares (taking into account actual realisation prices
of investments and realisation expenses) calculated on the Valuation Date at which such decision shall take effect.
Assets which may not be distributed to their beneficiaries upon the implementation of the redemption will be deposited
with the Depositary for a period of six (6) months thereafter; after such period, the assets will be deposited with the
Caisse de Consignations on behalf of the persons entitled thereto.
Art. 27. Fiscal Year. The fiscal year of the Company shall commence on 1 January of each year and shall terminate on
31 December of the same year.
Art. 28. Distributions. With respect to the legal and regulatory measures applicable to the Company, the Shareholders
hereby agree that the amount of distributions duly approved by the annual general meeting of the Shareholders, shall be
distributed to each such Shareholder pro rata to the number of its respective Shares.
The Board of Directors will make interim distributions out of Proceeds and other available cash, such as dividends or
other earnings derived from Hydropower Investments, in a timely manner and when considered appropriate by it in its
sole and absolute discretion.
The Company shall not make in-kind distributions of securities or other assets of the Company to any Shareholder
without such Shareholder's consent. In kind distributions shall be valued at the lower of cost or book value.
Any distribution that has not been claimed within three (3) years of its declaration shall be forfeited and become assets
of the Shares issued.
No interest shall be paid on a dividend declared by the Company and kept by it at the disposal of its beneficiary.
In any event, no distribution may be made if, as a result of such distribution the net assets of the Company would fall
below EUR 1,250,000.
Title V. Final provisions
Art. 29. Depositary. To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary agreement with a banking
or saving institution as defined by the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended.
The Depositary shall fulfill the duties and responsibilities as provided for by the Law of 2007 and the Law of 2013.
Where the law of a third party country requires that certain financial instruments be held in custody by a local entity
and there are no local entities that satisfy the delegation requirements under the Law of 2013, the Company shall be
expressly authorised to discharge in writing the Depositary from its liability with respect to the custody of such financial
instruments, provided that the conditions of article 19(14) of the Law of 2013 are met.
If the Depositary desires to retire, the Board of Directors shall use its best endeavours to find a successor depositary
within two (2) months of the effectiveness of such retirement. The Board of Directors may terminate the appointment
52462
L
U X E M B O U R G
of the Depositary but shall not remove the Depositary unless and until a successor depositary shall have been appointed
to act in the place thereof.
Art. 30. Dissolution of the Company. The Company may at any time be dissolved by a resolution of the general meeting
of Shareholders.
At this meeting, Shareholders who represent at least two-thirds (2/3) of the share capital of the Company must be
present or represented and the decision to dissolve the Company must be taken by at least three-fourths (3/4) of the
votes validly cast.
Whenever the share capital falls below two-thirds (2/3) of the minimum capital indicated in Article 6 hereof, the
question of the dissolution of the Company shall be referred to the general meeting of Shareholders by the Board of
Directors. The general meeting, for which no quorum shall be required, shall decide on such dissolution by simple majority
of the Shares represented at the meeting.
The question of the dissolution of the Company shall further be referred to the general meeting of Shareholders
whenever the share capital falls below one-fourth (1/4) of the minimum capital set by Article 6 hereof; in such an event,
the general meeting shall be held without any quorum requirements and the dissolution may be decided at the majority
of one-fourth (1/4) of the Shares present and represented at the meeting.
The meeting must be convened so that it is held within a period of forty (40) days from ascertainment that the net
assets of the Company have fallen below two-thirds (2/3) or one-fourth (1/4) of the legal minimum, as the case may be.
Art. 31. Liquidation. Liquidation shall be carried out by one or several liquidators, who may be physical persons or
legal entities, appointed by the general meeting of Shareholders which shall determine their powers and their compen-
sation.
The liquidator(s) shall use its/their best efforts to terminate, sell or otherwise dispose of any outstanding investments
of the Company. The liquidator(s) shall apply the assets available for distribution among the Shareholders in accordance
with the provisions of these Articles and the Issuing Document and shall act in accordance with applicable laws and
regulations when disposing of the investments and terminating the Company.
Art. 32. Statement. Words importing a masculine gender also include the feminine gender and words importing persons
or Shareholders also include corporations, partnerships associations and any other organized group of persons whether
incorporated or not.
Art. 33. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law
of 2007 and the Law of 2013 as such laws have been or may be amended from time to time.
Art. 34. Definitions. Capitalised terms used in these Articles (unless defined herein) shall have the meanings as indicated
in the Issuing Document.
<i>Transitory provisionsi>
1) The first financial year will begin on the date of the incorporation of the Company and will end on 31
st
December
2015.
2) The first annual general meeting of Shareholders will be held in 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The initial share capital is fixed at EUR 31.000 (in words: thirty-one-thousand Euro) represented by 310 Shares without
nominal value.
The share capital of the Company is subscribed as follows:
Name of Subscribers Number of subscribed shares
Alceda Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningbergerg All Shares of the Company so subscribed have
been fully paid-up in cash, proof of which has been duly given to the undersigned notary.
<i>Declarationi>
The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions enumerated in article 26,
26-3 and 26-5 of the Company Law and expressly states that they have been fulfilled.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, are estimated at about eight hundred euros (800.-€).
<i>Resolutions of the shareholder(s)i>
Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person(s), representing the entirety of the
subscribed capital, held a general meeting of shareholders, and acknowledging being validly convened, passed the following
resolutions:
1. The following person is appointed as chairman of the Company:
52463
L
U X E M B O U R G
- Jost Rodewald, geboren am 31. Mai 1971 in Braunschweig, beruflich ansassig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
2. The following persons are appointed as directors of the Company for a term to expire at the close of the annual
general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts of the Fund as at 31
st
December 2019:
- Jost Rodewald, geboren am 31. Mai 1971 in Braunschweig, beruflich ansassig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
- Dr. Michael Dröge, geboren am 10. Januar 1966 in Hameln, beruflich ansassig in Neuer Wall 63, D-20354 Hamburg.
- Jean-Claude Michels, geboren am 30. Juni 1972 in Malmedy, beruflich ansassig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
3. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.
4. The following is elected as independent auditor (“Réviseur d' Entreprises Agréé”) of the Company for a term to
expire at the close of the annual general meeting of Shareholders which shall deliberate on the annual accounts of the
Company as at 31
st
December 2015:
PricewaterhouseCoopers, Societe cooperative, 2 rue Gerhard Mercatoris,L-2182 Luxembourg, RCSL B 65.477.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above appearing
parties.
Whereof this notarial deed is drawn up in Ettelbruck, on the date named at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, said proxy holder signed together with
the notary the present deed.
Gezeichnet: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.
Enregistre à Diekirch Actes Civils, Le 8 avril 2015. Relation: DAC/2015/5847. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Carlo RODENBOUR.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veroffentlichung im
Memorial erteilt.
Ettelbruck, den 15. April 2015.
Référence de publication: 2015057188/759.
(150065989) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 avril 2015.
Malake S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 190.885.
<i>1- Transfert de partsi>
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 12 mars 2015, que AIM Services S.à r.l., a transféré
la totalité des 12.500 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à:
- Kennedy Avenue Limited, une BVI Business Company, constituée et régie selon les lois des Iles Vierges Britanniques,
ayant son siège social à l'adresse suivante: Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanni-
ques, immatriculée auprès du BVI Trade and Companies register sous le numéro 1864262.
Les parts de la Société sont désormais réparties comme suit:
Kennedy Avenue Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales
<i>2- Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date 12 mars 2015i>
En date du 12 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- de nommer Monsieur Olivier HAMOU, actuellement gérant unique de la Société, en tant que nouveau gérant B de
la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée;
- de nommer Monsieur Mohammed Saleh M ALSUOBIE, né le 30 décembre 1959 à Tabouk, Arabie Saoudite, ayant
comme adresse professionnelle: 2, Aletedal Street, Alwaha area, Riyad, Arabie Saoudite, en tant que nouveau gérant A
de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 mars 2015.
Malake S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015041130/27.
(150047026) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
52464
Acres Financial, S.à r.l.
Advent Energy
AGS Invest S.A. SPF
Altaïr Investments S.A.
Aquila Capital European Hydropower Fund S.A., SICAV-SIF
Arm Holding S.A.
Banyal Aragorn Investments S.A.
Brico Luxembourg S.à r.l.
CaCh
Capula ESS Lux 1 S.à r.l.
Esso Luxembourg
Key Note S.à r.l.
La Cité Sàrl
Le Cigare S.à r.l.
Malake S.à r.l.
Managua Holdings S.A. SPF
MCI Prop Co. B S.à r.l.
MCI Prop Co. C S.à r.l.
Melga Finance S.à r.l.
MH Germany Property VI S.à r.l.
Monterey Capital I Sàrl
Naudin S.A. Spf
Phebus S.A.
Pizzeria El Barbaro S.àr.l.
Radwan Investments S.à r.l.
RCSL
Romanico
R.P. Real Properties S.A.
Savin Hill Holding S.à r.l.
SE Investmentfund-FIS
Skandia Life S.A.
Société Européenne pour la Restructuration et l'Ingénierie de l'Entreprise S.A.
SPUERKEESS Ré S.A.
STAEDEL HANSEATIC Luxembourg S.A.
Stratego Managing S.à r.l.
Strateteq International S.A.
SWM South
TCN Holding (Luxembourg) S.à.r.l.
Tech-It PSF SA
Tevennec
Top Patrimoine S.A., SPF
Treveria G S.à r.l.
TriCap Administration (Luxembourg) S.A.