logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1066

23 avril 2015

SOMMAIRE

AIEREF Holding 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

51126

AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51125

Arendt & Medernach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51125

Arendt Regulatory Solutions S.A. . . . . . . . .

51130

Art Conseil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51128

Aviva Investors European Renewable Ener-

gy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51126

Beko Toiture Construction Immobilière et

Façade S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51127

Berkeley Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

51129

BHM Vietnam Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . .

51125

Bicknell Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51124

Blue Shield Investments S.A.  . . . . . . . . . . . .

51134

Bocci Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51127

Bolt Ventures Investments S.C.A.  . . . . . . .

51125

Bow S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51128

BSI Flex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51124

Building and Office Investment S.A.  . . . . .

51128

Bulkinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51126

Choral Sainte Cécile Strassen a.s.b.l. . . . . .

51136

Chrisco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51129

Clamar Investissements S.A.  . . . . . . . . . . . .

51123

CMI Luxembourg S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

51128

Constroplus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51129

Digital Services XXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

51143

Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l.  . . . . .

51124

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l. . . . . .

51122

E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51131

Fourteen Spruce S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

51129

Generali Investments SICAV . . . . . . . . . . . .

51142

Gestion Conseil Formation S.A.  . . . . . . . . .

51122

Immobs S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51127

K-Point S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51122

Lamudi Global S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51143

LE 19 société civile immobilière  . . . . . . . . .

51167

Low Carbon Accelerator Luxembourg Li-

mited S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51168

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l.  . . .

51122

Manco Groupe Osead S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

51122

Mezzanine Finance Europe S.A.  . . . . . . . . .

51138

Midbal Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51123

Multi Opportunity Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . .

51123

Oresys International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51168

Realinvest Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51125

Telesat Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

51133

51121

L

U X E M B O U R G

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 164.578.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2014.

Référence de publication: 2015039851/10.
(150044970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Manco Groupe Osead S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 174.246.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015039870/10.
(150045527) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 170.493.

Monsieur Pascal CORBEL a démissionné de son mandat de gérant A de la Société avec effet au 9 mars 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040304/11.
(150046203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Gestion Conseil Formation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8371 Hobscheid, 1, route de Steinfort.

R.C.S. Luxembourg B 130.412.

<i>Extrait de la convention de dépositaire d'actions au porteur du 02/03/2015

La société charge AFC Benelux Sàrl, expert-comptables, établie et ayant son siège social au 1, rue de Steinfort, L-8371

Hobscheid, R.C.S. Luxembourg B 60.162, de maintenir le registre des actions au porteur de la société.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015040389/11.
(150046237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

K-Point S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 308, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 120.186.

Frau Kirsten Ludwig hat ihren Rucktritt aus dem Verwaltungsrat der K-Point S.A. mit Wirkung zum 19. Dezember

2014 erklärt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

K-Point S.A.
Petra Hauer / Andrea Schmitt

Référence de publication: 2015040453/12.
(150045900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51122

L

U X E M B O U R G

Multi Opportunity Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.631.

EXTRAIT

Le Conseil d'administration de la Société en date du 26 Janvier 2015 décide:
- De nommer Madame Simona Bortolazzi, née le 15 janvier 1972 à Milan, Italie, et ayant son adresse 6, avenue Marie-

Thérèse, L-2132 Luxembourg, Président du conseil d'administration, avec effet 20 Novembre 2014, jusqu'au Conseil
d'administration qui se tiendra en 2015;

- D'acter la démission de Monsieur Stefano Ambrogi, en tant que Membre du conseil d'administration, avec effet 20

Novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015040532/17.
(150046222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Midbal Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 64.664.

<i>Extrait des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 9 mars 2015 à Luxembourg ville

1. D'accepter la démission de Monsieur David COCKSEDGE de ses fonctions d'administrateur de la Société.
2. De nommer aux fonctions d'administrateur de la Société, Madame Jane STAPLETON, né à Londres au Royaume-

Uni, le 6 octobre 1970, demeurant 67, Eleftherias Street, Parekklisia, 4520 Limassol à Chypre, jusqu'à l'Assemblée générale
annuelle des actionnaires qui se tiendra en l'année 2021.

3. De reconduire Monsieur Marc-Hubert TRIPET dans ses mandats d'administrateur et d'administrateur délégué, Jamie

Edward THOMPSON dans son mandat d'administrateur et FIRI Treuhand G.m.b.H. dans son mandat de Commissaire
aux Comptes jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en l'année 2021.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015040553/18.
(150046198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Clamar Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 52.111.

<i>Extrait de la décision de l'associé unique prise en date du 5 mars 2015 au sein de la société CD-GEST S.A.R.L., RCS Luxembourg

<i>B 65174

Il résulte de la décision de l'associé unique de la société CD-GEST S.A.R.L. prise en date du 5 mars 2015 que:
Dans le cadre de son mandat d'administrateur au sein de notre société, et conformément à l'article 51bis de la loi

modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'associé unique de la société CD-GEST S.A.R.L. a décidé
de nommer en qualité de représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de
la société, Monsieur Frédéric COLLOT, directeur financier, demeurant professionnellement à L-1258 Luxembourg, 4 rue
Jean-Pierre Brasseur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015040264/19.
(150045903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51123

L

U X E M B O U R G

BSI Flex, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 134.419.

EXTRAIT

Le Conseil d'administration de la Société en date du 26 Janvier 2015 décide:
- De nommer Madame Simona Bortolazzi, née le 15 janvier 1972 à Milan, Italie, et ayant son adresse 6, Avenue Marie

Thérèse, L-2132 Luxembourg a été nommée Président du conseil d'administration, avec effet 20 Novembre 2014, jusqu'au
Conseil d'administration qui se tiendra en 2015;

- D'acter la démission de Monsieur Stefano Ambrogi en tant que Membre du conseil d'administration, avec effet 20

Novembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015040207/17.
(150046199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Bicknell Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 136.939.

Conformément à un contrat de transfert de parts sociales en date du 20 février 2015, cinq cents (500) parts sociales

de la Société, émises et en circulation à la date du contrat, ont été transférées par Mme Jacqueline Ruimy à M. Ely Michel
Ruimy, né le 31 décembre 1964 à Casablanca (Maroc) et résidant professionnellement à 49 Grosvenor Street, W1K 3HP
Londres, Royaume-Uni.

Traduction pour les besoins de l'enregistrement

Pursuant to a share purchase agreement dated February 20 

th

 , 2015, five hundred (500) shares of the Company, issued

and outstanding as of the date of the agreement, have been transferred from Ms. Jacqueline Ruimy to Mr. Ely Michel
Ruimy born on December 31 

st

 , 1964 in Casablanca (Morocco) and residing professionally at 49 Grosvenor Street, W1K

3HP London, United Kingdom.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015040199/18.
(150045763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.430.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts, signé en date du 20 février 2015, que l'associé unique de la Société, Digital

Services XXXVI S.à r.l., a transféré 698 des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), une Gesellschaft mit beschränkter Haftung, constituée et régie selon les

lois de l'Allemagne, ayant son siège social à l'adresse suivante: 20, Johannisstrasse, 10117 Berlin, Allemagne et immatriculée
auprès du Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg sous le numéro HRB 126893 B.

Les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:

Digital Services XXXVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.802 parts sociales
Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

698 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l.

Référence de publication: 2015040283/19.
(150045690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51124

L

U X E M B O U R G

Realinvest Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11B, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 42.597.

Par la présente, je vous fais part de ma démission de la fonction d'Administrateur de votre société avec effet immédiat.

Luxembourg, le 15 février 2015.

Isabelle Accary.

Référence de publication: 2015040647/9.
(150046485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Bolt Ventures Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 165.959.

Les comptes Annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040191/10.
(150046331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

BHM Vietnam Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 163.860.

Les comptes Annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040198/10.
(150046332) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Arendt &amp; Medernach, Société Anonyme.

Siège social: L-1468 Luxembourg, 14, rue Erasme.

R.C.S. Luxembourg B 186.371.

La liste des signataires autorisés de la Société a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Arendt &amp; Medernach

Référence de publication: 2015040127/11.
(150045735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 180.498.

EXTRAIT

En date du 22 Janvier 2015, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Alan Botfield, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat;
- Madame Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015040163/14.
(150045795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51125

L

U X E M B O U R G

Bulkinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.906.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de la réunion du Conseil d'Administration du 28 août 2014, le Conseil a pris les résolutions

suivantes:

1. Le siège social de la société est transféré de son adresse actuelle 25, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, au 20,

Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, avec effet au 28 août 2014.

2. L'adresse professionnelle de Monsieur Vincent MULDER, Administrateur, est dorénavant au 20, Avenue Pasteur,

L-2310 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015040209/15.
(150046139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

AIEREF Holding 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 169.661.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 9 Mars 2015, que:
- M. Francesco Piantoni, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la Société avec effet au 28 Février 2015;

- Mme. Alix van Ormelingen, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, a été nommée en tant que gérante de la Société avec effet au 1 

er

 Mars 2015;

Le conseil de gérance se compose donc comme suit au 1 

er

 Mars 2015:

- Emmanuel BABINET, Gérant
- Alix VAN ORMELINGEN, Gérante
- Jerome PETIT, Gérant
Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 11 Mars 2015.

Référence de publication: 2015040150/19.
(150045862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Aviva Investors European Renewable Energy S.A., Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 16, avenue de la gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.875.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la Société prises en date du 9 Mars 2015, que:
- M. Francesco Piantoni, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, a démissionné de son mandat de administrateur de la Société avec effet au 28 Février 2015;

- Mme. Alix van Ormelingen, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, a été nommée en tant que administrateur de la Société avec effet au 1 

er

 Mars 2015;

Le conseil d'administration se compose donc comme suit au 1 

er

 Mars 2015:

- Emmanuel BABINET, Administrateur
- Alix VAN ORMELINGEN, Administrateur
- Jerome PETIT, Administrateur
Pour extrait conforme,

A Luxembourg, le 12 Mars 2015.

Référence de publication: 2015040135/20.
(150046336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51126

L

U X E M B O U R G

Immobs S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 178.393.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 10 février 2015

I
De nommer Madame Géraldine SANTI, (née le 12 mai 1971 à F - Longwy, demeurant professionnellement, 7a rue des

Glacis, à L - 1628 Luxembourg), en remplacement de Madame Stéphanie ROTOLONI, démissionnaire, administrateur
pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, à savoir l'assemblée générale annuelle de 2019.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015040433/15.
(150045825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Beko Toiture Construction Immobilière et Façade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3491 Dudelange, 4, An Hinnefen.

R.C.S. Luxembourg B 132.763.

<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique du 31 janvier 2015

<i>Décision n°1

L'associé unique décide de nommer aux fonctions de gérant technique, Monsieur António ROCHA DIAS, né le 23

juillet 1962 à Arouca (Portugal) et demeurant à L-3491 Dudelange, 4, An Hinnefen.

<i>Décision n°2

L'associé unique décide d'acter la démission des fonctions de gérant technique de Monsieur Marco Dinis FERREIRA

AMADO, né le 30 mars 1984 à Sé Nova, Coimba (Portugal) et demeurant à L-4810 Rodange, 69, rue du Clopp.

Esch-sur-Alzette, le 31 janvier 2015.

Pour extrait sincère et conforme à l'original
Fiduciaire C.G.S.
Signature

Référence de publication: 2015040195/18.
(150045967) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Bocci Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 188.884.

EXTRAIT

Il résulte de la décision de l'associé unique de la Société en date du 9 mars 2015 que la société BRE/Management 7

S.A. a démissionné en tant que gérant unique de la Société avec effet au 9 mars 2015.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer la société BRE/Management 6 S.A., société anonyme de droit

Luxembourgeois, ayant son siège social au 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 164.777, en tant que gérant unique de la Société, avec effet au 9 mars
2015 pour une durée indéterminée.

La Société est désormais gérée par la société BRE/Management 6 S.A. en qualité de gérant unique.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015040190/19.
(150046161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51127

L

U X E M B O U R G

CMI Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.270.

Les comptes annuels au 31 janvier 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CMI LUXEMBOURG S.àR.L.

Référence de publication: 2015040265/10.
(150046280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Bow S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3850 Schifflange, 17-19, avenue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 103.204.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015040204/10.
(150045687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Art Conseil, Société Anonyme.

Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 143.535.

<i>Extrait du Procès-verbal de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 6 mars 2015 à 16 heures au siège social de la Société

<i>Décisions

1°) Le conseil d'administration, après avoir pris connaissance de la démission de Monsieur Henri de Crouy-Chanel,

propose néanmoins la réinscription de celui-ci, qui accepte, en tant que membre du Conseil d'administration de la société
jusqu'à la date de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'année 2015.

2°) Monsieur Alexandre Marguet présente sa démission en tant qu'administrateur et administrateur-délégué avec effet

à l'issue de la présente réunion.

Référence de publication: 2015040128/14.
(150046144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Building and Office Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 34.384.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire en date du 2 mars 2015

Il résulte des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du

2 mars 2015 que:

1. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires accepte la démission de Monsieur Yannick Kantor de ses

fonctions d'administrateur avec effet à ce jour.

2. L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer aux fonctions d'administrateur Monsieur

Pierre Petit, né le 16 juin 1977 à Liège (Belgique), domicilié au 11 place Saints Pierre et Paul, L-2334 Luxembourg. Son
mandat prendra fin lors de l'Assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31
décembre 2016.

Luxembourg, le 2 mars 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015040208/20.
(150045693) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51128

L

U X E M B O U R G

Constroplus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4149 Schifflange, 70, rue Romain Fandel.

R.C.S. Luxembourg B 167.341.

Le Bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015040270/10.
(150046399) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Fourteen Spruce S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 183.430.

Suite à une erreur matérielle, les statuts coordonnés rectifiés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg et remplacent les statuts coordonnés précédemment déposés en date du 6 mars 2015 sous la référence
L150042714.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015038571/12.
(150043825) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Berkeley Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 34.999,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 154.898.

<i>Rectificatif au dépôt N° L150044684

Suite à une erreur matérielle, il convient de noter que Monsieur Christiaan van Arkel a été nommé gérant de catégorie

B avec effet au 1 

er

 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Berkeley Luxembourg S.à r.l.
Christiaan van Arkel
<i>B manager

Référence de publication: 2015040189/15.
(150046076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Chrisco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 161.887.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique

En date du 31 octobre 2014, l'actionnaire unique a pris connaissance de la démission de Monsieur Orozco Domingo

PALACIOS en tant qu'administrateur B et ce avec effet rétroactif au 20 août 2014.

En cette même date, l'actionnaire unique a pris connaissance de la démission de Monsieur Laurence Olivier KYD en

tant qu'administrateur B et ce avec effet rétroactif au 20 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015040261/16.
(150045716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51129

L

U X E M B O U R G

Arendt Regulatory Solutions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 8, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 175.516.

L'an deux mille quinze le trois mars.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme de droit luxembourgeois Arendt Regula-

tory Solutions S.A. (ci-après la “Société”), ayant son siège social au 8, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 175.516, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 20 février 2013, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 979 en date du 24 avril 2013. Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée générale est ouverte à 16.00 heures sous la présidence de Maître Jean-Marc UEBERECKEN, Avocat à la

Cour, avec résidence professionnelle à Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Maître Anne Marie REUTER, Avocat à la Cour, avec résidence professionnelle à Lu-

xembourg.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur également Maître Anne Marie REUTER, prénommée.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I. Que la présente assemblée extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cent vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-),

représenté par cent vingt-cinq mille (125.000) actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1) chacune, à six cent vingt-
cinq mille Euro (EUR 625.000,-), par l'émission de cinq cent mille (500.000) actions d'une valeur nominale de un Euro
(EUR 1,-) chacune, par un versement en numéraire.

2. Souscription - Libération
3. Modification subséquente de l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société.
4. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cent

vingt-cinq mille Euro (EUR 125.000,-) représentés par cent vingt-cinq mille (125.000) actions d'une valeur nominale de
un Euro (EUR 1,-) chacune à six cent vingt-cinq mille Euro (EUR 625.000,-), par l'émission de cinq cent mille (500.000)
actions d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Souscription et paiement

L'assemblée, après avoir constaté la renonciation des actionnaires en place à exercer leur droit de souscription, décide

d'admettre  à  la  souscription  des  cinq  cent  mille  (500.000)  nouvelles  actions:  Arendt  &amp;  Medernach  S.A.,  une  société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 14, rue Erasme, L-1468 Luxembourg,, immatriculée auprès
du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.371.

Arendt &amp; Medernach S.A., représentée aux présentes par Maître Jean-Marc UEBERECKEN, prénommé, en vertu d'une

procuration sous seing privé, qui demeurera annexée aux présentes après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire
et le notaire instrumentant, déclare libérer l'intégralité des actions souscrites par un apport en numéraire de cinq cent
mille euro (EUR 500.000) qui est entièrement affecté au capital social de la Société.

51130

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

Afin de refléter la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5 paragraphe

1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à six cent vingt-cinq mille euros (EUR 625.000,-), représenté par six cent

vingt-cinq mille (625.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.»

<i>Frais et Dépenses

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte est évalué à environ deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: J.-M. UEBERECKEN, A M REUTER et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 6 mars 2015. 1LAC/2015/6988. Reçu soixante-quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur

 (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039522/72.
(150045139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6793 Grevenmacher, 77, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 50.469.

L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven,

S'est réunie:

L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la  société  anonyme  E.C.  HANDELSAGENTUR  -  EURO-

CUISINES S.A., avec siège social à L- 6793 Grevenmacher, 77, Route de Trèves, inscrite au Registre de commerce et des
sociétés à Luxembourg sous le numéro B 50469, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean Seckler, de résidence à
Junglinster, en date du 16 février 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 285 en l'an
1995. (la «Société»).

Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Jean-Paul Hencks, alors notaire

de résidence à Luxembourg, en date du 27 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
459 du 25 août 1997.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gerd IHL, indépendant, demeurant professionnellement à L-6793 Grevenma-

cher, 77, Route de Trèves,

qui nomme comme secrétaire Monsieur Jean-Pierre Dias, salarié, demeurant professionnellement à Senningerberg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gerd IHL, prénommé.
Monsieur le président expose ensuite:
I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:
1° Confirmation que les actions de la Société sont et resteront nominatives et modification subséquente de l'article 4

des statuts de la Société.

2° Adaptation des statuts de la Société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et modification subséquente des

articles 1, 5 et 6.

3°Acceptation de la démission de Monsieur Christian Josef HENN et de Monsieur Norbert MERKLER en tant qu'ad-

ministrateurs et de Monsieur Gerd IHL en tant qu'administrateur-délégué de la Société, décharge.

4° Révocation de Madame Maria Elisabeth MEY née NETELER en tant que commissaire aux comptes de la Société.
5° Nomination de Monsieur Norbert MERKLER en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à l'assemblée

ordinaire qui se tiendra en l'année 2019.

6° Confirmation de Monsieur Gerd IHL en tant qu'administrateur unique pour une durée de six ans.
7° Divers.
II. Que les actionnaires présents ou représentés à la présente assemblée ainsi que le nombre d'actions possédées par

chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence contrôlée par les membres du bureau. Les procurations éventuelles
émanant des actionnaires représentés à la présente assemblée, après avoir été signées ne varietur par les actionnaires

51131

L

U X E M B O U R G

présents et représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec
lequel elles seront enregistrées.

III. Qu'il résulte de la liste de présences que l'intégralité du capital social est présente ou représentée à l'assemblée,

que l'assemblée peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l'ordre du jour et qu'il a
pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris, avec l'accord unanime des actionnaires

présents ou représentés, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale confirme que les actions de la Société sont et resteront nominatives, et modification subséquente

de l'article 4 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 4. Les actions de la société sont nominatives.
Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre connaissance, et qui

contiendra les indications prévues à l'article trente-neuf de la loi sur les sociétés commerciales.

La propriété des actions nominatives s'établit par une inscription sur ledit registre.
La société peut, dans la mesure où et aux conditions auxquelles la loi le permet, racheter ses propres actions.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'adapter les statuts de la Société à ceux d'une société anonyme unipersonnelle et de

modifier en conséquence les articles 1, 5 et 6 comme suit:

ajout d'un paragraphe en fin d'article:

Art. 1 

er

 . (dernier paragraphe).  «La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la

Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas
besoin d'être l'actionnaire unique de la Société.»

« Art. 5. Si la Société est constituée par un actionnaire unique ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des ac-

tionnaires, il est établi que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur,
appelé «administrateur unique», jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence
de plus d'un actionnaire.

Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant au moins

trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale doit
nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'administrateur unique
ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils seront rééligibles.

Toute référence dans les statuts au conseil d'administration sera une référence à l'administrateur unique (lorsque la

Société a un actionnaire unique) tant que la Société a un actionnaire unique.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.»

« Art. 6. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale,

tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique selon les cas.

Le conseil d'administration peut désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la présidence

de la réunion peut-être conférée à un administrateur présent.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat

entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télex ou téléfax, étant admis.

En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou téléfax.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui

préside la réunion est prépondérante. Le conseil d'administration peut déléguer, avec l'accord préalable de l'assemblée

51132

L

U X E M B O U R G

des actionnaires, ses pouvoirs de gestion journalière et les affaires courantes de la Société ainsi que la représentation de
la Société dans cette gestion et ces affaires, à un ou plusieurs administrateur, directeurs, ou autre agents.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés par l'administrateur unique, et dont les
copies ou extraits pourront être produits en justice ou autrement.

La société se trouve engagée, vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par la signature obligatoire et incontournable

de l'administrateur-délégué de la société, ayant toute capacité pour exercer les activités décrites dans l'objet ci-avant,
conformément aux critères retenus par le Ministère des Classes Moyennes, ou conjointement avec la signature de l'un
des deux autres administrateurs ou, le cas échéant par la signature de l'administrateur unique.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Christian Josef HENN et de Monsieur Norbert

MERKLER en tant qu'administrateurs et de Monsieur Gerd IHL en tant qu'administrateur-délégué de la Société, et leur
accorde décharge pleine et entière pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de révoquer Madame Maria Elisabeth MEY née NETELER en tant que commissaire aux

comptes de la Société.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Norbert MERKLER, né le 5 juin 1954, à Neuwied (D), demeurant

à D-56566 Neuwied, Heimbach-Weiss, 14, Oberbüngstr. en tant que commissaire aux comptes de la Société jusqu'à
l'assemblée ordinaire qui se tiendra en l'année 2019.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide de confirmer le mandat de Monsieur Gerd IHL en tant qu'administrateur unique de la

Société pour une durée de six ans.

L'ordre du jour étant épuisé, le président prononce la clôture de l'assemblée.

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s'élèvent approximativement à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

DONT ACTE, fait et passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède à l'assemblée et aux membres du bureau, tous

connus du notaire instrumentaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, ces derniers ont signé avec Nous notaire
le présent acte.

Signé: Gerd Ihl, Jean-Pierre Dias, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 2 mars 2015. 1LAC / 2015/ 6328. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015039672/131.
(150045634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Telesat Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 1.999.999,00.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 179.004.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015040052/10.
(150045629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

51133

L

U X E M B O U R G

Blue Shield Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 113.423.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of February.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "BLUE SHIELD INVESTMENTS S.A.", a société anonyme,

having its registered office at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered with the “Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg” under the number B 113.423, incorporated by a deed of Maître Alex WEBER,
notary residing in Bascharage, dated January 12 

th

 , 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

number 739 on April 12 

th

 , 2006. Which Articles of Association of the Company have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo,

who appoints as secretary Mrs Alexandra FUENTES, private employee, residing professionally at the same address.
The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed “ne varietur” by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the one thousand (1,000) shares are represented. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which
the shareholders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the Company’s registered office to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange and subsequent amend-

ment of article 2 of the articles of association of the Company;

2. Miscellanous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting decides to change the headoffice of the company of the Company from its current address 15-17, avenue

Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, with immediate effect and subsequent
amendment of article 2 of the articles of incorporation, which should be read as follows:

Art. 2. paragraph 1. The registered office of the company is established in the city of Bertrange."

<i>Second resolution

The meeting notes that the professional address of the director Mr. Simon Woodville BAKER, Ms. Corinne NERE and

Ms. Dawn Evelyn SHAND and the registered office of the “Commissaire aux Comptes”, the company “CITADEL AD-
MINISTRATION S.A.” have changed to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-cinq février.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «BLUE SHIELD INVESTMENTS S.A.»,

avec  siège  social  au  15-17,  avenue  Gaston  Diderich,  L-1420  Luxembourg,  inscrite  au  Registre  de  Commerce  et  des

51134

L

U X E M B O U R G

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.423, constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de
résidence à Bascharage, en date du 12 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
739 du 12 avril 2006, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Alexandra FUENTES, employée privée, demeurant professionnellement à la

même adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de la liste de présence, que toutes les mille (1.000) actions sont représentés. La réunion est donc

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour de la réunion citée ci-dessus, dont
les actionnaires ont été informés avant la réunion.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, et modification subséquente

de l'article 2 des statuts;

2. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, à savoir 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, avec effet immediat et de modifier l’article
2 des statuts qui se lira désormais comme suit:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.».

<i>Deuxième résolution

L’assemblée constate que l’adresse professionnelle des administrateurs Mr. Simon Woodville BAKER, Mme Corinne

NERE et Mme Dawn Evelyn SHAND et le siège social du Commissaire aux Comptes, la société «CITADEL ADMINIS-
TRATION S.A.», a été transférée au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi, A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 4 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4710. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039582/101.
(150045234) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

51135

L

U X E M B O U R G

Choral Sainte Cécile Strassen a.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-8032 Strassen, 2, place des Martyrs.

R.C.S. Luxembourg F 10.314.

STATUTS

Chapitre 1 

er

 . - Dénomination, objet, siège, durée

Art. 1 

er

 .  L'association prend la dénomination Chorale Sainte Cécile Strassen a.s.b.l, appelée par la suite «la Chorale».

Cette Association regroupe la Chorale proprement dite, la Chorale Enfantine appelée «Hueflachspatzen» et l'Equipe

Théâtral.

Art. 2. Le but principal de la Chorale consiste à assurer l'encadrement musical des services religieux de la paroisse de

Strassen et à contribuer à la vie culturelle de la Commune de Strassen. A ces fins, elle cultive un large répertoire de
musique sacrée et profane.

En outre, elle peut déployer des activités non liturgiques comme des concerts publics, des séances de théâtre ou autres

manifestations à caractère culturel ou servant à promouvoir la convivialité entre ses membres et envers l'extérieur ou à
assurer la pérennité de l'association.

Art. 3. Le siège social se situe sur le territoire de la Commune de Strassen. L'adresse exacte du siège social est définie

par décision du conseil d'administration.

Art. 4. L'association est constituée pour une durée indéterminée. L'exercice social prend cours le 1 

er

 janvier et se

termine le 31 décembre. Par dérogation, l'exercice social de la première année prend cours à la date de la constitution
de la présente et se termine le 31 décembre 2014.

Chapitre 2. - Membres, admission, démission et exclusion

Art. 5. Le nombre minimum de membres actifs est fixé à sept.

Art. 6. L'association comprend comme membres:
- Les membres actifs,
- Les membres d'honneur.
Les membres actifs s'engagent à participer activement et régulièrement aux activités de la Chorale, soit comme cho-

riste, soit comme membre du conseil d'administration, soit comme membre de théâtre.

Les membres d'honneur soutiennent la Chorale moralement et financièrement par une cotisation annuelle. Le montant

de la cotisation est proposé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale. Le taux maximum des
cotisations des membres d'honneur est de 100,00 €.

Les membres d'honneur peuvent assister à l'assemblée générale ordinaire sans disposer du droit de vote.

Art. 7. Les nouveaux membres choristes sont agréés par le conseil d'administration à la majorité des deux tiers sur

proposition du directeur musical. Pour les nouveaux membres actifs qui ne pratiquent pas le chant, la proposition du
directeur musical n'est pas requise.

Art. 8. Tout membre qui veut se retirer de la Chorale adresse sa démission par écrit au conseil d'administration.

Art. 9. Le membre actif qui n'a pas participé aux activités de la Chorale durant six mois, sans excuse valable, est invité

par le conseil d'administration à s'y prononcer. Si après un délai de trois mois la situation ne s'est pas normalisée, le
membre peut être exclu de la Chorale sur décision de l'assemblée générale.

Le membre qui perturbe gravement le fonctionnement de la Chorale ou qui porte sérieusement atteinte à sa réputation

peut être exclu sans délai sur décision de l'assemblée générale.

Le membre d'honneur qui ne s'est pas acquitté de la cotisation annuelle pendant deux ans de suite est rayé du relevé

des membres d'honneur.

Chapitre 3. - Administration, gestion journalière

Art. 10. L'association est gérée par un conseil d'administration composé de 13 membres au maximum. Le Curé de la

paroisse est d'office membre du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut délibérer valablement si au moins 5 de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est

pas atteint, une nouvelle réunion avec le même ordre du jour est convoquée. Alors le conseil d'administration peut
délibérer valablement indépendamment du nombre de présences.

Les décisions sont prises par acclamation à la majorité simple des voix des membres présents. En cas d'égalité de voix,

la voix du président ou en son absence celle du vice-président est décisive.

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour assurer la défense des intérêts moraux et matériels

de l'association. Il a dans sa compétence tout ce qui n'est pas réservé expressément par les statuts ou par la loi à l'assemblée

51136

L

U X E M B O U R G

générale. Il gère les affaires de l'association et la représente dans tous les actes judicaires ou extra judicaires. Il agit de
façon collégiale.

Le conseil d'administration élit parmi ses membres le président, le vice-président, le secrétaire et le trésorier. Il peut

déléguer partie de ses pouvoirs à un ou à plusieurs de ses membres.

Art. 11. Le conseil d'administration se réunira sur convocation du président chaque fois que l'intérêt de l'association

l'exige. Le président doit convoquer le conseil d'administration également à la demande d'au moins 3 de ses membres.

Art. 12.  La  durée  du  mandat  des  membres  du  conseil  d'administration  est  de  4  ans.  Les  membres  sortants  sont

rééligibles.

Une partie du conseil d'administration est renouvelée tous les deux ans.
A la mise en vigueur des nouveaux statuts, les membres du comité élus sous le régime des statuts de la «Chorale Ste

Cécile Strassen» reprennent les mêmes fonctions dans le nouveau conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée
générale ordinaire.

Le premier mandat de la moitié des membres du conseil d'administration incluant le vice-président et le secrétaire est

limité à 2 ans

Les membres sortants autres que le vice-président et le secrétaire sont désignés par tirage au sort.
Le premier mandat du président, du trésorier et des autres membres est de 4 ans.

Art. 13. En cas de vacance d'un poste d'administrateur, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause,

les membres restants du conseil d'administration peuvent nommer un nouveau membre qui achève le mandat de celui
qu'il remplace. Sa nomination est soumise pour approbation à la prochaine assemblée générale ordinaire.

Art. 14. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, signés par le secrétaire

ou à défaut par celui qui a dressé le procès-verbal. Les procès-verbaux sont distribués à tous les membres du conseil
avant la prochaine réunion où ils sont soumis pour approbation.

Chapitre 4. - Assemblées générales

Art. 15. Sont réservés à la compétence de l'assemblée générale:
- La nomination et la révocation des membres du conseil d'administration,
- La nomination des commissaires aux comptes,
- L'approbation des budgets et des comptes,
- Les modifications des statuts (majorité avec 2/3 des voix)
- L'exclusion des membres (majorité avec 2/3 des voix par vote secret),
- La dissolution volontaire de l'association (majorité avec 2/3 des voix).

Art. 16. L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement, par

le vice-président et, en cas d'empêchement de ceux-ci, par l'administrateur délégué par ses collègues présents.

Tous les ans au courant du premier trimestre, les membres de l'association se réunissent en assemblée générale

statutaire. Cette assemblée générale entend un rapport du conseil d'administration sur les travaux et sur la situation
financière de l'association durant l'exercice précédent. Sur rapport des commissaires aux comptes, l'assemblée vérifie et
arrête les comptes de l'exercice écoulé; elle fixe le budget et le montant des cotisations pour l'exercice en cours. Elle
décide, s'il y a lieu, de donner décharge aux commissaires aux comptes et aux administrateurs. Tous les deux ans elle
procède à l'élection d'une partie des membres du conseil d'administration.

Le délai pour le dépôt de la liste complétée des membres du conseil d'administration auprès du Greffe du Tribunal est

fixé à un mois à partir de l'assemblée générale ordinaire. Les personnes qui sont candidates pour un poste au conseil
d'administration doivent présenter leur candidature avant l'élection au président de la Chorale.

L'assemblée générale procède à l'élection par vote secret si le nombre de candidats dépasse le nombre de postes

prévus selon l'Art. 10. Le principe de la majorité relative est appliqué.

En cas d'égalité des voix, les candidats en ballotage se soumettent à un deuxième vote. Si le nombre de candidats est

inférieur au nombre ou égal aux postes prévus selon l'Art. 10, le vote se fait par acclamation.

Les convocations aux assemblées générales contenant l'ordre du jour sont adressées aux membres au moins huit jours

avant la date de l'assemblée. Toute proposition signée d'un nombre de membres égal au vingtième de celui de la dernière
liste annuelle doit être portée à l'ordre du jour.

Art. 17. L'assemblée générale ordinaire est valablement constituée quel que soit le nombre de membres présents ou

représentés. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, à l'exception
des décisions pour lesquelles la loi prévoit une majorité qualifiée. Chaque membre actif a droit à une voix.

Les membres peuvent se faire représenter au vote par d'autres membres, pourvu que ceux-ci soient porteurs d'une

procuration écrite, remise au président ou à son remplaçant avant l'ouverture de la séance. Aucun des membres ne peut
participer au vote en nom personnel et comme mandataire de plus de deux autres membres.

51137

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Des assemblées générales extraordinaires ont lieu sur convocation du président ou à la demande écrite de

membres représentant un cinquième des voix. Elles statuent sur les objets portés à l'ordre du jour.

Art. 19. Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre spécial signé par le président et le

secrétaire du conseil d'administration. Les résolutions de l'assemblée générale sont tenues à la disposition des membres
qui pourront en prendre connaissance au siège social.

Chapitre 5. - Commissaires aux comptes

Art. 20. Le contrôle de la gestion financière de l'association est confié à deux commissaires aux comptes, nommés par

l'assemblée générale. Les commissaires ont, conjointement ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle
sur toutes les opérations de la trésorerie de l'association. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement des livres,
de toutes les écritures de l'association. Les commissaires sont nommés pour un terme d'un an. Ils sont rééligibles. Leur
mandat vaut pour la période entre deux assemblées générales ordinaires consécutives.

Chapitre 6. - Dissolution, liquidation

Art. 21. La dissolution de la Chorale ne peut se faire que par une assemblée générale extraordinaire spécialement

convoquée à ces fins.

L'assemblée générale extraordinaire ne peut prononcer la dissolution que si les 2/3 de ses membres sont présents ou

représentés. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde réunion délibérera valablement, quel que soit le nombre
de membres présents ou représentés. La dissolution ne sera admise que si elle est votée par une majorité des 2/3 des
voix.

Art. 22. Lors de la dissolution et après apurement de toutes les charges, les fonds et autres biens et valeurs, constituant

la fortune de la Chorale, reviendront à la Commune de Strassen.

Ils seront gérés par celle-ci pour la période intérimaire et seront transmis, le cas échéant, à une association nouvelle-

ment constituée répondant au but de l'ancienne Chorale. Si après un délai d'au moins cinq ans, il n'y a pas eu de constitution
de société qui a pris la succession de la Chorale en dissolution, la Commune de Strassen est autorisée à liquider la fortune
de la Chorale dissoute en l'investissant dans des activités se rapprochant le plus près possible des activités d'une Chorale
comme p.ex. l'organisation de concerts, de stages musicaux pour jeunes ou l'organisation de représentations théâtrales.

Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas réglementé par les présents statuts, il est renvoyé à la loi du 21 avril 1928 sur les

associations sans but lucratif telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2008 sur les associations et les
fondations sans but lucratif.

Chapitre 7. - Disposition concernant la reprise de l'ancienne association «Chorale Ste Cécile Strassen»

Art. 24. L'association nommée Chorale Sainte Cécile Strassen a.s.b.l reprend tous les biens actifs et passifs de l'ancienne

association «Chorale Ste Cécile Strassen».

Les présents statuts ont été adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2014.
Ils remplacent les statuts de la «Chorale Ste Cécile Strassen» du 25 novembre 2005.
Référence de publication: 2015039599/142.
(150045893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Mezzanine Finance Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 116.353.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Mezzanine Finance Europe S.A., a société anonyme governed

by the laws of Luxembourg, with registered office at 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
(the "Company"), having been incorporated following a deed of Maître Henri Hellinckx, notary then residing in Mersch,
Grand Duchy of Luxembourg, dated 10 May 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 1064 of 31 May 2006, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 116353. The Articles of Incorporation have been amended for the last time following a deed of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 23 March 2012, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1153 of 8 May 2012.

The meeting is declared open at 6.51 p.m. by Maître Claire Prospert, lawyer, with professional address in Luxembourg,

in the chair,

who appointed, Maître Elodie Michaud, lawyer, with professional address in Luxembourg, as secretary.
The meeting elected Mr Pit Dostert, with professional address in Luxembourg, as scrutineer.

51138

L

U X E M B O U R G

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman called upon the notary to record that:
(i) The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1 To remove the jurisdictional limitations in relation to the members of the board of directors and to amend paragraphs

2, 10 and 11 of Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.

2 To modify the quorum requirements for the deliberations of the board of directors and to amend paragraph 7 of

Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.

3 To acknowledge the resignation of Mr James Pope, Mr Patrick Zurstrassen, Mr Yves Wagner and Mr Roland Frey

acting as directors of the Company with effect as of 20 February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time and to acknowledge
the resignation of Ms Frances Hutchinson acting as director of the Company with effect as of 31 December 2014.

4 To appoint Ms Karla Rabusch, Mr Michael Niedermeyer, Mr Michael Hogan and Mr Richard Goddard as new directors

of the Company with effect as of 21 February 2015.

5 Miscellaneous.
(ii) That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance-list; this attendance-list, signed by the shareholders, the proxies of the repre-
sented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same
time with the registration authorities.

(iii) That the proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain

annexed to the present deed.

(iv) The whole corporate capital is represented at the present meeting and all the shareholders present or represented

declare that they have been duly informed on all items of the above agenda prior to the meeting and that they waive the
convening notice.

(v) That the present meeting is consequently regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the

agenda.

Then the general meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to remove the jurisdictional limitations in relation to

the members of the board of directors of the Company with immediate effect and to amend paragraphs 2, 10 and 11 of
Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company accordingly.

Paragraph 2 of Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“Subject to the provisions of these Articles, the board may regulate its proceedings as it thinks fit.”
Paragraph 10 of Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“Without prejudice to the second and seventh sentence of this Article 8, a person entitled to be present at a meeting

of the board or of a committee of the board shall be deemed to be present for all purposes if he is able (directly or by
electronic means) to speak to and be heard by all those present or deemed to be present simultaneously. A director so
deemed to be present shall be entitled to vote and be counted in a quorum accordingly. Such a meeting shall be deemed
to take place where it is convened to be held or (if no director is present in that place) where the largest group of those
participating is assembled, or, if there is no such group, where the chairman of the meeting is.”

Paragraph 11 of Article 8 of the Articles of Incorporation of the Company shall from now on read as follows:
“A resolution in writing executed by all the directors shall be as valid and effectual as if it had been passed at a meeting

of the board or (as the case may be) a committee of the board duly convened and held. For this purpose:

(a) a resolution may be in hard copy form or in electronic form sent to the registered office; and
(b) a resolution may consist of several documents in hard copy form or electronic form, each executed by one or

more directors, or a combination of both.”

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to modify the quorum requirements for the delibe-

rations of the board of directors of the Company with immediate effect and to amend paragraph 7 of Article 8 of the
Articles of Incorporation of the Company so that it shall read as follows:

“The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-

sented at a meeting of the board of directors.”

<i>Third resolution

The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to acknowledge the resignation of Mr James Pope,

Mr Patrick Zurstrassen, Mr Yves Wagner and Mr Roland Frey acting as directors of the Company with effect as of 20
February 2015 at 11.59 p.m. Luxembourg time and resolved to acknowledge the resignation of Ms Frances Hutchinson

51139

L

U X E M B O U R G

acting as director of the Company with effect as of 31 December 2014 and resolved to grant all of them full discharge
for the performance of their duties as far as legally possible.

<i>Fourth resolution

The extraordinary general meeting of shareholders resolved to appoint the following persons as new directors of the

Company with effect as of 21 February 2015 for a period ending at the annual general meeting of the shareholders
approving the Company’s annual accounts as of 31 March 2016:

(i) Ms Karla Rabusch, director, born on 13 April, 1959 in Brookings, South Dakota, United States of America, with

professional address at Wells Fargo Funds Management, LLC, 525 Market Street, San Francisco, California 94105, United
States of America;

(ii) Mr Michael Niedermeyer, director, born on 4 October, 1954 in Portland, Oregon, United States of America, with

professional address at Wells Fargo Asset Management, 525 Market Street, San Francisco, California 94105, United States
of America;

(iii) Mr Michael Hogan, director, born on 4 February, 1959 in Saint Paul, Minnesota, United States of America, with

professional address at Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, California
94596, United States of America; and

(iv) Mr Richard Goddard, director, born on 5 December, 1959 in Fareham, United Kingdom, with professional address

at The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

As a result, the Company will forthwith be managed as of 21 February 2015 by a board of directors composed of:
- Ms Karla Rabusch;
- Mr Michael Niedermeyer;
- Mr Michael Hogan;
- Mr Richard Goddard; and
- Mr Jürgen Meisch.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400).

There being no further business, the meeting is closed at 7.00 p.m..

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing persons, the

present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences
between the English and the French text, the English text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, who are known to the notary by their surname, first name,

civil status and residence, the said persons signed together with Us notary this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie

une assemblée générale extraordinaire des associés de Mezzanine Finance Europe S.A., une société anonyme régie par

le droit luxembourgeois, avec siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, (la
«Société») constituée par acte de Maître Henri Hellinckx, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxem-
bourg, en date du10 mai 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1064 en date du 31
mai 2006 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 116353. Les statuts
de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 23 mars 2012, ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations numéro 1153 du 8 mai 2012.

L'assemblée a été déclarée ouverte à 18.51 heures sous la présidence de Maître Claire Prospert, avocat, demeurant

professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné comme secrétaire Maître Elodie Michaud, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée a choisi comme scrutateur M. Pit Dostert, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président a prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
(i) L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1 Suppression des limitations juridictionnelles concernant les membres du conseil d’administration de la Société et

modification des paragraphes 2, 10 et 11 de l’article 8 des statuts de la Société en conséquence.

51140

L

U X E M B O U R G

2 Modification du quorum nécessaire pour les délibérations des réunions du conseil d’administration et modification

du paragraphe 7 de l’article 8 des statuts de la Société en conséquence.

3 Acceptation de la démission de M. James Pope, M. Patrick Zurstrassen, M. Yves Wagner et M. Roland Frey en leur

fonction d’administrateurs de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59, heure de Luxembourg et acceptation de
la démission de Mme Frances Hutchinson en sa fonction d’administrateur de la Société avec effet au 31 décembre 2014.

4 Nomination de Mme Karla Rabusch, M. Michael Niedermeyer, M. Michael Hogan et M. Richard Goddard en tant que

nouveaux administrateurs de la Société avec effet au 21 février 2015.

5 Divers.
(ii) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

(iii) Que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées "ne varietur" par les comparants

resteront pareillement annexées aux présentes.

(iv) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, il a pu être
fait abstraction des convocations d'usage,

(v) Que la présente assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur tous

les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de supprimer les limitations juridictionnelles concernant les

membres du conseil d’administration de la Société et de modifier avec effet immédiat les paragraphes 2, 10 et 11 de
l’article 8 des statuts de la Société en conséquence.

Le paragraphe 2 de l’article 8 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions des présents statuts, le conseil d’administration peut déterminer les procédures le

concernant qu’il juge appropriées.».

Le paragraphe 10 de l’article 8 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Sans préjudice des dispositions de la seconde et de la septième phrase du présent Article 8, une personne dont la

présence est admise à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité du conseil d’administration est réputée
être présente à toutes fins si elle est capable (directement ou par voie électronique) de parler et d’être entendue de
façon simultanée par toutes personnes présentes ou réputées être présentes. Un administrateur ainsi réputé présent est
autorisé à voter et par conséquent est pris en compte dans le calcul du quorum. Une telle réunion est réputée avoir lieu
à l’endroit spécifié dans la convocation ou (si aucun administrateur n’est présent à un tel lieu) là où le groupe le plus
important de participants est réuni, ou, s'il n'existe pas de groupe, là où le président de la réunion se trouve.»

Le paragraphe 11 de l’article 8 des statuts de la Société est modifié comme suit:
«Une résolution écrite signée par l'ensemble des administrateurs est valable et exécutoire de la même façon que si

elle avait été adoptée lors d’une réunion du conseil d’administration ou (le cas échéant) d’un comité du conseil d’admi-
nistration dûment convoquée et tenue. A cette fin:

a) une résolution peut être émise sous forme papier ou sous forme électronique envoyée au siège social; et
b) une résolution peut se composer de plusieurs documents sous forme papier ou sous forme électronique, chaque

document étant signé par un ou plusieurs administrateurs, ou une combinaison des deux.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier le quorum nécessaire pour les délibérations des

réunions du conseil d’administration et de modifier le paragraphe 7 de l’article 8 des statuts de la Société comme suit:

«Le conseil d’administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins une majorité des administrateurs

est présente ou représentée à la réunion du conseil d’administration.»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d’accepter la démission de M. James Pope, M. Patrick Zurs-

trassen, M. Yves Wagner et M. Roland Frey en tant qu’administrateurs de la Société avec effet au 20 février 2015 à 23h59,
heure de Luxembourg et a décidé d’accepter la démission de Mme Frances Hutchinson en tant qu’administrateur de la
Société avec effet au 31 décembre 2014 et a décidé de donner décharge a tous les administrateurs pour l’exécution de
leurs devoirs dans la mesure légalement possible.

51141

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que nouveaux

administrateurs de la Société, avec effet au 21 février 2015, pour la période se terminant à l’assemblée générale annuelle
des associés approuvant les comptes annuels de la Société en date du 31 mars 2016:

(i) Mme Karla Rabusch, administrateur, née le 13 avril, 1959 à Brookings, Dakota du Sud, États-Unis d’Amérique, avec

adresse professionnelle à Wells Fargo Funds Management, LLC, 525 Market Street, San Francisco, Californie 94105, États-
Unis d’Amérique;

(ii) M. Michael Niedermeyer, administrateur, né le 4 octobre, 1954 à Portland, Oregon, États-Unis d’Amérique, avec

adresse professionnelle à Wells Fargo Asset Management, 525 Market Street, San Francisco, Californie 94105, États-Unis
d’Amérique;

(iii) M. Michael Hogan, administrateur, né le 4 février, 1959 à Saint Paul, Minnesota, États-Unis d’Amérique, avec adresse

professionnelle à Wells Fargo Funds Management, LLC, 2001 North Main Street, Suite 600, Walnut Creek, Californie
94596, États-Unis d’Amérique; et

(iv) M. Richard Goddard, administrateur, né le 5 décembre, 1959 à Fareham, Royaume-Uni, avec adresse profession-

nelle à The Directors Office, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il en résulte que la Société sera gérée avec effet au 21 février 2015 par le conseil d’administration composé comme

suit:

- Mme Karla Rabusch;
- M. Michael Niedermeyer;
- M. Michael Hogan;
- M. Richard Goddard; et
- M. Jürgen Meisch.

<i>Evaluation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont évalués

à mille quatre cents euros (EUR 1.400).

Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19.00 heures.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci

avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; à la demande des même comparants, et
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom,

prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: C. Propert, E. Michaud, P. Dostert, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 15 janvier 2015. GAC/2015/513. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015038716/219.
(150043518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Generali Investments SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

R.C.S. Luxembourg B 86.432.

La convention de domiciliation conclue entre l'agent domiciliataire Caceis Bank Luxembourg, société anonyme imma-

triculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B91985 dont le siège social
est situé au 5 Allée Scheffer, 2520 Luxembourg, et Generali Investments Sicav, société d'investissement à capital variable,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B86432 dont le siège social est situé au 5 Allée
Scheffer, 2520 Luxembourg, a été résiliée avec effet au 2 mars 2015.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour CACEIS Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015038590/14.
(150044057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

51142

L

U X E M B O U R G

Lamudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Digital Services XXV S.à r.l.).

Capital social: EUR 30.502,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.486.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of January,
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “AIH”),

being the holder of six thousand two hundred fifty (6,250) common shares and six thousand two hundred fifty (6,250)

series A1 shares, and becoming the holder of four thousand two (4,002) series B shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin,

Germany, on 26 January 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 January 2015,

2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) common shares and three thousand one hundred

twenty-five (3,125) series A2 shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin,

Germany, on 26 January 2015,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),

being the holder of one thousand five hundred sixty-two (1,562) common shares and one thousand five hundred sixty-

three (1,563) series A3 shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, on

27 January 2015,

4. TEC Global Invest VII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26063, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),

being the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) common shares and one thousand five hundred

sixty-two (1,562) series A4 shares, and becoming the holder of one thousand five hundred (1,500) series B shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Mülheim an

der Ruhr, Germany, on 26 January 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all of the shareholders, representing the entire share capital of Digital Services XXV S.à r.l.

(hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 188486, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 2492 on 16 September 2014. The articles of association have been amended
pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 13 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The appearing parties representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general meeting

of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of the name of the Company from “Digital Services XXV S.à r.l.” to “Lamudi Global S.à r.l.” and

subsequently amend article one (1) of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Lamudi Global

S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915  concerning  commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

51143

L

U X E M B O U R G

2. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B shares (hereinafter “Series B Shares”),

with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have six (6) classes of shares in total, divided into common
shares, series A1 shares, series A2 shares, series A3 shares, series A4 shares and Series B Shares.

3. Increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand five hundred two euro (EUR 5,502)

from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to thirty thousand five hundred two euros (EUR
30,502) through the issuance of five thousand five hundred two (5,502) Series B Shares, with a nominal value of one euro
(EUR 1) each.

4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty thousand five hundred two euro (EUR 30,502), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A1 Shares”),

5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A3 Shares”),

5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and

5.1.6 five thousand five hundred two (5,502) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Lamudi Global

S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915  concerning  commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on

51144

L

U X E M B O U R G

such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty thousand five hundred two euro (EUR 30,502), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A1 Shares”),

5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A3 Shares”),

5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and

5.1.6 five thousand five hundred two (5,502) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

51145

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated

to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);

7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity

(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or

any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the

shareholders' meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.

7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with Article 8.4 to the Shareholders pro rata to
their participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Share an amount of EUR 2,000 being

subject to the Liquidity Event.

8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series

A4 Shares shall receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:

Share Class

Amount per

Share in Euro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.00

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,695.18

Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,599.49

51146

L

U X E M B O U R G

Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,600.51

8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall

be allocated on a third level (“Third Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any Investor on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be allocated to
such Investor on this Third Level provided that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First
Level and/or Second Level. Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after the
Liquidity Event in one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares (and
shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its Share in the total
Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such
shareholder on the First Level and/or Second Level and/or Third Level from a subsequent sale. All rights related to the
liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so

long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

51147

L

U X E M B O U R G

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

51148

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the

consent of the Advisory Board:

17.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and

transformation of the Company;

17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

17.1.4  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing

shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of

the Investors.

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued Shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being

51149

L

U X E M B O U R G

sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions

and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros

(EUR 500,000.00) in aggregate;

22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;

22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary

course of business;

22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set

forth in any shareholders' agreement between the shareholders;

22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections

291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and

22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further

51150

L

U X E M B O U R G

transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of four (4) voting members. The shareholders may by

way of unanimous Shareholders' Consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.

25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders' consent.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having six (6) votes, shall be nominated by the shareholder AIH

in its sole discretion;

25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder

LIH in its sole discretion;

25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder

Aismare in its sole discretion; and

25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder

TEC in its sole discretion.

25.4 Upon subscription to the Series B Shares Holtzbrinck I, Holtzbrinck shall be entitled to nominate one (1) voting

member of the Advisory Board, having one (1) vote (“Holtzbrinck Member”), in its sole discretion, and the other Sha-
reholders hereby undertake to increase the number of Advisory Board members by one (1) member, having one (1) vote,
upon subscription of the Series B Shares Holtzbrinck I.

25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The chairman shall be the member nominated

by the largest shareholder in terms of percentage participation that is entitled to nominate a member to the Advisory
Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions in particular on the self-orga-
nization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. In case
of a vote tie, the chairman shall have a casting vote if at the point in time of the respective decision the Shareholder having
nominated the chairman holds more than 50 % of all shares in the Company. For the avoidance of doubt the deputy
chairman shall not have a casting vote.

25.6 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions

of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders' resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.

25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

51151

L

U X E M B O U R G

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

51152

L

U X E M B O U R G

6. Appointment of Mr Julien De Mayer as new class B manager of the Company with immediately effect and for an

unlimited duration.

7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr Rüdiger

Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders decides to modify the name of the Company from “Digital Services XXV S.à r.l.”

to “Lamudi Global S.à r.l.” and subsequently amend article one (1) of the articles of association of the Company which
shall now read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Lamudi Global

S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915  concerning  commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B

shares (hereinafter “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have six (6) classes
of shares in total, divided into common shares, series A1 shares, series A2 shares, series A3 shares, series A4 shares and
Series B Shares.

<i>Third Resolution

The  general  meeting  of shareholders decides  to increase the  share capital of the Company  by  an  amount of five

thousand five hundred two euro (EUR 5,502) from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to
thirty thousand five hundred two euros (EUR 30,502) through the issuance of five thousand five hundred two (5,502)
Series B Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The new five thousand five hundred two (5,502) Series B Shares have been duly subscribed as follows:
1. four thousand two (4,002) Series B Shares have been subscribed by AIH, aforementioned, for the subscription price

of four thousand two euro (EUR 4,002);

2. one thousand five hundred (1,500) Series B Shares have been subscribed by TEC, aforementioned, for the sub-

scription price of one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

<i>Payment

The new five thousand five hundred two (5,502) Series B Shares subscribed by AIH and TEC, aforementioned, have

been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of five thousand five hundred two euro (EUR 5,502).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of five thousand five hundred two euro (EUR 5,502) is entirely allocated to the share

capital of the Company.

<i>Fourth Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5)

of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty thousand five hundred two euro (EUR 30,502), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A1 Shares”),

5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A3 Shares”),

5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”), and

51153

L

U X E M B O U R G

5.1.6 five thousand five hundred two (5,502) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”

<i>Fifth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the

articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Sixth Resolution

The general meeting of shareholders appoints Mr Julien De Mayer, private employee, born on 9 April 1982, in Etterbeek,

Belgium, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new class B
manager with immediately effect and for an unlimited duration.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Mr. Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 2,400.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Januar,
vor uns, der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  unter  der  Nummer  B  177.038,  mit  Sitz  in  7,  avenue  Pescatore,  L-2324  Luxemburg,  Großherzogtum
Luxemburg („AIH“),

Inhaber von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Stammanteilen und sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) An-

teilen der Serie A1 und zukünftiger Inhaber von viertausendzwei (4.002) Anteilen der Serie B,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in

Berlin, Deutschland, am 26. Januar 2015 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 27. Januar 2015,

51154

L

U X E M B O U R G

2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Stammanteilen und dreitausendeinhundertfünfundzwanzig

(3.125) Anteilen der Serie A2,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Januar

2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),

Inhaber von eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Stammanteilen und eintausendfünfhundertdreiundsechzig

(1.563) Anteilen der Serie A3,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 27. Januar

2015, ausgestellt in London,

4. TEC Global Invest VII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26063, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),

Inhaber von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Stammanteilen und eintausendfünfhundertzweiundsechzig

(1.562) Anteilen der Serie A4 und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhundert (1.500) Anteilen der Serie B,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Januar

2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-

raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die besagten erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Digital

Services XXV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188486, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Carlo
Wersandt, welche am 16. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2492 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 13. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux
geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten ver-

zichtet  haben,  ist  die  Gesellschafterversammlung  ordnungsgemäß  zusammengekommen  und  kann  wirksam  über  alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services XXV S.à r.l.“ in „Lamudi Global S.à r.l.“ und dement-

sprechende Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Lamudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, welche als Anteile der Serie B (die „Anteile

der Serie B“) bezeichnet werden, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und nunmehr insgesamt sechs (6)
Anteilsklassen zu haben, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3,
Anteile der Serie A4 und Anteile der Serie B.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro

(EUR 25.000) um einen Betrag von fünftausendfünfhundertzwei Euro (EUR 5.502) auf einen Betrag von dreißigtausend-
fünfhundertzwei Euro (EUR 30.502) durch die Ausgabe von fünftausendfünfhundertzwei (5.502) Anteilen der Serie B mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreißigtausendfünfhundertzwei Euro (EUR 30.502), bestehend

aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00) (die „Anteile der Serie A1“),

51155

L

U X E M B O U R G

5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),

5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.6 fünftausendfünfhundertzwei (5.502) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)
LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Lamudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

51156

L

U X E M B O U R G

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreißigtausendfünfhundertzwei Euro (EUR 30.502), bestehend

aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00) (die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),

5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.6 fünftausendfünfhundertzwei (5.502) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)
LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

51157

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);

7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines

Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.

7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren

Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.

7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der

Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel 8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil einen Betrag von

EUR 2.000, vorausgesetzt, dass das Liquiditätsereignis eingetroffen ist.

8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,

Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle
neben der entsprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse vereinbarten Betrag:

Anteilsklasse

Betrag pro

Anteil in Euro

51158

L

U X E M B O U R G

Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,00

Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.695,18

Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.599,49

Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600,51

8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen

Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entspre-
chend  ihrer  Beteiligung  am  Liquiditätsereignis  verteilt.  Sämtliche  von  einem  Investor  auf  der  Ersten  Ebene  und/oder
Zweiten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Dritten Ebene,
mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene erhaltenen
Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach
in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen
und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/
oder  Zweiten  Ebene  und/oder  Dritten  Ebene  aus  einem  späteren  Verkauf  zugeteilt  wurde.  Sämtliche  mit  der  hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie

dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.

9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.

10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.

10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.

10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

51159

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.

51160

L

U X E M B O U R G

14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-

schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und

Umwandlung der Gesellschaft;

17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;

17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder

die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-

stimmung der Investoren:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

51161

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte

und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-

derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;

51162

L

U X E M B O U R G

22.8.3  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;

22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;

22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des

gewöhnlichen Geschäftsgangs;

22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,

wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;

22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes

(AktG)); und

22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils-oder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwi-
schen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers,  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

51163

L

U X E M B O U R G

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/

oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit sechs (6) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach

eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem
Gesellschafter TEC nach eigenem Ermessen ernannt.

25.4 Bei Zeichnung der Anteile der Serie B Holtzbrinck I wird Holtzbrinck dazu ermächtigt, ein (1) stimmberechtigtes

Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme („Holtzbrinck Mitglied“) nach eigenem Ermessen zu ernennen, und die anderen
Gesellschafter verpflichten sich hiermit dazu, bei Zeichnung der Anteile der Serie B Holtzbrinck I die Anzahl der Mitglieder
des Beirats um ein (1) Mitglied mit einer (1) Stimme zu erhöhen.

25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist das

Mitglied, welches von dem Gesellschafter ernannt wurde, welcher von der prozentualen Beteiligung her der größte der-
jenigen ist, welche zur Ernennung eines Beiratsmitglieds ermächtigt sind. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme, sofern
zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung derjenige Gesellschafter, der den Vorsitzenden ernannt hat, mehr als 50%
aller Anteile an der Gesellschaft hält. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Vorsitzende
nicht die entscheidende Stimme hat.

25.6 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser
Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten können
dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen hat der
Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

51164

L

U X E M B O U R G

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

6. Ernennung von Herrn Julien De Mayer als neuer Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft mit sofortiger

Wirkung und für unbegrenzte Dauer.

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „Digital Services XXV S.à r.l.“ in „Lamudi

Global S.à r.l.“ zu ändern und Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft dementsprechend zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Lamudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, welche als Anteile der

Serie B (die „Anteile der Serie B“) bezeichnet werden, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und nunmehr

51165

L

U X E M B O U R G

insgesamt sechs (6) Anteilsklassen zu haben, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile
der Serie A3, Anteile der Serie A4 und Anteile der Serie B.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von fünftausendfünfhundertzwei Euro (EUR 5.502) auf einen
Betrag von dreißigtausendfünfhundertzwei Euro (EUR 30.502) durch die Ausgabe von fünftausendfünfhundertzwei (5.502)
Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die neuen fünftausendfünfhundertzwei (5.502) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
1. viertausendzwei (4.002) Anteile der Serie B wurden von AIH, vorbenannt, zu einem Bezugspreis von viertausendzwei

Euro (EUR 4.002) gezeichnet;

2. eintausendfünfhundert (1.500) Anteile der Serie B wurden von TEC, vorbenannt, zu einem Bezugspreis von eintau-

sendfünfhundert Euro (EUR 1.500) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von AIH und TEC, vorbenannt, gezeichneten fünftausendfünfhundertzwei (5.502) neuen Anteile der Serie B wurden

vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von fünftausendfünfhundertzwei Euro (EUR 5.502).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin

erbracht.

Die Einlage in Höhe von fünftausendfünfhundertzwei Euro (EUR 5.502) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zu-

geführt.

<i>Vierter Beschluss

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf (5) der Satzung der Ge-

sellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreißigtausendfünfhundertzwei Euro (EUR 30.502), bestehend

aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00) (die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“),

5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.6 fünftausendfünfhundertzwei (5.502) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)

51166

L

U X E M B O U R G

LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-

fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Julien De Mayer, private employee, geboren am 9. April 1982 in Et-

terbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, als neuen Ge-
schäftsführer der Kategorie B mit sofortiger Wirkung und für unbegrenzte Dauer.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  sowie  Herrn  Rüdiger  Trox,  das  Anteilsinhaberregister  der  Gesellschaft  in  Einzelunterschrift  und  mit  uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden

Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.400,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3356. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015039109/1372.
(150044346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

LE 19 société civile immobilière, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 19, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg E 2.656.

L’an deux mil quinze, le seizième jour du mois février.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Kader Chergui, commerçant, né le 25 avril 1967 à Mondelange (F), demeurant à L-5620 Mondorf-Les-

Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure;

2.- Madame Isabelle Capozza, épouse Chergui, commerçante, née le 6 octobre 1968 à Algrange, demeurant à L-5620

Mondorf-Les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure;

Lesquelles parties comparantes sont les seuls associés de la société «Le 19 société civile immobilière» société civile,

ayant son siège social à L- 5620 Mondorf-les-Bains, 4, Rue Jean-Pierre Ledure, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous la section E et le numéro 2656, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger,
notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  en  date  du  28  novembre  2002,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations le 11 février 2003, numéro 139. Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire
instrumentant en date du 31 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 12 juin 2014,
numéro 1508 (la «Société»).

51167

L

U X E M B O U R G

Ensuite, les associés, représentant l’intégralité du capital social de la Société, ont prié le notaire instrumentant d'acter

les résolutions suivantes prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L- 5620 Mondorf-les-Bains, 4, rue Jean-Pierre Ledure

vers L-1212 Luxembourg, 19, Rue des Bains.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède les associés décident de modifier l’article 3 (paragraphe 1) des statuts:

Art. 3. (paragraphe 1). "Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg."

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l’Étude du notaire

soussigné, à l’effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont acte, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Kader Chergui, Isabelle Capozza, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 18 février 2015. 1LAC / 2015/ 5170. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015037135/43.
(150042129) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Oresys International, Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 72.852.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039913/10.
(150044928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Low Carbon Accelerator Luxembourg Limited S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 134.614.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 6 mars 2015 que:
- Effigi S.à r.l. Société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, en-

registrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 107.313, est nommée
Gérant B de la société pour une durée indéterminée en remplacement de la société D.M.C. S.à r.l., gérant B démission-
naire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015038691/18.
(150044123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

51168


Document Outline

AIEREF Holding 1 S.à r.l.

AMP Capital Investors (IDF II SBT N°2) S.à r.l.

Arendt &amp; Medernach

Arendt Regulatory Solutions S.A.

Art Conseil

Aviva Investors European Renewable Energy S.A.

Beko Toiture Construction Immobilière et Façade S.à r.l.

Berkeley Luxembourg S.à r.l.

BHM Vietnam Holdings S.à r.l.

Bicknell Capital S.à r.l.

Blue Shield Investments S.A.

Bocci Midco S.à r.l.

Bolt Ventures Investments S.C.A.

Bow S.A.

BSI Flex

Building and Office Investment S.A.

Bulkinvest S.A.

Choral Sainte Cécile Strassen a.s.b.l.

Chrisco S.A.

Clamar Investissements S.A.

CMI Luxembourg S.àr.l.

Constroplus S.A.

Digital Services XXV S.à r.l.

Digital Services XXXVI (GP) S.à r.l.

DS Smith Perch Luxembourg S.à r.l.

E.C. Handelsagentur - Euro-Cuisines S.A.

Fourteen Spruce S.à r.l.

Generali Investments SICAV

Gestion Conseil Formation S.A.

Immobs S.A.

K-Point S.A.

Lamudi Global S.à r.l.

LE 19 société civile immobilière

Low Carbon Accelerator Luxembourg Limited S. à r.l.

LSREF2 Star Gate Investments S.à r.l.

Manco Groupe Osead S.A.

Mezzanine Finance Europe S.A.

Midbal Immo S.A.

Multi Opportunity Sicav

Oresys International

Realinvest Europe S.A.

Telesat Luxembourg S.à r.l.