logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1064

23 avril 2015

SOMMAIRE

3P (L) Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51035

Adma A.G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51028

Agatha Estates S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51040

Altercap CCA I SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51029

Auris Luxembourg I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

51038

Axis 10 Sports Consulting Group S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51046

Bazarkids S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51045

Boomer Gestion SPF, S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

51045

Caissa S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51026

Carmudi Global S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51046

CBRE Equity  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51036

Chamly International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

51036

Combolux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51028

Compagnie Margaux S.A. SPF . . . . . . . . . . .

51031

Coverlux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51028

Cristalnet S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51028

Delphimmo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51029

Delta M.G.M. Lux S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

51037

Delux Private Investments S.A.  . . . . . . . . .

51033

Digital Services XXVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

51046

Elbblick (November) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

51036

FarVision S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51029

Gestielle Investment Sicav  . . . . . . . . . . . . . .

51027

ILP Acquisitions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51034

KEB S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51033

Kilbroney Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

51027

Lendico Mexico S.C.Sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

51035

Lendico Netherlands  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51046

Leopard Germany Ed 2 LP S.à.r.l.  . . . . . . .

51034

Leopard Germany Property Ed 1 S.à.r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51034

Les Carles Property S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .

51040

Licensing Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51026

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51035

Mora Funds SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51032

Motion Prod Management S.A.  . . . . . . . . . .

51035

NextEnergy Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

51031

Pizzeria Rossini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51044

Platinum Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51033

Protea Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51042

Spray Peace  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51030

Starting 2008 Investment S.à r.l. . . . . . . . . .

51026

Sucafina Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51032

Truffe Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51029

Villa D'Asie S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51072

Vison  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51027

V.V.C. Holding G.m.b.H., SPF  . . . . . . . . . . .

51035

51025

L

U X E M B O U R G

Starting 2008 Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 170.690.

<i>Extrait des résolutions prises en date du 10 mars 2015

- La démission de Madame Fantine JEANNON de son mandat de gérant de catégorie B, avec effet au 17 mars 2015,

est acceptée.

- Madame Delphine BIRCKER, employée privée, née le 30 mai 1981 à La Fère (France), demeurant professionnellement

au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, est nommée nouveau gérant de catégorie B, avec effet au 17 mars 2015, et
ce pour une période indéterminée.

Fait à Luxembourg, le 10 mars 2015.

Certifié sincère et conforme
Starting 2008 Investment S.à r.l.

Référence de publication: 2015040670/17.
(150046337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Caissa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 176.420.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015 à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq

jours francs avant l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015054940/1267/18.

Licensing Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 139.270.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>08 mai 2015 à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq

jours francs avant l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015054947/1267/19.

51026

L

U X E M B O U R G

Kilbroney Investments S.A., Société Anonyme.

Capital social: GBP 435.030.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 157.560.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 mars 2015

1. Madame Mounira MEZIADI a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Tamas MARK, administrateur de sociétés, né à Budapest (Hongrie), le 8 juin 1981, demeurant profes-

sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme d'administrateur pour une durée
indéterminée avec effet au 11 mars 2015.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour KILBRONEY INVESTMENTS S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015040465/17.
(150045887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Vison, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 173.151.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq

jours francs avant l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015054948/1267/18.

Gestielle Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 63.851.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 16 février 2015

En date du 16 février 2015, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Arendt Services S.A., une

société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse
suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 145917, en tant que dépositaire des Actions au Porteur de la Société, conformément à
l'article premier de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'Immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Gestielle Investment SICAV
Gianfranco BARP
<i>Chairman

Référence de publication: 2015038592/19.
(150044032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

51027

L

U X E M B O U R G

Coverlux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 85.146.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015040273/10.
(150045978) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Cristalnet S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4031 Esch-sur-Alzette, 67, rue Zénon Bernard.

R.C.S. Luxembourg B 83.837.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015040274/10.
(150046056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Adma A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 100.100.

<i>Auszug aus dem Bericht des Verwaltungsrates vom 16. Dezember 2014 an die Aktionäre und an den Aufsichtskommissar

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ernennung als Depositar FIDUCIAIRE MOSELLAN SARL., eingeschrie-

ben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015039530/12.
(150045095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Combolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9678 Nothum, 40, Kaunereferstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 55.767.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être

exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre,
le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour
le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social en date du <i>4 mai 2015 à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats.
2. Discussion sur rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions

exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014.

4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C.
6. Divers.

<i>Le conseil d'administration.

Référence de publication: 2015055292/1004/22.

51028

L

U X E M B O U R G

Truffe Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 174.268.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015040059/10.
(150045532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Altercap CCA I SA, Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 153.371.

EXTRAIT

Monsieur Matthieu Delamaire, administrateur de catégorie A, réside désormais au Avenue Hamoir 24 D, 1180 Uccle,

Belgique.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Certifié conforme

Référence de publication: 2015039542/12.
(150045173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

FarVision S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 351.000,00.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 145.535.

Les comptes annuels au 31.01.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06.03.2015.

<i>Pour: FarVision S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015038559/14.
(150043556) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Delphimmo, Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 143.185.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu vendredi <i>04 mai 2015 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq

jours francs avant l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015054946/1267/18.

51029

L

U X E M B O U R G

SP, Spray Peace, Association sans but lucratif.

Siège social: L-1221 Luxembourg, 41, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg F 10.311.

STATUTS

A. Valeurs et convictions de l'organisation:

Spray Peace a été fondée pour promouvoir des valeurs de paix et d'égalité à travers l'art. Spray Peace s'engage acti-

vement pour le dialogue, la multiculturalité et la tolérance. C'est avec l'art comme arme principale que Spray Peace s'active
contre les stéréotypes, le racisme et les discriminations en tout genre. C'est dans l'unité, le partage et l'espoir que Spray
Peace se mobilise pour la compréhension mutuelle et un meilleur avenir.

B. Statuts

Art. 1er. Dénomination et Objet.
1.0 L'association prend la dénomination "Spray Peace", abréviée SP.
1.1 Son siège se trouve à Luxembourg.
1.2 L'association est créée pour une durée illimitée.
1.3 L'objet de l'association est de promouvoir la paix à travers l'art.

Art. 2. Composition.
2.0 L'association se compose du conseil d'administration et des membres ordinaires.

Art. 3. Conseil d'administration.
3.0 Le Conseil d'administration se compose de la Présidence, du Secrétariat et de la Trésorerie.
3.1 Le Conseil d'administration est élu une fois par an lors de l'assemblée générale et comporte au minimum 3 et au

maximum 7 membres.

3.2 Afin de pouvoir se porter candidat pour le Conseil d'administration, toute personne doit d'abord être membre

ordinaire.

3.3 Le Conseil d'administration est en charge des affaires administratives et financières de l'ASBL. Il représente éga-

lement l'ASBL vis-à-vis des tiers. Spray Peace Statuts 2015

3.4 Le Conseil d'administration se réserve le droit d'exclure un membre de l'association s'il juge que les actions de ce

dernier sont contraires aux principes de l'association.

Art. 4. Assemblée générale.
4.0 L'assemblée générale est réunie au moins une fois par an. Elle se charge d'élire le conseil d'administration à la

majorité simple des membres présents.

4.1 L'assemblée générale est convoquée par voie électronique au moins deux semaines à l'avance.
4.2 Lors de l'assemblée générale, les résolutions pour l'année à suivre sont présentées. Le conseil d'administration se

charge ensuite de l'application des résolutions de l'assemblée générale et les partage avec les membres ordinaires par
voie électronique.

4.3 La présence d'un membre ne se limite pas à sa présence physique. Un membre peut rejoindre la réunion par vidéo

conférence et de cette façon bénéficier du droit de vote.

4.4 Chaque membre peut se faire représenter à l'Assemblée générale au moyen d'une procuration qu'il aura remise

préalablement au Conseil d'administration.

Art. 5. Conditions d'entrée et de sortie des membres.
5.0 Est considérée membre toute personne ayant payé la cotisation annuelle à l'association et agissant toujours selon

les principes de l'association.

5.1 Tout membre voulant démissionner doit en informer le conseil d'administration au moins un mois à l'avance.

Art. 6. Mode de modification des statuts.
6.0 Toute proposition de modification des statuts venant du Conseil d'administration doit être envoyée aux membres

aux moins 2 semaines avant l'assemblée générale.

6.1 Toute proposition de modification des statuts venant d'un membre ordinaire doit être envoyée au Conseil d'ad-

ministration au moins 3 semaines avant l'assemblée générale. Le conseil d'administration discute ensuite du bien-fondé
de cette Spray Peace Statuts 2015 proposition et décide en conséquence de l'ajouter ou non à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée générale.

6.2 Toute modification adoptée à l'ordre du jour doit être présentée devant l'assemblée générale. Elle est ensuite

discutée et finalement admise ou refusée par vote à la majorité simple de tous les membres présents à l'assemblée générale.

51030

L

U X E M B O U R G

L'admission d'une modification requiert cependant le soutien d'au moins la moitié des membres du Conseil d'adminis-
tration.

Art. 7. Finances.
7.0 Cotisation maximale
7.0.a Les membres sont libres de choisir le montant de leur cotisation, sachant néanmoins que la cotisation minimum

est fixée par le règlement interne.

7.0.b La cotisation maximale s'élève à 50 euros ou équivalent au moment de l'admission du membre. Tout montant

dépassant 50 euros est considéré comme un don.

7.1 Mode de règlement des comptes
7.1.a Le trésorier est responsable de la gérance des comptes de l'ASBL.
7.1.b La manipulation des comptes de l'ASBL est exclusivement réservée au trésorier, au président et au secrétaire

général.

7.1.c Le trésorier se doit de faire un rapport financier lors de l'assemblée générale.
7.2 Emploi du patrimoine dans le cas d'une dissolution:
7.2.a En cas de dissolution, le Conseil d'administration se charge de la répartition du patrimoine de l'ASBL qui, dans la

mesure du possible, sera reversé à d'autres organisations caritatives s'engageant pour les mêmes idéaux que Spray Peace.

Art. 8. Règlement Interne.
8.0 Tout ce qui ne figure pas dans ces statuts est définit par le règlement interne.
Référence de publication: 2015040001/73.
(150045374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

NextEnergy Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 136.767.

EXTRAIT

Il convient de modifier les informations suivantes inscrites au RCS:
- Rectifier le nom et le prénom de Monsieur (prénom): Gianluca et (nom): NINNO. et non Mr GIANLUCA Ninno;

et

- Rectifier le nom et le prénom de Monsieur (prénom): Michael Fritz Herbert (nom): BONTE FRIEDHEIM et non

BONTE FRIEDHEIM Michael Fritz Herbert.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 mars 2015.

Référence de publication: 2015040566/15.
(150046188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Compagnie Margaux S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 167.448.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015 à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :

<i>Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposé ses titres au siège social cinq

jours francs avant l'assemblée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015054945/1267/18.

51031

L

U X E M B O U R G

Sucafina Holding, Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 142.529.

<i>Extrait de la décision de l'assemblée générale

En date du 15 Février 2015, l'assemblée générale
A accepté la nomination de M. Peter Bun, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

de poste d'administrateur Président; jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2015.

A accepté la démission de M. Franz Bondy, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

de son poste d'administrateur Président.

A accepté la nomination de M. Franz Bondy, demeurant professionnellement au 8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg,

de son poste d'administrateur; jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 11/03/2015.

Référence de publication: 2015040696/17.
(150046235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Mora Funds SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 157.613.

The Company convened the

ORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company (the “Meeting”) to be held at the registered office of the Company at 5, rue

Goethe, L-1637 Luxembourg, on <i>28 April 2015 at 2:00 pm, with the following agenda:

<i>Agenda:

1. To resolve on the approval of the management report of the directors for the year ended 31 December 2014.
2. To resolve on the approval of the audited annual report of the Company for the financial year ended 31 December

2014.

3. To resolve on the discharge the Board members and the auditor with respect to the performance of their duties

for the financial year ended 31 December 2014.

4. To resolve to re-appoint the following persons as Directors, each to hold office until the next Annual General

Meeting of Shareholders in 2016 and until their successor is duly elected and qualified:
Mrs Maribel Tumi
Mr Salvador Vila
Mr Serge D'Orazio.

5. Proposal to appoint Ivan Comerma Poza as new Director, subject to the CSSF approval, to hold office until the

next Annual General Meeting of Shareholders in 2016 and until his successor is duly elected and qualified.

6. To resolve to re-appoint Deloitte as independent auditor of the Company for the forthcoming fiscal year and office

until the next Annual General Meeting of Shareholders in 2016.

7. Consideration of such other business as may properly come before the Annual General Meeting.

If you do not expect to attend the Annual General Meeting in person, please fill in, sign and date the enclosed proxy

form and return it at your earliest convenience by fax to the following number +352 27 177 530, along with the original
to follow by post to 5, rue Goethe, L-1637 Luxembourg.

In order to be valid for this meeting, proxy forms should be received by the close of business on 24th April 2015. Only

those Shareholders on record at the close of business on 24th April 2015 are entitled to vote at the Annual General
Meeting of Shareholders and at any adjournments thereof.

Shareholders are advised that the resolutions are not subject to specific quorum or majority requirements.
A copy of the annual report, the auditor's report and the Directors' report is available free of charge at the registered

office of the Company. Shareholders wishing to obtain a copy are asked to contact Mora Asset Management Luxembourg
in the following email address moralux@moralux.com or phone number +352 27 177 520.

<i>By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2015057157/755/37.

51032

L

U X E M B O U R G

KEB S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 91.778.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

KEB S.A.
Louis VEGAS-PIERONI / Alexis DE BERNARDI
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015039784/12.
(150045259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Delux Private Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 5, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 165.871.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Actionnaire unique le 13 février 2015:

1) L'Actionnaire unique décide de révoquer, avec effet immédiat, le mandat de l'Administrateur suivant:
- Monsieur Mike ABREU PAIS, né le 09 janvier 1981 à Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg), et résidant pro-

fessionnellement au 5, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

DELUX PRIVATE INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2015040282/13.
(150046038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Platinum Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 143.329.

The Shareholder are hereby invited to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the Fund, to be held on <i>11th May 2015 at 14:00 p.m. CET, at the offices of Citco, located at Carré Bonn, 20 rue de

la Poste, L-2346 Luxembourg and/or any other date before Me Henri Hellinckx public notary residing in the Grand-Duchy
of Luxembourg or before any other public notary residing in the Grand-Duchy of Luxembourg, to vote on the following
agenda below:

<i>Agenda:

1. Amendment of article 3 of the articles of association of the Fund in order to reflect that the Fund will appoint an

alternative investment fund manager pursuant to the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers
(AIFM Law);

2. Amendment of article 8 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
3. Amendment of article 16 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
4. Amendment of article 17 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
5. Amendment of article 22 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions

relating to the valuation;

6. Amendment of article 23 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions

regarding the determination of the net asset value;

7. Amendment of article 24 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
8. Amendment of article 25 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
9. Amendment of article 28 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions

regarding the depositary;

10. Amendment  of  article  29  of  the  articles  of  association  of  the  Fund  in  order  to  reflect  the  appointment  of  an

alternative investment fund manager pursuant the AIFM Law;

11. Amendment of article 30 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions;
12. Amendment of article 32 of the articles of association of the Fund in order to reflect the AIFM Law provisions; and
13. Any other business.

51033

L

U X E M B O U R G

The quorum required by law having not been reached at a first extraordinary general meeting of shareholders on 18th

March 2015, the second extraordinary general meeting of shareholders shall validly vote on the points of the agenda, no
matter what portion of the share capital of the Company will be present or represented at such meeting. The items on
the agenda shall be passed at a two-thirds majority of the shares present or represented at the meeting and voting.

To be valid, proxies should be duly completed, dated, signed and lodged, before 10:00 am (Luxembourg time) on 11th

of May 2015, with Citco Fund Services (Luxembourg) S.A., attention of Investor Relations Group, either by fax + 352
260236 470

or by e-mail to luxir3@citco.com
or by mail to Citco Fund Services (Luxembourg) S.A / Attn Investor Relations Group / 20 rue de la Poste / P.O Box

230/ L-2012 Luxembourg.

The draft text of the restated articles of incorporation is available for inspection at the registered office of the Fund

and a copy thereof may be obtained on request.

Signed for and on behalf of the Fund

<i>The Board of Directors.

Référence de publication: 2015050900/46.

Leopard Germany Ed 2 LP S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 156.096.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039809/10.
(150044963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Leopard Germany Property Ed 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 155.842.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039810/10.
(150044937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

ILP Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 109.755.

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 20 février 2015 que:
1. La personne suivante a démissionné de sa fonction de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 20

février 2015:

- Monsieur Christopher Finn;
2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau membre du conseil de gérance de la Société en qualité de

gérant de catégorie A pour une période illimitée, avec effet au 20 février 2015:

- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
3. L'adresse de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle, 4 

ème

 étage, L-1653 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mars 2015.

ILP Acquisitions S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015038649/19.
(150043448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

51034

L

U X E M B O U R G

3P (L) Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1142 Luxembourg, 1A, rue Pierre d'Aspelt.

R.C.S. Luxembourg B 133.951.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015040768/9.
(150046463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 111.928.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039860/10.
(150045010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Motion Prod Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 113.780.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015039879/10.
(150045438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

V.V.C. Holding G.m.b.H., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 47.694.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour V.V.C. Holding G.m.b.H. SPF
United International Management S.A.

Référence de publication: 2015040735/11.
(150045778) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Lendico Mexico S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.648.

En date du 1 

er

 octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg

au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.

En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, CIS Internet Holding (GP) précité, a également déménagé

son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Lendico Mexico S.C.Sp.

Référence de publication: 2015039802/14.
(150045491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

51035

L

U X E M B O U R G

Chamly International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 62.755.

La société ComCo S.A. enregistrée au RCSL sous le nr B112.813 dont le siège social est au 68, Rue de Koerich 8437

Steinfort a fusionné en date du 30 décembre 2014 avec la société HRT REVISION S.A. (RCSL B51.238), dont le siège
social est au 163, Rue du Kiem 8030 Strassen, société absorbante, qui a repris à la date du 30.12.2014.

Le mandat de commissaire aux comptes de HRT REVISION S.A. aura pour échéance la date de l'Assemblée Générale

Extraordinaire qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015040257/15.
(150045722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Elbblick (November) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 127.075.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à l'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 11 février 2015, les Associés:
- Prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir

du 11 février 2015 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 11 mars 2015.

Référence de publication: 2015040318/16.
(150045926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

CBRE Equity, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 191.412.

Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société en date du 13 février 2015 que Monsieur Patrick

Moinet a démissionné son poste de gérant de type B de la Société avec effet au 14 février 2015.

Il est décidé de nommer Monsieur Livio Gambardella, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie et résidant profession-

nellement au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg comme gérant de type B de la Société avec effet au 14 février 2015
pour une durée indéterminée.

Par conséquent, le conseil de gérance de la Société est maintenant composé comme suit:
- Laurence H. Midler comme gérant de type A de la Société;
- Philip George Emburey comme gérant de type A de la Société;
- Elizabeth Cormack Thetford comme gérant de type A de la Société;
- Becky H. Younger comme gérant de type A de la Société;
- Scott McKinlay comme gérant de type B de la Société; et
- Livio Gambardella comme gérant de type B de la Société.

Le 11 mars 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015040247/23.
(150045997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

51036

L

U X E M B O U R G

Delta M.G.M. Lux S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3784 Tétange, 12, rue de Rumelange.

R.C.S. Luxembourg B 185.356.

L'an deux mille quinze,
Le vingt-deux janvier,
Pardevant Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, soussigné,

Ont comparu:

1. Monsieur Mihajlo DUKIC, gérant de société, né à Bijeljina (Bosnie et Herzegovina), le 18 septembre 1956, demeurant

à BIH-76300 Bijeljina, Ul. Marka Miljanova, N2,

2. Monsieur Mehdija SKRIJELJ, entrepreneur de construction, né à Lagatore (Montenégro), le 1 

er

 juillet 1971, de-

meurant à L-3543 Dudelange, 25, rue Pasteur,

3. Monsieur Goran DUKIC, gérant de société, né à Bijeljina (Bosnie et Herzegovina), le 31 août 1973, demeurant à

BIH-76300 Bijeljina, Ul. Ugljevicka BB,

Ce dernier étant ici représenté par Monsieur Mehdija SKRIJELJ, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing

privé,

laquelle, après avoir été signée "ne varietur" par tous les comparants et le notaire instrumentant, restera annexée aux

présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l'enregistrement.

Lesquels comparants ont exposé au notaire instrumentaire ce qui suit:
Les comparants Mihajlo DUKIC, Mehdija SKRIJELJ et Goran DUKIC sont les seuls associés de la société à responsabilité

limitée "DELTA M.G.M. LUX S.à r.l.", ayant son siège social à L3784 Tétange, 12, rue de Rumelange, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 185356,

constituée suivant acte reçu par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 30

janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1263 du 17 mai 2014.

Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.-) représenté par cent (100) parts sociales

d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125.- €) chacune, entièrement souscrites et libérées comme suit:

- 34 parts sociales par Monsieur Mehdija SKRIJELJ, entrepreneur de construction, né à Lagatore (Montenégro), le 1

er

 juillet 1971, demeurant à L-3543 Dudelange, 25, rue Pasteur,

-  33  parts  sociales  par  Monsieur  Mihajlo  DUKIC,  gérant  de  société,  né  à  Bijeljina  (Bosnie  et  Herzegovina),  le  18

septembre 1956, demeurant à BIH-76300 Bijeljina, Ul. Marka Miljanova, N2,

- 33 parts sociales par Monsieur Goran DUKIC, gérant de société, né à Bijeljina (Bosnie et Herzegovina), le 31 août

1973, demeurant à BIH-76300 Bijeljina, Ul. Ugljevicka BB,

Lesquels comparants agissant en lieu et place de l'assemblée générale, ont pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution.

Monsieur Goran DUKIC, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, dix-sept (17) parts sociales,

inscrites au nom de Monsieur Goran DUKIC de la société «DELTA M.G.M. LUX S.à r.l.», prénommée, à Monsieur Mehdija
SKRIJELJ, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour le prix de deux mille cent vingt-cinq euros (2.125.- €).

La présente cession est faite moyennant le prix de deux mille cent vingt-cinq euros (2.125.- €), que le cédant reconnaît

avoir reçu du cessionnaire avant la passation des présentes et hors la présence du notaire instrumentaire, ce dont il
consent bonne et valable quittance au cessionnaire.

Le cessionnaire Monsieur Mehdija SKRIJELJ sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit

aux revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

<i>Deuxième résolution.

Monsieur Goran DUKIC, préqualifié, déclare céder et transporter en pleine propriété, seize (16) parts sociales, in-

scrites au nom de Monsieur Goran DUKIC de la société «DELTA M.G.M. LUX S.à r.l.», prénommée, à Monsieur Mihajlo
DUKIC, préqualifié, ici présent et ce acceptant, pour le prix de deux mille euros (2.000.-€).

La présente cession est faite moyennant le prix de deux mille euros (2.000.- €), que le cédant reconnaît avoir reçu du

cessionnaire avant la passation des présentes et hors la présence du notaire instrumentaire, ce dont il consent bonne et
valable quittance au cessionnaire.

Le cessionnaire Monsieur Mihajlo DUKIC sera propriétaire des parts cédées à partir des présentes et il aura droit aux

revenus et bénéfices dont ces parts sont productives à compter de ce jour.

<i>Troisième résolution.

L’assemblée générale déclare accepter la démission de Monsieur Goran DUKIC, prénommé, de sa fonction de gérant

administratif et lui donne décharge quant à l’exécution de son mandat.

51037

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution.

Monsieur Mehdija SKRIJELJ, préqualifié, agissant en sa qualité de gérant technique, Monsieur Mihajlo DUKIC, agissant

en sa qualité de gérant administratif, déclarent accepter les prédites cessions de parts pour compte de la société con-
formément à l'article 190 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, respectivement à
l'article 1690 du code civil, et ils déclarent dispenser les cessionnaires de les faire signifier à la société par voie d'huissier
et n'avoir entre leurs mains aucune opposition ou aucun empêchement qui puisse en arrêter l'effet.

<i>Souscription

Le capital a été souscrit comme suit:

1) Monsieur Mehdija SKRIJELJ, prénommé, cinquante et une parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

2) Monsieur Mihajlo DUKIC, prénommé, quarante-neuf parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Frais.

Les frais et honoraires des présentes et tous ceux qui en seront la conséquence seront à la charge solidaire des

comparants et de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Dudelange, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée en langue du pays aux comparants, connus du notaire instrumentaire

par nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. DUKIC, M. SKRIJELJ, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 février 2015. Relation: EAC/2015/3379. Reçu cent cinquante euros Amen-

des: 75,00 € + 75,00 €= 150,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins

de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 17 février 2015.

C. GOEDERT.

Référence de publication: 2015039659/81.
(150044881) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Auris Luxembourg I S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 183.386.

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh of Febuary,
Before Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Auris Luxembourg I S.A., a public limited liability company

(société anonyme) having its registered office at 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg and registered with the Luxem-
bourg Register of Commerce and Companies under number B 183.386, incorporated by a deed of the undersigned notary
residing in Esch-sur-Alzette, on 10 January 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
500 of 25 February 2014 (the “Company”). The articles of association of the Company have been amended for the last
time by a deed of the undersigned notary on 14 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

The meeting was presided by Eamonn McDONALD, lawyer, residing in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Aïcha CISSE, lawyer, residing in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Frédéric LEMOINE, attorney-at-law, residing in Luxembourg.
The chairman declared and requested the notary to state:
I. - That the shareholders and the number of shares held by them are shown on an attendance list, signed by the

chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be annexed
to this document to be filed with the registration authorities.

II. - That it appears from the attendance list, that all the one billion one hundred and sixty million (1,160,000,000)

shares are present or represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting may validly decide
on all the items of the agenda of which the shareholders have been duly informed ahead of the meeting.

III. - That the agenda of the meeting is the following:

51038

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda:

1. Decision to change the financial year of the Company so that it shall commence on the first day of October and end

on the last day of September of each year and therefore that (i) the first financial year of the Company ended on 31
December 2014 and (ii) the current financial year of the Company commenced on 1 January 2015 and will end on 30
September 2015.

2. Subsequent amendment of Article 15 of the articles of association of the Company.
IV. - After this had been set forth by the chairman and acknowledged by the members of the meeting, the meeting

proceeded to the agenda. The meeting having considered the agenda, the chairman submitted to the vote of the members
of the meeting the following resolutions which were taken unanimously:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change the financial year of the Company so that it shall commence on the first day

of October of each year and shall end on the last day of September of each year and therefore that (i) the first financial
year of the Company ended on 31 December 2014 and (ii) the current financial year of the Company commenced on 1
January 2015 and will end on 30 September 2015.

<i>Second resolution

The general meeting resolves, subsequently, to amend Article 15 of the articles of association of the Company, which

henceforth shall read as follows:

“ Art. 15. Financial year. The financial year of the Company starts on the first of October and ends on the thirtieth of

September of each year.”

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English, followed by a French translation and that in case of any divergences between the
English and the French text, the English version shall be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this do-

cument.

The document having been read to the appearing persons, known to the notary by name, surname, civil status and

residence, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

Follows the french version:

L'an deux mille quinze, le onze février,
Devant nous, Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

A COMPARU

A été tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Auris Luxembourg I S.A., une société anonyme

organisée selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 183.386, constituée suivant un acte
du notaire instrumentaire résidant à Esch-sur-Alzette, le 10 janvier 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 500 du 25 février 2014 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant un acte du notaire instrumentaire le 14 janvier 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.

L'assemblée était présidée par Eamonn McDONALD, juriste, résidant à Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Aïcha CISSE, juriste, résidant à Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Frédéric LEMOINE, avocat, résidant à Luxembourg.
Le président a déclaré et prié le notaire d'acter:
I. - Que les actionnaires et le nombre d'actions détenues par eux sont présentés sur une liste de présence, signée par

le président, la secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentaire. Ladite liste ainsi que les procurations seront annexées
à ce document pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. - Qu'il apparait d'après la liste de présence, que les un milliard cent soixante millions (1.160.000.000) actions sont

présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de manière à ce que l'assemblée puisse
décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour dont les actionnaires ont été dûment informés avant l'assemblée.

III. - Que l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Décision de modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence le premier jour d'octobre et se termine le

dernier jour de septembre de chaque année et donc que (i) le premier exercice social de la Société s'est terminé le 31

51039

L

U X E M B O U R G

décembre 2014 et (ii) l'exercice social en cours de la Société a commencé le 1 janvier 2015 et se terminera le 30 septembre
2015.

2. Modification subséquente de l'Article 15 des statuts de la Société.
Les résolutions suivantes sont prises:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'exercice social de la Société afin qu'il commence le premier jour d'octobre

de chaque année et se termine le dernier jour de septembre de chaque année et donc que (i) le premier exercice social
de la Société s'est terminé le 31 décembre 2014 et (ii) l'exercice social en cours de la Société a commencé le 1 janvier
2015 et se terminera le 30 septembre 2015.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide, en conséquence, de modifier l'Article 15 des statuts de la Société, qui aura désormais la

teneur suivante:

« Art. 15. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le 1 

er

 octobre et se termine le 30 septembre de

chaque année.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui parle et comprend l'anglais, déclare que sur la demande des personnes comparantes, le présent

acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise prévaudra.

DONT acte, passé à Luxembourg, en date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentaire par nom, prénoms, état et de-

meure, lesdites personnes comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: McDonald, Cissé, Lemoine, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 13 février 2015. Relation: EAC/2015/3876. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015039525/106.
(150045130) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Les Carles Property S.A., Société Anonyme,

(anc. Agatha Estates S.A.).

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 167.090.

L'an deux mille quinze, le sixième jour du mois de mars.
Par-devant nous Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

ESTATES S.A., une société anonyme ayant son siège social au 18, rue Robert Stümper, L 2557 Luxembourg et enre-

gistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 106 770,

en sa qualité d’actionnaire unique de Agatha Estates S.A., une société anonyme constituée et régie par les lois du Grand-

Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 167.090, constituée suivant acte du notaire soussigné, du
20 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 6 avril 2012, n° 907 et dont les statuts
ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire soussigné, du 9 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations du 14 août 2012, n° 2013 (la «Société»).

ici  représentée  par  Madame  Rachel  Germain,  maître  en  droit,  demeurant  professionnellement  au  18,  rue  Robert

Stümper, L 2557 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 2 mars 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

L’Actionnaire Unique a reconnu être pleinement informé des résolutions à prendre sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Changement de la dénomination sociale de la Société en “Les Carles Property S.A.” et modification subséquente de

l’article 1 des statuts de la Société;

51040

L

U X E M B O U R G

2 Divers.
L’Actionnaire Unique a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Actionnaire Unique décide de changer, avec effet immédiat, la dénomination sociale de la Société de “Agatha Estates

S.A.” en “ Les Carles Property S.A.” et de modifier en conséquence l’article 1 des statuts de la Société pour lui donner
désormais la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé une société anonyme sous la dénomination de «Les Carles Property S.A.».»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont

estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue française, déclare par la présente qu'à la demande de la personne

comparante ci-avant, le présent acte est rédigé en langue française, suivi d'une version anglaise, et qu'à la demande de la
même personne comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la personne comparante, connu du notaire

soussigné par ses nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Follows the English version of the preceding text:

In the year two thousand and fifteen, on the sixth day of the month of March.
Before us Maître Edouard Delosch, notary, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

ESTATES S.A., a société anonyme with registered office at 18, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg and registered

with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 106 770,

in its capacity as Sole Shareholder of Agatha Estates S.A., a société anonyme incorporated and existing under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper, registered
at the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 167.090, incorporated pursuant to a deed
of the undersigned notary, dated 20 February 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of
6 April 2012, n° 907, and whose articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated 9 July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 14 August
2012, n° 2013 (the “Company”).

duly represented by Mrs Rachel Germain, maître en droit, with professional address at 18, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, by virtue of a proxy dated 2 March 2015.

Said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present

deed for the purpose of registration.

The Sole Shareholder has requested to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following

agenda:

<i>Agenda

1. Change the denomination of the Company into “Les Carles Property S.A.” and to amend subsequently the article

1 of the articles of association of the Company;

2. Miscellaneous.
The Sole Shareholder has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting resolves to change, with immediate effect, the denomination of the Company from “Agatha Estates

S.A.” to “Les Carles Property S.A.” and to amend subsequently the article 1 of the articles of association of the Company
so as to henceforth read as follows:

“ Art. 1. A joint stock company is herewith formed under the name of “Les Carles Property S.A.”.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in French followed by a English version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the French and the English text, the French text will prevail.

51041

L

U X E M B O U R G

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing person, who is known to the undersigned notary

by his surname, first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original
deed.

Signé: R. GERMAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 09 mars 2015. Relation: DAC/2015/3908. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 10 mars 2015.

Référence de publication: 2015039509/88.
(150045160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Protea Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 80.092.

L'an deux mille quinze, le vingt-six février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du compartiment PROTEA FUND - KUYLENSTIERNA &amp; SKOG

EQUITIES de la société PROTEA FUND, société d'investissement à capital variable, avec siège social à 15, avenue J.F.
Kenneday, L-1855 Luxembourg, dûment inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 80092 et
constituée suivant acte de Maître Frank Baden, notaire de résidence à Luxembourg, le 10 janvier 2001, publié au Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C daté du 22 février 2001, numéro 138. Les statuts en ont été modifiés en dernier
lieu suivant acte notarié, en date du 21 juillet 2010, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro
2392 du 8 novembre 2010.

L'Assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Hugues de Monthébert, employé de banque, avec adresse

professionnelle à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président expose et prie alors le notaire instrumentant d'acter comme suit:
I.- Que toutes les actions étant nominatives, la présente assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée

par des avis contenant la convocation envoyés par lettre recommandée en date du 18 février 2015.

II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

Approbation de la fusion de PROTEA FUND KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES avec SEF -KUYLENSTIERNA &amp;

SKOG EQUITIES.

III.- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions détenues par chacun d'entre eux est indiqué

sur une liste de présence signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste ainsi
que les procurations seront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités de l'enregistrement.

III.- Qu'il apparaît de cette liste de présence que toutes les 2'345'275,16827 actions en circulation du compartiment

PROTEA FUND - KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES, sont présentes ou représentées à la présente assemblée gé-
nérale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut délibérer valablement sur son ordre du jour.

Ces faits ayant été approuvés par l'assemblée, cette dernière a pris à l'unanimité des voix la résolution suivante:

<i>Résolution:

L'Assemblée décide d'approuver la fusion du compartiment PROTEA FUND -KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES

avec le compartiment SEF -KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES de la société SEF, société d'investissement à capital
variable, avec siège social à L-1331 Luxembourg, 65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, (RCS Luxembourg B 168502)
et de fixer la date d'effet de fusion au 27 février 2015.

Tous les actionnaires, représentant 100% des actions en circulation, ont spécifiquement marqué leur accord sur la

suppression du préavis d'un mois.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

51042

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants le présent acte est

rédigé en français suivi d'une version anglaise; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte français et le texte anglais, le texte français fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of February.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of the sub-fund PROTEA FUND - KUYLENSTIERNA &amp; SKOG

EQUITIES” of the company PROTEA FUND, société d'investissement à capital variable, with registered office at Luxem-
bourg, RCS Luxembourg B 80092, incorporated by a deed of Maître Frank Baden, notary residing in Luxembourg, on
January 10, 2001, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C dated February 22, 2002, number
138. The Articles of Incorporation have been amended for the last time by a notarial deed of July 21, 2010, published in
the Mémorial, Recueil des Sociétés et Assocations number

The meeting is opened with Mr Hugues de Monthebert, bank employee, residing professionally in Luxembourg, in the

chair, who assumes also the function of scrutineer.

Mrs Arlette Siebenaler, employee, residing professionally in Luxembourg, is appointed secretary.
The chairman then declared and requested the notary to declare the following:
I.- That all the shares being registered shares, the present extraordinary general meeting has been convened by notices

containing the agenda sent to all the shareholders on 18 February 2015.

II- That the agenda of the present meeting is the following:
Approval of the merger of PROTEA FUND KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES into SEF- KUYENSTIERNA &amp;

SKOG EQUITIES.

III.- That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as
the proxies will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.

IV.- That it appears from the attendance list, that all the 2'345'275.16827 shares of the sub fund PROTEA FUND -

KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES, are represented at the present extraordinary general meeting, so that the meeting
can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>Resolution

The meeting resolves to approve the merger of PROTEA FUND KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES into the sub

fund SEF - KUYLENSTIERNA &amp; SKOG EQUITIES of the company SEF, société d'investissement à capital variable, with
registered office à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte and to fix the effective date of the
merger on February 27, 2015.

The shareholders, representing 100% of the outstanding shares, formally agree that the One Month prior Notice be

waived.

There being no further item on the agenda, the extraordinary meeting was thereupon closed.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of the document.
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the persons appearing the present

deed is worded in French followed by an English version; at the request of the appearing persons and in case of divergences
between the French text and the English text, the French text will prevail.

The document having been read to the persons appearing, the members of the bureau of the Extraordinary Meeting

signed together with the notary the present deed.

Signé: H. DE MONTHÉBERT, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 27 février 2015. Relation: 1LAC/2015/6169. Reçu douze euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015038812/92.
(150042869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

51043

L

U X E M B O U R G

Pizzeria Rossini, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 16, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 37.612.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le trois mars.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Marziale CACCHIONE, pensionné, demeurant à L-3321 Berchem, 32, rue Oscar Romero, Lequel comparant

a requis le notaire instrumentant d'acter:

- que la société PIZZERIA ROSSINI, une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1630 Luxembourg,

16, Rue Glesener, a été constituée suivant acte notarié en date du 15 juillet 1991, publié au Mémorial Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 37 du 1 

er

 février 1992, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro B 37612, («la Société»). Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant assemblée générale des
actionnaires tenue en date du 3 décembre 2001, dont un extrait a été publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 762 du 18 mai 2002;

- que le capital social de la société PIZZERIA ROSSINI s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (EUR

12.500,-) représenté par cinq cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune,
entièrement libérées;

- que M. Marziale CACCHIONE, précité, est devenu seul propriétaire de toutes les parts sociales et qu'il déclare avoir

parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la Société;

- que la partie comparante, en sa qualité d’associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée

et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l’associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 9 février 2015, déclare

que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;

La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associé unique est investi de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 9 février 2015 étant seulement un
des éléments d’information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée au gérant de la Société;
- il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-1630 Luxembourg,

16, Rue Glesener.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l’avoir social de, ou remboursement à, l’associé

unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à compter
de la publication et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et liquidée n’aura exigé la
constitution de sûretés

<i>Frais.

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués approximativement à mille euros (EUR 1.000,-).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par son nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Cacchione, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 4 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6627. Reçu soixante-quinze euros (75,00

€).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Référence de publication: 2015038808/54.
(150044217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

51044

L

U X E M B O U R G

Boomer Gestion SPF, S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

R.C.S. Luxembourg B 168.046.

La convention de Domiciliation concernant la société BOOMER GESTION SPF S.A. ayant son siège social au 20, Rue

de la Poste, L-2346 Luxembourg a été dénoncée avec effet en du 18/02/2015 par la société Citco C&amp;T (Luxembourg)
S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015038455/13.
(150044175) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Bazarkids S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6440 Echternach, 33, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 147.614.

L’an deux mil quinze, le dix-neuvième jour du mois de février.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

Ont comparu:

1.- Madame Marguerite SCHEFFEN, retraitée, née à Luxembourg, le 4 août 1950, demeurant à L-7258 Helmsange, 5,

rue des Pommiers, et

2.- Monsieur Michel WAGENER, fonctionnaire communale, né le 6 septembre 1964 à Luxembourg, demeurant à

L-7242 Helmsange 32, rue du Nord.

Lesquels comparants, prénommés, déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée BAZARKIDS

S. À R.L., avec siège social à L-6130 Junglinster, 14, route de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce à Luxembourg
sous la section B et le numéro 147614, constituée par acte reçu par le notaire soussigné, en date du 23 juillet 2009, publié
au Mémorial C du 4 septembre 2009, numéro 1705, (la «Société»).

Les associés, prénommés, ont prié le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les associés décident de transférer le siège social de la Société de L-6130 Junglinster, 14, route de Luxembourg, à

L-6440 Echternach, 33, rue de la Gare.

<i>Deuxième résolution

En conséquence les associés décident de modifier la première phrase de l'article deux des statuts pour lui donner

dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. (première phrase). "Le siège de la société est établi dans la commune d’Echternach."

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (1.100.-EUR).

<i>Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent pouvoir à tous clercs et employés de l'Étude du notaire

soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Marguerite Scheffen, Michel Wagener, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 23 février 2015. 1LAC / 2015 / 5587. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 mars 2015.

Référence de publication: 2015037649/40.
(150043427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

51045

L

U X E M B O U R G

Lendico Netherlands, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 180.209.

En date du 1 

er

 octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg

au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.

En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, CIS Internet Holding (GP) précité, a également déménagé

son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

Lendico Netherlands

Référence de publication: 2015039803/14.
(150045495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.

Axis 10 Sports Consulting Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 63, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 186.179.

EXTRAIT

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue le 23 février 2015, les associés de la Société ont:
- nommé Fernando Mendes, né le 15 août 1960 à Mortagua, Portugal, et résidant au 11, Rue Robert Schumann, L-4779

Petange, Luxembourg, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société avec effet au 5 mars 2015 pour une durée
indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Signature

Référence de publication: 2015040179/16.
(150045889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 mars 2015.

Carmudi Global S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Digital Services XXVI S.à r.l.).

Capital social: EUR 32.718,00.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.487.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of January,
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (he-
reinafter “AIH”),

being the holder of six thousand seventy-one (6,071) common shares and six thousand seventy-one (6,071) series A1

shares, and becoming the holder of five thousand four hundred sixty-eight (5,468) series B shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin,

Germany, on 27 January 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 26 January 2015,

2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “MKC”),

being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) common shares and one thousand eight hundred

seventy-five (1,875) series A2 shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin,

Germany, on 26 January 2015,

51046

L

U X E M B O U R G

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000) (hereinafter “Aismare”),

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares and one thousand five hundred eighteen

(1,518) series A3 shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munsbach

(L), on 28 January 2015,

4. TEC Global Invest VIII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26060, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares and one thousand five hundred eighteen

(1,518) series A3 shares, and becoming the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series B shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Mülheim an

der Ruhr, Germany, on 26 January 2015,

5. SHCO 57 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B183425, having its regis-
tered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter “SHCO”),

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) common shares and one thousand five hundred eighteen

(1,518) series A3 shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, on 28 January 2015, and

6. Leifina GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany,

registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRA 80493, having its business
address at Maximilianstr. 21, 80539 Munich, Germany (hereinafter “Leifina”),

becoming the holder of one thousand (1,000) series B shares,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Munich,

Germany, on 27 January 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1., 2., 3., 4. and 5. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XXVI S.à

r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 188487, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2516 on 17 September 2014. The articles of association have been amended
pursuant to a deed of notary Cosita Delvaux dated 13 January 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda whereby
Leifina participates and votes for the purpose of agenda point 5 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Amendment of the name of the Company from “Digital Services XXVI S.à r.l.” to “Carmudi Global S.à r.l.” and

subsequently amend article one (1) of the articles of association of the Company which shall now read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Carmudi

Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

2. Decision to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B shares (hereinafter “Series B Shares”),

with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have five (5) classes of shares in total, divided into common
shares, series A1 shares, series A2 shares, series A3 shares and Series B Shares.

3. Acceptance of Leifina GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany with its statutory seat in

Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRA 80493,
having its business address at Maximilianstr. 21, 80539 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the share capital of the Company by an amount of seven thousand seven hundred eighteen euro (EUR

7,718) from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000) up to thirty-two thousand seven hundred
eighteen euro (EUR 32,718) through the issuance of seven thousand seven hundred eighteen (7,718) Series B Shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

51047

L

U X E M B O U R G

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-two thousand seven hundred eighteen euro (EUR 32,718), represented

by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and

5.1.5 seven thousand seven hundred and eighteen (7,718) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”) and (vi) Leifina GmbH &amp;
Co KG (“Leifina”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO and Leifina jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be
entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an
investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved
by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or
more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital
increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH,
(iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO and (vi) Leifina shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks
after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC,
(v) SHCO and (vi) Leifina intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article
5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Carmudi Global

S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915  concerning  commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

51048

L

U X E M B O U R G

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-two thousand seven hundred eighteen euro (EUR 32,718), represented

by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and

5.1.5 seven thousand seven hundred and eighteen (7,718) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”) and (vi) Leifina GmbH &amp;
Co KG (“Leifina”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO and Leifina jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be
entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an
investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved
by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or
more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital
increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH,
(iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO and (vi) Leifina shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks
after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC,
(v) SHCO and/or (vi) Leifina intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this
Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

51049

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.

7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.

7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated

to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);

7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity

(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer of Shares from Leifina to a company affiliated to Leifina within the meaning of sections 15 et

seqq. German Stock Corporation Act (Aktiengesetz) and/or to any entity the ultimate owner of which is Dr. Kurt Schwarz,
the spouse of Dr. Kurt Schwarz and/or all children of Dr. Kurt Schwarz, provided that (i) the acquiring entity assumes all
rights and obligations under the existing shareholders' agreement in its most recent version among, inter alia, the sha-
reholders of the company and (ii) for the purpose of determining the Shareholders' or Investors majority all entities
succeeding Leifina jointly shall be deemed to be one (1) Investor;

7.4.4 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a shareholder to the Company and/or

any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme.

7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the

shareholders' meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.

7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.

8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Articles 8.2 and 8.3 below - will be distributed in accordance with Article 8.4 to the Shareholders pro rata to
their participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series B Shares shall receive per Share an amount of EUR 2,000 being

subject to the Liquidity Event.

8.3 On a second level (“Second Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares shall

receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being subject to the
Liquidity Event in the following table:

51050

L

U X E M B O U R G

Share Class

Amount

per Share

in Euro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.06

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553.25

Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,646.90

8.4 After the payments on the First Level and on the Second Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall

be allocated on a third level (“Third Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event.
Any amounts received by any Investor on the First Level and/or Second Level shall reduce the amount to be allocated to
such Investor on this Third Level provided that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First
Level and/or the Second Level. Irrespective of whether or not the sale of Shares is made in one Liquidity Event or after
the Liquidity Event in one transaction or more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its Shares
(and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an amount exceeding the higher of (i) its share in the
total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a common equivalent basis or (ii) the amount allocated
to such shareholder on the First Level and/or Second Level and/or Third Level from a subsequent sale. All rights related
to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.5 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so

long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.

Art. 9. Redemption of Shares.

9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:

9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.

10.1 Redemption is made against compensation.

10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.

10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

51051

L

U X E M B O U R G

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is

51052

L

U X E M B O U R G

no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the

consent of the Advisory Board:

17.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and

transformation of the Company;

17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

17.1.4  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing

shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of

the Investors.

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued Shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

51053

L

U X E M B O U R G

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions

and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros

(EUR 500,000.00) in aggregate;

22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;

51054

L

U X E M B O U R G

22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary

course of business;

22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set

forth in any shareholders' agreement between the shareholders;

22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections

291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and

22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of five (5) voting members. The shareholders may by way

of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.

25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders' consent.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having seven (7) votes, shall be nominated by the shareholder

AIH in its sole discretion;

25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder

LIH in its sole discretion;

25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder

Aismare in its sole discretion;

25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder

TEC in its sole discretion; and

25.3.5 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder

SHCO in its sole discretion.

25.4 Upon subscription to the Series B Shares Holtzbrinck I, Holtzbrinck shall be entitled to nominate one (1) voting

member of the Advisory Board, having one (1) vote (“Holtzbrinck Member”), in its sole discretion, and the other Sha-
reholders hereby undertake to increase the number of Advisory Board members by one (1) member, having one (1) vote,
upon subscription of the Series B Shares Holtzbrinck I.

51055

L

U X E M B O U R G

25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. The chairman shall be the member nominated

by the largest shareholder in terms of percentage participation that is entitled to nominate a member to the Advisory
Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions in particular on the self-orga-
nization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast. In case
of a vote tie, the chairman shall have a casting vote if at the point in time of the respective decision the Shareholder having
nominated the chairman holds more than 50 % of all shares in the Company. For the avoidance of doubt the deputy
chairman shall not have a casting vote.

25.6 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions

of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders' resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.

25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

51056

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

7. Appointment of Mr Julien De Mayer as new class B manager of the Company with immediately effect and for an

unlimited duration.

8. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr Rüdiger

Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register of the Company.

9. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders decides to modify the name of the Company from “Digital Services XXVI S.à r.l.”

to “Carmudi Global S.à r.l.” and subsequently amend article one (1) of the articles of association of the Company which
shall now read as follows:

“ Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Carmudi

Global S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.”

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, referred to as the series B

shares (hereinafter “Series B Shares”), with a nominal value of one euro (EUR 1) each, and to hence have five (5) classes
of shares in total, divided into common shares, series A1 shares, series A2 shares, series A3 shares and Series B Shares.

<i>Third Resolution

The general meeting of shareholders accepts Leifina GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany

with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany,
under no. HRA 80493, having its business address at Maximilianstr. 21, 80539 Munich, Germany, as new shareholder of
the Company.

<i>Fourth Resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the share capital of the Company by an amount of seven

thousand seven hundred eighteen euro (EUR 7,718) from its current amount of twenty-five thousand euro (EUR 25,000)
up to thirty-two thousand seven hundred eighteen euro (EUR 32,718) through the issuance of seven thousand seven
hundred eighteen (7,718) Series B Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The new seven thousand seven hundred eighteen (7,718) Series B Shares have been duly subscribed as follows:
1. five thousand four hundred sixty-eight (5,468) Series B Shares have been subscribed by AIH, aforementioned, for

the subscription price of five thousand four hundred sixty-eight euro (EUR 5,468);

2. one thousand two hundred fifty (1,250) Series B Shares have been subscribed by TEC, aforementioned, for the

subscription price of one thousand two hundred fifty euro (EUR 1,250); and

3. one thousand (1,000) Series B Shares have been subscribed by Leifina, aforementioned, for the subscription price

of one thousand euro (EUR 1,000).

51057

L

U X E M B O U R G

<i>Payment

The new seven thousand seven hundred eighteen (7,718) Series B Shares subscribed by AIH, TEC and Leifina, afore-

mentioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of seven thousand seven hundred
eighteen euro (EUR 7,718).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of seven thousand seven hundred eighteen euro (EUR 7,718) is entirely allocated to

the share capital of the Company.

<i>Fifth Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article five (5)

of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirty-two thousand seven hundred eighteen euro (EUR 32,718), represented

by:

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (he-

reinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) series A1 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) series A2 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) series A3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”),
and

5.1.5 seven thousand seven hundred and eighteen (7,718) series B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series B Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”), (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”) and (vi) Leifina GmbH &amp;
Co KG (“Leifina”; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO and Leifina jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be
entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an
investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”)) and which has been approved
by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or
more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital
increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH,
(iii) Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO and (vi) Leifina shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks
after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC,
(v) SHCO and (vi) Leifina intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article
5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”

<i>Sixth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the

articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders appoints Mr Julien De Mayer, private employee, born on 9 April 1982, in Etterbeek,

Belgium, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new class B
manager with immediately effect and for an unlimited duration.

<i>Eighth Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Mr. Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register
of the Company.

51058

L

U X E M B O U R G

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 2,300.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Januar,
vor uns, der unterzeichnenden Notarin Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg („AIH“),

Inhaber von sechstausendeinundsiebzig (6.071) Stammanteilen und sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der

Serie A1 und zukünftiger Inhaber von fünftausendvierhundertachtundsechzig (5.468) Anteilen der Serie B,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in

Berlin, Deutschland, am 27. Januar 2015 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 26. Januar 2015,

2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („MKC“),

Inhaber  von  eintausendachthundertfünfundsiebzig  (1.875)  Stammanteilen  und  eintausendachthundertfünfundsiebzig

(1.875) Anteilen der Serie A2,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Januar

2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000) („Aismare“),

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen und eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) An-

teilen der Serie A3,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 28. Januar

2015, ausgestellt in Munsbach (L),

4. TEC Global Invest VIII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26060, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen und eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) An-

teilen der Serie A3 und zukünftiger Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie B,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 26. Januar

2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland,

5. SHCO 57 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und be-

stehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister  unter  der  Nummer  B183425,  mit  Sitz  in  13-15,  avenue  de  la  Liberté,  L-1931  Luxemburg,  Großherzogtum
Luxemburg („SHCO“),

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Stammanteilen und eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) An-

teilen der Serie A3,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 28. Januar

2015, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, und

6. Leifina GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft bestehend unter deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz

in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer
HRA 80493, mit Geschäftssitz in Maximilianstr. 21, 80539 München, Deutschland („Leifina“),

51059

L

U X E M B O U R G

zukünftiger Inhaber von eintausend (1.000) Anteilen der Serie B,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 27. Januar

2015, ausgestellt in München, Deutschland.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-

raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1., 2., 3., 4. und 5. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services

XXVI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz
in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister  unter  der  Nummer  B  188487,  gegründet  am  18.  Juni  2014  gemäß  einer  Urkunde  des  Notars  Carlo
Wersandt, welche am 17. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2516 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde am 13. Januar 2015 gemäß einer Urkunde der Notarin Cosita Delvaux
geändert, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln, wobei Leifina ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teil-
nahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Änderung des Namens der Gesellschaft von „Digital Services XXVI S.à r.l.“ in „Carmudi Global S.à r.l.“ und de-

mentsprechende Änderung des Artikels eins (1) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Carmudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

2. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Klasse von Anteilen, welche als Anteile der Serie B (die „Anteile

der Serie B“) bezeichnet werden, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und nunmehr insgesamt fünf (5)
Anteilsklassen zu haben, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie B.

3. Aufnahme von Leifina GmbH &amp; Co. KG, einer Kommanditgesellschaft bestehend unter deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 80493, mit Geschäftssitz in Maximilianstr. 21, 80539 München, Deutschland, als neuer Gesell-
schafter der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro

(EUR 25.000) um einen Betrag von siebentausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 7.718) auf einen Betrag von zwei-
unddreißigtausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 32.718) durch die Ausgabe von siebentausendsiebenhundertacht-
zehn (7.718) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zweiunddreißigtausendsiebenhundertachtzehn  Euro  (EUR

32.718), bestehend aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.5 siebentausendsiebenhundertachtzehn (7.718) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“)
und (vi) Leifina GmbH &amp; Co KG („Leifina“; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO und Leifina gemeinschaftlich die „Investoren“
und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile

51060

L

U X E M B O U R G

berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter,
noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels
5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Carmudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zweiunddreißigtausendsiebenhundertachtzehn  Euro  (EUR

32.718), bestehend aus:

51061

L

U X E M B O U R G

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.5 siebentausendsiebenhundertachtzehn (7.718) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“)
und (vi) Leifina GmbH &amp; Co KG („Leifina“; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO und Leifina gemeinschaftlich die „Investoren“
und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile
berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter,
noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels
5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:

51062

L

U X E M B O U R G

7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);

7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines

Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung von Anteilen von Leifina an eine mit Leifina verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15

ff. des Deutschen Aktiengesetzes und/oder an ein Unternehmen, deren letztendliche/r Eigentümer/in Dr. Kurt Schwarz,
die Ehefrau von Dr. Kurt Schwarz und/oder die Kinder von Dr. Kurt Schwarz sind, vorausgesetzt, dass (i) das erwerbende
Unternehmen alle Rechte und Pflichten aus der bestehenden Gesellschaftervereinbarung in ihrer letzten Fassung zwischen,
unter anderem, den Gesellschaftern der Gesellschaft, wahrnimmt und (ii) alle Rechtsnachfolger von Leifina zum Zwecke
der Bestimmung der Gesellschafter- oder Investorenmehrheit gemeinschaftlich als ein (1) Investor angesehen werden;

7.4.4 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.

7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren

Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.

7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der

Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich der Artikel 8.2 und 8.3 - im Einklang mit Artikel 8.4 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer
Beteiligung am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie B pro Anteil einen Betrag von

EUR 2.000, vorausgesetzt, dass das Liquiditätsereignis eingetroffen ist.

8.3 Auf einer zweiten Ebene („Zweite Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2

und Anteilen der Serie A3 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle neben der entsprechenden
vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse vereinbarten Betrag:

Anteilsklasse

Betrag

pro Anteil

in Euro

Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,06

Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553,25

Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.646,90

8.4 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene und auf der Zweiten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen

Exiterlöse auf einer dritten Ebene („Dritte Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entspre-
chend  ihrer  Beteiligung  am  Liquiditätsereignis  verteilt.  Sämtliche  von  einem  Investor  auf  der  Ersten  Ebene  und/oder
Zweiten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Dritten Ebene,
mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene erhaltenen

51063

L

U X E M B O U R G

Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines Liquiditätsereignisses oder danach
in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu den Anteilen, die auf einer gemeinsamen
und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/
oder  Zweiten  Ebene  und/oder  Dritten  Ebene  aus  einem  späteren  Verkauf  zugeteilt  wurde.  Sämtliche  mit  der  hierin
festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.5 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie

dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

51064

L

U X E M B O U R G

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

51065

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-

schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und

Umwandlung der Gesellschaft;

17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;

17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder

die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-

stimmung der Investoren:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

51066

L

U X E M B O U R G

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte

und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-

derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;

22.8.3  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;

22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

51067

L

U X E M B O U R G

22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;

22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des

gewöhnlichen Geschäftsgangs;

22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,

wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;

22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes

(AktG)); und

22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwi-
schen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers,  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/

oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit sieben (7) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

51068

L

U X E M B O U R G

25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter TEC nach

eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.5 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem
Gesellschafter SHCO nach eigenem Ermessen ernannt.

25.4 Bei Zeichnung der Anteile der Serie B Holtzbrinck I wird Holtzbrinck dazu ermächtigt, ein (1) stimmberechtigtes

Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme („Holtzbrinck Mitglied“) nach eigenem Ermessen zu ernennen, und die anderen
Gesellschafter verpflichten sich hiermit dazu, bei Zeichnung der Anteile der Serie B Holtzbrinck I die Anzahl der Mitglieder
des Beirats um ein (1) Mitglied mit einer (1) Stimme zu erhöhen.

25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Beirats ist das

Mitglied, welches von dem Gesellschafter ernannt wurde, welcher von der prozentualen Beteiligung her der größte der-
jenigen ist, welche zur Ernennung eines Beiratsmitglieds ermächtigt sind. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmgleichheit hat der Vorsitzende die entscheidende Stimme, sofern
zu dem Zeitpunkt der jeweiligen Entscheidung derjenige Gesellschafter, der den Vorsitzenden ernannt hat, mehr als 50%
aller Anteile an der Gesellschaft hält. Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass der stellvertretende Vorsitzende
nicht die entscheidende Stimme hat.

25.6 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, (ii) dieser
Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v) entsprech-
ender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten können
dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen hat der
Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund Ver-
lustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

51069

L

U X E M B O U R G

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

7. Ernennung von Herrn Julien De Mayer als neuer Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft mit sofortiger

Wirkung und für unbegrenzte Dauer.

8. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, den Namen der Gesellschaft von „Digital Services XXVI S.à r.l.“ in „Car-

mudi Global S.à r.l.“ zu ändern und Artikel eins (1) der Satzung der Gesellschaft dementsprechend zu ändern, welcher
nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Carmudi Global S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Han-
delsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.“

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Klasse von Anteilen zu schaffen, welche als Anteile der

Serie B (die „Anteile der Serie B“) bezeichnet werden, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), und nunmehr
insgesamt fünf (5) Anteilsklassen zu haben, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile
der Serie A3 und Anteile der Serie B.

<i>Dritter Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  akzeptiert  Leifina  GmbH  &amp;  Co. KG, eine  Kommanditgesellschaft bestehend  unter

deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
München, Deutschland, unter der Nummer HRA 80493, mit Geschäftssitz in Maximilianstr. 21, 80539 München, Deutsch-
land, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) um einen Betrag von siebentausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 7.718)
auf einen Betrag von zweiunddreißigtausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 32.718) durch die Ausgabe von sieben-

51070

L

U X E M B O U R G

tausendsiebenhundertachtzehn (7.718) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu
erhöhen.

<i>Zeichnung

Die neuen siebentausendsiebenhundertachtzehn (7.718) Anteile der Serie B wurden ordnungsgemäß wie folgt ge-

zeichnet:

1. fünftausendvierhundertachtundsechzig (5.468) Anteile der Serie B wurden von AIH, vorbenannt, zu einem Bezugs-

preis von fünftausendvierhundertachtundsechzig Euro (EUR 5.468) gezeichnet;

2. eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie B wurden von TEC, vorbenannt, zu einem Bezugspreis von

eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) gezeichnet; und

3. eintausend (1.000) Anteile der Serie B wurden von Leifina, vorbenannt, zu einem Bezugspreis von eintausend Euro

(EUR 1.000) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von AIH, TEC und Leifina, vorbenannt, gezeichneten siebentausendsiebenhundertachtzehn (7.718) neuen Anteile

der Serie B wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von siebentausendsiebenhundertachtzehn Euro
(EUR 7.718).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin

erbracht.

Die Einlage in Höhe von siebentausendsiebenhundertachtzehn Euro (EUR 7.718) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Fünfter Beschluss

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf (5) der Satzung der Ge-

sellschaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zweiunddreißigtausendsiebenhundertachtzehn  Euro  (EUR

32.718), bestehend aus:

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden), und

5.1.5 siebentausendsiebenhundertachtzehn (7.718) Anteilen der Serie B mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie B“).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“), (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“)
und (vi) Leifina GmbH &amp; Co KG („Leifina“; AIH, LIH, Aismare, TEC, SHCO und Leifina gemeinschaftlich die „Investoren“
und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile
berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter,
noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv)
TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii)
Aismare, (iv) TEC, (v) SHCO und (vi) Leifina ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels
5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend
anwendbar.“

51071

L

U X E M B O U R G

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-

fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Julien De Mayer, private employee, geboren am 9. April 1982 in Et-

terbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, als neuen Ge-
schäftsführer der Kategorie B mit sofortiger Wirkung und für unbegrenzte Dauer.

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  sowie  Herrn  Rüdiger  Trox,  das  Anteilsinhaberregister  der  Gesellschaft  in  Einzelunterschrift  und  mit  uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden

Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.300,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3357. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 26. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015039110/1443.
(150044773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

Villa D'Asie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8384 Koerich, 4, rue Windhof.

R.C.S. Luxembourg B 148.883.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 2 mars 2015

L'assemblée générale prend acte de:
La cession de parts en date du 2 mars 2015, que Monsieur PAN Liping cède 20 parts sociales de la société à Monsieur

ZHANG Zixian, de fait que la nouvelle répartition des parts sociales s'établit comme suit:

- Monsieur ZHANG Zixian, soixante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

- Madame PAN Qiangqiang, quarante parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

Total: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Changement d'adresse des associés
L'adresse privée de Monsieur ZHANG Zixian et Madame PAN Qiangqian est à L-8384 Koerich, 4, rue Windhof.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Koerich, le 02/03/2015.

<i>Pour la société
Villa d'Asie s.à r.l.

Référence de publication: 2015039456/20.
(150044377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

51072


Document Outline

3P (L) Sàrl

Adma A.G.

Agatha Estates S.A.

Altercap CCA I SA

Auris Luxembourg I S.A.

Axis 10 Sports Consulting Group S.à r.l.

Bazarkids S. à r.l.

Boomer Gestion SPF, S.A.

Caissa S.A. SPF

Carmudi Global S.à r.l.

CBRE Equity

Chamly International S.A.

Combolux S.A.

Compagnie Margaux S.A. SPF

Coverlux S.A.

Cristalnet S.à r.l.

Delphimmo

Delta M.G.M. Lux S. à r.l.

Delux Private Investments S.A.

Digital Services XXVI S.à r.l.

Elbblick (November) S.à r.l.

FarVision S.à r.l.

Gestielle Investment Sicav

ILP Acquisitions S.à r.l.

KEB S.A.

Kilbroney Investments S.A.

Lendico Mexico S.C.Sp.

Lendico Netherlands

Leopard Germany Ed 2 LP S.à.r.l.

Leopard Germany Property Ed 1 S.à.r.l.

Les Carles Property S.A.

Licensing Invest S.A.

Luxembourg Kirchberg Investment S. à r.l.

Mora Funds SICAV

Motion Prod Management S.A.

NextEnergy Capital S.à r.l.

Pizzeria Rossini

Platinum Funds

Protea Fund

Spray Peace

Starting 2008 Investment S.à r.l.

Sucafina Holding

Truffe Capital S.à r.l.

Villa D'Asie S.à r.l.

Vison

V.V.C. Holding G.m.b.H., SPF