logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1043

21 avril 2015

SOMMAIRE

Akragas SIF-SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50030

AM Fine Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

50025

Armat GGH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50022

Atrium Dominikanska SCSp  . . . . . . . . . . . .

50063

Centrale Immobilière du Luxembourg SA,

en abrégé C.I.L. SA.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50022

Ceratungsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50026

CEREP III Eastern S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

50018

CEREP II Investment Ten S.à r.l.  . . . . . . . .

50018

CETP III Participations S.à r.l. SICAR  . . . .

50021

Charcot Fox Participations . . . . . . . . . . . . . .

50019

Chemical Project Investments S.A.  . . . . . .

50026

Cled S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50021

Cyriel Investissement S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

50020

Darla S.à.r.l., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50064

Diffusion Benelux Parfumerie SA  . . . . . . . .

50024

Digital Services Holding XXI s.à r.l.  . . . . . .

50042

Dome 3 0909 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50024

Durimmo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50025

ECM Credit Fund SICAV  . . . . . . . . . . . . . . .

50018

Effetre Investment & Trading Company

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50019

Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l.  . .

50026

Euro Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50020

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l.  . . . . . . .

50019

Federal Express Luxembourg, Inc.  . . . . . . .

50018

Fondation Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50021

Global Bond Series IV, S.A.  . . . . . . . . . . . . .

50018

Global Bond Series IX S.A. . . . . . . . . . . . . . .

50020

Global Bond Series VI, S.A.  . . . . . . . . . . . . .

50023

Global Investor Solutions I SA . . . . . . . . . . .

50034

Globalstone Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

50019

Groove Corporate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

50020

HSBC Investment Funds (Luxembourg)

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50019

Immobilière Josy Welter S.à r.l.  . . . . . . . . .

50023

Institut de la Propriété Intellectuelle Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50033

Intralot Finance Luxembourg S.A.  . . . . . . .

50023

Katcon Global S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50027

Les Laboratoires homéopathiques du Lu-

xembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50022

Luxoutils Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50029

MCCI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50023

Mevengreen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50030

Parker Hannifin Global Capital Manage-

ment  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50038

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l. . . . . . . .

50035

Retail Investment I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50025

Simap Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50021

STRAT & Fi Lux  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50022

TRS Venture S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50024

50017

L

U X E M B O U R G

Federal Express Luxembourg, Inc., Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 27.511.

Les comptes annuels au 31 mai 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037835/9.
(150042022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

CEREP II Investment Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.036.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015037717/10.
(150043363) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

CEREP III Eastern S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.378.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015037718/10.
(150043390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

ECM Credit Fund SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 148.817.

Les statuts coordonnés au 27/02/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 09/03/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015039128/12.
(150044560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

Global Bond Series IV, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 157.026.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015037862/13.
(150043029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

50018

L

U X E M B O U R G

Globalstone Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5244 Sandweiler, 2B, Ennert dem Bierg.

R.C.S. Luxembourg B 185.105.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 252 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037870/9.
(150042775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Charcot Fox Participations, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 143.540.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015037730/10.
(150043109) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 110.860.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015037821/10.
(150042441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 57.941.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015039130/12.
(150044472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 28.888.

Les administrateurs de HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A. ont noté la démission de Madame Alexa

Coates (demeurant au Royaume-Uni, St James Street 78, SW1 A1JB Londres) comme Administrateur du Conseil d'Ad-
ministration avec effet au 13 février 2015.

<i>Pour HSBC INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG) S.A.
HSBC Bank plc, Luxembourg Branch
Signatures

Référence de publication: 2015037923/13.
(150042997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

50019

L

U X E M B O U R G

Groove Corporate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 191.556.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015037875/10.
(150042691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Cyriel Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.910.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037746/10.
(150042890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Global Bond Series IX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.444.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015037863/13.
(150043093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Euro Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 137.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 191.295.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société

En date du 23 février 2015 l'associé unique de la Société a accepté la nomination des nouveaux gérants de la Société:
- M. Mark Zünd, né le 10 septembre 1967 à Balgach, Suisse, résident professionnellement au 20 Sihlstrasse, 8021 Zurich,

Suisse, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

- M. Russell Proffitt-Perchard, né le 16 janvier 1978 à St Helier, Jersey, Channel Islands, résident professionnellement

au 40 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a été nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée.

Le conseil de gérance est désormais composé comme suit:
- M. Maxence Philippe Alexis Monot, (gérant);
- M. John Howard Cosnett, (gérant);
- M. Mark Zünd, (gérant);
- M. Russell Proffitt-Perchard, (gérant);
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mars 2015.

Référence de publication: 2015038539/21.
(150043483) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50020

L

U X E M B O U R G

Cled S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8011 Strassen, 309, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 169.851.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CLED S.àr.l.

Référence de publication: 2015038500/10.
(150043603) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Fondation Peters, Fondation.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg G 227.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2015038566/10.
(150042952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Simap Finance S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 48.000.

La convention de Domiciliation concernant la société SIMAP FINANCE S.A. ayant son siège social au 20, Rue de la

Poste, L-2346 Luxembourg a été dénoncée avec effet en date du 18/02/2015 par la société Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015039399/12.
(150044290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

CETP III Participations S.à r.l. SICAR, Société à responsabilité limitée sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 184.620.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 06 mars 2015 que:
1. La personne suivante a démissionné de sa fonction de membre du conseil de gérance de la Société avec effet au 06

mars 2015:

- Monsieur Christopher Finn;
2. La personne suivante a été nommée en tant que nouveau membre du conseil de gérance de la Société pour une

période illimitée, avec effet au 06 mars 2015:

- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
3. L'adresse de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle, 4 

ème

 étage, L-1653 Luxembourg;

Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Madame Erica K. Herberg, membre du conseil de gérance de la Société,

a changé comme suit: 57, Berkeley Square, Lansdowne House, W1J 6ER London, United Kingdom.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 mars 2015.

CETP III Participations S.à r.l. SICAR
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015038495/22.
(150043493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50021

L

U X E M B O U R G

STRAT &amp; Fi Lux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1740 Luxembourg, 20, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 174.799.

Les statuts coordonnés suivant l'acte n° 250 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015038241/9.
(150042537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Les Laboratoires homéopathiques du Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 17.214.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037988/9.
(150043419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Armat GGH S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 176.854.

EXTRAIT

La nouvelle adresse de Monsieur Didier Bensadoun est la suivante:
4, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

ARMAT GGH S.A.

Référence de publication: 2015038405/13.
(150043898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Centrale Immobilière du Luxembourg SA, en abrégé C.I.L. SA., Société Anonyme.

Siège social: L-2167 Luxembourg, 134, rue des Muguets.

R.C.S. Luxembourg B 106.476.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue de manière ordinaire le 3 mars 2014

Le 3 mars 2014 s'est tenue de manière ordinaire, au siège social de la société, l'Assemblée Générale Annuelle des

Actionnaires, durant laquelle les résolutions suivantes ont été prises:

L'assemblée a nommé comme Administrateur et Administrateur-délégué avec pouvoir de signature individuelle:
- Mr. Bouraoui EL KHAL, demeurant rue des Muguets, 134 à 2167 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2016 qui statuera sur les comptes au 31.12.2015.
Comme Administrateur:
- Mme Nadia EL KHAL, demeurant rue des Maraichers, 90 à 2124 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2016 qui statuera sur les comptes au 31.12.2015.
- Mr. Rami EL KHAL, demeurant rue des Maraichers, 90 à 2124 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de 2016 qui statuera sur les comptes au 31.12.2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme
Centrale Immobilière Luxembourg S.A. C.I.L.
Bouraoui EL KHAL / Nadia EL KHAL / Rami EL KHAL
<i>Administrateur / Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015038481/23.
(150043653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50022

L

U X E M B O U R G

Intralot Finance Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 177.543.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015037930/13.
(150042482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Global Bond Series VI, S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 159.221.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015037864/13.
(150043128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Immobilière Josy Welter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1623 Luxembourg, 10, rue Génistre.

R.C.S. Luxembourg B 5.339.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015037929/14.
(150042429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

MCCI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste Lumière.

R.C.S. Luxembourg B 186.209.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 29 janvier 2015, le conseil d'administration de MCCI S.à.r.l a transféré le siège social

de la société ainsi que le changement d'adresse de Mademoiselle Alix le LEVREUR-BARTON au 14 rue Auguste Lumière
L1950 Luxembourg, avec effet au 15 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 6 mars 2015.

Référence de publication: 2015038049/14.
(150042903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

50023

L

U X E M B O U R G

TRS Venture S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 165.696.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015038385/14.
(150044072) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Diffusion Benelux Parfumerie SA, Société Anonyme.

Siège social: L-9647 Doncols, 98, Duerfstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 92.688.

Monsieur Michel Ghislain Nicolas Marcel TRIFAUX, administrateur et administrateur-délégué, déclare que son adresse

est désormais au 98 Duerfstrooss L-9647 DONCOLS.

Madame Françoise LUPCIN-GIGOT, commissaire aux comptes, déclare que son adresse est désormais au 27 Burre-

beerig L-9676 NOERTRANGE.

Luxembourg, le 9 mars 2015.

<i>Pour DIFFUSION BENELUX PARFUMERIE SA
Fiduciaire des P.M.E.
Société anonyme
Signatures

Référence de publication: 2015039117/16.
(150044480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

Dome 3 0909 S. à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 149.704.

Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 20 février 2015 que:
1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec

effet au 20 février 2015:

- Madame Erica K. Herberg;
- Monsieur Christopher Finn;
- Monsieur David B. Pearson;
- CEP II Managing GP Holdings, Ltd.;
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour

une période illimitée, avec effet au 20 février 2015:

- Monsieur William Cagney, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- CEP II Advisor S.à r.l., avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
3. L'adresse de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle, 4 

ème

 étage, L-1653 Luxembourg;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05 mars 2015.

Dome 3 0909 S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015038520/24.
(150043449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50024

L

U X E M B O U R G

Retail Investment I, Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 183.232.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015038162/14.
(150042594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Durimmo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 116.630.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 02 mars 2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue en date du 02 mars 2015:
L'Assemblée décide de nommer en remplacement de Madame Visaka KIMARI démissionnaire, au poste d'Adminis-

trateur Unique, jusqu'à l'Assemblée Générale d'approbation des comptes qui se tiendra en 2020:

-  Madame  Nicole  WALLEMACQ,  née  le  02  octobre  1983  à  Arlon  (Belgique),  demeurant  professionnellement  au

296-298 route de Longwy L-1940 Luxembourg.

<i>Le Mandataire

Référence de publication: 2015039111/15.
(150044659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

AM Fine Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 174.172.

<i>Procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 2 janvier 2015

L'an deux mille quinze, et le 2 janvier à neuf heures,
Les associés de la société «AM fine Luxembourg», Société à Responsabilité Limitée au Capital de 15.000 €uros, divisée

en 1500 parts de 10 €uro chacune, se sont réunis en Assemblée Générale, au siège social sur convocation du Gérant.

Sont présents ou représentés:
«BADAJAM Software» SAS, associé unique, propriétaire de 1 500 parts représentée par Monsieur Michaël PRIEM,

Président,

L'assemblée est présidée par le Gérant de la société, Monsieur Michaël PRIEM.
Le Président dépose sur le bureau et met à disposition de l'Assemblée:
- les copies des lettres de convocation,
- le texte des résolutions proposées.
Le président constate que l'actionnaire unique détient l'intégralité du capital social; en conséquence, l'assemblée ré-

gulièrement convoquée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de transférer le siège social de la société du 17, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg

au 9b, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, et ce, à compter de ce jour.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Référence de publication: 2015038396/25.
(150044168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50025

L

U X E M B O U R G

Chemical Project Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 72.868.

EXTRAIT

Il résulte de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 mars 2015 que le siège social de la société a

été transféré de son ancienne adresse au 10, rue Antoine Jans à L-1820 Luxembourg.

En outre, il est à noter que Madame Laurence BARDELLI et Monsieur Vincent WILLEMS, sont désormais domiciliés

au 10, rue Antoine Jans L-1820 à Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015038498/13.
(150043464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Ceratungsten, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4562 Niederkorn, route de Bascharage, Z.I. Hahneboesch.

R.C.S. Luxembourg B 24.496.

Le vingt-six février 2015 l'associé unique de la société CERATUNGSTEN sarl a résolu:
MM. Jacques Lanners et John O'Hara ne sont plus gérants à partir du premier mars 2015.
Avec effet au premier mars 2015, M. Paul Jung, né le 19 juillet 1964 à Luxembourg, domicilié à 23, rue Joseph Flies,

L-9061 Ettelbruck a été nommé gérant pour une durée indéterminée.

Mamer, le 3 mars 2015.

Gerhard Kerckhoff
<i>Corporate Secretary

Référence de publication: 2015038491/14.
(150043664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 175.927.

Il en résulte des résolutions en date du 2 Mars 2015 que:
- La désignation de Promocions GSVB S.L comme gérant de la société pour une période indéterminée.
- La désignation de Mathieu Gangloff, dont l’adresse est 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg comme gérant

de la société pour une période indéterminée.

- Les gérants sont divisés en Gérant de Classe A et Classe B de la manière suivante:

<i>Gérant de Classe A:

- Ian Sandford
- Promocions GSVB S.L

<i>Gérant de Classe B:

- Hermanus Troskie
- Mathieu Gangloff
Il en résulte du transfert de parts sociales sous forme nominative en date du 2 Mars 2015 que:
- Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a transféré le 2 Mars 2015

29,167 parts sociales sous forme nominative a Promocions GSVB S.L, Roncesvalles 19, Begues, Barcelona 08859, Spain.

- Eurofund Investments Luxembourg S.à r.l., 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg a transféré le 2 Mars 2015

29,167 parts sociales sous forme nominative a Social Efforts S.L. C/ Marcelino Alvarez 11 casa 43, 50012 Zaragoza, Spain.

Luxembourg, le 06 Mars 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015038540/27.
(150043692) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50026

L

U X E M B O U R G

Katcon Global S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4940 Hautcharage, 5, rue Bommel.

R.C.S. Luxembourg B 143.038.

In the year two thousand fourteen, on the twenty-third day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of shareholders of Katcon Global S.A., a Luxembourg société anonyme,

having its registered office at 5, rue Bommel, L-4940 Hautcharage, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 143.038. The Company was incorporated by a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing
in Luxembourg on November 14, 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial
C) on December 3, 2008 under number 2887. The articles of association of the Company have been lastly amended by
a notarial deed enacted on 1 

st

 July 2013, published in the Mémorial C number 2116 dated 30 August 2013. (the Company).

The Meeting was opened by the Chairman, Régis Galiotto, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg,
who appointed as Secretary and the Meeting elected as Scrutineer Solange Wolter, notary’s clerk, with professional

address in Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the Meeting is the following:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 726,400.- and issuance of 7,264 new ordinary

shares of the Company with a par value of EUR 100 each, having the same rights and obligations as the already existing
ordinary shares of the Company;

3. Amendment of the article 5.1 of the articles of association of the Company to reflect the share capital increase of

the Company; and

4. Amendment of the share register of the Company.
II. The shareholders represented at the Meeting and the number of shares they hold are shown on an attendance list.

This attendance list as well as the proxies, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties, the
officers of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed.

III. As appears from the said attendance list, all the issued share capital of the Company is represented at the Meeting,

so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

IV. The Meeting unanimously takes the following resolutions:

<i>First resolution

The Meeting resolves to waive the convening notices, the shareholders of the Company having been duly convened

and having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an amount of seven hundred and twenty-six

thousand four hundred euro (EUR 726,400) and to issue seven thousand two hundred and sixty-four (7,264) new ordinary
shares of the Company with a par value of one hundred euro (EUR 100) each, having the same rights and obligations as
the already existing ordinary shares of the Company.

<i>Declaration - Subscription - Payment

Thereupon, Katcon Global, S.A. de C.V., a Mexican corporation with registered address at Manuel Ordoñez 601

Centro, Santa Catarina, NL Mexico 66350, here represented by Mr Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given
under private seal,

the said proxy, signed ne varietur by the persons appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities,

declares to subscribe to seven thousand two hundred and sixty-four (7,264) new shares of EUR 100.- each and to have

them fully paid up by the conversion of seven hundred and twenty-six thousand four hundred euro (EUR 726,400) from
a special premium account of the Company (“non-share capital contribution”) to the share capital account of the Com-
pany.

The valuation of the Contribution is evidenced inter alia, by a balance sheet dated October 31 

st

 , 2013, which will

remain annexed to the present deed.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to amend the article 5.1 of the articles of association of the Company to read as follows:

50027

L

U X E M B O U R G

“The subscribed share capital is set at seven hundred and fifty seven thousand four hundred euro (EUR 757,400.-)

represented by seven thousand five hundred and seventy-four (7,574) shares with a par value of one hundred euro (EUR
100.-) each, fully paid up.”

<i>Fourth resolution

The Meeting further resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above share capital

increase and empowers and authorizes any employee of the company, acting individually, with full power of substitution,
to proceed to the registration of the newly issued ordinary shares of the Company in the share register of the Company.

<i>Declaration - Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed are estimated to be approximately two thousand one

hundred Euros (2,100.- EUR).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, said proxyholder signed together with

us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de Katcon Global S.A., une société anonyme de

droit Luxembourgeois, avec siège social à 5, rue Bommel, L-4940 Hautcharage, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.038. La Société a été constituée suivant un acte de Maître Gérard
Lecuit, notaire de résidence à Luxembourg, le 14 novembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations (le Mémorial C) le 3 décembre 2008 sous le numéro 2887. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois suivant un acte notarié du 1 

er

 juillet 2013, publié au Mémorial C sous le numéro 2116 en date du 30 août

2013.

L’Assemblée est ouverte par le Président, Régis Galiotto, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Lu-

xembourg,

qui désigne comme Secrétaire et l’Assemblée nomme comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, ayant son

adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau de l’Assemblée ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter que:
I. L’agenda de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux convocations préalables;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de sept cent vingt-six mille quatre cent euro (EUR 726.400)

et émission de sept mille deux cent soixante-quatre (7.264) nouvelles actions ordinaires de la Société avec une valeur
nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions ordinaires existantes
de la Société;

3. Modification du second paragraphe de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation du capital

social de la Société;

4. Modification du registre des actionnaires de la Société.
II.- Les actionnaires représentés à l’Assemblée ainsi que le nombre d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une

liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signée
ne varietur par le mandataire des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera
annexée au présent acte.

III. A la vue de la liste de présence sus mentionnée, l’entièreté du capital social émis de la Société est représentée à

l’Assemblée de sorte que l’Assemblée peut valablement délibérer sur les points portés à l’ordre du jour.

IV. L’Assemblée prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide de renoncer aux convocations préalables, les actionnaires de la Société ayant été régulièrement

convoqués et ayant une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

50028

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de sept cent vingt-six mille quatre cent

euro (EUR 726.400) et d’émettre sept mille deux cent soixante-quatre (7.264) nouvelles actions ordinaires de la Société
avec une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune, ayant les même droits et obligations que les actions ordinaires
existantes de la Société.

<i>Déclaration - Souscription - Payment

Ces faits exposés, Katcon Global, S.A. de C.V., une société de droit mexicain ayant son siège social à Manuel Ordoñez

601 Centro, Santa Catarina, NL Mexico 66350, ici représentée par Monsieur Régis Galiotto, prenommé, en vertu d’une
procuration sous seing privée,

laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par les comparants et le notaire instrumentant, annexée

aux présentes pour être formalisée avec elles,

laquelle société déclare souscrire les sept mille deux cent soixante-quatre (7.264) nouvelles actions ordinaires de la

Société avec une valeur nominale de cent euro (EUR 100,-) chacune et de les libérer entièrement par un apport en
consistant en la conversion de sept cent vingt-six mille quatre cent euro (EUR 726.400) du compte «apport en capitaux
propres non rémunéré par des titres» vers le compte capital de la Société.

La valeur de la contribution est évaluée par un bilan en date du 31 décembre 2013 qui restera annexé au présent acte.

<i>Troisième résolution

L’Assemblée décide de modifier le second paragraphe de l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l’aug-

mentation du capital social de la Société, qui aura la teneur suivante:

«Le capital social souscrit de la Société est fixé à sept-cent cinquante-sept mille quatre cent euros (EUR 757.400,-)

représenté par sept mille cinq cent soixante quatorze (7.574) actions ayant une valeur nominale de cent euros (EUR
100,-) chacune, entièrement libérées.»

<i>Quatrième résolution

L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société pour refléter l’augmentation de capital sus-

mentionnée, et mandate et autorise, avec pouvoir de substitution, tout employé de la Société agissant individuellement,
de procéder à l’enregistrement des nouvelles actions ordinaires de la Société dans le registre des actionnaires de la Société.

<i>Estimation des frais et dépenses

Le montant des dépenses relatives au présent acte s’élèvent approximativement à deux mille cents Euros (2.100.-

EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date sus mentionnée.
Et après lecture faite aux membres du bureau, ils ont signé, avec le notaire instrumentant, le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64324. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 février 2015.

Référence de publication: 2015037969/147.
(150042300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Luxoutils Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8079 Bertrange, 115B, rue de Leudelange.

R.C.S. Luxembourg B 115.340.

Le bilan au 31/12/2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015038708/10.
(150043946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

50029

L

U X E M B O U R G

Akragas SIF-SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.091.

En date du 21 janvier 2015, le Conseil d'Administration de la Société décide:
- D'acter la démission de Monsieur Alessandro Rizzi, en tant que Membre du conseil d'administration, avec effet au 1

er

 mars 2015;

- De co-opter Monsieur Pascal Schiltz, né le 26 mars 1965, à Bayonne, France, et ayant son adresse professionnelle au

2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg Membre du conseil d'administration, avec effet au 1 

er

 mars 2015,

jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2015;

- De nommer Monsieur Gabriele Corte, né le 8 novembre 1970, à Turin, Italie, et ayant son adresse professionnelle

2, via Magatti, 6900 Lugano, Suisse, Président du conseil d'administration, avec effet au 1 

er

 mars 2015, jusqu'à l'Assemblée

Générale Annuelle qui se tiendra en 2015;

Référence de publication: 2015038968/16.
(150044452) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.

Mevengreen, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 195.090.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de février.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1. Madame Marion MARTIN, née le 28 janvier 1988 à Sallanches, demeurant à F-57390 Audun-le-tiche (France), 9 rue

Emile Mayrisch.

2. Monsieur Jean-Philippe BERNARD, né le 20 janvier 1987 à Provins, demeurant à F-57390 Audun-le-tiche (France),

9, rue Emile Mayrisch, ici représenté par Madame Marion MARTIN, précitée, en vertu d'une procuration donnée sous
seing privé le 25 février 2015.

Laquelle  procuration,  après  avoir  été  signée  «ne  varietur»  par  le  mandataire  et  le  notaire  instrumentant,  restera

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lesquels comparants, présents ou représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant de dresser

l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer et dont ils ont arrêté les statuts comme
suit:

«  Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes, par les personnes comparantes, présentes ou représentées, et toutes les

personnes qui pourraient devenir associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y
relatives, et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents
statuts (ci-après la "Société").

Art. 2. La société a pour objet le consulting dans le secteur de l'événementiel.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle

et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations,

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développe-
ment de ces participations.

Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-

trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «MEVENGREEN».

Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Pétange.

50030

L

U X E M B O U R G

Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.

La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-

bourg, ainsi qu'à l'étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une

valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.

Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de

l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.

Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en

proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune

d'elles.

Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même

personne.

Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions

énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la

Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.

Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique

de parts sociales.

Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 13. La Société sera engagée par la signature de son gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de deux membres du Conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société

par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.

Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne

peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.

En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement

passées  et  effectives  comme  si  passées  lors  d'une  réunion  dûment  convenue  et  tenue.  De  telles  signatures  peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.

De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de

communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.

Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

50031

L

U X E M B O U R G

Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins

qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de

parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,

les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité

des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)

associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois
de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.

Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour

ouvrable suivant.

Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil

de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de

l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).

Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amor-

tissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que

celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en

réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»

<i>Disposition transitoire:

Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération:

Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, les comparants, pré-qualifiés, présents ou représentés comme dit ci-

avant, déclarent souscrire cent (100) parts sociales comme suit:

- Madame Marion MARTIN, pré-qualifiée, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

- Monsieur Jean-Philippe BERNARD, pré-qualifié, cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

TOTAL: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR
1.100,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants, présents ou représentés, pré-qualifiés, représentant l'intégralité du capital social souscrit, se consi-

dérant comme dûment convoqués, se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, ils ont pris les résolutions suivantes:

50032

L

U X E M B O U R G

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérante unique de la Société pour une durée indéterminée:
- Madame Marion MARTIN, née le 28 janvier 1988 à Sallanches, demeurant à F-57390 Audun-le-tiche (France), 9, rue

Emile Mayrisch.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-4702 Pétange, 29, rue Robert Krieps.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant et comparante, connue du notaire ins-

trumentant par ses nom, prénom usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: M. MARTIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le03 mars 2015. Relation: DAC/2015/3565. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 05 mars 2015.

Référence de publication: 2015038055/160.
(150042447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg, Groupement d'Intérêt Economique.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 19-21, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg C 115.

STATUTS

1. Dénomination. Le groupement a été constitué sous la dénomination “Institut de la Propriété Intellectuelle Luxem-

bourg”.

2. Objet du groupement. Le groupement a pour objet la création, le financement, l'administration et la gestion d'un

organisme dans le domaine de la propriété intellectuelle dont l'objectif est:

- coordonner la mise en oeuvre de la politique publique et fédérer les acteurs impliqués;
- développer et offrir des services de support et d'accompagnement pour les entreprises, les acteurs de la recherche,

institutions publiques et tout autre public intéressé;

- développer et assurer des formations ainsi que des activités de promotion et de sensibilisation;
- conduire des projets et études afin de conseiller le Gouvernement.
Le groupement peut réaliser, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, toutes opérations générale-

ment quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, qui seraient utiles ou nécessaires
à la réalisation de son objet social ou qui se rapportent directement ou indirectement en tout ou en partie à cet objet.

3. Membres du groupement. Les membres du groupement sont:
1. L'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par:
a. Monsieur Etienne Schneider, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie, ayant ses bureaux à L-2449 Luxembourg,

19-21, boulevard Royal;

b. Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ayant ses bureaux à L-2327

Luxembourg, 18-20, montée de la Pétrusse;

c. Monsieur Pierre Gramegna, Ministre des Finances, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 3, rue de la Congré-

gation;

ayant pour objet la création, le financement, l'administration et la gestion d'un organisme dans le domaine de la pro-

priété intellectuelle dont l'objectif est:

- coordonner la mise en oeuvre de la politique publique et fédérer les acteurs impliqués;
- développer et offrir des services de support et d'accompagnement pour les entreprises, les acteurs de la recherche,

institutions publiques et tout autre public intéressé;

- développer et assurer des formations ainsi que des activités de promotion et de sensibilisation;
- conduire des projets et études afin de conseiller le Gouvernement.
ci-après dénommés collectivement “l'Etat”;
2. La Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, sise à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi,

représentée par Monsieur Michel Wurth, Président;

établissement de droit public institué par la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

élective, avec siège à Luxembourg, ayant comme objet social de créer et de subventionner, le cas échéant, tous établis-

50033

L

U X E M B O U R G

sements, institutions, oeuvres ou services voués essentiellement au développement de l'entreprise industrielle, financière
et commerciale, d'en féconder l'activité, de fournir des avis, de formuler des réclamations, de solliciter des informations
et la production de données statistiques

3. La Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg, sise à L-1347 Luxembourg, 2, Circuit de la Foire Inter-

nationale, représentée par Monsieur Roland Kuhn, Président;

ayant pour objet:
-  d'améliorer  la  situation  professionnelle  et  sociale  des  artisans,  de  défendre  leurs  intérêts  et  d'encourager  leurs

activités,

- de garantir le développement et l'application de la législation artisanale,
- de perfectionner l'instruction des chefs d'entreprises et du personnel,
- de fournir des avis dans les matières intéressant principalement l'artisanat,
- de solliciter des enquêtes et l'établissement de statistiques, et d'y procéder elle-même.

4. Siège du groupement. Le siège du groupement est à Luxembourg.

5. Condition de nomination et de révocation du ou des gérants. Le groupement est géré par un conseil de gérance,

composé de quatre gérants parmi les personnes physiques que les membres de l'assemblée générale auront désignées en
tant que leurs représentants respectifs. Le mandat du président a une durée de 6 ans. Le mandat des trois autres gérants
a une durée de 2 ans renouvelable une fois. Les mandats sont révocables ad nutum par l'assemblée générale. Les premiers
gérants sont désignés par l'assemblée générale extraordinaire qui suivra immédiatement la conclusion du contrat consti-
tutif du groupement. Les membres du conseil de gérance, personnes physiques, portent le titre de gérant. Le directeur
général, à être nommé par le conseil de gérance, assiste celui-ci en qualité de secrétaire.

6. Représentation du groupement. Sont nommés membres du conseil de gérance pour une période prenant fin à l'issue

de l'assemblée annuelle à tenir en 2016:

- M. Lex. KAUFHOLD, conseiller de direction 1ère classe, avec adresse professionnelle à L-2449 Luxembourg, 19-21,

boulevard Royal;

- M. Gaston SCHMIT, Premier Conseiller de Gouvernement, avec adresse professionnelle à L-2327 Luxembourg,

18-20, Montée de la Pétrusse;

- M. Jean-Marie HAENSEL, Premier inspecteur des Finances, avec adresse professionnelle à L-1352 Luxembourg, 2,

rue de la Congrégation;

- M. Gérard EISCHEN, Membre du Comité de direction de la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxem-

bourg, avec adresse professionnelle à L-2981 Luxembourg, 7, rue Alcide de Gasperi.

- M. Lex KAUFHOLD, pré qualifié, est nommé Président du conseil de gérance, pour une durée de 6 ans.

7. Pouvoir de signature. Le groupement est valablement représenté à l'égard des tiers et en justice par deux gérants

agissant conjointement. Le conseil de gérance peut déléguer, à l'unanimité de ses membres, certains des pouvoirs et
missions qui lui incombent, notamment la gestion journalière, à un ou plusieurs gérants délégués, directeurs, fondés de
pouvoir ou fondés de pouvoir spéciaux, dont il détermine les fonctions, attributions et rémunérations.

Pour l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg: Etienne Schneider, Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Economie; Pierre

Gramegna, Ministre des Finances; Claude Meisch, Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,

Pour la Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg: Michel Wurth, Président.
Pour la Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg: Roland Kuhn, Président.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015038643/80.
(150044125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Global Investor Solutions I SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 149.163.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 mars 2015.

TMF Luxembourg S.A.
Signature
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015037884/13.
(150043259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

50034

L

U X E M B O U R G

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue JF Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 194.382.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of February.
Before Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L., a private limited liability company (société

à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51
Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 93646, duly represented by Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, with profes-
sional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, given under private seal in Luxembourg, on
February 19, 2015; and

PFIZER HEALTH AB, a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at 191 90 Sol-

lentuna, Sweden, registered with the Swedish Companies Registration Office under number: 556131-9608, duly repre-
sented by Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, with professional address at 2 rue Peternelchen, Howald, Grand-
Duchy of Luxembourg, given under private seal in Luxembourg, on February 19, 2015.

Which proxies shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named parties and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entities PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L. and PFIZER HEALTH

AB are the partners in PFIZER PFE SWEDEN HOLDING S.À R.L., a private limited liability company (société à respon-
sabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51 Avenue JF
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 194382 (the “Company”) incorporated by deed of the aforementioned notary on February 3,
2015 not yet published in the Memorial C.

The appearing parties, represented as stated hereabove and representing the whole corporate capital require the

notary to enact the following resolutions taken unanimously:

<i>First resolution

The partners resolve to increase the share capital of the Company by an amount of FIVE HUNDRED FIFTEEN MIL-

LION  EIGHT  HUNDRED  FIFTY-THREE  THOUSAND  SEVEN  HUNDRED  THIRTY-  TWO  U.S.  DOLLARS  (USD
515,853,732.-) to bring it from its present amount of TWENTY THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 20,000.-) to the
amount of FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED
THIRTY-TWO U.S. DOLLARS (USD 515,873,732.-) by the creation and the issue of FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION
EIGHT HUNDRED FIFTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO (515,853,732) new shares having a
par value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each (the “New Shares”), having the same rights and obligations as the existing
shares, together with total issue premium of FOUR BILLION SIX HUNDRED FORTY-TWO MILLION SIX HUNDRED
EIGHTY-THREE THOUSAND FIVE HUNDRED EIGHTY-NINE U.S. DOLLARS (USD 4,642,683,589.-).

The aggregate contribution of FIVE BILLION ONE HUNDRED FIFTY- EIGHT MILLION FIVE HUNDRED THIRTY-

SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY- ONE U.S. DOLLARS (USD 5,158,537,321.-) in relation to the New
Shares is allocated as follows:

(i) FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED FIFTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-

TWO U.S. DOLLARS (USD 515,853,732.-) to the share capital of the Company, and

(ii) FOUR BILLION SIX HUNDRED FORTY-TWO MILLION SIX HUNDRED EIGHTY-THREE THOUSAND FIVE

HUNDRED EIGHTY-NINE U.S. DOLLARS (USD 4,642,683,589.-) to the share premium account of the Company.

<i>Second resolution

The partners resolve to accept that all the FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED FIFTY-THREE

THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO (515,853,732) New Shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS
(USD 1.-) each, be subscribed by PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L. and PFIZER
HEALTH AB, by a contribution in kind consisting of 100% of the shares, in the share capital of Pfizer Sweden Holding
B.V., a private limited liability company (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under Dutch law, having
its corporate seat at Rotterdam (address: 2909 LD Capelle aan den IJssel, Rivium Westlaan 142, trade register number:
61929085) consisting of 1,000 shares with a nominal value of USD 1 per share, numbered 1 through 1,000 (the “Pfizer
Sweden Holding B.V.” or the “Shares”).

<i>Subscription - Payment

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L. through its proxy holder declared to sub-

scribe to the above mentioned increase of capital for FIVE HUNDRED TEN MILLION SIX HUNDRED NINETY-FIVE

50035

L

U X E M B O U R G

THOUSAND ONE HUNDRED NINETY-FIVE (510,695,195) New Shares of the Company having a par value of ONE
U.S. DOLLARS (USD 1-) each and allocate to the share premium account of the Company an amount of FOUR BILLION
FIVE HUNDRED NINETY-SIX MILLION TWO HUNDRED FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED FIFTY-THREE
U.S. DOLLARS (USD 4,596,256,753.-) the whole being fully paid up by contributing 99% of Pfizer Sweden Holding B.V.

PFIZER HEALTH AB through its proxy holder declared to subscribe to the above mentioned increase of capital for

FIVE MILLION ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT THOUSAND FIVE HUNDRED THIRTY-SEVEN (5,158,537) New Shares
of the Company having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1-) each and allocate to the share premium account of
the Company an amount of FORTY-SIX MILLION FOUR HUNDRED TWENTY-SIX THOUSAND EIGHTY HUNDRED
THIRTY-SIX U.S. DOLLARS (USD 46,426,836.-) the whole being fully paid up by contributing 1% of Pfizer Sweden Holding
B.V.

<i>Evaluation

The value of the Shares is set at a total amount of FIVE BILLION ONE HUNDRED FIFTY-EIGHT MILLION FIVE

HUNDRED THIRTY-SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED TWENTY-ONE U.S. DOLLARS (USD 5,158,537,321.-).

Such contribution has been valued by all the managers of the Company, pursuant to a valuation statement which has

been produced to the notary.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 7 of the by-laws of the Company in order to

reflect such increase of capital, which shall be now read as follows:

Art. 7. First paragraph. “The corporate capital of the company is set at FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION EIGHT

HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND SEVEN HUNDRED THIRTY-TWO U.S. DOLLARS (USD 515,873,732.-)
divided into FIVE HUNDRED FIFTEEN MILLION EIGHT HUNDRED SEVENTY-THREE THOUSAND SEVEN HUN-
DRED THIRTY-TWO (515,873,732) parts having a par value of ONE U.S. DOLLAR (USD 1.-) each.

<i>Valuation - Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at EUR 6,700.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby

grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Senningerberg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné;

A COMPARU

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.À R.L., une société à responsabilité limitée régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 51 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 93
646, représentée par Me Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen,
L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 19 février 2015;

PFIZER HEALTH AB, une société régie par les lois de la Suède, ayant son siège social au 191 90 Sollentuna, Suède

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Suède sous le numéro 556131-9608, représentée par Me
Sonia BELLAMINE, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen, L-2370 Howald, Grand-
Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 19 février 2015.

Lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par la personne représentant les parties comparantes

susnommées et le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les  sociétés  prénommées,  PFIZER  HOLDINGS  INTERNATIONAL  LUXEMBOURG  (PHIL)  S.À  R.L.  et  PFIZER

HEALTH AB, sont les associés de PFIZER PFE SWEDEN HOLDING S.A R.L, Société à responsabilité limitée régie par
les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège au 51 Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B

50036

L

U X E M B O U R G

194382, constituée par acte devant le notaire susmentionné, en date du 3 février 2015, non encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la «Société»).

Lesquelles parties comparantes, représentées comme dit ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, ont

requis le notaire instrumentaire de documenter les résolutions suivantes prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Les associés décident d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant de CINQ CENT QUINZE MILLIONS

HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX U.S. DOLLARS (USD 515.853.732,-) pour le
porter de son montant actuel de VINGT MILLE U.S. DOLLARS (USD 20.000,-) à un montant de CINQ CENT QUINZE
MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX U.S. DOLLARS (USD 515.873.732,-)
par l’émission de CINQ CENT QUINZE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-
DEUX (515.853.732) de nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d’UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) chacune (les
«Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec une
prime d’émission de QUATRE MILLIARDS SIX CENT QUARANTE-DEUX MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-
TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF U.S. DOLLARS (USD 4.642.683.589,-).

L’apport  total  de  CINQ  MILLIARDS  CENT  CINQUANTE-HUIT  MILLIONS  CINQ  CENT  TRENTE-SEPT  MILLE

TROIS CENT VINGT ET UN U.S. DOLLARS (USD 5.158.537.321,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué
comme suit:

(i) CINQ CENT QUINZE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX U.S.

DOLLARS (USD 515.853.732,-) au capital social de la Société, et

(ii)  QUATRE  MILLIARDS  SIX  CENT  QUARANTE-DEUX  MILLIONS  SIX  CENT  QUATRE-VINGT-TROIS  MILLE

CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF U.S. DOLLARS (USD 4.642.683.589,-) au compte de prime d’émission de la So-
ciété.

<i>Deuxième résolution

Les associés décident d’accepter que les CINQ CENT QUINZE MILLIONS HUIT CENT CINQUANTE-TROIS MILLE

SEPT CENT TRENTE-DEUX (515.853.732) Nouvelles Parts Sociales de la Société ayant une valeur nominale d’UN U.S.
DOLLAR (USD 1,-) chacune, soient souscrites par PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL Luxembourg (PHIL) S.A R.L
et PFIZER HEALTH AB au moyen d’un apport en nature consistant en l’intégralité des actions émises et existantes dans
la société Pfizer PFE Sweden Holding B.V., une société à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid) régie par les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Rotterdam (adresse: 2909 LD Capelle aan den
Ijssel, Rivium Westlaan 142, register du commerce numéro 61929085), et consistant en 1.000 actions ayant une valeur
nominale de USD 1.- chacune et numérotées de 1 à 1.000 (la “Pfizer PFE Sweden Holding BV” ou les “Actions Apportées”).

<i>Souscription - Paiement

PFIZER HOLDINGS INTERNATIONAL LUXEMBOURG (PHIL) S.A R.L, représentée par son mandataire, a déclaré

souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée en souscrivant à CINQ CENT DIX MILLIONS SIX CENT QUATRE-
VINGT-QUINZE MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUINZE (510.695.195) Nouvelles Parts Sociales de la Société d’une
valeur nominale d’UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) chacune et alloué au compte de prime d’émission de la Société pour un
montant de QUATRE MILLIARDS CINQ CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE-SIX
MILLE SEPT CENT CINQUANTRE-TROIS U.S. DOLLARS (USD 4.596.256.753,-) le tout étant entièrement libéré par
la contribution de 99% des actions de Pfizer PFE Sweden Holding B.V.

PFIZER HEALTH AB, représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée

en souscrivant à CINQ MILLIONS CENT CINQUANTE-HUIT MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT (5.158.537) Nouvelles
Parts Sociales de la Société d’une valeur nominale d’UN U.S. DOLLAR (USD 1,-) chacune et alloué au compte de prime
d’émission de la Société pour un montant de QUARANTE-SIX MILLIONS QUATRE CENT VINGT-SIX MILLE HUIT
CENT TRENTE-SIX U.S. DOLLARS (USD 46.426.836,-) le tout étant entièrement libéré par la contribution de 1% des
actions de Pfizer PFE Sweden Holding B.V..

<i>Evaluation

La valeur des Actions Apportées a été fixée à CINQ MILLIARDS CENT CINQUANTE-HUIT MILLIONS CINQ CENT

TRENTE-SEPT MILLE TROIS CENT VINGT ET UN U.S. DOLLARS (USD 5.158.537.321,-).

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

et de l’évaluation présentée au notaire soussigné.

Cet apport a été évalué par tous les gérants de la Société, conformément à une déclaration sur la valeur de l’apport

et de l’évaluation présentée au notaire soussigné.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société pour refléter

l’augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

50037

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à CINQ CENT QUINZE MILLIONS HUIT CENT

SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX U.S. DOLLARS (USD 515.873.732,-) divisé par CINQ CENT
QUINZE MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE-DEUX (515.873.732) parts sociales
ayant une valeur nominale d’UN US DOLLAR (USD 1,-) chacune.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à EUR 6.700.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu’elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l'Étude du notaire soussigné, à l'effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Senningerberg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Sonia Bellamine, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 25 février 2015. 1LAC / 2015 / 5878. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 mars 2015.

Référence de publication: 2015038115/189.
(150043346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Parker Hannifin Global Capital Management, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 113.372.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of January.
Before Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur- Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

PARKER HANNIFIN BERMUDA LUXEMBOURG S.C.S., a "société en commandite simple", incorporated under the

laws of Luxembourg, having its registered office at 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 113.245, here represented by, represented by Maître Claire
Puel, attorney-at-law, residing in Howald, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy after having been signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary shall remain attached

to the present deed for the purpose of registration.

The pre-named is the sole shareholder of “Parker Hannifin Global Capital Management”, having its registered office

at L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, registered with the Luxembourg Register of Commerce under the number B
113 372, incorporated on November 21, 2005 by deed of Maître Paul Frieders, published in the Mémorial C on April 6,
2006 and the articles of association of which have been amended for the last time by deed of Maître Carlo Wersandt
dated June 1 

st

 , 2011, published in the Mémorial C number 2061 of September 6, 2011 (the “Company”).

Which appearing person, acting in its above-mentioned capacity, requested the undersigned notary to draw up as

follows:

I) That the agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Amendment of Article 4 of the articles of association of the Company;
2. Amendment of Article 9 of the articles of association of the Company;
3. Amendment of Article 10 of the articles of association of the Company;
II) That the sole shareholder of the Company has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder of the Company has resolved to amend Article 4 of the articles of association of the Company

which shall be read as follows:

“ Art. 4. The company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the

50038

L

U X E M B O U R G

transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, the possession,
the administration and the development of its portfolio.

The company may participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enter-

prises; it may raise funds and lend them to directly or indirectly owned subsidiaries or other affiliated companies in any
manner, including by granting loans to, or by acquiring, purchasing, subscribing for or otherwise receiving rights to debt
instruments of any kind issued by such affiliated companies; more generally, it may render any assistance, including by way
of guarantees, to its subsidiaries or affiliated companies. The company may borrow in any form, save that it may not raise
funds from the public.

The company (i) may employ any technique and instrument relating to its assets or investments for the purpose of

their efficient management, including techniques and instruments to protect against exchange risks and interest rate risks
and (ii) may provide any administrative services, investment services, advisory and risk management services to its affiliates.

In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any financial, movable or immovable,

commercial and industrial operation that it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.”

<i>Second resolution

The sole shareholder of the Company has resolved to amend Article 9 of the articles of association of the Company

which shall be read as follows:

“ Art. 9. The company is managed by one (1) or more managers, whether participant(s) or not, who is/are appointed

by the sole participant or by the general meeting of participants for an indeterminate period.

The general meeting of participants has the power to remove any manager at any time without giving reasons.
The powers and remunerations of any manager possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

The office of a manager shall be vacated if:
1. he resigns his office by notice to the company, or
2. he ceases by virtue of any provision of the law or he becomes prohibited or disqualified by law from being a manager,
3. he becomes bankrupt or makes any arrangement or composition with his creditors generally, or
4. he is removed from office by resolution of the sole participant or, as the case may be, by the general meeting of the

participants.

Insofar as the law allows, every present or former manager of the company shall be indemnified out of the assets of

the company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a manager.”

<i>Third resolution

The sole shareholder of the Company has resolved to amend Article 10 of the articles of association of the Company

which shall be read as follows:

“ Art. 10.
1. As long as there is a sole manager, all resolutions taken by the sole manager are validly adopted if they are in writing.
2. If there is more than one (1) manager appointed, all resolutions are valid if adopted in writing by any two (2) managers

acting jointly.

3. All managers shall be convened to physical meetings which shall be held as often as required by the interest of the

company, and twice a year at least, at any time convenient. At any such meetings of the board of managers, the managers
shall determine the business strategy, the objectives and authorise within the limits set forth by the board, transactions
and dealings by the company. In addition, at any such meetings, the managers shall be entitled to review any and all actions
undertaken by any two (2) managers having acted jointly in compliance with paragraph 2. above.

The board of managers elects among its members a chairman; in the absence of the chairman, another manager may

preside over the meeting.

A manager unable to take part in a meeting may delegate by letter, telex, telefax or telegram another member of the

board of managers to represent him at the meeting and to vote in his name.

Any member of the board of managers, who participates in the proceedings of a meeting of the board of managers by

means of a communications device (including a telephone or a video conference) which allows all the other members of
the board of managers present at such meeting (whether in person, or by proxy, or by means of such communications
device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present in person at such
meeting, shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
Members of the board of managers, who participate in the proceedings of a meeting of the board of managers by means
of such a communications device, shall ratify their votes so cast by signing a copy of the minutes of the meeting.

The board of managers convenes upon call by the chairman, or any third party delegated by him, or in the absence of

the chairman, by any manager. Separate convening notices shall not be required in respect of meetings contained in on
advance schedule previously adopted by a meeting of the board of managers.

The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of managers is present or represented.

50039

L

U X E M B O U R G

Resolutions shall be passed with the favourable vote of the majority of managers present or represented.
The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or any

two (2) managers who took part at the deliberation. Copies or extracts of such minutes to be produced in judicial
proceeding or elsewhere, will be validly signed by the chairman of the meeting or any two (2) managers.

4. Circular resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effective as if passed at a

meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical
resolution.

5. Any two (2) managers, or as the case may be, the board of managers may delegate their powers to conduct the

daily management of the company to one (1) or more managers, who will be called «managing director(s).

Any two (2) managers, or as the case may be, the board of managers may also appoint attorneys of the company, who

are entitled to bind the company by their sole signature, but only within the limits to be determined by the power of
attorney.

6. Unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation of powers or

proxies given by any two (2) managers under paragraph 2. or, as the case may be, the board of managers pursuant to the
previous paragraph, the company is validly bound in any circumstances by the sole signature of the sole manager and in
case of a board of managers, by the joint signature of any two (2) members thereof.»

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

party the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party, in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Howald (Grand-Duchy of Luxembourg), on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the person representing the appearing party, who is known to the notary, by first

name, last name, civil status and residence, the said person signed together with the notary, the present original deed.

Follows the french version

L’an deux mille quinze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu

PARKER HANNIFIN BERMUDA LUXEMBOURG S.C.S., une société en commandite simple, constituée et existant

selon le droit luxembourgeois, avec siège social à 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, immatriculée au Registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.245, représentée par Maître Claire Puel avocat à la
Cour, demeurant à Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

Le comparant prénommé est l’associé unique de «Parker Hannifin Global Capital Management», ayant son siège social

au L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 113 372, constituée le 21 novembre 2005 suivant acte reçu par le notaire Maître Paul Frieders, publié
au Mémorial C le 6 avril 2006 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
Maître Carlo Wersandt le 1 

er

 juin 2011, publié au Mémorial C numéro 2061 le 6 septembre 2011 (la «Société»).

Lequel comparant, ès qualités qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I) Que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Modification de l’article 4 des statuts de la Société;
2. Modification de l’article 9 des statuts de la Société;
3. Modification de l’article 10 des statuts de la Société;
II. Que l’associé unique de la Société a pris les décisions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique de la Société a décidé de modifier l’article 4 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 4. La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration et le développement de son portefeuille.

La société peut participer à la création et au développement de n’importe quelle entreprise financière, industrielle ou

commerciale; elle peut lever des fonds et les prêter à des filiales directes ou indirectes ou d’autres sociétés affiliées par
tous moyens y compris en accordant des prêts ou en acquérant, achetant, souscrivant ou en recevant des droits relatifs
à des instruments de dette de toutes sortes émis par ces sociétés affiliées; plus généralement, elle peut prêter tous

50040

L

U X E M B O U R G

concours, y compris accorder des garanties, à ses filiales ou sociétés affiliées. La société peut emprunter sous toutes les
formes à l’exception des levés de fonds auprès du public.

La société (i) pourra utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs à ses biens et/ou ses investissements per-

mettant une gestion efficace de ceux-ci, y compris toutes techniques et tous instruments pour la protéger contre des
risques de change et des risques de taux d’intérêts et (ii) pourra fournir tous services administratifs, services d’investis-
sement et services de conseils et de contrôle des risques à ses sociétés affiliées.

D’une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations

financières, commerciales et industrielles qu'elle jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique de la Société a décidé de modifier l’article 9 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 9. La société est administrée par un (1) ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, qui est/sont nommé(s) par

l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, pour une période indéterminée.

L’assemblée générale des associés a le pouvoir de révoquer un gérant à tout moment et sans justification.
Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l’acte de nomination.

Le poste d’un gérant sera vacant si:
1. il démissionne de son poste avec préavis à la société, ou
2. il cesse d’être gérant par application d’une disposition légale ou il se voit interdit par la loi d’occuper le poste de

gérant, ou

3. il tombe en faillite ou conclut un arrangement avec ses créanciers, ou
4. il est révoqué par une résolution du/des associé(s).
Dans les limites de la loi, chaque gérant, présent ou passé, sera indemnisé sur les biens de la société en cas de perte

ou de responsabilité l’affectant du fait de l’exercice, présent ou passé, de la fonction de gérant.».

<i>Troisième résolution

L’associé unique de la Société a décidé de modifier l’article 10 des statuts de la Société comme suit:

« Art. 10.
1. Tant que la société aura un gérant unique, toutes les décisions prises par le gérant unique sont valablement adoptées

si elles le sont par écrit.

2. S'il y a plus d'un (1) gérant, toutes les décisions prises par deux gérants (2) agissant conjointement, sont valablement

adoptées si elles le sont par écrit.

3. Tous les gérants doivent être convoqués aux réunions qui seront tenues physiquement aussi souvent que l'intérêt

de la société l'exige, deux fois par an, à une heure convenue. A chaque réunion du conseil de gérance, les gérants devront
déterminer la stratégie commerciale et les objectifs de la société, et devront autoriser, selon les limites fixées par le
conseil de gérance, les transactions et autres arrangements effectués par la société.

De plus, à chaque réunion, les gérants auront le droit de revoir tous les actes pris par deux (2) gérants ayant agi

conjointement en application du paragraphe 2 mentionné ci-dessus.

Le conseil de gérance choisit un président parmi ses membres; en cas d'absence du président, la présidence de la

réunion peut être conférée à un autre gérant présent.

Un gérant empêché de participer à une réunion du conseil de gérance peut désigner par écrit, télex, téléfax ou télé-

gramme, un autre membre du conseil de gérance comme son mandataire, aux fins de le représenter à cette réunion et
de voter en son nom.

Tout membre du conseil de gérance qui participe à une réunion du conseil de gérance via un moyen de communication

(incluant le téléphone ou une vidéo conférence) qui permet aux autres membres du conseil de gérance présents à cette
réunion (soit en personne, soit par mandataire, soit au moyen de ce type de communication) d'entendre et d'être entendu
par les autres membres à tout moment, sera considéré comme étant présent en personne à cette réunion, sera pris en
compte pour le calcul du quorum et sera autorisé à voter sur les matières traitées à cette réunion.

Les membres du conseil de gérance qui participent à une réunion du conseil de gérance via un tel moyen de commu-

nication, doivent ratifier leurs votes exprimés de cette façon en signant une copie du procès-verbal de cette réunion.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation du président, ou tout tiers délégué par lui, ou en l'absence du

président, sur convocation de tout autre gérant de la société.

Des convocations séparées ne sont pas requises dans le cadre de réunions comprises par avance dans le programme

adopté précédemment par une réunion du conseil de gérance.

Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir que si une majorité des gérants est présente ou représentée.
Les résolutions doivent être adoptées à la majorité des votes favorables des membres présents soit en personne soit

par mandataire à telle réunion.

50041

L

U X E M B O U R G

Les résolutions du conseil de gérance seront enregistrées sur un procès-verbal signé par le président de la réunion ou

deux (2) gérants qui ont participé à la réunion. Des copies ou extraits de ce procès-verbal à produire lors d'une procédure
judiciaire ou ailleurs seront valablement signés par le président de la réunion ou par deux (2) gérants.

4. Les résolutions circulaires signées par tous les membres du conseil de gérance seront considérées comme étant

valablement adoptées comme si une réunion valablement convoquée avait été tenue. Ces signatures pourront être ap-
posées sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique.

5. Deux (2) des gérants, ou selon le cas, le conseil de gérance pourront déléguer la gestion journalière de la société à

un (1) ou plusieurs gérants, qui prendront la dénomination de «gérant(s)-délégué(s)». Deux (2) des gérants, ou selon le
cas, le conseil de gérance, pourront également nommer des mandataires de la société, qui ont le pouvoir d'engager la
société sous leur seule signature, mais uniquement dans les limites déterminées pour leur mandat.

6. La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique, et en cas de conseil

de gérance, par la signature conjointe de deux (2) de ses membres, sauf si des décisions spéciales ont été prises concernant
la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par deux (2) des gérants conformément au
paragraphe 2. sus-mentionné, ou selon le cas, par le conseil de gérance conformément au paragraphe précédent.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, l’assemblée est ajournée.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare par la présente que sur demande des parties comparantes,

le présent document a été établi en langue anglaise suivi d’une version française. Sur demande des mêmes parties com-
parantes et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Howald (Grand-Duché du Luxembourg), date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentaire par nom, prénom, état

et demeure, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: Puel, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 22 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1765. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): M. Halsdorf

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015038129/225.
(150041448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Digital Services Holding XXI s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.836,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.604.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of January,
before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in

Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 16 January 2015;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its re-
gistered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Berlin, Germany, on 13 January 2015;

3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with

the commercial register of the Dutch Trade Register, under no. 60628022, having its business address at Schiphol Bou-
levard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),

being the holder of six hundred ninety-five (695) series A1 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Schiphol, the Netherlands, on 19 January 2015 and 16 January 2015;

50042

L

U X E M B O U R G

4. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda, having its

business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 (hereinafter “TJT”),

being the holder of three hundred forty-eight (348) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Bermuda, on 16 January 2015;

5. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

 Street -33 

rd

 Floor, New York, NY 10019,

United States of America (hereinafter “DZ”),

being the holder of three hundred forty-eight (348) series A2 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in New York, United States of America, on 13 January 2015; and

6. TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of

Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under no. HRB 23773, having its business address at Wissollstraße
5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany (hereinafter “TEC”),

becoming the holder of six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares,
here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given in Mülheim an der Ruhr, Germany, on 13 January 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing parties under 1., 2., 3., 4. and 5. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services

Holding XXI S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.604 and
incorporated pursuant to a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2447 dated 11 September 2014. The articles of association
have been amended pursuant to a deed of notary Henri Hellinckx dated 24 December 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby TEC parti-
cipates and votes for the purpose of agenda point 4 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have four (4) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), series
A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) and series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”; the Series A1 Shares,
the Series A2 Shares and the Series A3 Shares together the “Series A Shares”).

2. Acceptance of TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Han-
delsregister) at the local court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under no. HRB 23773, having its business
address at Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, as new shareholder of the Company.

3. Increase of the Company's share capital by an amount of six thousand nine hundred forty-five euros (EUR 6,945.00)

so as to raise it from its current amount of thirteen thousand eight hundred ninety-one euros (EUR 13,891.00) up to
twenty thousand eight hundred thirty-six euros (EUR 20,836.00) by issuing six thousand nine hundred forty-five (6,945)
Series A3 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

4. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand eight hundred thirty-six euros (EUR 20,836.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

50043

L

U X E M B O U R G

5. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name Digital

Services Holding XXI S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand eight hundred thirty-six euros (EUR 20,836.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

50044

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

("Rocket"), the shareholder Netris B.V. (“Eiffel”), the shareholder TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”),
the shareholder David W. Zalaznick (“DZ”) and the shareholder TEC Global Invest XI GmbH ("TEC", jointly with Rocket,
Eiffel, TJT and DZ the "Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the meaning
of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50 %) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company

50045

L

U X E M B O U R G

hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to be determined by

an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

50046

L

U X E M B O U R G

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

50047

L

U X E M B O U R G

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

50048

L

U X E M B O U R G

21.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board (as defined below) for the legal transactions and

measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and
have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 future transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board (“Advisory Board”). It shall consist of three (3) voting members. The

shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of
the Advisory Board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous

shareholders' consent.

24.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

50049

L

U X E M B O U R G

24.3.1 two (2) voting members of the Advisory Board, each having two (2) votes, shall be nominated by Rocket in its

sole discretion; and

24.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by TEC in its sole

discretion.

24.4 Each member of the Advisory Board may be represented by another member of the Advisory Board or any other

representative of the respective party. In this case a written proxy must be presented at the respective Advisory Board
meeting. For this purpose, Rocket and TEC are entitled to appoint one substitute member for each Advisory Board
member.

24.5 The Advisory Board may have non-voting members of the Advisory Board as observers.
24.6 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board, if any, may provide for further
provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with
the simple majority of votes cast. The Advisory Board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar
quarter.

24.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
24.8 In addition to any consents or approvals otherwise required under these articles of association and/or any sha-

reholders' agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not
interfere in the management of the Company.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

50050

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”;

6. Appointment of Mr Julien De Mayer as new class B manager of the Company for unlimited duration.
7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr Ruediger

Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have four (4) classes of shares, divided into Common Shares, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3
Shares. The Series A1 Shares, the Series A2 Shares and the Series A3 Shares are jointly referred to as the Series A Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts TEC Global Invest XI GmbH, a limited liability company (Gesellschaft

mit beschränkter Haftung) under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the
commercial register (Handelsregister) at the local court of Duisburg (Amtsgericht Duisburg), Germany, under no. HRB
23773, having its business address at Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, as new shareholder of
the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of six thousand

nine hundred forty-five euros (EUR 6,945.00) so as to raise it from its current amount of thirteen thousand eight hundred
ninety-one euros (EUR 13,891.00) up to twenty thousand eight hundred thirty-six euros (EUR 20,836.00) by issuing six
thousand nine hundred forty-five (6,945) Series A3 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

The six thousand nine hundred forty-five (6,945) Series A3 Shares have been duly subscribed by TEC, aforementioned,

for the price of six thousand nine hundred forty-five euros (EUR 6,945).

<i>Payment

The six thousand nine hundred forty-five (6,945) Series A3 Shares subscribed by TEC, aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of six thousand nine hundred forty-five euros (EUR 6,945.00).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of six thousand nine hundred forty-five euros (EUR 6,945.00) is entirely allocated to

the share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty thousand eight hundred thirty-six euros (EUR 20,836.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,

50051

L

U X E M B O U R G

5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
5.1.3 six hundred ninety-six (696) series A2 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.4 six thousand nine hundred forty-five (6,945) series A3 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Fifth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Sixth Resolution

The general meeting of shareholders appoints Mr Julien De Mayer, private employee, born on 9 April 1982, in Etterbeek,

Belgium, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, as new class B
manager for unlimited duration.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Mr Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders' register
of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 1,800.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Januar,
vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 16. Januar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-

stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 13. Januar 2015, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-

register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),

Inhaber von sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Herrn Julien de Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 19. Januar 2015 und 16. Januar 2015, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;

4. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft (limited liability company) nach dem Recht der

Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 („TJT“),

Inhaber von dreihundertachtundvierzig (348) Anteilen der Serie A2,

50052

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 16. Januar 2015, ausgestellt in Bermuda;

5. Herr David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, wohnhaft in 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York,

NY 10019, Vereinigte Staaten von Amerika („DZ“),

Inhaber von dreihundertachtundvierzig (348) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 13. Januar 2015, ausgestellt in New York, Vereinigte Staaten von Amerika; und

6. TEC Global Invest XI GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmä-

ßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der
Nummer HRB 23773, mit Geschäftssitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland („TEC“),

zukünftiger Inhaber von sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 13. Januar 2015, ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur pa-

raphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1., 2., 3., 4. und 5. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services

Holding XXI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senninger-
berg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.604, gegründet am 1.
Juli 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 11. September 2014
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2447, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft
wurde am 24. Dezember 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx geändert, welche noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, veröffentlicht wurde.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei TEC ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt
ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr vier (4) An-

teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile
der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) und Anteile der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“; die Anteile der Serie A1,
die Anteile der Serie A2 und die Anteile der Serie A3 gemeinsam die „Anteile der Serie A“).

2. Aufnahme von TEC Global Invest XI GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht

mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland,
unter der Nummer HRB 23773, mit Geschäftssitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, als
neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von dreizehntausendachthun-

derteinundneunzig  Euro  (EUR  13.891,00)  um  einen  Betrag  von  sechstausendneunhundertfünfundvierzig  Euro  (EUR
6.945,00) auf einen Betrag von zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig Euro (EUR 20.836,00) durch die Ausgabe von
sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00).

4. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig  Euro  (EUR

20.836,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00), und

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

5. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

50053

L

U X E M B O U R G

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services Holding XXI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig  Euro  (EUR

20.836,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00), und

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

50054

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten-oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“), den Gesellschafter Netris B.V. („Eiffel“), den Gesellschafter TJT (B) (Bermuda) Investment
Company Ltd. („TJT“), den Gesellschafter David W. Zalaznick („DZ“) und den Gesellschafter TEC Global Invest XI GmbH
(„TEC“, gemeinschaftlich mit Rocket, Eiffel, TJT und DZ die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit
einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikeln 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

50055

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen

50056

L

U X E M B O U R G

dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Ein-
klang mit Artikel 12.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei

50057

L

U X E M B O U R G

eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

50058

L

U X E M B O U R G

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (wie unten definiert) für die unten genannten Rechts-

geschäfte und Maßnahmen im Einklang mit Artikel 24.5. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsge-
schäfte und Maßnahmen präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des
Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils-oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

50059

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat („Beirat“). Dieser besteht aus drei (3) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-

sellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des
Beirats erhöhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats mit je zwei Stimmen werden von Rocket nach eigenem Er-

messen ernannt; und

24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer Stimme wird von TEC nach eigenem Ermessen ernannt.
24.4 Jedes Mitglied des Beirats kann von einem anderen Mitglied des Beirats oder einem anderen Vertreter der je-

weiligen Partei vertreten werden. In diesem Fall muss bei der jeweiligen Sitzung des Beirats eine schriftliche Vollmacht
vorgelegt werden. Zu diesem Zweck sind Rocket und TEC berechtigt, ein Ersatzmitglied für jedes Beiratsmitglied zu
ernennen.

24.5 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.6 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann gegebenenfalls weitere
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalen-
derquartal.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
24.8 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

50060

L

U X E M B O U R G

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“.

6. Ernennung von Herrn Julien De Mayer als neuer Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft für unbegrenzte

Dauer.

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie

Herrn Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit un-
eingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

8. Verschiedenes.

50061

L

U X E M B O U R G

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht die unterzeichnende Notarin, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr

vier (4) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie
A3. Die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2 und die Anteile der Serie A3 werden gemeinsam als Anteile der
Serie A bezeichnet.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert TEC Global Invest XI GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 23773, mit Geschäftssitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der
Ruhr, Deutschland, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

dreizehntausendachthunderteinundneunzig Euro (EUR 13.891,00) um einen Betrag von sechstausendneunhundertfün-
fundvierzig Euro (EUR 6.945,00) auf einen Betrag von zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig Euro (EUR 20.836,00)
durch die Ausgabe von sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteile der Serie A3 wurden ordnungsgemäß von TEC, vorbe-

nannt, zu einem Preis von sechstausendneunhundertfünfundvierzig Euro (EUR 6.945) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von TEC, vorbenannt, gezeichneten sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteile der Serie A3 wurden

vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von sechstausendneunhundertfünfundvierzig Euro (EUR 6.945,00).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die Einlage in Höhe von sechstausendneunhundertfünfundvierzig Euro (EUR 6.945,00) wird vollständig dem Gesell-

schaftskapital zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  zwanzigtausendachthundertsechsunddreißig  Euro  (EUR

20.836,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00),
5.1.3 sechshundertsechsundneunzig (696) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR

1,00), und

5.1.4 sechstausendneunhundertfünfundvierzig (6.945) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ernennt Herrn Julien De Mayer, private employee, geboren am 9. April 1982 in Et-

terbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, für
unbegrenzte Dauer als neuen Geschäftsführer der Kategorie B.

50062

L

U X E M B O U R G

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  sowie  Herrn  Rüdiger  Trox,  das  Anteilsinhaberregister  der  Gesellschaft  in  Einzelunterschrift  und  mit  uneinge-
schränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 1.800,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher der Notarin mit Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unter-
zeichnet worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 23 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2010. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 2. März 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015037756/1165.
(150041889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Atrium Dominikanska SCSp, Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 195.119.

EXTRAIT

I/ La Société, Atrium Dominikanska SCSp, une société en commandite spéciale, a été constituée par acte sous seing

privé signé en date du 4 mars 2015 pour une durée illimitée, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

II/ Il résulte du contrat social que l'objet social de la Société s'inscrit comme suit:
La Société est formée pour réaliser toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de par-

ticipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger. En particulier, la Société prendra
le contrôle stratégique et la gérance des participations (sous quelque forme que ce soit) dans le but de générer de la
valeur ajoutée au niveau des actifs/entreprises sous gestion, par le biais de leviers d'investissement, techniques et financiers.

La Société peut notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et droits de propriété intellectuelle de toute origine, et participer à la création,
au développement et au contrôle de toute entreprise. Elle peut également acquérir par voie d'apport, de souscription,
de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre manière, tous titres et droits de propriété intellectuelle, les faire
mettre en valeur et les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

La Société peut accorder tout concours (par voie de prêts, avances, garanties, sûretés ou autres) aux sociétés ou

entités dans lesquelles elle détient une participation ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société
(notamment par exemple, ses associés ou entités liées).

En général, la Société peut également réaliser toute opération financière, commerciale, industrielle, mobilière ou Im-

mobilière, prendre toutes mesures pour sauvegarder ses droits et réaliser toutes opérations, qui se rattachent directe-
ment ou indirectement à son objet ou qui favorisent son développement.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit notamment par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé ou public, à l'émission de parts sociales et obligations et d'autres titres repré-
sentatifs d'emprunts, convertibles ou non, et/ou de créances. Elle peut également consentir des garanties ou des sûretés
au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute
autre société. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges ou créer, de toute autre manière, des sûretés
portant sur tout ou partie de ses avoirs.

50063

L

U X E M B O U R G

III/ Il résulte du contrat social que la société suivante a été nommée en tant qu'associé commandité assurant les pouvoirs

de gérance de la Société pour une durée illimitée:

- Atrium Poland Holding GP S.à r.l. (anciennement Hedan S.A.), une société à responsabilité limitée de droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 156548.

Son pouvoir est inscrit comme suit:
Envers les tiers, la Société est valablement engagée par la signature de son associé commandité représenté par ses

signataires dûment autorisés.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 4 mars, 2015.

Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature

Référence de publication: 2015037571/50.
(150042828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.

Darla S.à.r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 181.884.

L'an deux mille quinze.
Le deux février.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.

A comparu:

La société COURTSIDE CORPORATION, dont le siège social est au Citco Building, Wickhams Cay, PO Box 662,

Road  Town,  Tortola, BVI,  ici représentée par  Madame  Sofia  AFONSO-DA CHAO  CONDE,  employée privée, avec
adresse professionnelle à Esch/Alzette, agissant en vertu d'une procuration lui donnée sous seing privée, ci-annexée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être la seule associée de la société à responsabilité

limitée DARLA S. à r.l., SPF, avec siège social à L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 181.884,
constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 31 octobre 2013, publié au Mémorial

C numéro 33 du 04janvier 2014,

dont le capital social est de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (€ 2.500.000,-), représenté par DEUX

MILLE CINQ CENTS (2.500) PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de MILLE EUROS (€ 1.000,-) chacune.

Laquelle comparant prie le notaire instrumentant de documenter ce qui suit:

Pour le futur l'exercice social débutera le 1 

er

 janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

Le premier exercice social ayant débuté le 31 octobre 2013 prend fin le 31 décembre 2014.
Suite à cette décision l'article seize (16) des statuts a désormais la teneur suivante:

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année."

DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l'étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donné aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 février 2015. Relation: EAC/2015/3365. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015038522/33.
(150043498) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

50064


Document Outline

Akragas SIF-SICAV

AM Fine Luxembourg S.à r.l.

Armat GGH S.A.

Atrium Dominikanska SCSp

Centrale Immobilière du Luxembourg SA, en abrégé C.I.L. SA.

Ceratungsten

CEREP III Eastern S.à r.l.

CEREP II Investment Ten S.à r.l.

CETP III Participations S.à r.l. SICAR

Charcot Fox Participations

Chemical Project Investments S.A.

Cled S.à r.l.

Cyriel Investissement S.A.

Darla S.à.r.l., SPF

Diffusion Benelux Parfumerie SA

Digital Services Holding XXI s.à r.l.

Dome 3 0909 S. à r.l.

Durimmo S.A.

ECM Credit Fund SICAV

Effetre Investment &amp; Trading Company S.A.

Eurofund Holdings Luxembourg S.à r.l.

Euro Invest S.à r.l.

Fairacre Properties (Lux) 3 S.à r.l.

Federal Express Luxembourg, Inc.

Fondation Peters

Global Bond Series IV, S.A.

Global Bond Series IX S.A.

Global Bond Series VI, S.A.

Global Investor Solutions I SA

Globalstone Lux S.à r.l.

Groove Corporate S.à r.l.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Immobilière Josy Welter S.à r.l.

Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg

Intralot Finance Luxembourg S.A.

Katcon Global S.A.

Les Laboratoires homéopathiques du Luxembourg

Luxoutils Sàrl

MCCI S.à r.l.

Mevengreen

Parker Hannifin Global Capital Management

Pfizer PFE Sweden Holding S.à r.l.

Retail Investment I

Simap Finance S.A.

STRAT &amp; Fi Lux

TRS Venture S.A.