This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 1036
20 avril 2015
SOMMAIRE
Aida Wedo 9 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49689
Angelo Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
49682
Ardent Oil (Denmark) S.A. . . . . . . . . . . . . .
49692
Compagnie Generale du Pacifique SARL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49682
Corelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49686
Corso Computer + Software GmbH . . . . .
49682
Coves S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49721
CPPL Lux 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49686
Créaforme S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49686
Createch S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49682
CR Realty S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49686
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49728
EPG Investment Partners . . . . . . . . . . . . . . .
49686
ETI Electronique Tôlerie Intégration S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49685
Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. . . . . . . . .
49703
Fondation Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49697
Harvester Cleanco S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49711
HGHQK 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49722
HGHQK 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49690
Institut de Formation Bancaire, Luxem-
bourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49692
International Trading and Engineering S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49685
LaVita Marketing BeNeLux S.à r.l. . . . . . . .
49683
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49685
Les Mots de Zaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49724
Les Mots de Zaza de l'Ecole Européenne
Luxembourg I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49724
Li Tung S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49685
Luphar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49684
Mango Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49727
Meluna Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49684
Meluna Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
49684
MWV Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
49718
Office Portfolio Minerva III Sàrl . . . . . . . . .
49682
Orthodontie Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49683
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l. . . . .
49683
Phytolux International Pharmaceutical
Company S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49683
Private Theory Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
49689
PROMIS@Service S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
49689
Rodina (Luxembourg) II S.à r.l. . . . . . . . . . .
49688
SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49687
SOUTHRAB INVESTMENTS . . . . . . . . . . .
49687
Sparinvest SICAV-SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49689
UKSA 60 CR S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49688
UKSA Isledon S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49688
Xella International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
49687
49681
L
U X E M B O U R G
Corso Computer + Software GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3441 Dudelange, 15, avenue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 54.355.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 06 mars 2015.
Référence de publication: 2015037742/10.
(150042964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
Createch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8833 Wolwelange, 44, rue de l'Ermitage.
R.C.S. Luxembourg B 169.643.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015037745/10.
(150042897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
Compagnie Generale du Pacifique SARL, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-2651 Luxembourg, 20, rue Saint Ulric.
R.C.S. Luxembourg B 63.015.
En date du 27 février 2015 le siège social de la société a été transféré au 20, rue Saint Ulric, L-2651 Luxembourg.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015039097/11.
(150044446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
Office Portfolio Minerva III Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.906.619,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 135.142.
Les comptes de liquidation au 25 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Office Portfolio Minerva III S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015039303/11.
(150044526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
Angelo Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 89A, rue Pafebruch.
R.C.S. Luxembourg B 172.375.
Les statuts coordonnés au 12/02/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05/03/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015037556/12.
(150042667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
49682
L
U X E M B O U R G
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 82.605.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015039923/10.
(150045458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
Orthodontie Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1514 Luxembourg, 2, rue Xavier de Feller.
R.C.S. Luxembourg B 110.385.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015039914/10.
(150045274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
LaVita Marketing BeNeLux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, Zare-Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 98.241.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015039794/11.
(150045286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
Phytolux International Pharmaceutical Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1450 Luxembourg, 13, Côte d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 113.500.
<i>Extrait de la résolution des Actionnaires tenue à Luxembourg le 6 mars 2015i>
<i>Première résolutioni>
Acceptation de la démission des Administrateurs avec effet au 13/01/2015:
a) Acceptation de la démission de Mrs. Nelly Noel, administrateur de la société.
b) Acceptation de la démission de Mr. Roger Greden, administrateur de la société.
<i>Deuxième résolutioni>
Nomination des nouveaux Administrateurs:
a) Mrs Annemarie Steen Olsen, résidant professionnellement au 35, am Grëndchen à L-1655 Luxembourg.
b) Mr. Anani Daniel Voule, résidant professionnellement au 23, Gamla Brovagen, à 370 12 Hallabro, Suède.
<i>Troisième résolutioni>
Décision de transférer le siège social de la société du L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange au L-1450 Luxem-
bourg, 13, Côte d'Eich avec effet au 17/11/2014.
Les nouveaux administrateurs seront nommés pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 6 mars 2015.
Référence de publication: 2015038794/21.
(150043857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
49683
L
U X E M B O U R G
Luphar S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 133.416.
- Monterey Audit Sàrl, agent domiciliataire, dénonce le siège social de la société
Luphar S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 133.416.
et domiciliée au 29, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Philippe GAIN
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015038704/13.
(150043816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Meluna Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 112.467.
Veuillez noter que Mr. Jordan FINKLER réside désormais professionnellement au 280 Park Avenue, 30
ème
étage,
NY-10017 New York (Etats-Unis d'Amérique)
Luxembourg, le 9 mars 2015.
Pour extraits et avis sincère et conforme
<i>Pour Meluna Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015038742/14.
(150044160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Meluna Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 112.467.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 20 janvier 2015i>
1. Monsieur Vincent COENTEPAS a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 20 janvier 2015.
2. Monsieur Jean-Christophe DAUPHIN a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 20 janvier 2015.
3. Monsieur Georges SCHEUER a démissionné de son mandat de gérant avec effet au 20 janvier 2015.
4. Monsieur Sébastien BOMBENGER, administrateur de sociétés, né à Colmar (France), le 23 janvier 1983, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indé-
terminée et ce à partir du 20 janvier 2015.
5. Monsieur David CATALA, administrateur de sociétés, né à Gand (Belgique), le 19 janvier 1979, demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant pour une durée indéterminée
et ce à partir du 20 janvier 2015.
6. Madame Sophie PERRIN-JANET, administrateur de société, née à Vénissieux (France), le 15 janvier 1981 demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme gérante pour une durée
indéterminée et ce à partir du 20 janvier 2015.
7. Le siège de la société a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453
Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert et ce avec effet au 20 janvier 2015.
Luxembourg, le 9 mars 2015.
Pour extraits et avis sincère et conforme
<i>Pour Meluna Investments S.à r.l.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015038741/27.
(150043889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
49684
L
U X E M B O U R G
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.843.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 mars 2015.
Référence de publication: 2015039231/10.
(150044777) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
Li Tung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2267 Luxembourg, 18, rue d'Orange.
R.C.S. Luxembourg B 182.449.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015039233/10.
(150044426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
ETI Electronique Tôlerie Intégration S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4716 Pétange, 4, rue Bommert.
R.C.S. Luxembourg B 123.514.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour ETI Electronique Tôlerie Intégration S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015039705/12.
(150045113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
International Trading and Engineering S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 131.501.
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'actionnaire unique de la société tenue en date du 3 mars 2015i>
Les mandats suivants ont été renouvelés avec effet immédiat et ceux jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en
2020:
<i>Administrateur de Classe A:i>
1. Christian Tailleur, administrateur,
<i>Administrateur de Classe B:i>
2. Keimpe Reitsma, administrateur,
3. James Body, administrateur,
<i>Commissaire aux comptes:i>
4. TSM Services (Luxembourg) S.à r.l.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015038657/22.
(150043831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
49685
L
U X E M B O U R G
CR Realty S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 116.076.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015039642/10.
(150045456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
Créaforme S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8361 Goetzingen, 19A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 109.235.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015039643/10.
(150045062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
Corelis, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3368 Leudelange, 12, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 99.150.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour CORELIS S.à r.l.
i>C&D - Associés S.à r.l.
Référence de publication: 2015039639/11.
(150045227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
EPG Investment Partners, Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 162.295.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015039703/11.
(150045549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
CPPL Lux 1, Société Anonyme.
Capital social: EUR 126.850,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 77.025.
Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015039641/12.
(150045300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
49686
L
U X E M B O U R G
SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 124.781.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 06 mars 2015.
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015038876/14.
(150044185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
SOUTHRAB INVESTMENTS, Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 20.760.
La société GESTOR Société Fiduciaire, représentée par Monsieur Philippe SLENDZAK, gérant unique, enregistrée au
Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B36079, ayant son siège social au 10A, rue Henri
M. Schnadt L-2530 Luxembourg, remet par la présente sa démission de sa fonction de Commissaire aux Comptes de la
société anonyme SOUTHRAB INVESTMENTS, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous
le numéro B20760, domiciliée au 10A, rue Henri M. Schnadt L-2530 Luxembourg, et ce, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 20 février 2015.
GESTOR Société Fiduciaire
Représentée par Monsieur Philippe SLENDZAK
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015038889/16.
(150043886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Xella International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 43-45, Allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 139.488.
EXTRAIT
Il résulte de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 9 mars 2015 que M. Heiko Karschti a été
révoqué de son mandat d'administrateur de classe B du conseil d'administration de la Société avec effet au 28 février
2015 et que M. Hans-Jürgen Wiecha, né le 4 avril 1962 à Cologne, Allemagne, résidant professionnellement au Düssel-
dorfer Landstr. 395, 47259 Duisburg, Allemagne a été nommé avec effet au 9 mars 2015 en tant qu'administrateur de
classe B du conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société qui
se tiendra en 2016.
Le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- Mme Marielle Stijger, administrateur de classe A,
- M. David Richy, administrateur de classe A,
- M. Peter Steiner, administrateur de classe B et président du conseil d'administration,
- M. Boudewijn van den Brink, administrateur de classe B,
- M. Jan Buck-Emden, administrateur de classe B,
- M. Hans-Jürgen Wiecha, administrateur de classe B,
- Dr. Joachim Fabritius, administrateur de classe B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 mars 2015.
Référence de publication: 2015039472/24.
(150044292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
49687
L
U X E M B O U R G
Rodina (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 2A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 129.961.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par jugement rendu en date du 5 février 2015, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, a
déclaré closes pour absence d'actif les opérations de la liquidation de la société à responsabilité limitée RODINA (Lu-
xembourg) II sàrl (R.C.S. N° B 129961), dont le siège social à L-1840 Luxembourg, 2a, boulevard Joseph II, a été dénoncé
en date du 12 janvier 2010.
Pour extrait conforme
Me Réguia AMIALI
<i>Le liquidateur
i>48-52, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette
Référence de publication: 2015038818/17.
(150043949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
UKSA 60 CR S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 173.575.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 17 février 2015i>
L'associé unique de la Société a décidé de prendre acte et d'accepter la démission de CEREP Management S.à r.l., de
M Damien Rensonnet et M. David Pearson, de leur poste de gérants de la Société avec effet au 2 mars 2015.
L'Associé Unique a décidé de nommer, pour une durée indéterminée et à compter du 2 mars 2015:
- M Vitalij Farafonov, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mme Nicole Goetz, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; et
- M Maxime Nino, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UKSA 60 CR S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015039446/18.
(150044256) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
UKSA Isledon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 154.732.
<i>Extrait des décisions de l'associé unique de la Société adoptées le 17 février 2015i>
L'associé unique de la Société a décidé de prendre acte et d'accepter la démission de CEREP Management S.à r.l., de
M Damien Rensonnet et M. David Pearson, de leur poste de gérants de la Société avec effet au 2 mars 2015.
L'Associé Unique a décidé de nommer les personnes suivantes comme gérants, pour une durée indéterminée et à
compter du 2 mars 2015:
- M Vitalij Farafonov, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg;
- Mme Nicole Goetz, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg; et
- M Maxime Nino, résidant professionnellement au 1-3, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
UKSA Isledon S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015039445/19.
(150044458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
49688
L
U X E M B O U R G
Sparinvest SICAV-SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 165.126.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015039406/9.
(150044448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
Aida Wedo 9 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1340 Luxembourg, 8, place Winston Churchill.
R.C.S. Luxembourg B 185.530.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015037591/10.
(150042586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
PROMIS@Service S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 139.546.
Die neue Adresse der Gesellschaft lautet, laut außerordentlichem Gesellschafterbeschluss vom 08.01.2015:
PROMIS@Service Sàrl
14, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
Luxembourg, den 09.03.2015.
Référence de publication: 2015038811/13.
(150044193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Private Theory Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 194.923.
Il est notifié qu'en date du 4 mars 2015:
- 1,250,000 parts sociales détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée et existante sous les
lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Lu-
xembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du Luxembourg sous
numéro B 174367, ont été transférées à Private Theory LP, Limited Partnership, ayant son adresse professionnelle au c/
o Richard M. Cashin, 10 Gracie Square, Apt. 8G, New York, NY 10028, Etats-Unis d'Amérique et enregistrée à l'Etat de
Delaware sous le numéro 5697331
Résultant des décisions susmentionnées les 1,250,000 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme
suit:
- Private Theory LP détient 1,250,000 parts sociales de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Private Theory Luxco S.à r.l.
Joost Anton Mees
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015038796/22.
(150043876) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
49689
L
U X E M B O U R G
HGHQK 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.400,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 192.493.
In the year two thousand and fifteen, on the third of February,
Before Maître Karine REUTER, Civil Law Notary, residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.
THERE APPEARED
Harel Insurance Company Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel, having its registered
office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, and having the following company number
52-000407-8 (hereinafter referred to as the “Appearing Party”),
duly represented by Mr Yves MERTZ, professionally residing at 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg by virtue of a
power of attorney, given privately to him on 26 January 2015.
Said proxy, after having been initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
The appearing party is the sole shareholder of HGHQK 2 S.à r.l., a Société à responsabilité limitée, having its registered
office at 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned
notary on 8 December 2014, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section
B number 192493 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 3878 on 15 December
2014; the Articles of Association of which have never been amended.
Article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as amended ("Article 200-2")
provides that a sole shareholder of a Société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders of the Company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
The Sole Shareholder, acting in its capacity of sole shareholder of the Company, hereby passes the following written
resolutions in accordance with Article 200-2 and, declared and requested the Notary to act that:
<i>First resolutioni>
The sole member decides to amend article 8.2. (v) of the Articles of Association so that as from now on it will read
as follows:
« Art. 8.2. (v). The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.
Board resolutions shall be validly adopted by the unanimity of the votes of the managers present or represented, provided
that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, all class A
manager and all class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.»
<i>Second resolutioni>
The sole member decides to amend article 8.3. (i) of the Articles of Association so that as from now on it will read
as follows:
« Art. 8.3. (i). The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of all managers,
or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint
signature of all class A managers and all class B managers.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-). With regard to the
undersigned notary, all the appearing and/or signatories hereto recognize jointly and severally being bound to costs,
expenses and charges arising from the present notarial deed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original
deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil quinze, le trois février,
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, soussignée.
49690
L
U X E M B O U R G
A COMPARU
Harel Insurance Company Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l’Etat d’Israël, dont le
siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro
52-000407-8, (ci-après la «Partie Comparante»),
dûment représentée par Monsieur Yves MERTZ, avec adresse professionnelle au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 26 janvier 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante est l’associée unique de la Société à responsabilité limitée HGHQK 2 S.à r.l., ayant son siège
social au 37, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous
la section B numéro 192493, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 décembre 2014 publié au
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3878 du 15 décembre 2014; et dont les statuts n’ont
jamais été modifiés.
L'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 dans sa version coordonnée
(«Article 200-2») dispose qu'un associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs de l'assemblée
générale des associés de la Société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès verbal ou
rédigées par écrit.
L'Associé Unique, agissant dans sa capacité d'associé unique de la Société, par la présente adopte les résolutions écrites
suivantes conformément à l'Article 200-2, déclare et demande au Notaire d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l’article 8.2. (v) des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 8.2 (v). Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les résolutions du Conseil sont valablement adoptées à l’unanimité des voix des gérants présents ou re-
présentés, étant entendu que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants
de classe B, tous les gérants de classe A et tous les gérants de classe B vote en faveur de la résolution. Les décisions du
Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n’a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.»
<i>Seconde résolutioni>
L'associé unique décide de modifier l’article 8.3. (i) des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 8.3. (i). La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tous
les gérants, ou, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par
les signatures conjointes de tous les gérants de classe A et de tous les gérants de classe B.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (1.400.-€). A l’égard du notaire instru-
mentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes. Et après lecture faite au comparant,
le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française.
Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais
fera foi.
Signés: Y. MERTZ, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 février 2015. Relation: EAC/2015/3449. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME
PETANGE, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015038637/105.
(150044132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
49691
L
U X E M B O U R G
Ardent Oil (Denmark) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 193.529.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour la société
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015038373/14.
(150043474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Institut de Formation Bancaire, Luxembourg, Etablissement d'Utilité Publique.
Siège social: L-1468 Luxembourg, 12, rue Erasme.
R.C.S. Luxembourg G 22.
<i>Annual accounts as at December 31, 2014i>
<i>(with the report of the Réviseur d'Entreprises agréé)i>
<i>Table of contentsi>
<i>Annual accountsi>
- Report of the Réviseur d'Entreprises agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
- Balance sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
- Profit and loss account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
- Notes to the annual accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-10
<i>Report of the Réviseur d'entreprises agrééi>
We have audited the accompanying annual accounts of Institut de Formation Bancaire, Luxembourg, which comprise
the balance sheet as at December 31, 2014 and the profit and loss account for the year then ended and a summary of
significant accounting policies and other explanatory information.
<i>Responsibility of the Board of Directors for the annual accountsi>
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual accounts in accordance
with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts, and for such
internal control as the Board of Directors determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are
free from material misstatement, whether due to fraud or error.
<i>Responsibility of the Réviseur d'entreprises agrééi>
Our responsibility is to express an opinion on these annual accounts based on our audit. We conducted our audit in
accordance with International Standards on Auditing as adopted for Luxembourg by the Commission de Surveillance du
Secteur Financier. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance about whether the annual accounts are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the annual
accounts. The procedures selected depend on the judgement of the réviseur d'entreprises agréé, including the assessment
of the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to fraud or error. In making those risk assess-
ments, the réviseur d'entreprises agréé considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation
of the annual accounts in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.
An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates made by the Board of Directors, as well as evaluating the overall presentation of the annual accounts.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
<i>Opinioni>
In our opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of Institut de Formation Bancaire,
Luxembourg as of December 31,2014, and of the results of its operations for the year then ended in accordance with
Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation of the annual accounts.
49692
L
U X E M B O U R G
Bertrange, February 26, 2015.
CLERC
Cabinet de révision agréé
Jean-Jacques Soisson
<i>Balance sheet December 31, 2014 (in Euro)i>
ASSETS
2014
2013
FIXED ASSETS
Tangible assets (note 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.400,64
39.261,25
Financial assets (note 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.533,68
3.000,00
30.934,32
42.261,25
CURRENT ASSETS
Debtors becoming due and payable within one year (note 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308.489,47
607.869,90
Transferable securities (note 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206.500,00
206.500,00
Term deposit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
650.000,00
650.000,00
Cash at bank
- current account . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483.713,61
349.212,77
- deposits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136.865,39
126.437,25
1.785.568,47 1.940.019,92
DEFFERED CHARGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.841,25
28.002,12
TOTAL ASSETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.852.344,04 2.010.283,29
LIABILITIES
EQUITY
Retained earnings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.350.908,88 1.345.385,17
Result for the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.306,24
5.523,71
1.380.215,12 1.350.908,88
PROVISIONS FOR LIABILITIES AND CHARGES
Other provisions (note 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
114.700,00
CREDITORS
Becoming due and payable within one year (note 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
455.634,92
528.897,32
DEFFERED INCOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.494,00
15.977,09
TOTAL LIABILITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.852.344.04 2.010.283,29
<i>Profit and loss accounti>
<i>Year ended December 31, 2014 (in Euro)i>
CHARGES
2014
2013
Direct expenses of training activities (note 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.338.763,27 1.370.189,92
Other external charges (note 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421.258,09
568.535,97
Staff costs (note 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.441.626,28 1.378.460,08
Value adjustments in respect of tangible fixed assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.684,91
14.809,34
Extraordinary charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
121.755,60
Surplus for the financial year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29.306,24
5.523,71
3.249.638,79 3.459.274,62
INCOME
ABBL contribution (note 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
350.000,00
Ventes Projet "House Of Training" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217.391,30
0,00
Donation from "Mathieu Frères Foundation" (note 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.154,96
8.029,56
Income from training activities (note 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.529.488,16 2.785.341,74
Subvention - FSE - Fonds Social Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436.006,95
0,00
Other income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.085,15
302.340,37
Income from transferable securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.087,35
7.500,00
Other interest receivable and similar income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.424,92
6.062,95
3.249.638,79 3.459.274,62
The accompanying notes form an integral part of these annual accounts.
49693
L
U X E M B O U R G
Notes to the annual accounts December 31, 2014
Note 1. General. The «lnstitut de Formation Bancaire, Luxembourg» (hereafter "IFBL" or "the Institution") was in-
corporated on December 28,1990 In the form of a public purpose Institution.
The articles of incorporation of IFBL were approved by a Grand-Ducal decree, as laid down in article 30 of the law of
April 21, 1928 on non-profit-making organisations and public purpose institutions.
The object of the IFBL is to conceive, establish, develop and promote all training methods, programmes and activities
in the interest of the Luxembourg financial sector.
Note 2. Principal accounting policies.
- General
The annual accounts have been prepared in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements. The
annual accounts of the Institution are based amongst other on the articles 34 and 46 of the law of December 19, 2002
and the legal presentations are adapted according to the specificities of the activity of the Institution.
- Foreign exchange
The Institution maintains its accounts in Euros (EUR) and the balance sheet and profit and loss account are expressed
in this currency.
Transactions expressed in a currency other than Euros are translated into Euros at the exchange rates prevailing at
payment date.
- Tangible assets
Tangible assets are valued at purchase price including the expenses incidental thereto. Tangible fixed assets are amor-
tised on a straight-line basis over their estimated useful lives.
- The amortisation rates and methods applied on a straight-line basis as follows:
* Furniture and installations: 10%
* IT Equipment: 33%
- Financial assets
Financial fixed assets are stated at cost
A value adjustment is made when a permanent decrease in value has occurred.
- Receivables
Receivables resulting from the supply of services are valued at their nominal value. A value adjustment is made when
the realisable value at the balance sheet date is lower than the nominal value.
- Transferable securities
Transferable securities are valued at the lower of purchase cost or market value. A value adjustment is recorded where
the market value is lower than the purchase cost. The value adjustments are note continued if the reasons for which the
value adjustments were made have ceased to apply.
- Provisions for liabilities and charges
The provisions for liabilities and charges are intended to cover losses or debts the nature of which is clearly defined
and which at the balance sheet date are likely either to be incurred or certain to be incurred but uncertain as to their
amount or as to the date on which they will arise.
- Taxation
The IFBL is subject to VAT but not Tax Company.
Note 3. Tangible assets. Tangible fixed assets include furniture and office equipment.
2014
EUR
2013
EUR
Acquisition cost:
At the beginning of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
788.754,43
772.271,39
Acquisitions during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
824.30
16.483.04
Outgoing inventory during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.00
0.00
At the end of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
789.578.73
788.754.43
Value adjustments:
At the beginning of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (749.493,18) (734.683,84)
For the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(18.684,91)
(14.809.34)
At the end of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (768.178.09) (749.493.18)
Net value at the end of the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21.400.64
39.261.25
Note 4. Financial assets. The Institution holds a minor participation In «Agence de Transfert de Technologie Financière
Luxembourg S.A.» (ATTF). The acquisition cost amounts to EUR 0.533,68
49694
L
U X E M B O U R G
Note 5. Debtors.
2014
EUR
2013
EUR
Receivables resulting from the supply of services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.050,95 485.108,63
Interest receivables from transferable securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.765,43
5.686 26
VAT receivable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 117.075,01
304.816,38 607.869,90
Note 6. Transferable securities. At year end, the market value of these transferable securities amounts to EUR
220.366,00
Note 7. Provisions for liabilities and charges. Provisions mainly include the following points:
2014
EUR
2013
EUR
Provision for Course Training / Maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
77.700,00
Provision Staff related Claims Settlement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
37.000,00
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00 114.700.00
Note 8. Creditors.
2014
EUR
2013
EUR
Salaries and social security debts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110.093,89 122.561,21
Trade creditors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345.541.03 406.136.11
455.634.92 528.697.32
Note 9. Share of abbl budget. A portion of IFBL's income is derived from a contribution from ABBL which amounts,
2014, to EUR 0,00 (2013:350,000,00)
Note 10. Donation from "MATHIEU FRERES" Foundation. Every year, the Institution receives a donation from the
Mathieu Frères Foundation (domiciliated in Switzerland). The funds received are allocated to the trainings of professional
bank employees.
Note 11. Income from training activities / Direct expenses on training activities. IFBL recovers direct charges relating
to training activities and a portion of its general operating expenses from training course participants.
Note 12. Other external charges.
2014
EUR
2013
EUR
Offices:
Rent, cleaning and insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.951,93 165.278,20
Functioning:
Equipment rental and maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.528,24
15.389,53
Telephone, telefax, mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.894,37
16.118,01
Office equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.311,50
20.582,48
Maintenance of IT equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.426,84 173.546,25
Other expenses:
Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.600,00
5.600,00
Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194,51
608,15
Travel and representation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17.904,44
16.273,35
Contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.895,00
6.150,00
Outsourced services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.058,09
16.031,29
Miscellaneous expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.969,90
8.610,36
Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108.810,78 116.195,85
Internal / staff education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.712,49
8.152,50
421.258,09 568.535.97
Note 13. Staff costs.
2014
EUR
2013
EUR
Gross salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.206.284,08 1.144.000,00
Social security charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161.060,26
155.393,88
49695
L
U X E M B O U R G
Refunds mutual insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(25.132,39)
(26.613,81)
Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54.970,24
51.765,03
Social Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44.444,09
53.914,98
1.441.626,28 1.378.460.08
In the course of the year, the average number of staff employed by the Institution was 14,72 FTE persons (2013:14,93
persons).
IFBL
Accounts
December
31, 2014
Budget
2015
INCOME
Contributions
- Projet "House Of Training" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217 391,30
0
- Mathieu Frères Foundation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 154,96
8 000
Interests & similar products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 512,27
9 000
Subvention - FSE - Fonds Social Européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436 006,95
Income activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 529 488,16 2 830 000
Other income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 085,15
0
Total Income . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 249 638,79 2 847 000
EXPENSES
Staff
- Gross salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 206 284,08 1 188 000
- Social security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161 060,26
181 50
- Refunds mutual insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-25 132,39
-21 000
- Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54 970,24
50 000
- Social fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44 444,09
57 000
Total staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 441 626,28 1 455 500
Operating expenses
Offices
- House of Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 506,11
51 969
- Conciergerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 000,00
5 000
- Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 257,72
500
Rent, maintenance, cleaning & insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55 763,83
57 469
Functioning
- Equipment rental & maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 528,2
14 800
- Telecom & mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 894,37
16 000
- Office & IT equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 499,60
12 000
- IT maintenance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162 426,84
161 800
Total functioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201 349,05
204 600
Other expenses
- Fees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 600,00
6 000
- Documentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194,51
500
- Travel & representation expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 904,44
17 000
- Contributions to third parties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 895,00
6 000
- Staff training and conferences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 712,49
15 000
Total other expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 306,44
44 500
Outsourced services & miscellaneous
- HR administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 058,09
6 000
- Miscellaneous (bank charges & Cetrel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 694,90
10 000
Total outsourced services & miscellaneous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 752,99
16 000
Depreciation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 684,91
18 000
- Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 670,38
35 000
- Logistics events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 843,18
50 000
- Catalog and print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
488,58
- Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 549,41
5 000
49696
L
U X E M B O U R G
- Other expenses / promotional materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 534,23
10 000
Promotion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109 085,78
100 000
- Trainers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 201 241,99 1 200 000
- Print . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67 069,23
- Accomodation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 452,05
Expenses activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 338 763,27 1 200 000
Provision staff related claims settlement
Provision for new development / Maintenance
Total Expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 220 332,55 3 096 069
Result . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 306,24
-249 069
Référence de publication: 2015038644/266.
(150043444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Fondation Peters, Fondation.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg G 227.
L’an deux mille quatorze, le dix décembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Monsieur Jean PETERS né le 29 avril 1941 à Colmar, France, directeur de sociétés e.r., demeurant à Esher, Surrey,
Grande-Bretagne,
agissant en sa qualité de mandataire du Conseil d’Administration de la fondation dénommée FONDATION PETERS
(la «Fondation»), ayant son siège statutaire à L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II, inscrite au Registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro G 227, constituée par acte du notaire soussigné en date du 9 avril
2013, publié au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 1706 du 16 juillet 2013, dont les statuts
n’ont pas été modifiés depuis,
en vertu d’une résolution du Conseil d’Administration de la Fondation en date du 1
er
décembre 2014, dont le procès-
verbal restera annexée aux présentes pour être soumis avec elles à la formalité de l’enregistrement.
Lequel comparant, ès-qualité qu’il agit, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. Suivant résolution du Conseil d’Administration réuni le 28 mars 2014, à laquelle tous les administrateurs étaient
présents, dont le procès-verbal restera annexé aux présentes, il a été décidé, à l’unanimité des voix, de modifier les articles
4, 5, 7, 10, 12, 14, 15 et 16 des statuts dont la teneur a été arrêtée par le Conseil d’Administration.
Le projet de modification des statuts a été envoyé au Ministre de la Justice pour approbation en date du 9 avril 2014.
Le Ministre de la Justice a donné son accord en date du 24 novembre 2014.
II. Suivant résolution du 1
er
décembre 2014, le Conseil d’Administration a mandaté Monsieur Jean PETERS, prénommé,
aux fins de faire acter les modifications statutaires pardevant le notaire soussigné, de sorte que les statuts de la Fondation
ont désormais la teneur suivante:
Version française:
«Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Durée
Art. 1
er
. La Fondation prend la dénomination de «Fondation Peters», ci-après «la Fondation».
Art. 2. Le siège de la Fondation se situe dans la commune de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d’ad-
ministration rédigée par acte notarié et approuvée par arrêté grand-ducal.
Art. 3. La Fondation est constituée pour une durée illimitée.
Chapitre II. Objet
Art. 4. La Fondation a pour objet de soutenir des activités caritatives au Grand- Duché de Luxembourg ou à l’étranger,
destinées à servir un, plusieurs ou tous les objectifs suivants:
- promotion des arts ou de la culture
- promotion de l’éducation
- assistance aux personnes dans le besoin
- promotion de la santé ou sauvetage de vies
49697
L
U X E M B O U R G
Le conseil d’administration versera ou fera affecter à sa discrétion les recettes de la Fondation en faveur de la promotion
de cet objet au moment et de la manière qu’il jugera opportuns, étant entendu qu’il lui sera loisible, en vue de la réalisation
de cet objet, d’accumuler toute partie desdites recettes pour la durée qu’il estimera, à sa discrétion, comme étant ap-
propriée.
Chapitre III. Patrimoine et Recettes
Art. 5. Les fondateurs comparants apportent, comme premier apport lors de la création à la Fondation, un patrimoine
équivalent à cinq millions trente-six mille trois cent quatre-vingt-huit euros et quatre cents (EUR 5.036.388,04.-) composé
d’espèces pour un montant de cinq millions trente-cinq mille dollars US (USD 5.035.000.-) et de valeurs mobilières pour
un montant d’un million cent soixante-cinq mille huit cent quarante et un euros et quatre-vingt-six cents (EUR
1.165.841,86).
La Fondation pourra disposer de la dotation en conformité avec ses statuts dès la date de l’arrêté grand-ducal d’ap-
probation des présents statuts.
Des libéralités entre vifs et testamentaires supplémentaires sont admis par le conseil d’administration et autorisés
conformément à l’article 36 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. La
Fondation financera ses activités essentiellement à l’aide des revenus des capitaux affectés à la création de la Fondation
ou recueillis depuis.
Il est interdit à la Fondation de poursuivre une quelconque activité lucrative, en ce compris toute activité commerciale.
Art. 6. Dans les conditions prévues par l’article 36 de la prédite loi, les recettes de la Fondation comprennent:
(a) les dons, legs, subsides et subventions de toutes sortes, qu’elle pourra recevoir;
(b) les intérêts et revenus généralement quelconques provenant de son patrimoine et
(c) de façon plus générale, toutes autres ressources autorisées par la loi.
Cette énumération n’est pas limitative.
Chapitre IV. Administration et Gestion journalière
Art. 7. La Fondation est administrée par un conseil d’administration qui la représente dans tous les actes judiciaires et
extrajudiciaires. Ce conseil d’administration est composé de trois membres au moins et de dix membres au plus. Lors
de la constitution de la Fondation, les fondateurs désigneront les administrateurs. Les administrateurs ont un mandat de
trois (3) ans renouvelable. A la fin du mandat, ou en cas de vacance, les nouveaux administrateurs sont nommés par le
conseil d’administration. Les fondateurs sub 1) et sub 2) auront de leur vivant un droit de proposition pour toute élection
d’administrateur, soit en cas de vacance soit en cas de renouvellement du conseil d’administration.
Toute modification dans la composition du conseil d’administration doit se faire par acte notarié, approuvée par arrêté
grand-ducal conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi.
Le patrimoine et les fonds de la Fondation ne devront servir qu’aux seules fins de la promotion de son objet et ne
seront pas la propriété du conseil d’administration.
(a) Les mandats des membres du conseil d’administration sont tous bénévoles. Les membres du conseil d’administration
ne seront pas habilités à percevoir une quelconque rémunération ou un quelconque paiement ou autre avantage matériel
(direct ou indirect) de la part de la Fondation, à l’exception:
(i) d’une assurance responsabilité civile et des paiements contractuels (voir Article 7(b) ci-dessous)
(ii) du remboursement des dépenses raisonnablement encourues, preuve à l’appui, dans le cadre de l’administration
de la Fondation
(iii) d’une indemnité pour toute dette dûment contractée dans le cadre de la gestion de la Fondation
(b) Les membres du conseil d’administration ne pourront pas être employés par la Fondation. Tout membre du conseil
d’administration ou toute personne ayant un lien avec ce membre (dans le sens le plus large du terme) sera toutefois
autorisé à conclure un contrat de fourniture de biens ou de services avec la Fondation en contrepartie d’un paiement ou
autre avantage matériel, sous réserve toutefois que:
(i) la Fondation ait un besoin réel de tels biens ou services;
(ii) la nature et l’importance de l’avantage correspondent raisonnablement à la valeur des biens ou services et soient
fixées à une réunion du conseil d’administration, à laquelle le membre intéressé devra exposer son intérêt, quitter la
réunion lors de la discussion du point en question et rester absent de la réunion durant le vote, et sera dépourvu de tout
droit de vote à ce sujet, et
(iii) pas plus de la moitié des membres du conseil d’administration ne s’intéresse à un tel contrat au cours d’une même
année.
Art. 8. Le conseil d’administration élit en son sein un Président. Le Président-fondateur assurera la gestion journalière
des affaires de la Fondation sous sa seule signature. Tant que l’un des fondateurs fera partie du conseil d’administration,
l’un des deux fondateurs sera le Président. Le Président-fondateur ne pourra pas être révoqué durant l’exercice de son
mandat, sans préjudice à l’article 40 alinéa 2 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans
but lucratif.
49698
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un ou plusieurs vice-présidents.
Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président, à son défaut par un vice-président, et, en leur
absence, par l’administrateur le plus ancien en rang.
Le conseil d’administration peut s’adjoindre un secrétaire.
Art. 10. Le conseil d’administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la Fondation l’exigent, mais au moins
une fois par an au siège de la Fondation. Les avis de convocation aux réunions du conseil d’administration sont envoyés
par courrier, fax ou email et postés au moins huit jours à l’avance. Ceux-ci renseignent l’ordre du jour et sont signés par
son président, et, en son absence, par un vice-président. En cas d’urgence et à titre exceptionnel et si tous les membres
sont d’accord avec cette procédure, une décision du conseil d’administration peut être prise par écrit.
Il ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Un administrateur absent peut,
même par correspondance (lettre, télécopie ou courriel) donner mandat à un autre administrateur pour le représenter
aux délibérations du conseil d’administration. Le mandat n’est valable que pour une séance. Un administrateur ne peut
représenter qu’un seul autre administrateur par séance.
Les administrateurs peuvent aussi participer aux débats et votes par des moyens de communication où il est possible
à l’administrateur, relié par télécommunication, de s’exprimer et d’entendre les observations des autres membres siégeant
ou connectés par un moyen de télécommunication.
Sauf en cas de modification des statuts et de désignation de nouveaux administrateurs où la majorité requise est de
deux tiers (2/3), les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les administrateurs
peuvent être révoqués par le conseil d’administration par un vote à une majorité de deux tiers (2/3) des votants en ne
tenant pas compte des administrateurs à révoquer.
En cas de partage des voix, la voix de celui qui préside la séance est prépondérante.
Chapitre V. Les pouvoirs du conseil d’administration
Art. 11. Le conseil d’administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’objet de la Fondation; il décide
tous actes d’administration, de disposition et de gestion.
Art. 12. Le conseil d’administration ne peut déléguer que la seule gestion journalière des affaires de la Fondation et la
gestion et la mise en œuvre des lignes directrices approuvées de temps à autre par le conseil d’administration, à l’exclusion
de tous autres pouvoirs, à une ou plusieurs personnes choisies en son sein ou en-dehors de son sein, sous réserve toutefois
que toute délégation de la sorte soit revue au moins une fois par an par le conseil d’administration et que la personne
déléguée à cette fin fournisse régulièrement des rapports au conseil d’administration.
Art. 13. La Fondation est engagée dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires par la signature individuelle d’un de
ses fondateurs sub 1) ou sub 2), tant qu’ils font partie du conseil d’administration, de même que par la signature conjointe
de deux administrateurs, sans préjudice de délégations générales ou particulières décidées par le conseil d’administration.
Chapitre VI. Comptes annuels et Budget
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Avant le premier décembre de chaque année, le conseil d’administration arrête le budget qui couvrira les dépenses et
recettes prévisionnelles de l’année à venir.
Les comptes de la Fondation sont tenus selon les principes et modalités de la comptabilité commerciale.
À la clôture de l’exercice, le conseil d’administration établit un bilan et un compte de profits et pertes de l’exercice
écoulé.
La Fondation est tenue de confier le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de leur régularité au
regard de la loi et des statuts à un réviseur d’entreprises agréé auprès de l’Institut des réviseurs d’entreprises au Luxem-
bourg. Son mandat a une durée d’une année et est renouvelable. Sa rémunération est à charge de la Fondation. Il remet
son rapport au conseil d’administration.
Les comptes annuels de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice en cours sont communiqués au Ministre de la
Justice conformément aux dispositions légales. À la même occasion, les comptes annuels et le budget sont publiés au
Mémorial, Recueil des Sociétés et des Associations.
Chapitre VII. Modification des statuts
Art. 15. Toute modification des statuts doit être faite conformément à l’article 32 de la loi modifiée du 21 avril 1928
sur les associations et fondations sans but lucratif. Elle ne peut être décidée que par le conseil d’administration statuant
à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres. Elle n’entre en vigueur qu’après avoir été approuvée par arrêté grand-
ducal. Toutefois, aucune modification de la sorte ne sera valable dans la mesure où elle entraînerait de quelconques
changements de l’objet (Article 4) ou modifications des dispositions stipulées à l’Article 7(a) et 7(b) et à l’Article 16.
Chapitre VIII. Dissolution
Art. 16. En cas de dissolution de la Fondation un ou plusieurs liquidateurs peuvent être nommés par le Conseil d’ad-
ministration. L’actif net de la Fondation sera affecté après apurement du passif à une fondation sans but lucratif de droit
49699
L
U X E M B O U R G
luxembourgeois, à une association sans but lucratif reconnue d’utilité publique par arrêté grand-ducal ou à une fondation
sans but lucratif ayant son siège dans un autre Etat-membre de Union européenne ou de l’Association européenne de
libre échange et poursuivant un but identique ou semblable à celui de la présente fondation.
Chapitre IX. Divers
Art. 17. Tout ce qui n’est pas prévu explicitement par les présents statuts est régi conformément à la loi modifiée du
21 avril 1928 sur les associations et fondations à but non lucratif.
Chapitre X. Composition du premier conseil d’administration
À la constitution de la Fondation sont désignés comme administrateurs pour un mandat de trois ans, renouvelable:
1. Monsieur Jean Peters, né le 29 avril 1941 à Colmar, France, directeur de sociétés e.r., demeurant à GB-Esher, Surrey
KT10 8PJ; 27, Lammas Lane, de nationalité française;
2. Madame Hélène Peters, née Le Roux de Bretagne le 14 septembre 1945 à Bernieulles, France, cadre d’entreprises
internationales e.r., demeurant à GB-Esher, Surrey KT10 8PJ; 27, Lammas Lane, de nationalité française;
3. Madame Amélie Schmidt, née Waché le 2 juillet 1970 à Cambrai, France, cadre d’entreprise internationale, demeu-
rant à D-85521 Ottobrunn, Spitzwegstrasse 42a, de nationalité française;
4. Monsieur Kurt Ehrke, né le 31 janvier 1942 à Bremen, Allemagne, directeur de société e.r. et demeurant à L-2326
Luxembourg; 4, rue Nicolas Petit, de nationalité allemande;
5. Monsieur Sam Reckinger, né le 14 mars 1965 à Luxembourg, directeur de société, demeurant professionnellement
à L-1840 Luxembourg; 40, boulevard Joseph II, de nationalité luxembourgeoise.»
Version anglaise:
«Chapter I. Name - Registered Office - Duration
Art. 1. The name of the Foundation shall be “Fondation Peters” (hereinafter “the Foundation”).
Art. 2. The registered office of the Foundation shall be located in the municipality of Luxembourg. It may be transferred
to any other locality within the Grand Duchy of Luxembourg by ordinary decision of the Governing Board drawn up in
the form of a notarial instrument and approved by Grand-Ducal decree.
Art. 3. The Foundation is set up for an unlimited period of time.
Chapter II. Objects
Art. 4. The objects of the Foundation shall be to support charitable activities in the Grand-Duchy of Luxembourg and
elsewhere, serving one, several or all of the following purposes:
- the advancement of the arts or culture
- the advancement of education
- the relief of those in need
- the advancement of health or the saving of lives
The Governing Board shall pay or cause to be applied at such time or times and in such manner as the Governing
Board shall in their discretion think fit the income of the Foundation in promoting the objects. Provided that the Governing
Board may in pursuance of the objects accumulate any part of the income for such period as in their discretion they
consider appropriate.
Chapter III. Assets and income
Art. 5. The founders, appearing as described above before the notary, are contributing, as their initial contribution
upon the setting-up of the Foundation, assets having a value equivalent to five million thirty six thousand three hundred
and eighty eight euros and four cents (EUR 5 036 388.04), composed of a cash sum amounting to five million thirty five
thousand US dollars (USD 5 035 000.-) and securities valued at one million one hundred and sixty five thousand eight
hundred and forty one euros and eighty six cents (EUR 1 165 841.86).
The Foundation shall be empowered to make use of the endowment in accordance with its statutes as from the date
of the Grand-Ducal decree approving those statutes.
Gifts inter vivos or testamentary gifts shall be accepted by the Governing Board of the Foundation and authorised in
accordance with Article 36 of the Law of 21 April 1928 on not-for-profit associations and foundations, as amended. The
Foundation shall finance its activities, in essence, by means of the income earned from the capital sums allocated for the
setting-up of the Foundation or received thereafter.
The Foundation is not allowed to pursue any for-profit activity, including any trading activity.
Art. 6. As provided in Article 36 of the said Law, the income of the Foundation shall comprise:
(a) gifts, legacies, subsidies and grants of all kinds that it may receive;
(b) interest and earnings generally, of whatever kind, deriving from its assets, and
(c) more generally, all other resources permitted by law.
49700
L
U X E M B O U R G
The foregoing list is not exhaustive.
Chapter IV. Administration and day-to-day management
Art. 7. The Foundation shall be administered by a Governing Board, which shall represent it in all judicial and extra-
judicial matters. That Board shall consist of not fewer than three and not more than ten members. Upon the setting-up
of the Foundation, the founders shall designate the members of the Board. The term of office of those members shall be
three (3) years, and shall be renewable. At the end of a term of office, or if an office falls vacant, the new members of the
Board shall be appointed by the Governing Board. The founders, being the persons specified under (1) and (2) above,
shall have, during their lifetime, the right to propose any person for election as a member of the Governing Board, either
in the event of a vacancy on the Board or in the case of renewal of the Board.
Any change in the composition of the Governing Board must be effected by a notarial instrument and approved by
Grand-Ducal decree in accordance with the provisions of Article 32 of the Law.
The property and funds of the Foundation must be used only for promoting the objects and do not belong to the
Governing Board.
(a) The mandates of the Governing Board members are all volunteer mandates. The members of the Governing Board
are not entitled to receive any kind of remuneration or payment of money or other material benefit (whether direct or
indirect) from the Foundation except:
(i) indemnity insurance and contractual payments (see Article 7(b) below)
(ii) reimbursement of reasonable out-of-pocket expenses actually incurred in the administration of the Foundation on
proof of receipt
(iii) an indemnity in respect of any liabilities properly incurred in the running of the Foundation
(b) A member of the Governing Board may not be an employee of the Foundation, but a member of the Governing
Board or person connected to him or her (in the widest sense) may enter into a contract with the Foundation to supply
goods or services in return for a payment or other material benefit but only if:
(i) The goods or services are actually required by the Foundation;
(ii) The nature and level of the benefit is no more than reasonable in relation to the value of the goods or services and
is set at a meeting of the Governing Board at which the member who is interested declares his interest, is absent from
the meeting for that item and shall be absent during the vote and have no vote on the matter and
(iii) Not more than one half of the members of the Governing Board are interested in such a contract in any one year.
Art. 8. The Governing Board shall elect a Chairman from among its members. The founder-Chairman shall handle the
day-to day management of the Foundation's affairs under his/her signature alone. For as long as one of the founders is a
member of the Governing Board, one of the two founders shall be the Chairman. The founder-Chairman may not be
dismissed during his/her term of office, without prejudice to the second paragraph of Article 40 of the Law of 21 April
1928 on not-for- profit associations and foundations, as amended.
Art. 9. The Governing Board shall elect one or more vice-chairmen from among its members.
Meetings of the Governing Board shall be chaired by the Chairman or, in his or her absence, by a vice-chairman or, in
the absence of the vice-chairmen, by the most senior member of the Board.
The Governing Board may appoint a secretary to assist it.
Art. 10. The Governing Board shall meet as often as the interests of the Foundation so require, but at least once per
year, at the registered office of the Foundation. Notices calling meetings of the Board shall be despatched by post, fax or
e-mail and must be sent at least eight days in advance. Such notices shall set out the agenda and shall be signed by the
Chairman or, in his or her absence, by a vice-chairman. Exceptionally, in urgent cases, provided all the Board members
agree, a decision of the Board may be taken by means of a written procedure.
The Board may validly deliberate and pass resolutions only if a majority of its members are present or represented.
An absent Board member may confer a proxy, even by means of correspondence (letter, fax or e-mail), upon another
Board member, authorising the latter to represent him or her in the deliberations of the Board. Such a proxy shall be
valid for one meeting only. A Board member may only arrange to be represented by one other Board member per
meeting.
The Board members may also take part in the discussions and votes by means of telecommunication where the Board
member in question, linked up to the meeting by such means, is able to express him/herself and to hear the observations
made by the other members physically present at the meeting or linked up to it by means of telecommunication.
Save in the case of amendment of the statutes and/or appointment of new Board members, where a two-thirds (2/3)
majority is required, decisions shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the members present or rep-
resented. Board members may be removed from office by the Board by a two-thirds (2/3) majority of the votes cast, not
including the Board members whose dismissal is being voted upon.
In the event of a tied vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
49701
L
U X E M B O U R G
Chapter V. Powers of the Governing Board
Art. 11. The Governing Board shall be vested with the widest possible powers to achieve the Foundation's object, and
shall decide on all acts of administration, disposal and management.
Art. 12. The Governing Board may delegate only the day-to-day management of the affairs of the Foundation and the
management and implementation of policies approved from time to time by the Governing Board, to the exclusion of all
other powers, to one or more persons chosen from amongst its members or to persons who are not Board members
provided that any such delegation shall be reviewed by the Governing Board at least once a year and the delegate provides
regular reports to the Governing Board.
Art. 13. The Foundation shall be bound, in all judicial and extrajudicial matters, by the sole signature of one of its
founders referred to in (1) and (2) above, as long as they remain members of the Governing Board, or by the joint
signatures of two Board members, without prejudice to any general or special delegations decided upon by the Governing
Board.
Chapter VI. Annual accounts and budget
Art. 14. The Foundation's accounting year shall commence on the first of January and end on the thirty first of De-
cember in each year.
Before the first of December in each year, the Governing Board shall fix the budget, which shall cover the forecast
expenses and income for the coming year.
The accounts of the Foundation shall be kept in accordance with the principles and practices of commercial accounting.
Upon the close of each accounting period, the Governing Board shall draw up a balance sheet and a profit and loss
account for the year that has elapsed.
The Foundation shall be required to entrust the auditing of its financial situation, its annual accounts and their cor-
rectness under the law and under the statutes to a company auditor registered with the Institut des réviseurs d'entreprises
(Institute of Registered Auditors) in Luxembourg. The term of office of the auditor shall be one year and shall be re-
newable. The auditor's remuneration shall be payable by the Foundation. The auditor shall submit his or her report to
the Governing Board.
The annual accounts for the accounting period that has elapsed and the budget for the current accounting year shall
be communicated to the Minister of Justice in accordance with the applicable legislation. At the same time, the annual
accounts and the budget shall be published in the Mémorial (Official Gazette), in the section relating to companies and
associations.
Chapter VII. Amendment of the statutes
Art. 15. Any amendment of the statutes must be done in accordance with Article 32 of the Law of 21 April 1928 on
not-for-profit associations and foundations, as amended. Amendments may be decided upon only by a two-thirds (2/3)
majority of the members of the Governing Board, and shall not enter into force until they have been approved by Grand-
Ducal decree but no such amendment shall be valid if it would result in any changes to the objects (Article 4) or
amendments to the provisions set out in Articles 7(a) and 7(b) and Article 16.
Chapter VIII. Dissolution
Art. 16. In the event of dissolution of the Foundation, one or more liquidators may be appointed by the Governing
Board. The net assets of the Foundation shall be transferred, after the liabilities have been settled and discharged, to a
not-for-profit foundation established under Luxembourg law, to a not-for-profit association recognised by Grand- Ducal
decree as being of public interest or to a not-for-profit foundation having its registered office in another Member State
of the European Union or of the European Free Trade Association, which pursues an objective which is the same as, or
similar to, that of the Foundation.
Chapter IX. Miscellaneous provisions
Art. 17. Any matter which is not expressly provided for by these statutes shall be governed by the Law of 21 April
1928 on not-for-profit associations and foundations, as amended.
Chapter X. Composition of the first Governing Board
Upon the setting-up of the Foundation, the following persons are appointed to serve as members of the Governing
Board for a term of office of three years, which shall be renewable:
1. Mr Jean Peters, a French national, born on 29 April 1941 in Colmar, France, retired company director, residing at
27 Lammas Lane, Esher, Surrey KT10 8PJ, United Kingdom;
2. Ms Hélène Peters, née Le Roux de Bretagne, a French national, born on 14 September 1945 in Bernieulles, France,
retired international company executive, residing at 27 Lammas Lane, Esher, Surrey KT10 8PJ, United Kingdom;
3. Ms Amélie Schmidt, née Waché, a French national, born on 2 July 1970 in Cambrai, France, international company
executive, residing at Spitzwegstrasse 42a, D-85521 Ottobrunn;
49702
L
U X E M B O U R G
4. Mr Kurt Ehrke, a German national, born on 31 January 1942 in Bremen, Germany, retired company director, residing
at 4 Rue Nicolas Petit, L-2326 Luxembourg;
5. Mr Jacques Reckinger, known as Sam Reckinger, a Luxembourg national, born on 14 March 1965 in Luxembourg,
company director, having his business address at 40 Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.»
III. Suivant résolution du Conseil d’Administration réuni en date de ce jour, à laquelle tous les administrateurs étaient
présents ou représentés à l’exception de Madame Amélie Schmidt, dont le procès-verbal restera annexé aux présentes,
il a été décidé, à l’unanimité des voix, de nommer en qualité de nouvel administrateur de la Fondation Monsieur Manuel
BALDAUFF, né à Luxembourg, le 26 avril 1968, demeurant à L-1244 Luxembourg, 54, rue J.-F. Boch, son mandat devant
prendre fin le 10 décembre 2017, et de mandater Monsieur Jean PETERS, prénommé, aux fins de faire acter ladite no-
mination pardevant le notaire soussigné, de sorte que Monsieur Manuel BALDAUFF, prénommé, est nommé en tant que
nouvel administrateur de la Fondation jusqu’au 10 décembre 2017.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, ès-qualité qu’il agit, celui-ci a signé avec le notaire le
présent procès-verbal.
Signé: J. PETERS et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 décembre 2014. LAC / 2014 / 59678. Reçu douze euros € 12,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 22 décembre 2014.
Référence de publication: 2015038568/334.
(150043971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 195.167.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second day of the month of March.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Logicor Europe Holdings II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company) incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
having a share capital of twelve thousand and five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de
Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 181.528,
represented by Me Vianney de Bagneaux, avocat, professionally residing in Luxembourg pursuant to a proxy which
shall be registered together with the present deed.
The appearing party, represented as above stated, has requested the undersigned notary to draw up the articles of
incorporation of a limited liability company Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l. (société à responsabilité limitée) which is
hereby established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Ferrari Logistics
Pledgeco S.à r.l.” (the “Company”) is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders
thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company shall be the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and
development of its portfolio.
The Company may also carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of real estate,
properties and real estate rights in Luxembourg and abroad as well as any participations in any real estate enterprise or
undertaking in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participa-
tions and assets.
The Company may further give guarantees, grant security interests, grant loans or otherwise assist the companies in
which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.
The Company may also acquire loans including at a discount, originate loans and lend funds under any form, advance
money or give credit on any terms including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from
49703
L
U X E M B O U R G
the issue of any equity or debt securities of any kind to any person or entity as it deems fit in relation to any real estate
enterprise or undertaking. The Company may enter into swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock
lending and similar transactions, and, without prejudice to the generality of the foregoing, employ any techniques and
instruments in connection with its real estate activities. The Company may also enter into any guarantees, contracts of
indemnities, security interests and any other equivalent agreements in order to receive the benefit of any guarantee and/
or security interest granted in the context of such real estate activities. The Company may undertake any roles necessary
in connection with such lending activity including, without limitation, the role of arranger, lead manager, facility agent,
security agent, documentation agent. The Company shall not undertake such real estate lending or real estate loan
acquisition activities in a way that would require it to be regulated pursuant to the Luxembourg act dated 5 April 1993
on the financial sector, as amended or any future act or regulation amending or replacing such act.
The Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly
in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purposes.
In particular, the Company will provide the companies within its portfolio with the services necessary to their admi-
nistration, control and development. For that purpose, the Company may require and retain the assistance of other
advisors.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand and five hundred Euros (EUR
12,500) represented by five hundred (500) shares with a nominal value of twenty-five Euros (EUR 25) each. The capital
of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for
amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other shares upon
resolution of its shareholders.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy-five per cent
(75%) of the Company's share capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who do not need to be
shareholders.
The sole manager or as the case may be, the board of managers, is vested with the broadest powers to manage the
business of the Company and to authorise and/or perform all acts of disposal and administration falling within the purposes
of the Company. All powers not expressly reserved by the law or by the articles of association to the general meeting
shall be within the competence of the sole manager or as the case may be, the board of managers.
Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be, the board of managers, has the most extensive powers
to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all acts and operations relative to
the Company and not reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.
The managers are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of share-
holders, which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed
for an undetermined period. The managers may be re-elected but their appointment may also be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also at
any time be held by conference call or similar means only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be
49704
L
U X E M B O U R G
represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager
may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours (24) at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of that meeting or, in its absence,
by any two managers. Copies or excerpts of such minutes shall be signed by the chairman of that meeting or by any two
managers.
The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means
when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar means of communication. The entirety
will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions, including circular
resolutions, may be conclusively certified or an extract thereof may be issued under the individual signature of any
manager.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the sole signature of anyone of the managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of
any person or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only
one) or as the case may be the board of managers or anyone of the managers.
Art. 8. Liability of the Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company.
As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence
or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;
(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in
the interest of the Company; or
(iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by
the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article.
Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 10. Shareholder meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting, the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days before the proposed effective date
49705
L
U X E M B O U R G
of the resolutions. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority as provided for by law for
collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements, on the date set out therein). Unanimous
written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the articles of association are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.
At no time shall the Company have more than thirty (30) shareholders. At no time shall an individual be allowed to
become a shareholder of the Company.
Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December of the
same year save for the first accounting year which shall commence on the day of incorporation and end on 31
st
December
2015.
Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or, as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August 1915 on commercial com-
panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, the appearing party has
subscribed and entirely paid-up the following shares:
Subscriber
Number
of shares
Subscription
price (EUR)
Logicor Europe Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12,500
Evidence of the payment of the total subscription price has been shown to the undersigned notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,600.-.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The sole shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at: 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
2. The following person is appointed manager of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company with such signature powers as set forth in the articles of association of the Company:
49706
L
U X E M B O U R G
- BRE/Management 7 S.A., a société anonyme incorporated under the laws of Luxembourg, with registered office at
35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and being registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxembourg under number B 180.304.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
The document having been read to the appearing party, who requested that the deed should be documented in English,
the said appearing party signed the present original deed together with the notary, having personal knowledge of the
English language. The present deed, worded in English, is followed by a translation into German. In case of divergences
between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by its name, first
name, civil status and residence, said person signed together with the notary the present deed.
Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiten Tag des Monats März,
Vor dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen,
Logicor Europe Holdings II S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) lu-
xemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg, deren Gesellschaftskapital zwölftausend-
fünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt, und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter
der Nummer B 181.528,
hier vertreten durch Herrn Vianney de Bagneaux, avocat, beruflich wohnhaft in Luxemburg, aufgrund einer privat-
schriftlichen Vollmacht welche vorliegender Urkunde beigefügt ist um mit dieser bei der Registrierungsbehörde einge-
reicht zu werden.
Die erschienene Partei hat in ihrer vorgenannten Eigenschaft den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründungs-
satzung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) "Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l."
wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Gesellschaftsname. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
"Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l." (die "Gesellschaft") wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die
gegebenenfalls zukünftig als Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und
durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung geregelt.
Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen in jeder beliebigen Form an in-
und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form von Investitionen, sowie den Erwerb durch Kauf, Zeichnung
oder andere Art und Weise wie Übertragung durch Verkauf oder Tausch von Finanzinstrumenten jeder Art und die
Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung ihres Portfolios.
Die Gesellschaft kann ebenfalls alle Transaktionen welche sich auf direkten oder indirekten Erwerb von Grundbesitz,
Eigentum, und Grundbesitzrechte in Luxemburg oder im Ausland oder auf den Erwerb von Beteiligungen an Unternehmen
welche im Besitz von Grundrechten sind oder von Unternehmensbeteiligungen jedweder Form beziehen, durchführen
sowie die Verwaltung, Aufsicht und Entwicklung dieser Beteiligungen und dieses Vermögen ausführen.
Die Gesellschaft kann Bürgschaften geben, Sicherheiten leisten, Darlehen ausgeben oder die Gesellschaften an denen
die Gesellschaft direkte oder indirekte Beteiligungen besitzt oder die zur Gruppe von Gesellschaften gehört, der die
Gesellschaft angehört, in jeder anderen Form unterstützen.
Die Gesellschaft kann außerdem in jeder beliebigen Form Darlehen erwerben, auch mit Preisnachlass, Darlehen ver-
geben, Kapital verleihen, sowie Vorschüsse gewährleisten oder unter jeglichen Konditionen Kredite vergeben, einschließ-
lich und ohne Einschränkungen derer Kredite, in Bezug auf ein Immobilien-Unternehmen oder -Unterfangen, die sich von
jeglichen Kreditaufnahmen der Gesellschaft oder von der Ausgabe von Kapital oder Schuldtitel jeglicher Art an alle Per-
sonen und Unternehmen, für die es für richtig empfunden wurde, ergeben. Die Gesellschaft kann Swaps, Futures,
Forwards, derivative Instrumente, Optionen, Rückkäufe, Wertpapierverleihe und ähnliche Transaktionen abschließen und
unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden, jegliche Methode und Instrumente im Zusammenhang mit ihren
Immobiliengeschäften einsetzen. Die Gesellschaft kann auch jegliche Verträge über Garantien, Entschädigungen, Sicher-
heiten und alle weiteren äquivalente Verträge abschließen, so dass der Nutzen der, im Rahmen solcher Immobilienge-
schäfte vergebenen, Garantien und/oder Sicherheiten ihr zu Gute kommen kann. Die Gesellschaft kann im Rahmen solcher
Immobiliengeschäfte jegliche erforderliche Rolle übernehmen, einschließlich und ohne Einschränkungen der Rolle des
Arranger, lead Manager, Facility Agent, Security Agent, Documentation Agent. Die Gesellschaft wird die Tätigkeit der
Immobilienfinanzierung oder des Immobilienkrediterwerbs nicht in einer Weise ausüben, die eine Regulierung erfordern
würde gemäß der geänderten Fassung des Gesetzes des 5. Aprils 1993 bezüglich des Finanzsektors oder jeglichen zu-
künftigen Gesetzes oder Regulierungsmaßnahme, die dieses Gesetz abändern oder ersetzen sollte.
Die Gesellschaft kann alle geschäftlichen, technischen, finanziellen ebenso wie alle andere direkt oder indirekt ver-
bundenen Tätigkeiten welche die Erfüllung des Geschäftszwecks in den oben genannten Bereichen erleichtern, vorneh-
men.
49707
L
U X E M B O U R G
Unter anderem wird die Gesellschaft allen Gesellschaften ihres Portfolios die für die Verwaltung, Entwicklung und
Aufsicht dieser Gesellschaften notwendigen Leistungen zur Verfügung stellen. Für diesen Zweck kann die Gesellschaft die
Unterstützung anderer Berater beanspruchen und auf solche zurückgreifen.
Art. 3. Geschäftsdauer. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Dauer gegründet
Art. 4. Gesellschaftssitz. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg. Dieser kann,
durch Beschluss einer außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich, in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, an jeden Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Der eingetragene Sitz der Gesellschaft kann durch Beschluss des Geschäftsführers, beziehungsweise durch die Ge-
schäftsführung innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten.
Sollte der Geschäftsführer, oder im Falle einer Geschäftsführung die Geschäftsführung, feststellen, dass außerordent-
liche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eingetreten sind oder unmittelbar bevorstehen welche die
normalen Tätigkeiten der Gesellschaft an ihrem eingetragenen Sitz oder die problemlose Kommunikation zwischen die-
sem Sitz und Personen im Ausland beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zum
vollständigen Ende solcher ungewöhnlichen Umstände ins Ausland verlegt werden; derartige vorläufige Maßnahmen haben
keine Auswirkung auf die staatliche Zugehörigkeit der Gesellschaft, die unbeschadet einer solchen vorübergehenden
Sitzverlegung eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Solche vorübergehenden Maßnahmen werden vom Geschäftsführer
oder, im Falle einer Geschäftsführung, von der Geschäftsführung vorgenommen und jeglichen betroffenen Personen mit-
geteilt.
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500), eingeteilt in fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je fünfund-
zwanzig Euro (EUR 25).
Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden und die Gesellschaft kann seine anderen Gesell-
schaftsanteile durch Beschluss der Gesellschafter zurückkaufen.
Verfügbare Anteilsprämien können verteilt werden.
Art. 6. Übertragung der Anteile. Die Anteile sind unter den Gesellschaftern frei übertragbar. Soweit es das Gesetz
nicht anders bestimmt, bedarf die Übertragung von Anteilen auf Dritte der Einwilligung von Gesellschaftern, welche
zusammen mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals halten.
Art. 7. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch einen oder mehrere Geschäftsführer
die keine Gesellschafter sein müssen.
Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung ist mit den weitestreichenden Befugnissen aus-
gestattet, das Geschäft der Gesellschaft zu verwalten und ist dazu befugt, jede Handlungen und Tätigkeiten, die mit dem
Gegenstand der Gesellschaft im Einklang stehen, zu genehmigen und/oder auszuführen. Sämtliche Befugnisse, die nicht
ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern vorbehalten sind, fallen in den Zustän-
digkeitsbereich des Geschäftsführers beziehungsweise der Geschäftsführung.
Gegenüber Dritten hat der Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung die weitestreichenden Befugnisse
um in allen Umständen, im Namen und Auftrag der Gesellschaft zu handeln und in jeden Umständen, jeden Akt und jede
Handlung, welche nicht durch die vorliegende Satzung oder durch die entsprechende luxemburgische Gesetzgebung im
Kompetenzbereich der Gesellschafterversammlung liegt, im Auftrag der Gesellschaft vorzunehmen, zu erlauben und gut-
zuheißen.
Die Geschäftsführer werden durch mehrheitlichen Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter gewählt und
abberufen, welche ihre Befugnisse und die Amtsdauer beschließt. Wenn keine Frist gesetzt wird, dann sind die Geschäfts-
führer auf unbestimmte Zeit ernannt. Die Geschäftsführer können wiedergewählt werden, jedoch kann ihre Ernennung
zu jeder Zeit mit oder ohne Grund (ad nutum) widerrufen werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bilden diese die Geschäftsführung. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Sitzung der
Geschäftsführung teilnehmen mittels Telefonkonferenz oder anderen zur Verfügung stehenden Kommunikationsmitteln
insofern gewährleistet ist, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich hören und miteinander kommunizieren
können. Eine Sitzung kann jederzeit mittels einer Telefonkonferenz oder ähnlichen Kommunikationsmitteln abgehalten
werden. Die Teilnahme oder das Abhalten einer Sitzung mit Hilfe dieser Mittel entspricht einer persönlichen Teilnahme
an der betroffenen Sitzung. Die Geschäftsführer können sich in den Sitzungen ohne Einschränkung der Anzahl der Voll-
machten durch einen anderen Geschäftsführer, der hierzu bevollmächtigt ist, vertreten lassen.
Die Geschäftsführer sind mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn einer Sitzung der Geschäftsführung
mittels schriftlicher Einberufung, zu benachrichtigen, außer in Notfällen, in welchem Fall die Art und die Gründe dieser
Umstände in der Einberufung erläutert werden müssen. Auf das Recht auf die oben beschriebene Weise einberufen zu
werden kann jeder Geschäftsführer durch schriftliche Zustimmung per Telegramm, Telekopie, Email, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel verzichten. Spezifische Einberufungen sind nicht notwendig für Sitzungen, welche vorher
49708
L
U X E M B O U R G
zu einem durch Geschäftsführungsbeschluss genehmigten Zeitplan und zu vorgesehenen Zeiten und an vorbestimmten
Orten abgehalten werden.
Entscheidungen der Geschäftsführung werden durch die Mehrheit der Geschäftsführer der Gesellschaft gefasst.
Die Protokolle aller Geschäftsführerratssitzungen werden vom Vorsitzenden der Sitzung oder, in seiner Abwesenheit,
von zwei Geschäftsführern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle werden vom Vorsitzenden oder von
zwei Geschäftsführern unterzeichnet.
Schriftliche Beschlüsse der Geschäftsführung können, aus einem einzigen oder mehreren einzelnen Dokumenten, gültig
abgeschlossen werden, wenn sie von allen Mitgliedern der Geschäftsführung schriftlich, per Telegramm, Telefax oder per
ähnlichem Kommunikationsmittel genehmigt wurden. Die verschiedenen Dokumente gleichen Inhalts bilden zusammen
einen gültigen schriftlichen Beschluss. Beschlüsse der Geschäftsführung, einschließlich schriftliche Beschlüsse, können von
einem einzelnen Geschäftsführer beweiskräftig beglaubigt und ein Auszug davon beweiskräftig unterschrieben werden.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder durch die Unterschrift eines einzel-
nen Geschäftsführers im Falle einer Geschäftsführung gebunden. Die Gesellschaft ist in jedem Fall wirksam durch die
Unterschrift einer oder mehrerer hierzu durch den alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise durch die Geschäftsfüh-
rung oder einer der Geschäftsführer, bevollmächtigten Personen, gebunden.
Art. 8. Haftung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführer sind für Verschuldung der Gesellschaft nicht persönlich
haftbar. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie jedoch für die Ausführung ihrer Aufgaben und Pflichten verantwortlich.
Vorbehaltlich den unten aufgeführten Ausnahmen und Beschränkungen, wird jede Person, die ein Geschäftsführer oder
leitender Angestellter der Gesellschaft ist oder war, von der Gesellschaft in vollem, gesetzlich erlaubten, Umfang gegen
Verbindlichkeiten und gegen alle Ausgaben, welche üblicherweise entstanden sind oder von ihm gezahlt wurden in Ver-
bindung mit Klagen, Prozessen oder Verfahren in die er als Partei oder anderweitig eintritt aufgrund dessen, dass er ein
Geschäftsführer oder leitender Angestellter ist oder gewesen ist und die diesbezüglich gezahlten Beträge oder von durch
deren Beilegung entstandenen Beträge, schadlos gehalten werden. Die Begriffe „Klage“, „Streitsache“, „Prozess“ oder
„Verfahren“ finden auf alle anhängigen oder bevorstehenden Klagen, Streitsachen, Prozesse oder Verfahren Anwendung
(zivilrechtlich, strafrechtlich oder sonstige, einschließlich Rechtsmittel) Anwendung und die Begriffe „Verbindlichkeit“ und
„Ausgaben“ beinhalten ohne Beschränkung Anwaltskosten, Prozesskosten, Sicherheitsleistungen, gezahlte Beträge bei
Streitbeilegung und andere Verbindlichkeiten.
Einem Geschäftsführer oder leitendem Angestellten wird keine Schadloshaltung gewährt:
(i) gegen Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschaft oder ihrer Gesellschafter, aufgrund von vorsätzlich begangenen
unerlaubten Handlungen, Bösgläubigkeit, grober Fahrlässigkeit oder rücksichtsloser Missachtung der Aufgaben, die in
seiner Amtsführung enthalten sind;
(ii) im Zusammenhang mit jeglichen Verfahren bei welchen er wegen bösgläubigem und nicht im Interesse der Gesell-
schaft erfolgtem Handeln, verurteilt wurde; oder
(iii) im Falle einer Beilegung, es sei denn die Beilegung ist von einem Gericht unter zuständiger Gerichtsbarkeit oder
von der Geschäftsführung genehmigt worden.
Das Recht der Schadloshaltung, das hier vorgesehen ist, ist abtrennbar und berührt keine anderen Rechte auf die das
Verwaltungsratsmitglied oder der leitende Angestellte jetzt oder später ein Anrecht hat, und soll fortgeführt werden in
der Person, die aufgehört hat, ein Geschäftsführer oder leitender Angestellter zu sein und soll dem Vorteil der Erben,
Testamentsvollstreckern und Verwaltern einer solchen Person dienen. Nichts hierin Enthaltenes berührt die Rechte zur
Schadloshaltung, auf die Gesellschaftspersonal, eingeschlossen Geschäftsführer und leitende Angestellte, aufgrund von
Vertrag oder anderweitig durch Gesetz, Anspruch haben könnten.
Ausgaben in Verbindung mit Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung einer Klage, Streitsache, Prozess oder
Verfahren beschrieben in diesem Artikel, soll von der Gesellschaft vor der endgültigen Verfügung darüber bei Zugang
jeglicher Unternehmung seitens oder im Namen eines leitenden Angestellten oder Geschäftsführers vorgestreckt werden,
um den benannten Betrag zurückzuzahlen wenn es letztlich bestimmt ist, dass er keinen Anspruch auf Schadloshaltung
unter diesem Artikel hat.
Art. 9. Stimmrechte der Gesellschafter. Jeder Gesellschafter kann an kollektiven Entscheidungen teilnehmen. Die Zahl
seiner Stimmen entspricht der Zahl seiner Gesellschaftsanteile und der Gesellschafter kann bei jeder Versammlung durch
eine spezielle Vollmacht vertreten werden.
Art. 10. Gesellschafterversammlungen. Die Beschlüsse der Gesellschafter werden in der im luxemburgischen Gesell-
schaftsrecht vorgeschriebenen Form und mit der darin vorgesehenen Mehrheit, schriftlich (soweit dies gesetzlich möglich
ist) oder in Gesellschafterversammlungen, gefasst. Jede ordnungsgemäß konstituierte Gesellschafterversammlung der
Gesellschaft beziehungsweise jeder ordnungsgemäß schriftlicher Beschluss vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter der
Gesellschaft.
Die Einberufung der Versammlungen durch den Geschäftsführer/die Geschäftsführung hat mindestens acht (8) Tage
vor der Versammlung mittels eingeschriebenen Briefes an die Gesellschafter an ihre im Anteilsregister der Gesellschaft
eingetragene Adresse, zu erfolgen. Wenn das gesamte Gesellschaftskapital der Gesellschaft vertreten ist, kann die Sitzung
ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.
49709
L
U X E M B O U R G
Werden Beschlüsse im Wege eines Zirkularbeschlusses der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt des Beschlusses
mindestens acht (8) Tage bevor der Beschluss wirksam werden soll, an alle Gesellschafter an ihre im Anteilsregister
eingeschriebene Adresse mittels eingeschriebenen Briefs übersandt. Die Beschlüsse werden wirksam bei Zustimmung
der vom Gesetz vorgesehenen Mehrheiten für gemeinsame Entscheidungen (oder, unter der Voraussetzung der Befrie-
digung der Mehrheitsvoraussetzungen, am in dieser Entscheidung festgelegten Tag). Einstimmige Zirkularbeschlüsse
können jederzeit ohne vorherige Ankündigung getroffen werden.
Soweit gesetzlich nichts anderes vorgesehen ist, (i) werden die in den Gesellschafterversammlungen zu fassenden
Beschlüsse von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Geschäftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Gesellschafterversammlung nicht erreicht, werden die Gesellschafter per Einschreiben zu
einer zweiten Gesellschafterversammlung geladen und die Beschlüsse werden sodann aufgrund der Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Anzahl der vertretenen Geschäftsanteile. (ii) Die Satzung kann jedoch nur mit
Zustimmung (x) der Mehrheit der Gesellschafter, welche (y) zwei Drittel des Gesellschaftskapitals vertreten, abgeändert
werden und (iii) Entscheidungen, die Nationalität der Gesellschaft zu ändern, bedürfen der Zustimmung von Gesellschaf-
tern, die einhundert Prozent (100%) des Gesellschaftskapitals vertreten.
Zu keiner Zeit soll die Gesellschaft mehr als dreißig (30) Gesellschafter haben. Zu keiner Zeit soll es einer natürlichen
Person gestattet sein, ein Gesellschafter der Gesellschaft zu werden.
Art. 11. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten (1.) Januar und endet am einunddreißigsten (31.) Dezember
eines jeden Jahres. Das erste Geschäftsjahr, welches am Tage der Gründung der Gesellschaft beginnt, wird am 31. De-
zember 2015 enden.
Art. 12. Jahresabschluss. Der alleinige Geschäftsführer beziehungsweise die Geschäftsführung erstellt jedes Jahr die
Jahresabrechnung der Gesellschaft.
Jeder Gesellschafter kann die Jahresabrechnung am Sitz der Gesellschaft einsehen.
Art. 13. Gewinnverwendung. Fünf Prozent (5%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft werden der gesetzlich
vorgeschriebenen Rücklage zugeführt. Diese Rücklageeinzahlungspflicht besteht nicht mehr, sobald die gesetzliche Rück-
lage zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
Die Gesellschafter können auf der Grundlage eines von dem alleinigen Geschäftsführer, beziehungsweise der Ge-
schäftsführung angefertigten Zwischenabschlusses die Ausschüttung von Abschlagsdividenden beschließen, sofern dieser
Zwischenabschluss zeigt, dass ausreichend Gewinne und andere Reserven zur Ausschüttung zur Verfügung stehen, wobei
der auszuschüttende Betrag die seit dem Ende des vorhergehenden Geschäftsjahres erzielten Gewinne, für welches die
Jahresabschlüsse bereits bewilligt wurden, erhöht um die vorgetragenen Gewinne und ausschüttbaren Rücklagen, ver-
mindert um die vorgetragenen Verluste und die der gesetzlichen Rücklage zuzuführenden Beträge, nicht übersteigen darf.
Der Saldo kann nach Entscheidung der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
Das Anteilsprämienkonto kann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung an die Gesellschafter ausgeschüttet
werden. Die Gesellschafterversammlung kann beschließen, jeden Betrag vom Anteilsprämienkonto auf die gesetzliche
Rücklage zu übertragen.
Art. 14. Auflösung. Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ernennen die Gesellschafter einen oder mehrere Liqui-
datoren, bei welchen es sich nicht um Gesellschafter handeln muss, zwecks der Durchführung der Auflösung und
bestimmen ihre Befugnisse und Vergütung.
Art. 15. Alleingesellschafter. Sofern nur ein Gesellschafter alle Geschäftsanteile der Gesellschaft hält, gilt Artikel 179
(2) des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und die Artikel 200-1 und 200-2 finden u.a. Anwendung.
Art. 16. Anwendbares Recht. Sämtliche nicht ausdrücklich durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten richten
sich nach den entsprechenden Regelungen des anwendbaren Gesetzes.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Nach dem die erschienene Partei die Gründungssatzung erstellt hat, hat sie das gesamte Gesellschaftskapital wie folgt
eingezahlt und gezeichnet:
Einzahler
Zahl der
Geschäftsanteile
Einzahlungspreis
(EUR)
Logicor Europe Holdings II S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Summe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500
EUR 12.500
Ein Beleg für die vollständige Einzahlung der Geschäftsanteile wurde dem unterzeichneten Notar vorgelegt.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund der vorlie-
genden Gesellschaftsgründung entstehen, werden auf ungefähr EUR 1.600,- geschätzt.
49710
L
U X E M B O U R G
<i>Außerordentliche Beschlüsse des Gesellschaftersi>
Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft hat der Alleinige Gesellschafter folgende Beschlüsse gefasst:
1. Sitz der Gesellschaft ist in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für einen unbeschränkten Zeitraum zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit der in der
Satzung der Gesellschaft beschriebenen Unterschriftsbefugnis ernannt:
- BRE/Management 7 S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 35, avenue
Monterey, L-2163 Luxemburg und eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés in Luxemburg unter der Num-
mer B 180.304.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei, die vorliegende Urkunde in English abgefasst wird, gefolgt von einer deutschen Übersetzung.
Auf Ersuchen derselben erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deut-
schen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die erschienene Partei die dem amtierenden Notar nach
Namen, Vornamen, Zivilstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde
unterschrieben.
Gezeichnet: V. DE BAGNEAUX, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 03 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/6478. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 09. März 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015038563/452.
(150044082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Harvester Cleanco S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 195.144.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of the month of January.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Harvester Topco S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 4 rue Albert Borschette L-1246
Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg and a share capital of EUR 12,500, in the process of being registered with
the Luxembourg Trade and Companies Registry,
represented by Maître Alexandre Pel, Maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 23 January
2015 which shall be registered together with the present deed.
The appearing party, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to draw up the articles
of association of a limited liability company (“société à responsabilité limitée”) “Harvester Cleanco S.à r.l”, which is hereby
established as follows:
Art. 1. Denomination. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "Harvester Cleanco
S.à r.l.” (the "Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter.
The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.
Art. 2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg
and foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as
well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind,
and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds and debentures.
In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to
companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies
49711
L
U X E M B O U R G
to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and
carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.
Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or
indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.
Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.
The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the
case may be the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary
political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500)
divided into twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one Euro (EUR 1.00) each.
The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner
required for amendment of these articles of association.
Any available share premium shall be distributable.
Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the
share transfer to non-shareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent
of the Company's capital.
Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-
holders.
They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,
which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.
In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers. Any manager may participate in
any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means of communication allowing all the
persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another. A meeting may also be
held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation
in person at such meeting or the holding of a meeting in person. Managers may be represented at meetings of the board
by another manager without limitation as to the number of proxies which a manager may accept and vote.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by cable, telegram, telex, email or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.
Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company
(including by way of representation). The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several
similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by cable or facsimile or any other similar
means of communication. The entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution.
Managers' resolutions, including circular resolutions, may be conclusively signed, certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.
Art. 8. Management Powers, Binding signature. The sole manager or as the case may be the board of managers is
vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of
disposal and administration falling within the purposes of the Company. All powers not expressly reserved by the law or
by the articles of incorporation to the general meeting shall be within the competence of the sole manager or as the case
may be the board of managers. Vis-à-vis third parties the sole manager or as the case may be the board of managers has
the most extensive powers to act on behalf of the Company in all circumstances and to do, authorise and approve all
49712
L
U X E M B O U R G
acts and operations relative to the Company not reserved by law or the articles of association to the general meeting or
as may be provided herein.
The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers
by the signature of any two managers. In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person
or persons to whom such signatory powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only a sole manager),
or the board of managers or by any two managers (including by way of representation).
Art. 9. Liability Managers. The manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As
agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.
Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the
Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgements, amounts paid in settlement and other
liabilities.
No indemnification shall be provided to any manager or officer: (i) Against any liability to the Company or its Share-
holders by reason of wilful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the
conduct of his office; (ii) With respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in
bad faith and not in the interest of the Company; or (iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been
approved by a court of competent jurisdiction or by the board of managers.
The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager
or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including managers and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.
Expenses in connection with the preparation and representation of a defence of any claim, action, suit or proceeding
of the character described in this article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or manager, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this article
Art. 10. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes
equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.
Art. 11. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-
scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.
Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing
in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.
In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses
inscribed in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval
of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements,
on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.
Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by
shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing 100% of the issued share capital.
In case and for as long as the Company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on first
Tuesday of the month of June at 11:00 of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the
immediately following business day.
Art. 12. Accounting Year. The accounting year begins on first day of the month of January of each year and ends on
the last day of the month of December of the same year.
Art. 13. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the
manager or as the case may be, the board of managers.
The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.
49713
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction
ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,
or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve to be established by law.
The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.
Art. 15. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators
who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.
Art. 16. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall
exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10
th
August, 1915 on commercial
companies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.
Art. 17. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the
relevant legislation.
The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing party, said appearing party has
subscribed and entirely paid-up the twelve thousand five hundred (12.500) shares.
The shares so subscribed are fully paid up in cash so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR
12,500) is available to the Company. Evidence of the payment of the subscription price has been shown to the undersigned
notary.
<i>Expenses, Valuationi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its formation are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Extraordinary general meetingi>
The shareholder has forthwith taken immediately the following resolutions:
1. The registered office of the Company is fixed at 4, rue Albert Borschette, L- 1246 Luxembourg.
2. The following persons are appointed managers of the Company for an undetermined period of time subject to the
articles of association of the Company:
Name
professional or private
Address
Title
Date of birth
City and country
of birth
Danielle (dit Danièle)
Arendt-Michels
Op Fanckenacker,
L-3265 Bettembourg
Manager
9
th
January 1961 Ettelbruck (Luxembourg)
Xavier Geismar
Square Edouard VII,
75009 Paris, France
Manager
24
th
January 1975 Nancy (France)
Gautier Laurent
4, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg
Manager
19
th
May 1983
Mont-Saint Martin (France)
Ben Osnabrug
Warwick Court
Paternoster Square
London EC4M 7AG
United Kingdom
Principal
2
nd
August 1979 Weert (The Netherlands)
<i>Special dispositioni>
The first accounting year shall begin on the date of incorporation and shall terminate on 31
st
December 2015.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The present deed, worded in English, is followed by a translation into French. In case of divergences between the
English and the French text, the English version will prevail.
The document having been read to the person appearing, who requested that the deed should be documented in the
English language, the said person appearing signed the present original deed together, the Notary, having personal know-
ledge of the English language.
49714
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire, résidant à Luxembourg, Grand- Duché du Luxembourg.
A comparu:
Harvester Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et un capital social de 12.500 Euros, en voie d’être enregistrée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg,
représentée par Maître Alexandre Pel, Maître en droit, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration en date
du 23 janvier 2015, laquelle sera enregistrée avec le présent acte.
La partie comparante, agissant en sa qualité telle que décrite ci-dessus, a demandé au notaire soussigné mettre en place
les statuts d'une société à responsabilité limitée «Harvester Cleanco S.à r.l.» qui est constituée comme suit:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par la partie comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite
associés, une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Harvester Cleanco S.à r.l.» (la «Société»). La
Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.
Art. 2. Objet. L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés
luxembourgeoises et étrangères, ou dans toute autre entreprise, l'acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre
moyen, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance,
notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de
son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité
par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations et de
certificats de créance.
D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des
sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel
appartient la Société (y compris upstream ou cross stream), prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et
effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets.
Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique et financière ou autre, liée directement
ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand- Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire de ses associés délibérant dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être transférée à l'intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant,
du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre
politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée
de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d’avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré
provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; de telles mesures temporaires
n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert temporaire de son siège social, demeurera
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.
Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) divisé
en douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,00) chacune.
Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptés de la manière requise
pour la modification des présents statuts.
Toute prime d'émission disponible est distribuable.
Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions
contraires de la loi, le transfert de parts sociales à des non associés est soumis à l'agrément donné par les associés
représentant au moins soixante-quinze pourcent du capital de la Société.
Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité simple, qui détermine leurs
pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Si aucune durée n'est indiquée, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans cause (ad nutum)
à tout moment.
49715
L
U X E M B O U R G
Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance. Tout gérant peut participer à une
réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de communication similaires permettant
à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres et de communiquer les uns avec les
autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de conférence téléphonique. La participation à
ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion ou à une réunion
tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil de gérance par un autre gérant, sans
limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures
avant la date prévue pour la réunion, sauf s’il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, email ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l'accord de la majorité de gérants de la Société (y
compris par voie de représentation). Le conseil de gérance peut également, à l'unanimité, prendre des résolutions sur un
ou plusieurs documents similaires par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par câble ou télécopie ou
tout autre moyen de communication similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant
foi de la résolution. Les résolutions des gérants, y compris celles prises par voie circulaire, peuvent être signées ou
certifiées comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de tout gérant.
Art. 8. Pouvoirs des gérants, Signatures engageantes. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance est
investi des pouvoirs les plus étendus pour conduire les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les
actes de disposition et d’administration qui entrent dans les objets de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas réservés
expressément par la loi ou par les statuts à l’assemblée générale sont de la compétence du gérant unique ou, le cas
échéant, du conseil de gérance. Vis-à-vis des tierces parties, le gérant unique, ou le cas échéant, le conseil de gérance a
les pouvoirs les plus étendus pour agir pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour faire, autoriser et
approuver tous actes et toutes opérations relatifs à la Société qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l’assemblée
générale ou conformément aux dispositions des présents statuts.
La Société sera engagée par la signature individuelle du gérant unique s’il y a un gérant unique et en cas de conseil de
gérance par la signature de deux gérants. Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature individuelle
de toute personne ou de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique
(s’il y a un gérant unique) ou par le conseil de gérance ou par deux gérants (y compris par voie de représentation).
Art. 9. Responsabilité des gérants. Le(s) gérant(s) ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société.
En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.
Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant
ou fondé de pouvoir de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société pour
toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou fondé de pouvoir et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement. Les
mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s’appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou procé-
dures (civiles ou pénales, y compris le cas échéant toute procédure d’appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d’avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement d’une transaction et autres responsabilités.
Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant ou dirigeant: (i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis
de la Société ou de ses Associés en raison d'un abus de pouvoir, de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence
dans l'accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa fonction; (ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait
finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt de la Société; ou (iii) Dans le cas d’un compromis
ou d’une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n’ait été approuvé par une juridiction
compétente ou par le conseil de gérance.
Le droit à indemnisation prévu par les présentes est séparable, n’affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant
ou fondé de pouvoir peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l'égard de toute personne ayant cessé
d’être gérant, dirigeant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de
cette personne. Les dispositions du présent article n'affecteront aucun droit à indemnisation dont pourrait bénéficier le
personnel de la Société, y compris les gérants et dirigeants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.
Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d’une défense à l’encontre de toute demande, action,
plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l'engagement par ou pour le compte du fondé de
pouvoir ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation
conformément au présent article.
49716
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix
égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter à toute assemblée des associés
par un mandataire spécial.
Art. 11. Assemblées Générales. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par la
loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c’est permis par la loi) ou lors d'assem-
blées. Toute assemblée des associés de la Société régulièrement constituée ou toute résolution circulaire valable (le cas
échéant) représente l’entièreté des associés de la Société.
Les assemblées sont convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à l’adresse
contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l’assemblée. Si l’entièreté
du capital social de la Société est représentée à une assemblée, l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.
Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions doit être envoyé aux associés à leur adresse inscrite
dans le registre des associés tenu par la Société ou. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité
tel que prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction de la majorité, à la date y précisée).
Des résolutions peuvent être passées à l’unanimité à tout moment sans convocation préalable.
A moins que la loi n’en dispose autrement, (i) les décisions de l'assemblée générale seront valablement adoptées si
elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représentée. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société doivent être prises par les Associés représentant 100% du capital social émis.
A partir du moment et aussi longtemps que la Société compte plus de 25 associés l’assemblée générale annuelle sera
tenue le premier mardi du mois de juin de chaque année à 11:00 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvrable, l’assemblée
sera tenue le jour ouvrable suivant.
Art. 12. Année Sociale. L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine
le dernier jour du mois de décembre de la même année.
Art. 13. Comptes annuels. Chaque année le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social de la Société pour tout associé.
Art. 14. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.
Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la
Société.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par le gérant
ou le cas échéant par le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution,
étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et
des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.
Le solde peut être distribué aux associés par décision de l’assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par une décision de l’assemblée générale des associés.
L’assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant du compte prime d'émission à la réserve légale.
Art. 15. Dissolution. Au cas où la Société est dissoute, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 16. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre
ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont applicables.
Art. 17. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions
légales en vigueur.
Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante, celle-ci a souscrit et intégralement libéré douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales.
Les parts sociales ainsi souscrites sont entièrement libérées par paiement en espèce de sorte que la somme de douze
mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société. Preuve du paiement du prix de souscription au taux
de change susmentionné a été montrée au notaire soussigné.
<i>Dépenses, Evaluationi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa
constitution sont évaluées à environ EUR 1.500.-
49717
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, l’associé a immédiatement pris les résolutions suivantes:
1. Le siège social de la Société est fixé au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées gérants de la Société pour une durée indéterminée sous réserve des statuts
de la Société:
Nom
Adresse professionnelle
ou privée
Profession Date
de naissance
Pays et lieu
de naissance
Danielle (dit Danièle)
Arendt-Michels
42 Op Fanckenacker,
L-3265 Bettembourg
Gérant
9 janvier 1961
Ettelbruck (Luxembourg)
Xavier Geismar
4, Square Edouard VII,
75009 Paris, France
Gérant
24 janvier 1975 Nancy (France)
Gautier Laurent
4, rue Albert Borschette,
L-1246 Luxembourg
Gérant
19 mai 1983
Mont-Saint Martin (France)
Ben Osnabrug
Warwick Court
Paternoster Square
London EC4M 7AG
United Kingdom
Principal
2 août 1979
Weert (The Netherlands)
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Le présent acte, rédigé en anglais, est suivi d'une traduction française. En cas de divergences entre la version anglaise
et la version française, la version anglaise fera foi.
Le document ayant été lu à la personne comparante, qui a requis que le présent acte soit rédigé en langue anglaise,
ladite personne comparante a signé le présent acte avec le Notaire, ayant une connaissance personnelle de la langue
anglaise.
Signé: A. PEL et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 février 2015. Relation: 1LAC/2015/3109. Reçu soixante-quinze euros
(75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015038612/396.
(150043689) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
MWV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 413.246,30.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 159.099.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of February.
Before the undersigned, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
MWV International Holdings S.à r.l., a private limited liability company existing under the laws of Luxembourg, having
its registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, in process of registration with
the Luxembourg Trade and Companies Register,
represented by Mr Cyrille TERES, professionally residing at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand Duchy of
Luxembourg,
by virtue of a power of attorney given under private seal on January 26, 2015,
And
Meadwestvaco Corporation, a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, United
States of America, having its registered office at 501, South 5
th
Street, USA - VA 23219-0501 Richmond, United States
of America, registered with the Secretary of State of Delaware under number 3429632,
represented by Mr Cyrille TERES, aforementioned,
by virtue of a power of attorney given under private seal on February 4, 2015,
49718
L
U X E M B O U R G
Said proxies, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing persons and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration,
Such appearing persons, through their proxy holder, have requested the notary to enact that:
I. The appearing persons are the partners (the “Partners”) of MWV Luxembourg S.à r.l, a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée) with registered office at 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 159.099 (the
“Company”). The Company was migrated to Luxembourg on February 1, 2011 pursuant to a notarial deed, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°729 of April 15, 2011. The Company's articles of association (the
”Articles”) have been amended for the last time on December 31, 2014 pursuant to a notarial deed, in course of publication
with the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
II. The Company has a share capital of four hundred thirteen thousand two hundred forty-six Euro and thirty cents
(EUR 413,246.30), represented by four million one hundred thirty-two thousand four hundred sixty-three (4,132,463)
shares, with a par value of ten Euro cents (EUR 0.10) each.
III. By virtue of article 199 of the Companies Act of 1915, any amendments of the articles of association, other than
the change of nationality, are resolved upon by a majority of members representing three-quarters of the corporate
capital.
It appears that of the four million one hundred thirty-two thousand four hundred sixty-three (4,132,463) shares
representing the entire share capital of the Company, four million one hundred thirty-two thousand four hundred sixty-
three (4,132,463) shares are duly present or represented at the present extraordinary general meeting, which is deemed
duly constituted and can validly deliberate on the items of the agenda.
IV. The agenda of the meeting is as follows:
1. Amendment of the corporate object of the Company by adding paragraph 3.5. and paragraph 3.6. to article 3 of the
Company’s Articles which shall read as follows:
“ 3.5. The Company may render all kind of shared services on behalf of other group companies, in particular directing,
accounting, controlling or human resources services.
3.6. The Company is entitled to distribute all products of the MeadWestvaco Group of companies including but not
limited to packaging and printing products, pumps, dispenser, trigger and lithographic artwork services. In this regard, the
Company may enter into business relationships with external service providers.”
2. Miscellaneous.
The appearing persons, through their proxy holder, have requested the undersigned notary to document the following
resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Partners decide to extend the corporate object of the Company and for this purpose they resolve to add paragraph
3.5. and paragraph 3.6. to article 3 of the Articles of the Company which shall read as follows:
“ Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any legal means and instruments to manage its investments efficiently and protect itself
against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
3.5. The Company may render all kind of shared services on behalf of other group companies, in particular directing,
accounting, controlling or human resources services.
49719
L
U X E M B O U R G
3.6. The Company is entitled to distribute all products of the MeadWestvaco Group of companies including but not
limited to packaging and printing products, pumps, dispenser, trigger and lithographic artwork services. In this regard, the
Company may enter into business relationships with external service providers.”
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French translation. At the request of the same appearing parties, in
case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Strassen, on the year and day first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing parties, he signed together with the notary the
present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).
Ont comparu,
MWV International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, existant selon les lois du Luxembourg, ayant
son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg, en cours d’enregistrement auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg,
ici représentée par Monsieur Cyrille TERES, demeurant professionnellement au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen,
Grand-Duché du Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 26 janvier 2015,
et,
Meadwestvaco Corporation, une société constituée et organisée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats Unis
d'Amérique, ayant son siège social au 501, South 5 th Street, USA - VA 23219-0501 Richmond, Etats Unis d'Amérique,
enregistrée auprès du Secrétaire d'Etat de l'Etat du Delaware, sous le numéro 3429632,
ici représentée par Monsieur Cyrille TERES, prénommé,
en vertu d'une procuration donnée le 4 février 2015,
Lesquelles procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentant, resteront annexées aux présentes pour être enregistrées en même temps.
Lesquelles comparantes représentées par leur mandataire, ont requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Les comparantes sont les associées (les «Associées") de MWV Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité
limitée établie à Luxembourg, ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, Grand-Duché du Luxembourg,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.099 (la «Société»). La société
a transféré son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, aux termes d'un acte notarié en date du 1
er
février 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 729 en date du 15 avril 2011. Les statuts ont été modifiés
en dernier lieu suivant acte notarié en date du 31 décembre 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
II. Le capital social de la Société est de quatre cent treize mille deux cent quarante-six euros et trente centimes (EUR
413.246,30) représenté par quatre millions cent trente-deux mille quatre cent soixante-trois (4.132.463) parts sociales,
d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (EUR 0.10) chacune, toute souscrites et entièrement libérées.
III. En vertu de l'article 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, toutes modifications des statuts,
autre que le changement de nationalité, sont décidées à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital
social.
Qu'il appert que sur les quatre millions cent trente-deux mille quatre cent soixante-trois (4.132.463) parts sociales
représentant l'intégralité du capital social émis de la Société, quatre millions cent trente-deux mille quatre cent soixante-
trois (4.132.463) parts sociales sont dûment présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire,
qui est donc régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à l'ordre du jour.
IV. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1. Modification de l’objet social de de la Société par ajout d’un paragraphe 3.5 and d’un paragraphe 3.6 à l’article 3 des
statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
« 3.5. La Société peut rendre toutes sortes de services partagés pour le compte d'autres sociétés du groupe, notam-
ment pour la direction, la comptabilité, le contrôle ou les services de ressources humaines.
3.6. La Société est autorisée à distribuer tous les produits du groupe MeadWestvaco, y compris mais non limité à
l'emballage et l'impression des produits, les pompes, distributeur, déclencheur et services d'oeuvres d'art lithographiques.
À cet égard, la Société peut entrer en relations d'affaires avec des prestataires de services externes»
2. Divers.
Les parties comparantes, agissant ès-qualité, ont demandé au notaire de documenter la résolution suivante:
49720
L
U X E M B O U R G
<i>Résolution uniquei>
Les Associées décident d’étendre l’objet social de la Société et dès lors décident d’ajouter un alinéa 3.5 et un alinéa
3.6 à l’article 3 des statuts de la Société qui aura la teneur suivante:
« Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute
autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés
affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut obtenir et détenir des emprunts et des créances. La Société peut
également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur
toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale,
en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune
activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
3.5. La Société peut rendre toutes sortes de services partagés pour le compte d'autres sociétés du groupe, notamment
pour la direction, la comptabilité, le contrôle ou les services de ressources humaines.
3.6. La Société est autorisée à distribuer tous les produits du groupe MeadWestvaco, y compris mais non limité à
l'emballage et l'impression des produits, les pompes, distributeur, déclencheur et services d'oeuvres d'art lithographiques.
À cet égard, la Société peut entrer en relations d'affaires avec des prestataires de services externes.»
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare à la demande des parties comparantes, que
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en
cas de divergences entre les deux versions, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Strassen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture du document faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci signe le présent acte avec le notaire.
Signé: C. TERES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 12 février 2015. Relation: EAC/2015/3633. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
Référence de publication: 2015038750/172.
(150043706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Coves S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 60.476.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue exceptionnellement du 19/01/2015:i>
Les Actionnaires décident de reconduire les mandats des administrateurs A&C MANAGEMENT SERVICES, société à
responsabilité limitée, n° RCSL B-127330, Madame Ingrid Hoolants et Taxioma s.à r.l., n° RCSL B-128542, pour une durée
de 6 ans soit jusqu'au 19/01/2021.
Les Actionnaires décident de reconduire le mandat de Paul Janssens en tant que Commissaire pour une durée de 6
ans soit jusqu'au 19/01/2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015039101/14.
(150044568) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 mars 2015.
49721
L
U X E M B O U R G
HGHQK 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.400,00.
Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.
R.C.S. Luxembourg B 192.556.
In the year two thousand and fifteen, on the third of February,
Before Maître Karine REUTER, Civil Law Notary, residing in Pétange, Grand-Duchy of Luxembourg, the undersigned.
THERE APPEARED
1. Harel Provident Funds and Education Funds Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel,
having its registered office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company
number 51-220520-4;
2. Harel Atidit Provident Funds Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel, having its registered
office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company number
51-286736-7;
3. Harel Pension Fund Management Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel, having its
registered office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company number
51-226759-2;
4. Manof Pension Fund Management Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel, having its
registered office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company number
51-226257-7;
5. Leatid Pension Fund Management Company Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel,
having its registered office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company
number 51-142304-8;
6. Tzava Hakeva Saving Fund - Provident Funds Management Company Ltd, a limited company existing under the laws
of the State of Israel, having its registered office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having
the following company number 51-103306-0,
7. Dikla - Insurance Company Ltd, a limited company existing under the laws of the State of Israel, having its registered
office at Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan and having the following company number
52-003050-3,
(Collectively, the "Harel Entities" and/or the “Appearing Parties”),
duly represented by Mr Yves MERTZ, professionally residing at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg by virtue of a
power of attorney, given privately to him on 26 January 2015.
Said proxy, after having been initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.
The appearing parties are the shareholders of HGHQK 1 S.à r.l, a Société à responsabilité limitée, having its registered
office at 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg incorporated pursuant to a notarial deed enacted by the undersigned
notary on 8 December 2014, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under section
B number 192556 published in the Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 3882 on 15 December
2014; the Articles of Association of which have never been amended.
The Shareholders hereby passed the following written resolutions and declared and requested the Notary to act that:
<i>First resolutioni>
The shareholders decide to amend article 8.2. (v) of the Articles of Association so that as from now on it will read as
follows:
« Art. 8.2. (v). The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented.
Board resolutions shall be validly adopted by the unanimity of the votes of the managers present or represented, provided
that if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, all class A
manager and all class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in minutes signed
by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present or represented.»
<i>Second resolutioni>
The shareholders decide to amend article 8.3. (i) of the Articles of Association so that as from now on it will read as
follows:
« Art. 8.3. (i). The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of all managers,
or, if the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, by the joint
signature of all class A managers and all class B managers.»
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
49722
L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-). With regard to the
undersigned notary, all the appearing and/or signatories hereto recognize jointly and severally being bound to costs,
expenses and charges arising from the present notarial deed.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the representative of the appearing persons, the mandatory signed with us, the
notary, the present original deed. The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on
request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On
request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English
version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mil quinze, le trois février,
Par devant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, soussignée.
ONT COMPARU
1. Harel Provident Funds and Education Funds Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de
l'Etat d'Israël, dont le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée
sous le numéro 51-220520-4;
2. Harel Atidit Provident Funds Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat d'Israël, dont
le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro
51-286736-7;
3. Harel Pension Fund Management Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat d'Israël,
dont le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro
51-226759-2;
4. Manof Pension Fund Management Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat d'Israël,
dont le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro
51-226257-7;
5. Leatid Pension Fund Management Company Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de
l'Etat d'Israël, dont le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée
sous le numéro 51-142304-8;
6. Tzava Hakeva Saving Fund - Provident Funds Management Company Ltd, une société à responsabilité limitée con-
stituée selon les lois de l'Etat d'Israël, dont le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951
Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro 51-103306-0,
7. Dikla - Insurance Company Ltd, une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de l'Etat d'Israël, dont
le siège social est établi à Harel Building, 3 Abba Hillel Street, P.O.B 1951 Ramat-Gan, et immatriculée sous le numéro
52-003050-3,
(Collectivement, les "Entités Harel" et/ou les “Parties Comparantes”),
dûment représentées par Monsieur Yves MERTZ, avec adresse professionnelle au 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxem-
bourg en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 26 janvier 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes sont les associés de la Société à responsabilité limitée HGHQK 1 S.à r.l, ayant son siège social
37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, sous la section
B numéro 192556 constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 8 décembre 2014 publié au Mémorial
C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 3882 du 15 décembre 2014; et dont les statuts n'ont jamais été
modifiés.
Les associés par la présente adoptent les résolutions écrites suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 8.2. (v) des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 8.2. (v). Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les résolutions du Conseil sont valablement adoptées à l'unanimité des voix des gérants présents ou re-
présentés, étant entendu que si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants
de classe B, tous les gérants de classe A et tous les gérants de classe B vote en faveur de la résolution. Les décisions du
Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été
nommé, par tous les gérants présents ou représentés.»
49723
L
U X E M B O U R G
<i>Seconde résolutioni>
Les associés décident de modifier l'article 8.3. (i) des statuts qui se lira désormais comme suit:
« Art. 8.3. (i). La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de tous
les gérants, ou, si les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe B, par
les signatures conjointes de tous les gérants de classe A et de tous les gérants de classe B.»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations et charges, de toute forme, qui seront supportés par la société
en conséquence du présent acte est estimé à environ mille quatre cents euros (1.400.-€). A l'égard du notaire instru-
mentaire, toutes les parties comparantes et/ou signataires des présentes se reconnaissent solidairement et indivisiblement
tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des comparants, le mandataire a signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signés: Y. MERTZ, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 février 2015. Relation: EAC/2015/3445. Reçu soixante-quinze euros 75.-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015038636/134.
(150044133) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Les Mots de Zaza de l'Ecole Européenne Luxembourg I, Association sans but lucratif,
(anc. Les Mots de Zaza).
Siège social: L-1115 Luxembourg, 23, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg F 3.449.
STATUTS
I. Dénomination, Siège, Durée
Art. 1
er
. L’Association est dénommée LES MOTS DE ZAZA DE L’ECOLE EUROPEENNE LUXEMBOURG I. Son
siège est établi à Luxembourg, à l’Ecole Européenne Luxembourg I, 23, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Kirchberg.
Art. 2. L’Association est constituée pour une durée illimitée.
II. Objet
Art. 3. L’Association a pour objet la promotion de la lecture en apportant son assistance aux bibliothèques des cycles
Maternelle, Primaire, et Secondaire, accessibles à tous les enfants qui fréquentent cette Ecole, ci-dessus mentionnée, que
leurs parents, ou ceux qui en tiennent lieu, soient ou non des membres associés. La promotion de la lecture se fera
également par l’organisation d’activités évènementielles, telles que la venue d’écrivains et d’illustrateurs de livres sur le
site de l’Ecole.
III. Membres, Admission, Exclusion, Cotisations
Art. 4. Tous les parents dont les enfants fréquentent l’Ecole, ainsi que les membres du corps enseignant de cette Ecole,
peuvent être membres de l’Association.
Les membres associés sont les membres qui participent activement à la vie de l’Association. Le nombre des membres
associés, dont le minimum est fixé à quatre, est illimité. Ils sont officiellement nommés pour une durée d’un an à partir
de l’Assemblée Générale annuelle à laquelle ils ont été élus. Leur mandat peut être renouvelé indéfiniment chaque année
tant qu’un de leurs enfants, au moins, fréquente l’Ecole. La qualité de membre associé est attestée par l’inscription au
registre tenu à cette fin et publié dans les minutes de chaque Assemblée Générale annuelle.
La qualité de membre d’honneur peut être conférée aux personnes physiques ou morales qui, sans prendre une part
active aux activités de l’Association, lui prêteront leur appui matériel ou moral. Leur nombre est illimité.
Art. 5. Tout membre associé est libre de se retirer en adressant sa démission aux membres du Conseil d’Administration
qui organise la nomination d’un remplaçant lors de l’Assemblée Générale suivante.
49724
L
U X E M B O U R G
L’exclusion d’un associé peut être prononcée par l’Assemblée Générale statuant à la majorité des deux tiers des voix
présentes dans les deux cas suivants:
- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission grave contraire aux statuts et règlements de
l’Association;
- lorsqu’un associé s’est rendu responsable d’un acte ou d’une omission de nature à porter atteinte soit à l’honneur
ou à sa considération personnels, soit à l’honneur ou à la considération d’un associé, soit à la considération de l’Asso-
ciation.
Le Conseil d’administration, après avoir entendu l’intéressé en ses explications, et statuant à la majorité des deux tiers
de ses membres associés, peut, pour l’une des mêmes raisons, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire
de l’affiliation d’un membre associé. Cette suspension prendra fin lors de la plus proche Assemblée Générale Ordinaire
ou Extraordinaire qui sera appelée à statuer sur l’exclusion de ce membre.
En cas de démission ou d’exclusion, les membres concernés n’ont aucun droit sur le fond social et en peuvent prétendre
au remboursement des cotisations versées.
Art. 6. La cotisation annuelle à payer par chaque membre est acquittée au moment de son admission et par la suite
au cours du premier trimestre de chaque année scolaire. Son montant est fixé par l’Assemblée Générale; il ne pourra
dans tous les cas être supérieur à 25 euros.
IV. Administration de l’Association
Art. 7. L’association est administrée par un Conseil d’Administration composé au minimum de trois membres, admi-
nistrateurs, qui remplissent au moins les fonctions de Président, Secrétaire et de Trésorier. Ceux-ci sont nommés par
l’Assemblée Générale ordinaire et annuelle statuant à la majorité simple des voix des membres présents, et peuvent être
choisis en dehors du cercle des membres associés.
A l’exception de celle du Président, élu par vote séparé de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration détermine
les fonctions assumées par chacun de ses membres associés.
Le Conseil d’Administration est élu pour une durée de un an et ses membres associés sont rééligibles. Toutefois, ils
sont révocables à tout moment par décision de l’Assemblée Générale.
En cas de vacance du mandant d’un ou plusieurs administrateurs, les membres du Conseil d’Administration restants,
pour autant que leur nombre ne soient pas inférieur à trois, continuent à former un Conseil d’Administration ayant les
mêmes pouvoirs et attributions que celui nommée par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration peut coopter un ou plusieurs membres supplémentaires s’il estime que la diversité lin-
guistique des membres de l’Association n’est pas suffisamment représentée en son sein ou en cas de besoin.
Art. 8. Le Conseil d’Administration se réunit sur convocation du Président, ou sur celle d’un autre administrateur,
aussi souvent que l’intérêt de l’Association l’exige. Il ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est
présente.
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs présents.
Les administrateurs qui s’abstiennent au vote ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majorité nécessaire
à l’adoption du vote.
Les administrateurs qui ont un intérêt personnel lors d’une délibération doivent s’abstenir de voter.
En cas de partage des voix, celle du Président ou de son remplaçant est prépondérante.
Chaque réunion du Conseil Administratif fait l’objet d’un procès-verbal signé du Secrétaire et contresigné du Président
ou de son remplaçant mentionnant les noms des personnes présentes, l’ordre du jour ainsi que les décisions prises.
Art. 9. Le Conseil d’Administration gère les affaires de l’Association et la représente dans tous les actes judiciaires et
extra-judiciaires. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les statuts à
l’Assemblée Générale.
Art. 10. Le Conseil d’Administration peut déléguer, sous sa responsabilité, ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses
membres.
Art. 11. Vis-à-vis des tiers, l’Association est valablement engagée par les signatures conjointes de deux administrateurs,
parmi lesquelles doivent figurer celle du Président ou de son remplaçant, qui ne doivent pas justifier d’un pouvoir spécial
ou d’une décision du Conseil d’Administration pour disposer des avoirs en Banque, donner quittance des sommes, ac-
complir les formalités devant les administrations et services publics, ministères, offices culturels… Ceux-ci pourront à
leur tour déléguer tout ou partie des pouvoirs qui leur sont attribués ci-dessus.
V. Assemblée Générale
Art. 12. Une Assemblée Générale doit être convoquée chaque année par le Conseil d’Administration, de préférence
au cours du premier trimestre de l’année administrative.
En cas de besoin, le Conseil d’Administration peut convoquer à tout moment une Assemblée Générale Extraordinaire.
49725
L
U X E M B O U R G
L’Assemblée Générale Extraordinaire doit être convoquée par le Conseil d’Administration sur demande d’un cinquiè-
me des membres associés de l’Association.
Toute convocation d’Assemblée Générale doit se faire au moins 10 jours à l’avance et être accompagnée d’un projet
d’ordre du jour.
Il est lisible aux membres associés de se faire représenter à l’Assemblée Générale par un autre associé, muni d’une
procuration écrite.
Art. 13. L’Assemblée Générale possède la plénitude des pouvoirs permettant la réalisation de l’objet de l’Association.
Elle est notamment chargée:
- d’élire et de révoquer le Président et les membres du Conseil d’Administration;
- de modifier les statuts et de se prononcer sur la dissolution de l’Association;
- de décider, sur proposition du Conseil d’Administration, du montant de la cotisation;
- d’approuver les comptes annuels et de voter le budget de l’exercice suivant.
Art. 14. L’Assemblée Générale est présidée par le Président du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration fait fonction de bureau de L’Assemblée Générale.
Art. 15. Toute proposition signée d’un nombre de membres associés égal au cinquième de la dernière liste annuelle
des membres associés doit être portée à l’ordre du jour.
Art. 16. Les membres associés qui, en application des articles 12 et 15, veulent faire convoquer une Assemblée Générale
Extraordinaire ou proposer une question à l’ordre du jour de l’Assemblée, doivent soumettre au Président du Conseil
d’Administration une note écrite précisant leur intention. S’il s’agit d’une question à porter à l’ordre du jour, cette note
doit être entre les mains du Président du Conseil d’Administration huit jours avant la date de l’Assemblée Générale.
Art. 17. Des résolutions en dehors de l’ordre du jour ne peuvent être prises que si une majorité des deux tiers des
voix émises par les membres présents marque son accord pour procéder à un vote sur elles. Aucune résolution en dehors
de l’ordre du jour ne peut être prise sur les points indiqués à l’article 13.
Art. 18. Les résolutions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix des membres présents ou repré-
sentés sauf dans les cas où il en est décidé autrement par les présents statuts ou par la loi. En cas de partage égal des
voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 19. Les procès-verbaux et les résolutions des Assemblées Générales sont portés à la connaissance des membres
associés par courrier électronique et à celle des membres par voie de publication électronique via le site de l’association,
de l’Ecole ou l’une de ses publications.
VI. Comptes, budget
Art. 20. Les ressources de l’Association se composent notamment:
- des cotisations des membres,
- des subsides et subventions qui pourraient lui être versés,
- des intérêts et revenus généralement quelconques.
Cette énumération n’est pas limitative.
Art. 21. L’année administrative de l’Association s’étend du quinze septembre de l’année en cours au quatorze sep-
tembre de l’année suivante.
A la fin de l’année, le Conseil d’Administration arrête les comptes de l’exercice écoulé et dresse le budget du prochain
exercice, aux fins d’approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire, conformément aux prescriptions de l’article 13 de
la loi du 21 avril 1928.
Art. 22. Les comptes sont tenus et réglés par un Trésorier, membre du Conseil d’Administration. Chaque mouvement
devra être justifié par une facture ou une autre pièce comptable à l’appui.
L’excédent favorable appartient à l’Association.
Art. 23. L’Assemblée Générale élit pour un an un Commissaire aux Comptes. Ce Commissaire aux Comptes a les
pouvoirs les plus étendus pour la vérification de la comptabilité et de toutes les pièces comptables, qui feront l’objet d’au
moins un contrôle annuel.
Les fonctions de Commissaire aux Comptes sont incompatibles avec toute autre fonction de l’Association.
VII. Modification des statuts
Art. 24. Tout projet de modification aux présents statuts doit être soumis à une Assemblée Générale. Pour être adopté,
il doit être spécialement indiqué dans la convocation à l’Assemblée Générale et doit recueillir les deux tiers au moins des
voix des membres présents ou représentés.
49726
L
U X E M B O U R G
Si les deux tiers des membres associés ne sont pas présents ou représentés à la première Assemblée Générale, une
seconde réunion sera convoquée qui pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de membres associés présents
ou représentés.
VIII. Dissolution et Liquidation
Art. 25. La dissolution de l’Association ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par la modification
des statuts.
En cas de dissolution, l’Assemblée Générale désignera un ou plusieurs liquidateurs qui, après acquittement du passif,
affecteront le patrimoine de l’Association à l’Ecole Européenne Lux I.
IX. Dispositions générales
Art. 26. Les dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif sont applicables pour tous les
cas non prévus par les présents statuts.
La présente version des statuts, adoptée par l’Assemblée Extraordinaire du 9 février 2015, remplace celle du 25
novembre 1997, publiée au Mémorial C n. 529 du 20 juillet 1998, p. 25376.
Référence de publication: 2015038699/149.
(150043570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
Mango Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 177.432.
L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
La société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois d'Espagne “PUNTO FA, S.L.”, ayant son siège
social à E-08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelone), Calle Mercaders, n° 9-11 (Polígono Industrial Riera de Caldes)
(Espagne), inscrite au Registro Mercantil de Barcelona sous le numéro N.I.F. B-59-088948,
ici représentée par Maître Guillaume DEFLANDRE, avocat à la Cour, avec adresse professionnelle au 252, avenue
Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, (le “Mandataire”), en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée; laquelle
procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le Mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte afin d'être enregistrée avec lui.
Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
- Que la société à responsabilité limitée “MANGO LUXEMBOURG S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-1855
Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 177432, (la “Société”), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 14 mai
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1666 du 11 juillet 2013,
que l'acte de constitution a été amendé suivant une rectification dressée par le notaire instrumentant en date du 26
février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1189 du 10 mai 2014,
et que les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors;
- Que la partie comparante est la seule associée actuelle (l'“Associé Unique”) de la Société et qu'elle a pris, par son
Mandataire, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de sept cent mille cinq cents Euros
(700.500,-EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million cinq cent mille Euros (1.500.000,-EUR) à deux millions
deux cent mille cinq cents Euros (2.200.500,-EUR), par la création et l'émission de quatre cent soixante-sept (467) nou-
velles parts sociales d'une valeur nominale de mille cinq cents Euros (1.500,-EUR) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»),
jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.
<i>Intervention - Souscription - Libérationi>
Est intervenu ensuite Maître GLillaume DEFLANDRE, pré-qualifié, lequel déclare souscrire au nom et pour le compte
de l'Associé Unique aux quatre cent soixante-sept (467) parts sociales nouvelles et de les libérer intégralement moyennant
un versement en numéraire, de sorte que la somme de sept cent mille cinq cents Euros (700.500,-EUR) se trouve dès à
présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate
expressément.
49727
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des Statuts afin
de lui donner la teneur suivante:
“Le capital social est fixé à deux millions deux cent mille cinq cents Euros (2.200.500,-EUR), représenté par mille quatre
cent soixante-sept (1.467) parts sociales d'une valeur nominale de mille cinq cents euros (1.500,- EUR) chacune.”
<i>Troisième résolutioni>
Il est décidé, pour autant que de besoin, de modifier, respectivement de compléter, les données inscrites au Registre
de Commerce et des Sociétés dans le chef de l'Associé Unique comme indiqué ci-avant.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de deux mille cent
soixante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. DEFLANDRE, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 3 mars 2015. Relation: 2LAC/2015/4556. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivré à la société.
Luxembourg, le 5 mars 2015.
Référence de publication: 2015038039/60.
(150043370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 32.303,03.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.250.
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 3 mars 2015, que l'associé de la Société, RBC
cees Nominees Limited, a transféré 4.000 parts sociales ordinaires de catégorie B, qu'il détenait dans la Société, à DH
Services Employee Benefit Trust représenté par son trustee, RBC cees Trustee Limited.
En conséquence, les parts sociales de la Société sont désormais réparties comme suit:
RBC cees Nominees Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25.426 parts sociales ordinaires de catégorie A
233.385 parts sociales ordinaires de catégorie B
DH Services Employee Benefit Trust représenté par son
trustee, RBC cees Trustee Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39.640 parts sociales ordinaires de catégorie B
DH C-Holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.407.500 parts sociales de préférence de catégorie C
AEA Investors Fund V LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
592.972 parts sociales ordinaires de catégorie A
AEA Investors Fund V-A LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.891 parts sociales ordinaires de catégorie A
AEA Investors Fund V-B LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.295 parts sociales ordinaires de catégorie A
AEA Investors QP Participant Fund V LP . . . . . . . . . . . . . . . .
20.379 parts sociales ordinaires de catégorie A
AEA Investors Participant Fund V LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.015 parts sociales ordinaires de catégorie A
AEA Europe Fund II LP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.424 parts sociales ordinaires de catégorie A
2348614 Ontario Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
757.976 parts sociales ordinaires de catégorie A
Monsieur Cletus VON PICHLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.800 parts sociales ordinaires de catégorie B
G. Richard Wagoner Jr. Trust représenté par son Trustee
M. George Richard WAGONER Jr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.600 parts sociales de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015037778/31.
(150043228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
49728
Aida Wedo 9 S.A.
Angelo Investments S.A.
Ardent Oil (Denmark) S.A.
Compagnie Generale du Pacifique SARL
Corelis
Corso Computer + Software GmbH
Coves S.A.
CPPL Lux 1
Créaforme S.A.
Createch S.à r.l.
CR Realty S.à r.l.
DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.
EPG Investment Partners
ETI Electronique Tôlerie Intégration S.à r.l.
Ferrari Logistics Pledgeco S.à r.l.
Fondation Peters
Harvester Cleanco S.à.r.l.
HGHQK 1 S.à r.l.
HGHQK 2 S.à r.l.
Institut de Formation Bancaire, Luxembourg
International Trading and Engineering S.A.
LaVita Marketing BeNeLux S.à r.l.
Leopard Germany Property Ed 2 S.à.r.l.
Les Mots de Zaza
Les Mots de Zaza de l'Ecole Européenne Luxembourg I
Li Tung S.à r.l.
Luphar S.A.
Mango Luxembourg S.à r.l.
Meluna Investments S.à r.l.
Meluna Investments S.à r.l.
MWV Luxembourg S.à r.l.
Office Portfolio Minerva III Sàrl
Orthodontie Sàrl
Patron Holding (Luxembourg) S.à r.l.
Phytolux International Pharmaceutical Company S.A.
Private Theory Luxco S.à r.l.
PROMIS@Service S.à r.l.
Rodina (Luxembourg) II S.à r.l.
SJ Properties Aubervilliers DebtCo Lux S.C.A.
SOUTHRAB INVESTMENTS
Sparinvest SICAV-SIF
UKSA 60 CR S.à r.l.
UKSA Isledon S.à r.l.
Xella International S.A.