logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 988

14 avril 2015

SOMMAIRE

AEW Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47399

Digital Services XXX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

47378

Fashion and Cosmetics Isabelle T . . . . . . . .

47414

FGP XII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47423

Fitness & Bikes Support S.A.  . . . . . . . . . . . .

47415

Flocapu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47415

Food Delivery Holding 7. S.à r.l.  . . . . . . . . .

47414

Gantner & Laux Malerbetrieb S.à r.l.  . . . .

47415

Globetrot Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47401

Greenlit Consultancy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

47404

Greyswan Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47415

International Trading and Engineering S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47416

Investazur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47416

Inyxa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47416

Ishtar Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47416

IVP LuxCo 2014 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47417

James S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47422

JB Advisory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47417

JPP Polymere S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47417

Karsika Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47418

Kergral S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47419

Kids Care Gestion S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

47418

Kismet Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

47419

Kleopatra Lux 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

47418

Kualibat S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47419

La Table de Léon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

47419

Letterone Corporate Partner S.à r.l. . . . . .

47420

Letterone Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

47420

Lion/Gem Lux 1 SCA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47420

Little Bird Securitization S.à r.l.  . . . . . . . . .

47420

Little Bird Securitization S.à r.l.  . . . . . . . . .

47421

Luxaro Retail Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

47421

Luxas S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47422

Lux'n Com S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47421

Plantes Tropicales Services S.à r.l.  . . . . . . .

47406

Plaza Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47406

PMS Partners S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47406

Racines S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47407

Racines S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47407

TES Global Investments S.à r.l. . . . . . . . . . .

47424

Venglo Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47424

VEREF I Management S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

47424

47377

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 16.669,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.474.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fourth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in

Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and four hundred seventeen

(417) series A1 shares,

here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its re-
gistered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstra.e
14b, 80801 Munich, Germany (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A1 shares;
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
4. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with

the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address at Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),

being the holder of eight hundred thirty-four (834) series A2 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda, having its

business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11 (hereinafter “TJT”),

becoming the holder of four hundred seventeen (417) series A3 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given; and

6. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019,

United States of America (hereinafter “DZ”),

becoming the holder of four hundred seventeen (417) series A3 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1., 2., 3. and 4. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XXX S.à r.l.

(the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.474 and incorporated pursuant
to a deed of the notary Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, on 18 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2514 dated 17 September 2014. The articles of association have been amended
pursuant to a deed of notary Henri Hellinckx, prenamed, dated 18 December 2014, not yet published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby TJT and DZ
participates and vote for the purpose of Agenda point 5 et seqq. only:

47378

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have four (4) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), series
A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) and series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”).

2. Acceptance of TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda,

having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11, as new shareholder of the
Company.

3. Acceptance of David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

 Street - 33 

rd

 Floor, New York,

NY 10019, United States of America, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company's share capital by an amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834) so as to raise

it from its current amount of fifteen thousand eight hundred thirty-five euros (EUR 15,835) up to sixteen thousand six
hundred sixty-nine euros (EUR 16,669) by issuing eight hundred thirty-four (834) Series A3 Shares with a nominal value
of one euro (EUR 1.00) each.

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand six hundred sixty-nine euros (EUR 16,669.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each,

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) with a nominal value of one

euro (EUR 1.00) each, and

5.1.4 eight hundred thirty-four (834) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares” and jointly with the Series A1

Shares and Series A2 Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”) with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XXX S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

47379

L

U X E M B O U R G

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand and six hundred sixty-nine Euros (EUR 16,669.00), repre-

sented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each,

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), with a nominal value of one

euro (EUR 1.00) each, and

5.1.4 eight hundred thirty-four (834) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares” and jointly with the Series A1

Shares and Series A2 Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”), with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 5. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

("Rocket"), HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG ("Holtzbrinck"), Netris B.V. (“Eiffel”), TJT (B) (Bermuda)
Investment Company Ltd. (“TJT”) and David W. Zalaznick (“DZ”; jointly with Rocket, Holtzbrinck, Eiffel and TJT the

47380

L

U X E M B O U R G

"Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation
procedure.

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the

47381

L

U X E M B O U R G

redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.

47382

L

U X E M B O U R G

13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company;
16.2 resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.2.5 Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

47383

L

U X E M B O U R G

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the advisory board for the legal transactions and measures specified

below in accordance with § 24.5, provided that at any time two (2) or more voting members have been appointed to the
advisory board in addition to the voting members nominated by Rocket, it includes the affirmative vote of at least one
voting member other than the voting members appointed by Rocket. No consent is required if such legal transactions
and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of
the advisory board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The

47384

L

U X E M B O U R G

consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the advisory board. The advisory board may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders may by

way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the advisory board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a unanimous

shareholders' consent.

24.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by Rocket in its sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the advisory board shall be nominated by Holtzbrinck in its sole discretion.
24.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
24.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

24.6 In addition to any consent or approvals otherwise required under these articles of association and/or any share-

holders' agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not
interfere in the management of the Company.

24.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

47385

L

U X E M B O U R G

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Messrs. Julien

De Mayer and Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders
register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have four (4) classes of shares, divided into Common Shares, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3
Shares.

47386

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders accepts TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company

under the laws of Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,
as new shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders accepts David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57 

th

Street - 33 

rd

 Floor, New York, NY 10019, United States of America, as new shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of eight hundred

thirty-four euros (EUR 834) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand eight hundred thirty-five euros
(EUR 15,835) up to sixteen thousand six hundred sixty-nine euros (EUR 16,669) by issuing eight hundred thirty-four (834)
Series A3 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each

<i>Subscription

The eight hundred thirty-four (834) Series A3 Shares have been duly subscribed as follows:
1. Four hundred seventeen (417) Series A3 Shares have been subscribed by TJT, aforementioned, for the price of four

hundred seventeen euros (EUR 417), and

2. Four hundred seventeen (417) Series A3 Shares have been subscribed by DZ, aforementioned, for the price of four

hundred seventeen euros (EUR 417).

<i>Payment

The eight hundred thirty-four (834) Series A3 Shares have been paid as follows:
1. four hundred seventeen (417) Series A3 Shares subscribed by TJT, aforementioned, have been entirely paid up

through a contribution in cash in an amount of four hundred seventeen euros (EUR 417), and

2. four hundred seventeen (417) Series A3 Shares subscribed by DZ, aforementioned, have been entirely paid up

through a contribution in cash in an amount of four hundred seventeen euros (EUR 417).

The amount of eight hundred and thirty-four Euro (EUR 834.-) is as now available to the Company as has been proved

to the undersigned notary.

The contribution in the amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834) is entirely allocated to the share capital.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that:
1. TJT has now become the holder of four hundred seventeen (417) Series A3 Shares, and
2. DZ has now become the holder four hundred seventeen (417) Series A3 Shares.
As a consequence TJT, aforementioned, and DZ, aforementioned, entitled to vote and here represented by Kristof

De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxies, join the general meeting
of shareholders for the purpose of the following resolutions.

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at sixteen thousand six hundred sixty-nine euros (EUR 16,669.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each,

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) with a nominal value of one

euro (EUR 1.00) each, and

5.1.4 eight hundred thirty-four (834) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares' and jointly with the Series A1

Shares and Series A2 Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”) with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

47387

L

U X E M B O U R G

<i>Sixth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Messrs. Julien De Mayer and Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely,
the shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,000.-

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierundzwanzigsten Dezember.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und vierhundertsiebzehn (417) Anteilen

der Serie A1,

hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht.
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-

stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstra.e 14b, 80801, München, Deutschland („Holtzbrinck“),

Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
4. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-

register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),

Inhaber von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht;
5. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht der Bermuda-Inseln mit satzungs-

mäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda-
Inseln HM11 („TJT“),

zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht; und
6. David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New York, Vereinigte

Staaten von Amerika („DZ“),

zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

47388

L

U X E M B O U R G

Die Parteien unter 1., 2., 3. und 4. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services XXX

S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.474, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß
einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 17. September 2014 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2514, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt
am 18. Dezember 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, vorbenannt, geändert, welche noch nicht im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
Tagesordnung verhandeln, wobei TJT und DZ ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimm-
berechtigt sind:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr vier (4) An-

teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile
der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) und Anteile der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“).

2. Aufnahme von TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht der Bermuda-Inseln

mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton,
Bermuda-Inseln HM11, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

3. Aufnahme von David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57 

th

 Street, 33 

rd

 Floor, New

York, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausendachthun-

dertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835) um einen Betrag von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) auf einen Betrag
von sechzehntausendsechshundertneunundsechzig Euro (EUR 16.669) durch die Ausgabe von achthundertvierunddreißig
(834) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  sechzehntausendsechshundertneunundsechzig  Euro  (EUR

16.669,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von

je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.4 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 und den Anteilen der Serie A2 die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XXX S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

47389

L

U X E M B O U R G

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  sechzehntausendsechshundertneunundsechzig  Euro  (EUR

16.669,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von

je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.4 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 und den Anteilen der Serie A2 die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

47390

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“), HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG („Holtzbrinck“), Netris B.V. („Eiffel“),
TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“) und David W. Zalaznick („DZ“; gemeinschaftlich mit Rocket, Holtz-
brinck, Eiffel und TJT die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft

47391

L

U X E M B O U R G

bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

47392

L

U X E M B O U R G

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft;
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.2.5 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

47393

L

U X E M B O U R G

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

47394

L

U X E M B O U R G

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen im Einklang mit Artikel 24.5 sofern, wenn zu einem Zeitpunkt zwei (2) oder mehr stimmberechtigte Mitglieder
des Beirats zusätzlich zu den von Rocket ernannten stimmberechtigten Mitgliedern ernannt wurden, diese die Ja-Stimme
mindestens eines stimmberechtigten Mitglieds beinhaltet, bei welchem es sich nicht um die von Rocket ernannten stimm-
berechtigten Mitglieder handelt. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen
den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-

47395

L

U X E M B O U R G

führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter

können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats er-
höhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von Rocket nach eigenem Ermessen ernannt; und
24.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen ernannt.
24.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

47396

L

U X E M B O U R G

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie die

Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr

vier (4) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie
A3.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem

Recht der Bermuda-Inseln mit satzungsmäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House,
2 Church Street, Hamilton, Bermuda-Inseln HM11, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57 

th

Street, 33 

rd

 Floor, New York, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

fünfzehntausendachthundertfünfunddreißig  Euro  (EUR  15.835)  um  einen  Betrag  von  achthundertvierunddreißig  Euro

47397

L

U X E M B O U R G

(EUR 834) auf einen Betrag von sechzehntausendsechshundertneunundsechzig Euro (EUR 16.669) durch die Ausgabe von
achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die achthundertvierunddreißig (834) Anteile der Serie A3 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
1. vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 wurden von TJT, vorbenannt, zu einem Preis von vierhundertsiezehn

Euro (EUR 417) gezeichnet, und

2. vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 wurden von DZ, vorbenannt, zu einem Preis von vierhundertsiezehn

Euro (EUR 417) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die achthundertvierunddreißig (834) Anteile der Serie A3 wurden wie folgt eingezahlt:
1. die von TJT, vorbenannt, gezeichneten vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 wurden vollständig eingezahlt

durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417), und

2. die von DZ, vorbenannt, gezeichneten vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A3 wurden vollständig eingezahlt

durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417).

Die Summe von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung, so

wie dies dem amtierenden Notar erbracht wurde.

Die Einlage in Höhe von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zuge-

führt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass:
1. TJT nun der Inhaber von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 geworden ist, und
2. DZ nun der Inhaber von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 geworden ist.
Demzufolge schließen sich TJT, vorbenannt, und DZ, vorbenannt, stimmberechtigt und hier vertreten durch Kristof

De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmachten der Gesellschafterversammlung
für die folgenden Beschlüsse an.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1  Das  Gesellschaftskapital  der  Gesellschaft  beträgt  sechzehntausendsechshundertneunundsechzig  Euro  (EUR

16.669,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00),

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von

je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.4 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 und den Anteilen der Serie A2 die „Anteile der Serie A“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  sowie  die  Herren  Julien  De  Mayer  und  Rüdiger  Trox  dazu  zu  ermächtigen,  das  Anteilsinhaberregister  der
Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

47398

L

U X E M B O U R G

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: K. DE WAEL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 2 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/40. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 27. Februar 2015.

Référence de publication: 2015036262/1181.
(150040995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

AEW Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 90.603.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of February.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,

THERE APPEARED:

AEW EUROPE, a société anonyme incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at

1-3 rue des Italiens, 75009 Paris, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Paris under number 409
039 914,

here represented by Ms Madia CAMARA, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given on 11

February 2015, which is initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, and shall remain
annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, as represented, represents the entire share capital of AEW Europe S.à r.l. (hereinafter the

“Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 90603, incor-
porated pursuant to a deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
on 19 December 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 146 on 12 February 2003.
The articles of association have last been amended pursuant to a deed of the undersigned notary, on 9 January 2015, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and acting in

place of the extraordinary general meeting of shareholders, may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1) Amendment to article 3 of the articles of association of the Company regarding the corporate purpose of the

Company; and

2) Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder, as represented, takes, and requires the notary

to enact, the following resolution:

<i>Sole Resolution

The sole shareholder resolves to amend the article 3 of the articles of association of the Company regarding the

corporate object of the Company in order to suppress the possibility for the Company to grant loans or guarantees.

Therefore, the sole shareholder resolves that article 3 of the articles of association of the Company shall henceforth

read as follows:

“ Art. 3. Corporate purpose. The Corporate purpose of the Company is the management of alternative investment

funds («AIFs») within the meaning and in compliance with the Directive 2011/61/EU regarding alternative investment fund
managers as implemented in Luxembourg by the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the «AIFM
Law»).

The management of AIFs shall comprise, at least, the portfolio management and the risk management functions in

compliance with article 5.2 and Annex I of the AIFM Law.

47399

L

U X E M B O U R G

The Company may also exercise other ancillary functions within the context of the collective management of an AIF,

such as:

a) Administration in compliance with point 2 (a) of Annex I of the AIFM Law and which includes (i) legal and fund

management accounting services, (ii) customer inquiries, (iii) share valuation and pricing (including tax returns), (iv) re-
gulatory compliance monitoring, (v) maintenance of unit-/shareholder register, (vi) distribution of income, (vii) unit/shares
issues and redemptions, (viii) contract settlements (including certificate dispatch) and (ix) record keeping.

b) Marketing, distribution or placement of units, shares or interest in AIFs.
c) Activities related to the assets of AIFs, namely services necessary to meet the fiduciary duties of the AIFM, facilities

management,  real  estate  administration  activities,  advice  to  undertakings  on  capital  structure,  industrial  strategy  and
related matters, advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings and other services connected
to the management of the AIF and the companies and other assets in which it has invested.

The Company may further manage its own assets and perform any activities and actions which it considers useful or

necessary for the accomplishment and development of its purpose, within the limits set forth by the law. It may hold,
acquire, transfer its participations, in any form whatsoever, in any Luxembourg and foreign companies, and act as a legal
representative in the aforementioned companies and provide corporate services to the aforementioned companies and
services to any companies belonging to the same group.

The Company may provide services in Luxembourg and abroad and may therefore establish offices and / or branches

in Luxembourg and abroad.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand two hundred Euro (EUR 1,200.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze février,
Pardevant Maître Joëlle BADEN notaire de résidence à Luxembourg,

A COMPARU:

AEW EUROPE, une société anonyme constituée et existant selon le droit Français, ayant son siège social à 1-3 rue

des Italiens, 75009 Paris, France, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
409 039 914,

dûment représentée par Mme Madia CAMARA, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procu-

ration donnée le 11 février 2015, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, qui restera
annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

Ladite partie comparante représente la totalité du capital social de AEW Europe S.à r.l. (ci-après dénommée la “So-

ciété”) une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L- 2520 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 90603,
constituée par un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 19
décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 146 le 12 février 2003. Les statuts de la
société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu du notaire soussigné, notaire résidant à Luxembourg, le
9 janvier 2015, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

La partie comparante représentant l'intégralité du capital social déclare renoncer aux formalités de convocation et agit

en tant qu'assemblée générale extraordinaire qui peut valablement délibérer sur l'ensemble des points inscrits à l'ordre
du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1) Modification de l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société; et
2) Divers.
Ayant dûment examiné chaque point de l'ordre du jour, l'associé unique adopte, et requiert du notaire d'acter la

résolution suivante:

47400

L

U X E M B O U R G

<i>Unique résolution

L'associé unique décide de modifier l'article 3 des statuts de la Société concernant l'objet social de la Société afin de

supprimer la possibilité pour la Société d'octroyer des prêts et des garanties.

Par conséquent, l'associé unique décide que l'article 3 des statuts de la Société aura désormais de la teneur suivante:

“ Art. 3. Objet social. La Société a pour objet la gestion de fonds d'investissement alternatifs (les «FIAs») au sens de

et en conformité avec la Directive 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs telle que trans-
posée en droit luxembourgeois par la loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la
«Loi AIFM»).

La gestion de FIAs s'entend, à tout le moins, de la gestion du portefeuille et de la gestion des risques en conformité

avec l'article 5.2 et l'Annexe I de la Loi AIFM.

La Société peut également exercer d'autres fonctions à titre complémentaire dans le cadre de la gestion collective

d'un FIA, telles que:

a) Administration conformément à l'Annexe I alinéa 2 (a) de la Loi AIFM et qui comprend (i) les services juridiques et

de gestion comptable du fonds, (ii) les demandes de renseignements des clients, (iii) l'évaluation et la détermination de
la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux), (iv) le contrôle du respect des dispositions réglementaires, (v) la tenue
du registre des porteurs de parts et/ou actionnaires, (vi) la répartition des revenus, (vii) les émissions et rachats de parts
ou actions, (viii) les règlements des contrats (y compris l'envoi des certificats), et (ix) l'enregistrement et conservation
des opérations.

b) Commercialisation, distribution ou placement de parts, actions ou intérêts dans des FIAs.
c) Activités liées aux actifs des FIAs, à savoir l'exécution des services nécessaires pour que soient remplis les devoirs

fiduciaires du gestionnaire, et assurés la gestion des infrastructures, les activités d'administration des immeubles, le conseil
aux entreprises concernant la structure du capital, la stratégie industrielle et les questions connexes, le conseil et les
services concernant les fusions et les acquisitions, et d'autres services liés à la gestion du FIA et des sociétés et autres
actifs dans lesquels il a investi.

La Société peut en outre gérer ses propres actifs et effectuer toutes les opérations et activités considérées comme

utiles ou nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet, tout en restant dans les limites prévues par
la loi. Elle peut détenir, acquérir, céder des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entités de droit
luxembourgeois ou étranger, et exercer toute fonction de représentants légaux dans lesdites sociétés et fournir toutes
prestations de nature corporate pour lesdites sociétés et des prestations de services au bénéfice des sociétés de son
groupe.

La Société peut fournir ses services au Luxembourg et à l'étranger et peut à cette fin établir des bureaux et / ou des

branches représentatives au Luxembourg et à l'étranger.»

<i>Coûts et Dépenses

Les coûts, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui seront supportés par la Société à la suite de cet acte

sont estimées à mille deux cents Euros (EUR 1.200,-).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, le jour indiqué au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que sur demande de la partie comparante, le présent acte

est rédigé en anglais suivi par une traduction française; sur la demande de la même partie et en cas de divergence entre
le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire par nom, prénom et domicile, ledit

mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. CAMARA et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 13 février 2015. 1LAC / 2015 / 4643. Reçu soixante quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015036165/141.
(150040993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Globetrot Investments, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 176.831.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth of the month of February.
Before us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg,

47401

L

U X E M B O U R G

was held

the extraordinary general meeting of shareholders of Globetrot Investments, a private limited liability company (société

à responsabilité limitée) existing under Luxembourg law, having its registered office at L-2086 Luxembourg, 412 F, Route
d’Esch, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
176.831, with a share capital of two million six hundred twenty-five thousand twelve Euro and eighty-nine cents (EUR
2,625,012.89), incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy
of Luxembourg, on 16 April 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1439 on 18 June
2013 (the “Company”).

The meeting was opened with Mr. Victorien HÉMERY, Avocat à la Cour, in the chair, professionally residing in Lu-

xembourg,  who  appointed  as  secretary  Mr.  Amaury  LAMBERT,  Avocat,  professionally  residing  in  Luxembourg.  The
meeting elected as scrutineer Mr. Amaury LAMBERT, Avocat, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present

or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus
no convening notices were necessary.

III. The present meeting is thus regularly constituted and could validly deliberate on all the items on the agenda.
IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Approval of the decision to use the annual accounts of the Company as of 31 

st

 December 2014 as opening balance

sheet of the liquidation.

2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of a liquidator and determination of its powers and duties.
4. Determination of the remuneration of the liquidator.
5. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders resolves to approve the decision to use the annual accounts of the Company as

of 31 

st

 December 2014 as opening balance sheet of the liquidation.

<i>Second Resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended (the “Law”)

the general meeting of shareholders resolves to dissolve and liquidate the Company.

<i>Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders resolves to appoint Merlis S.à r.l.,

a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of Grand
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.320, having
its registered office at L-2086 Luxembourg, 412F, Route d’Esch, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of
twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), as liquidator of the Company (the “Liquidator”).

The Liquidator has the broadest powers as provided for by articles 144 to 148bis of the Law.
The Liquidator is hereby expressly empowered to carry out all such acts as provided for by article 145 of the Law

without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders.

The Liquidator is relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the sole signature of the Liquidator.
The Liquidator may, under her responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxyholders

such powers as it determines and for the period as it thinks fit.

The Liquidator may distribute the Company’s assets to the shareholders in cash and/or in kind in his sole discretion.

Such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds.

47402

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth Resolution

The general meeting of shareholders resolves that the Liquidator shall receive a compensation of nine thousand euro

(EUR 9,000) per year for the accomplishment of his duties.

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500.-).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the members of the Bureau, known to the notary by name, first name and residence,

they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février.
Par-devant nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des associés de Globetrot Investments, une société à responsabilité limitée existant

selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social situé au L-2086 Luxembourg, 412 F, route d’Esch, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.831, avec
un capital social de deux millions six cent vingt-cinq mille douze euros et quatre-vingt-neuf centimes (EUR 2.625.012,89),
constituée selon acte reçu par Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg,
en date du 16 avril 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1439 en date du 18 juin 2013 (la
«Société»).

L’assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Victorien HÉMERY, Avocat à la Cour, résidant profession-

nellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Monsieur Amaury LAMBERT, Avocat, résidant professionnel-
lement  à  Luxembourg.  L’assemblée  a  élu  comme  scrutateur  Monsieur  Amaury  LAMBERT,  Avocat,  résidant
professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l’assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d’acter ce

qui suit:

I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions

qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires
présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l’assemblée et le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II. Il résulte de la liste de présence que l’intégralité du capital social de la Société autorisé à voter est présent ou

représenté et que tous les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarent par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour bien avant la présente assemblée et que par conséquent il n’y avait pas
besoin d’envoyer des avis de convocation.

III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés

à l’ordre du jour.

IV. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de la décision d’utiliser les comptes annuels de la Société clos le 31 décembre 2014 comme bilan

d’ouverture de la liquidation.

2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination du liquidateur et détermination de ses pouvoirs et de ses fonctions.
4. Détermination de la rémunération du liquidateur.
5. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’assemblée générale des actionnaires adopte à

l’unanimité, et requiert le notaire instrumentant d’acter les résolutions suivantes:

47403

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide d’approuver la décision d’utiliser les comptes annuels de la Société clos

le 31 décembre 2014 comme bilan d’ouverture de la liquidation.

<i>Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi»), l’assemblée générale des associés décide de dissoudre et de liquider la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée générale des associés décide de nommer Merlis S.à r.l., une

société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.320, ayant son siège social au L-2086
Luxembourg, 412 F, route d’Esch, Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq cent euros
(EUR 12.500), en tant que liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.
Le Liquidateur est par la présente expressément autorisé à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans

devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de l’assemblée générale des associés.

Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
La Société est engagée par la seule signature du Liquidateur.
Le Liquidateur pourra, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires une partie de ses pouvoirs dont il fixera l’étendue et la durée.

Le Liquidateur pourra distribuer, à sa discrétion, les actifs de la Société aux associés en espèce et/ou en nature. Cette

distribution pourra prendre la forme d’une avance sur le boni de liquidation.

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires décide que le Liquidateur percevra une compensation de neuf mille euros (EUR

9.000) par an pour l’accomplissement de sa gestion.

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte

est évalué à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500.-).

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ils ont

signé avec le notaire le présent acte.

Signé: V. HEMERY. A. LAMBERT, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 février 2015. Relation: DAC/2015/3470. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 03 mars 2015.

Référence de publication: 2015036338/153.
(150040751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Greenlit Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7214 Bereldange, 2, rue Belle Vue.

R.C.S. Luxembourg B 194.982.

STATUTS

L'an deux mille quinze.
Le vingt-six février;
Pardevant Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg.

A comparu:

Madame Jacqueline GEISEN, indépendante, célibataire, née à Luxembourg le 16 août 1965, demeurant à L-7214 Be-

reldange, 2 rue Belle Vue;

47404

L

U X E M B O U R G

Laquelle comparante a requise le notaire instrumentaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à

responsabilité limitée unipersonnelle qu'elle déclare constituer.

Art. 1 

er

 .  La société prend la dénomination de «Greenlit Consultancy S.à r.l.»

Art. 2. Le siège de la société est établi à Bereldange.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 3. La société a pour objet en général toutes activités et services administratifs et commerciaux et notamment

permettant de faciliter le processus administratif d'une cotation en bourse.

La société a également comme objet le coaching de tout genre ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales

ou financières, mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de
nature à en faciliter l'extension ou le développement.

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. Par dérogation,

le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

Art. 6. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EURO (Euro. 12.500.-) représenté par CENT (100)

parts sociales de chacune CENT VINGT-CINQ EURO (Euro 125.-).

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par l'associée unique, Madame Jacqueline GEISEN, indépendante,

célibataire, née à Luxembourg le 16 août 1965, demeurant à L-7214 Bereldange, 2 rue Bellevue.

Ces parts ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de DOUZE MILLE

CINQ CENT EURO (Euro. 12.500.-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle dans l'actif social et dans les bénéfices.

Art. 8.
a) La cession entre vifs:
Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il entend.
b) La transmission pour cause de mort:
Le décès de l'associée unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associée unique n'a laissé aucune disposition

de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les
héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succes-
sion, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront

l'obligation pour lesdits parts sociales de désigner un mandataire.

Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par l'associée qui fixe leurs

pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision des associés.

A moins que l'associée n'en décide autrement, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de

la société en toutes circonstances.

Art. 10. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obli-

gation personnelle relativement à celles-ci, ils ne seront responsables que de l'exécution de leur mandat.

Art. 11. Chaque année, le 31 décembre, il sera dressé un inventaire de l'actif et du passif de la société. Le bénéfice net

constaté, déduction faite des frais généraux, traitements et amortissements, sera réparti de la façon suivante:

- cinq pour cent (5,00 %) pour la constitution d'un fonds de réserve légal, dans la mesure des dispositions légales;
- le solde restera à la libre disposition de l'associée.

Art. 12. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

désignés par les associés.

Art. 13. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Frais

Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-

mativement à MILLE CINQ CENTS EUROS (Euro 1.500.-)

<i>Assemblée générale

Et à l'instant, l'associée unique à savoir Madame Jacqueline GEISEN, indépendante, célibataire, née à Luxembourg le

16 août 1965, demeurant à L-7214 Bereldange, 2 rue Belle Vue, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, fait
désigner elle-même comme gérante unique.

47405

L

U X E M B O U R G

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.
Le siège social est établi à L-7214 Bereldange, 2, rue Belle Vue.
Avant la clôture du présent acte le notaire instrumentaire soussigné a attiré l'attention de la constituante sur la nécessité

d'obtenir une autorisation administrative pour exercer les activités décrites dans l'objet social.

DONT ACTE, fait et passé à Bettembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Geisen, C. Doerner.
Enregistré à Esch/Alzette A.C. le 27 février 2015. Relation: EAC/2015/4668. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Bettembourg, le 02 mars 2015.

Référence de publication: 2015036342/77.
(150040401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Plantes Tropicales Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 10, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 106.368.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 4 mars 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015036573/11.
(150041355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Plaza Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 185.705.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015036574/10.
(150040942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

PMS Partners S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 34.112.

DISSOLUTION

L'an deux mille quinze, le dix-huit février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

ROSEVARA LIMITED, R.C. Dublin 196711, avec siège social Eaton Neary, Custume Place, Athlone, République d’Ir-

lande,

ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé privé, avec adresse professionnelle au 3, route de Luxembourg,

L-6130 Junglinster, en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.

La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter comme suit

ses déclarations et constatations:

a) Que la société anonyme..PMS PARTNERS S.A..., (ci-après la "Société"), avec siège social à L-2121 Luxembourg, 231,

Val des Bons- Malades, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
34.112, a été constituée suivant acte reçu par Me André-Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors notaire de résidence à

47406

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, en date du 29 mai 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°456 du 7 décembre
1990. Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire instrumentant, en date
du 20 juin 2007, publié au Mémorial C n°1777 du 22 août 2007.

b) Que le capital social de la Société est fixé à un montant de trente-six mille euros (36.000,- EUR), divisé en huit cent

(800) actions d’une valeur nominale de quarante-cinq euros (45,- EUR) chacune, entièrement libérées.

c) Que la comparante, représentée comme dit ci-avant, est devenue successivement propriétaire de toutes les actions

de la Société.

d) Que l’activité de la Société ayant cessé, la comparante prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet

immédiat et sa mise en liquidation.

e) Que la comparante, en tant qu'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société.
f) Que la comparante déclare fixer à tout de suite la deuxième et la troisième assemblée conformément à l’article 151

de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et les tenir immédiatement l’une après l’autre.

g) Qu'en sa qualité de liquidateur de la Société, elle requiert le notaire instrumentant d’acter qu'elle déclare avoir réglé

tout le passif de la Société ou l’avoir dûment provisionné et avoir transféré tous les actifs à son profit.

h) Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la Société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la Société même inconnus à ce jour.

i) Que les déclarations du liquidateur ont fait l’objet d’une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par SG Services S.àr.l., R.C.S. Luxembourg B 78 306, avec siège social au 231, Val des Bons- Malades à L-2121 Lu-
xembourg, désigné "commissaire-vérificateur" par l’actionnaire unique de la Société.

j) Que la comparante approuve les comptes de liquidation au 31 décembre 2014 et donne décharge pleine et entière

au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ultérieure.

k) Que la comparante, constituée en troisième assemblée, prononce la clôture de la liquidation et constate que la

Société a définitivement cessé d’exister.

l) Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

m) Qu'il a été procédé à l’annulation du registre des actionnaires de la Société.
n) Que les livres et documents de la Société, dissoute, seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

social au 231, Val des Bons- Malades à L-2121 Luxembourg.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à la somme de 950,- EUR et le comparant,
en tant qu'actionnaire unique, s'y engage personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 24 février 2015. Relation GAC/2015/1509. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé.): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015036575/61.
(150040803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Racines S.A., Société Anonyme,

(anc. Racines S.à r.l.).

Siège social: L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave Kahnt.

R.C.S. Luxembourg B 135.349.

L'an deux mille quinze, le treize février.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1) Madame Dalia LION, sans état particulier, née à Haïfa, (Israël), le 2 mars 1943, demeurant à L-1851 Luxembourg,

12, rue Gustave Kahnt.

2) Madame Bat-El BAHBOUT, employée privée, née à Haïfa, (Israël), le 2 février 1964, demeurant à L-1145 Luxem-

bourg, 79, rue des Aubépines.

3) Monsieur Eli BAHBOUT, employé privé, né à Haïfa, (Israël), le 17 mars 1968, demeurant à L-2523 Luxembourg, 70,

rue Jean Schoetter.

47407

L

U X E M B O U R G

4) Madame Hila BAHBOUT, sans état particulier, née à Haïfa, (Israël), le 1 

er

 août 1969, demeurant à B-1640 Rhode

St Genèse, 160 chaussée de la grande Espinette (Belgique).

ici représentés par Madame Laure SINESI, employée, ayant son adresse professionnelle à Howald, 45, rue des Scillas,

en vertu de quatre (4) procurations lui délivrées, lesquelles après avoir été signées «ne varietur» par la mandataire et le
notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes.

Lesquelles personnes comparantes déclarent et requièrent, par leur mandataire, le notaire instrumentant d'acter ce

qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée "RACINES S.à R.L.", avec siège social à L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave

Kahnt, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 135.349 (ci-après
la "Société"), a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 10 décembre 2007, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 362 du 12 février 2008.

- Que le capital social est fixé à treize mille euros (13.000,- EUR), représenté par cinquante-deux (52) parts sociales

de deux cent cinquante euros (250,- EUR) chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils ont pris à l'unanimité des voix, en

assemblée générale extraordinaire, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social à concurrence d'un montant de dix-neuf mille euros (EUR

19'000.-), pour le porter de son montant actuel de treize mille euros (EUR 13'000) à trente-deux mille euros (EUR
32'000.-), par incorporation au capital d'une partie des bénéfices reportés à concurrence de dix-neuf mille euros (EUR
19'000.-), par l'émission et la création de soixante-seize (76) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de deux-cent-
cinquante euros (EUR 250.-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, à attribuer
entièrement libérées aux propriétaires des parts sociales anciennes proportionnellement aux parts sociales qu'ils détien-
nent.

Preuve  de  l'existence  de  cet  apport  a  été  repris  dans  le  rapport  du  réviseur  d'entreprises  agréé,  détaillé  dans  la

deuxième résolution.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide de transformer, avec effet au 1 

er

 janvier 2015, la Société en une société anonyme, sans

changement de sa personnalité juridique, sur la base du rapport du réviseur d'entreprises sur la situation active et passive
de la Société, conformément aux articles 26-1 et 31-1 de la loi modifiée du 10 août 1915; le capital et les réserves
demeurent intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values,
la société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société à responsabilité limitée.

<i>Rapport du réviseur d'entreprises

Cette transformation en société anonyme fait l'objet d'un rapport établi par le réviseur d'entreprises indépendant, la

société à responsabilité limitée INTERAUDIT, ayant son siège social à L-2529 Howald, 37 rue des Scillas, sous la signature
de Monsieur Edward KOSTKA réviseur d'entreprises, conformément aux stipulations des articles 26-1 et 31-1 de la loi
sur les sociétés commerciales et qui conclut de la manière suivante:

<i>"Conclusion

Sur base des vérifications effectuées telles que décrites ci-dessus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la

transformation de la Société de Société à responsabilité limitée en Société Anonyme et sur la valeur de l'apport qui
correspond au moins au nombre et à la valeur nominale des actions à émettre en contrepartie.

Howald, le 12 février 2015"
Ledit rapport, signé "ne varietur" par la mandataire des comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte pour être formalisé avec lui.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale accorde pleine et entière décharge au gérant de la Société, Monsieur Moshe BAHBOUT pour

l'exercice de son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale déclare que les 128 (cent-vingt-huit) parts sociales existantes d'une valeur nominale de deux-

cent-cinquante euros (EUR 250.-) chacune sont échangées contre 128 (cent-vingt-huit) actions d'une valeur nominale de
deux-cent-cinquante euros (EUR 250.-) chacune entièrement libérées.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de convertir 64 (soixante-quatre) des actions ordinaires d'une valeur nominale de deux-

cent-cinquante euros (EUR 250.-) en 64 (soixante-quatre) actions privilégiées sans droit de vote, qui seront attribuées
entièrement libérées aux propriétaires des actions anciennes proportionnellement aux actions qu'ils détiennent.

47408

L

U X E M B O U R G

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale décide:
- de changer la dénomination sociale de la Société en «RACINES S.A.»;
- de confirmer l'adresse du siège social de la Société à L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave Kahnt;
- de procéder à une refonte complète des statuts de la Société pour les mettre en concordance avec ce qui précède

et pour les adapter aux dispositions réglementant les sociétés anonymes et les arrêter comme suit:

Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il existe une société anonyme sous la dénomination de «RACINES S.A.» (ci-après la «Société»), régie par

les lois du Grand- Duché de Luxembourg, en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales, et par les présents statuts.

Art. 2. Le siège de la Société est établi dans la commune de Luxembourg. Il pourra être transféré dans tout autre lieu

de la commune de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et

portée à la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque

manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. Elle peut aussi contracter des emprunts et
accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avan-
ces et de garanties.

La Société peut également acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange, vente

ou autrement. Elle peut également acquérir, mettre en valeur et aliéner des brevets et licences, ainsi que des droits en
dérivant ou les complétant.

De plus, la Société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation d'immeubles situés tant au

Luxembourg qu'à l'étranger.

D'une façon générale, la Société peut faire toutes opérations commerciales, industrielles et financières, de nature

mobilière et immobilière, susceptibles de favoriser ou de compléter les objets ci-avant mentionnés.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 32'000,- (trente-deux mille euros) représenté par 128 (cent-vingt-huit) actions

d'une  valeur  nominale  de  EUR  250.-  (deux-cent-cinquante  euros)  chacune  et  réparties  en  deux  catégories  d'actions
comme suit:

- 64 (soixante-quatre) actions ordinaires avec droits de vote (ci-après les «Actions Ordinaires»),
- 64 (soixante-quatre) actions privilégiées sans droit de vote (ci-après les «Actions Privilégiées»).
Les Actions Privilégiées donnent droit à un dividende privilégié et récupérable correspondant à quatre pour cent (4

%) de la valeur nominale desdites actions, sans préjudice du droit pouvant leur être accordé dans la répartition du surplus
des bénéfices et des droits conférés par la loi.

Pour les besoins des présents statuts, le terme «action(s)» désigne collectivement les Actions Ordinaires et les Actions

Privilégiées sauf si le contexte le requiert autrement.

Les privilèges des actions en cause sont précisés aux articles 18 et 20 des statuts.
Les actions de la Société peuvent être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs

de plusieurs actions.

Les actions seront exclusivement émises sous forme nominative.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.
Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les actions entre ses seules mains, la Société est une société

anonyme unipersonnelle au sens de la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à
directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle. Lorsque la Société ne comporte qu'une seule
personne, celle-ci est dénommée «associé unique». La Société peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi
que par réunion de toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'associé unique n'entraîne pas la
dissolution de la Société.

47409

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Transmission des actions.
6.1. Restriction à la cessibilité des actions
6.1.1. Sauf accord préalable de l'assemblée générale des actionnaires décidé à l'unanimité des voix exprimées ou accord

contractuel écrit entre les actionnaires, les actionnaires de la Société ne pourront pas gager ou grever de quelque manière
que ce soit et pour quelque raison que ce soit, leurs actions (présentes ou futures) dans la Société.

6.1.2. Champ d'application
Les dispositions telles que définies à l'article 6 s'appliquent à tout transfert d'actions (présentes ou futures et sans

distinction de catégories) de la Société fait en faveur d'un actionnaire de la Société et/ou d'un tiers non actionnaire de la
Société (au sens le plus large et à l'exclusion des cas visés expressément et limitativement ci-dessous) et donc notamment
toute cession à titre onéreux ou gratuit, donation et autre y compris tout apport en société (à l'exclusion de tout cas où
la société bénéficiaire est détenue exclusivement par l'actionnaire apporteur et que celui-ci en est le bénéficiaire écono-
mique unique).

Les présentes dispositions s'appliquent également de plein droit aux droits de souscription éventuellement émis par

la Société ainsi qu'à tout autre titre émis par la Société et donnant droit à des actions de la Société.

Les présentes dispositions s'appliquent également en cas de changement de l'actionnariat (sous quelque forme que ce

soit y compris notamment par voie d'apport) au niveau de tout actionnaire personne morale de la Société, lorsqu'un tel
changement a pour effet qu'un tiers devienne actionnaire et/ou bénéficiaire économique de l'actionnaire concerné. Dans
une telle situation et lors de la survenance d'un des événements susmentionnés et préalablement à toute réalisation du
transfert consécutif, les actionnaires de la Société s'engagent à le notifier préalablement, par lettre recommandée avec
accusé de réception, au Conseil d'Administration qui le notifiera immédiatement aux autres actionnaires afin que les
procédures puissent être mises en place dans les meilleurs délais conformément aux présentes dispositions.

En cas de pluralité de candidats acquéreurs (actionnaire ou tiers) ou de pluralité d'offres par un même candidat ac-

quéreur (actionnaire ou tiers) portant sur les mêmes actions de la Société, leurs offres respectives (même simultanées)
seront considérées et traitées comme autant d'offres distinctes et donc soumises chacune de manière séparée aux pro-
cédures telles que prévues par les présentes dispositions.

6.1.3. Sanction/Pénalité
En tout état de cause, tout transfert d'actions de la Société fait en violation des présentes dispositions sera considéré

comme non valable et irrégulier et partant inopposable à la Société; aucune inscription dans le registre des actionnaires
de la Société ne pouvant être dès lors actée.

6.2. Droit de préemption
Tout actionnaire de la Société qui désire transférer tout ou partie de ses actions à un tiers notifiera son intention, par

lettre recommandée avec accusé de réception, au Conseil d'Administration qui le notifiera immédiatement, aux autres
actionnaires de la Société en précisant notamment:

- pour un cessionnaire personne physique, son nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, et curriculum vitae,
- pour un cessionnaire personne morale, sa dénomination sociale, sa forme, le montant de son capital, le siège, le RCS,

la composition de son actionnariat,

- le nombre d'actions dont la cession est envisagée,
- la valeur par action déterminée sur la base minimum de la valorisation établie lors de la dernière assemblée générale

annuelle de la Société,

- le prix offert par action et les conditions de la cession.
Cette notification de l'actionnaire cédant vaudra promesse unilatérale de vente de sa part.
En cas d'exercice du droit de préemption, le prix par action sera au moins celui déterminé lors de la dernière assemblée

générale annuelle de la Société.

A compter de la réception de cette notification, les actionnaires de la Société disposeront d'un délai de quinze (15)

jours calendaires pour notifier, par tout moyen de communication permettant d'établir date certaine, au Conseil d'Ad-
ministration  leur  décision  d'exercer  leur  droit  de  préemption  et  de  se  porter  acquéreurs  de  la  totalité  des  actions
proposées.

En cas de pluralité d'actionnaires qui désirent se porter acquéreurs, la répartition des actions se fera au prorata de

leurs participations respectives dans le capital de la Société avant l'exercice du droit de préemption. Dans l'hypothèse où
l'intégralité des actions concernées n'aurait pas été préemptée, les actionnaires intéressés pourront notifier au Conseil
d'Administration leur intention d'exercer à nouveau chacun leur droit de préemption respectif sur le solde restant des
actions; les actions étant ainsi réparties entre eux librement sauf convention contraire des actionnaires.

Si dans une cession, le droit des actionnaires n'absorbe pas la totalité des actions dont la cession est projetée, la Société

peut, en vertu d'un droit de préemption subsidiaire, acquérir les actions concernées non préemptées. Elle dispose, à cette
fin, d'un délai complémentaire de trente (30) jours.

Si, à l'expiration du délai de trente (30) jours susmentionné, aucun des actionnaires concernés ou la Société n'a exercé

son droit de préemption ou le droit de préemption n'a pas été exercé sur la totalité des actions concernées, la cession
desdites actions sera soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires pris à l'unanimité des voix exprimées.

47410

L

U X E M B O U R G

Toute cession d'actions à un tiers réalisée en violation des clauses ci-dessus est nulle.
6.3. Agrément
En cas de projet de transfert par un actionnaire de la Société de tout ou partie de ses actions de la Société à un

acquéreur tiers de la Société et sous réserve que les droits de préemption n'aient pas été exercés sur l'intégralité des
actions à céder, l'offre dont le contenu est identique à celui sur base duquel la procédure d'exercice du droit de préemption
a été exercée, sera soumise à l'agrément de tous les actionnaires réunis en assemblée générale et pris à l'unanimité des
voix exprimées.

Toute décision ainsi prise par l'assemblée générale des actionnaires est souveraine et soumise à leur libre appréciation

sans qu'ils soient dans l'obligation de se justifier ou motiver une telle décision de quelque manière que ce soit et/ou à
l'égard de qui que ce soit.

En cas d'agrément, le transfert d'actions devra être réalisé effectivement, conformément aux présentes dispositions,

dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de l'agrément. Pour les besoins des présentes dispositions, tout transfert
non réalisé effectivement conformément aux présentes dispositions et dans le délai d'un (1) mois tel que requis, sera
réputé comme nouveau et donc soumis une nouvelle fois aux procédures de préemption et d'agrément telles que décrites
par les présentes dispositions.

Le prix de rachat des actions du cédant est fixé d'un commun accord. En cas de désaccord persistant, le prix de rachat

pourra être déterminé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du
président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

En cas de refus, l'intégralité des actions de l'actionnaire cédant devra être rachetée par la Société et/ou un ou plusieurs

actionnaires et/ou tout candidat de leur choix, à des conditions et modalités au moins égales à celles contenues dans
l'offre soumise à agrément. La décision sera ensuite notifiée immédiatement par le Conseil d'Administration, par lettre
recommandée avec accusé de réception, à l'actionnaire cédant.

Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

Elles peuvent aussi s'appliquer à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de
réserves, primes d'émission ou bénéfices, ainsi qu'en cas de cession de droits de souscription à une augmentation de
capital par voie d'apports en numéraire ou de renonciation individuelle au droit de souscription en faveur de personnes
dénommées.

6.4. Cessions libres
Les actions sont librement cessibles entre les actionnaires.
Tout transfert d'actions de la Société du fait d'une restructuration de la Société, à quelque titre que ce soit et sous

quelque forme que ce soit, est libre sous réserve qu'une telle restructuration n'aboutisse pas à un changement d'un ou
plusieurs bénéficiaires économiques de la Société; les dispositions relatives à la procédure de préemption et d'agrément
n'étant dés lors pas applicables.

6.5. Décès d'un actionnaire personne physique
Dans l'hypothèse du décès d'un des actionnaires personnes physiques de la Société, seules ses Actions Privilégiées

sans droit de vote reviendront à ses descendants en ligne directe. Quant aux Actions Ordinaires du défunt, ses héritiers
et ayants-droits s'engagent à les échanger auprès de chacun des autres actionnaires, au prorata de leurs participations
respectives au sein de l'actionnariat de la Société, contre des Actions Privilégiées sans droit de vote.

A défaut de descendants en ligne directe, la Société s'engage à racheter l'intégralité de la participation du défunt à un

prix par action basé sur la formule convenue entre les actionnaires de la Société par pacte, puis procèdera à leur annulation.

Les Actionnaires conviennent que les présentes dispositions s'appliquent également aux bénéficiaires économiques des

actionnaires personnes morales de la Société.

Les actionnaires s'engagent, au titre des présentes dispositions, pour eux-mêmes ainsi que, le cas échéant, pour leurs

héritiers et ayants-droits.

6.6. Entrée d'un nouvel actionnaire
Dans l'hypothèse de l'entrée dans le capital de la Société d'un nouvel actionnaire autrement qu'au moyen d'une cession

d'actions  existantes  de  la  Société  par  un  ou  plusieurs  actionnaires,  l'agrément  préalable  de  l'assemblée  générale  des
actionnaires pris aux deux tiers des voix exprimées, est requis. Cet agrément devra également porter sur la nouvelle
répartition du capital de la Société entre les actionnaires (et pas uniquement sur l'identité du nouvel actionnaire).

Art. 7. Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des prescriptions légales, et notamment celles régissant

les Actions Privilégiées sans droit de vote.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse,

les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour représenter l'action à l'égard
de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne
ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

Les actions nominatives soumises à usufruit sont inscrites au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier. Ils sont con-

voqués tous les deux aux Assemblées Générales.

47411

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Les héritiers, ayant-cause et créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, pro-

voquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils doivent
pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et bilans sociaux et aux décisions du Conseil d'Adminis-
tration et de l'Assemblée.

Titre III. Administration

Art. 9. La Société est administrée par un Conseil composé de trois membres au moins, associés ou non, nommés pour

un terme qui ne peut excéder six ans, par l'assemblée générale des actionnaires, et toujours révocables par elle. Toutefois,
lorsque la Société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté
que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre
dénommé administrateur unique jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un
associé.

Le nombre des administrateurs ainsi que leur rémunération et la durée de leur mandat sont fixés par l'assemblée

générale de la Société.

Art. 10. Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un vice-président. En

cas d'empêchement de l'un et de l'autre, ils sont remplacés par l'administrateur le plus âgé.

Le Conseil d'Administration se réunit sur la convocation du président, ou en cas d'empêchement de celui-ci, du vice-

président, ou à leur défaut, de l'administrateur le plus âgé, aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige. Il doit être
convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Lorsque le conseil d'administration est limité à un administrateur unique, cet article n'est pas d'application.

Art. 11. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration

et de disposition qui rentrent dans l'objet social. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expres-
sément par la loi et les statuts à l'assemblée générale. De plus, il est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, aux
conditions prévues par la loi.

Art. 12. La Société est engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par

la signature d'un administrateur-délégué ou par la signature de l'administrateur unique, sans préjudice des décisions à
prendre quant à la signature sociale en cas de délégation de pouvoirs et mandats conférés par le Conseil d'Administration
en vertu des dispositions de l'article 13 des statuts.

Art. 13. Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Art. 14. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la Société par le Conseil

d'Administration, poursuites et diligences de son président, d'un administrateur délégué à ces fins ou de l'administrateur
unique.

Titre IV. Surveillance

Art. 15. La Société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six ans.

Dans le cas où la Société dépasserait deux des trois critères de l'article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002

concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises,
l'institution du commissaire aux comptes sera supprimée et un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, choisis parmi les
membres de l'institut des réviseurs d'entreprises, seront désignés par l'assemblée générale, qui fixera la durée de leur
mandat qui ne pourra pas excéder six années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 16. L'Assemblée Générale Annuelle se réunit au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations,

le premier mardi du mois de juin à 14.00 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.
Lorsque la Société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 17. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et finit le 31 décembre de la même année.

Art. 18. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la Société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé:

47412

L

U X E M B O U R G

1. cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque

la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à
un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé;

2. telles sommes que, sur proposition du Conseil d'Administration, l'Assemblée Générale décide d'affecter à la dotation

de fonds de réserve ou de prévision, ou de reporter à nouveau.

3. le surplus du bénéfice est réparti comme suit:
a) il sera payé aux Actions Privilégiées sans droit de vote un dividende prioritaire annuel brut de 10 € (dix euros)

équivalent à quatre pour cent (4 %) de la valeur nominale, prorata temporis.

En cas d'absence ou d'insuffisance des bénéfices d'un ou plusieurs exercices pour payer ce dividende prioritaire, celui-

ci ou son reste sera récupérable sur les exercices utiles des années suivantes, les dividendes arriérés étant payés dans
l'ordre de leur ancienneté avant le dividende prioritaire de l'année.

b) du solde éventuel, il sera procédé à une répartition uniforme entre toutes les actions sans distinction de catégorie

au prorata de leur libération et prorata temporis, sur proposition du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'administration est autorisé, dans la mesure et sous les conditions prévues par la loi, à procéder à des

versements d'acomptes sur dividendes.

Le dividende est payable aux époques et lieux qui sont fixés par le Conseil d'Administration. Les dividendes non

réclamés dans les cinq (5) ans à dater de leur exigibilité seront prescrits au profit de la Société et versés au fonds de
réserve.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 19. La Société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 20. En cas de liquidation de la Société, l'avoir social, après déduction de toutes les dettes, est affecté dans l'ordre

de priorité suivant:

1. au remboursement aux Actions Privilégiées sans droit de vote;
2. au remboursement aux Actions Ordinaires.
Si après les opérations de remboursement mentionnées à l'alinéa précédent, il reste un surplus, celui-ci sera affecté

au paiement des dividendes prioritaires accrus, dans l'ordre de priorité fixé au point 3 de l'article 18; le solde éventuel
sera réparti également entre toutes les actions émises sans distinction de catégorie.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 21. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et de ses lois modificatives.

<i>Septième résolution

L'assemblée décide de fixer le nombre des administrateurs à 3 et de nommer à la fonction d'administrateur, leurs

mandats expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2020:

- Madame Dalia LION, sans état particulier, née à Haïfa, (Israël), le 2 mars 1943, demeurant à L-1851 Luxembourg, 12,

rue Gustave Kahnt,

- Monsieur Moshe BAHBOUT, commerçant, né à Beyrouth (République Libanaise) le 31 mars 1940, demeurant à

L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave Kahnt,

- Monsieur Eli BAHBOUT, employé privé, né à Haïfa, (Israël), le 17 mars 1968, demeurant à L-2523 Luxembourg, 70,

rue Jean Schoetter.

<i>Huitième résolution

L'assemblée décide de nommer à la fonction de commissaire aux comptes, son mandat expirant lors de l'assemblée

générale de 2020:

SWL S. à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 121 avenue de la Faïencerie,

immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 85782.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée décide, à titre exceptionnel, que le premier Président du Conseil d'Administration et les premiers admi-

nistrateurs-délégués seront nommés par la première assemblée générale des actionnaires, désignant le premier conseil
d'administration, à savoir:

- Monsieur Moshe BAHBOUT, commerçant, né à Beyrouth (République Libanaise) le 31 mars 1940, demeurant à

L-1851 Luxembourg, 12, rue Gustave Kahnt, en qualité de Président du conseil d'administration et d'administrateur-
délégué avec pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule signature dans le cadre de la gestion journalière;

47413

L

U X E M B O U R G

- Monsieur Eli BAHBOUT, employé privé, né à Haïfa, (Israël), le 17 mars 1968, demeurant à L-2523 Luxembourg, 70,

rue Jean Schoetter, en qualité d'administrateur-délégué, avec le pouvoir d'engager valablement la Société par sa seule
signature dans le cadre de la gestion journalière

<i>Evaluation des frais

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 2.000,- EUR.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Howald, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'elle agit, connue du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Laure SINESI, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 18 février 2015. Relation GAC/2015/1347. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015036596/359.
(150040980) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

Food Delivery Holding 7. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 192.174.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mars 2015

En date du 4 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à

l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.

En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Ralf WENZEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Food Delivery Holding 7. S.à r.l.

Référence de publication: 2015036981/20.
(150041804) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Fashion and Cosmetics Isabelle T, Société Anonyme.

Siège social: L-8010 Strassen, 244, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 45.786.

Madame Isabelle Thuillier, administrateur et administrateur-délégué, et Monsieur Vladimir Ivanov, administrateur, de-

meurent tous les deux professionnellement au 244, route d'Arlon, L-8010 Strassen, avec effet immédiat.

Il résulte de décisions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2011 que le mandat de Madame Isabelle

Thuillier, administrateur-délégué, demeurant professionnellement au 244, route d'Arlon, L-8010 Strassen, est prorogé
jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire de l'année 2017 approuvant les comptes de l'année 2016.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Fiduciaire comptable B+C S.à.r.l.

Référence de publication: 2015036985/15.
(150042045) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

47414

L

U X E M B O U R G

Fitness &amp; Bikes Support S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 175.284.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La société
Signature

Référence de publication: 2015036990/11.
(150042208) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Flocapu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 184.541.

EXTRAIT

L'assemblée générale du 4 mars 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Stéphanie GRISIUS, Administrateur, M. Phil. Finance B. Sc. Economics, 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg,

Luxembourg;

- Monsieur Laurent HEILIGER, Administrateur, licencié en sciences commerciales et financières, 6, rue Adolphe, L-1116

Luxembourg, Luxembourg;

-  Madame  Nathalie  GAUTIER,  Administrateur-Président,  Master  Administration  des  Entreprises,  6,  rue  Adolphe,

L-1116 Luxembourg, Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
L'assemblée générale du 4 mars 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

<i>Pour FLOCAPU S.A.
Société anonyme

Référence de publication: 2015036992/22.
(150041850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Greyswan Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 134.380.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037014/10.
(150041799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Gantner &amp; Laux Malerbetrieb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 123.558.

AUSZUG

Aus einem Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft mit beschränkter Haftung GANTNER &amp; LAUX MALERBETRIEB

S.à r.l., mit Sitz in L-5447 Schwebsingen, 111, route du Vin, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxem-
burg unter der Nummer B 123.558, vom 30. Januar 2015 geht hervor dass:

- der Rücktritt von Herrn Kevin SCHWINDLING als technischer Geschäftsführer angenommen wurde und ihm Ent-

lastung für die Ausübung seines Mandates erteilt wurde;

- Herr Timo KALUZA, geboren in Freudenstadt (Deutschland), am 13. Juni 1985, wohnhaft in D-66693 Mettlach,

Cloefstrasse 76A, zum technischen Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer ernannt wurde;

47415

L

U X E M B O U R G

- das Mandat von Herrn Daniel GANTNER und von Herrn Sandy LAUX als administrative Geschäftsführer bestätigt

wurde.

Die Gesellschaft wird in allen Fällen durch die gemeinsame Unterschrift der drei Geschäftsführer rechtsgültig vertreten

und verpflichtet.

Echternach, den 3. März 2015.

Henri BECK
<i>Notar

Référence de publication: 2015037017/22.
(150041423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

International Trading and Engineering S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 131.501.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037093/10.
(150041721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Investazur S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 128.010.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 26 février 2015

Il résulte du jugement du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg (jugement n°270/15), 6 

ème

 Chambre, sié-

geant en matière commerciale que les opérations de liquidation de la société anonyme INVESTAZUR SA., dont le siège
social à L-2163 Luxembourg, 29, Avenue Monterey, a été dénoncé en date du 29 octobre 2010, ont été déclarées closes
pour absence d'actif.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait conforme
Maître Nathalie WEBER-FRISCH
<i>Le liquidateur
1, rue Jean-Pierre Brasseur
L-1258 Luxembourg

Référence de publication: 2015037096/18.
(150042100) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Inyxa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 164.102.

Les comptes annuels au 30 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037097/10.
(150041797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Ishtar Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 73.786.

Par jugement rendu en date du 12 février 2015, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg sixième chambre,

siégeant en matière commerciale, après avoir entendu le juge commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Mi-
nistère Public en leurs conclusions, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société anonyme
ISHTAR HOLDING SARL en liquidation, préqualifiée et a mis le solde à la charge du Trésor.

47416

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 19 février 2015.

Pour extrait conforme
Amir MIR MOTAHARI
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015037098/15.
(150041809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

IVP LuxCo 2014 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 185.456.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 3 mars 2015

En date du 3 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- d'accepter la démission de Monsieur Joseph SANFORD MILLER de son mandat de gérant de la Société avec effet

immédiat;

- de nommer Madame Tracy HOGAN, née le 23 septembre 1970 à Bridgeport, Connecticut, Etats-Unis d'Amérique,

résidant professionnellement à l'adresse suivante: 3000 Sand Hill Road, Building 2, Ste 250 Menlo Park, Menlo Park,
Californie 94025-7153, Etats-Unis d'Amérique, en tant que nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce pour
une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

IVP LuxCo 2014 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015037103/20.
(150042064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

JB Advisory, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1950 Luxembourg, 14, rue Auguste lumière.

R.C.S. Luxembourg B 187.930.

EXTRAIT

Par résolutions prises en date du 16 février 2015, le gérant unique de JB ADVISORY S.à r.l. a transféré le siège social

de la société au 14 rue Auguste Lumière L1950 Luxembourg, avec effet au 20 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015037105/13.
(150041641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

JPP Polymere S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8437 Steinfort, 23, rue de Koerich.

R.C.S. Luxembourg B 169.813.

<i>Extrait de la résolution prise par l'Administrateur unique de la société le 15 décembre 2014

Il résulte de la dite résolution:
Le transfert, avec effet immédiat, du siège social de la société de son adresse actuelle au 23, rue de Koerich L-8437

Steinfort

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015037108/15.
(150042008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

47417

L

U X E M B O U R G

Kids Care Gestion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.394,68.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 23, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 49.108.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'associée unique tenue extraordinairement le 2 mars 2015

Il est noté la cession de l'intégralité des parts sociales, soit 500, de Kidscare Sarl en faveur de EUROPE CRECHE &amp;

KINDERGARTEN, RCS Luxembourg B 182.259, 23 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

L'Associée accepte la démission de Madame Béatrice MARTIN de son poste de gérante unique.
L'Associée décide de nommer au poste de gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Fabrice Martinez, né le 8 décembre 1967 à Binche, domicilié au 11 rue Remy Thiel, F-57100 Thionville
- Stanislas Lavorel, né le 26 mai 1972 à Lyon (FR), domicilié au 23 rue du Nord, L-2229 Luxembourg
L'Associée décide que vis à vis des tiers, la société est valablement engagée et représentée par la signature conjointe

de deux gérants.

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société au 23 avenue Monterey, L-2163 Luxembourg.

Dandois &amp; Meynial

Référence de publication: 2015037110/19.
(150042056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Kleopatra Lux 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 128.331.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Kleopatra Lux 2 S.à r.l.
J. Goffin / C. Tschepe
<i>Gérant / Gérant

Référence de publication: 2015037115/13.
(150041752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Karsika Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 133.862.

EXTRAIT

Il résulte de l'Assemblée Générale tenue Extraordinairement en date du 25 février 2015 que:
- Monsieur Paolo PASSARO et Monsieur Eric VANDERKERKEN ont démissionnés de leur fonction d'administrateur.
- Madame Elena LATORRE, employée privée, née le 6 décembre 1975 à Luxembourg et demeurant professionnelle-

ment au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg et Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, né le 30 septembre
1975 à Liège (Belgique) et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg, ont été nommés
administrateurs en remplacement des administrateurs démissionnaires.

Leur mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.
- Est réélu administrateur et président, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale qui se tiendra en 2021,

Madame Orietta RIMI, employée privée, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie) et demeurant professionnellement au
10 rue antoine Jans L-1820 Luxembourg.

- Est réélu commissaire, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021, SER.COM S.à

r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19 boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

- Le siège social a été transféré du 26/28 rives de Clausen L-2165 Luxembourg au 10 rue Antoine Jans L-1820 Lu-

xembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015037117/23.
(150041859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

47418

L

U X E M B O U R G

Kergral S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 30.574.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 05.03.2015.

<i>Pour: KERGRAL S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015037121/14.
(150042215) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Kismet Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 111.397.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037126/10.
(150041490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Kualibat S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3858 Schifflange, 22, rue Denis Netgen.

R.C.S. Luxembourg B 158.960.

Le Bilan au 31 Décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015037132/10.
(150041486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

La Table de Léon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3237 Bettembourg, 17, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.156.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 décembre 2014

1) L'assemblée générale valide la cession de parts sociales signée en date du 21 novembre 2014.
Madame Odile Gallo, demeurant 29 rue Michel Hack à L-3240 Bettembourg, cède 100 (cent) parts sociales lui appar-

tenant dans la société La Table de Léon sàrl à Monsieur Serge FALCOMER, demeurant 20, Boucle du Millénaire à F-57190
Florange.

Monsieur Serge FALCOMER devient associé unique de la société.
2) L'assemblée accepte la démission de Madame Odile Gallo, préqualifiée, de son poste de gérante technique notifié

en date de 15 décembre 2014.

3) Madame SCHAMMÉ Joseline Fosca, demeurant 54 Allée Raymond Poincaré, F-57100 Thionville, est nommée gérante

technique de la société pour une durée indéterminée.

4) Monsieur Serge FALCOMER, pré-qualifiée, est nommé gérant administratif de la société pour une durée indéter-

minée.

La société se trouve valablement engagée par la signature conjointe du gérant administratif et de la gérante technique.

Dont acte, fait et passé à Bettembourg, au siège de la société le 15 décembre 2014.

47419

L

U X E M B O U R G

Pour extrait conforme
Serge FALCOMER

Référence de publication: 2015037134/23.
(150042351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Letterone Corporate Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 181.081.

EXTRAIT

Monsieur Jonathan MUIR, gérant de la Société, a changé d'adresse comme suit:
1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Référence de publication: 2015037136/13.
(150041700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Letterone Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1-3, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 176.010.

EXTRAIT

Monsieur Jonathan MUIR et Monsieur David GOULD, tous deux administrateurs de Classe I de la Société, ont changé

d'adresse comme suit:

- Jonathan MUIR: 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- David GOULD: 1-3, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Référence de publication: 2015037137/14.
(150041670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Lion/Gem Lux 1 SCA, Société en Commandite par Actions.

Capital social: EUR 1.187.213,00.

Siège social: L-1748 Luxembourg-Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 141.354.

Les comptes annuels pour l'année 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015037141/12.
(150042213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Little Bird Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 173.289.

<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 17 février 2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 17 février 2015, que:
- L'Assemblée Générale nomme en tant que Gérante de la société Monsieur Sylvain Kirsch, ayant son adresse pro-

fessionnelle au 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg. La durée du mandat débute au 17 février 2015 pour une durée
indéterminée.

47420

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015037146/16.
(150042200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Little Bird Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 173.289.

Les comptes annuels au 30 septembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015037147/10.
(150042203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Lux'n Com S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3583 Dudelange, 12, rue des Lamineurs.

R.C.S. Luxembourg B 190.191.

La Société Lux'n Com SA déclare que:
Monsieur VALENTIN- BIEDERMANN Laurent Nicolas a changé d'adresse, il demeure à présent 12 Rue des Lamineurs

L- 3583 DUDELANGE.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Dudelange, le 16/02/2015.

Mr Laurent Nicolas VALENTIN- BIEDERMANN / Mme C. SIMON / Mme A.VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015037151/16.
(150042356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Luxaro Retail Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 177.170.

<i>Extrait de la résolution des Actionnaires tenue à Luxembourg le 27 février 2015

<i>Première résolution

Acceptation de la démission des Gérants de catégorie C avec effet au 02/03/2015:
a) Acceptation de la démission de Mr. Gérard Birchen, gérant de catégorie C de la société.
b) Acceptation de la démission de Mr. Nicolas Gasztonyi, gérant de catégorie C de la société.

<i>Deuxième résolution

Nomination des nouveaux Gérants de catégorie C avec effet au 02/03/2015:
a) Mr. Eriks Martinovskis, résidant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.
b) Mr. Xavier Soulard, résidant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg.

<i>Troisième résolution

Décision de transférer le siège social de la société du L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert au L-1143 Luxem-

bourg, 24, rue Astrid.

Le mandat des nouveaux gérants de catégorie C, prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire statutaire de l'an 2020.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015037152/21.
(150041518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

47421

L

U X E M B O U R G

Luxas S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 51, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 185.685.

Les comptes relatifs à la période du 14 mars 2014 au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et

des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037153/10.
(150042150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

James S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 169.469.

L'an deux mil quatorze, le six novembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.
KAISERSTADT HOLDING S.A., avec siège social au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg, enregistrée au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184 892,

ici représentée par son administrateur unique, Monsieur Paolo PANICO, administrateur unique, demeurant profes-

sionnellement au 92, rue de Bonnevoie, L-1260 Luxembourg,

en sa qualité d'associé unique de la société responsabilité limitée de droit luxembourgeois dénommée JAMES S.à.r.l.,

ayant son siège social à Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie, inscrite au R.C.S. Luxembourg, sous la Section B et le numéro
169.469,

constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 5 juillet 2012, publié au Mémorial C n° 1760 du 12 juillet 2012,

dont les statuts n'ont jamais été modifiés entretemps,

déclare et prie le notaire d'acter:
I: Que l'ordre du jour des présentes est conçu comme suit:
- Modification de l'objet social en vue d'y comprendre l'activité de conseil stratégique.
III: Ensuite l'associé unique prend la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'associé unique décide de modifier l'objet social de la société en y incluant l'activité de conseil stratégique,
de sorte que l'article 2 des statuts se lira dorénavant en langue anglaise suivi d'une traduction française, comme suit:

Version anglaise

Art. 2.
2.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in

any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.

2.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect member of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the "Connected Companies"). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets.

2.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-

lectual property rights of any nature or origin whatsoever.

2.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose

of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.

2.5. The Company may carry out for its own account any commercial and/or financial transactions with respect to

direct or indirect investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring,

47422

L

U X E M B O U R G

letting, leasing, renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise
alienating, mortgaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.

2.6. The Company may carry out strategic consulting and advisory services.
2.7. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.

Traduction française

Art. 2.
2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, sous quelque forme que ce

soit, et la gestion de ces participations. La Société pourra en particulier acquérir par voie de souscription, achat, échange
ou de toute autre manière des actions, parts et autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse, certificats de dépôt
et autres instruments de dettes et plus généralement toutes valeurs mobilières et instruments financiers émis par toute
entité publique ou privée.

2.2. La Société pourra également apporter toute assistance financière, que ce soit sous forme de prêts, d'octroi de

garanties ou autrement, à ses filiales ou aux sociétés dans lesquelles elle a un intérêt direct ou indirect, sans que celui-ci
ne soit substantiel, ou à toute société qui serait actionnaire direct ou indirect de la Société, ou encore à toute société
appartenant au même groupe que la Société (ci-après reprise comme les «Sociétés Apparentées»). La Société pourra
accorder toute garantie, fournir tout gage ou toute autre forme de sûreté, que ce soit par engagement personnel ou par
hypothèque ou charge sur tout ou partie des avoirs (présents ou futurs), ou par l'une et l'autre de ces méthodes, pour
l'exécution de tout contrat ou obligation de la Société ou de Sociétés Apparentées

2.3. La Société pourra en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets et/ou autres droits

de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.

2.4. La Société peut, d'une manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en

vue d'une gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit,
change, taux d'intérêt et autres risques.

2.5. La Société peut faire pour son propre compte toutes opérations commerciales et/ou financières en relation directe

ou indirecte avec des investissements de propriété mobilières et immobilières y compris mais non limité à l'acquisition,
la possession, le louage, la location, le leasing, le bail, la division, le drainage, la réclamation, le développement, l'amélio-
ration, la culture, la construction, la vente ou toute autre aliénation, hypothèque, gage ou toute autre obstruction de
propriété mobilière ou immobilière.

2.6. La Société peut prester des services de conseil stratégique.
2.7. L'énumération qui précède est purement énonciative et non limitative.

<i>Frais

Le montant des frais, coûts, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société au

présent acte, est estimé à EUR 1400.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes,
Le présent acte ayant été lu en langue française au comparant, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec nous, notaire, le présent acte les actionnaires présents, ayant également demandé à signer.

Signé: P. Panico et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 14 novembre 2014. LAC/2014/53621. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 mars 2015.

Référence de publication: 2015036409/89.
(150041246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

FGP XII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 165.531.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Référence de publication: 2015036327/10.
(150041121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.

47423

L

U X E M B O U R G

TES Global Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 269.879,25.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 178.804.

EXTRAIT

En date du 20 février 2015, Louise Rogers à transféré à Appleby Trust (Jersey) Limited les parts sociales suivantes:
- 74.819 Parts Sociales de Classe A Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe B Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe C Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe D Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe E Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe F Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe G Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe H Catégorie SWE-2;
- 74.819 Parts Sociales de Classe I Catégorie SWE-2;
- 74.820 Parts Sociales de Classe J Catégorie SWE-2.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Référence de publication: 2015037453/22.
(150042040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Venglo Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 83.632.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 3 mars 2015

Sont nommés administrateurs, leurs mandats prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2016:

- Monsieur Carl HEGGLI, avocat, demeurant à 4, rue de l'Université, CH-1205 Genève, Président du Conseil d'Ad-

ministration,

- Monsieur Jean-François DUCREST, avocat, demeurant à, 4, rue de l'Université, CH-1205 Genève,
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2 avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2016:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg

Luxembourg, le 3 mars 2015.

Pour extrait

Référence de publication: 2015037471/20.
(150042364) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

VEREF I Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 154.388.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mars 2015.

Référence de publication: 2015037472/10.
(150042312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

47424


Document Outline

AEW Europe S.à r.l.

Digital Services XXX S.à r.l.

Fashion and Cosmetics Isabelle T

FGP XII S.à r.l.

Fitness &amp; Bikes Support S.A.

Flocapu S.A.

Food Delivery Holding 7. S.à r.l.

Gantner &amp; Laux Malerbetrieb S.à r.l.

Globetrot Investments

Greenlit Consultancy S.à r.l.

Greyswan Invest S.à r.l.

International Trading and Engineering S.A.

Investazur S.A.

Inyxa S.A.

Ishtar Holding S.à r.l.

IVP LuxCo 2014 S.à r.l.

James S.à r.l.

JB Advisory

JPP Polymere S.A.

Karsika Invest S.A.

Kergral S.A.

Kids Care Gestion S.à r.l.

Kismet Properties S.à r.l.

Kleopatra Lux 2 S.à r.l.

Kualibat S.à r.l.

La Table de Léon S.à r.l.

Letterone Corporate Partner S.à r.l.

Letterone Holdings S.A.

Lion/Gem Lux 1 SCA

Little Bird Securitization S.à r.l.

Little Bird Securitization S.à r.l.

Luxaro Retail Holding S.à r.l.

Luxas S.à r.l.

Lux'n Com S.A.

Plantes Tropicales Services S.à r.l.

Plaza Group S.A.

PMS Partners S.A.

Racines S.A.

Racines S.à r.l.

TES Global Investments S.à r.l.

Venglo Holding S.A.

VEREF I Management S.à r.l.