This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 985
14 avril 2015
SOMMAIRE
Alteralia SCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47247
Alteralia S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .
47247
Articvision S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47239
Banque Internationale à Luxembourg . . . .
47242
Barclays Metis Investments S.à r.l. . . . . . . .
47280
BNP Paribas LDI Solution . . . . . . . . . . . . . .
47237
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l. . . .
47278
Cofinalux S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47278
Dundee International (Luxembourg) In-
vestments 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47277
ECE European Prime Shopping Centre II B
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47263
ECE European Prime Shopping Centre II
C, SCSp SIF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47280
Exclusif esthétique S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
47257
Fiduciaire Nationale de Révision Compta-
ble S.A., FIDAUDIT succursale de Lu-
xembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47235
Food Delivery Holding 11 S.à r.l. . . . . . . . .
47274
Grey Juice Lab. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47242
Harkand Luxembourg Holdings S.à.r.l. . . .
47274
Hermes Universal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47234
Hodge Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47260
Hubema S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47234
Invesco Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47243
JC Aviation (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . . .
47237
JNC Ameublements S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
47278
JPLFGDM Securitization S.à r.l. . . . . . . . . .
47242
JPMorgan Investment Funds . . . . . . . . . . . .
47240
JPMorgan Liquidity Funds . . . . . . . . . . . . . . .
47238
JS Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47236
KBC Interest Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47235
Kim'Mobilière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47241
La Mancha International GEC S.à r.l. . . . .
47235
Lseg LuxCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47247
Luxembourg Finance House S.A. . . . . . . . .
47240
L & Y International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
47236
Mantex SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47236
Parvest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47241
Planalto S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47246
Pro Fonds (Lux) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47239
Prolifica International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
47238
Sensata Management Company S.A. . . . . .
47244
Sharp S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47234
Sibelco Laos Invest S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . .
47275
Vontobel Asset Management S.A. . . . . . . .
47264
Wogema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47260
47233
L
U X E M B O U R G
Sharp S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 194.819.
En date du 3 mars 2015, l'associé unique de la Société, International Pyramide Holdings (Luxembourg) S.A. a transféré
1,250,000 parts sociales de la Société à:
- First State Infrastructure S.à r.l.
11-13, Boulevard de la Foire
L-1528 Luxembourg
Grand-Duché du Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Gwenaëlle Cousin
<i>Gérant Uniquei>
Référence de publication: 2015037375/17.
(150041658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Hubema S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 105.595.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>23 avril 2015i> à 14.30 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015050221/833/18.
Hermes Universal, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 114.409.
Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui aura lieu le <i>24 avril 2015i> à 13 h 00, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2014.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises.
4. Election des administrateurs et du réviseur d'entreprises.
5. Divers.
Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer vala-
blement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix des actionnaires présents ou
représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015049600/755/19.
47234
L
U X E M B O U R G
La Mancha International GEC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 178.257.
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société en date du 12 janvier 2015 que:
- Madame Iman Hassan Ahmed Naguib démissionne de son poste de gérant de catégorie A de la société avec effet
immédiat;
- Monsieur Geoffroy d'Hauteville, né le 16 février 1973 à Paris (France) et demeurant 72 avenue Victor Hugo, 75116
Paris (France) été nommé en remplacement du gérant de catégorie A démissionnaire avec effet immédiat et ce pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015035805/15.
(150039893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
Fiduciaire Nationale de Révision Comptable S.A., FIDAUDIT succursale de Luxembourg, Succursale
d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1952 Luxembourg, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre.
R.C.S. Luxembourg B 154.811.
<i>Extrait des délibérations de l'Assemblée Générale Mixte et du Conseil d'administration tenus au siège social en date du 28 marsi>
<i>2013i>
Modification des données relatives à la personne morale de droit étranger
<i>Délibérations:i>
Personne(s) ayant le pouvoir d'engager la société:
Organe: Conseil d'administration
Le remplacement de CORRÉARD Jocelyne, Administrateur et Directeur Général Délégué, domiciliée Chemin de
Bouscaron, Mas des Aubes, F-13940 Mollèges par PINHAS Jean-Jacques, Administrateur, domicilié 40, Route des Bré-
guières - Les Terrasses du Soleil -06110 LE CANNET.
Référence de publication: 2015037379/17.
(150042024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
KBC Interest Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 30.382.
Nous avons l'honneur de vous convier à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
des actionnaires de la Société (l'Assemblée) qui se tiendra au siège social le <i>22 avril 2015i> à 11h00 (heure de Luxem-
bourg) avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Election de Monsieur Jos LENAERTS en tant qu'administrateur de la Société jusqu'à l'assemblée générale statutaire
de 2020
Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum et sont adoptées à la simple majorité
des voix exprimées à l'Assemblée. Des procurations sont disponibles au siège social de la Société.
Par délégation d'European Fund Administration agissant en tant que dépositaire au sens prévu par la loi du 28 juillet
2014 relative à l'immobilisation et à la tenue du registre des actions au porteur (la Loi de 2014), les détenteurs d'actions
au porteur souhaitant participer à l'Assemblée sont tenus d'immobiliser leurs actions cinq jours ouvrables avant l'As-
semblée auprès de KBL European Private Bankers S.A., 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg (KBL) permettant ainsi
l'inscription de leurs actions dans le registre des actions au porteur.
Les droits afférents aux actions au porteur ne pourront être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès
de KBL conformément à la Loi de 2014.
Référence de publication: 2015049605/755/22.
47235
L
U X E M B O U R G
L & Y International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 71.100.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2015i>
1. La liquidation de la société L&Y INTERNATIONAL S.A. est clôturée.
2. Décharge est accordée au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats.
3. Les livres et documents sociaux sont déposés au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et y seront conservés
pendant cinq ans au moins.
Extrait certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015037133/14.
(150041636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
JS Holding AG, Société Anonyme.
Siège social: L-5440 Remerschen, 34, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 148.726.
Bei Gelegenheit der jährlichen Generalversammlung vom 16. Januar 2014 wird G.T. Fiduciaires S.A., mit Sitz in L-1273
Luxemburg, 19, rue de Bitbourg, zum neuen Kommissar ernannt, sie ersetzt die ausscheidende G.T. Experts Comptables
s.àr.l.
Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsratsmitgliedes, sowie des neuen Kommissars werden verlängert und enden
bei Gelegenheit der Jahreshauptversammlung, die im Jahre 2019 stattfinden wird.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. März 2015.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2015037109/16.
(150041426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Mantex SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 166.612.
Notice is hereby given to the shareholders of Mantex Sicav (the "Company"), that the
ANNUAL GENERAL MEETING
shall be held at the Registered Office of the Company on <i>21 April 2015i> at 11:00 CET (the"Meeting"), with the following
<i>Agenda:i>
1. Approval of the Board of Directors and the Auditor Report for the fiscal year ended December 31st, 2014.
2. Approval of the Financial Statements for the fiscal year ended December 31st, 2014.
3. Distribution Policy - dividend payments.
4. Approval of the conduct of the Directors and Auditors with respect to the respective mandate obligations during
the year ended 31 December 2014.
5. Appointment of the Board of Directors and of the Auditors for the financial year ending 31st December 2015.
All resolutions of the items on the agenda are passed without quorum, by a majority of the votes cast thereon at the
Meeting. Each share is entitled to one vote. Each Shareholder may act at any Meeting by proxy. Proxy forms can be
obtained from the Registered Office of the Company.
Shareholders may personally attend the Meeting provided that, for organisational reasons, the Company has been
notified in writing of such an intention no later than April 17th 2015. Shareholders unable to personally attend the Meeting
are kindly invited to send a duly completed and signed proxy form to be delivered to the Company no later than April
17th 2015.
<i>By order of the Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015050924/755/24.
47236
L
U X E M B O U R G
JC Aviation (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 161.517.
EXTRAIT
Modification au dépôt n° L 140 095 862 du 10.06.2014
- Les démissions de M. Christian BÜHLMANN et de Mme Claire-Hélène DUPONT de leurs fonctions d'administra-
teurs de la Société ont été acceptées avec effet au 31 mai 2014.
- La cooptation de:
* M. Fabrice HUBERTY, employé privé, né le 21 juillet 1970 à Bastogne (Belgique), résidant professionnellement au
127, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg;
et de
* M. Nicolas MILLE, employé privé, né le 8 février 1978 à Antony (France), résidant professionnellement au 127, rue
de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.
en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 31 mai 2014 jusqu'au 9 juin 2017 a été décidée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
JC AVIATION (LUXEMBOURG) S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015037106/21.
(150042461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
BNP Paribas LDI Solution, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 108.079.
The
STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Tuesday <i>April 28, 2015i> at 10:00 a.m., at the Offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
located at 33, rue de Gasperich, Building H2O, block A, ground floor, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg,
in order to deliberate on the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2014 and allocation of the
results;
3. Discharge to the Directors for the performance of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
Pursuant to the Luxembourg Law of 28 July 2014 regarding immobilisation of bearer shares, voting rights attached to
bearer shares not immobilised by 18 February 2015 as described in the notice published on 23 January 2015 will auto-
matically be suspended. The holders of these shares will no longer be admitted to the General Meeting, nor included in
the quorum calculation or when voting majorities, until such time as the shares are immobilised.
The shareholders must express their intention to take part in the Meeting at the latest five (5) business days before
the date of the Meeting. They will be admitted at the Meeting upon proof of their identity and presentation of a share(s)
blocking certificate.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office
of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request,
either by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015048925/755/33.
47237
L
U X E M B O U R G
Prolifica International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 102.684.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
<i>Pour: PROLIFICA INTERNATIONAL S.A.
i>Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015036578/14.
(150041149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
JPMorgan Liquidity Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 25.148.
Notice is hereby given to the shareholders that the
ANNUAL GENERAL MEETING
will be held at the registered office of the Fund on <i>24 April 2015i> at 11.00 CET, with the following agenda <i>:i>
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report from Auditors and Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board for the performance of its duties for the past fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors' fees?
5. Should the following Directors be reappointed to the Board? Jacques Elvinger, Jean Frijns, John Li, Iain Saunders,
Peter Schwicht
6. Should shareholders confirm the appointment of Mr. Daniel Watkins, co-opted by the Board of Directors with
effects from 13
th
December 2014, in replacement of Mr. Berndt May, and his election to serve as a Director of
the Company?
7. Should Mr. Massimo Greco be appointed to the Board?
8. Should shareholders re-appoint PricewaterhouseCoopers, Société cooperative as its Auditors?
9. Should shareholders approve the payment of any distributions shown in the Audited Annual Report for the past
fiscal year?
10. Consideration of any other item that is properly presented for a vote.
All appointments being voted on are for terms that end at the next annual general meeting.
To vote by proxy, use the proxy form at jpmorganassetmanagement.com/extra. Your form must arrive at the registered
office, via post or fax, by 18.00 CET on Wednesday, 22 April 2015.
To vote in person, attend the meeting in person.
Quorum: None required.
Voting: Agenda items will be resolved by a simple majority of the votes cast.
THE FUND
Name
JPMorgan Liquidity Funds
Legal form
SICAV
Fund type
UCITS
Auditors
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Registered office
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax
+352 3410 8000
Registration number
(RCS Luxembourg)
B 25.148
Past fiscal year
12 months, ended 30 November 2014
Référence de publication: 2015049603/755/40.
47238
L
U X E M B O U R G
Articvision S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 98.836.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 5 janvier 2015:i>
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Monsieur Claudio TOMASSINI, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur;
- Monsieur Henri REITER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux fonctions
d'administrateur;
- Monsieur Jacques RECKINGER, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, aux
fonctions d'administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-
cembre 2020.
L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.
COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Référence de publication: 2015036781/23.
(150042034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Pro Fonds (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 45.890.
Die Aktionäre der Pro Fonds (Lux) werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre eingeladen, die am <i>24. April 2015i> um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
mit folgender Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 31. Dezember 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember
2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für das abgelaufene Geschäftsjahr
4. Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder Nikolaus Rummler, Dr. Urban Bacher, Ole Klose und Marco Herrmann
bis zur Ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2018
5. Wiederwahl des Wirtschaftsprüfers PricewaterhouseCoopers Société coopérative bis zur nächsten Ordentlichen
Generalversammlung im Jahr 2016
6. Verwendung der Erträge
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-
fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der
Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.
Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung
einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft fünf Tage vor der
Generalversammlung vorliegen.
Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Pro Fonds (Lux) (DZ PRIVATBANK S.A.)
per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015049609/755/31.
47239
L
U X E M B O U R G
Luxembourg Finance House S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 53.589.
<i>Rectificatif de l'avis déposé au RCS sous la référence L150040779 en date du 4 mars 2015i>
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 2 mars 2015i>
L'assemblée a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouvel administrateur:
Mr. Marten Peter Niemantsverdriet, ayant son adresse professionnelle au Jan Van Rijswijcklaan 162, B-2020 Antwerpen.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire à tenir en l'an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015037199/14.
(150041528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
JPMorgan Investment Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 49.663.
Notice is hereby given to the shareholders that the
ANNUAL GENERAL MEETING
will be held at the registered office of the Fund on <i>24 April 2015i> at 12.00 CET, with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Presentation of the report from Auditors and Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board for the performance of its duties for the past fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors' fees?
5. Should the following Directors be reappointed to the Board? Jacques Elvinger, Jean Frijns, John Li, Iain Saunders,
Peter Schwicht
6. Should shareholders confirm the appointment of Mr Daniel Watkins, co-opted by the Board of Directors with
effect from 13
th
December 2014, in replacement of Mr. Berndt May, and his election to serve as a Director of the
Company?
7. Should Mr. Massimo Greco be appointed to the Board?
8. Should shareholders re-appoint PricewaterhouseCoopers, Société cooperative as its Auditors?
9. Should shareholders approve the payment of any distributions shown in the Audited Annual Report for the past
fiscal year?
10. Consideration of any other item that is properly presented for a vote.
All appointments being voted on are for terms that end at the next annual general meeting.
To vote by proxy, use the proxy form at jpmorganassetmanagement.com/extra. Your form must arrive at the registered
office, via post or fax, by 18.00 CET on Wednesday, 22 April 2015.
To vote in person, attend the meeting in person.
Quorum: None required.
Voting: Agenda items will be resolved by a simple majority of the votes cast.
THE FUND
Name
JPMorgan Investment Funds
Legal form
SICAV
Fund type
UCITS
Auditors
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Registered office
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax
+352 3410 8000
Registration number
(RCS Luxembourg)
B 49.663
Past fiscal year
12 months, ended 31 December 2014
Référence de publication: 2015049602/755/40.
47240
L
U X E M B O U R G
Kim'Mobilière, Société Civile Immobilière.
Siège social: L-8069 Strassen, 40-42, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg E 1.889.
<i>Constatation de cession de parts d'intérêtsi>
Suite à une convention de cession sous-seing privé, il résulte que le capital social de la société civile KIM'MOBILIERE
est désormais réparti comme suit:
Monsieur Camille WEIS, administrateur de société, né le 19/01/1953 à Luxembourg,
demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Op den Rousen: quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . .
99
Madame Viviane WEIS-SEIL, administrateur de société, né le 03/08/1967 à Luxembourg,
demeurant à L-8398 Roodt-Eisch, 18, Op den Rousen: une part d'intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Total: cent parts d'intérêts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Luxembourg, le 31 décembre 2014.
Pour extrait conforme
Camille WEIS / Viviane WEIS-SEIL
<i>Les associés
i>Camille WEIS
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015037124/21.
(150041948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Parvest, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.
R.C.S. Luxembourg B 33.363.
The
STATUTORY GENERAL MEETING
will be held on Monday, <i>April 27, 2015i> at 3.00 p.m., at the offices of BNP Paribas Investment Partners Luxembourg,
building H2O, block A, ground floor, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Grand Duchy of Luxembourg, to deliberate
on the following agenda :
<i>Agenda:i>
1. Presentation and approval of the reports of the Board of Directors and of the Auditor;
2. Approval of the annual accounts for the financial period closed as at December 31, 2014 and allocation of the
results;
3. Discharge to the Directors for the exercise of their mandates;
4. Statutory appointments;
5. Miscellaneous.
Pursuant to the Luxembourg Law of 28 July 2014 regarding immobilisation of bearer shares, voting rights attached to
bearer shares not immobilised by 18 February 2015 as described in the notice published on 23 January 2015 will auto-
matically be suspended. The holders of these shares will no longer be admitted to the General Meeting, nor included in
the quorum calculation or when voting majorities, until such time as the shares are immobilised.
The shareholders must express their intention to take part in the Meeting at the latest five (5) business days before
the date of the Meeting. They will be admitted at the Meeting upon proof of their identity and presentation of a share(s)
blocking certificate.
The Meeting will validly deliberate regardless of the number of shares present or represented and the decisions will
be taken by a simple majority of the shares present or represented; account shall not be taken of abstentions. Every share,
whatever its unit value, gives the right to one vote. Fractional shares shall have no voting right.
Annual accounts, as well as the report of the Auditor and the management report are available at the Registered Office
of the Company. Shareholders may request that these documents are sent to them. They have to send their request,
either by post to the following address: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826
Hesperange - or by email to fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015048912/755/33.
47241
L
U X E M B O U R G
Grey Juice Lab. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 117, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 180.075.
Les statuts coordonnés au 18/02/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 02/03/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015035726/12.
(150040028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
JPLFGDM Securitization S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 181.760.
<i>Extrait des résolutions prises par les associés en date du 04 mars 2015i>
Il résulte du procès-verbal du 04 mars 2015, que:
- L'associé Sycamore Luxembourg S.A. vend toutes les parts à Monsieur Fabien Wannier.
Luxembourg, le 04 mars 2015.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015037107/14.
(150042090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
BIL, Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 6.307.
Nous avons l'honneur de convoquer les Actionnaires de la Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme (ci-
après, la " BIL "), à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui aura lieu au siège social de la BIL, immeuble l' "Indépendance", 69, route d'Esch, L- 2953 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, le vendredi <i>24 avril 2015i> à 11.00 heures.
<i>Ordre du jour:i>
1. Article 57 alinéa 2 de la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 août 1915;
2. Rapport de gestion du Conseil d'administration sur les opérations et la situation pour l'exercice 2014;
3. Approbation des comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2014, y compris l'affectation du résultat de l'année 2014;
4. Décharge à donner aux Administrateurs;
5. Nominations et allocations statutaires;
6. Politique de rémunération;
7. Divers.
Pour pouvoir prendre part à l'assemblée générale, les Actionnaires de la BIL sont priés de se conformer à l'article 19
des statuts et de déposer leurs titres pour le 16 avril 2015 au plus tard à notre siège social ou auprès d'une de nos agences
au Grand-Duché de Luxembourg.
La procuration devra être déposée à notre siège social ou auprès d'une de nos agences au Grand-Duché de Luxem-
bourg pour le 21 avril 2015 au plus tard.
Luxembourg, le 11 mars 2015
Pour le Conseil d'Administration
François Pauly
Président
Référence de publication: 2015047497/28.
47242
L
U X E M B O U R G
Invesco Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 34.457.
Notice is hereby given to the shareholders of Invesco Funds (the “Company”) that the extraordinary general meeting
of Shareholders of the Company held on 27 March 2015 could not validly deliberate on the agenda for lack of quorum.
Shareholders are hereby reconvened to assist at an
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
of the Company to be held on <i>29 April 2015i> at 2:00 p.m. (Luxembourg time) (the “Reconvened Meeting”) at the
registered office of the Company at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to deliberate and vote on the following
agenda:
<i>Agenda:i>
<i>Sole Resolutioni>
1. Full restatement of the articles of incorporation of the Company and more particularly to amend some Articles as
follows:
• Amendment to Article 1 (Form, Name) to clarify that the Company is harmonized under the European Union
Council Directive 2009/65/EC on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating
to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS), which has been implemented
under the law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment or any legislative
replacements or amendments thereof.
• Amendment to Article 4 (Purpose) to use term “2010 Law” as defined under the Article 1.
• Amendment to Article 7 (Issue of Shares) for clarification purposes, to add further information on the power
of the board of directors to wholly or partially reject any subscription application or to suspend the issue of
shares in one or more or all of the Sub-Funds at any time and without prior notification and clarify the process
in case of rejection.
• Amendment to Article 9 (Conversion of Shares) to extend the right of the board of directors to switch
shareholders who cease to satisfy the eligibility requirements applicable to the classes of shares as described
in the prospectus of the Company.
• Amendment to Article 11 (Calculation of Net Asset Value per Share) to clarify the mechanism of fair value
and swing pricing which may apply in order to ensure that the relevant Sub-Fund's investments will be valued
at their fair value as determined in good faith by the Board.
• Amendment to Article 12 (Frequency and Temporary Suspension of Calculation of Net Asset Value per
Share, of Issue, Redemption and Conversion of Shares) to protect further the investors in case of emergency
situations affecting the valuation of assets (paragraph b) and to clarify in which circumstances the net asset
value of feeder funds could be suspended (paragraph f).
Shareholders are advised that there is no quorum requirement for this reconvened extraordinary general meeting and
that the passing of the resolution requires the consent of two thirds of the votes cast. If the resolutions are duly passed,
the changes to the Articles will take effect as from the date of this meeting.
Shareholders may request a copy of the proposed text of the restated articles, free of charge, from the registered
office of the Company.
Shareholders may vote in person or by proxy.
Shareholders who cannot attend the meeting may vote by returning the form of proxy sent to them, to Capita Asset
Services, Shareholder solutions (Ireland), P.O. Box 7117, Dublin 2, Ireland (if delivered by post) or Capita Asset Services,
Shareholder solutions (Ireland), 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (if delivered by hand during normal business
hours) not later than 27 April, 2015. Alternatively, the appointment of a proxy may be submitted by telefax to + 353 1
224 0700, provided it is received in legible form and unencumbered.
The bearer Shareholders wishing to attend this Meeting are required to block their shares at the depositary one day
prior to the Meeting and to provide the registered office of the Company with the related certificate, stating that these
shares remain blocked until the end of the Meeting.
For organisational reasons, those shareholders who intend to attend the meeting in person are requested to register
with Invesco Funds, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg to the attention of Yann Foll - Fax (+352) 24 524 204
by 20 April 2015 at the latest.
Shareholders in Hong Kong may contact Invesco Funds Hong Kong Sub-Distributor and Representative, Invesco Asset
Management Asia Limited on telephone number (+852) 3191 8282 for any questions.
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015047508/755/57.
47243
L
U X E M B O U R G
Sensata Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 114.569.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of December,
Before the undersigned, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Sensata Management Company SA, a public
limited liability company (société anonyme) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 114.569 (the Company).
The Company was incorporated deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, dated 8 February
2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Mémorial) number 979 on May 18, 2006
(the Company). The articles of association of the Company have been amended several times and for the last time on
October 26, 2007 pursuant to a deed of of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, published in the
Mémorial number 2827 on December 6, 2007.
The Meeting is chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg.
The chairman appointed as secretary, and the Meeting elected as scrutineer, Solange Wolter, notary's clerk, with
professional address in Luxembourg.
The Meeting's officers having thus been appointed, the chairperson declares and requests the notary to state that:
I. the Shareholders of the Company are present or represented and the number of their shares are shown on an
attendance list. Such list signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, shall remain attached
to the present minutes;
II. as it appears from the attendance list that all the shares are represented. The Meeting is thus regularly constituted
and may deliberate and decide on the items on the agenda of which the participants have been beforehand informed;
III. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Dissolution and liquidation of the Company;
3. Appointment of the liquidator;
4. Powers of the liquidator; and
5. Instructions for the liquidator.
IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive the convening
notices, acknowledging being sufficiently informed of the agenda which has been made available to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to dissolve the Company with immediate effect and to put it into liquidation (liquidation
volontaire).
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to appoint Bain Capital Fund VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under
the laws of Cayman Islands, with its registered office at Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church
Street PO BOX 309, KY1-1104 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, as the Company's liquidator (the Liqui-
dator). The Liquidator is empowered, by its sole signature, to do whatever is required for the liquidation of the Company
and the disposal of its assets.
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholders resolve to grant the Liquidator all the powers set out in articles 144 et seq. of the Luxembourg law
of 10 August, 1915 on commercial companies, as amended (the Law).
The Liquidator is entitled to execute all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145
of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, on its sole responsibility, delegate
some of its powers to one or more persons or entities for specifically defined operations or tasks.
The Liquidator is authorised to make advance payments of the liquidation proceeds (boni de liquidation) to the Sha-
reholders, subject to the drawing-up of interim accounts.
47244
L
U X E M B O U R G
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to instruct the Liquidator to realise all the Company's assets on the best possible terms and
to pay all its debts.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with this
notarial deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (EUR 1,500.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the Shareholders, this deed
is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English text prevails.
This notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the Meeting's officers and the Shareholders' authorised repre-
sentative.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-troisième jour de décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
Une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires de Sensata Management Company S.A., une
société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est établi au 4,
rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 114.569 (la Société).
La Société a été constituée suivant un acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 8
février 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), n°979 du 18 mai 2006. Les statuts
de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois le 26 octobre, 2007 suivant un acte de Maître
Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié dans le Mémorial n°2827 du 6 décembre 2007.
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire et l'Assemblée choisit Solange Wolter, clerc de notaire, de résidence profes-
sionnelle à Luxembourg comme scrutateur.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le président déclare et demande au notaire d'acter que:
I. les Actionnaires de la Société sont présents ou représentés et le nombre des actions qu'ils détiennent est indiqué
sur une liste de présence. Ladite liste signée ne varietur par les parties comparantes et le notaire instrumentant restera
attaché au présent procès-verbal;
II. tel qu'il apparaît sur la liste de présence, l'intégralité des actions est représentée. L'Assemblée est par conséquent
valablement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l'ordre du jour auxquels les participants ont pré-
alablement eu connaissance;
III. l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Dissolution et liquidation de la Société;
3. Nomination du liquidateur;
4. Pouvoirs du liquidateur;
5. Instructions données au liquidateur; et
6. Divers.
IV. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'intégralité du capital social étant représentée lors de la présente Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer
aux formalités de convocation, déclarant avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué
au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Actionnaires décident de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la placer en liquidation volontaire.
<i>Troisième résolutioni>
Les Actionnaires décident de nommer Bain Capital Fund VIII L.P., une limited partnership, existant sous les lois des
îles Caïmans, ayant son siège social à Maples Corporate Services Limited, Ugland House, South Church Street, PO BOX
309, KY1-1104 George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, en tant que liquidateur de la Société (le Liquidateur). Le
47245
L
U X E M B O U R G
Liquidateur est autorisé à accomplir tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation des actifs
de la Société sous sa seule signature.
<i>Quatrième résolutioni>
Les Actionnaires décident d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi
luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, en ce compris les actes prévus
à l'article 145 de la Loi, sans l'autorisation préalable des Actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa seule
responsabilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser des acomptes sur le boni de liquidation aux Actionnaires de la Société, sous réserve
de l'établissement de comptes intérimaires.
<i>Cinquième résolutioni>
Les Actionnaires décident de confier au Liquidateur la mission de réaliser, dans les meilleures conditions, tous les actifs
de la Société, et de payer toutes les dettes de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais et rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui pourraient incomber à la Société
à la suite du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (EUR 1.500.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate, qu'à la requête des Actionnaires, le présent acte est
rédigé en anglais suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergence entre la version anglaise et la version française,
la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite par le notaire, ce dernier signe le présent acte avec les membres du Bureau.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 31 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64317. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 13 février 2015.
Référence de publication: 2015035999/135.
(150040612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
Planalto S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 49.431.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 4 mars 2015i>
1. Monsieur Frank PLETSCH a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Gérard BIRCHEN a démissionné de ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'adminis-
tration.
3. Monsieur Olivier COMPE, administrateur de sociétés, né le 19 juillet 1977 à Hayange (France), demeurant profes-
sionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme administrateur jusqu'à l'issue de
l'assemblée générale statutaire de 2018.
4. Mme Urszula PRZYBYSLAWSKA, administrateur de sociétés, née le 27 janvier 1972 à Debica (Pologne), demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommée comme administrateur et présidente
du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2018.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour PLANALTO S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015037331/21.
(150041725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47246
L
U X E M B O U R G
Lseg LuxCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.620.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 192.191.
<i>Extrait rectificatif concernant la modification déposée le 17 décembre 2014 sous la référence L140224632i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 17 décembre 2014 sous
la référence L140224632.
En date du 24 novembre 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution de nommer Monsieur Serge HARRY
et Monsieur Elvin MONTES en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Toutes autres mentions de la publication demeurent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
LSEG LuxCo 2 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015037194/20.
(150041929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Alteralia S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions,
(anc. Alteralia SCA).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6A, Rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 193.864.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-fifth of March.
Before Maître Jean-Paul Meyers, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,
was held:
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of Alteralia S.C.A., a société en commandite par
actions, having its registered office at 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg register of commerce and companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg)
under number B 193.864 (the Company), incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 29 December
2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations N° 215 on 28 January 2015.
The Meeting is chaired by Thibaud Herberigs, lawyer, professionally residing in Luxembourg (the Chairman), who
appoints as secretary Oana Millich, employee, professionally residing in Luxembourg (the Secretary).
The Meeting appoints as scrutineer Oana Millich, employee, professionally residing in Luxembourg (the Scrutineer).
(the Chairman, the Secretary and the Scrutineer constituting the Bureau of the Meeting).
I. The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:
The shareholders present or represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list.
This list and the proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed for registration purposes.
It appears from said attendance list that 100% of the share capital of the Company, i.e. one (1) management share and
thirty thousand nine hundred ninety-nine (30,999) ordinary shares, with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, subscribed
and fully paid-up, is represented at the Meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the
items on the agenda, hereinafter reproduced, the shareholders represented at the Meeting having agreed to meet after
examination of the agenda.
The proxies from the shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present deed
and are signed/initialled ne varietur by the members of the Bureau and the notary.
II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Election by the Company of the investment company in risk capital (SICAR) regime under the law of 15 June 2004
on the investment company in risk capital, as amended;
2. Subsequent change of the corporate denomination of the Company by replacing the current name “Alteralia S.C.A.”
by “Alteralia S.C.A. SICAR” in order to reflect the change of legal status;
3. Subsequent amendment and restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the changes
resulting from the foregoing, and amongst others:
47247
L
U X E M B O U R G
(a) Change of object as follows:
“ Art. 3. Object.
3.1 The Company is established as an umbrella structure with multiple compartments as for under Article 3 of the
2004 Law (each such compartment, a “Compartment”).
3.2 The object of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the meaning of article
1 of the 2004 Law and CSSF Circular 06/241 as more specifically defined and described in the Prospectus.
3.3. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to its participations in companies and/
or enterprises, including the administration, management, control, development, optimization and realization of such
participations as an investor in such participations, which it may deem useful for the fulfilment and development of its
purpose as stated herein, to the extent permitted under the 2004 Law.
3.4 The Company may grant loans, advances or guarantees to direct and indirect subsidiaries for the accomplishment
of its purpose.
3.5 The Company can generally perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly
or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”
(b) Modification of the day of the general meeting as follows:
“ Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
13.1 The General Partner will convene, at least, an annual meeting of the Company on the 20
th
of the month of June
(unless such date falls on a legal bank holiday, in which case on the next Business Day) at 2 p.m in any case on not less
than 8 calendar days’ written notice in advance.
(…)”; and
4. Miscellaneous.
III. The Meeting, after deliberation, unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting acknowledges the letter received from the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
authorising the Company to carry out its activities as an investment company in risk capital (SICAR) and resolves that
the Company shall elect with immediate effect for the investment company in risk capital (SICAR) regime under the
Luxembourg law of 15 June 2004 on the investment company in risk capital, as amended.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to change the corporate denomination of the Company into “Alteralia S.C.A. SICAR”.
<i>Third resolutioni>
As a result of the foregoing resolutions, the meeting resolves to abandon and annul any translation of the articles of
association and to fully restate the articles of association of the Company in English only.
The new articles of association of the Company (the Articles) will have exclusively the following wording:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name.
1.1 There is formed among Alteralia Management S.à r.l., a Luxembourg Société à responsabilité limitée, registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 188.217, the unlimited shareholder and the ma-
naging general partner of the Company (the General Partner - actionnaire-commandité gérant) and the holders of various
classes of ordinary shares (the Limited Shareholders - actionnaires commanditaires), and collectively with the General
Partner, the Shareholders), a société en commandite par actions with variable capital qualifying as a société d'investisse-
ment en capital à risque (SICAR) under the name “Alteralia S.C.A., SICAR” (the Company), which shall be governed by
the laws of Luxembourg, in particular by the 2004 Law, the Companies Act, and to the extent applicable, by the 2013
Law, as well as by the Articles of Association and the Prospectus.
Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established at Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg. It may be trans-
ferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the General Partner. The registered office may further
be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg through simple resolution of the General Partner.
2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
a resolution of the General Partner. Where the General Partner determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent as determined in its sole discretion and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
47248
L
U X E M B O U R G
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.
Art. 3. Object.
3.1 The Company is established as an umbrella structure with multiple compartments as for under Article 3 of the
2004 Law (each such compartment, a “Compartment”).
3.2 The object of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the meaning of article
1 of the 2004 Law and CSSF Circular 06/241 as more specifically defined and described in the Prospectus.
3.3 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to its participations in companies and/
or enterprises, including the administration, management, control, development, optimization and realization of such
participations as an investor in such participations, which it may deem useful for the fulfilment and development of its
purpose as stated herein, to the extent permitted under the 2004 Law.
3.4 The Company may grant loans, advances or guarantees to direct and indirect subsidiaries for the accomplishment
of its purpose.
3.5 The Company can generally perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly
or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an indefinite period of time and may be liquidated at the discretion of the General
Partner.
4.2 The Company may, subject to the approval of the CSSF, be dissolved, at any time, by a resolution of the Shareholders
of the Company adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association, but only with the
consent of the General Partner.
4.3 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting any of the Shareholders. In case of death, incapacity or inability of the General
Partner, article 112 of the Companies Act shall apply.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1 The capital of the Company is variable and shall be represented by shares (the “Shares”) with no nominal value
comprising at least one Share held by the General Partner (the “General Partner Share”), all other Shares being referred
to as ordinary shares (the “Ordinary Shares") and shall at all times be equal to the total net assets of the Company pursuant
to the Prospectus. The minimum subscribed share capital of the Company, increased by the share premium if any, which
must be achieved within twelve (12) months after the date on which the Company was authorised as a “société d’inves-
tissement en capital à risque” or “SICAR” under the 2004 Law, shall be EUR 1,000,000 (one million Euro).
5.2 The General Partner may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more Compartments in
such cases the Prospectus will be amended accordingly. The Shares to be issued in a Compartment may, as the General
Partner will determine, be of one or more different classes, the features, terms and conditions of which will be established
in the Prospectus, the relevant Compartment Appendix and the provisions set out in these Articles of Association re-
garding Compartments shall apply mutatis mutandis of the Class therein.
5.3 The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Compartment will be invested for the exclusive
benefit of the Shareholders of the corresponding Compartment and the assets of a specific Compartment are solely
accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Compartment.
5.4 The General Partner may create each Compartment for an unlimited or a limited period of time, as set forth in
the relevant Compartment Appendix.
5.5 The proceeds from the issuance of Shares of any Class within a Compartment will be invested in risk capital pursuant
to Article 3 hereof.
5.6 For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Compartment will,
if not expressed in Euros, be converted into Euros and the capital will be the total of the net assets of all the Compartments.
5.7 The general meeting of holders of Shares of a Compartment or Class, deciding with simple majority, may consolidate
or split the Shares of such Compartment or Class.
5.8 All Share Class in the Company may only be subscribed for by Well-Informed Investors within the meaning of
article 2 of the 2004 Law, i.e. any institutional investor, professional investor or any other investor who confirmed in
writing that it/he/she adheres to the status of Well-Informed Investor and who either (i) invests or commits to invest in
Euros a minimum of one hundred and twenty-five thousand Euros (€ 125,000) in the Company, or (ii) has obtained an
assessment made by a credit institution, within the meaning of Directive 2006/48/EC, an investment firm within the
meaning of Directive 2004/39/EC, or a management company within the meaning of Directive 2001/107/EC or 2009/65/
EC certifying its/his/her expertise, its/his/her experience and its/his/her knowledge in adequately appraising an investment
in risk capital (a “Well-informed Investor”) within the meaning of the 2004 Law.
47249
L
U X E M B O U R G
5.9 Each Shareholder shall have signed a Subscription Agreement recording its Commitment irrevocably committing
to make all subscriptions and payments for the entire Commitment, unless otherwise decided by the General Partner
but ensuring that all Shareholders are treated equally in this regard.
5.10 The AIFM will adopt such provisions as necessary to ensure that any preferential treatment granted by the
Company, as the case may be, to a shareholder will not result in an overall material disadvantage to other shareholders,
as further disclosed in the Company’s Prospectus.
5.11 Each Share grant the right to one vote at the general meeting of Shareholders and at separate Compartment or
Class meetings of the holders of Shares of each of the Compartments or Classes.
5.12 The Company, after receiving SICAR authorisation, qualifies as a financial institution within the meaning of the
Luxembourg anti-money laundering legislation. The Company’s Administrative Agent shall be entrusted by the General
Partner to apply all applicable measures in order to prevent money laundering and terrorist financing as well as in order
to comply with insider regulations. Such measure shall include, in particular, the introduction of necessary KYC checks
and anti-money laundering procedures for the Company.
Art. 6. Increase and Reduction of share capital.
6.1 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Partner.
Art. 7. Shares - Issuance - Redemption - Default.
7.1 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives) will be immaterial and delivered to the
Shareholders in the form of a material certificate only at their request.
7.2 A Shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of
the Companies Act and may be examined by each Shareholder who so requests.
7.3 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders’ register of the
Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Company.
7.4 Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence, subject to the terms of the Prospectus and the Compartment Appendix.
7.5 Towards the Company, the Company’s Shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
7.6 The Company may redeem its own Shares in accordance with the provisions of the Prospectus, the Compartment
Appendix and within the limits set forth by the 2004 Law.
7.7 There will generally be no redemption at the initiative of the Shareholders. The General Partner may, however,
cause the Company to acquire and redeem its own Shares, for example with a view to effect distributions or a return of
capital in compliance with the terms of the Prospectus, the Compartment Appendix, the Articles of Association and
subject to the limits set forth by the Companies Act and the 2004 Law. Such redemption is, however, currently not
anticipated and, in case it is made, shall be made in accordance with the procedures set out in the Companies Act.
7.8 Notwithstanding the above, if a Shareholder loses its status of Well-Informed Investor for any reason, the General
Partner will automatically and immediately cause the repurchase of the Shares of such Shareholder by the Company
without approval from the Shareholder. The purchase price of the repurchased Shares will be determined on the basis
of the Net Asset Value of the Company discounted by 50% and the purchase price will be paid on the liquidation of the
Company.
7.9 The Company shall issue Shares to the Shareholders in such number as provided in the drawdown notices issued
by the General Partner in relation to the Shareholders’ Commitments pursuant to Article Art.5 not less than 10 Business
Days prior to the due date so that amounts drawn under each notice shall constitute the consideration payable for the
new Shares to be issued by the Company. The Shares will be fully paid up.
7.10 If a Shareholder fails to pay the amount which is the subject of a drawdown notice on or before the date of expiry
of such drawdown notice, such Shareholder shall be a “Defaulting Shareholder” and the General Partner will, at any time
thereafter, give notice to such Defaulting Shareholder (the “Defaulting Letter”). The rights of the General Partner fol-
lowing a Shareholder becoming a Defaulting Shareholder are set out in the Prospectus.
Art. 8. Share transfers.
8.1 Any transfer of Shares shall be subject to the terms of the Prospectus.
Art. 9. Expenses and fees.
9.1 The Company shall be responsible for all expenses, direct or indirect, incurred in relation to the administration
and business of the Company including, without limitation, costs of printing and circulating reports and notices, all intro-
duction and similar fees, abort costs, legal fees, administrators’, auditors’ and valuers’ fees, registration fees, accounting
expenses (including any expenses associated with the preparation of the Company’s financial statements and tax returns)
fees and expenses incurred in relation to any custodian or nominee of the assets and the general meeting of Shareholders,
ongoing fees and expenses of any conduit entity, external consultants’ fees, advertising costs, bank charges, insurance
47250
L
U X E M B O U R G
costs, borrowing costs, hedging costs, extraordinary expenses (such as litigation) and all stamp duties and fees of lawyers,
auditors, valuers and any external consultants arising in respect of identifying, evaluating, negotiating, acquiring, holding,
monitoring, protecting and realising Investments, and for the avoidance of doubt the General Partner shall be entitled to
charge the Company for any of the above expenses which it has itself incurred on behalf of the Company; provided that
the Company shall not be responsible for disbursements in respect of:
(a) overheads of the General Partner properly payable by the General Partner from the Management Fee including
remuneration and expenses paid to their employees, rent and utilities expenditure; or
(b) expenses recovered from companies or other entities in which the Company has made (or proposes to make) an
Investment.
9.2 The General Partner shall be entitled to allocate such expenses and fees incurred pursuant to Article 9.1 between
one or more Compartments in the manner that it reasonably considers to be just in compliance with the provisions of
the Prospectus and the relevant Compartment Appendix. Expenses and fees not reasonably attributable to a single Com-
partment pursuant to the foregoing sentence shall be divided between Compartments pro rata to the aggregate
Commitments of their respective Shareholders, as provided in clause 11.1 of the Prospectus.
III. Management - Representation
Art. 10. Management of the Company.
10.1 The Company shall be managed by the General Partner. Subject to the provisions of Article 10.8 below, Alteralia
Management S.à r.l., a Luxembourg Société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 188.217 is and shall remain the General Partner for the duration of the Company.
10.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles of Association to the Shareholders fall
within the competence of the General Partner, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.
10.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the General Partner.
10.4 The General Partner is authorised to delegate the day-to-day management of the Company and the power to
represent the Company in respect thereto to one or more officers, or other agents who may but are not required to
be Shareholders, acting individually or jointly.
10.5 The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the joint or
single signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Articles 10.3
and 10.4 of these Articles of Association and within the limits of such power.
10.6 No contract or other transaction between the Company and any other company or person shall be affected or
invalidated by the fact that the General Partner or any officers of the Company has an interest in the transaction, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or person.
10.7 Subject to its overall supervision and ultimate responsibility, the General Partner has appointed A&G Luxembourg
AM, S.A. as AIFM within the meaning of the 2013 Law and this latter shall be responsible to ensure the compliance of the
Company with the 2013 Law, in accordance with the terms and conditions of the AlFM Services Agreement, effective as
from 26 March 2015. The AIFM shall also be responsible for portfolio management and risk management as well as for
certain administrative tasks as defined in section 13.5 of the Prospectus, marketing and activities related to the assets of
the Company.
10.8 Potential Conflicts of interest
10.8.1 Conflicts of interest will in any case be dealt with in accordance with article 7a of the 2004 Law, regulations
from the CSSF, the 2013 Law and the provisions of the Prospectus. In particular, the Company shall be structured and
organised so that the risk of conflicts of interest between the Company and, where applicable, any Person contributing
to the activities of the Company or any Person directly or indirectly linked to the Company is minimised and does not
harm the interest of the Shareholders.
10.8.2 The General Partner and the AIFM recognise that there may be situations where conflicts of interest arise and
intend to avoid or mitigate such situations during the life of the Company. Where this is not possible, conflicts of interest
shall be managed fairly, openly, honestly and with integrity.
10.8.3 Conflicts of interest will be diligently identified and disclosed to the parties concerned. The board of managers
of the General Partner and the AIFM are responsible to supervise possible conflicts of interest that may exist. Conflicts
of interest shall be subject to the approval of the General Partner and the AIFM and no transaction which is or could be
considered to be a conflict of interest will proceed without such consent. Potential or actual conflicts of interest may
furthermore be identified by the Shareholders. Shareholders may furthermore notify the General Partner and AIFM of
any such potential conflict matters.
10.8.4 Board meetings of the General Partner shall be held when deemed appropriate for the proper handling of any
conflicts brought to its attention. On any matter involving a potential or actual conflict of interest, the AIFM and the
General Partner shall be guided by their good faith judgment as to the best interests of all parties involved and shall take
47251
L
U X E M B O U R G
such actions as are determined by them, as the case may be, to be necessary or appropriate to ameliorate such conflicts
of interest.
10.8.5 In case of a potential conflict situation, the AIFM and the General Partner will make a sound and reasonable
assessment of the situation taking into account all relevant facts and circumstances. If it is decided that the matter at hand
does not represent a conflict of interest situation, the General Partner and/or the AIFM will approve to continue with
the respective transaction, provided that it does not act in contravention of any decision or advice. If it is decided that
the matter does present a (potential) conflict of interest situation, the General Partner and/or the AIFM shall fully disclose
and refer any (potential) conflict of interest to the Advisory Board and the investors of each Compartment.
Art. 11. Liability.
11.1 To the extent permissible under Luxembourg law, the General Partner and other officers of the Company, as
well as those persons to whom such signatory powers have been validly delegated in accordance with Articles 10.3 and
10.4 of these Articles of Association, shall be indemnified out of the assets of the Company against all costs, charges,
losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any actions, claims, suits or proceedings
to which they may be made a party by reason of being or having been managers, officers or delegates of the Company,
by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered into or any action performed, concurred
in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for any matter resulting from fraud, or gross negligence
or wilful misconduct on the part of any indemnified party in relation to the Company or the relevant Compartment.
11.2 The General Partner is liable for all liabilities of the Company to the extent that they cannot be paid out of the
assets of the Company.
IV. General meetings of Shareholders
Art. 12. Powers and Voting rights.
12.1 The general meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of Shareholders of the
Company. Meetings in any Compartment or Share Class may also be held in circumstances where the rights of the
Shareholders in the Compartment or the Share Class, respectively, may be changed as a result of the resolutions.
12.2 It cannot order, adopt, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company without the consent of
the General Partner; provided that the General Partner shall consent to any decision or approval of the Shareholders or
the Advisory Board, if any, made pursuant to the terms of the Prospectus.
12.3 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at general meetings.
12.4 Each Shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.
Art. 13. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings.
13.1 The General Partner will convene, at least, an annual meeting of the Company on the 20
th
of the month of June
(unless such date falls on a legal bank holiday, in which case on the next Business Day) at 2 p.m in any case on not less
than 8 calendar days’ written notice in advance.
13.2 For any other meeting, any Shareholder whose Commitments in aggregate represent 25% (twenty five per cent)
or more of Total Commitments may, by notice in writing together with an agenda, require the General Partner to call a
meeting of the Company and the General Partner shall convene such a meeting for a date no later than 21 calendar days
from the date of that notice. The accidental omission to give notice of a meeting to, or the non-receipt of a notice of a
meeting by, any Shareholder shall not invalidate the proceedings at the meeting.
13.3 The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice
for, and conduct of, the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.
13.4 Meetings of Shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective
convening notices of the meetings.
13.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the Shareholders of the
Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.
13.6 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.7 Each Shareholder may also participate in any meeting of the Shareholders of the Company by telephone or video
conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.
13.8 Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain
the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each
proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the
proposed resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to
the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the
47252
L
U X E M B O U R G
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be void.
13.9 Any resolution of a meeting of shareholders to the effect of amending the present Articles of Association must
be passed with (i) a presence quorum of fifty (50) percent of the share capital, (ii) the approval of a majority of at least
two-thirds (2/3) of the share capital present or represented and voting at the meeting and (iii) the consent of the General
Partner, in accordance with applicable law. If, however, the particular action would under the terms of the Prospectus,
the Compartment Appendix or the Articles of Association require approval by Shareholders’ Extraordinary Consent,
such resolution shall only be validly adopted if also approved pursuant to the approval of more than 80% of the capital.
13.10 The nationality of the Company may be changed and its SICAR status may be abandoned only with the unanimous
consent of the Shareholders. The change of the nationality and abandon of the SICAR status can only be made with prior
approval of the CSSF.
V. Supervision - Annual accounts - Distributions and allocation of profits
Art. 14. Approved Statutory Auditor.
14.1 The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be audited by the
Approved Statutory Auditor, chosen from the list of approved auditors held by the CSSF who shall be appointed by the
General Partner and who shall carry out the duties prescribed by the 2004 Law.
14.2 The Approved Statutory Auditor shall, among other duties, promptly notify the CSSF of any fact or decision of
which the Approved Statutory Auditor has become aware while carrying out the audit of the accounting information
contained in the annual report of the Company or any other legal issue concerning the Company, where such fact or
decision is liable to constitute a material breach of the 2004 Law or the regulations adopted for its execution, or affect
the continuous functioning of the Company, or lead to a refusal to certify the accounts or to the expression of reservations
thereon.
14.3 The Approved Statutory Auditor has extensive duties of informing and notifying the CSSF that may require the
Approved Statutory Auditor to exercise control over one or several particular aspects of the activities and operations
of the Company, at the Company’s expense.
Art. 15. Accounting Year and Annual general meeting.
15.1 The accounting year of the Company shall begin on the first (1
st
) of January of each year and end on the Accounting
Date of the same year. Notwithstanding the before, the first accounting year shall commence on the date of the Company’s
establishment and end on 31 December 2014.
15.2 Each year, with reference to the end of the Company’s year, the General Partner must prepare the balance sheet
and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company’s assets and liabilities, with an annex summarising all the Company’s commitments and the debts of the manager
(s), and auditor(s) of the Company.
15.3 The annual general meeting of the Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg
law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the 20
th
of the month of June (unless
such date falls on a legal bank holiday, in which case on the next Business Day) at 2 p.m. The General Partner shall also
be obliged to convene a general meeting within a period of 21 calendar days, if Shareholders representing 25% of the
capital require so in writing with an indication of the agenda.
15.4 The annual general meeting of the Shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final
judgement of the General Partner, exceptional circumstances so require.
Art. 16. Distributions and allocation of profits.
16.1 No distributions will be made unless there is sufficient cash available, or (except as part of the liquidation of the
Company) if the capital of the Company would as a consequence of the distribution fall below the legal minimum of EUR
1,000,000 (as required by the 2004 Law).
16.2 Distributions shall be paid in the Base Currency.
16.3 Distributions and allocation of profits will be made as follows.
Step 1 - Initial allocation between Share Classes
Allocations of profits and losses of the Company shall be made by the AIFM in accordance with the principles set out
in relation to distributions in the Prospectus.
Step 2 - Distributions in relation to the various Share Classes
The right to distributions and the right to capital reimbursement of each Share Class are determined by the AIFM in
accordance with the provisions of the relevant Compartment´s distribution waterfall further disclosed in the Prospectus.
47253
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Net Asset Value Calculation.
17.1 The Net Asset Value of the Company will be expressed in the Base Currency and shall be calculated as often as
the Administrative Agent may think useful, but in no event less than annually by the Administrative Agent and supervised
by the AIFM in accordance with Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles.
17.2 The Net Asset Value per Share of each Share Class for each Compartment is determined by dividing the value
of the total assets of the Compartment properly allocated to such Share Class less the liabilities of the Compartment
properly allocated to such Share Class by the total number of Shares of such Share Class outstanding on a Valuation Date.
The Net Asset Value per Share will be given to three (3) decimal places. The Compartment Assets are valued on the
basis of their fair value.
17.3 The net value of the Compartment Assets is equal to the difference between the value of its gross assets and its
commitments.
17.4 The Valuation principles will be determined by the AIFM as further provided for in a Compartment Appendix, in
clause 15 of the Prospectus and in accordance to Article 17 of the 2013 Law.
17.5 The Net Asset Value per Share of each Share Class of the relevant Compartment on each Valuation Date will be
made available to the Shareholders at the latest within forty five (45) calendar days of the Valuation Date.
17.6 Pursuant to the Articles of Association, the AIFM may temporarily suspend the valuation of the Net Asset Value
of one or more Compartments in any of the following events:
(a) any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the Compartment Assets are
quoted is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are restricted or suspended;
(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of Compartment
Assets would be impracticable;
(c) a breakdown has occurred with respect to the means of communication normally employed in determining the
price of any of the Compartment Assets or the current prices on any market or stock exchange; or
(d) any period when the Company is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in the
realisation or acquisition of Compartment Assets cannot in the opinion of the AIFM be effected at normal rates of
exchange.
17.7 No issue or, if applicable, redemption of Shares will take place during any period when the calculation of the Net
Asset Value is suspended. Notice of any suspension will be given to Shareholders who are concerned because of sub-
scription or, if applicable, redemption reasons if, according to the AIFM, the suspension will exceed eight (8) Business
Days.
VI. Dissolution - Liquidation
For the dissolution and liquidation of the Company, the prior approval of the CSSF will be required.
In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in accordance with the provisions of the
1915 Law and the 2004 Law, by one or more liquidators named by the general meeting of Shareholders resolving to
dissolve the Company, upon proposal by the General Partner, and approved by the CSSF. Such meeting shall determine
their powers and their remuneration. The net proceeds may be distributed in kind to the holders of Shares.
Compartments may be established for a limited or unlimited period, as specified in the relevant Compartment Ap-
pendix.
If the net assets of any Compartment or Class fall below or do not reach a minimum amount of EUR 50,000,000 (fifty
million Euro) determined by the General Partner to be the minimum level for such Compartment or such Class to be
operated in an economically efficient manner or if a change in the economic or political situation relating to the Com-
partment or Class concerned justifies it, the General Partner with the approval by simple majority of the votes of
Shareholders has the power to liquidate such Compartment or Class by compulsory redemption of shares of such Com-
partment or Class at the Net Asset Value per Share determined as at the Valuation Day at which such a decision shall
become effective. The decision to liquidate will be mailed to the Shareholders concerned prior to the effective date of
the liquidation.
The net proceeds of liquidation corresponding to each Compartment shall be distributed by the liquidators to the
Shareholders of each Compartment in proportion to their holding in the respective Compartment(s).
Upon the circumstances provided for under the third paragraph of this section, the General Partner with the approval
by simple majority of the votes of Shareholders may decide to allocate the assets of any Compartment to those of another
existing Compartment within the Company (the “New Compartment”) and to re-designate the Shares of the Compart-
ment concerned as shares of the New Compartment (following a split or consolidation, if necessary and the payment of
the amount corresponding to any fractional entitlement to shareholders). Such decision will be notified to the Sharehol-
ders concerned (and, in addition, the notification will contain information in relation to the New Compartment) by mail
to the address of each concerned Shareholder as disclosed in the Register of Shareholders.
Assets which could not be distributed to the relevant Shareholders upon the closure of the liquidation of a Compart-
ment or Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant Shareholders.
Amounts not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg Law.
47254
L
U X E M B O U R G
Any distribution resulting of the foregoing shall be made and processed in accordance with the relevant provisions set
out in the Prospectus and the relevant provisions set out in the applicable Compartment Appendix under section “Dis-
tribution Waterfall”.
The Company will not merge or convert its Compartments.
VII. General provision
Reference is made to the provisions of the Companies Act and to any agreement which may be entered into among
the Shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is made in these Articles of
Association.
In the event of any conflict or ambiguity between this Articles of Association and the Prospectus, the terms of the
Articles of Association shall prevail.
VIII. Definitions
Any capitalised terms used in these Articles of Association which have not been defined in them but which are defined
in the Prospectus, will have the meaning ascribed to them in the Prospectus.
1915 Law
the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time
2004 Law
the Luxembourg law of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital
(SICAR), as amended from time to time
2013 Law
the Luxembourg law of July, 12, 2013 on alternative investment fund managers, as may be
amended from time to time
Administrative Agent
has the meaning given in the Prospectus
Accounting Date
31 December 2014 and 31 December in each year thereafter or such other date as the
General Partner may determine and notify to the Shareholders or (in the case of the final
Accounting Period of the Company) the date when the Company is ultimately dissolved
Accounting Period
a period ending on and including an Accounting Date and beginning on the day following
the immediately preceding Accounting Date or, in the case of the first Accounting Period,
on the date of establishment of the Company
Advisory Board
the Advisory Board as may be established by the General Partner in relation to one or
several Compartments
AIFM
A&G Luxembourg AM, S.A., the alternative investment fund manager, as defined in the
2013 Law, of the Company
AIFM Services
Agreement
the agreement entered into by the General Partner and the AIFM
Approved Statutory
Auditor
the réviseur d'entreprises agréé of the Company appointed in accordance with the 2004
Law
Articles of Association
the articles of association of the Company as amended from time to time
Base Currency
means the Euro; the currency of the member states of the European Union that have
adopted the single currency in accordance with the Treaty establishing the European
Community (signed in Rome 1957) as amended by the Treaty on European Union (signed
in Maastricht on 7 February 1992)
Business Day
a day (not being a Saturday or Sunday or a public holiday) on which banks are generally
open for non-automated business in Luxembourg
CSSF
The Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg
supervisory authority of the financial sector
Commitment
the total amount committed to be paid in consideration for the subscription of Shares in
a Compartment by a Shareholder from time to time as specified in the relevant
Shareholder’s Subscription Agreement.
Compartment
any compartment of the Company which constitutes a distinct and segregated part of the
assets and liabilities of the Company, having its own Net Asset Value and represented by
one or more separate Classes of Shares
Compartment Appendix the appendix to the Prospectus corresponding to the relevant Compartment
Defaulting Letter
the meaning given in Article 7.10
Defaulting Shareholder
the meaning given in Article 7.10
Euro or EUR
the currency used within the European Monetary System which is used as the reference
accounting unit of the Company
Investment
an investment or investments in a Portfolio Company, through the acquisition (either
directly or indirectly) by a Compartment of, including but not limited to: shares,
debentures, convertible loan stock, options, guarantees, warrants, financial or debt
47255
L
U X E M B O U R G
instruments or other securities and/or loans (whether secured or unsecured and whether
or not subordinated), which will in all times complies with the definition of the risk capital
investment provided by the 2004 Law and the CSSF circular 06/241.
Net Asset Value
the meaning given in Article Art. 17
Portfolio Company
a body corporate, fund or other collective investment scheme or other entity or person
whenever established, incorporated or resident that is the issuer of an instrument in which
the Company intends to invest or has invested, directly or indirectly
Prospectus
the private placement memorandum relating to the Company, as amended form time to
time
Shares
any shares of the Company
Shareholder
with respect to a given Compartment, a person who is admitted as a Shareholder within
a Compartment of the Company by signing a Subscription Agreement and whose name is
entered in the Register of Shareholders of the Company as the holder of one or more
Shares or fractional Shares
Shareholders'
Extraordinary Consent
the written consent of the Shareholders (excluding Class D Shareholders, if applicable)
representing more than 80% of the capital of the Company, it being understood that such
written consent may consist of one or more documents in like form, each being signed by
the foregoing consenting parties (for the avoidance of doubt, each Share shall entitle the
holder of such Share to one vote)
Shareholders’ Ordinary
Consent
the written consent of the Shareholders (excluding Class D Shareholders, if applicable)
representing more than 2/3 of the capital of the Company, it being understood that such
written consent may consist of one or more documents in like form, each being signed by
the foregoing consenting parties (for the avoidance of doubt, each Share shall entitle the
holder of such Share to one vote)
Subscription Agreement the subscription agreement, in such form as the Company may approve, under which a
Shareholder subscribes for Shares in the Company
Well-Informed Investor
an investor as defined in Article 2 of the 2004 Law
Valuation Day
31 December of each year and such other days as determined from time to time by the
AIFM on which the Net Asset Value of all Shares of the Company shall be determined by
the Administrative Agent
Value
except where otherwise expressly stated shall mean, in relation to any Investment, such
value as shall be determined by the AIFM in its reasonable discretion in accordance with
its internal guidelines which are in line with the “International Private Equity and Venture
Capital valuation Guidelines” (or any replacement thereof)
<i>Statement and poweri>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that accordingly to the Luxembourg Law
of 2010 on undertakings for collective investment as amended, and on the special request of the appearing person, the
present deed is worded in English only and the English version will always prevail whereas the company representatives
will deliver on first request to any public administration or service the required or necessary applicable translation of any
statutory or other dispositions contained herein as the notary is not enabled or in charge of any translation procedures.
Thus, the above appearing party, as represented, hereby gives power to any agent or employee of the office of the
signing notary, acting individually, to sign all additional recordings, draw, correct and sign any error, lapse or typo contained
herewith.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing persons, the said proxyholder signed together
with the notary the present deed.
Signé: Herberigs, Millich, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 31 mars 2015. Relation: EAC/2015/7575. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 31 mars 2015.
Jean-Paul MEYERS.
Référence de publication: 2015053390/540.
(150061426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2015.
47256
L
U X E M B O U R G
Exclusif esthétique S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 194.970.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour de février.
Pardevant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Laurence STREVELER, Esthéticienne, née le 31 janvier 1970 à Charleroi, demeurant à L-8041 Strassen, 120,
rue des Romains.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte constitutif d'une société à responsabilité limitée
qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les présentes, par la personne comparante, et toutes les personnes qui pourraient devenir
associés par la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, et notamment celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts (ci-après la "Société").
Art. 2. La Société a pour objet un salon d'esthétique avec soins esthétiques: la pédicure, la manucure, les soins visage,
les massages corps gommage et les épilations, ainsi que le soin amincissant et la balnéothérapie.
La Société a également pour objet la vente de produits et accessoires, de bijoux, de parfum et de produits de maquillage.
La Société pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle
et/ou réelle, au profit d'autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
D'une façon générale, la Société pourra réaliser toutes opérations mobilières et immobilières, commerciales, indus-
trielles ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en faciliter
l'extension ou le développement, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution
de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.
Art. 4. La Société prend la dénomination sociale de «Exclusif esthétique S.à r.l.».
Art. 5. Le siège de la Société est établi dans la commune de Strassen.
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d'autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé en cent (100) parts sociales d'une
valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites et
entièrement libérées.
Art. 7. Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision écrite et régulièrement publiée de
l'associé unique, sinon de l'assemblée des associés, conformément à l'article 16 des présents statuts.
Art. 8. Chaque part sociale ouvre un droit à l'actif social de même qu'aux bénéfices réalisés au cours de l'exercice, en
proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un unique propriétaire pour chacune
d'elles.
Les copropriétaires indivis des parts sociales sont tenus d'être représentés auprès de la Société par une seule et même
personne.
Art. 10. Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seing privé.
En cas d'associé unique, les cessions et transmissions, sous quelque forme que ce soit, de parts sociales sont libres.
Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles sous réserve de la stricte observation des dispositions
énoncées à l'article 189 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
47257
L
U X E M B O U R G
Toute opération de cession n'est opposable à la Société comme aux tiers qu'à la condition d'avoir été notifiée à la
Société ou acceptée par elle conformément aux dispositions prescrites à l'article 1690 du Code civil.
Au surplus, il ne pourra être contracté d'emprunt par voie publique d'obligations, ni procédé à une émission publique
de parts sociales.
Art. 11. La Société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil
de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocable(s) ad nutum.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, dispose des pouvoirs les plus étendus afin d'accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux qui sont
expressément réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale des associés.
Art. 13. La Société sera engagée par la signature individuelle de son gérant unique, et en cas de pluralité de gérants,
par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance, peut sous-déléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Tout litige dans lequel la Société apparaît comme demandeur ou comme défendeur, sera géré au nom de la Société
par le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le Conseil de gérance représenté par un gérant délégué à cet effet.
Art. 14. Les réunions du Conseil de Gérance auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil de gérance ne
peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est présente en personne ou par procu-
ration. Les résolutions du Conseil de gérance sont adoptées à la majorité des votes des gérants présents ou représentés.
En cas d'urgence, les résolutions écrites signées par l'ensemble des membres du Conseil de gérance seront valablement
passées et effectives comme si passées lors d'une réunion dûment convenue et tenue. De telles signatures peuvent
apparaître sur un document unique ou plusieurs exemplaires d'une résolution identique et peuvent être prouvées par
lettre, fax ou communication similaire.
De plus, tout membre qui participe aux débats d'une réunion du Conseil de gérance aux moyens d'un appareil de
communication (notamment par téléphone), qui permet à tous les membres présent à cette réunion (que ce soit en
personne ou par procuration ou tout autre appareil de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres
membres à tout moment, sera supposé être présent à cette réunion et sera comptabilisé pour le calcul du quorum et
sera autorisé à voter sur les questions à l'ordre du jour de cette réunion. Si une résolution est prise par voie de conférence
téléphonique, la résolution sera considérée comme ayant été prise au Luxembourg si l'appel provient initialement du
Luxembourg.
Art. 15. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Toutefois, la Société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins
qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des
circonstances, sans que la publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 16. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de
parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés,
les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant
plus de la moitié du capital social, sans préjudice des autres dispositions de l'article 194 de la loi modifiée du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales.
Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que par l'accord de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 17. Une assemblée générale annuelle des associés, qui doit se tenir au cas où la Société a plus de vingt-cinq (25)
associés, se réunira une fois par an pour l'approbation des comptes annuels, elle se tiendra le deuxième mardi du mois
de mai de chaque année au siège de la Société ou en tout autre lieu à spécifier dans la convocation de cette assemblée.
Si ce jour n'est pas généralement un jour bancaire ouvrable à Luxembourg, l'assemblée se tiendra le premier jour
ouvrable suivant.
Art. 18. L'année sociale de la Société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Art. 19. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le Conseil
de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.
47258
L
U X E M B O U R G
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir, prendre au siège social de la Société, communication de
l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance (si la Société compte plus de vingt-cinq associés parmi ses
rangs, conformément aux dispositions prescrites par la loi).
Art. 20. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annue9%ls, déduction faite des frais généraux,
amortissements et charges, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que
celui-ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.
Art. 21. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique, ou le cas échéant les associés, s'en
réfèrent aux dispositions légales de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
<i>Disposition transitoire:i>
Par dérogation le premier exercice social commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libération:i>
Les statuts de la Société ayant été ainsi arrêtés, la comparante pré-qualifiée, déclare souscrire cent (100) parts sociales
comme suit:
- Madame Laurence STREVELER, pré-qualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
TOTAL : cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts
La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze
mille cinq cent euros (EUR 12.500,-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné, qui le constate expressément.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de mille cent euros (EUR
1.100,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
La comparante pré-qualifiée, présente ou représentée comme mentionné ci-avant, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, se considérant comme dûment convoquée, s'est ensuite constituée en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée était régulièrement constituée, elle a pris les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Laurence STREVELER, Esthéticienne, née le 31 janvier 1970 à Charleroi, demeurant à L-8041 Strassen, 120,
rue des Romains.
3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.
4.- L'adresse du siège social de la Société est fixée à L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif la partie comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société,
celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation avec l'objet social tel
que modifié ci-dessus, ce qui est expressément reconnu par la partie comparante.
DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom
usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: L. STREVELER, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 27 février 2015. Relation: DAC/2015/3475. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 03 mars 2015.
Référence de publication: 2015035651/156.
(150040727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
47259
L
U X E M B O U R G
Hodge Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 171.422.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires de la Société tenue à Luxembourg, en date du 03i>
<i>Septembre 2014i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société que l'Assemblée
- décide de nommer Monsieur Egor Zhelezov, né à Moscou, Russie le 06 mai 1988, ayant son adresse professionnel
au 3 Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg avec effet immédiat la personne
suivante en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée;
- décide que la Société est valablement engagée par la signature individuelle de chaque gérant.
- le mandat du commissaire aux comptes de la Société, à savoir PricewaterhouseCoopers, S.à r.l., situe a 2 rue Gerhard
Mercator, L-2182, Luxembourg, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale appelée à délibérer sur les comptes annuels
de la Société au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 Septembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2015037043/19.
(150041438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Wogema, Société Anonyme.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 29, rue Notre Dame.
R.C.S. Luxembourg B 194.913.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dritten Februar
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Ist erschienen:
Pevia Private Equity S.A., eine Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts mit Sitz in L-1750 Luxemburg, 62, Avenue
Victor Hugo, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 137.977, hier ver-
treten durch Herrn Robert Langmantel, delegierter Verwalter, beruflich wohnhaft in L-1313 Luxemburg, 2A, rue des
Capucins,
Vorbenannte Person ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr zu gründenden Aktiengesellschaft
wie folgt zu dokumentieren.
Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Es wird eine anonyme Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung:
"WOGEMA S.A.".
Die Gesellschaft kann einen einzigen oder mehrere Gesellschafter haben. Solange die Gesellschaft nur einen Gesell-
schafter hat, kann diese durch einen einzigen Verwalter verwaltet werden, welcher nicht der einzige Gesellschafter zu
sein braucht.
Der Tod, die Aufhebung der Zivilrechte, der Konkurs, die Liquidation oder der Bankrott des einzigen Gesellschafters
lösen die Gesellschaft nicht auf.
Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters können Niederlassungen, Zweigstellen,
Agenturen und Büros sowohl im Grossherzogtum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates oder des einzigen Verwalters kann der Sitz der Gesellschaft an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden.
Sollte die normale Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder auch dieses
Sitzes mit dem Ausland durch aussergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet wer-
den, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins
Ausland verlegt werden. Diese einstweilige Massnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft,
die unabhängig von dieser einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Die Bekanntmachung von einer derartigen Verlegung hat durch die Organe zu erfolgen, die mit der täglichen Ge-
schäftsführung beauftragt sind.
Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.
47260
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck jedwelche Beteiligung an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften,
der Erwerb durch Ankauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie Übertragung durch Verkauf, Wechsel oder auf andere
Art, von Wertpapieren, Verbindlichkeiten, Schuldforderungen, Scheinen und anderen Werten aller Art, der Besitz, die
Verwaltung und Verwertung ihres Wertpapierbestandes.
Die Gesellschaft kann sich an der Gründung und Entwicklung jeder finanziellen, industriellen oder kommerziellen
Gesellschaft beteiligen und an verbundene Gesellschaften alle Mithilfe geben, sei es durch Kredite, Garantien oder auf
andere Art und Weise. Die Gesellschaft kann auf jede Art Darlehen und Unterstützung an verbundene Gesellschaften
geben.
Sie kann alle Kontrollen und Aufsichtsmaßnahmen durchführen und jede Art von finanziellen, kommerziellen und
industriellen Operationen tätigen, beweglicher oder unbeweglicher Natur, welche sie für nötig hält zur Verwirklichung
und Durchführung ihres Zweckes.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) eingeteilt in neunzigtausend (90.000)
Aktien mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1,-) pro Aktie.
Die Aktien sind Namensaktien.
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf Ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder reduziert werden.
Verwaltung - Überwachung
Art. 6. Wenn die Gesellschaft durch einen einzigen Gesellschafter gegründet wurde oder wenn durch Generalver-
sammlung festgestellt wird, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Gesellschafter hat, kann die Gesellschaft durch einen
einzigen Verwalter verwaltet werden, der „einziger Verwalter“ genannt wird, bis zur nächsten ordentlichen Generalver-
sammlung, welche das Vorhandensein von mehr als einem Aktionär feststellt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Gesellschafter hat wird diese durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus
mindestens drei (3) Mitgliedern besteht, die nicht Aktionär sein müssen. In diesem Fall muss die Generalversammlung
zusätzlich zu dem einzigen Verwalter zwei (2) neue Verwalter ernennen. Der einzige Verwalter beziehungsweise die
Verwalter werden für eine Dauer ernannt, die sechs Jahre nicht überschreiten darf. Sie können von der Generalver-
sammlung wiedergewählt und jederzeit abberufen werden.
Jeder Verweis auf den Verwaltungsrat in vorliegender Satzung ist ein Verweis auf den einzigen Verwalter solange die
Gesellschaft einen einzigen Gesellschafter hat.
Wenn eine juristische Person Verwalter der Gesellschaft ist, muss diese einen ständigen Vertreter bestimmen, welcher
die juristische Person gemäss Artikel 51bis des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, so wie
dies abgeändert wurde (das „Gesetz von 1915“), vertritt.
Der/die Verwalter werden durch die Generalversammlung ernannt. Die Gesellschafter bestimmen ebenfalls die Anzahl
der Verwalter, ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates.
Wird die Stelle eines Mitglieds des Verwaltungsrates durch Tod, Pension oder jeden anderen Grund, frei, so können
die verbleibenden Mitglieder durch einfache Stimmenmehrheit das frei gewordene Amt bis zur nächsten Generalver-
sammlung der Aktionäre besetzen.
Art. 7. Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter hat die weitestgehenden Befugnisse alle Verwal-
tungs- und Verfügungshandlungen durchzuführen, die im Interesse der Gesellschaft sind.
Alle Handlungen, die nicht ausdrücklich durch gegenwärtige Satzung und das Gesetz von 1915, der Generalversamm-
lung vorbehalten sind, fallen der Kompetenz des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwalters zu.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden. Wenn kein Vorsitzender vorhanden
ist, kann der Vorsitz der Versammlung einem anwesenden Verwalter anvertraut werden.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist, wobei
Vollmacht zwischen Mitgliedern möglich ist. Die Verwaltungsratsmitglieder können die Vollmacht schriftlich, fernschrift-
lich, telegraphisch oder per Telefax geben.
In Dringlichkeitsfällen können die Verwaltungsratsmitglieder ihre Stimme auch schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch
oder per Telefax abgeben.
Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden durch einfache Stimmenmehrheit gefasst. Im Falle von Stimmgleichheit
ist die Stimme des Vorsitzenden der Versammlung entscheidend.
Handeln die Verwaltungsratsmitglieder einstimmig auf dem Wege eines Zirkularbeschlusses, so können sie ihre Zus-
timmung auf einem oder mehreren individuellen Dokumenten schriftlich, fernschriftlich, telegraphisch oder per Telefax
oder über jedes andere elektronische Kommunikationsmittel, das die Zustimmung belegt, abgeben.
Die Beschlüsse, die durch den einzigen Verwalter gefasst werden haben die gleiche Ausführungskraft wie diejenigen,
die durch den Verwaltungsrat gefasst werden und werden in Protokollen festgehalten, welche durch den einzigen Ver-
walter unterschrieben werden und wovon Kopien und Auszüge angefertigt werden können.
47261
L
U X E M B O U R G
Der erste Vorsitzende wird von der Generalversammlung gewählt.
Art. 9. Der Verwaltungsrat kann seinen Mitgliedern seine Befugnisse zur täglichen Geschäftsführung sowie der Ver-
tretung der Gesellschaft in der Verwaltung dieser Geschäfte, übertragen.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter kann ausserdem jedwelcher Person, die nicht Verwalter
sein muss, jedwelche Spezialvollmacht erteilen sowie Vertreter und Angestellte ernennen und abberufen und ihren Lohn
festsetzen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird nach aussen verpflichtet durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsrats-
mitgliedern, in der täglichen Geschäftsführung durch die Einzelunterschrift des delegierten Verwalters, beziehungsweise
durch die Unterschrift des einzigen Verwalters oder durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift eines im Rahmen
der ihm erteilten Vollmachten handelnden Bevollmächtigten des Verwaltungsrates beziehungsweise des einzigen Verwal-
ters.
Art. 11. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere von der Generalversammlung ernannte(n)
Kommissar(e) überwacht, die die Anzahl und Vergütung festlegt.
Die Dauer der Amtszeit des(der) Kommissars/Kommissare, wird von der Generalversammlung festgelegt. Sie kann
jedoch sechs Jahre nicht überschreiten.
Geschäftsjahr - Generalversammlung
Art. 12. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.
Art. 13. Für den Fall, dass es nur einen Gesellschafter (einziger Gesellschafter) gibt, übt dieser im Laufe der ordnungs-
gemäss abgehaltenen Generalversammlungen sämtliche Befugnisse aus, welche laut dem Gesetz von 1915 der General-
versammlung obliegen.
Die Generalversammlungen werden gemäss den gesetzlichen Bestimmungen einberufen. Sie sind nicht nötig, wenn alle
Gesellschafter bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind und wenn sie erklären vorab von der Tagesordnung
Kenntnis genommen zu haben.
Jede Aktie gibt Anrecht auf eine Stimme.
Art. 14. Jede ordentliche oder ausserordentliche Generalversammlung kann nur gültig über die Tagesordnung befinden,
wenn die Gesellschafter in den gesetzlich vorgesehenen Verhältnissen anwesend oder vertreten sind.
Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse, um alle Handlungen im Interesse der Gesellschaft zu
tätigen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die Generalversammlung bestimmt über die Verwendung und die Zuteilung der Gewinne.
Der Verwaltungsrat beziehungsweise der einzige Verwalter ist ermächtigt Zwischendividenden, auszuschütten gemäss
den gesetzlichen Bestimmungen.
Art. 16. Die jährliche Generalversammlung tritt in dem im Einberufungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar
am dritten Freitag des Monats Mai um 10 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 17. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes von 1915 erfüllt sind.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
- Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
- Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die aufgrund dieser Gründung angefallenen Ausgaben, Kosten, Entschädigungen oder Gebühren jeglicher Form, welche
durch die Gesellschaft zu begleichen sind, werden auf ungefähr eintausendsechshundert Euro (EUR 1.600.-) geschätzt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Der vorgenannte Komparent erklärt, die gesamten neunzigtausend (90.000) Aktien mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1,-) zu zeichnen und sie ganz durch eine Geldeinlage von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,-)
einzubezahlen, welche wie folgt eingeteilt wird:
- Der Betrag von neunzigtausend Euro (EUR 90.000,-) wird dem Kapital zugeteilt;
- Der Betrag von einhundertzehntausend Euro (EUR 110.000,-) wird der Emissionsprämie zugeteilt.
47262
L
U X E M B O U R G
<i>Beschlüsse des Alleinigen Gesellschaftersi>
Sodann hat der Erschienene folgende Beschlüsse gefasst:
1.- Zum einzigen Verwalter wird ernannt:
Herr Gerhard Henze, Bankkaufmann, geboren in Berlin (Deutschland) am 13. Januar 1943, wohnhaft in CH-8126
Zumikon, Weberacher 10.
Der einzige Verwalter wird für eine Dauer von sechs (6) Jahren genannt.
2.- Zum Kommissar wird ernannt:
ANKIN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Bonameser Strasse 9a, D-60433 Frankfurt am Main, eingetragen
beim Amtsgericht Frankfurt am Main unter der Nummer HRB 98136.
Der Kommissar wird für eine Dauer von sechs (6) Jahren genannt.
3.- Der Gesellschaftssitz befindet sich an folgender Adresse:
L-2240 Luxemburg, 29, rue Notre Dame.
<i>Bevollmächtigungi>
Der Erschienene erteilt hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten Notars Spezialvollmacht, in seinem
Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen in Senningerberg, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der anwesenden Person, welche dem unterzeichnenden Notar durch Name, Vorname, Fa-
milienstand und Anschrift bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die anwesende Person zusammen mit dem Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Robert Langmantel, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 10 février 2015. 1LAC / 2015 / 4131. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 24. Februar 2015.
Référence de publication: 2015035430/169.
(150039543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
ECE European Prime Shopping Centre II B, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 189.417.
<i>Auszüge aus dem Gesellschaftvertrag (der „Gesellschaftsvertrag") der ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSP, eineri>
<i>Speziellen Kommanditgesellschaft Luxemburger rechts (Special Limited Partnership)i>
1) Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften
ECE European Prime Shopping Centre Fund II GP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 188.551 mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) (die „Komplementärin"); und
KG CURA Luxemburg Beteiligungs II G.m.b.H. & Co., eine Kommanditgesellschaft, gegründet und bestehend nach
deutschem Recht, mit Gesellschaftsitz in der Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, eingetragen im Handelsregister
beim Amstgericht Hamburg unter der Nummer HRA 117847, vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin
Cura Luxemburg Verwaltung G.m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deut-
chem Recht, mit Gesellschaftssitz in der Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 112032 (die „Gründungskomplementärin").
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. März 2015.
ECE European Prime Shopping Centre II B
Unterschrift
Référence de publication: 2015036946/25.
(150041540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47263
L
U X E M B O U R G
Vontobel Asset Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 2-4, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 78.142.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg
There appeared
Vontobel Holding AG, a company existing under the laws of Switzerland, with registered office in 43 Gotthardstrasse,
CH-8022 Zurich, Switzerland,
represented by Maître Linda Funck, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
12 March 2015 which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted
together with it to the registration formalities,
being the sole shareholder of Vontobel Asset Management S.A. (the "Company") (the “Sole Shareholder”), a société
anonyme with its registered office at 2-4, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade
and companies register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 78 142, incorporated by
a deed of Me Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 29 September
2000, which was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 221 on 26
March 2001. The articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on 3 February 2014
published in the Mémorial number 1059 of 25 April 2014.
The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the sole shareholder of the Company and holds thirty three thousand and one hundred
ninety-two shares in registered form (33,192) with a par value of sixty-five Euro and twenty five cents (EUR 65,25) each
in issue in the Company so that the entire share capital of two million one hundred and sixty-five thousand and seven
hundred and seventy-eight euro (EUR 2,165,778) is represented and decisions can be validly taken by the Sole Shareholder.
II. The common draft terms of merger of the Company (as absorbing company) and Vontobel Management S.A. (he-
reinafter “VOMSA”) (as absorbed company) (the “Merger Proposal”) had been approved by the board of directors of
VOMSA and the board of directors of the Company on 10 February 2015 and had been published on 17 February 2015
in the Mémorial number 423 in accordance with article 262 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies
as amended (the “1915 Law”);
III. The items on which resolutions are to be passed are the following:
1) Approval of the Merger Proposal and decision to realise the merger of the Company (as absorbing company) and
Vontobel Management S.A. (“VOMSA”) (as absorbed company), according to article 259 of the law on commercial com-
panies dated 10 August 1915, as amended (the “1915 Law”) by the contribution, following VOMSA’s dissolution without
liquidation, of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of VOMSA to the Company;
2) Acknowledgement of the report of the approved statutory auditor, prepared in accordance with article 26-1 of the
Law, in accordance to which the value of VOMSA is of an amount of at least four million three hundred ninety-three
thousand nine hundred forty-seven euro and forty-one cents (EUR 4,393,947.41)(the “Total Value”).
3) Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of two million one hundred and sixty-
five thousand and seven hundred and seventy-eight euro (EUR 2,165,778) to two million one hundred and sixty-six
thousand and three hundred euro (EUR 2,166,300) by the issue of eight (8) shares of a nominal value of sixty-five euro
and twenty-five cents (EUR 65.25) each to the Sole Shareholder of VOMSA, in consideration of the universal transfer of
all assets and liabilities of VOMSA to the Company, with the balance between the Total Value and the new shares so
issued being allocated to the freely distributable reserve of the Company.
4) Amendment and restatement of the articles of incorporation of the Company so as to read as follows:
“ Art. 1. There exists among the subscribers and all those who may become owners of shares hereafter issued a
Corporation (the “Corporation”) in the form of a public limited company under the denomination of “Vontobel Asset
Management S.A.”.
Art. 2. The registered office is established in Luxembourg-City.
The registered office can be relocated to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by of resolution of the
Board of Directors.
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
The power of representation of branch heads is limited to the activities of the branch. The branch heads are obliged
to report comprehensively to the head-office on branch’s activities.
In the event that the Board of Directors determines that extraordinary political, economic or social developments
occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Corporation at its registered office or with
47264
L
U X E M B O U R G
the ease of communications with such office or between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures
shall have no effect on the nationality of the Corporation, which notwithstanding the temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg corporation.
Art. 3. The purpose of the Corporation is:
1. the management of Luxembourg and foreign undertakings for collective investment in transferable securities
("UCITS") authorised according to EU Directive 2009/65/EC and the additional management of other Luxembourg and
foreign undertakings for collective investment (UCIs), in accordance with Article 101(2) and Annex II of the Luxembourg
Law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment (the "2010 Law") (i.e. Article 6.2. and Annex
II of EU Directive 2009/65/EC); and
2. the management, administration and marketing of, Luxembourg and foreign alternative investment funds ("AIFs")
within the meaning of EU Directive 2011/61/EU and the exercise other activities related to the assets of AIFs, in accor-
dance with Article 5(2) and Annex I of the Luxembourg Law of 12 July 2013 relating to alternative investment fund
managers (the "2013 Law") (i.e. Article 6.2. and Annex I of EU Directive 2011/61/EU).
The Corporation may provide the services of (a) management of portfolios of investments on a discretionary client-
by-client basis and (b) investment advice as contemplated in Article 101(3) of the 2010 Law (i.e. Article 6.3. of EU Directive
2009/65/EC) and/or Article 5.4. of the 2013 Law (i.e. Article 6.4. of EU Directive 2011/61/EU).
The Corporation may provide the above-mentioned management, administration and marketing services also to the
subsidiaries of UCITS, UCIs and AIFs to which it provides services, including domiciliation and administration support
services.
The Corporation may perform permitted activities outside of Luxembourg through the free provision of services and/
or through the opening of subsidiaries, branches or representative offices.
More generally, the Corporation may carry out any activities connected with the services it provides to UCITS, UCIs
and AIFs to the furthest extent permitted by the 2010 Law, the 2013 Law and any other applicable laws and regulations.
The Corporation may carry out any activities connected directly or indirectly to, and/or deemed useful and/or ne-
cessary for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth in, but to the furthest
extent permitted by, the provisions of the 2010 Law and the 2013 Law.
For the avoidance of doubt, the Corporation may act as manager (gérant) of partnerships (including corporate part-
nerships limited by shares, common limited partnerships or special limited partnerships) within the meaning of article
107, article 17 and article 22-3 of the Luxembourg Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended or the
equivalent under the relevant law.
Art. 4. The Corporation is established for an unlimited duration.
The Corporation may be dissolved by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment
of these articles of incorporation (the “Articles of Incorporation”), as prescribed in Article 17 hereof.
Art. 5. The corporate capital is set at TWO MILLION ONE HUNDRED SIXTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED
EURO (EUR 2,166,300) divided into THIRTY THREE THOUSAND TWO HUNDRED (33,200) shares with a nominal
value of SIXTY FIVE EURO AND TWENTY FIVE CENTS (EUR 65.25), each fully paid-up.
The corporate capital can be increased or decreased as resolved by the shareholders.
Art. 6. The shares shall be in registered form and a shareholders' register shall contain the precise designation of each
shareholder, the indication of the number of his shares and, if applicable, their transfer with the relevant date.
Art. 7. The Corporation shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need
not to be shareholders.
The directors shall be elected by the shareholders' meeting which shall determine their number, subject however that
a member of the Board of Directors can be removed from his office or replaced by a decision of the shareholders with
or without stating a reason. They shall be elected for a period of one year and they may be re-elected for further terms.
In the event of a vacancy in the office of a director, the remaining directors may meet and elect, by majority vote, a
director to fill such a vacancy until the next meeting of shareholders.
Art. 8. The Board of Directors shall choose from among its members a chairman and may choose a vice-chairman.
The Board of Directors may also nominate any secretary, officer or employee it deems necessary for the performance
of its duties hereunder.
The Board of Directors shall meet upon call by the chairman or if convened by any other two directors.
The chairman shall preside at all meetings of shareholders and of the Board of Directors, but in his absence the general
meeting or the Board will appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of votes cast at such
general meeting or the majority present at such board meeting.
Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be given to all directors at least eight days in advance
of the day set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances
47265
L
U X E M B O U R G
shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing of each director. No
separate notice shall be required for meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by
resolution of the Board of Directors.
Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing another director as his proxy.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or repre-
sented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
The Board of Directors may approve resolutions by circular vote, expressed in writing on one or several instruments,
provided these are approved by the unanimous vote of all directors.
Any director may participate at any meeting of Board of Directors by video conference or any other communication
means which allow to participate at a meeting, i.e. to listen/hear each other and to talk to each other. The participation
via video conference or any other communication means is considered equivalent to personal participation.
Art. 9. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be signed by the chairman of the meeting and by
the secretary of the Board of Directors or by any other director. The proxies will remain attached thereto.
Copies of extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman of the Board and by the secretary of the Board of Directors or by any two directors.
Art. 10. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for
accomplishing the Corporation's object. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the
general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.
The Board of Directors may delegate the daily management of the Corporation, the representation of the Corporation
within such daily management to two or more directors, officers, executives, employees or other persons who may, but
need not, be shareholders, or delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary func-
tions to persons or agents chosen by it.
Delegation of daily management to a member of the Board is subject to previous authorization by the general meeting
of shareholders.
The Board of Directors may proceed to the payment of interim dividends in accordance with the provisions of the
law.
Art. 11. No contract or other transaction between the Corporation and any other company or firm shall be affected
or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Corporation is interested in, or is a
director, associate, officer or employee of such other company or firm.
In the event that any director or officer of the Corporation may have any personal interest in any transaction of the
Corporation, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of shareholders. The term “personal interest”, as used in the preceding
sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving Vontobel
Holding AG and any subsidiary or affiliate thereof or such other corporation or entity as may from time to time be
determined by the Board of Directors in its discretion, unless such “personal interest” is considered to be a conflicting
interest by applicable laws and regulations.
The Corporation may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses
reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason
of his being or having been a director or officer of the Corporation, or, at its request, of any other corporation of which
the Corporation is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to
matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or misconduct;
in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the
settlement as to which the Corporation is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a
breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 12. The Corporation will be bound by the joint signatures of any two directors or by the joint signatures of any
director and any duly authorized officer, or by the individual signature of any director or agent of the Corporation duly
authorized for this purpose, or by the individual signature of any person to which special power has been delegated by
the Board, but only within the limits of such powers.
Art. 13. The accounts and the operations of the Corporation shall be reviewed by one or more approved statutory
auditors (“réviseurs d'entreprises agréés”).
The approved statutory auditor(s) shall be elected by the general meeting of shareholders and shall remain in office
until the next annual general meeting of shareholders and until his/their successor(s) is/are elected.
47266
L
U X E M B O U R G
The approved statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the shareholders in accordance with
applicable legal provisions.
Art. 14. The shareholders' meeting, regularly constituted, shall represent the entire body of shareholders. It shall have
the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Corporation.
Art. 15. The annual meeting of shareholders shall be held in Luxembourg-City, at the principal office of the Corporation
or such other place as may be specified in the notice of meeting, one day after the last Tuesday in March of each year, at
2.30 pm.
If such day is a Luxembourgish legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day in
Luxembourg. The annual meeting of shareholders may be postponed to another date and/or time if the majority of the
shareholders agree. Shareholders' meetings, including the statutory annual meeting, may be held abroad if, in the judgment
of the Board of Directors, which shall be final, circumstances of force majeure so require or a majority of the shareholders
agree to another meeting place.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing in writing as
his proxy another person who need not be a shareholder.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled in order to take part in a shareholders'
meeting.
Art. 16. Shareholders shall meet upon call by the Board of Directors made in the forms provided by law.
If all of the shareholders are present or represented at a shareholders' meeting and if they state that they have been
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.
Art. 17. In the case of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum and majorities shall be those laid
down in company law; at all other meetings, the decisions shall be taken, irrespectively of the number of shares present
or represented, by a simple majority of the vote casts.
Art. 18. The accounting year of the Corporation shall begin the first of January of each year and shall terminate on the
thirty-first of December of the same year.
Art. 19. From the annual net profit of the Corporation five per cent shall be allocated to the reserve required by law.
This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent of the value
capital of the Corporation.
The general meeting may decide how to allocate the remainder of the annual net benefit or may distribute it from
time to time to the shareholders.
The Corporation may distribute interim dividends subject to all requirements provided by law.
The Board of Directors may decide on currency and moment in time for interim dividend payments. The Board of
Directors is entitled to ultimately decide the exchange rate to convert the dividend into the currency in which it will be
paid out.
Art. 20. In the event of a dissolution of the Corporation, liquidation shall be carried out by one or several liquidators
who may be physical persons or legal entities appointed by the general meeting of shareholders which shall determine
their powers and their compensation.
Art. 21. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance with the Law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Law of 2010 and the Law of 2013.
5) Acknowledgement of the effective date of the merger, which is set at 31 March 2015;
6) Acknowledgment of the resignation of Mr Remigio Luongo and Mr Axel Jürgen Schwarzer from their function as
directors of the Company and decision to appoint Me Sophie Dupin as director of the Company with immediate effect
until the ordinary general meeting of shareholders of the Company to be held in 2016.
IV. The provisions regarding mergers of the 1915 Law have been fulfilled:
a) publication on the 17 February 2015 of the Merger Proposal in the Mémorial number 423, at least one month before
the date of the general meetings deciding on the Merger Proposal;
b) waiver by the Sole Shareholder of the merging companies, pursuant to a written resolution dated 9 February 2015,of
the requirement to have the board of directors of the Company prepare a written report in accordance with article 265
of the 1915 Law;
c) waiver by the Sole Shareholder of the merging companies, pursuant to a written resolution dated 9 February 2015,of
the requirement to have an expert report drawn up in accordance with article 265 of the 1915 Law;
d) deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least
one month before the date of the general meeting of the merging companies respectively, except for the reports of the
board of the directors of the merging companies and the independent expert provided for by article 266 respectively
article 265 of the 1915 Law, which were waived by the Sole Shareholder of each of the merging companies pursuant to
their respective resolutions dated 9 February 2015.
47267
L
U X E M B O U R G
After the approval of the foregoing, the Sole Shareholder passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the Merger Proposal in all its provisions and in its entirety, without exception
or reserves.
The Sole Shareholder resolved to realise the merger by the transfer by VOMSA following its dissolution without
liquidation of any and all assets liabilities, rights, obligations and contracts to the Company, in accordance with article 259
of the 1915 Law.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged the report of the approved statutory auditor, prepared by Ernst & Young S.A.,
on 31 March 2015 in accordance with article 26-1 of the Law, the conclusion of which is the following:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 8 shares with a
nominal value of EUR 65.25 each to be issued with a total related share premium of EUR 4,393,425.41. The total value
of the contribution is EUR 4,393,947.41.”
The report, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary will remain attached
to this deed to be filed with it with the registration authorities.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of two
million one hundred and sixty-five thousand and seven hundred and seventy-eight euro (EUR 2,165,778) to two million
one hundred and sixty-six thousand and three hundred euro (EUR 2,166,300) by the issue of eight (8) shares of a nominal
value of sixty-five euro and twenty-five cents (EUR 65.25) each to the Sole Shareholder of VOMSA, in consideration of
the universal transfer of all assets and liabilities of VOMSA to the Company, with the balance between the net Total Value
and the new shares so issued being allocated to the freely distributable reserve of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company as set forth in item
4 of the agenda above.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder noted that the merger is effective, from an accounting and tax point of view, as from 31 March
2015 without prejudice to the provisions of article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third
parties.
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder acknowledged the resignation of Mr Remigio Luongo and Mr Axel Jürgen Schwarzer from their
function as directors of the Company with effective date today and decided to appoint Me Sophie Dupin, born on 5 April
1974, in Dax (F) and professionally residing at 2, place Winston Churchill, L-2014 Luxembourg, as director of the Company
with immediate effect until the ordinary general meeting of shareholders of the Company to be held in 2016.
<i>Statementsi>
The undersigned notary stated, the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by
the Company and the Absorbed Company, and the Merger Proposal.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this merger are estimated at approximately EUR 7,000.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the parties hereto,
these minutes are drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing persons in
case of discrepancies between the English and German text, the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einunddreißigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Grossherzogtum
Luxemburg).
Erschien die
47268
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft Vontobel Holding AG, eine Gesellschaft welche unter den Gesetzen der Schweiz besteht, mit Sitz in
CH-8022 Zürich, Gotthardstrasse 43, vertreten durch Maître Linda Funck, maître en droit, mit beruflicher Adresse in
Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12 März 2015, welche ne varietur unterzeichnet wurde und der vorliegenden
notariellen Urkunde als Anlage beiliegen wird, alleinige Aktionärin der "Vontobel Asset Management S.A." (die "Gesell-
schaft") (die "Alleinige Aktionärin"), société anomyme, mit Gesellschaftssitz in L-1148 Luxemburg, 2-4, rue Jean l'Aveugle,
gegründet durch notarielle Urkunde von Maître Joseph Elvinger, Notar, mit dem damaligne Amtswohnsitz in Luxemburg,
am 29. September 2000, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") vom 26. März
2001, Nummer 221, veröffentlicht wurde (die "Gesellschaft"),
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert durch Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar
am 13. Februar 2014 veröffentlicht im Mémorial Nummer 1059 vom 25. April 2014.
Die erschienene Partei erklärte und beauftragte den Notar folgendes festzustellen:
I. Die erschienene Partei ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft und hält dreiunddreißigtausend und ein hundert
zweiundneunzig (33.192) Namensaktien mit einem Nominalwert von jeweils fünfundsechzig Euro und fünfundzwanzig
Cent (EUR 65,25), alle von der Gesellschaft ausgegeben so dass das gesamte Aktienkapital von zwei Millionen einhun-
dertfünfundsechzigtausend und siebenhundertachtundsiebzig (EUR 2.165.778) vertreten ist und der Alleinige Aktionär
wirksam beschließen kann.
II. Der gemeinsame Verschmelzungsplan der Gesellschaft (als aufnehmende Gesellschaft) und Vontobel Management
S.A. (nachfolgend "VOMSA")(als übertragende Gesellschaft)(der "Verschmelzungsplan") wurde vom Verwaltungsrat der
VOMSA und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft am 10. Februar 2015 genehmigt und wurde am 17. Februar 2015 im
Mémorial unter der Nummer 423, gemäß Artikel 262 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften (das "1915 Gesetz"), veröffentlicht;
III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1) Zustimmung zum Verschmelzungsplan und Beschluss die Verschmelzung der Gesellschaft (als aufnehmende Gesell-
schaft) und Vontobel Management S.A. ("VOMSA") (als übertragende Gesellschaft) durchzuführen, gemäß Artikel 259 des
abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das "1915 Gesetz"), durch Übertragung, infolge
der Auflösung ohne Liquidation, von allen Aktiva, Passiva, Rechten, Verpflichtungen und Verträgen der VOMSA an die
Gesellschaft.
2) Zur Kenntnisnahme des Berichtes des unabhängigen Wirtschaftsprüfers ausgearbeitet gemäß Artikel 26-1 des 1915
Gesetzes, gemäß welchem der Wert der VOMSA mindestens vier Millionen dreihundertdreiundneunzigtausend neun-
hundertsiebenundvierzig Euro und einundvierzig Cent (EUR 4.393.947,41) (der "Gesamtwert") beträgt.
3) Erhöhung des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft von zur Zeit zwei Millionen einhundertfünfundsechzig-
tausend siebenhundert achtundsiebzig Euro (EUR 2.165.778) auf zwei Millionen einhundertsechsundsechzigtausend
dreihundert Euro (EUR 2.166.300), durch die Ausgabe von acht (8) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils fünfund-
sechzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 65,25), an den alleinigen Aktionär der VOMSA, im Gegenzug der Gesamt-
übertragung von allen Aktiva und Passiva der VOMSA an die Gesellschaft, vobei die Differenz zwischen dem Gesamtwert
und den so neuausgegebenen Aktien der freiverfügbaren Rücklage der Gesellschaft zugeteilt wird.
4) Abänderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft welche so dann wie folgt lautet:
„ Art. 1. Zwischen den Unterzeichneten und allen zukünftigen Aktionären besteht eine Aktiengesellschaft in Form
einer Société Anonyme unter der Bezeichnung „Vontobel Asset Management S.A.“ (die „Gesellschaft“).
Art. 2. Der Gesellschaftssitz befindet sich in Luxemburg-Stadt. Durch Beschluss des Verwaltungsrats kann der Sitz an
jeden anderen Ort des Großherzogstums Luxemburg verlegt werden.
Niederlassungen oder andere Büros können sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland, durch Be-
schluss des Verwaltungsrates, errichtet werden.
Die Vertretungsmacht der Zweigniederlassungsleiter ist auf die Tätigkeiten der Zweigniederlassung beschränkt. Die
Zweigniederlassungsleiter sind zur umfassenden Information über die Aktivitäten der Zweigniederlassung an die Haupt-
geschäftsstelleverpflichtet.
Sollten außergewöhnliche politische, militärische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse eintreten oder bevorstehen,
welche nach Meinung des Verwaltungsrats die normale Tätigkeit am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Kommu-
nikationsverkehr mit diesem Gesellschaftssitz, oder zwischen diesem Gesellschaftssitz und sich im Ausland befindlichen
Personen beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur Beendigung dieser außergewöhnlichen Ereignisse
vorübergehend ins Ausland verlegt werden; diese vorläufigen Maßnahmen haben jedoch keinerlei Einfluss auf die Natio-
nalität der Gesellschaft, welche ungeachtet der vorübergehenden Verlegung ihres Sitzes weiterhin eine luxemburgische
Gesellschaft bleibt.
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist:
1. die Verwaltung luxemburgischer und ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (nach-
stehend „UCITS“), erlaubt gemäß EU Richtlinie 2009/65/EC und die zusätzliche Verwaltung luxemburgischer und
47269
L
U X E M B O U R G
ausländischer Organismen für gemeinsame Anlagen (nachstehend „UCIs“), gemäß Artikel 101 (2) und Anhang II des
luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“)
(d.h. Artikel 6.2. und Anhang II der EU Richtlinie 2009/65/EC); und
2. die Verwaltung, Leitung und Vermarktung luxemburgischer und ausländischer alternativer Investmentfonds („AIFs“)
im Sinne der EU Richtlinie 2011/61/EU und die Ausübung anderer Tätigkeiten bezüglich des Vermögens von AIFs, gemäß
Artikel 5(2) und Anhang I des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds (das "Gesetz
von 2013"), (d.h. Artikel 6.2. und Anhang I der EU Richtlinie 2011/61/EU).
Die Gesellschaft kann die Dienstleistungen der: (a) individuellen Verwaltung von Anlageportfolios mit Ermessensspiel-
raum im Rahmen eines Mandats der Anleger, und (b) Anlageberatung, wie vorgesehen in Artikel 101 (3) des Gesetzes
von 2010 (d.h. Artikel 6.3. der EU Richtlinie 2009/65/EC) und/oder Artikel 5.4 des Gesetzes von 2013 (d.h. Artikel 6.4.
der EU Richtlinie 2011/61/EU), erbringen.
Die Gesellschaft kann die oben genannten Verwaltungs-, Leitungs-, und Vermarktungsdienstleistungen auch an die
Tochterunternehmen der UCITS, UCIs und AIFs erbringen, welchen sie Dienstleistungen erbringt, inbegriffen Dienst-
leistungen wie Domizilierung und Unterstützung bei der Verwaltung.
Die Gesellschaft kann die erlaubten Tätigkeiten außerhalb von Luxemburg, über den freien Dienstleistungsverkehr
und/oder die Eröffnung von Tochtergesellschaften, Zweigstellen oder Repräsentanzen, durchführen.
Im Allgemeinen kann die Gesellschaft alle Tätigkeiten erbringen, die mit den Dienstleistungen zusammenhängen, die
sie für UCITS, UCIs und AIFs erbringt, soweit diese Tätigungen im weitesten Sinne durch das Gesetz von 2010, das Gesetz
von 2013, und allen anderen anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen, erlaubt sind.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten erbringen die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit, und/oder als
nützlich und/oder notwendig gelten für, die Vollendung ihres Zweckes, solange diese im Rahmen der Bestimmungen des
Gesetzes von 2010 und des Gesetzes von 2013 bleiben, dieser Rahmen aber im weitesten Sinne ausgelegt.
Um Zweifel auszuräumen, kann die Gesellschaft als Geschäftsführer (gérant) von Partnerschaften (inbegriffen Kom-
manditgesellschaften auf Aktien, einfache Kommanditgesellschaften oder spezielle Kommanditgesellschaften), im Sinne
der Artikel 107, 17 und 22-3 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften oder ent-
sprechenden Bestimmungen in dem anwendbaren Recht, handeln.
Art. 4. Die Gesellschaft ist für eine unbeschränkte Dauer gegründet.
Die Gesellschaft kann mittels eines Beschlusses der Aktionäre aufgelöst werden, wobei dieser Beschluss gemäß den
in Artikel 17 dieser Satzung (die „Satzung“) aufgeführten Bestimmungen, betreffend die Abänderung der Satzung, erfolgen
muss.
Art. 5. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf ZWEI MILLIONEN EINHUNDERTSECHSUNDSECHZIGTAUSEND
DREIHUNDERT EURO (EUR 2.166.300), unterteilt in DREIUNDDREISSIGTAUSEND ZWEIHUNDERT (33.200) Aktien
mit einem Nominalwert von je FÜNFUNDSECHZIG EURO UND FÜNFUNDZWANZIG CENT (65,25 EUR), alle voll
eingezahlt.
Das Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Aktionäre erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Die Aktien der Gesellschaft sind ausschließlich Namensaktien und das Aktienbuch enthält genaue Angaben über
jeden Aktionär, die Anzahl der von ihm gehaltenen Aktien, und soweit anwendbar, jede Übertragung von Aktien sowie
das Datum einer solchen Übertragung.
Art. 7. Die Leitung der Gesellschaft obliegt einem Verwaltungsrat, der aus mindestens drei Mitgliedern bestehen muss,
welche nicht Aktionäre sein müssen.
Die Verwaltungsratsmitglieder werden durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre ernannt, welche
ebenfalls ihre Anzahl festlegt, mit dem Vorbehalt jedoch, dass ein Verwaltungsratsmitglied jederzeit durch Beschluss der
Aktionäre mit oder ohne Grund seines Amtes enthoben und/oder ersetzt werden kann. Die Mitglieder des Verwaltungs-
rates werden jährlich gewählt und sind wieder wählbar.
Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds frei, so können die übrigen Mitglieder zusammentreten und mit Stim-
menmehrheit ein Verwaltungsratsmitglied bestellen, um diesen freien Posten bis zur nächsten Versammlung der Aktionäre
zu besetzen.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und kann einen stellvertretenden Vorsitzenden
wählen. Der Verwaltungsrat darf ebenfalls sämtliche Schriftführer, Direktoren oder Angestellte ernennen, die er für die
Erfüllung seiner hierin vorgesehenen Aufgaben benötigt.
Der Verwaltungsrat tritt auf Einberufung des Vorsitzenden oder zweier Verwaltungsratsmitglieder zusammen.
Der Vorsitzende übernimmt den Vorsitz sämtlicher Versammlungen der Aktionäre und des Verwaltungsrats; in seiner
Abwesenheit können die Aktionäre oder der Verwaltungsrat jedoch ein anderes Verwaltungsratsmitglied mit Stimmen-
mehrheit der in dieser Generalversammlung abgegebenen Stimmen oder der Mehrheit der Anwesenden bei einer
Verwaltungsratssitzung anwesenden Person zum vorübergehenden Vorsitzenden wählen.
Die Verwaltungsratssitzungen werden sämtlichen Verwaltungsratsmitgliedern mindestens acht Tage im Voraus durch
eine schriftliche Mitteilung angekündigt, außer in dringenden Fällen, in welchen die Art dieser Umstände im Einberu-
47270
L
U X E M B O U R G
fungsschreiben anzugeben ist. Auf dieses Einberufungsschreiben kann mittels schriftlicher Zustimmung aller Verwaltungs-
ratsmitglieder verzichtet werden. Versammlungen, welche an Ort und Zeitpunkt, wie zuvor in einem Beschluss vom
Verwaltungsrat festgelegten Kalender angegeben, abgehalten werden, bedürfen keines gesonderten Einberufungsschrei-
bens.
Jedes Verwaltungsratsmitglied ist berechtigt, sich in den Verwaltungsratssitzungen durch ein anderes, schriftlich be-
vollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, vertreten zu lassen.
Der Verwaltungsrat kann nur rechtsgültig beschließen oder handeln, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder in der Ver-
waltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder getroffen.
Im Falle der Stimmengleichheit, sei es für oder gegen eine vom Verwaltungsrat zu treffende Bestimmung, entscheidet
die Stimme des Verwaltungsratsvorsitzenden.
Der Verwaltungsrat kann einstimmig per Zirkularbeschluss, in einer oder mehreren getrennten schriftlichen Ausfer-
tigung(en), Entscheidungen treffen.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in jeder Sitzung durch Konferenzschaltung oder andere ähnliche kommunikati-
onsfähige Mittel teilnehmen, welche es den Verwaltungsratsmitgliedern die in der Sitzung teilnehmen, erlauben einander
zu hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an der Sitzung durch diese Möglichkeit entspricht einer Teilnahme
in Person an dieser Sitzung.
Art. 9. Die Protokolle sämtlicher Verwaltungsratssitzungen werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer des
Verwaltungsrats oder einem anderen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet. Die Vollmachten werden als Beilage dem
Protokoll angefügt.
Abschriften oder Auszüge dieser Protokolle, welche vor Gericht oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom
Vorsitzenden und vom Sekretär des Verwaltungsrats oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Art. 10. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitesten Befugnisse, um alle Handlungen der Verwaltung und Verfü-
gungen zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks zu tätigen. Ihm obliegen alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich von Gesetzes
wegen oder durch die vorliegende Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.
Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse im Hinblick auf die tägliche Verwaltung der Gesellschaft, sowie die Vertre-
tung der Gesellschaft im Rahmen dieser täglichen Verwaltung, an zwei oder mehr Verwaltungsratsmitglieder, Geschäfts-
führer, Direktoren, Angestellte oder andere Personen, welche Aktionäre der Gesellschaft sein können, aber nicht müssen,
übertragen, oder spezielle Vollmachten oder zeitlich befristete oder unbefristete Befugnisse an ausgewählte Personen
erteilen.
Die Übertragung der täglichen Geschäftsführung an ein Verwaltungsratsmitglied benötigt die vorherige Zustimmung
der Generalversammlung.
Der Verwaltungsrat kann jederzeit beschließen Interimdividenden, innerhalb des gesetzlichen Rahmens, auszuzahlen.
Art. 11. Zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma abgeschlossene Verträge oder Geschäfte
können weder beeinträchtigt noch ungültig werden durch die Tatsache, dass ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder
oder Geschäftsführer der Gesellschaft ein Interesse in einer anderen Gesellschaft oder Firma haben, oder Verwaltungs-
ratsmitglied, Gesellschafter, Geschäftsführer oder Angestellter dieser Gesellschaft oder Firma sind.
Falls ein Verwaltungsratsmitglied oder Direktor der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem Geschäft der
Gesellschaft hat, muss das betroffene Verwaltungsratsmitglied oder der betroffene Direktor dem Verwaltungsrat dieses
persönliche Interesse mitteilen, und darf keine solche Transaktion in Betracht ziehen oder diesbezüglich abstimmen; über
das Interesse des betreffenden Verwaltungsratsmitglieds oder Direktors wird in der nächstfolgenden Versammlung der
Aktionäre Bericht erstattet. Der Begriff „persönliches Interesse“, wie im vorstehenden Satz aufgeführt, gilt nicht für die
Beziehung zu oder das Interesse in irgendeiner Angelegenheit, Position oder einer Transaktion im Zusammenhang mit
einer Gesellschaft von, oder verbunden mit, Vontobel Holding AG oder irgendeiner ihrer Zweigstellen oder Tochter-
gesellschaften, oder mit einer sonstigen Gesellschaft oder Körperschaft wie sie der Verwaltungsrat nach Belieben von
Zeit zu Zeit festlegen kann, außer „persönliches Interesse“ wird durch anwendbare Gesetze als widersprüchliches Inte-
resse betrachtet.
Die Gesellschaft kann jedes Verwaltungsratsmitglied oder jeden Direktor, deren Erben, Testamentsvollstrecker und
Vermögensverwalter für alle vernünftigen Ausgaben entschädigen, welche diese im Zusammenhang mit jedweden Ver-
fahren, Prozessen und Gerichtsverfahren hatten, in welchen sie in ihrer Eigenschaft als jetzige oder ehemalige Verwal-
tungsratsmitglieder oder Direktor der Gesellschaft, oder, auf deren Antrag, jedweder anderen Gesellschaft in welcher
die Gesellschaft Aktionär oder Gläubiger ist und von welcher sie keine Entschädigung beanspruchen können, beteiligt
waren, es sei denn für solche Angelegenheiten, für welche sie in solchen Verfahren, Prozessen oder Gerichtsverfahren
schließlich für Fahrlässigkeit oder vorsätzliches Fehlverhalten für haftbar erklärt werden. Im Falle einer außergerichtlichen
Einigung ist eine Entschädigung nur im Zusammenhang mit den Sachverhalten, die durch die außergerichtliche Einigung
geregelt wurden, gegeben, und wo die Gesellschaft durch ihren Berater die Bestätigung erhalten hat, dass die zu ent-
schädigende Person keine Verletzung ihrer Pflichten begangen hat. Das oben beschriebene Entschädigungsrecht schließt
andere anwendbare Rechte nicht aus.
47271
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Die Gesellschaft wird vertreten durch die Unterschrift zweier Verwaltungsratsmitglieder, oder die gemein-
schaftliche Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds und eines rechtmäßig dazu bevollmächtigten Direktor oder die
einzelne Unterschrift eines Verwaltungsratsmitglieds oder eines anderen rechtmäßig von der Gesellschaft Bevollmäch-
tigten, oder der einzelnen Unterschrift einer Person, die vom Verwaltungsrat rechtmäßig bevollmächtigt worden ist,
jedoch ausschließlich im Rahmen dieser Vollmacht.
Art. 13. Die Gesellschaft bestellt einen oder mehrere unabhängige(n) Wirtschaftsprüfer, der ein „réviseur d'entreprises
agréé“ sein muss, der/die mit der Überprüfung der Buchhaltung sowie der Geschäfte der Gesellschaft betraut sind/ist.
Der Wirtschaftsprüfer wird von der Generalversammlung der Aktionäre gewählt und bleibt im Amt bis zur nächsten
jährlichen Generalversammlung und bis zur Ernennung seines Nachfolgers.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer kann jederzeit von den Aktionären, im Einklang mit den anwendbaren rechtlichen
Bestimmungen, abgesetzt werden.
Art. 14. Die ordnungsgemäß einberufene Versammlung der Aktionäre vertritt sämtliche Gesellschaftsaktionäre. Sie
verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, um alle im Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Gesellschaft stehenden
Geschäfte anzuordnen, auszuführen oder zu ratifizieren.
Art. 15. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre findet am Gesellschaftssitz, oder an jedem anderen im Ein-
berufungsschreiben angegebenen Ort in Luxemburg, einen Tag nach dem letzten Dienstag im März um 14 Uhr 30 eines
jeden Jahres.
Ist dieser Tag kein Bankgeschäftstag in Luxemburg, so wird die Versammlung auf den nächstfolgenden Bankgeschäftstag
in Luxemburg verlegt. Die Mehrheit der Aktionäre kann die Verschiebung der jährlichen Generalversammlung auf einen
anderen Tag und/oder zu einer anderen Uhrzeit beschliessen.
Die jährliche Generalversammlung kann im Ausland abgehalten werden, sofern sich dies nach freiem Ermessen des
Verwaltungsrats aufgrund von außergewöhnlichen Umständen als notwendig erweist, oder die Mehrheit der Aktionäre
einen anderen Versammlungsort beschließen sollte.
Jede Aktie gibt Recht auf eine Stimme. Die Aktionäre können sich in jeder Versammlung der Aktionäre von einer
anderen bevollmächtigten Person vertreten lassen, die nicht Aktionärin sein muss.
Der Verwaltungsrat kann jedwede sonstigen, seitens der Aktionäre zwecks Beteiligung an einer Versammlung der
Aktionäre zu erfüllenden Bedingungen, festlegen.
Art. 16. Die Aktionäre treten auf Einberufung des Verwaltungsrats, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erfolgt,
zusammen.
Wenn alle Aktionäre an einer Generalversammlung anwesend oder vertreten sind, und wenn sie erklären, dass sie
über die Tagesordnung der Versammlung in Kenntnis gesetzt worden sind, kann die Versammlung ohne vorherige Ein-
berufung stattfinden.
Art. 17. Im Falle einer Änderung der Satzung, finden die durch das Gesellschaftsrecht vorgesehenen Anwesenheits-
und Mehrheitsbestimmungen Anwendung; bei sämtlichen anderen Versammlungen werden Entscheidungen ohne Beach-
tung der Anzahl der anwesenden oder vertretenen Aktien mit einfacher Mehrheit getroffen.
Art. 18. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Art. 19. Aus dem jährlichen Bilanzgewinn der Gesellschaft werden 5% dem vom Gesetz verlangten Reservefonds
zugewiesen. Diese Zuweisung ist nicht mehr zwingend, sobald und solange die gesetzliche Reserve ein Zehntel des
Grundkapitals erreicht hat.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann bestimmen, wie über den Restbetrag des jährlichen Reingewinns verfügt
wird und kann von Zeit zu Zeit die Ausschüttung von Dividenden festsetzen.
Die Gesellschaft kann Interimdividenden, unter Beachtung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen, verteilen.
Der Verwaltungsrat bestimmt in welcher Währung und zu welchem Zeitpunkt die Zahlungen von Interimdividenden
erfolgen. Der Verwaltungsrat kann den Wechselkurs, der anwendbar ist, um die Dividende in ihre Zahlungswährung zu
übertragen, endgültig bestimmen.
Art. 20. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft erfolgt die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren (welche
natürliche oder juristische Personen sein können), die von der diese Auflösung beschließenden Versammlung der Akti-
onäre ernannt werden, welche auch ihre Befugnisse und die Vergütung beschließt.
Art. 21. Sämtliche nicht in der vorliegenden Satzung geregelten Angelegenheiten unterliegen dem Luxemburger Gesetz
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (wie abgeändert), dem Gesetz von 2010 und dem Gesetz von 2013.“
5) Zur Kenntnisnahme des Verschmelzungsstichtages welcher auf den 31. März 2015 festgelegt wird.
6) Zur Kenntnisnahme der Mandatsniederlegung von Herr Remigio Luongo und Herr Axel Johann Schwartzer als
Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft und Beschluss Me Sophie Dupin als Mitglied des Verwaltungsrates der
47272
L
U X E M B O U R G
Gesellschaft, mit sofortiger Wirkung und bis zu der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft welche im Jahre
2016 abgehalten wird, zu ernennen.
IV. Die Bestimmungen betreffend Verschmelzungen gemäß des 1915 Gesetzes sind erfüllt:
a) Veröffentlichung am 17. Februar 2015 des Verschmelzungsplans im Mémorial Nummer 423, mindestens einem Monat
vor dem Datum der Generalversammlung welche über den Verschmelzungsplan beschließt;
b) Verzicht seitens des alleinigen Aktionärs der verschmelzenden Gesellschaften, gemäß eines schriftlichen Beschlusses
vom 9. Februar 2015, auf die Verpflichtung des Verwaltungsrates der Gesellschaft einen schriftlichen Bericht gemäß Artikel
265 des 1915 Gesetzes, zu erstellen;
c) Verzicht seitens des alleinigen Aktionärs der verschmelzenden Gesellschaften gemäß eines schriftlichen Beschlusses
vom 9. Februar 2015, auf die Verpflichtung einen Bericht eines unabhängigen Sachverständigen gemäß Artikel 266 des
1915 Gesetzes, erstellen zu lassen;
d) Hinterlegung der gemäß Artikel 267 des 1915 Gesetzes verlangten Dokumente beim Sitz der Gesellschaft mindes-
tens einen Monat vor dem Datum der Generalversammlung der verschmelzenden Gesellschaften, mit Ausnahme der
Berichte der Verwaltungsräte der verschmelzenden Gesellschaften und des Berichtes des unabhängigen Sachverständigen,
gemäß Artikel 265, sowie Artikel 266 des 1915 Gesetzes, auf welche der alleinige Aktionär der verschmelzenden Ge-
sellschaften gemäß seiner jeweiligen Beschlüsse verzichtet hat.
Nach Genehmigung des Vorangehenden, hat der alleinige Aktionär folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt dem Verschmelzungsplan zu zustimmen, in all seinen Bestimmungen und in vollem
Umfang, ohne Ausnahme oder Vorbehalte.
Der alleinige Aktionär beschließt die Verschmelzung mittels Übertragung seitens VOMSA, im Zuge dessen Auflösung
ohne Liquidation, von all seinen Aktiva, Passiva, Rechten und Verpflichtungen und Verträgen an die Gesellschaft, gemäß
Artikel 259 des 1915 Gesetzes, durchzuführen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär nimmt den Bericht des unabhängigen Wirtschaftsprüfers Ernst & Young zur Kenntnis, welcher
gemäß Artikel 26-1 des 1915 Gesetzes am 31. März 2015 erstellt wurde, und dessen Schlussfolgerung wie folgt lautet (in
englischer Sprache):
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that
the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 8 shares with a
nominal value of EUR 65.25 each to be issued with a total related share premium of EUR 4,393,425.41. The total value
of the contribution is EUR 4,393,947.41.”
Der Bericht, nachdem er ne varietur durch die erschienene Partei und den amtierenden Notar unterschrieben wurde,
bleibt vorliegender Urkunde beigebogen um mit derselben formalisiert zu werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft von zur Zeit zwei Millionen einhun-
dertfünfundsechzigtausend siebenhundertachtundsiebzig Euro (EUR 2.165.778) auf zwei Millionen einhundertsechsund-
sechzigtausend dreihundert Euro (EUR 2.166.300), durch die Ausgabe von acht (8) Aktien mit einen Nominalwert von
jeweils fünfundsechzig Euro und fünfundzwanzig Cent (EUR 65,25), an den alleinigen Aktionär der VOMSA, im Gegenzug
zur Gesamtübertragung von allen Aktiva und Passiva der VOMSA an die Gesellschaft, zu erhöhen, wobei die Differenz
zwischen dem Gesamtwert und den so neuausgegebenen Aktien der freiverfügbaren Rücklage der Gesellschaft zugeteilt
wird.
<i>Vierter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt die Satzung der Gesellschaft gemäß des unter Punkt 4 der Tagesordnung aufgeführten
Textes zu ändern und neu zu fassen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär nimmt zur Kenntnis, dass die Verschmelzung für die Zwecke der Rechnungslegung sowie aus
steuerlicher Sicht, ab dem 31. März 2015, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 273 des 1915 Gesetzes betreffend
die Auswirkungen von Verschmelzungen auf Dritte, wirksam ist.
<i>Sechster Beschlussi>
Der alleinige Aktionär nimmt die Mandatsniederlegungen von Herr Remigio Luongo und Herr Axel Johann Schwarzer
als Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft zur Kenntnis und beschließt Me Sophie Dupin, geboren am 5. April
1974, in Dax (F), und beruflich ansässig 2, Place Winston Churchill, L-2014 Luxemburg, als Mitglied des Verwaltungsrates
der Gesellschaft mit sofortige Wirkung und bis zu der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft welche im 2016
abgehalten wird, zu ernennen.
47273
L
U X E M B O U R G
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit der Urkunden und Formalitäten
der Verschmelzung welche durch die Gesellschaft und die übertragende Gesellschaft durchgeführt wurden, sowie des
Verschmelzungsplanes.
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Ver-
schmelzung entstehen, werden auf ungefähr EUR 7.000,- abgeschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf
Anfrage der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem dieses Dokument der erschienen Person vorgelesen wurde, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. FUNCK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1
er
avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10150. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 7. April 2015.
Référence de publication: 2015052757/576.
(150059797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.
Harkand Luxembourg Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 162.060.
En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 24 octobre 2014, les 145 parts sociales B d'une valeur
nominale de 0,01 USD de la Société ont été transférées d'OCM Luxembourg EPOF II Sàrl, 26A Boulevard Royal L-2449
Luxembourg (RCSL B133551) à Harkand Luxembourg Holdings Sàrl 26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCSL
B162060)
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015036362/12.
(150041053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Food Delivery Holding 11 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 192.197.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 mars 2015i>
En date du 4 mars 2015, l'associé unique de la Société a pris la résolution suivante:
- de nommer Monsieur Julien DE MAYER, né le 9 avril 1982 à Etterbeek, Belgique, résidant professionnellement à
l'adresse suivante: 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, en tant que nouveau gérant de catégorie B de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Ralf WENZEL, gérant de catégorie A
- Monsieur Ulrich BINNINGER, gérant de catégorie B
- Monsieur Julien DE MAYER, gérant de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
Food Delivery Holding 11. S.à r.l.
Référence de publication: 2015036977/20.
(150041803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47274
L
U X E M B O U R G
Sibelco Laos Invest S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.700.000,00.
Siège social: L-8008 Strassen, 98, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 194.937.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le douze février.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
A COMPARU:
La société anonyme de droit belge SCR-Sibelco NV ayant son siège social à B-2018 Antwerpen (Belgique), 1A, Plantin
en Moretuslei, inscrite au registre des personnes morales de Antwerpen (Belgique) sous le numéro d'entreprise
0450.732.769
ici représentée par Steven De Jonghe, résidant au Pasteurlaan 4, bt6, B-2900 Schoten, Belgique, en vertu d'une pro-
curation sous seing privé datée du 4 février 2015.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire
instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, telle que représentée, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-
sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Art. 2. L'objet de la Société est aussi bien au Luxembourg qu'à l'étranger de prendre des participations et des intérêts
sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres,
luxembourgeoises ou étrangères et d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou
d'option d'achat, de négociation ou de toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres
propriétés, droits et intérêts de propriété que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, dé-
velopper, les vendre ou en disposer, en tout ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier
en contrepartie de parts sociales ou de titres de toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer
à des transactions financières, commerciales ou autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée,
ou toute autre société liée d'une manière ou d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées
dans lesquelles la Société a un intérêt financier direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter
et de lever des fonds de quelque manière que ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin
de mener à bien toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination: “Sibelco Laos Invest S.à r.l.”
Art. 5. Le siège social est établi à Strassen.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L'adresse du siège social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à trois millions sept cent mille Euros (EUR 3.700.000,-) représenté par trois millions
sept cent mille (3.700.000) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.
La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être
décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.
47275
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l'article 6, le capital peut être modifié à tout moment par une décision de
l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés, en conformité avec l'article 14 des présents
Statuts.
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d'entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l'application de ce qui est prescrit par l'article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la
faillite de l'associé unique ou d'un des associés.
Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil
de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par les signatures
conjointes de deux gérants.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s'il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à la majorité des gérants présents
ou représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d'associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année, à l'exception
de la première année qui débutera à la date de constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l'année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l'indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice,
3. L'associé unique ou l'assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la
distribution d'acomptes sur dividendes.
47276
L
U X E M B O U R G
4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
<i>Souscription - Libérationi>
Toutes les trois millions sept cent mille (3.700.000) parts sociales ont été souscrites par la Société anonyme de droit
belge SCR-Sibelco NV, prédésignée, et entièrement libérées par versement en espèces, de sorte que la somme de trois
millions sept cent mille Euros (3.700.000. EUR) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire instru-
mentant, qui le reconnaît expressément.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ trois mille trois cents Euros
(3.300. EUR).
<i>Décision de l'associé uniquei>
1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
1. Jean-Luc Deleersnyder, né à Gent, le 9 mai 1961, avec adresse professionnelle à Plantin en Moretuslei 1A, 2018
Antwerpen, Belgique,
2. Laurence Boens, née à Elsene, le 7 novembre 1959, avec adresse professionnelle à Plantin en Moretuslei 1A, 2018
Antwerpen, Belgique,
3. Kurt Decat, né à Turnhout, le 23 juin 1965, avec adresse professionnelle à Plantin en Moretuslei 1A, 2018 Antwerpen,
Belgique,
4. Rich Lepoutre, né à Menen, le 1 octobre 1972, avec adresse professionnelle à Plantin en Moretuslei 1A, 2018
Antwerpen, Belgique;
2) L'adresse de la Société est fixée à 98 Route d'Arlon, L-8008 Strassen.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. DE JONGHE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4963. Reçu soixante-quinze euros (75. EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015036001/143.
(150039913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 9A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 162.359.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 2 mars 2015 que M. Frank Pletsch a été
révoqué de sa fonction de gérant B de la Société, avec effet immédiat.
Il résulte des mêmes résolutions que M. German Bell, né le 25 juin 1974 à Gerolstein/Daun, Allemagne, ayant son
adresse professionnelle au 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, a été nommé gérant B de la Société avec effet
immédiat et pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
Référence de publication: 2015036905/16.
(150042473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47277
L
U X E M B O U R G
Cofinalux S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 173.491.
Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015036842/10.
(150041794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.325.000,00.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 104.285.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale annuelle en date du 26 février 2015i>
L'assemblée générale a renouvelé les mandats suivants pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale
annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014:
1. Monsieur Jacques RECKINGER, gérant de la Société;
2. Monsieur Pierre METZLER, gérant de la Société;
3. Monsieur Michel BULACH, gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015036836/15.
(150041425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
JNC Ameublements S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
R.C.S. Luxembourg B 194.969.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le treize février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
Ont comparu:
1) Monsieur Nicolas Deloffre, indépendant, habitant F-52100 Saint-Dizier, 5, rue de la Planchotte, France, né à Saint
Dizier, le 20 septembre 1972.
2) Madame Cécilia Marchand, habitant F-52100 Saint-Dizier, 5, rue de la Planchotte, France, née à Saint Dizier, le 28
décembre 1972.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité
limitée unipersonnelle qu'ils déclarent constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par les propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité
limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet l'agence commerciale de vente de biens meubles ainsi que le commerce de meubles.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
En général, la société peut faire toutes transactions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières,
se rattachant directement ou indirectement à son objet ou à tout autre objet social similaire ou susceptible d'en favoriser
l'exploitation et le développement. Elle peut s'intéresser sous quelque forme et de quelque manière que ce soit dans
toutes sociétés ou entreprises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser ou à le développer.
Art. 3. La société prend la dénomination de "JNC Ameublements S.à r.l.".
Art. 4. Le siège social est établi à Kehlen.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 125.-(cent vingt-cinq euros) chacune.
47278
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
En cas de gérant unique, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique et en
cas de pluralité de gérants, les pouvoirs de signature seront déterminés par l'assemblée générale des associés/par l'associé
unique lors de la nomination des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Quand la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les
déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille quinze.
<i>Souscription et libérationi>
Les 100 (cent) parts sociales sont souscrites comme suit:
1) Monsieur Nicolas Deloffre, prénommé: vingt-quatre parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2) Madame Cécilia Marchand, prénommée: Soixante-seize parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500.-
(douze mille cinq cents euros) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire soussigné qui le constate expressément
<i>Décisions de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant technique pour une durée indéterminée:
Monsieur Nicolas Deloffre, prénommé.
2.- Est nommée gérante administrative pour une durée indéterminée:
Madame Cécilia Marchand, prénommée.
Vis-à-vis des tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux
gérants.
2. Le siège social est fixé à L-8287 Kehlen, Zone Industrielle.
47279
L
U X E M B O U R G
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.200.-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: N. DELOFFRE, C. MARCHAND et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 23 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5545. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015035783/92.
(150040633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
Barclays Metis Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 22.725,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 116.152.
Les comptes de clôture de liquidation au 15 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 3 mars 2015.
Certifié conforme et sincère
<i>Pour la Société
i>David Widart
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015036790/15.
(150042014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-5326 Contern, 17, rue Edmond Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 189.416.
<i>Auszüge aus dem Gesellschaftvertrag (der „Gesellschaftsvertrag") der ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSP SIF, eineri>
<i>Speziellen Kommanditgesellschaft Luxemburger Rechts (Special Limited Partnership)i>
1) Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften
ECE European Prime Shopping Centre Fund II GP, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 17,
rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 188.551 mit einem Gesellschaftskapital von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR
12.500,-) (die „Komplementärin"); und
KG CURA Luxemburg Beteiligungs II G.m.b.H. & Co., eine Kommanditgesellschaft, gegründet und bestehend nach
deutschem Recht, mit Gesellschaftsitz in der Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, eingetragen im Handelsregister
beim Amstgericht Hamburg unter der Nummer HRA 117847, vertreten durch ihre geschäftsführende Komplementärin
Cura Luxemburg Verwaltung G.m.b.H., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend nach deut-
chem Recht, mit Gesellschaftssitz in der Wandsbeker Strasse 3-7, D-22179 Hamburg, eingetragen im Handelsregister
beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 112032 (die „Gründungskomplementärin").
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 4. März 2015.
ECE European Prime Shopping Centre II C
Unterschrift
Référence de publication: 2015036947/25.
(150041559) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47280
Alteralia SCA
Alteralia S.C.A., SICAR
Articvision S.A.
Banque Internationale à Luxembourg
Barclays Metis Investments S.à r.l.
BNP Paribas LDI Solution
Carpathian Cable Luxembourg S.à r.l.
Cofinalux S.A., SPF
Dundee International (Luxembourg) Investments 1 S.à r.l.
ECE European Prime Shopping Centre II B
ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF
Exclusif esthétique S.à r.l.
Fiduciaire Nationale de Révision Comptable S.A., FIDAUDIT succursale de Luxembourg
Food Delivery Holding 11 S.à r.l.
Grey Juice Lab. S.à r.l.
Harkand Luxembourg Holdings S.à.r.l.
Hermes Universal
Hodge Holding S.à r.l.
Hubema S.A. SPF
Invesco Funds
JC Aviation (Luxembourg) S.A.
JNC Ameublements S.à r.l.
JPLFGDM Securitization S.à r.l.
JPMorgan Investment Funds
JPMorgan Liquidity Funds
JS Holding AG
KBC Interest Fund
Kim'Mobilière
La Mancha International GEC S.à r.l.
Lseg LuxCo 2 S.à r.l.
Luxembourg Finance House S.A.
L & Y International S.A.
Mantex SICAV
Parvest
Planalto S.A.
Pro Fonds (Lux)
Prolifica International S.A.
Sensata Management Company S.A.
Sharp S.à r.l.
Sibelco Laos Invest S.à.r.l.
Vontobel Asset Management S.A.
Wogema