This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 982
14 avril 2015
SOMMAIRE
Agraf Real Estate No 2 . . . . . . . . . . . . . . . . .
47103
Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47125
ArcelorMittal REACH OR . . . . . . . . . . . . . .
47091
Bacheron S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47091
Beggiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47129
Belgian European Agencies . . . . . . . . . . . . .
47093
BlueSPHERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47103
Caissa S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47092
Compagnie Margaux S.A. SPF . . . . . . . . . . .
47093
Compass Private Investments S.A. (FIS)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47107
Delphimmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47094
Diga Consulting SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47092
Dival S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47094
DWS Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47105
Elbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47106
Elbey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47107
Energreen Investment Europe S.A. . . . . . .
47105
Eremis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47094
Europe 94 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47095
European General Investments . . . . . . . . . .
47136
Foncière de Bagan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
47104
Gerlachus Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47103
Hillpark S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47094
JH-Holding Finance SA . . . . . . . . . . . . . . . . .
47117
Kicheneck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47107
KKR Co G.P S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47105
Korea Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47091
Licensing Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47093
LSEG LuxCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47095
Luxshipping S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47090
Managed Funds Portfolio . . . . . . . . . . . . . . .
47131
Millicom International Cellular S.A. . . . . . .
47096
MP Kings North 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47114
MP Kings North 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47125
MP Kings North 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
47125
MP Kings South S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47125
NN (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47131
Northgate Private Equity S.A. (FIS) . . . . .
47107
ParisInvest I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47135
RH Paris 3 Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47124
Serges Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47125
Société anonyme des Entreprises Minières
S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47092
SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l. . . . . . . . . .
47095
Swift Invest Holding SPF SA . . . . . . . . . . . .
47095
Switex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47090
TeamSystem HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
47135
Tonus & Cunha Associés S.à r.l. . . . . . . . . .
47104
Trias UK Edinburgh - T S.à r.l. . . . . . . . . . .
47136
T. Rowe Price (Luxembourg) Management
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47111
Vison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47090
Vontobel Management S.A. . . . . . . . . . . . . .
47108
Weatherford Capital Ltd. Luxembourg
Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47104
47089
L
U X E M B O U R G
Luxshipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5515 Remich, 9, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 90.856.
Sie werden hiermit zu einer
ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG
der Aktionäre von Luxshipping S.A., welche am <i>30. April 2015i> um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden
Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:
<i>Tagesordnung:i>
1. Verlesung der Jahresberichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung über das Jahresergebnis
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes
<i>Im Namen und Auftrag des Verwaltungsratesi>
Référence de publication: 2015053384/17.
Vison, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 173.151.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015i> à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054948/1267/18.
Switex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 9.988.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>8 mai 2015i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant
sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2014 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 ;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2014 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. nomination des Administrateurs et du Commissaire aux Comptes ;
7. divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015048896/10/19.
47090
L
U X E M B O U R G
ArcelorMittal REACH OR, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.395,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 24-26, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 44.046.
L'Assemblée générale ordinaire du 26 février 2015 a décidé de renouveler les mandats des administrateurs venus à
échéance:
- Frank HAERS, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- Eric PEZENNEC, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg,
- Xavier VERNI, avec adresse professionnelle au 24-26 boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg.
Les administrateurs sont nommés pour un terme de six (6) ans. Leur mandat expirera lors de l'assemblée générale
annuelle à tenir en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 mars 2015.
Référence de publication: 2015036155/17.
(150041013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Bacheron S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 57.520.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra extraordinairement le 04/05/2015 à 15.30 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire
2. Approbation du bilan et du compte de profits et pertes arrêtés au 31/12/2014
3. Affectation des résultats au 31/12/2014
4. Quitus aux Administrateurs et au Commissaire
5. Divers
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054891/18.
Korea Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 46.039.
Messieurs les Actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>05.05.2015i> à 11.00 heures au siège avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire;
- Approbation du Bilan et du compte de Profits et Pertes arrêtés au 31.12.2014;
- Affectation du résultat au 31.12.2014;
- Quitus aux administrateurs et au commissaire;
- Renouvellement du mandat des Administrateurs et du Commissaire pour une période de 1 an
- Divers.
Pour assister à cette Assemblée, Messieurs les Actionnaires, sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant
l'Assemblée au Siège Social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054902/19.
47091
L
U X E M B O U R G
Diga Consulting SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 81.383.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 13 février 2015 que
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société DIGA CONSULTING S.A. pour une durée
indéterminée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 4 mars 2015.
Référence de publication: 2015036271/17.
(150041358) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Caissa S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 176.420.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015i> à 14:30 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054940/1267/18.
S.A.D.E.M. S.A., SPF, Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF, Société Anonyme - Société
de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 6.016.
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>5 mai 2015i> à 15.00 heures au siège social 44, avenue J-F. Kennedy à Luxembourg, avec pour
<i>Ordre du jour:i>
- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes,
- Nominations statutaires,
- Fixation des émoluments du commissaire aux comptes.
Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer
leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054930/755/19.
47092
L
U X E M B O U R G
Belgian European Agencies, Société Anonyme.
Siège social: L-8832 Rombach, 5, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 104.675.
<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 04 mars 2015i>
Il résulte de l'AGE tenue ce 4 mars 2015 ce qui suit:
1) Démission de son poste de d'Administrateur de Monsieur Giovanni FASCIANELLA, domicilié B-1601 Ruisbroeck.
2) Nomination au poste d'Administrateur de Madame Christine NTIMA KIZOLA, domiciliée Bodegemstraat n°63 à
B- 1740 Ternat et ce pour une période indéterminée
3) Démission de son poste de d'Administrateur Délégué de Monsieur Giovanni FASCIANELLA, domicilié B-1601
Ruisbroeck.
4) Nomination au poste d'Administrateur Délégué de Madame Christine NTIMA KIZOLA, domiciliée Bodegemstraat
n°63 à B- 1740 Ternat et ce pour une période indéterminée
Belgian European Agencies SA.
Référence de publication: 2015036808/17.
(150042368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Compagnie Margaux S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 167.448.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu lundi <i>04 mai 2015i> à 10:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposé ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054945/1267/18.
Licensing Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue St. Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 139.270.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>08 mai 2015i> à 11:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Décision à prendre conformément à l´article 100 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
6. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054947/1267/19.
47093
L
U X E M B O U R G
Hillpark S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 182.335.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015036368/10.
(150041004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Eremis S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 4.664.
Les comptes annuels du 1
er
janvier 2013 au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015036302/11.
(150041291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Dival S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 37.630.
Messieurs les actionnaires de la Société Anonyme DIVAL S.A. sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le jeudi, <i>30 avril 2015i> à 11.00 heures au siège social de la société à Luxembourg, 9b, bd Prince Henri.
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31.12.2014.
3. Décharge à donner aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes.
4. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054949/750/15.
Delphimmo, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 143.185.
Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu vendredi <i>04 mai 2015i> à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2014.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour être admis à l'assemblée, tout détenteur d'actions au porteur est prié de déposer ses titres au siège social cinq
jours francs avant l'assemblée.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015054946/1267/18.
47094
L
U X E M B O U R G
Swift Invest Holding SPF SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-8017 Strassen, 9, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 93.500.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015036648/10.
(150041337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 165.348.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015036628/10.
(150041019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Europe 94 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9990 Weiswampach, 45, Duarrefstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 49.994.
Convocation à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des Obligataires du <i>8 mai 2015i> à 15 heures, au siège de la société. L'ordre du jour est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Informations générales concernant les emprunts obligataires émis en date du 15 février 2010 ;
2. Enregistrement des titres en début de séance
3. Divers
Assemblée convoquée par le C A
Référence de publication: 2015051507/14.
LSEG LuxCo 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 9.120.000,00.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 16, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 192.180.
<i>Extrait rectificatif concernant la modification déposée le 17 décembre 2014 sous la référence L140224678i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur s'est produite lors du dépôt enregistré en date du 17 décembre 2014 sous
la référence L140224678.
En date du 24 novembre 2014, l'associé unique de la Société a pris la résolution de nommer Monsieur Serge HARRY
et Monsieur Elvin MONTES en tant que gérants de la Société avec effet immédiat et ce pour une durée déterminée jusqu'à
l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016.
Toutes autres mentions de la publication demeurent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
LSEG LuxCo 1 S.à r.l
Signature
Référence de publication: 2015037193/20.
(150041928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47095
L
U X E M B O U R G
Millicom International Cellular S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.
R.C.S. Luxembourg B 40.630.
Notice is hereby given that the
ANNUAL GENERAL MEETING
("AGM") of the shareholders of MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. ("Millicom") is convened to be held
at the Millicom office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249, Luxembourg, on Friday, <i>May 15th, 2015i> at 10:00 a.m Central
European Time ("CET"), to consider and vote on the following agenda points:
<i>Agenda:i>
1. To elect the Chairman of the AGM and to empower the Chairman to appoint the other members of the bureau
of the meeting.
2. To receive the management report(s) of the Board of Directors (rapport de gestion) and the report(s) of the
external auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the financial year ended December 31,
2014.
3. To approve the annual accounts and the consolidated accounts for the year ended December 31, 2014.
4. To allocate the results of the year ended December 31, 2014. On a parent company basis, Millicom generated a
profit of approximately USD 354,658,451. Of this amount, an aggregate of approximately USD 264.30 million,
corresponding to USD 2.64 per share, is proposed to be distributed as a dividend, and the balance is proposed to
be carried forward as retained earnings.
5. To discharge all the current Directors of Millicom for the performance of their mandates during the financial year
ended December 31, 2014.
6. To set the number of Directors at eight (8).
7. To re-elect Mr. Paul Donovan as a Director for a term ending on the day of the next AGM to take place in 2016
(the "2016 AGM") .
8. To re-elect Mr. Tomas Eliasson as a Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
9. To re-elect Dame Amelia Fawcett as a Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
10. To re-elect Mr. Lorenzo Grabau as a Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
11. To re-elect Mr. Alejandro Santo Domingo as a Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
12. To re-elect Ms. Cristina Stenbeck as a Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
13. To elect Mr. Odilon Almeida as a new Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
14. To elect Mr. Anders Borg as a new Director for a term ending on the day of the 2016 AGM.
15. To re-elect Ms. Cristina Stenbeck as Chairman of the Board of Directors for a term ending on the day of the 2016
AGM.
16. To approve the Directors' fee-based compensation, amounting to SEK 5,025,000 for the period from the AGM to
the 2016 AGM and share-based compensation, amounting to SEK 3,800,000 for the period from the AGM to the
2016 AGM, such shares to be provided from the Company's treasury shares or alternatively to be issued within
Millicom's authorised share capital to be fully paid-up out of the available reserves i.e. for nil consideration from
the relevant Directors.
17. To re-elect Ernst & Young S.à r.l., Luxembourg as the external auditor of Millicom for a term ending on the day of
the 2016 AGM.
18. To approve the external auditor's compensation.
19. To approve a procedure on the appointment of the Nomination Committee and determination of the assignment
of the Nomination Committee.
20. Share Repurchase Plan
(a) To authorise the Board of Directors, at any time between May 15, 2015 and the day of the 2016 AGM, provided
the required levels of distributable reserves are met by Millicom at that time, either directly or through a subsidiary
or a third party, to engage in a share repurchase plan of Millicom's shares to be carried out for all purposes allowed
or which would become authorised by the laws and regulations in force, and in particular the Luxembourg law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law") and in accordance with the objectives,
conditions, and restrictions as provided by the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22 December
2003 (the "Share Repurchase Plan") by using its available cash reserves in an amount not exceeding the lower of
(i) ten percent (10%) of Millicom's outstanding share capital as of the date of the AGM (i.e., approximating a
maximum of 10,173,921 shares corresponding to USD 15,260,881 in nominal value) or (ii) the then available amount
of Millicom's distributable reserves on a parent company basis, in the open market on OTC US, NASDAQ Stock-
holm or any other recognised alternative trading platform, at an acquisition price which may not be less than SEK
50 per share nor exceed the higher of (x) the published bid that is the highest current independent published bid
on a given date or (y) the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system on the
same date, regardless of the market or exchange involved, provided, however, that when shares are repurchased
47096
L
U X E M B O U R G
on the NASDAQ Stockholm, the price shall be within the registered interval for the share price prevailing at any
time (the so called spread), that is, the interval between the highest buying rate and the lowest selling rate.
(b) To approve the Board of Directors' proposal to give joint authority to Millicom's Chief Executive Officer and
the Chairman of the Board of Directors (at the time any such action is taken) to (i) decide, within the limits of the
authorization set out in (a) above, the timing and conditions of any Millicom Share Repurchase Plan according to
market conditions and (ii) give mandate on behalf of Millicom to one or more designated broker-dealers to imple-
ment the Share Repurchase Plan.
(c) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, in the event the Share Repurchase Plan is
done through a subsidiary or a third party, to purchase the bought back Millicom shares from such subsidiary or
third party.
(d) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, to pay for the bought back Millicom shares
using the then available reserves.
(e) To authorise Millicom, at the discretion of the Board of Directors, to (i) transfer all or part of the purchased
Millicom shares to employees of the Millicom Group in connection with any existing or future Millicom long-term
incentive plan, and/or (ii) use the purchased shares as consideration for merger and acquisition purposes, including
joint ventures and the buy-out of minority interests in Millicom's subsidiaries, as the case may be, in accordance
with the limits set out in Articles 49-2, 49-3, 49-4, 49-5 and 49-6 of the 1915 Law.
(f) To further grant all powers to the Board of Directors with the option of sub-delegation to implement the above
authorization, conclude all agreements, carry out all formalities and make all declarations with regard to all au-
thorities and, generally, do all that is necessary for the execution of any decisions made in connection with this
authorization.
21. To approve the guidelines for remuneration of senior management.
22. To approve a sign-on share grant for the CEO.
NOTES REGARDING THE NOTICE
<i>CHAIRMAN OF THE MEETING (AGM - item 1)
i>Millicom's Nomination Committee, proposes Mr. Jean-Michel Schmit, attorney at law (avocat à la Cour), with profes-
sional address in Luxembourg, the duty to preside over the AGM.
In case of absence of Mr. Jean-Michel Schmit, the Chairman of the Board of Directors of Millicom or in the absence
of the Chairman of the Board of Directors, any member of the Board of Directors shall be empowered to appoint the
person to preside over the AGM amongst the persons present at the meeting.
The Chairman of the AGM shall be empowered to appoint the other members of the bureau of the meeting, i.e. the
Secretary and the Scrutineer, amongst the persons present at the meeting.
<i>PARTICIPATION AND PAYMENT INFORMATION FOR PROPOSED DIVIDEND (AGM - item 4)
i>On a parent company basis, Millicom generated a profit of approximately USD 354,658,451 for the year ended De-
cember 31, 2014. Of this amount the Board of Directors of Millicom proposes that the meeting approve the distribution
of a dividend of USD 2.64 per share to Millicom shareholders, in the manner provided in Article 21 and Article 23 of
Millicom's Articles.
The annual accounts of Millicom for the year ended on December 31, 2014 drawn up by Millicom's Board of Directors
show that Millicom has sufficient funds available, in accordance with applicable law, to distribute the considered USD 2.64
dividend per share which represents an aggregate dividend of approximately USD 264.30 million. The Board of Directors
confirms that the proposed dividend can be paid out of the carried forward profits available at the date of the AGM.
In accordance with Luxembourg income tax law, the payment of dividend will be subject to a 15% withholding tax.
Millicom will withhold the 15% withholding tax and pay this amount to the Luxembourg tax administration. The dividend
will be paid net of withholding tax. However a reduced withholding tax rate may be foreseen in a double tax treaty
concluded between Luxembourg and the country of residence of the shareholder or an exemption may be available in
cases where the Luxembourg withholding tax exemption regime conditions are fulfilled (e.g. for shareholdings repre-
senting at least 10% of the share capital for an uninterrupted period of at least 12 months). These shareholders should
contact their advisors regarding the procedure and the deadline for a potential refund of the withholding tax from the
Luxembourg tax administration.
The U.S. Federal Income Tax Considerations for U.S. holders of Millicom shares and SDRs can be found on Millicom's
website (www.millicom.com) under "Corporate Governance/AGM 2015".
Eligible Millicom shareholders will receive their dividends in USD (United States Dollars) whereas holders of Swedish
Depository Receipts ("SDR") will be paid exclusively in SEK (Swedish crowns). Millicom shall arrange for a conversion of
the dividend from USD to SEK. Such conversion shall be effected at a market rate of exchange, no earlier than eight (8)
and no later than three (3) banking days before the payment date, or the day when the funds are made available to
Euroclear Sweden AB. The applicable rate of exchange shall be the rate of exchange obtained through the combination
of all foreign exchange conversions.
47097
L
U X E M B O U R G
The dividend will be paid to shareholders who are registered in the shareholders register kept by Millicom or American
Stock Transfer & Trust Company ("AST") as well as to the holders of SDRs who are registered in the records maintained
by Euroclear Sweden AB as of May 19, 2015 (the "Dividend Record Date").
The ex-dividend date is estimated to be May 18, 2015.
Payment of dividends is planned for around May 25, 2015. Holders of SDRs will be paid by electronic transfer to bank
accounts linked to their securities accounts whereas a dividend check will be sent to all other eligible shareholders.
<i>ELECTION OF THE DIRECTORS (AGM - items 6-14)
i>The Nomination Committee proposes that the Board shall consist of Eight (8) directors.
Millicom's Nomination Committee proposes that, until the 2016 AGM, Mr. Paul Donovan, Mr. Tomas Eliasson, Dame
Amelia Fawcett, Mr. Lorenzo Grabau, Mr. Alejandro Santo Domingo and Ms. Cristina Stenbeck be re-elected as Directors
of Millicom and that Mr. Odilon Almeida and Mr. Anders Borg be elected as new Directors of Millicom.
Mr. Ariel Eckstein, Mr. Dominique Lafont and Ms. Mia Brunell Livfors have declined re-election as Directors of Millicom.
The Nomination Committee's motivated statement regarding the Board composition includes additional information
about the proposed Directors and is available on Millicom's website at www.millicom.com
<i>ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS (AGM - item 15)
i>Millicom's Nomination Committee, supported by the Board of Directors, proposes that Ms. Cristina Stenbeck be
elected as Chairman of the Board of Directors for a term ending at the 2016 AGM.
<i>DIRECTORS' FEES (AGM - item 16)
i>Millicom's Nomination Committee proposes a total of SEK 5,025,000 as fee-based compensation for the eight (8)
Directors expected to serve from the AGM to the 2016 AGM.
The Nomination Committee proposes the following split of the fee-based compensation:
- the annual remuneration to ordinary Board Members not employed by Millicom shall be SEK 425,000 per Member
(2014: SEK 375,000); SEK 500,000 to the Deputy Chairman (2014: no Deputy Chairman was appointed); and SEK 750,000
to the Chairman (unchanged);
- the annual remuneration for work on Board Committees shall be SEK 400,000 (2014: SEK 330,000) to the Chairman
of the Audit Committee, SEK 200,000 (2014: SEK 165,000) to each of the other members of the Audit Committee, SEK
225,000 (2014: SEK 75,000) to the Chairman of the Compensation Committee and SEK 100,000 (2014: SEK 38,000) to
each of the other members of the Compensation Committee.
The Nomination Committee also proposes a total of SEK 3,800,000 as share-based compensation for the period from
the AGM to the 2016 AGM in the form of fully paid-up shares of Millicom common stock. Such shares will be provided
from the Company's treasury shares or alternatively issued within Millicom's authorized share capital exclusively in ex-
change for the allocation from the premium reserve i.e. for nil consideration from the relevant Directors. The Nomination
Committee proposes that:
- the number of shares to be provided or issued to the Chairman of the Board of Directors shall be SEK 750,000
(unchanged);
- the number of shares to be provided or issued to the Deputy Chairman of the Board of Directors shall be SEK
500,000 (2014: no Deputy Chairman was appointed);
- the number of shares to be provided or issued to each of the six (6) other Directors to be SEK 425,000 (2014: SEK
375,000);
in each case divided by the Millicom share closing price on NASDAQ OMX Stockholm on the 2015 AGM date provided
that shares shall not be issued below the par value.
In respect of Directors who did not serve an entire term, the fee- and the share-based compensation will be pro-rated
pro rata temporis.
As specified above, the Nomination Committee proposes a considerable increase of the remuneration to ordinary
Board Members and for work on Board Committees compared to the current levels. The increase is proposed in light
of inter alia the increasing complexity and range of the emerging markets in which Millicom operates, and the ongoing
review of Millicom's existing compensation structures and long-term incentive plans. It is the Nomination Committee's
assessment that the increases, in combination with the significant part of Board compensation being share-based, reflects
Millicom's size and the complexity of the Company's operations, and will further incentivize the Board Directors to
maximize long-term shareholder value creation.
<i>ELECTION OF THE AUDITOR (AGM - item 17)
i>Millicom's Nomination Committee, supported by the Board of Directors, proposes that Ernst & Young, Luxembourg,
be re-elected as external auditor for a term ending at the 2016 AGM.
The proposal from the Nomination Committee is based on a periodic evaluation of external audit firms last conducted
in 2012 with annual follow-up reviews.
47098
L
U X E M B O U R G
<i>FEES PAYABLE TO THE AUDITOR (AGM - item 18)
i>The Nomination Committee proposes that the auditor fees be paid against approved account.
<i>PROCEDURE ON APPOINTMENT OF THE NOMINATION COMMITTEE AND DETERMINATION OF THE ASSIGNMENT OFi>
<i>THE COMMITTEE (AGM - item 19)i>
The Nomination Committee proposes that the work of preparing proposals to the 2016 Annual General Meeting
regarding the Board and auditor, in the case that an auditor should be elected, and their remuneration, Chairman of the
Annual General Meeting and the procedure for the Nomination Committee shall be performed by a Nomination Com-
mittee.
The Nomination Committee will be formed during September 2015 in consultation with the largest shareholders of
Millicom as per August 31, 2015. The Nomination Committee will consist of at least three members appointed by the
largest shareholders of Millicom who have wished to appoint a member. The Chairman of the Board will also be a member
of the Committee, and will act as its convenor. The members of the Nomination Committee will appoint the Nomination
Committee Chairman at their first meeting.
The Nomination Committee is appointed for a term of office commencing at the time of its formation and ending
when a new Nomination Committee is formed. If a member resigns during the Committee term, the Nomination Com-
mittee can choose to appoint a new member. The shareholder that appointed the resigning member shall be asked to
appoint a new member, provided that the shareholder still is one of the largest shareholders in Millicom. If that shareholder
declines participation on the Nomination Committee, the Committee can choose to ask the next largest qualified share-
holder to participate. In the event of changes to the ownership structure of the Company, the Committee can choose
to change its composition in order to ensure the Committee reflects the ownership of the Company. However, unless
there are special circumstances, the composition of the Nomination Committee may remain unchanged following changes
in the ownership structure of the Company that are either minor or occur less than three months prior to the 2016
Annual General Meeting. In all cases, the Nomination Committee shall consist of at least three members appointed by
shareholders of Millicom.
The Nomination Committee shall have the right to upon request receive personnel resources such as secretarial
services from Millicom, and to charge Millicom with costs for recruitment consultants and related travel if deemed nec-
essary.
<i>SHARE REPURCHASE PLAN (AGM - item 20)
i>The Board of Directors of Millicom proposes that the meeting approve a Share Repurchase Plan and authorises the
Board of Directors of Millicom, with the option to delegate, to acquire and dispose of Millicom's shares under the
abovementioned Share Repurchase Plan as further detailed below.
<i>a) Objectives:
i>The Share Repurchase Plan will be carried out for all purposes allowed or which would become authorised by the
laws and regulations in force, and in particular the 1915 Law and in accordance with the objectives, conditions, and
restrictions as provided by the European Commission Regulation No. 2273/2003 of 22 December 2003.
The purpose of the Share Repurchase Plan will be in particular to reduce Millicom's share capital (in value or in the
number of shares) or to meet obligations arising from any of the following:
(a) debt financial instruments exchangeable into equity instruments;
(b) employee share option programs or other allocations of shares to employees of Millicom or of an associate com-
pany;
(c) consideration for merger and acquisition purposes.
The transactions over the shares under the Share Repurchase Plan may be carried out by any means, on or off the
market or by the use of derivative financial instruments, listed on a regulated stock exchange or transacted by mutual
agreement subject to all applicable laws and stock exchange regulations.
<i>b) Maximum proportion of the share capital that may be repurchased
i>- The maximum aggregate number of shares authorised to be purchased is an amount not exceeding the lower of (i)
ten percent (10%) of Millicom's outstanding share capital as of the date of the AGM (i.e., approximating a maximum of
10,173,921 shares corresponding to USD 15,260,881 in nominal value) or (ii) the then available amount of Millicom's
distributable reserves on a parent company basis in the open market on OTC US, NASDAQ Stockholm or any other
recognised alternative trading platform. The nominal value or, in the absence thereof, the accountable par value of the
acquired shares, including shares previously acquired by Millicom and held by it (including the stakes held by other group
companies referred to in Article 49bis of the 1915 Law), and shares acquired by a person acting in his own name but on
Millicom's behalf, may not exceed ten percent (10%) of the issued share capital, it being specified that (i) such limit applies
to a number of shares that shall be, as necessary, adjusted in order to take into account transactions affecting the share
capital following the AGM as further detailed under c) below, (ii) that the acquisitions carried out by Millicom may in no
event cause it to hold, directly or indirectly, more than ten percent (10%) of the share capital, (iii) the aggregate amount
that Millicom may assign to the buyback of its own shares shall be set in accordance with the provisions of the 1915 Law.
47099
L
U X E M B O U R G
- The acquisitions may not have the effect of reducing Millicom's net assets below the amount of the subscribed share
capital plus those reserves, which may not be distributed under the law or Millicom's Articles.
- Only fully paid-up shares may be included in the transactions.
<i>c) Price and volume considerations
i>The minimum and maximum purchase prices at which Millicom may repurchase its shares shall be set at:
- Minimum repurchase price: SEK 50
- Maximum repurchase price not to exceed the higher of: (x) the published bid that is the highest current independent
published bid on a given date or (y) the last independent transaction price quoted or reported in the consolidated system
on the same date, regardless of the market or exchange involved.
The AGM shall grant all powers to the Board of Directors to proceed with unit price adjustments and the maximum
number of securities to be acquired in proportion to the variation in the number of shares or their nominal value resulting
from possible financial operations by Millicom such as but not limited to capital increase by incorporation of reserves and
free allocation of shares or in case of splitting or regrouping of shares et seq.
Any transaction undertaken by Millicom under the Share Repurchase Plan as to price and volume will be undertaken
in accordance with all legal and stock exchange requirements, including those of the European Commission Regulation
No. 2273/2003 of 22 December 2003 or any accepted market practices as defined under the Directive 2003/6/EC dated
28 January 2003 on insider dealing and market manipulation. The aforementioned includes that, when shares are re-
purchased on the NASDAQ Stockholm, the price shall be within the registered interval for the share price prevailing at
any time (the so called spread), that is, the interval between the highest buying rate and the lowest selling rate.
<i>d) Duration
i>Such a Share Repurchase Plan will start no earlier than May 15, 2015, and end no later than at the earliest of (i) the
2016 AGM, (ii) the moment when the aggregate value of shares repurchased by Millicom since the start of this Share
Repurchase Plan reaches the limits indicated under (b) above, (iii) the moment when Millicom' shareholding (including
the stakes held by other group companies referred to in Article 49bis of the 1915 Law and shares acquired by a person
acting in his own name but on Millicom's behalf) reaches 10 per cent of the subscribed share capital in accordance with
Article 49-2 (1) of the 1915 Law or (iv) within eighteen months as of the date of the AGM.
GUIDELINES FOR REMUNERATION TO SENIOR MANAGEMENT (AGM - item 21)
The Board of Directors proposes that the meeting resolves on the following guidelines for remuneration and other
employment terms for the senior management for the period up to the 2016 AGM.
Compensation guidelines
The objective of the guidelines is to ensure that Millicom can attract, motivate and retain executives, within the context
of Millicom's international talent pool, which consists of Telecom, Media & FMCG companies. The compensation shall be
based on conditions that are market competitive in Europe/US and at the same time aligned with shareholders' interests.
Compensation of the Executives shall consist of a fixed and variable salary, as well as the possibility of participation in the
equity based long-term incentive programs and pension schemes. These components shall create a well-balanced com-
pensation reflecting individual performance and responsibility, both short-term and long-term, as well as Millicom's overall
performance.
Base salary
The Executives' base salary shall be competitive and based on the individual Executive's responsibilities and perform-
ance.
Variable remuneration
The Executives may receive variable remuneration in addition to base salary. The maximum target variable remuner-
ation in any Executive's contract is 100% of the base salary and in case of exceptional performance the actual amount can
reach 200%. The variable amounts or percentages are considered to be competitive within market standards at total
compensation levels. The variable remuneration shall be based on the performance of the Executives in relation to
established goals and targets along with Millicom's financial performance.
Long-term Incentive Plans (LTIPs)
The aim of the LTIPs is to complement and support Millicom's long-term business view and strategy. The plans and
the amounts need to be competitive in order to attract and retain key executives.
The LTIPs currently consist of a deferred share plan and a performance share plan. Shares awards granted under the
deferred share plan are based on personal and corporate performance of the previous year and the awards vest over 3
years, 16.5% year 1, 16.5% year 2 and 67% year 3. Shares granted under the performance share plan vest at the end of a
three-year period, whereby vesting is subject to certain company performance conditions. The latter plan requires the
participant to own shares in Millicom.
Beginning with the CEO in 2015, and applicable to all performance share plan participants by 2016, the performance
share plan will be modified to permit employees to earn a number of Millicom shares ('Multiplier Shares') based on the
47100
L
U X E M B O U R G
performance of the Group against specified financial targets over a three-year period, and based on the ownership by the
employee of a certain number of Millicom shares ('Investment Shares'). The employee can acquire up to a maximum
number of Investment Shares and will be able to earn a number of Multiplier Shares based on the product of (1) the
multiple ascribed to each performance measure and (2) a percentage of the Company's achievement of that target.
The purposes behind these changes are:
• to focus senior management decision-making on medium-term shareholder value;
• retention of high-performing senior managers; and
• encouragement of significant personal ownership of Company shares by senior management.
Other benefits
Other benefits can include, for example, a car allowance, medical coverage and in some cases, housing allowance,
school fees, home leave and other travel expenses.
Pension
The Executives are entitled to participate in a global pension plan, covering also death and disability insurance, in
accordance with European standards. The global pension plan is secured through premiums paid to insurance companies.
Notice of termination and severance pay
If the employment of Millicom's senior executives is terminated, a notice period of up to 12 months potentially applies.
Deviations from the guidelines
In special circumstances, the Board of Directors may deviate from the above guidelines, for example additional variable
remuneration in the case of exceptional performance. In such a case the Board of Directors will explain the reason for
the deviation at the following Annual General Meeting.
SHARE BASED CEO COMPENSATION (AGM - item 22)
The Board of Directors proposes that the meeting approve a sign-on share grant (the "Share Grant") to the CEO, as
part of the CEO remuneration, on the following terms.
As a result of the Share Grant, a maximum of 77,394 Millicom shares may be allotted, representing a value of USD 5.5
million, based on the closing price on Nasdaq Stockholm on April 1, 2015, and representing 0.076 percent of the total
number of shares and votes outstanding in Millicom as of April 1, 2015. The shares will be provided from Millicom's
treasury shares, or alternatively issued within Millicom's authorised share capital exclusively in exchange for the allocation
from the premium reserve (i.e., for nil consideration from the CEO).
One-third of the total share amount will vest (and be delivered to the CEO along with accrued dividends) on each of
January 1, 2016, January 1, 2017 and January 1, 2018. The vesting of shares is conditional upon the CEO not being dismissed
for cause.
The Share Grant is proposed by the Board following review by the Compensation Committee of the entire compen-
sation package for the CEO. The components of this package are:
• an annual base salary of USD 1 million;
• variable remuneration with a target of 100% of base salary;
• participation in the LTIPs;
• the Share Grant; and
• other standard benefits, as described under AGM item 21.
The objective of the Share Grant was to ensure the successful recruiting of a new CEO in the interest of all shareholders
and achieve a long time alignment of the interests of such new CEO with the interests of Millicom and its shareholders.
A resolution to introduce the Share Grant, in accordance with the Board's proposal, is valid where supported by
shareholders representing more than 50 per cent of the votes cast by the shareholders at the Annual General Meeting.
For information on the LTIPs, please refer to item 23 of the agenda and page 106 (note 12) of the 2014 Annual Report
of Millicom.
OTHER INFORMATION
Millicom has 101,739,217 outstanding shares with a nominal value of USD 1.50 and with one vote attached to each
such share. Millicom holds 1,624,800 shares in treasury. Voting rights attached to shares held in treasury are suspended
by law.
<i>1. Right to propose new items to the agenda and to file draft resolutions
i>One or several shareholders or holders of SDRs representing, individually or collectively, at least 5 % of the share
capital of Millicom may require that some additional items be put on the agenda of the AGM and propose draft resolutions
with regard to items included or to be included in the agenda of the AGM.
These rights shall be exercised in writing and shall be submitted to Millicom by mail at the following address: Millicom
International Cellular S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, attention: Corporate Secretary, by telephone:
47101
L
U X E M B O U R G
+ 352 27 759 477, by fax: + 352 27 759 996 or by e-mail at the following address: information@millicom.com, no later
than April 23, 2015 and the revised agenda will be published by Millicom, at the latest on April 30, 2015.
The shareholders or holders of SDRs who send a request to Millicom to add an item to the agenda must send together
with their request a justification thereof or a draft of the resolution to be adopted at the AGM. They must indicate the
mail or e-mail address to which the acknowledgment of receipt of their request may be sent to by Millicom within forty-
eight (48) hours upon receipt of their request.
<i>2. Right to have access to the documents and information related to the AGM
i>The following documents and information related to the AGM are available to the shareholders and holders of SDRs
at the above mentioned address of Millicom and on Millicom's website, (www.millicom.com):
- this convening notice;
- the Notification Form to attend the AGM in person;
- the Power of Attorney Form for direct shareholders and holders of SDRs;
- the draft resolutions of the AGM;
- Millicom's annual accounts and consolidated accounts for the year ended December 31, 2014, the management report
(s) of the Board of Directors and the report(s) of the external auditor on these annual accounts and consolidated accounts,
the list of the Directors and the auditor of Millicom;
- U.S. general Federal Income Tax Considerations for U.S. holders of Millicom shares and SDRs;
- the Nomination Committee's motivated statement explaining its proposals regarding the Board of Directors and
information on the proposed Directors of Millicom;
- the evaluation of the programmes for variable remuneration to the executive management and the current remu-
neration structure and levels of remuneration in Millicom.
The shareholders and holders of SDRs may also receive a copy of the above mentioned documents by sending a request
by mail at Millicom International Cellular S.A., 2 rue du Fort Bourbon, L-1249, Luxembourg, attention: Corporate Sec-
retary, or by e-mail at the following address: information@millicom.com.
<i>3. Right to participate at the AGM in person or represented by power of attorney
i>3.1. Direct Shareholders
Participation at the AGM is reserved to shareholders who are duly registered as holder of shares in the share register
of Millicom and/ or AST on May 1, 2015 (the "Record Date") at 23.59 CET and who notify their intention to attend the
AGM to Millicom by mail, email or fax to the above mentioned address, either by using the Notification of Attendance
Form (to be duly completed, dated and signed) in case the shareholder wishes to attend the AGM in person, or by using
the Power of Attorney Form (to be duly completed, dated and signed) in case the shareholder wishes to be represented
at the AGM.
The Notification of Attendance Form and the Power of Attorney may be downloaded from Millicom's website,
www.millicom.com, or may be requested from Millicom free of charge at the mail and e-mail addresses indicated above.
The Notification of Attendance Form or the Power of Attorney shall be received by Millicom no later than on the
Record Date at 23:59 CET. Since the Record Date is a public holiday in Luxembourg, shareholders who elect to send
the Notification of Attendance Form or the Power of Attorney by mail only must ensure that it is delivered to Millicom
no later than 30 April. Shareholders who send the Notification of Attendance Form or the Power of Attorney by email
or fax must ensure that the originals will follow by mail within 3 business days.
3.2. Holders of SDRs
Participation at the AGM is reserved to holders of SDRs who are duly registered as holder of SDRs in the records
maintained by Euroclear Sweden AB as of the Record Date (as defined above) at 23.59 CET and who notify their intention
to attend the AGM to Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") by mail at the following address: SEB, Issuer Agent
Department, R B6, 106 40 Stockholm, Sweden, by email to issuedepartment4@seb.se or by fax to +46 8 763 6250, either
by using the Notification of Attendance Form (to be duly completed, dated and signed) in case the holder of SDRs wishes
to attend the AGM in person, or by using the Power of Attorney Form (to be duly completed, dated and signed) in case
the holder of SDRs wishes to be represented at the AGM. Since the Record Date is a public holiday in Sweden, holders
of SDRs must make certain that they are registered in the records maintained by Euroclear Sweden AB on 30 April 2015
at 23.59 CET.
The Notification of Attendance Form and the Power of Attorney may be downloaded from Millicom's website,
www.millicom.com, or may be requested from SEB or Millicom free of charge at the mail and e-mail addresses indicated
above.
The Notification of Attendance Form or the Power of Attorney shall be received by SEB no later than on April 30,
2015 at 12:00 CET. SDR holders who send the Notification of Attendance Form or the Power of Attorney by email or
fax must ensure that the originals will follow by mail to SEB, Issuer Agent Department, R B6, 106 40 Stockholm, within
3 business days, so that it is received by SEB no later than on 6 May 2015.
47102
L
U X E M B O U R G
Holders of SDRs having registered their SDRs in the name of a nominee must temporarily re-register the SDRs in
their own name in the records maintained by Euroclear Sweden AB in order to exercise their shareholders' rights at the
AGM. SDR holders wishing to re-register must inform their nominee well in advance of the Record Date so that they
appear on the records maintained by Euroclear Sweden AB at 23.59 CET on the Record Date. Please note that SDRs
holders who have not re-registered their SDRs with Euroclear Sweden AB by 23.59 CET on 30 April 2015 at will not be
eligible to participate in the AGM.
Conversions from shares into SDRs and vice versa will not be permitted from May 15 up to and including May 19,
2015.
Only the persons who are shareholders or holders of SDRs on the Record Date and who comply with the above
procedure may participate and vote at the AGM.
Notwithstanding the above, the Bureau of the AGM shall have the discretionary power exceptionally to accept the
attendance and voting of a shareholder or a holder of SDRs at the AGM, even if the relevant Form of the Notification of
Attendance or of the Power of Attorney has been received after the above mentioned deadlines.
April 13, 2015
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015054103/410.
Gerlachus Fund, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstellei>
Référence de publication: 2015033499/10.
(150037783) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Agraf Real Estate No 2, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.504.
Wir teilen mit, dass Herr Manuel Scheer mit Wirkung zum 28. Februar 2015 als Geschäftsführer der Gesellschaft
zurückgetreten ist.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015036762/11.
(150042251) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
BlueSPHERE, Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue des Trois Cantons.
R.C.S. Luxembourg B 102.777.
<i>Extrait des résolutions prises par les actionnaires en date du 2 mars 2015i>
Les actionnaires ont décidé:
- de renouveler les mandats d'Administrateurs avec effet au 14.05.2013 de:
* Monsieur Christian Collard, domicilié à B-1330 Rixensart, 12, Avenue des Ramiers;
* Monsieur Guy Carpentier, domicilié à F-78860 Saint Nom la Bretèche, Chemin des Longues Raies 25;
* Monsieur Alain Prick, domicilié à B-1390 Grez-Doiceau, Clos de Bettinval, 5;
Les mandats des Administrateurs viendront à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle à tenir
en l'an 2016.
Pour extrait conforme
BLUESPHERE S.A.
Signature
Référence de publication: 2015036795/18.
(150042524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47103
L
U X E M B O U R G
Weatherford Capital Ltd. Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 130.994.
<i>Extrait des décisions prises par le Conseil de gérance en date du 16 janvier 2015i>
1. Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 67, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-1931 Luxem-
bourg, 13-15 Avenue de la Liberté.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Weatherford Capital Ltd. Luxembourg Branch
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015036691/14.
(150041293) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Foncière de Bagan S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.698.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires tenue à Luxembourg, le 28 novembrei>
<i>2014 à 11.00 heures.i>
Reconduction du mandat du Réviseur d'Entreprises, la Société H.R.T. Révision S.A., ayant son siège au 163 rue du
Kiem L-8030 Strassen, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg B 51 238, pour une durée
d'un an.
Son mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire approuvant les comptes annuels de l'année 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 novembre 2014.
<i>Pour la société
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015036332/17.
(150040951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Tonus & Cunha Associés S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 139.158.
<i>Constatation pour dépôti>
Suite à une convention de cession de parts sociales sous-seing privé, signée en date du 04/02/2015, il résulte les
changements comme suit:
La société TWENTYTHREEFIVE SA, ayant son siège social au 61 Route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au RCSL
sous le numéro B 146 479, cède à Mme FERNANDES PEREIRA CATIA, née le 16 août 1990 à Coimbra, domiciliée à
L-7727 Colmar-Berg, 28 Rue Grand Duc Jean, 5,50 parts sociales de la Société.
La société TWENTYTHREEFIVE SA, ayant son siège social au 61 Route de Longwy, L-8080 Bertrange, inscrite au RCSL
sous le numéro B 146 479, cède à FERNANDES MARTINS ANDREIA, née le 1
er
mai 1989 à Coimbra, domiciliée à
L-9175 Niederfeulen, 4 Behmspasch, 5,50 parts sociales de la Société.
TWENTYTHREEFIVE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,00 parts de la Société
4 LU INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137,50 parts de la Société
BORGES CABRAL MICHAEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,50 parts de la Société
FERNANDES PEREIRA CATIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50 parts de la Société
FERNANDES MARTINS ANDREIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,50 parts de la Société
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
550 parts sociales
Bertrange, le 04/02/2015.
Référence de publication: 2015036654/23.
(150041240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
47104
L
U X E M B O U R G
KKR Co G.P S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 184.062.
EXTRAIT
M. Michael R. McFerran, né le 2 février 1972 à Los Angeles (États-Unis), avec adresse professionnelle au 555, California
Street, San Francisco CA 94104, États-Unis, a démissionné de son poste de gérant catégorie B de la Société avec effet au
27 février 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Dr. Wolfgang Zettel
<i>Gérant de catégorie Ai>
Référence de publication: 2015037128/16.
(150041551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Energreen Investment Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.588.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication, dans le Mémorial C n° 657 du 10 mars 201, page 31494, de la société
au 31 décembre 2007:
<i>au lieu de:
i>"En date du 19 janvier 2015, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur et de Président de la société ENERGREEN
INVESTMENT EUROPE SA, ayant son siège social au 19, Boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
RCSL B159588.",
<i>lire:
i>"En date du 19 janvier 2015, Monsieur Herman J.J. Moors a démissionné de sa fonction d'administrateur et de Président
de la société ENERGREEN INVESTMENT EUROPE SA, ayant son siège social au 19, Boulevard Grande-duchesse Char-
lotte, L-1331 Luxembourg, RCSL B159588."
Référence de publication: 2015054598/17.
DWS Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 25.754.
DWS 3rd Wave Emerging Africa Fund SIF
DWS Rendite Extra Garant
DWS Rendite Plus Garant
DWS Prospero Fund
Die oben genannten Fonds wurden zu den nachstehend aufgeführten Daten liquidiert:
DWS 3rd Wave Emerging Africa Fund SIF
13. Juni 2012
DWS Rendite Extra Garant
13. Juli 2012
DWS Rendite Plus Garant
13. Juli 2012
DWS Prospero Fund
06. Januar 2012
Die Liquidationsprozesse sind abgeschlossen. Die State Street Bank Luxembourg S.C.A., in ihrer Funktion als Depot-
bank, hat das jeweilige Fondsvermögen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Es wurden keine Beträge an die Caisse de
Consignation überwiesen.
Luxemburg, im April 2015
DWS Investment S.A.
Référence de publication: 2015054918/755/20.
47105
L
U X E M B O U R G
Elbey, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 66, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 194.976.
STATUTS
L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- Adel SOUALAH, commerçant, demeurant à L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.
Le comparant a requis le notaire de documenter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il
déclare constituer.
Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «ELBEY».
Art. 2. Le siège de la société est établi dans la commune de Luxembourg.
Art. 3. La société a pour objet l'exploitation d'un établissement de petite ou grande restauration avec l'exploitation
d'un débit de boissons alcoolisées et nonalcoolisées ainsi que toutes opérations industrielles, commerciales ou financières,
mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en
faciliter l'extension ou le développement.
Art. 4. La durée de la société est indéterminée.
Art. 5. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500,- €), représenté par CENT (100) parts
sociales de CENT VINGT-CINQ EUROS (125,- €) chacune.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que conformément aux dispositions
de l'article 189 du texte coordonné de la loi du 10 août 1915 et des lois modificatives.
Art. 7. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, choisis par les associés qui fixent la durée de
leur mandat, leur rémunération (s'il en est) et leurs pouvoirs. Ils peuvent être à tout moment révoqués sans indication
de motif.
Art. 8. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 9. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties s'en réfèrent aux dispositions légales.
Art. 10. La société prendra effet le 1
er
janvier 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Adel SOUALAH, susdit, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: Cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Elles ont été intégralement libérées par des versements en espèces.
<i>Fraisi>
Le montant des frais généralement quelconques incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approxi-
mativement à sept cent soixante euros (760,- €).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Ensuite l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:
- L'adresse de la société est fixée à L-2310 Luxembourg, 66, avenue Pasteur.
- Le nombre des gérants est fixé à deux (2).
- Est nommé gérant administratif, pour une durée illimitée:
* Adel SOUALAH, commerçant, demeurant à L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.
- Est nommé gérant technique, pour une durée illimitée:
* Driss OUSSALEM, gérant, demeurant à L-3398 Roeser, 1, rue d'Oradour.
La société est engagée par la signature conjointe du gérant administratif et du gérant technique.
47106
L
U X E M B O U R G
Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-
sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l'objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: SOUALAH, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 1, le 5 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/122. Reçu soixante-quinze euros
(75,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015036430/61.
(150041000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Kicheneck, Société à responsabilité limitée,
(anc. Elbey).
Siège social: L-2310 Luxembourg, 66, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 194.976.
RECTIFICATIF
L'an deux mille quinze, le dix-neuf février.
Par-devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
- Adel SOUALAH, commerçant, demeurant à L-2311 Luxembourg, 79, avenue Pasteur.
Le comparant est le seul associé de la société à responsabilité limitée «ELBEY», établie et ayant son siège à L-2311
Luxembourg, 66, avenue Pasteur, constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 30 décembre 2014 au
numéro 2692 de son répertoire, enregistré à Luxembourg, Actes Civils 1, le 5 janvier 2015, Relation: 1LAC/2015/122 en
voie d'inscription au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg.
Le comparant déclare qu'une erreur s'est glissée dans la dénomination de la société dans l'acte de constitution précité,
et qu'il y a lieu de lire:
« Art. 1
er
. La société prend la dénomination de «KICHENECK».»
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par ses nom, prénom usuel, état et
demeure, il a signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: SOUALAH, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, Actes Civils 1, le 20 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5377. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015036431/28.
(150041000) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Compass Private Investments S.A. (FIS), Société Anonyme,
(anc. Northgate Private Equity S.A. (FIS)).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 127.892.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015035589/10.
(150040517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
47107
L
U X E M B O U R G
Vontobel Management S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 2-4, rue Jean l'Aveugle.
R.C.S. Luxembourg B 115.113.
In the year two thousand and fifteen, on the thirty-first day of the month of March.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared
Vontobel Holding AG, a company existing under the laws of Switzerland, with registered office in 43 Gotthardstrasse,
CH-8022 Zurich, Switzerland, (the “Sole Shareholder”)
represented by Maître Linda Funck, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated
12 March 2015 which after having been signed ne varietur shall remain attached to the present deed to be submitted
together with it to the registration formalities,
being the sole shareholder of Vontobel Management S.A. (the "Company") (or “VOMSA”), a société anonyme with its
registered office at 2-4, rue Jean l’Aveugle, L-1148 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies
register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 115 113, incorporated by a deed of
Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 27 March 2006, which
was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1154 on 14 June 2006.
The articles were amended the last time on 17 November 2014 by a deed of the undersigned notary, published in the
Mémorial, number 69 on 9 January 2015.
The appearing party, represented as stated above, declared and the notary recorded as follows:
I. That the appearing party is the Sole Shareholder of the Company and holds one thousand five hundred (1,500)
registered shares with a par value of thousand Euros (EUR 1,000) each in issue in the Company so that the entire share
capital of one million five hundred thousand Euro (EUR 1,500,000) is represented and decisions can be validly taken by
the Sole Shareholder.
II. The common draft terms of merger of the Company (as absorbed company) and Vontobel Asset Management S.A.
(hereafter “VAMSA”)(the “Merger Proposal”) had been approved by the board of directors of the Company and by the
board of directors of VAMSA on 10 February 2015 and had been published on 17 February 2015 in the Mémorial number
423 in accordance with article 262 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies as amended (the “1915
Law”);
III. The items on which resolutions are to be passed are the following:
1) Approval of the Merger Proposal and decision to realise the merger of the Company (as absorbed Company) and
VAMSA (as absorbing company), according to article 259 of the law on commercial companies dated 10 August 1915, as
amended (the “1915 Law”) by the contribution, following the Company’s dissolution without liquidation, of any and all
assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to VAMSA;
2) Approval of the contribution, following the Company’s dissolution without liquidation, of any and all assets, liabilities,
rights, obligations and contracts of the Company to VAMSA, in consideration of the issue by VAMSA of eight (8) shares
of a nominal value of sixty-five Euro and twenty-five Cents (EUR 65.25) each to the Sole Shareholder of the Company,
with the balance between the Total Value and the new shares so issued being allocated to the freely distributable reserve
of VAMSA;
3) Acknowledgement of the effective date of the merger which is set at 31 March 2015.
IV. The provisions regarding mergers of the 1915 Law have been fulfilled:
a) publication on the 17 February 2015 of the Merger Proposal in the Mémorial number 423, at least one month before
the date of the general meetings deciding on the Merger Proposal;
b) waiver by the Sole Shareholder of the merging companies, pursuant to a written resolution dated 9 February 2015,of
the requirement to have the board of directors of the Company prepare a written report in accordance with article 265
of the 1915 Law;
c) waiver by the Sole Shareholder of the merging companies, pursuant to a written resolution dated 9 February 2015,of
the requirement to have an expert report drawn up in accordance with article 266 of the 1915 Law;
d) deposit of the documents required by article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Company at least
one month before the date of the general meeting of the merging companies respectively, except for the reports of the
board of the directors of the merging companies and the independent expert provided for by article 266 respectively
article 265 of the 1915 Law, which were waived by the Sole Shareholder of each of the merging companies pursuant to
their respective resolutions dated 9 February 2015.
After the meeting approved the foregoing, it passed the following resolutions:
47108
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the Merger Proposal in all its provisions and in its entirety, without exception
or reserves.
The Sole Shareholder resolved to realise the merger by the contribution by the Company following its dissolution
without liquidation of any and all assets liabilities, rights, obligations and contracts to VAMSA, in accordance with article
259 of the 1915 Law.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to approve the contribution, following the Company’s dissolution without liquidation,
of any and all assets, liabilities, rights, obligations and contracts of the Company to VAMSA, in consideration of the issue
by VAMSA of eight (8) shares of a nominal value of sixty-five euro and twenty-five cents (EUR 65.25) each to the Sole
Shareholder of VOMSA, with the balance between the Total Value and the new shares so issued being allocated to the
freely distributable reserve of VAMSA;
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder noted that the merger is effective, from an accounting and tax point of view, as from 31 March
2015 without prejudice to the provisions of article 273 of the 1915 Law regarding the effects of the merger towards third
parties.
The books, accounts and documents of VOMSA, will be safekept for a period of five years at the registered office of
VAMSA in L-1148 Luxembourg, 2-4, rue Jean l’Aveugle.
<i>Statementsi>
The undersigned notary stated the existence and the legality of the deeds and formalities of the merger executed by
VAMSA and the Company and of the Merger Proposal.
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of this merger are estimated at approximately EUR 2,000.-.
There being nothing further items on the agenda, The undersigned notary, who understands and speaks English, he-
rewith states that at the request of the parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a German
translation; at the request of the same appearing persons in case of discrepancies between the English and German text,
the English version will be prevailing.
Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day before mentioned.
After reading these minutes the members of the Bureau signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einunddreißigsten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg (Grossherzogtum
Luxemburg).
Erschien die
Gesellschaft Vontobel Holding AG, eine Gesellschaft welche gemäß den Gesetzen der Schweiz besteht, mit Sitz in
CH-8022 Zürich, Gotthardstrasse 43, (die "Alleinige Aktionärin")
vertreten durch Maître Linda Funck, maître en droit, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
vom 12. März 2015, welche ne varietur unterzeichnet wurde und der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage bei-
liegen wird, alleinige Aktionärin der "Vontobel Management S.A." (die "Gesellschaft") (oder „VOMSA“), société anomyme,
mit Gesellschaftssitz in L-1148 Luxemburg, 2-4, rue Jean l'Aveugle, eingetragen im Handelsregister in Luxemburg (Registre
de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 115 113, gegründet durch notarielle Urkunde von
Maître Joseph Elvinger, Notar, mit dem damaligen Amtswohnsitz in Luxemburg, am 27. März 2006, welche im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") vom 14. Juni 2006, Nummer 1154 veröffentlicht wurde.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notars am 17.
November 2014 veröffentlicht im Mémorial Nummer 69 vom 9. Januar 2015.
Die erschienene Partei erklärte und beauftragte den Notar Folgendes festzustellen:
I. Die erschienene Partei ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft und hält eintausend fünfhundert (1.500) Namens-
aktien mit einem Nominalwert von je eintausend Euro (EUR 1.000), alle von der Gesellschaft ausgegeben so dass das
gesamte Aktienkapital von einer Million fünfhunderttausend Euro (EUR 1.500.000) vertreten ist und der Alleinige Aktionär
wirksam beschließen kann.
II. Der gemeinsame Verschmelzungsplan der Gesellschaft (als übertragende Gesellschaft) und Vontobel Asset Ma-
nagement S.A. (nachfolgend "VAMSA")(als aufnehmende Gesellschaft)(der "Verschmelzungsplan") wurde vom Verwal-
tungsrat der Gesellschaft und vom Verwaltungsrat der VAMSA am 10. Februar 2015 genehmigt und wurde am 17. Februar
47109
L
U X E M B O U R G
2015 im Mémorial unter der Nummer 423, gemäß Artikel 262 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften (das "1915 Gesetz"), veröffentlicht;
III. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
<i>Tagesordnungi>
1) Zustimmung zum Verschmelzungsplan und Beschluss die Verschmelzung der Gesellschaft (als übertragende Gesell-
schaft) und Vontobel Asset Management S.A. ("VAMSA") (als aufnehmende Gesellschaft) durch zu führen, gemäß Artikel
259 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (das "1915 Gesetz"), durch Übertragung,
infolge der Auflösung ohne Liquidation, von allen Aktiva, Passiva, Rechten, Verpflichtungen und Verträgen der Gesellschaft
an die VAMSA;
2) Zustimmung der Übertragung, im Zuge der Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft, von allen Aktiva, Passiva,
Rechten, Verpflichtungen und Verträgen der Gesellschaft an die VAMSA, als Gegenleistung zu der Ausgabe seitens der
VAMSA von acht (8) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils fünfundsechzig Euro und fünfundzwanzig Cents (EUR
65,25) an den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, wobei die Differenz zwischen dem Gesamtwert der Gesellschaft und
den so neuausgegebenen Aktien der freiverfügbaren Rücklage der VAMSA zugeteilt werden;
3) Zur Kenntnisnahme des Verschmelzungsstichtages welcher auf den 31. März 2015 festgelegt wird.
IV. Die Bestimmungen betreffend Verschmelzungen gemäß des 1915 Gesetzes sind erfüllt:
a) Veröffentlichung am 17. Februar 2015 des Verschmelzungsplans im Mémorial Nummer 423, mindestens einem Monat
vor dem Datum der Generalversammlung welche über den Verschmelzungsplan beschließt;
b) Verzicht seitens des alleinigen Aktionärs der verschmelzenden Gesellschaften, gemäß eines schriftlichen Beschlusses
vom 9. Februar 2015, auf die Verpflichtung des Verwaltungsrates der Gesellschaft einen schriftlichen Bericht gemäß Artikel
265 des 1915 Gesetzes, zu erstellen;
c) Verzicht seitens des alleinigen Aktionärs der verschmelzenden Gesellschaften gemäß eines schriftlichen Beschlusses
vom 9. Februar 2015, auf die Verpflichtung einen Bericht eines unabhängigen Sachverständigen gemäß Artikel 266 des
1915 Gesetzes, erstellen zu lassen;
d) Hinterlegung der gemäß Artikel 267 des 1915 Gesetzes verlangten Dokumente beim Sitz der Gesellschaft mindes-
tens einen Monat vor dem Datum der Generalversammlung der verschmelzenden Gesellschaften, mit Ausnahme der
Berichte der Verwaltungsräte der verschmelzenden Gesellschaften und des Berichtes des unabhängigen Sachverständigen,
gemäß Artikel 265, sowie Artikel 266 des 1915 Gesetzes, auf welche der alleinige Aktionär der verschmelzenden Ge-
sellschaften gemäß seiner jeweiligen Beschlüsse verzichtet hat.
Nach Genehmigung des Vorangehenden, hat der alleinige Aktionär folgende Beschlüsse gefasst:
<i>Erster Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt dem Verschmelzungsplan zu zustimmen, in all seinen Bestimmungen und in vollem
Umfang, ohne Ausnahme oder Vorbehalte.
Der alleinige Aktionär beschließt die Verschmelzung mittels Übertragung seitens der Gesellschaft, im Zuge dessen
Auflösung ohne Liquidation, von all ihren Aktiva, Passiva, Rechten, Verpflichtungen und Verträgen an die VAMSA, gemäß
Artikel 259 des 1915 Gesetzes, durchzuführen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär beschließt der Übertragung, im Zuge der Auflösung ohne Liquidation der Gesellschaft, von allen
Aktiva, Passiva, Rechten, Verpflichtungen und Verträge der Gesellschaft an die VAMSA, als Gegenleistung zu der Ausgabe
seitens der VAMSA von acht (8) Aktien mit einem Nominalwert von jeweils fünfundsechzig Euro und fünfundzwanzig
Cents (EUR 65,25) an den alleinigen Aktionär der Gesellschaft, zu zustimmen, wobei die Differenz zwischen dem Ge-
samtwert der Gesellschaft und den so neuausgegebenen Aktien der freiverfügbaren Rücklage der VAMSA zugeteilt
werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Der alleinige Aktionär nimmt zur Kenntnis, dass die Verschmelzung für die Zwecke der Rechnungslegung sowie aus
steuerlicher Sicht, ab dem 31. März 2015, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 273 des 1915 Gesetzes betreffend
die Auswirkungen von Verschmelzungen auf Dritte, wirksam ist.
Die Bücher der VOMSA bleiben während einer Dauer von fünf Jahren ab heute am Gesellschaftssitz der VAMSA in
L-1148 Luxemburg, 2,4, rue Jean l’Aveugle hinterlegt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit der Urkunden und Formalitäten
der Verschmelzung welche durch die Gesellschaft und die aufnehmende Gesellschaft durchgeführt wurden, sowie des
Verschmelzungsplanes.
47110
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Die Ausgaben, Kosten, Vergütungen und Aufwendungen jeglicher Art, welche der Gesellschaft aufgrund dieser Ver-
schmelzung entstehen, werden auf ungefähr EUR 2.000,- abgeschätzt.
Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen und deutschen Sprache kundig ist, bestätigt hiermit, dass auf
Anfrage der erschienenen Partei vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung, und dass im Falle einer Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Fassung
maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nachdem dieses Dokument der erschienen Person vorgelesen wurde, hat dieselbe zusammen mit dem Notar die
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: L. FUNCK und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 1
er
avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10149. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 7. April 2015.
Référence de publication: 2015052758/179.
(150059750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 avril 2015.
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.529.400,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6C, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 33.422.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of the month of March.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
“T. Rowe Price International Ltd.”, an English limited liability company having its registered office at 60 Queen Victoria
Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom (the “Shareholder”),
here represented by Mr Brian Flanagan, professionally residing in Senningerberg, by virtue of a proxy under private
seal given.
Said proxy, after been signed “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain annexed to the present deed for registration purposes.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of “T.
Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg,
having a share capital of two million five hundred twenty-nine thousand four hundred US dollars (USD 2,529,400.-), with
registered office at 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a
notarial deed enacted on 05 April 1990, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 161
of 15 May 1990 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 33.422 (the
"Company"). The articles of incorporation of the Company have for the last time been amended following a notarial deed
enacted on 1 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3114 of 27
October 2014.
The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions
to be taken on the basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. To amend the corporate object of the Company so that article 2 of the articles of incorporation shall read: “The
purpose of the Company is the creation and the management of undertakings for collective investment in transferable
securities («UCITS») authorized pursuant to Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council of 13
July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended from time
to time and of alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of Directive 2011/61/EU of the European Par-
liament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers, as amended from time to time, and
of other undertakings for collective investment (“UCIs”).
More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and ne-
cessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Chapter 15 and Annex
II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (hereafter the “2010 Law”) and Annex I of
the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (hereafter the “2013 Law”).”.
47111
L
U X E M B O U R G
2. To amend article 5, second paragraph of the articles of incorporation of the Company to simplify it in order to read
that the registered office of the Company may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
3. To amend a typo in the second paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the Company.
4. To amend article 20 of the articles of incorporation of the Company to add that reference is also made to the 2013
Law and to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended for all matters for which no specific provision
is made in the articles of incorporation.
5. Miscellaneous.
Then the Shareholder took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the corporate object of the Company so that article 2 of the articles of incor-
poration of the Company shall now read as follows:
“The purpose of the Company is the creation and the management of undertakings for collective investment in trans-
ferable securities («UCITS») authorized pursuant to Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council
of 13 July 2009 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to UCITS, as amended from
time to time and of alternative investment funds (“AIFs”) within the meaning of Directive 2011/61/EU of the European
Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative Investment Fund Managers, as amended from time to time,
and of other undertakings for collective investment (“UCIs”).
More generally the Company may carry out all activities linked directly or indirectly to, and deemed useful and ne-
cessary for the accomplishment of its object remaining always within the limitations set forth by Chapter 15 and Annex
II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment (hereafter the “2010 Law”) and Annex I of
the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (hereafter the “2013 Law”).”.
<i>Second resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the second paragraph of article 5 of the articles of incorporation of the Company
so that it shall read:
“The address of the registered office may be transferred within the municipality by a decision of the board of managers.”
<i>Third resolutioni>
The Shareholder resolved to amend the second paragraph of article 16 of the articles of incorporation of the Company
so that it shall read:
“The independent auditor in office may be removed at any time by the shareholders with or without cause.”
<i>Fourth resolutioni>
The Shareholder resolved to amend article 20 of the articles of incorporation of the Company to add that reference
is also made to the 2013 Law and to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended for all matters
for which no specific provision is made in the articles of incorporation, so that article 20 shall now read as follows:
“Reference is made to the provisions of the Law, of the 2010 Law, of the 2013 Law and of the law of 10 August 1915
on commercial companies, as amended for all matters for which no specific provision is made in these Articles.” The
undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person,
the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case of
divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with Us the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt mars.
Par-devant Nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«T. Rowe Price International Ltd.», une société anglaise à responsabilité limitée ayant son siège social à 60 Queen
Victoria Street, London, EC4N 4TZ, Royaume Uni (l’«Associé»),
ici représentée par Monsieur Brian Flanagan, demeurant professionnellement à Senningerberg, aux termes d'une pro-
curation lui délivrée.
La prédite procuration, après avoir été signée «ne variteur» par la mandataire de la partie comparante et le notaire
soussigné, restera annexée au présent acte à des fins d’enregistrement.
47112
L
U X E M B O U R G
L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de «T. Rowe Price
(Luxembourg) Management S.à r.l.», une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant un capital
social de deux millions cinq cent vingt neuf mille quatre cents dollars américains (USD 2,529,400.-), dont le siège social
est au 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand- Duché de Luxembourg, constituée suivant acte notarié dressé
en date du 05 avril 1990, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 161 du 15 mai 1990
(la «Société»). Les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié reçu le 1
er
octobre 2014, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3114 du 27 octobre 2014.
L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à
intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de l’objet social de la Société, de sorte que l’article 2 des statuts aura la teneur suivante: «La Société
a pour objet la création et la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM») agréés
conformément à la directive 2009/65/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, telle qu'amendée de temps
à autre et de fonds d’investissement alternatifs («FIA») au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du
Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d’Investissement Alternatifs, telle qu'amendée de temps à autre et
d’organismes de placement collectif («OPC»).
Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et
estimées utiles et nécessaires à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par
le chapitre 15 et l’Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de
2010») et par le chapitre 2 et l’Annexe I de la loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la «Loi de 2013»).».
2. Modification du deuxième paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société afin de le simplifier pour lire que le siège
social de la Société peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision conseil de gérance.
3. Modification d’une faute de frappe au deuxième paragraphe de l’article 16 des statuts de la Société.
4. Modification de l’article 20 des statuts de la Société afin de rajouter qu'il est également fait référence à la Loi de
2013 et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une
disposition spécifique dans les Statuts.
5. Divers.
Ensuite l’Associé a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier l’objet social de la Société, de sorte que l’article 2 des statuts de la Société sera désormais
libellé comme suit:
«La Société a pour objet la création et la gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières («OPCVM»)
agréés conformément à la directive 2009/65/EC du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coor-
dination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM, telle qu'amendée de
temps à autre et de fonds d’investissement alternatifs («FIA») au sens de la Directive 2011/61/UE du Parlement européen
et du Conseil du 8 juin 2011 sur les Gestionnaires de Fonds d’Investissement Alternatifs, telle qu'amendée de temps à
autre et d’organismes de placement collectif («OPC»).
Plus généralement, la Société peut également entreprendre toutes opérations liées directement ou indirectement et
estimées utiles et nécessaires à l’accomplissement de son objet, en restant toutefois toujours dans les limites tracées par
le chapitre 15 et l’Annexe II de la loi du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif (ci-après la «Loi de
2010») et par le chapitre 2 et l’Annexe I de la loi du 12 juillet 2013 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
(ci-après la «Loi de 2013»).»
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 5 des Statuts comme suit:
«L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par décision du conseil de gérance.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier le deuxième paragraphe de l’article 16 des Statuts comme suit:
«Le réviseur d’entreprises peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par décision de l’assemblée des
associés.»
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé a décidé de modifier l’article 20 des statuts de la Société pour rajouter qu'il est également fait référence à
la Loi de 2013 et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée pour tout ce qui ne fait pas
l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, de sorte que l’article 20 est désormais libellé comme suit:
47113
L
U X E M B O U R G
«Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une disposition spécifique dans les Statuts, il est fait référence à la Loi, à la Loi
de 2010, à la Loi de 2013 et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec Nous le notaire soussigné, notaire le présent acte.
Signé: B. FLANAGAN et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 26 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/9307. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 1
er
avril 2015.
Référence de publication: 2015050170/160.
(150057458) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2015.
MP Kings North 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 37.502,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.665.
In the year two thousand and fifteen,
on the fifth day of March.
Before us, Maître Carlo GOEDERT, notary residing in Dudelange, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
MP Real Estate Investments W6 LLP, a limited liability partnership governed by the laws of United Kingdom, with
registered office at 10 Gloucester Place, Portman Square, London W1U 8EZ United Kingdom, registered with the Com-
panies House under number OC362425;
here represented by Maître Françoise PFEIFFER, lawyer, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy
given under private seal on 24
th
February 2015.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing party and the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here above, has requested the notary to enact the following:
I. MP Kings North 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with registered office at 40, avenue Monterey L-2163
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under section
B number 159.665 (the Company), has been incorporated by a deed dated 15 March 2011 and enacted by Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), as published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations dated 17 June 2011 under number 1321. The articles of association of the Company (the Articles)
have been amended for the last time on 30 December 2011 pursuant to a deed of Me Léonie Grethen, notary residing
in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number
677 on 14 March 2012.
II. The share capital of the Company amounts to GBP 12,501.-(twelve thousand five hundred and one Pounds Sterling)
represented by 12,501 (twelve thousand five hundred and one) shares with a nominal value of GBP 1.- (one Pond Sterling)
each.
III. The appearing party represented as described above, is the legal owner of the entire share capital of the Company
(the Sole Shareholder). The Sole Shareholder can thus validly deliberate on the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the Company’s share capital by an amount of GBP 25,001.- (twenty five
thousand one Pounds Sterling) to raise it from its present amount of GBP 12,501.- (twelve thousand five hundred and
one Pounds Sterling) to GBP 37,502.- (thirty seven thousand five hundred and two Pounds Sterling), by the issue of 25,001
(twenty five thousand one) new shares with a par value of GBP 1.- (one Pound Sterling) each (the New Shares).
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder declares to subscribe for the New Shares and to have them fully paid up in the aggregate amount
of GBP 25,001.-(twenty five thousand one Pounds Sterling), by a contribution in kind of:
47114
L
U X E M B O U R G
(i) 12,500 (twelve thousand five hundred) shares having a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) held in the
capital of MP Kings South S.à r.l. (MPKS), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 159.672 (the MPKS Shares), and
(ii) 12,501 (twelve thousand five hundred and one) shares having a nominal value of GBP 1.- (one Pound Sterling) held
in the capital of MP Kings North 2 S.à r.l. (MPKN2), a private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue
Monterey L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B 159.666 (the MPKN2 Shares, and together with the MPKS Shares, the Shares).
The Shares so contributed represent a net contribution in kind in an aggregate amount of GBP 25,001.- (twenty five
thousand one Pounds Sterling).
It results from the certificates issued on 5
th
March 2015 by the board of managers of MPKS and MPKN2, respectively
that, as of the date of such certificates:
- MP Real Estate Investments W6 LLP is the owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up;
- MP Real Estate Investments W6 LLP is the entity solely entitled to the Shares and possessing the power to dispose
of the Shares;
- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct; there exist no right to acquire any pledge or usufruct
on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that
one or more of the Shares be transferred to him;
- according to the articles of association of MPKS and MPKN2, respectively, the Shares are freely transferable.
- as at 24
th
February 2015, the MPKS Shares are worth at least GBP 12,500 (twelve thousand five hundred Pounds
Sterling) and the MPKN2 Shares are worth at least GBP 12,501 (twelve thousand five hundred and one Pounds Sterling);
these valuations being based on generally accepted accountancy principles and are supported by the interim balance sheets
of MPKS and MPKN2 as per 31 January 2015 which have not changed since.
The said certificates and a copy of the balance sheets referred to above after having been signed ne varietur by the
proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to the present deed in order to be registered with it.
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder resolves to amend article 5, paragraph 1 of the Articles
to give it henceforth the following wording:
" Art. 5. The share capital of the Company is set at GBP 37,502.-(thirty seven thousand five hundred and two Pounds
Sterling) divided into 37,502.- (thirty seven thousand five hundred and two) shares, with a par value of GBP 1.- (one Pound
Sterling) each.”
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg on the date first written above,
The document having been read to the proxy holder of the person appearing, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze,
Le cinq mars,
Par-devant Nous, Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
MP Real Estate Investments W6 LLP une société à responsabilité limitée constituée selon les lois d'Angleterre, ayant
son siège social à 10 Gloucester Place, Portman Square, London W1U 8EZ, Angleterre, enregistrée auprès du Companies
House en Angleterre sous le numéro OC362425;
ici représentée par Maître Françoise PFEIFFER, avocate, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée sous seing privé le 24 février 2015.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,
demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
47115
L
U X E M B O U R G
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. MP Kings North 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 40, avenue Monterey L-2163
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de et à Lu-
xembourg sous le numéro B 159.665 (la Société), a été constituée par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg), en date du 15 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1321 en date du 17 juin 2011. Les statuts de la Société (les Statuts) ont fait l’objet de
modifications pour la dernière fois le 30 décembre 2011, suivant un acte du notaire Me Léonie Grethen, notaire de
résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association
numéro 677 du 14 mars 2012.
II. Le capital social de la Société est fixé à GBP 12.501,- (douze mille cinq cent un livres sterling) représenté par 12.501
(douze mille cinq cent une)parts sociales d’une valeur nominale de GBP 1,- (un livre sterling) chacune.
III. La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus est le propriétaire de l’intégralité du capital social de la
Société (l’Associé Unique). L’Associé Unique peut donc valablement délibérer sur les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de GBP 25.001,- (vingt-cinq mille
une livres sterling) pour le porter de son montant actuel de GBP 12.501,- (douze mille cinq cent un livres sterling) à GBP
37.502,- (trente-sept mille cinq cent deux livres sterling) par l’émission de 25.501 (vingt-cinq mille cinq cent une) nouvelles
parts sociales d’une valeur de GBP 1,- (une livre sterling) chacune (les Nouvelles Parts Sociales).
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et les libérer intégralement à leur valeur nominale
total de GBP 25.001,-(vingt-cinq mille une livres sterling) par un apport en nature de:
(i) 12,500 (douze mille cinq cent) parts sociales détenues dans le capital social de MP Kings South S.à r.l. (MPKS), une
société à responsabilité limitée établie et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 40, avenue
Monterey L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des so-
ciétés de et à Luxembourg sous le numéro B 159.672 (les Parts MPKS) et;
(ii) 12,501 (douze mille cinq cent une) parts sociales détenues dans le capital social de MP Kings North 2 S.à r.l.
(MPKN2), une société à responsabilité limitée établie et existant sous le droit luxembourgeois, ayant son siège social au
40, avenue Monterey L-2163 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce
et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 159.666 (les Parts MPKN2, et ensemble avec les Parts MPKS, les
Parts Sociales).
Les Parts Sociales ainsi apportées représentent un apport en nature net d’un montant total de GBP 25.001,- (vingt-
cinq mille une livres sterling).
Il résulte des certificats émis le 5 mars 2015 par les conseil de gérances de MPKS et MPKN2, respectivement qu'en
date de ces certificats:
- MP Real Estate Investments W6 LLP est le propriétaire des Parts Sociales;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées;
- MP Real Estate Investments W6 LLP. est l’unique propriétaire des Parts Sociales et a tout pouvoir de disposer des
Parts Sociales;
- aucune des Parts Sociales n’est gagée ou grevée d’un usufruit; il n’existe aucun droit pour acquérir quelque gage ou
usufruit que ce soit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales ne fait l’objet d’une saisie;
- il n’existe aucun droit de préemption ou autre droit permettant à une personne de demander le transfert d’une des
Parts Sociales à son profit;
- selon les statuts de MPKS et MPKN2 respectivement., les Parts Sociales sont librement transmissibles;
- au 24 février 2015, la valeur des Parts MPKS s’élève au moins à 12,500 GBP (douze mille cinq cent livres sterling) et
la valeur des Parts MPKN2 s’élève au moins à 12,501 GBP (douze mille cinq cent et une livres sterling); ces évaluations
étant basées sur les principes comptables généralement acceptés et supportés par les bilans intérimaires de MPKS et
MPKN2 respectivement du 31 janvier 2015 qui n’ont pas changé depuis.
Les certificats et une copie des bilans mentionnés ci-avant, signés ne varietur par le représentant au nom de la partie
comparante et par le notaire instrumentant, resteront annexés au présent acte pour y être soumis ensemble aux for-
malités de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence des résolutions prises ci-dessus, l’associé unique décide de modifier l’article 5, premier alinéa des
statuts de la Société afin de lui conférer désormais la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à GBP 37.502,-(trente-sept mille cinq cent deux livres sterling) représenté
par 37.502 (trente-sept mille cinq cent deux) parts sociales d’une valeur nominale de GBP 1,- (une livre sterling) chacune.»
47116
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête des mêmes personnes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: F. PREIFFER, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2015. Relation: EAC/2015/5646. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 16 mars 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015043073/164.
(150049272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 mars 2015.
JH-Holding Finance SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 195.887.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the second of April,
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
JH-HOLDING GMBH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under
the laws of Germany, having its registered office in Römerweg 64, D-67434 Neustadt / Weinstraße, Germany, registered
with the local court (Amtsgericht) at Ludwigshafen / Rhein with registration number HRB 60814, duly represented by
Mr. Anthony THILLMANY, by virtue of a proxy given on 1 April 2015.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the appearing person and the undersigned notary and shall be attached
to the present deed to be filed at the same time.
Such appearing party, represented as said above, has requested the notary to inscribe as follows the articles of asso-
ciation of a “société anonyme” which it forms as single incorporating shareholder:
Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration
Art. 1. There exists a public limited liability company (société anonyme) (the Company) which will be governed by the
laws pertaining to such an entity, and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from
time to time (the Law), as well as by the present articles of association (the Articles).
Art. 2. The name of the Company is “JH-Holding Finance SA”.
Art. 3. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general
meeting of shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
The registered office may be transferred within the City of Luxembourg by decision of the sole director or, in case of
plurality of directors, of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such deci-
sion, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such declaration of the transfer of the registered
office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company, which is best situated for
this purpose under such circumstances.
The sole director or, in case of plurality of directors, the board of directors may establish branches or offices of
representation in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.
Art. 4. The corporate objects of the Company are:
a) the issuance of notes for the purpose of applying all of the proceeds thereof to grant one or more loans to its
shareholder JH-Holding GmbH (JHH);
47117
L
U X E M B O U R G
b) granting loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any
kind or which form part of the same group of companies as the Company;
c) the granting of security interests over its assets in relation to the issuance of notes referenced above;
d) the making of deposits at banks or with other depositories;
e) the entering into (i) the relevant documentation in connection with the issue of the notes and (ii) the aforesaid loan
agreement with JHH, and, in each case, into all documents and transactions contemplated thereby; and
f) the entering into documents necessary or useful in view of the proper operation of the Company.
The Company may not carry out any activity falling within the scope of the Luxembourg law dated 5 April 1993 relating
to the financial sector, as amended.
In addition to the issue of the notes, the Company may not incur any indebtedness other than for paying costs that (i)
arise in connection with the transactions contemplated by the Company's corporate objects or (ii) are necessary or useful
for the proper operation of the Company.
Art. 5. The Company is established for an unlimited period.
Title II. - Capital, Shares
Art. 6. The Company has an issued share capital of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) divided into
THIRTY-ONE THOUSAND (31,000) shares having a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each.
The shares are in registered form only.
Each share is entitled to one vote.
Title III. - Management
Art. 7. The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether shareholders
or not.
In the situation of the Company only having one single shareholder, only one (1) director may administer the Company,
regardless whether being a natural person or a legal entity.
Unless otherwise specified herein, all powers given to the board of directors in these Articles shall also apply to the
single director in case of appointment of only one director by the single shareholder.
If a director is a legal entity, it shall designate a permanent representative (the Permanent Representative) residing in
Luxembourg.
Members of the board of directors or the single director are appointed for a period not exceeding six (6) years by
the general meeting of shareholder(s) which may at any time remove them.
The number of directors, their term and their remuneration are fixed by the general meeting of the shareholder(s).
The office of a director shall be vacated if:
a) he resigns his office by notice to the Company, or
b) he is removed from office by resolution of the shareholder(s).
Insofar as the law allows, every present or former director of the Company shall be indemnified out of the assets of
the Company against any loss or liability incurred by him by reason of being or having been a director.
Art. 8. The board of directors shall elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It
must be convened each time two (2) directors so request.
Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing, by telegram, facsimile, electronic
mail, or letter another director as his proxy.
All meetings of the board of directors shall be held in Luxembourg.
The board of directors shall validly resolve on any matters if a majority of its members is present or represented.
Written resolutions signed by all members of the board of directors or by the single director, as the case may be, will
be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document
or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, telefax or similar communication. Written
resolutions will be delivered to and kept at the registered office of the Company.
In addition, any member of the board of directors who participates in the proceedings of a meeting of the board of
directors by means of a communication device (including a telephone and video conference), which allows all the other
members of the board of directors present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of
communications device) to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at
such meeting and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such
meeting. Conference calls of the meetings of the board of directors shall be initiated from Luxembourg.
The minutes of a meeting of the board of directors shall be signed by all directors present or represented at the
meeting. Extracts shall be certified by the chairman or any director or by any person nominated during a meeting of the
board of directors.
47118
L
U X E M B O U R G
Art. 9. The single director or the board of directors, as the case may be, is/are vested with the broadest powers to
perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the Company.
All powers not expressly reserved by law or by the present Articles to the general meeting of shareholder(s) fall within
the competence of the board of directors or the single director, as the case may be.
The board of directors may pay interim dividends in compliance with the relevant legal requirements.
Art. 10. If a board of directors is existing, the Company will be bound in any circumstances by the joint signatures of
any two directors, unless special decisions have been reached concerning the authorised signature in case of delegation
of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present Articles.
If only one director exists, the Company will be bound by the signature of such director. If the single director is a legal
entity, the signature shall be considered if given in accordance with the corporate documents and authorisation in place
for such legal entity.
Art. 11. The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or
more directors, who will be called managing directors.
The board of directors or the single director, as the case may be, may also commit the management of all the affairs
of the Company or of a special branch to one or more directors, and give special powers for determined matters to one
or more proxyholders, selected from its own members or not, whether shareholders or not.
Art. 12. Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the
Company by the board of directors or the single director, as the case may be, represented by its chairman or by the
director delegated for this purpose.
Title IV. - Supervision
Art. 13. Except where the Company’s annual accounts are audited by an approved independent auditor (réviseurs
d’entreprise agréés), the Company’s annual accounts shall be reviewed by one or several statutory auditors (commissai-
res) appointed by the general meeting of shareholders, which will fix their number and its/their remuneration, as well as
the term of its/their office, which must not exceed six (6) years.
Title V. - General meeting
Art. 14. The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the third
Wednesday of March of each year at 3 p.m.
If such day is a legal holiday, the annual general meeting will be held on the next following business day.
All other general meetings of shareholder(s) shall also be held in Luxembourg.
The general meeting may validly resolve by the vote of the majority of present or represented shares at the annual or
an extraordinary general meeting unless Luxembourg law or these Articles stipulate different quorum and voting requi-
rements.
Shareholders may participate in general meetings by way of video conference or by way of telecommunication devices
provided their full identification can be permitted and effective participation is ensured given the technical means used.
Title VI. - Financial year, Allocation of profits
Art. 15. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall terminate on the
thirty-first of December of the same year.
Art. 16. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortisations, the credit balance
represents the net profits of the Company.
Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory
when the reserve amounts to ten percent (10%) of the share capital of the Company, but it must be resumed until the
reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below 10% of the share capital
of the Company.
The remainder amount after deduction of the legal reserve is at the disposal of the general meeting of shareholders
or the single shareholder, as the case may be.
Title VII. - Dissolution, liquidation
Art. 17. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders or by decision of the
single shareholder, as the case may be. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more
liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholder(s) which will specify their powers
and fix their remuneration.
Title VIII. - General provisions
Art. 18. All matters not governed by these Articles are to be construed in accordance with the Law.
47119
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory dispositionsi>
1.- The first annual meeting will be held in the year 2016.
2.- The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and shall end on 31 December
2015.
<i>Subscriptioni>
The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share
capital upon incorporation as follows:
JH-HOLDING GMBH THIRTY-ONE THOUSAND SHARES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
All the shares of a par value of ONE EURO (EUR 1.-) each have been fully paid up by payment in cash and the amount
of THIRTY-ONE THOUSAND EURO (EUR 31,000.-) is now available to the Company, evidence thereof was given to
the undersigned notary.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 of the Law have been observed.
<i>Estimation - Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of its incorporation, is one thousand four hundred Euro (EUR 1,400.-).
<i>Extraordinary general meetingi>
The above named party, representing the entire subscribed share capital of the Company and considering the meeting
duly convened, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.
The single shareholder has passed the following resolutions by its affirmative vote:
1) The registered office of the Company is fixed at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg;
2) Have been appointed members of the board of directors of the Company:
a) Peter Lourents van Opstal, born on 12 February 1969 in Zwijndrecht, Netherlands, with professional residence at
40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
b) Christian Knauff, born on 4 August 1975 in Namur, Belgium, with professional residence at 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
c) Peter Van Nugteren, born on 19 April 1966 in Meppel, Netherlands, with professional residence at 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
3) Has been appointed independent auditor:
PricewaterhouseCoopers, société coopérative incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register
under number B 65477; and
4) The directors’ and auditor’s terms of office will expire after the annual meeting of shareholder(s) of the year 2021,
unless they previously resign or are revoked.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date mentioned at the beginning of
this document.
The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and
residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German Translation of above Text:
Im Jahr zweitausendundfünfzehn, am zweiten April,
Vor dem unterzeichneten Notar Blanche MOUTRIER mit Amtswohnsitz in Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Lu-
xemburg.
Erschien folgende Person:
JH-HOLDING GMBH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach deutschem Recht, mit Sitz in Rö-
merweg 64, D-67434 Neustadt / Weinstraße, Deutschland, registriert beim Amtsgericht Ludwigshafen / Rhein unter der
Nummer HRB 60814, wirksam vertreten durch Herr Anthony THILLMANY, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, auf
Grund einer am 1. April 2015 erteilten Vollmacht.
47120
L
U X E M B O U R G
Die von der erschienenen Partei ausgestellte Vollmacht, welche von der anwesenden Partei und dem Notar ne varietur
paraphiert wurde, bleibt der Urkunde beigeheftet, um zusammen mit dieser registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Aktiengesellschaft,
société anonyme, welche die Partei als Einzelaktionär gründen möchte, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer der Gesellschaft
Art. 1. Es besteht eine Aktiengesellschaft (die Gesellschaft), auf welche die jeweiligen luxemburgischen Gesetze An-
wendung finden, und im besonderen das Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (in der jeweils gültigen
Fassung) sowie der vorliegenden Satzung (die Satzung).
Art. 2. Der Name der Gesellschaft ist “JH-Holding Finance SA”.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg.
Der Sitz der Gesellschaft kann innerhalb Luxemburgs durch einen Gesellschafterbeschluss verlegt werden. Die Be-
schlussfassung muss den Anforderungen genügen, die an eine Satzungsänderung gestellt werden.
Der Sitz der Gesellschaft kann innerhalb der Stadt Luxemburg durch einen Beschluss des alleinigen Verwaltungsrats-
mitglieds oder, im Falle von mehreren Verwaltungsräten, durch einen Beschluss des Verwaltungsrats verlegt werden.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen
oder eingetreten sind, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen
diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg
geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen.
Eine solche Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft. Die Erklärung der Sitzverlegung soll
Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden welches angesichts der herrschenden Umstände
am besten dazu in der Lage ist.
Der Einzelvorstand oder, im Falle von mehreren Verwaltungsräten, der Verwaltungsrat kann Niederlassungen oder
Repräsentanzen in Luxemburg oder im Ausland gründen.
Art. 4. Der Gesellschaftszweck der Gesellschaft ist:
a) die Ausgabe von Schuldverschreibungen, deren Erlös in Form von einem oder mehreren Darlehen an den Gesell-
schafter JH-Holding GmbH (JHH) weiter gereicht wird;
b) die Ausgabe von Darlehen oder die anderweitige Unterstützung von Gesellschaften, in denen die Gesellschaft eine
direkte oder indirekte Beteiligung oder ein anderweitiges Recht hält oder die andere Gruppengesellschaften sind;
c) die Bestellung von Sicherheiten über ihre Vermögensgegenstände im Zusammenhang mit der oben erwähnten Aus-
gabe von Schuldverschreibungen;
d) die Vornahme von Einzahlungen bei Banken oder anderen Verwahrstellen;
e) der Eintritt in die (i) relevante Dokumentation im Zusammenhang mit der Ausgabe der Schuldverschreibungen und
(ii) der oben genannten Darlehensverträge mit JHH und, in jedem Fall, der Eintritt in alle Dokumente und Transaktionen,
die davon umfasst sind;
f) der Eintritt in alle für einen ordnungsgemässen Betrieb der Gesellschaft notwendigen oder nützlichen Dokumente.
Die Gesellschaft darf keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten nach dem luxemburgischen Gesetz vom 5. April 1993 über
den Finanzsektor (in der jeweils gültigen Fassung) ausführen.
Zusätzlich zur Ausgabe der Schuldverschreibungen darf die Gesellschaft keine weiteren Verbindlichkeiten eingehen
ausser der Begleichung von Kosten, die im Rahmen von Transaktionen entstanden sind, die vom Gesellschaftszweck der
Gesellschaft abgedeckt oder notwendig oder nützlich sind, um einen ordnungsgemässen Betrieb der Gesellschaft zu
gewährleisten.
Art. 5. Die Gesellschaft ist auf unbegrenzte Zeit gegründet.
Titel II. - Kapital, Aktien
Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (EUR 31.000,-), eingeteilt
in EINUNDDREISSIGTAUSEND (31.000) Aktien mit einem Nennwert von EINEM EURO (EUR 1,-) je Aktie.
Die Aktien sind Namensaktien. Jede Aktie hat eine Stimme.
Titel III. - Verwaltung
Art. 7. Die Gesellschaft wird durch den Verwaltungsrat, bestehend aus mindestens drei (3) Mitgliedern, geleitet, welche
Aktionäre sein können.
Sollte die Gesellschaft nur einen Einzelaktionär haben, so kann lediglich ein (1) Einzelvorstand die Geschäfte der Ge-
sellschaft führen, unabhängig davon, ob er eine natürliche oder juristische Person ist.
Sofern in dieser Satzung nicht anders vorgesehen, sind alle Vollmachten und Kompetenzen, welche dem Verwaltungsrat
zugewiesen werden, auch dem Einzelvorstand zugewiesen, sofern ein solcher gewählt wurde.
47121
L
U X E M B O U R G
Sollte ein Vorstandsmitglied oder Einzelvorstand eine juristische Person sein, so ernennt dieser Vorstand einen per-
manenten Vertreter (der Permanente Vertreter), welcher in Luxemburg residiert.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand werden durch die Generalversammlung der Aktionäre
für eine Dauer von höchstens sechs (6) Jahren gewählt, wobei die Generalversammlung die Mitglieder jederzeit abberufen
kann.
Die Anzahl der Verwaltungsratsmitglieder, die Dauer ihres Mandats sowie ihre Entschädigung werden durch die Ge-
neralversammlung der Aktionäre festgesetzt.
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
Das Amt eines Verwaltungsratsmitglieds gilt als unbesetzt wenn:
a) er von seinem Posten unter schriftlicher Benachrichtigung der Gesellschaft zurücktritt, oder
b) wenn er von seinem Posten durch Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre enthoben wird.
Sofern das Gesetz es erlaubt, soll jedes aktuelle oder ehemalige Mitglied des Verwaltungsrates aus dem Vermögen der
Gesellschaft für jeglichen Verlust oder Haftung entschädigt werden, welche ihm aufgrund der Ausübung seines Mandats
als Mitglied entstanden sind.
Art. 8. Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden.
Auf Einberufung durch den Vorsitzenden trifft sich der Verwaltungsrat so oft wie es im Interesse der Gesellschaft
notwendig ist. Der Verwaltungsrat muss zusammentreten, wenn zwei (2) Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.
Jedes Verwaltungsratsmitglied kann ein anderes Verwaltungsratsmitglied schriftlich, per Telegramm, Fax, E-mail oder
Brief zu seinem Vertreter bei Verwaltungsratssitzungen bestimmen.
Alle Verwaltungsratssitzungen werden in Luxemburg abgehalten.
Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig, sofern die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse können auch auf schriftlichem Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse). Solche Beschlüsse haben dieselbe
Wirksamkeit und Auswirkungen wie Beschlüsse einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Verwaltungsrats-
sitzung, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Einzelvorstand sie unterzeichnet haben. Die Unterschriften
der Mitglieder in einem Umlaufbeschluss können auf einem Dokument oder auf mehreren Kopien eines gleich lautenden
Beschlusses erscheinen und können im Wege eines Briefes, Fax oder ähnlichen Kommunikationsmittels erbracht werden.
Umlaufbeschlüsse sollen an den Sitz der Gesellschaft übersendet werden und dort aufbewahrt werden.
Mitglieder des Verwaltungsrates können Sitzungen auch durch Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abhalten.
Nimmt ein Mitglied an einer solchen Sitzung durch ein Fernkommunikationsmittel (einschließlich eines Telefons) teil, so
muss sichergestellt sein, dass alle anderen an der Sitzung teilnehmenden Mitglieder (die entweder anwesend sind oder
sich ebenfalls eines Ferntelekommunikationsmittels bedienen) dieses Mitglied hören und selbst von diesem Mitglied gehört
werden können. In einem solchen Fall gelten Mitglieder, die sich eines Fernkommunikationsmittels bedienen als an dieser
Sitzung teilnehmende Mitglieder, die für die Zählung des Quorums maßgeblich sind und wirksam über alle auf einer solchen
Sitzung besprochenen Angelegenheiten abstimmen können.
Protokollniederschriften von Verwaltungsratssitzungen werden von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Auszüge der Protokollniederschriften werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von der Person zertifiziert,
die hierfür während der Verwaltungsratssitzung bestimmt worden ist.
Art. 9. Der Einzelvorstand oder der Verwaltungsrat ist befugt, die Gesellschaft im weitesten Sinne zu leiten und alle
Geschäfte vorzunehmen, welche mit dem Gesellschaftszweck in Einklang stehen.
Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder diese Satzung der Generalversammlung zustehen, fallen
in den Aufgabenbereich des Verwaltungsrates oder des Einzelvorstandes.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, im Einklang mit den rechtlichen Vorschriften Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 10. Die Gesellschaft wird rechtlich in jeder Hinsicht durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-
ratsmitgliedern gebunden, es sei denn, dass eine gesonderte Entscheidung getroffen wurde, durch welche die Zeichnungs-
oder Vertretungsbefugnis nach Artikel 10 dieser Satzung durch Entscheidung des Verwaltungsrates an andere Personen
delegiert wurde.
Sollte lediglich ein Einzelvorstand existieren, wird die Gesellschaft durch die Unterschrift des Einzelvorstandes rechtlich
wirksam gebunden. Ist der Einzelvorstand eine juristische Person, so soll deren Unterschrift im Einklang mit ihren Ge-
sellschaftsdokumenten und existierenden Autorisation abgegeben werden.
Art. 11. Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse zur Führung des Tagesgeschäfts an einen oder mehrere seiner
Mitglieder, die geschäftsführenden Mitglieder, delegieren.
Der Verwaltungsrat kann weiterhin die Verwaltung aller Angelegenheiten der Gesellschaft oder der Angelegenheiten
eines bestimmten Sachgebietes einem oder mehrerer seiner Mitglieder zuweisen und für bestimmte Angelegenheiten
Sondervollmachten an andere Personen erteilen, die weder Verwaltungsratsmitglieder noch Aktionäre der Gesellschaft
sein müssen.
47122
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Der Verwaltungsrat, durch seinen Vorsitzenden oder einen für diesen Zweck bevollmächtigtes Mitglied des
Verwaltungsrates, oder der Einzelvorstand, falls vorhanden, vertritt die Gesellschaft in allen Rechtsstreitigkeiten im Na-
men der Gesellschaft.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 13. Ausser wenn die Bilanz der Gesellschaft von einem zugelassenen unabhängigen Rechnungssprüfer (réviseurs
d’entreprise agréés) geprüft wird, wird diese durch einen oder mehrere satzungsmässige Rechnungsprüfer (commissaires)
geprüft, welche durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt werden, die auch die Anzahl der Rechnungsprüfer,
ihre Entschädigung und die Dauer ihrer Bestellung, welche sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf, bestimmt.
Titel V. - Generalversammlung
Art. 14. Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich am dritten Mittwoch im Monat März um 15 Uhr in
Luxemburg an dem in der Einladung benannten Ort statt.
Sollte ein solcher Tag ein gesetzlicher Feiertag sein, wird die Generalversammlung am nächstfolgenden Arbeitstag
stattfinden.
Alle außerordentlichen Generalversammlungen finden ebenfalls in Luxemburg statt.
Die Generalversammlung kann wirksam Beschlüsse fassen, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden und vertre-
tenen Aktionäre auf einer jährlichen oder außergewöhnlichen Generalversammlung zustimmt, es sei denn, das Gesetz
oder diese Satzung sehen andere Mehrheits- und Quorumserfordernisse vor.
Titel VI. - Geschäftsjahr / Gewinnverwertung
Art. 15. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten Dezember eines
jeden Jahres.
Art. 16. Nach Abzug jeglicher Ausgaben der Gesellschaft und Amortisierungen, weist die Bilanz der Gesellschaft ihren
Nettogewinn aus.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden als gesetzliche Rücklage abgeführt. Diese zwangsweise Abführung endet
sobald die gesetzliche Rücklage einen Wert von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft erreicht
hat. Sollte die gesetzliche Rücklage unter diesen Wert sinken, muss die zwangsweise Abführung wieder aufgenommen
werden bis die gesetzliche Rücklage wieder vollständig aufgefüllt ist.
Über den verbleibenden Nettogewinn kann die Generalversammlung der Aktionäre oder der Einzelaktionär, wie vor-
handen, frei verfügen.
Titel VII. - Auflösung und Liquidation
Art. 17. Die Gesellschaft kann jederzeit, durch einen Beschluss der Generalversammlung der Aktionäre oder des
Einzelaktionärs aufgelöst werden. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren
Liquidatoren durchgeführt, die natürliche oder juristische Personen sein können und von der Generalversammlung bestellt
werden. Die Generalversammlung bestimmt die Befugnisse und die Entschädigung des bzw. der Liquidatoren.
Titel VIII. - Allgemeine Vorschriften
Art. 18. Alle Angelegenheiten, die nicht in dieser Satzung geregelt werden, unterliegen den Vorschriften des Gesetzes
vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften und den Änderungsgesetzen zu diesem Gesetz.
<i>Vorübergehende Bestimmungeni>
1.- Die erste ordentliche Generalversammlung findet im Jahre 2016 statt.
2.- Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschiene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital
wie folgt zu zeichnen:
JH-HOLDING GMBH EINUNDDREISSIGTAUSEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Aktien
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 Aktien
Alle Aktien wurden durch Barzahlung vollständig zu EINEM EURO (EURO 1,-) je Aktie bezahlt, so dass nunmehr die
Summe von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (EUR 31.000,-) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem
Notar gegenüber nachgewiesen wurde.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar erklärt, dass die Bedingungen des Artikels 26 des Gesetzes vom 10. August 1915, wie
abgeändert, beachtet und erläutert wurden.
47123
L
U X E M B O U R G
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Grün-
dung tragen muss belaufen sich auf ungefähr Eintausend vier hundert Euro (EUR 1.400,-).
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft repräsentiert und sich ordnungs-
gemäß zusammengefunden hat, beschließt, sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche
Generalversammlung abzuhalten.
Nach der Feststellung, dass sich die Generalversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat, beschließt der Ein-
zelaktionär folgendes:
1) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
2) Als Mitglieder des Verwaltungsrates werden folgende Personen ernannt:
a) Peter Lourents van Opstal, geboren am 12 Februar 1969 in Zwijndrecht, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in
40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
b) Christian Knauff, geboren am 4 August 1975 in Namur, Belgien, mit beruflicher Anschrift in 40, avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
c) Peter Van Nugteren, geboren am 19 April 1966 in Meppel, Niederlande, mit beruflicher Anschrift in 40, avenue
Monterey, L-2163 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg;
3) Als Rechnungsprüfer wird ernannt:
PricewaterhouseCoopers, société coopérative, gegründet nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2, rue Gerhard
Mercator, L-2182 Luxembourg, registriert beim luxemburgischen Handelsregister, Registre de Commerce et des Sociétés
Luxembourg unter der Nummer B 65477; und
4) Die Mandate der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Rechnungsprüfers enden nach der ordentlichen Gene-
ralversammlung der Aktionäre im Jahr 2021, es sei denn, sie treten vorher zurück oder werden abgewählt.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass die vorstehende Urkunde
auf Verlangen der Partei in englischer Sprache, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, verfasst wurde. Der Erschienene
legt fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.
WORÜBER diese notarielle Urkunde am Datum wie eingangs erwähnt und in Esch-sur-Alzette erstellt wurde.
Nachdem diese Urkunde dem Erschienenen, welcher dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort bekannt
ist, vorgelesen wurde, hat der Erschienene zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Signé: THILLMANY, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 03/04/2015. Relation: EAC/2015/7825. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): HALSDORF.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 03/04/2015.
Référence de publication: 2015051236/391.
(150059421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 avril 2015.
RH Paris 3 Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 5.350.000,00.
Siège social: L-1643 Luxembourg, 21, rue du Fort Elisabeth.
R.C.S. Luxembourg B 192.761.
Acte de constitution publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 09/01/2015
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises le 3 mars 2015 par les associés de la Société que:
- Monsieur Philippe ROTH a démissionné de ses fonctions de gérant A avec effet au 26 février 2015;
- Monsieur René MAURON, né le 9 novembre 1950 à Versoix (Suisse), demeurant professionnellement au 11 avenue
Calas, 1206 Genève (Suisse) a été nommé gérant A de la Société avec effet au 26 février 2015 et pour une durée indé-
terminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour RH Paris 3 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015037357/17.
(150042017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
47124
L
U X E M B O U R G
Serges Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8057 Bertrange, 15, rue du Chemin de Fer.
R.C.S. Luxembourg B 94.302.
Les statuts coordonnés au 20 novembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015036023/10.
(150040367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 125.012,00.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 14, boulevard F.D. Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 139.522.
AUSZUG
Aus dem Protokoll der ordentlichen jährlichen Generalversammlung des alleinigen Gesellschafters der Gesellschaft
vom 23. Februar 2015, geht hervor, dass KPMG Luxembourg, mit Sitz in L-1855 Luxemburg, 39, Avenue John F. Kennedy,
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B149133, als Wirtschaftsprüfer der
Gesellschaft bis zur ordentlichen jährlichen Generalversammlung, welche über die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres
2015 beschließt, ernannt wurde.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 3. März 2015.
Référence de publication: 2015036149/16.
(150041008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
MP Kings North 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.665.
MP Kings North 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.666.
MP Kings South S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 159.672.
In the year two thousand fifteen,
On the fifth day of March,
Before Maître Carlo GOEDERT, notary residing in Dudelange,
There appeared:
1) the board of managers of MP Kings North 1 S.àr.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered
office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.665;
hereby represented by Françoise PFEIFFER, pursuant to resolutions of the board of manager of MP Kings North 1
S.àr.l dated 5
th
March 2015; and
2) the board of managers of MP Kings North 2 S.àr.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered
office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.666;
hereby represented by Françoise PFEIFFER, pursuant to resolutions of the board of manager of the MP Kings North
2 S.àr.l dated 5
th
March 2015; and
3) the board of managers of MP Kings South S.àr.l. a Luxembourg société à responsabilité limitée, having its registered
office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
(Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.672;
hereby represented by Françoise PFEIFFER, pursuant to resolutions of the board of manager of the MP Kings South
S.àr.l dated 5
th
March 2015;
47125
L
U X E M B O U R G
A copy of the resolutions of the board of managers of each of the represented entities, after having been signed ne
varietur by the appearing parties and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed at the
same time with the registration authorities.
The appearing parties request the undersigned notary to record the following common merger plan, drawn-up by the
respective board of managers that they represent in accordance with section XIV (Mergers) of the Luxembourg law of
10 August 1915 on commercial companies, as amended (the 1915 Companies Law):
<i>1. Description of the Mergeri>
(a) Merging entities:
(i) MP Kings North 1 S.àr.l. a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.665 and having a share capital of GBP 37,502
(the Absorbing Company),
(ii) MP Kings North 2 S.àr.l. a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.666 and having a share capital of GBP 12,501
(the Absorbed Company 1),
(iii) MP Kings South S.àr.l. a société à responsabilité limitée, organised under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 159.672 and having a share capital of GBP 12,500
(the Absorbed Company 2 and collectively with the Absorbed Company 1, the Absorbed Companies),
The Absorbing Company and the Absorbed Companies are hereinafter collectively referred to as the Merging Com-
panies.
(b) The Absorbing Company holds the entire share capital and all voting rights of each of the Absorbed Companies.
(c) The Absorbing Company proposes to absorb the Absorbed Companies without liquidation in accordance with the
provisions of the articles 278 to 280 of the 1915 Companies Law as a result of which all assets and liabilities of the
Absorbed Companies will be transferred to the Absorbing Company (the Merger).
(d) The legal form, the name and the registered office of the Absorbing Company will not change as a result of the
Merger.
(e) Given that the Absorbing Company is the sole shareholder of each of the Absorbed Companies, the approval of
the Merger by the extraordinary general meeting of each of the Merging Companies will not be required in accordance
with article 279 of the 1915 Companies Law, it being understood that one or more shareholders of the Absorbing
Company holding at least 5% of its shares is/are entitled, during the one-month period preceding the Effective Date (as
defined below), to require that a general meeting of the Absorbing Company be called to resolve on the approval of the
Merger.
<i>2. Effective date of the Mergeri>
(a) The Merger will be effective between the Merging Companies, one month after the publication of the present
common merger plan in the Mémorial C; Recueil des Sociétés et Associations (the Effective Date).
(b) The Merger will be enforceable against third parties upon the publication in the Mémorial C; Recueil des Sociétés
et Associations of the notarial certificate confirming that the conditions of article 279 of the 1915 Companies Law have
been met.
(c) For accounting purposes, the Merger shall be deemed to be effective as from 1 April 2015. Consequently, the
operations performed by the Absorbed Companies between 1 April 2015 and the Effective Date shall for accounting
purposes be retroactively considered as having been performed by the Absorbing Company.
<i>3. Rights of the particular classes of shareholders and holders of other financial instrumentsi>
(a) There does not exist any particular classes of shareholders within the Merging Companies.
(b) MP Real Estate W6 No.1 Nominee Limited, in its capacity as sole holder of (i) all the £850,143 notes issued by the
Absorbed Company 1 on 30 March 2012 and (ii) all the £ 5,550,209 notes issued by the Absorbing Company on 30 March
2012 has given its consent to the Merger pursuant to resolutions adopted on 24 February 2015.
(c) No special advantages are provided in favour of the members of the administrative, management, supervisory or
controlling organs of the Merging Companies.
<i>4. Transfer of the assets and Liabilities.i>
(a) In accordance with articles 274 and 278 of the 1915 Companies Law, the Merger will produce the following legal
effects as from the Effective Date:
(i) all assets and liabilities of the Absorbed Companies will be transferred to the Absorbing Company by operation of
law;
47126
L
U X E M B O U R G
(ii) the Absorbed Companies will cease to exist, and
(iii) the shares of the Absorbed Companies will be cancelled.
(b) As from the Effective Date the Absorbing Company shall (i) be liable for all debts and payments obligations of the
Absorbed Companies existing prior to the Effective Date and (ii) be subrogated to all rights of the Absorbed Companies
pursuant to any agreements to which the Absorbed Companies were a party.
(c) By way of exception to paragraphs 4(a) and 4(b), the transfer of industrial and intellectual property rights and of
ownership rights or other rights in rem (other than collateral established on movable and immovable property) will be
enforceable against third parties upon fulfilment of the conditions provided for in the specific laws governing such ope-
rations.
<i>5. Information concerning the Mergeri>
(a) The documents referred to in article 267 paragraph 1, a), b) and c) of the 1915 Companies Law, will be available
at least during the one-month period preceding the Effective Date, for inspection by the shareholder(s) at the registered
offices of the Merging Companies.
(b) The books and records of the Absorbed Companies will be held at the registered office of the Absorbing Company
for the period legally prescribed.
The undersigned notary public hereby certifies the existence and legality of the merger project pursuant to article 271
(2) of the 1915 Companies Law.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French translation; on request of the appearing parties and in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, the appearing parties sign together with us, the notary, the
present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze,
Le cinq mars,
Par-devant, Maître Carlo GOEDERT, notaire de résidence à Dudelange,
Ont Comparu:
1) Le conseil de gérance de MP Kings North 1 S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et inscrit auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.665;
ici représentée par Françoise PFEIFFER, en vertu d'une résolution du conseil de gérance de MP Kings North 1 S.àr.l.
en date du 5 mars 2015;
2) Le conseil de gérance de MP Kings North 2 S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois,
ayant son siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et inscrit auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159.666;
ici représentée par Françoise PFEIFFER, en vertu d'une résolution du conseil de gérance de MP Kings North 2 S.àr.l.
en date du 5 mars 2015;
3) Le conseil de gérance de MP Kings South S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant
son siège social à 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, et inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159.672;
ici représentée par Françoise PFEIFFER, en vertu d'une résolution du conseil de gérance de MP Kings North 1 S.àr.l.
en date du 5 mars 2015;
Une copie des résolutions du conseil gérance de chacune des entités représentées, après avoir été signées ne varietur
par les parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec
lui aux formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes requièrent le notaire instrumentant d'acter le projet commun de fusion qui suit, préparé par
les conseils de gérance respectifs qu’elles représentent conformément à la section XIV (Fusions) de la loi du 10 août 1915
sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915 sur les Sociétés).
<i>1. Description de la Fusioni>
(a) Parties à la fusion:
(i) MP Kings North 1 S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 159.665 et ayant un capital social de 37.502 GBP (la Société Absorbante);
47127
L
U X E M B O U R G
(ii) MP Kings North 2 S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 159.666 et ayant un capital social de 12.501 GBP (la Société Absorbée 1);
(iii) MP Kings South S.àr.l. une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 40,
avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, inscrit auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 159.672 et ayant un capital social de 12.500 GBP (la Société Absorbée 2 et collectivement avec la Société
Absorbée 1, les Sociétés Absorbées.
La Société Absorbante et les Sociétés Absorbées sont désignées ci-après ensemble par les Sociétés Fusionnantes.
(b) La Société Absorbante détient l’intégralité du capital social et des droits de vote dans chacune des Sociétés Ab-
sorbées.
(c) Il est proposé que la Société Absorbante absorbera les Sociétés Absorbées sans liquidation conformément aux
articles 278 à 280 de la Loi de 1915 sur les Sociétés avec comme suite que tous les actifs et passifs des Sociétés Absorbées
seront transférés à la Société Absorbante (la Fusion)
(d) La forme légale, sa dénomination et le siège social de la Société Absorbante ne seront pas modifiées à la suite de
la Fusion.
(e) Étant donné que la Société Absorbante est l’associé unique des chacune des Sociétés Absorbées, l'approbation de
la Fusion par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des Sociétés Fusionnantes ne sera pas nécessaire confor-
mément aux dispositions de l'article 279 de la Loi de 1015 sur les Sociétés, étant entendu qu'un ou plusieurs actionnaires
de la Société Absorbante détenant au moins 5% des parts de la société peut ou peuvent, pendant le délai d'un mois qui
précède la Date d'Effet (tel que défini ci-dessous), convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante
pour statuer sur l'approbation de la Fusion.
<i>2. Date d'effet de la Fusioni>
(a) La Fusion prendra effet entre les Sociétés Fusionnantes un mois après la publication de ce projet commun de fusion
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (la Date d'Effet).
(b) La Fusion sera opposable aux tiers à la date de la publication du certificat du notaire constatant que les formalités
de l’article 279 de la Loi de 1915 sur les Sociétés sont remplies
(c) Du point de vue comptable, la Fusion sera réputée prendre effet à partir du 1
er
avril 2015. Par conséquent, les
opérations effectuées par les Sociétés Absorbées entre le 1
er
avril 2015 et la Date d'Effet doivent sur le plan comptable
être considérés comme ayant été effectués par la Société Absorbante de manière rétroactive.
<i>3. Droits réservés à des catégories particulières d'actionnaires ou des titulaires d'autres instrumentsi>
(a) Il n'existe pas de classes d'actionnaires particulières parmi les Sociétés Fusionnantes.
(b) MP Real Estate W6 No.1 Nominee Limited, en tant que seul détenteur (i) de toutes les £ 850,143 obligations
émises par la Société absorbée 1 le 30 mars 2012 et (ii) de toutes les £ 5,550,209 obligations émises par la Société
Absorbante le 30 mars 2012 a donné son consentement à la Fusion par des résolutions en date du 24 février 2015.
(c) Aucun avantage particulier n'est accordés aux membres du personnel administratif, de gestion, les organes de
surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent.
<i>4. Transfert de l'actif et du passif.i>
(a) Conformément aux articles 274 et 278 de la Loi sur les Sociétés, la Fusion produira les effets légaux suivant à partir
de la Date d’Effet:
(i) l'Actif et le Passif des Sociétés Absorbées seront transférés à la Société Absorbante de plein droit;
(ii) les Sociétés Absorbées cesseront d'exister, et
(iii) les actions des Sociétés Absorbées seront annulées.
(b) A partir de la Date d’Effet la Société Absorbante sera (i) responsable de toutes les dettes et obligations de paiement
des Sociétés Absorbées existant avant la Date d’Effet et (ii) sera subrogée dans tous les droits des Sociétés Absorbées
sous les contrats auxquelles les Sociétés Absorbées étaient parties.
(c) Par dérogation aux paragraphes 4(a) et 4(b), le transfert des droits de propriété industrielle et intellectuelle ainsi
que des droits de propriété ou autres droits sur les actifs autres que les sûretés réelles sur biens meubles et immeubles
sera opposable aux tiers, à la réalisation des conditions prévues dans les lois spécifiques régissant ces opérations.
<i>5. Informations concernant la Fusion.i>
(a) Les documents visés à l'article 267, alinéa 1, a), b) et c) de la Loi sur les Sociétés, seront disponibles au moins
pendant la période d'un mois précédant la Date d'Effet, aux fins d'inspection par les actionnaires au siège social des Sociétés
Fusionnantes.
(b) Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant
la période prescrite par la loi.
47128
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné déclare attester de l'existence et de la légalité du projet de fusion conformément à l'article 271
(2) de la Loi sur les Sociétés Commerciales.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que sur demande des personnes com-
parantes mentionnées ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française; à la demande des
mêmes personnes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, connus du notaire par leur noms et
prénoms, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: F. PFEIFFER, C. GOEDERT.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 mars 2015. Relation: EAC/2015/5656. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): A. SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés et aux fins
de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Dudelange, le 18 mars 2015.
C. GOEDERT.
Référence de publication: 2015050015/210.
(150057300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 1
er
avril 2015.
Beggiani, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 196.025.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le deux avril.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
A comparu:
Monsieur Francisco Manuel QUINTANS DE SOURE, dirigeant de sociétés, né le 29 septembre 1956 à Lisbonne
(Portugal), demeurant professionnellement à L- 1140 Luxembourg, 113, route d’Arlon,
ici représenté par Maître Thomas SARPCAN, avocat, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 49, Bou-
levard Royal, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du 2 avril 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la personne comparante et par le notaire
soussignée, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec celui-ci.
Ladite comparante, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte des statuts
d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives et
par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet le négoce international (importation, exportation, distribution) de tous produits à usage
industriel ou à destination du consommateur final ainsi que l'importation ou l'exportation de toutes matières premières,
notamment de tous produits en bois, et les prestations d’intermédiaires pouvant s’y rapporter.
La société a aussi pour objet l’activité de tout service de commerce dans des domaines en rapport avec des projets
de toute nature considérés sous les aspects d’ordre commercial et stratégique et en général, la réalisation de toutes
opérations commerciales en relation directe ou indirecte avec les secteurs pré-décrits de manière à en faciliter l’accom-
plissement.
La société peut en outre, prendre des participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises luxem-
bourgeoises et étrangères, l’acquisition de tous titres et droits, par voie de participation, d’apport, de souscription, de
prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, et, entre autres, l’acquisition de brevets et licences, leur gestion
et leur mise en valeur, ainsi que toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet, notamment
l’emprunt, avec ou sans garantie et en toutes monnaies, par la voie d’émissions d’obligations, qui pourront être conver-
tibles et/ou subordonnées, et de bons, en accordant des prêts ou garanties à des sociétés dans lesquelles elle aura pris
des intérêts.
La société peut accomplir toutes opérations qu'elles soient immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et
financières nécessaires ou autres se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social.
Art. 3. La société prend la dénomination de "BEGGIANI".
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
47129
L
U X E M B O U R G
Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La Société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille quatre cent soixante-cinq euros (EUR 12.465,-), représenté par cent
(100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-quatre euros et soixante-cinq centimes (EUR 124,65-) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants droits ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et à tout moment révocables
par l'assemblée des associés.
L'acte de nomination fixera l'étendue des pouvoirs et la durée des fonctions du ou des gérants.
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une
société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui/eux au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente et un décembre deux mille quinze.
<i>Souscription et libération:i>
Les cent (100) parts sociales sont souscrites par l'associé unique, Francisco Manuel QUINTANS DE SOURE, prén-
ommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de douze mille
quatre cent soixante-cinq euros (EUR 12.465,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, preuve en
ayant été fournie au notaire instrumentant.
47130
L
U X E M B O U R G
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué à la somme de neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).
<i>Résolutions de l’associe uniquei>
Et aussitôt après la constitution de la Société, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social souscrit a pris
les résolutions suivantes:
1.- Le nombre des gérants est fixé à un.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Monsieur Francisco Manuel QUINTANS DE SOURE, dirigeant de sociétés, né le 29 septembre 1956 à Lisbonne
(Portugal), demeurant professionnellement à L- 1140 Luxembourg, 113, route d’Arlon.
La société est engagée, en toutes circonstances, par la signature individuelle du gérant unique.
3.- L'adresse de la société est fixée à L-1140 Luxembourg, 113, route d’Arlon.
L’attention des comparants a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des
autorités compétentes les autorisations et/ou agréments requis le cas échéant afin d’exercer les activités telles que dé-
crites à l’article 2 des présents Statuts.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Sarpcan, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 3 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/0513. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 avril 2015.
Référence de publication: 2015054170/112.
(150062455) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2015.
Managed Funds Portfolio, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 81.144.
NN (L), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.
In the year two thousand fifteen, on the eighth day of April.
Before Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).
THERE APPEARED
The board of directors of Managed Funds Portfolio (the "Managed Funds Portfolio Board") and the board of directors
of NN (L) (the "NN (L) Board") commonly approve the terms of the proposed merger of the assets of Managed Funds
Portfolio - Serenity VSX 5 and Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 10 (the "Contributing Sub-Funds") into NN (L)
First Class Multi Asset, (the "Receiving Sub-Fund") a sub-fund of NN (L) as follows:
1. Managed Funds Portfolio (the "Contributing Company") is incorporated in Luxembourg as a société anonyme, having
its registered office at 3, rue Jean Piret - L-2350 Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de Commerce
et des Sociétés under number B 81.144. The Contributing Company qualifies as a société d’investissement à capital variable
organised as an umbrella fund pursuant to Part II of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective invest-
ment, as amended from time to time (the "Law of 2010"), and as an alternative investment fund in accordance with the
law of 12 July 2013 on Alternative Investment Fund Managers, as amended from time to time (the "Law of 2013").
2. NN (L) (the "Receiving Company") is incorporated in Luxembourg as a société anonyme, having its registered office
at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Registre de
Commerce et des Sociétés under number B 44.873. The Receiving Company qualifies as a société d’investissement à
capital variable organised as an Umbrella Fund pursuant to Part I of the Law of 2010.
The Contributing Company and the Receiving Company, together the Merging Companies, both here represented by
Ms Laure GERARD, Legal Counsel, residing professionally in Luxembourg, duly appointed by a resolution of the Board
of Directors of both companies on 8 April 2015, a copy of such resolution shall remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.
47131
L
U X E M B O U R G
TERMS OF MERGER
<i>Type of Merger and Sub-funds and AIF/UCITS involvedi>
The Contributing Sub-Funds shall merge into the Receiving Sub-Fund in accordance with the terms and provisions of
their respective prospectuses and articles of incorporation, and the provisions of Section XIV of the law on commercial
companies dated 10 August 1915, as amended from time to time (the “Law of 1915”), with effect as of the Effective Date
(as defined below).
The portfolio of the Contributing Sub-Funds will be liquidated and the merger will be done by the transfer of cash to
the Receiving Sub-Fund. As a consequence of the merger, the Contributing Sub-Funds and the Contributing Company
will be dissolved without liquidation, transferring all of its assets and liabilities into the Receiving Sub- Fund, in accordance
with article 259 (1) of the Law 1915. New shares of the Receiving Sub-Fund will be issued to the shareholders of the
Contributing Sub- Funds, as follows:
Contributing Sub-Funds and share classes
Receiving Sub-Fund and share classes
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 5
NN (L) First Class Multi Asset
A CAP EUR
LU0290137057
P CAP EUR
LU0809674541
A CAP USD (Hedged)
LU0290136240
P CAP USD (Hedged)
LU1175220752
I CAP EUR
LU0290136083
I CAP EUR
LU0809674202
I CAP USD (Hedged)
LU0290135788
I CAP USD (Hedged)
LU1175220679
Managed Funds Portfolio - Serenity VSX 10
NN (L) First Class Multi Asset
A CAP EUR
LU0290137560
P CAP EUR
LU0809674541
A CAP USD (Hedged)
LU0290136836
P CAP USD (Hedged)
LU1175220752
I CAP EUR
LU0290137305
I CAP EUR
LU0809674202
I CAP USD (Hedged)
LU0290136596
I CAP USD (Hedged)
LU1175220679
In addition, as part of the merger, the minimum holding requirements in the Receiving Sub-Fund will be waived for
shareholders of the Contributing Sub-Funds.
<i>Background and rationale of the Mergeri>
The reason for the merger is that the overall product streamlining of NN Investment Partners Group pertaining its
worldwide distribution of investment funds and the higher assets resulting from a merger would (a) optimize the product
offering and generate economy of scale and (b) lower the costs borne by the shareholders with more efficient usage of
fund management resources; therefore the merger of the Contributing Sub-Funds with the Receiving Sub-Fund would
benefit to the shareholders of the Contributing Sub-Funds.
<i>Expected impact of the Merger on shareholdersi>
The assets and liabilities of the Contributing Sub-Funds will be transferred into the Receiving Sub-Fund.
For your reference, a comparison of the main features of the Contributing Sub-Funds and of the Receiving Sub-Fund
is enclosed in Appendix I.
Shareholders of the Contributing Sub-Funds should note that the investment policies of the Contributing Sub-Funds
differ from the investment policy of the Receiving Sub-Fund.
Investment objective and policy
The objective of the Contributing Sub-Funds is to obtain long-term absolute performance by investing in a diversified
portfolio composed primarily of any type of fixed-income securities and/or money market instruments and/or equities
and/or any type of traditional or alternative funds or funds of funds, and on an ancillary basis in cash.
Fixed-income securities primarily include (but are not limited to) bonds, convertible bonds, inflation-linked bonds,
mortgage pass-through securities, collateralised mortgage obligations, mortgage-backed securities, variable-rate bonds
and asset-backed securities.
If it invests in other target investment funds or funds of funds, the Sub-Funds must ensure that the securities portfolios
of those target investment funds or funds of funds have the appropriate liquidity features to enable the Sub-Funds to meet
its redemption obligations to its investors.
47132
L
U X E M B O U R G
Investors’ attention is drawn to the fact that if it invests in other target investment funds, additional fees may be charged
because fees applicable to those target investment funds may be added to the usual fees applicable to the Sub-Funds.
The Receiving Sub-Fund aims to deliver attractive returns under all market circumstances by investing in assets classes
defined below. At all times the sub-fund will mainly invest in a combination of investment grade debt, cash equivalent, and
short term debt. The Sub-Fund may also invest, on an ancillary basis, in other asset classes as defined below (with maximum
20% of the sub-fund’s net assets in Asset- Backed and mortgage backed securities).
Eligible investments
The Sub-Fund may invest in transferable securities (including warrants on transferable securities up to a maximum of
10% of the Sub-Fund’s net assets), bonds, equities, money market instruments, 144A securities, units of UCITS and other
UCIs and deposits, as described in the full prospectus in Part III, Chapter III “Investment Restrictions”, Section A “Eligible
investments”. Investments in asset-back securities will however be limited to 20% and investments in UCITS and UCIs
may not exceed a total of 10% of the net assets.
Where the Sub-Fund invests in warrants on transferable securities, the Net Asset Value may fluctuate more than if
the Sub-Fund were invested in the underlying assets because of the higher volatility of the value of the warrant.
The Sub-Fund may be exposed to various exchange risks linked to investments in securities denominated in currencies
other than that of the Sub-Fund or in derivative instruments with underlying exchange rates or currencies.
With a view to achieving the investment objectives, the Sub-Fund may also use derivative financial instruments including,
but not limited to, the following:
- options and futures on transferable securities or money market instruments
- index futures and options
- interest rate swaps, futures and options
- performance swaps
- credit default swaps
- forward currency contracts and currency options.
The risks linked to this use of derivative financial instruments for purposes other than hedging are described in the full
prospectus in Part III, Chapter II “Risks linked to the investment universe: detailed description”.
Shareholders of the Contributing Sub-Funds should note that there may be a possible dilution in performance caused
by the merger.
The merger of the assets of the Contributing Sub-Funds into the Receiving Sub-Fund is and will represent a contribution
of 100% of the Receiving Sub-Fund’s assets under management.
Fees and expenses
For your reference, a comparison of the main fees and expenses of the Contributing Sub-Funds and of the Receiving
Sub-Fund is enclosed in Appendix I.
Cost of the Merger
The costs associated with the merger will be supported by the Alternative Investment Fund Manager.
<i>The Mergeri>
Criteria for valuation of assets and liabilities
The assets and liabilities of the Contributing Sub-Funds will be valued in accordance with the valuation principles laid
down in the articles of incorporation and the full prospectus.
Calculation method of the exchange ratio
Exchange ratio will be calculated on basis of the net asset value per share of the Contributing Sub-Funds set in relation
to the net asset value of the Receiving Sub- Fund on the effective date of the merger.
Planned Effective Date
The effective date shall be as of close of business on 19 May 2015 or at any other date thereafter (the "Effective Date").
Rules applicable to the transfer of assets and liabilities and exchange of shares
On the Effective Date, all assets and liabilities of the Contributing Sub-Funds, including any accrued income, valued in
accordance with the principles laid down above, will be transferred to the Receiving Sub-Fund. The shares of the Con-
tributing Sub-Funds will be cancelled and the Contributing Sub-Funds and Managed Funds Portfolio will then cease to
exist.
No subscription fee will be levied by the Receiving Sub-Fund as a result of the merger.
As from the Effective Date, for accounting purposes, the operations of the Contributing Company will be considered
as accomplished for the account of the Receiving Company.
The independent auditor, namely Deloitte has been designated by the Board of Directors of the Contributing Company
for the purposes of reviewing the exchange ratios and their fairness for the shareholders of the Contributing Company
and drawing up a written report on the proposed Merger appointed in accordance with article 266 of the Law of 1915.
47133
L
U X E M B O U R G
The independent auditor, namely Ernst & Young has been designated by the Board of Directors of the Receiving
Company for the purposes of reviewing the exchange ratios and their fairness for the shareholders of the Contributing
Company and drawing up a written report on the proposed Merger appointed in accordance with article 266 of the Law
of 1915.
The Receiving Company does not grant special rights to the shareholders or holders of securities, if any.
No special advantages are granted to the members of the board of directors or the approved statutory auditors of
the Merging Companies.
<i>Timeline of the Mergeri>
The issue of Shares in the Contributing Sub-Funds will be suspended with effect as of 12 May, 2015. Accordingly,
subscription and conversion applications in the Contributing Sub-Funds can be submitted up to the last cut-off at 3.30
p.m. Luxembourg time on 1 May, 2015.
Shareholders will be able to redeem their shares free of charges in the Contributing Sub-Funds until 12 May, 2015, i.e.
redemption applications can be submitted up to the last cut-off at 3.30 p.m. Luxembourg time on 1 May 2015. Any
redemption applications in the Contributing Sub-Funds received after 3.30 p.m. Luxembourg time on 1 May 2015 will not
be processed and any such redemption requests should be submitted to the Receiving Sub-Fund on or after 20 May 2015.
The shares will be exchanged as of close of business on 19 May, 2015 on the basis of the net asset value per share of
the Contributing Sub-Funds, calculated on 19 May, 2015 and based on the closing prices of 19 May, 2015. Shareholders
will be informed accordingly.
With effect as of 20 May 2015, shareholders of the Contributing Sub-Funds that have not exercised their right to
redeem their shares free of charges shall be able to exercise their rights as shareholders of the Receiving Sub-Fund.
<i>Notification of Shareholdersi>
Shareholders of the Contributing Sub-Funds will be notified of the merger and their rights in relation thereto. Infor-
mation on the merger shall also be made available to shareholders of the Contributing Sub-Funds, in the jurisdictions
where shares of the Contributing Sub-Funds are distributed.
All shareholders have the right, at least one month prior to the date of the extraordinary general meeting of the
shareholders (EGM) convened to consider the merger proposal, to consult the documents listed under article 267 (1)
of the Law of 1915 at the companies’ registered offices and to obtain copies thereof free of charge upon request.
In compliance with article 264 of the Law of 2015, one or more of the shareholders of the Receiving Company holding
at least 5% in the subscribed share capital of the Receiving Company are entitled to require that a general meeting of
shareholders of the Receiving Company be called in order to resolve on the approval of the Merger.
The meeting must be convened so as to be held within one month of the request for it to be held.
<i>Declarationi>
The undersigned notary declares that the foregoing merger proposal is validly and legally made pursuant to article 271
(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Alternative Investment Fund Manager as a result of
the present deed are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500,-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English with no need of further translation in accordance with Article 26(2) of
the Law of 2010.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by her surname, name, civil
status and residence, the appearing person signed together with the notary, the present original deed.
Signé: Gerard, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 8 avril 2015. Relation: 1LAC/2015/10970. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 10 avril 2015.
Référence de publication: 2015054408/187.
(150062034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 avril 2015.
47134
L
U X E M B O U R G
ParisInvest I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 139.491.
EXTRAIT
L'actionnaire unique a décidé lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 2 mars 2015:
- d'acter la démission de Moyse Dargaa de son mandat d'administrateur de la société avec effet au 23 janvier 2015,
ainsi que la démission de Messieurs Benoit Lejeune et Arnaud Schreiber, de leurs mandats d'administrateurs de la société
avec effet au 30 janvier 2015.
- de nommer Monsieur Sven Taymans, né le 25 novembre 1976 à Leuven, Belgique, résidant professionnellement au
Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles, Belgique en tant qu'administrateur unique de la société avec effet immédiat pour
une période prenant fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes
annuels de la Société arrêtés au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Pour extrait sincère et conforme
ParisInvest I S.A.
Signature
Référence de publication: 2015037300/21.
(150041605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
TeamSystem HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 3.667.186,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 154.473.
EXTRAIT
Par contrat de transfert de parts sociales entre parties au 20 février 2015, l'associé Intermediate Investments Jersey
Limited, a transféré une partie des parts sociales qu'il détenait dans la Société de la manière suivante:
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe A
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe B
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe C
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe D
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe E
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe F
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe G
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe H
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe I
- 1,729 parts sociales ordinaires de classe J
à ICG European Fund 2006 NO2 SARL, une société ayant son siège social au 412F route d'Esch L-2086 Luxembourg
et immatriculée sous le numéro B149429.
La situation après ce transfert se présente de la manière suivante:
ICG European Fund 2006 NO2 SARL détient:
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe A
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe B
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe C
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe D
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe E
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe F
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe G
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe H
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe I
- 19,229 parts sociales ordinaires de classe J
47135
L
U X E M B O U R G
Intermediate Investments Jersey Limited détient:
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe A
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe B
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe C
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe D
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe E
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe F
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe G
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe H
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe I
- 7,021 parts sociales ordinaires de classe J
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015034729/48.
(150038816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Trias UK Edinburgh - T S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 15.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 194.364.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales daté du 26 février 2015 que Trias Holdco C -T S.à r.l., associé
unique de la Société, a transféré l'ensemble des quinze mille (15.000) parts sociales qu'elle détenait dans le capital social
de la Société à Trias Pool VI - T S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 6A, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B194833.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015036657/16.
(150041025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
European General Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 94.997.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale qui s'est tenue le 17 février 2015 à 10.00 heures à Luxembourgi>
- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de ratifier le nomination de Jean-Charles THOUAND et de renouveler
le mandat des Administrateurs, Messieurs Koen LOZIE, Jean Charles THOUAND et de la société JALYNE S.A., 1, rue
Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, représentée par Jacques BONNIER, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, pour
une nouvelle durée, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes annuels arrêtés au
31 décembre 2015.
- L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité, de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes de Monsieur
Pierre SCHILL pour une nouvelle durée, celle-ci venant à échéance lors de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes
annuels arrêtés au 31 décembre 2015.
Copie Conforme
- / JALYNE S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015036965/20.
(150041576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
47136
Agraf Real Estate No 2
Allianz Investments II Luxembourg S.à r.l.
ArcelorMittal REACH OR
Bacheron S.A.
Beggiani
Belgian European Agencies
BlueSPHERE
Caissa S.A. SPF
Compagnie Margaux S.A. SPF
Compass Private Investments S.A. (FIS)
Delphimmo
Diga Consulting SA
Dival S.A.
DWS Investment S.A.
Elbey
Elbey
Energreen Investment Europe S.A.
Eremis S.A.
Europe 94 S.A.
European General Investments
Foncière de Bagan S.A.
Gerlachus Fund
Hillpark S.A.
JH-Holding Finance SA
Kicheneck
KKR Co G.P S.à r.l.
Korea Invest S.A.
Licensing Invest S.A.
LSEG LuxCo 1 S.à r.l.
Luxshipping S.A.
Managed Funds Portfolio
Millicom International Cellular S.A.
MP Kings North 1 S.à r.l.
MP Kings North 1 S.à r.l.
MP Kings North 2 S.à r.l.
MP Kings South S.à r.l.
NN (L)
Northgate Private Equity S.A. (FIS)
ParisInvest I S.A.
RH Paris 3 Sàrl
Serges Finance S.A.
Société anonyme des Entreprises Minières S.A., SPF
SoWiTec Luxembourg 4 S.à r.l.
Swift Invest Holding SPF SA
Switex S.A.
TeamSystem HoldCo S.à r.l.
Tonus & Cunha Associés S.à r.l.
Trias UK Edinburgh - T S.à r.l.
T. Rowe Price (Luxembourg) Management Sàrl
Vison
Vontobel Management S.A.
Weatherford Capital Ltd. Luxembourg Branch