logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 945

8 avril 2015

SOMMAIRE

Brissond Investissements S.A.  . . . . . . . . . . .

45358

Creation Julia S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45334

Damina S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45321

Dekra Automobil GmbH, Zweigniederlas-

sung Luxemburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45324

Digital Services XXX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

45338

Dokumenta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45331

Drive for Life  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45324

EFA Promo S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45322

Eos Products S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45327

European DSBK Holding S.à r.l.  . . . . . . . . .

45314

European Property Services S.à r.l.  . . . . . .

45314

Fontainbleu S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45321

Groupe Leonard de Vinci International  . .

45337

Grove Holdings 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45331

Hansteen Hannover S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

45321

IFS Capital Luxemburg II S.A. . . . . . . . . . . .

45320

Jezioro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Laccolith S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45318

Le Bistrot Gourmand S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

45316

Lombard Odier Funds  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45316

Lone Star Capital Investments S.à r.l. . . . .

45316

LSREF3 Tiger Luxembourg S.à r.l. . . . . . . .

45319

Lux.G.L. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45320

Lyrics Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45316

Mainpoint Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45320

Malintra Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45317

Marzilux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45319

Maximilian Centre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45318

Mayfair Estates S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

45319

MCT Berlin Vier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45317

Megapolis S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45318

Methanex Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

45315

Neopolis Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45319

Nucleus Management S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

45320

Ocean Oil Construction and Services  . . . .

45317

OCM Starfish Debtco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

45318

PK201 SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45315

Popken International G.m.b.H. & Co  . . . .

45315

SAE S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45315

Secufund S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Sem International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

45314

Setas International SPF S.A.  . . . . . . . . . . . .

45359

Watchmoor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45360

45313

L

U X E M B O U R G

European DSBK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 171.475.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015034990/10.
(150039684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

European Property Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.859.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015034992/10.
(150039362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Secufund S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 174.524.

EXTRAIT

Monsieur Marc Vanhellemont, administrateur et administrateur délégué de la société, est domicilié professionnellement

au 1, rue Bender à L-1229 Luxembourg.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015035354/11.
(150039463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Sem International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 39.612.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
SEM INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2015035355/11.
(150039163) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Jezioro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 91.940.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 8 décembre 2014

<i>Première résolution

Le Conseil décide de nommer la société Omnes &amp; Partners S.A. en sa qualité d'expert-comptable, ayant son siège

social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159.142 en tant qu'agent dépositaire, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2014.

Référence de publication: 2015035149/12.
(150038733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45314

L

U X E M B O U R G

PK201 SA, Société Anonyme.

Siège social: L-4281 Esch-sur-Alzette, 7, rue Portland.

R.C.S. Luxembourg B 167.244.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015035302/9.
(150038975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Popken International G.m.b.H. &amp; Co, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 61.155.

EXTRAIT

Par décision en date du 9 février 2015, les associés de la société ont décidé de transférer le siège social de la société

de L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie à L-1940 Luxembourg, 296-298 route de Longwy, à compter du 1

er

 mars 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015035303/13.
(150039352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

SAE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4101 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 168.021.

<i>Extrait de résolution de l'Associé unique du 19 février 2015

L'associé unique de la société SAE S.à.r.l. a décidé, en date du 19/02/2015 de prendre la résolution suivante:
- Le siège social est transféré, avec effet immédiat, à l'adresse suivante:
L-4101 Esch-sur-Alzette, 12, rue de l'Eau

Esch-sur-Alzette, le 19 février 2015.

Pour extrait conforme
Jean-Philippe HANS
<i>L'associé unique

Référence de publication: 2015035345/15.
(150039432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Methanex Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 200.002,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 172.158.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 25 février 2015 que:
(i) La démission de Monsieur Patrick MOINET, gérant de catégorie B de la Société, a été acceptée avec effet au 14

février 2015;

(ii) Monsieur Scott McKinlay, né à Dunfermline, Royaume-Uni, le 11 avril 1983, résidant professionnellement au 16,

avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de catégorie B avec effet au 14 février 2015 et ce pour une
durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015035208/17.
(150039148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45315

L

U X E M B O U R G

Lone Star Capital Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 91.796.

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2014.

Référence de publication: 2015035179/10.
(150039619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Le Bistrot Gourmand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5440 Remerschen, 77, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 109.842.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015035189/10.
(150039246) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Lyrics Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 166.632.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions écrites des associés de la Société du 25 février 2015 que:
- La démission de M. Patrick MOINET, gérant de classe B de la Société, avec effet au 13 février 2015, a été acceptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Référence de publication: 2015035183/13.
(150039095) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Lombard Odier Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 25.301.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26 Février 2015

En date du 26 février 2015, l'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
- de renouveler les mandats de Madame Francine Keiser, Monsieur Yvar Mentha, Monsieur Johannes Gerardus Simon

Maria Straatman (alias Jan Straatman) et Monsieur Patrick Zurstrassen en qualité d'Administrateurs pour une durée d'un
an, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

- de renouveler le mandat de PricewaterhouseCoopers, société coopérative, ayant comme nouvelle adresse 2, rue

Gerhard Mercator, L-1014 Luxembourg, en qualité de réviseur d'entreprise pour une durée d'un an, jusqu'à la prochaine
Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Olvia TOURNIER
<i>Responsable juridique / Head of legal

Référence de publication: 2015035177/21.
(150039451) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45316

L

U X E M B O U R G

Malintra Holdings S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 37.307.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

<i>Pour: MALINTRA HOLDINGS S.A.
Société anonyme
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015035217/14.
(150039055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Ocean Oil Construction and Services, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 104.834.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 février 2015 que l'assemblée accepte la

démission de James D. Leewong de son poste d'Administrateur.

L'assemblée note également le changement d'adresse de John O'Kelly -Lynch. Il réside au Williams House, 4 

th

 Floor,

20 Reid Street, Hamilton HM12, aux Bermudes.

<i>Pour Ocean Oil Construction and Services S.à r.l.
Otto A. Meier / Roeland Pels / Alan Jones
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015035259/15.
(150039786) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

MCT Berlin Vier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 120.529.

<i>Ordentliche Generalversammlung vom 19. März 2014

Durch Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 19. März 2014 wurden die Mandate aller Mitglieder des

Verwaltungsrats bis nach der Generalversammlung von 2020 erneuert und der Verwaltungsrat setzt sich demnach wie
folgt zusammen:

<i>Kategorie “A” Verwaltungsratsmitglieder

a) Mr. Stéphane de Blonay, 2-4 Place du Molard, CH-1211 Genf
b) Mr. Frédéric Königsegg-Aulendorf , 2-4 Place du Molard, CH-1211 Genf

<i>Kategorie “B” Verwaltungsratsmitglieder

c) Mr. Marcel Marbach, 5, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg
d) Mr. Jean-Paul Schaul, 5, Avenue Monterey, L-2163 Luxemburg

<i>Außerordentliche Generalversammlung vom 1. Dezember 2014

Durch Beschluss der außerordentlichen Generalversammlung vom 1. Dezember 2014 wurde
Herr Fabrice Broto, geschäftsansässig 2-4 Place du Molard , 1211 Genf, Schweiz
zum Verwaltungsratsmitglied der Kategorie „A“ der MCT BERLIN VIER (die „Gesellschaft“) ernannt und zwar bis nach

der ordentlichen Generalversammlung von 2020.

Herr Fabrice Broto übernimmt das Mandat von Herrn Frédéric Königsegg-Aulendorf, der vorher von der General-

versammlung der Gesellschaft abgerufen worden war.

Luxemburg, den 25. Februar 2015.

Référence de publication: 2015035226/25.
(150039589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45317

L

U X E M B O U R G

Megapolis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1145 Luxembourg, 59, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 159.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 Mars 2015.

Référence de publication: 2015035207/10.
(150039482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Laccolith S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 32.369.

EXTRAIT

Par décision en date du 4 février 2015, le Conseil d'Administration de la société LACCOLITH S.A. a décidé de trans-

férer le siège social de la société de L-1511 Luxembourg, 121 Avenue de la Faïencerie à L-1940 Luxembourg, 296-298
route de Longwy, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Howald.

Signature.

Référence de publication: 2015035184/13.
(150039346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Maximilian Centre, Société Anonyme.

Capital social: EUR 7.775.807,00.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 126.765.

<i>Extrait du conseil d'administration du 20/02/2015

Le conseil d'administration de la société Bastow Charleton S.à r.l., administrateur de type B de Maximilian Centre S.A.,

décide de:

- nommer M. Brian CONROY, demeurant professionnellement à Clanwilliam Court, Marine House, Dublin 2, Irlande,
comme représentant permanent de la société Bastow Charleton S.à r.l. dans le cadre de son mandat d'Administrateur

de type B de Maximilian Centre S.A.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015035206/15.
(150039561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

OCM Starfish Debtco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 171.903.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 3 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, Mme. Katherine Margaret Ralph, M. Frank Laval et M.

Christopher Boehringer avec effet du 31 janvier 2015

- De nommer Mme. Jennifer Box, ne le 8 novembre 1981 a Charlotte, (Etats-Unis) ayant sa résidence professionnelle

au 333, South Grand Avenue, 28 

th

 Floor, Los Angeles, CA 900710 (Etats-Unis) comme Gérant de la société avec effet

au 31 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Starfish Debtco Sàrl

Référence de publication: 2015035269/16.
(150039167) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45318

L

U X E M B O U R G

Marzilux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4222 Esch-sur-Alzette, 195-197, rue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 80.485.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015035221/10.
(150039577) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Neopolis Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 169.610.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 mars 2015.

Référence de publication: 2015035250/10.
(150039581) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

LSREF3 Tiger Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 192.107.

Les statuts coordonnés au 22/01/2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25/02/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015035194/12.
(150039387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Mayfair Estates S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 172.063.

EXTRAIT

L'associé unique de la société a pris en date du 15 janvier 2015 les décisions suivantes:
1. Monsieur Laurent Weis est révoqué de son mandat d'administrateur avec effet immédiat;
2. Monsieur Patrick de Froidmont est révoqué de son mandat d'administrateur avec effet immédiat;
3. Monsieur Simon-Pierre Saverys est révoqué de son mandat d'administrateur avec effet immédiat;
4. Monsieur Benoît de Froidmont est nommé en tant qu'administrateur, demeurant au 18, rue Robert Stümper, L-2557

Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes au 31 décembre
2018;

5. Monsieur Adrien Rollé est nommé en tant qu'administrateur, demeurant professionnellement au 18, rue Robert

Stümper, L-2557 Luxembourg, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes
au 31 décembre 2018;

6. Monsieur Spyridon Grigoratos est nommé en tant qu'administrateur, demeurant au 4A, Troias Street, Nea Erythrea,

Attiki, Grèce, son mandat expirant à l'assemblée générale ordinaire des associés statuant sur les comptes au 31 décembre
2018.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015035223/22.
(150039404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45319

L

U X E M B O U R G

Mainpoint Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.

R.C.S. Luxembourg B 128.943.

Les comptes annuels au 4 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015035204/9.
(150038887) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Lux.G.L. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3770 Tétange, 81, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 129.591.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015035196/9.
(150039183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

IFS Capital Luxemburg II S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 159.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015035127/13.
(150039005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Nucleus Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 60.101.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenue le 23 décembre 2014

Etaient présents: Monsieur Vincent DERUDDER, Administrateur Délégué
Monsieur Alain de MIOMANDRE, Administrateur
Monsieur Alvar VIRKUS, Administrateur

<i>Résolution unique: Démission du mandat d'administrateur

Le Conseil d'Administration prend note de la démission du mandat d'Administrateur de Monsieur Romain BICHEL,

né le 17 novembre 1960 à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), demeurant à Maison 67, L-6835 BOUDLER.

Le Conseil d'Administration est désormais composé de trois membres:
Vincent DERUDDER
Alain de MIOMANDRE
Alvar VIRKUS
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020, qui statue sur

les comptes annuels de l'année 2019.

Cette résolution a été unanimement adoptée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NUCLEUS MANAGEMENT S.A.

Référence de publication: 2015035247/23.
(150039078) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45320

L

U X E M B O U R G

Hansteen Hannover S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.296.350,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 113.226.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 25 février 2015

1. Madame Sarah Michaella Hornbuckle a démissionné de son mandat de gérante avec effet au 27 février 2015.
2. Le nombre de gérants a été diminué de 4 à 3.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Mme Janine McDONALD, de Mr Paul RODGER et de Mr Richard

LOWES, gérants, se situe désormais au 1 

er

 étage, Pegasus House, 37-43 Sackville Street, Londres W1S 3DL, Angleterre.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour Hansteen Hannover S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015035076/17.
(150039319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Damina S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 179.063.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 2015

L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société anonyme DAMINA S.A., SPF, ayant son

siège social à Luxembourg, a définitivement cessé d'exister.

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période

de cinq (5) ans au siège de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 février 2015.

<i>Pour DAMINA S.A., SPF
FIDESCO S.A.
<i>Liquidateur

Référence de publication: 2015034969/18.
(150039460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Fontainbleu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 65.232.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu en date du 16 février 2015

Suivant les dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la

tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, et en application de l'article 42 de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, les membres du conseil d'administration de la Société,
délibérant valablement, nomment la société TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., société anonyme ayant son siège
social  au  127,  rue  de  Mühlenbach,  L-2168  Luxembourg,  immatriculée  au  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de
Luxembourg sous le numéro B 86 955 et membre de l'Ordre des Experts Comptables de Luxembourg, en qualité de
dépositaire des actions au porteur de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FONTAINBLEU S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015035042/19.
(150038590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45321

L

U X E M B O U R G

EFA Promo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4342 Esch-sur-Alzette, 8, Cité Verte.

R.C.S. Luxembourg B 194.900.

STATUTS

L'an deux mille quinze.
Le vingt-quatre février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Monsieur Elvir FRLJUCKIC, agent immobilier, demeurant à L-4342 Esch-sur-Alzette, 8, Cité Verte.
Lequel comparant est ici représenté par Peggy SIMON, employée privée, demeurant professionnellement à L-6475

Echternach, 9, Rabatt, en vertu d'une procuration sous seing privé, donnée à Esch-sur-Alzette, en date du 5 février 2015,
laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la mandataire du comparant et le notaire instrumentant,
restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les

statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il entend constituer:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée régie par la loi du 10 août 1915, la loi du 18 septembre 1933

telles qu'elles ont été modifiées et par les présents statuts.

La société peut avoir un associé unique ou plusieurs associés. L'associé unique peut s'adjoindre à tout moment un ou

plusieurs co-associés, et de même les futurs associés peuvent prendre les mesures tendant à rétablir le caractère uni-
personnel de la société.

Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d'une agence immobilière, la promotion immobilière ainsi que toutes

prestations de services et activités commerciales.

Elle pourra faire toutes les opérations commerciales ou industrielles, financières, mobilières et immobilières se ratta-

chant directement ou indirectement à cet objet ou pouvant en faciliter l’extension ou le développement.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution.

Art. 4. La société prend la dénomination de "EFA PROMO S.à r.l.".

Art. 5. Le siège social est établi à dans la commune d'Esch-sur-Alzette.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en vertu d'une décision

de l’associé unique ou du consentement des associés en cas de pluralité d'eux.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400.-), représenté par

CENT (100) parts sociales de CENT VINGT-QUATRE EUROS (€ 124.-) chacune.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié dans les conditions prévues par l’article cent quatre-vingt-

dix-neuf de la loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l’actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l’agrément donné en assemblée

générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément des

propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Dans le cas de l’alinéa 2 le consentement n'est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réser-

vataires, soit au conjoint survivant et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.

Les héritiers ou les bénéficiaires d'institutions testamentaires ou contractuelles qui n'ont pas été agréés et qui n'ont

pas trouvé un cessionnaire 3-ps réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société,
trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d'huissier et notifiée aux associés par pli recom-
mandé à la poste.

Toutefois, pendant le dit délai de trois mois, les parts sociales du défunt peuvent être acquises, soit par les associés,

sous réserve de la prescription de la dernière phrase de l’art. 199 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
et ses modifications ultérieures, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même, lorsqu'elle remplit les
conditions exigées pour l’acquisition par une société de ses propres titres.

Le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société

ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.

45322

L

U X E M B O U R G

S'il n'a pas été distribué de bénéfice, ou s'il n'intervient pas d'accord sur l’application des bases de rachat indiquées par

l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.

L'exercice des droits afférents aux parts sociales du défunt est suspendu jusqu'à ce que le transfert de ces droits soit

opposable à la société.

Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été signifiées à la société ou acceptées par elle

dans un acte notarié conformément à l’art. 1690 du Code civil.

Art. 10. Le décès de l’associé unique ou de l’un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne met pas fin à la société.

Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers de l’associé unique ou d'un des associés, en cas de pluralité d'eux, ne

pourront pour quelque motif que ce soit faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé

unique ou par l’assemblée des associés. La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature du
ou des gérants agissant dans la limite de l’étendue de sa (leur) fonction telle qu'elle résulte de l’acte de nomination.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société. Simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l’assemblée des associés.
Les décisions de l’associé unique visées à l’alinéa qui précède sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal

ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 15. En cas de pluralité d'associés, chacun d'eux peut participer aux décisions collectives, quelque soit le nombre

de parts qui lui appartiennent, dans les formes prévues par l’article 193 de la loi sur les sociétés commerciales.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et chaque associé peut se faire

valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 16. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire com-

prenant  l’indication  des  valeurs  actives  et  passives  de  la  société,  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et  pertes,  le  tout
conformément à l’article 197 de la loi du 18 septembre 1933.

Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 18. Les produits de la société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux et des amor-

tissements constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent du capital social. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 19. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par l’associé unique ou par les associés en cas de pluralité d'eux, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions légales.

<i>Souscription et libération du capital social

Toutes ces parts ont été entièrement souscrites par Monsieur Elvir FRLJUCKIC, pré qualifié, et ont été immédiatement

libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (€ 12.400.-)
se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire qui le constate expressément.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice commence le jour de sa constitution et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Evaluation

Les frais incombant à la société du chef des présentes sont évalués à environ mille Euros (€ 1.000.-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Et aussitôt l’associé unique, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris en outre

les résolutions suivantes:

1.- Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée:
Monsieur Elvir FRLJUCKIC, pré qualifié.

45323

L

U X E M B O U R G

2.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant. Il peut conférer des pouvoirs

à des tiers.

3.- L'adresse de la société est fixée à L-4342 Esch-sur-Alzette, 8, Cité Verte.

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant a rendu attentif le comparant au fait qu'avant toute activité commerciale de la société pré-

sentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

DONT ACTE, fait et passé à Echternach, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la représentante du comparant, connue du notaire instrumentant

d'après ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 25 février 2015. Relation: GAC/2015/1582. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 02 mars 2015.

Référence de publication: 2015034999/121.
(150039423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Dekra Automobil GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 114.828.

Herr Werner VON HEBEL ist als Geschäftsführer zurückgetreten.
Dr. Gerd, NEUMANN, geboren am 24.06.1953 in Kritzmow (Deutschland), mit professioneller Anschrift in D-70565

Stuttgart, Handwerkstrasse, 15, wurde zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Herr Guido KUTSCHERA, geboren am 15.06.1968 in Köln (Deutschland), mit professioneller Anschrift in D-70565

Stuttgart, Handwerkstrasse, 15, wurde zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Herr Thomas REUTER, Handlungsbevollmächtigter der Zweigniederlassung, ist jetzt wohnhaft in
D-54451 Irsch, Schulstrasse, 29

Luxemburg, den 26. Februar 2015.

Référence de publication: 2015034388/15.
(150038061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Drive for Life, Association sans but lucratif.

Siège social: L-6553 Berdorf, 10, rue Michel Müller.

R.C.S. Luxembourg F 10.300.

STATUTS

Entre les soussignés
DA FONSECA Antonio, dit Tun, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-6553 Berdorf. 2. rue Michel Müller,
de nationalité luxembourgeoise,
VIEIRA Miguel, salarié, demeurant à L-6553 Berdorf, 10, rue Michel Müller,
de nationalité luxembourgeoise.
WAHL Tessy, fonctionnaire d'Etat, demeurant à L-6553 Berdorf, 10. rue Michel Müller,
de nationalité luxembourgeoise,
Paulo ALVES DA ROCHA salarié, demeurant à L-3290 Bettembourg. 12. am Leischemer,
de nationalité luxembourgeoise,
José SANTOS DA COSTA, salarié, demeurant à L-5881 Dalheim. 2, Waasserklapp.
de nationalité portugaise,
et tous ceux qui seront admis par la suite, une association sans but lucratif est crée, régie par les présents statuts ainsi

que par la loi du 24 avril 1928 sur les associations sans but lucratif

45324

L

U X E M B O U R G

Chapitre I 

er

 . Dénomination, Siège, et Objet social

Art. 1 

er

 .  L'association est dénommée Drive for Life.

Art. 2. L'association est créé pour une durée indéterminée et son siège social est établi à l’adresse de l’administration

communale de BERDORF

Commune de BERDORF, 10, rue Michel Müller L-6553 BERDORF.

Art. 3. L'association a pour objet de promouvoir le sport motorisé, d'organiser des manifestations sportives à caractère

recrutant et caritatif. à l’exclusion des évènements officiels énumérés au

«CODE SPORTIF NATIONAL XX CHAPITRE II: L'ORGANISATION DES COMPETITIONS, ARTICLE 5: DEFIN-

TION DES EPREUVES OFFICIELLES ET DES COMPETITIONS INTERDITES A. LES ÉPREUVES OFFICIELLES

1. Seuls les clubs organisateurs agréés sont autorisés à organiser des épreuves officielles et à introduire une demande

d'inscription au calendrier national ou international.

2. Les demandes d'inscription doivent en principe être introduites l’année précédant celle de l’épreuve, dans les délais

suivants:

- championnat FIA: 1 

er

 février

- calendrier international: 1 

er

 juillet,

- calendrier national: 1 

er

 novembre.

Une amende de maximum € 1.500 peut être infligée si les délais ci-dessus ne sont pas respectés.
3. La CS peut accepter une modification du calendrier national passée ces délais et ceci tout au long de la saison

sportive. Des épreuves peuvent également être ajournées, ajoutées ou retirées du calendrier sur décision de la CS. Dans
ces cas, aucun recours des organisateurs, des pilotes ou d'autres personnes physiques ou morales est possible.

4. A titre exceptionnel, des demandes d'inscription au calendrier national ou international peuvent être introduites en

cours de saison. Dans ce cas, l’organisateur peut se voir infliger une amende de maximum € 1.500.

5. A titre exceptionnel, des épreuves initialement non prévues au calendrier peuvent être inscrites en cours de saison

et être prises en compte pour un championnat, une coupe ou un challenge.

6. A titre exceptionnel ou en cas de force majeure, des épreuves peuvent être retirées du calendrier en cours de

saison par la CS. Au cas où l’organisateur désire retirer son épreuve en cours de saison, il peut se voir infliger une amende
de maximum € 1.500. Un minimum de 6 voitures est requis pour l’organisation d'une épreuve.

7. A titre exceptionnel, des changements de dates peuvent être introduits en cours de saison par l’organisateur, mais

il peut se voir infliger une amende de maximum € 1.500.

8. Dans le cadre d'une épreuve, toute parade et/ou démonstration doit être mentionnée dans le règlement particulier;

les engins (voitures, motos et assimilés) y participant doivent être mentionnées dans le programme. Aucun programme-
cadre ne peut être organisé sans l’autorisation expresse de la CS,

ainsi que des voyages à caractère sportif
L'association peut par ailleurs s'affilier à des organisations nationales ou internationales poursuivant le même but ou

plus généralement ayant pour but le soutien du sport motorisé.

Chapitre II. Membres de l’association

Art . 4. L'association comprendra au minimum 3 associés.

Art. 5. L'association comprendra deux catégories de membres:
a) Des membres associés. Seuls les membres associés ont un droit de vote.
Sont admissibles comme membres associés toutes les personnes qui en manifestent la volonté et qui sont déterminés

à observer les dispositions des présents statuts. L'admission d'un nouveau membre associé est décidée par le conseil
d'administration avec une majorité des 2/3 des voix.

b) Des membres d'honneurs qui ne soutiennent l’association que par leur «don».
Les membres d'honneur n'ont pas le droit de vote. Sont admissibles comme membres d'honneur toutes les personnes

qui en manifestent la volonté en soutenant l’association par des «dons». Les membres d'honneur n'exerceront aucune
prérogative prévue par la loi ou les présents statuts en faveur des membres associés.

Art. 6. La cotisation annuelle par les membres associés est fixée par l’assemblée générale et ne peut excéder le montant

de 50€. (Article 2-8° de la loi du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif).

Art. 7. La perte de la qualité de membre ne donne aucun droit à un remboursement de la cotisation.

Art. 8. Un membre peut se retirer de l’association en présentant sa démission à l’assemblée générale. Est réputé

démissionnaire le membre qui a refusé de payer la cotisation annuelle ce qui a omis de la payer trois mois après qu'elle
lui a été réclamée. L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration, peut, à majorité des deux tiers des
voix émises, exclure un membre de l’association lorsque ce dernier

45325

L

U X E M B O U R G

- a commis un acte ou une omission grave contraire aux présents statuts ou aux règlements de l’association;
- a commis un acte ou une omission de nature à porter préjudice à l’honneur ou à la considération de sa personne,

de la personne d'un autre membre ou de l’association.

Le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, peut, après avoir entendu l’intéressé

en ses explications, pour l’une des raisons ci-dessus établies, prononcer avec effet immédiat la suspension temporaire de
l’affiliation de ce membre. Cette suspension fera l’objet d'une délibération lors de la prochaine assemblée générale. En
cas de démission ou d'exclusion, le membre concerné n'a aucun droit sur le fond social et ne peut réclamer le rembour-
sement des cotisations payées par lui. En plus la personne démissionnaire ou exclu devra rendre tout objet appartenant
à l’association et mis à sa disposition.

Chapitre III. L'assemblée générale

Art. 9. L'assemblée générale se réunit annuellement durant le premier trimestre de l’année.

Art. 10. En cas de besoin, le conseil d'administration peut convoquer à chaque moment une assemblée extraordinaire.

Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration endéans deux mois lorsqu'un
cinquième des membres associés en fait la demande. Seule une assemblée générale extraordinaire pourra statuer sur les
modifications aux présents statuts.

Art. 11. Tous les membres associés sont convoqués à l’assemblée générale par voie postale ou email au moins 8 jours

à l’avance. Les convocations contiendront l’ordre du jour.

Art. 12. L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications des présents statuts que si l’objet

de celle-ci est spécialement indiqué dans la convocation et que si l’assemblée réunit les deux tiers des membres associés.
Si les deux tiers des membres associés ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, une seconde réunion
peut être réunie qui pourra délibérer quelque soit le nombre des membres associés présents, mais dans ce cas, la décision
sera soumise à l’homologation du tribunal civil. Toutefois, si la modification porte sur l’un des objets en vue desquels
l’association s'est constituée, les règles qui précèdent sont modifiées comme suit:

- la seconde assemblée ne sera valablement constituée que si la moitié au moins des membres associés sont présents,
- la décision n'est admise dans l’une ou l’autre assemblée que si elle est votée à la majorité des trois quarts des voix;
- si dans la seconde assemblée, les deux tiers des associés ne sont pas présents, la décision devra être homologuée

par le tribunal civil.

Art. 13. Chaque associé peut être porteur d'une et d'une seule procuration.

Art. 14.  Les  résolutions  de  l’assemblée  générale  détaillées  dans  un  rapport  seront  portées  à  la  connaissance  des

membres associés et des tiers par voie postale ou via email.

Chapitre IV. Administration

Art. 15. L'association est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de cinq

membres au plus, élus par l’assemblée générale. Les différentes tâches sont réparties entre eux par les membres du conseil
d'administration. Ne peuvent être admis au conseil d'administration que des membres majeurs associés qui font partie
du conseil des membres associés depuis déjà au moins un an.

Art. 16. La durée du mandat des administrateurs est de cinq ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Les

candidatures pour un mandat d'administrateur doivent être adressées au président lors de l’assemblée générale ou par
écrit au président au moins vingt-quatre heures avant l’assemblée générale. Les élections auront lieu en principe par vote
secret à la majorité simple. En cas de voix égales, la décision sera prise par tirage au sort. En cas de vacance d'un mandat
d'un ou de plusieurs administrateurs en cours d'exercice, les membres restants continuent à former un conseil d'admi-
nistration ayant les mêmes pouvoirs et attributions que celui nommé par l’assemblée générale. Un pouvoir de cooptation
permettra au conseil d'administration de remplir les postes vacants par des nouveaux membres même en cours d'exercice.

Art. 17. Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l’administration de l’association.

Tout ce qui n'est pas explicitement réservé à l’assemblée générale, par la loi ou par les présents statuts, est de sa com-
pétence. Le vice président remplace le président à titre égal en cas d'absence de celui-ci.

Art. 18. Les documents de l’association doivent porter la signature du président ou du vice-président ou celle du

secrétaire.

Art. 19. Les documents financiers doivent porter la signature du président ou celle du vice-président ou celle du

Trésorier.

Art. 20. Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont

responsables que de l’exécution de leur mandat.

Art. 21. Les décisions au sein du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix présentes. En cas

de parité, la voix du président est prépondérante.

45326

L

U X E M B O U R G

Chapitre V. Divers

Art. 22. L'exercice de l’association commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 23. La dissolution de l’association ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire, déli-

bérant dans les conditions de l’article 12 des présents statuts.

Art. 24. Dans le cas de dissolution volontaire, l’actif net sera affecté à une ou plusieurs associations à caractère caritative,

à désigner par l’assemblée générale.

Art. 25. L'association est régie par les dispositions des présents statuts. Tout ce qui n'est pas prévu par ces statuts est

régi par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif.

<i>Les membres fondateurs:

DA FONSECA Tun, demeurant à L-6553 Berdorf, 2, rue Michel Müller,
VIEIRA Miguel, demeurant à L-6553 Berdorf, 10, rue Michel Müller,
WAHL Tessy, demeurant à L-6553 Berdorf, 10, rue Michel Müller,
ALVES DA ROCHA Paulo, demeurant à L-3290 Bettembourg, 12, a Leischemer,
SANTOS DA COSTA José, demeurant à L-5681 Dalheim, 2, Waasserklapp,

Signatures.

Référence de publication: 2015034966/142.
(150039628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Eos Products S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.750,00.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 193.794.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of Eos Products S.à r.l., a private limited liability

company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with regis-
tered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve
thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) and in the process of being registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) (the Company). The Company has been incorporated on December
19, 2014 pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company
have not been amended since the date of incorporation of the Company.

There appeared

Eos Products LLC, a limited liability company incorporated and organized under the laws of the State of New York,

United States of America, having its registered office at 19 W 44 

th

 St. # 811, New York, NY 10036-5902, United States

of America (the Sole Shareholder),

here represented by Mr Frank Stolz-Page, notary’s clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on December 22, 2014.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, represented as described above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty Euro (EUR 250.-) in order to bring

the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-), repre-
sented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share to twelve
thousand seven hundred fifty Euro (EUR 12,750.-), by way of the issue of two hundred fifty (250) new shares of the
Company, having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share, with such shares having the same rights and obligations as
the existing shares.

2. Subscription to and payment of the increase of the share capital as described in item 1. above by a contribution in

kind.

45327

L

U X E M B O U R G

3. Subsequent amendment to article six (6) of the Articles in order to reflect the changes adopted under item 1. above.
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative), each individually, to proceed in the
name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of
the Company.

5. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First Resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of two hundred fifty Euro

(EUR 250.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of twelve thousand five hundred
Euro (EUR 12,500.-), represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares having a par value of one Euro (EUR
1.-) per share to twelve thousand seven hundred fifty Euro (EUR 12,750.-), by way of the issue of two hundred fifty (250)
new shares of the Company, having a par value of one Euro (EUR 1.-) per share, with such shares having the same rights
and obligations as the existing shares.

<i>Second Resolution:

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the capital

increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder hereby declares that it subscribes to two hundred fifty (250) new shares of the Company having

a par value of one Euro (EUR 1.-) per share, and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting of two
hundred fifty (250) shares (the Shares) it holds in the share capital of eos Products GmbH, a private company with limited
liability (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) with seat in Berlin, registered with the commercial register of the Local
Court of Berlin under HRB 160929 B and business address in Platz der Einheit 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
(Eos Products GmbH), such Shares having an aggregate fair market value in an amount of two hundred fifty Euro (EUR
250.-).

The contribution in kind of the Shares from the Sole Shareholder to the Company in an amount of two hundred fifty

Euro (EUR 250.-) is to be allocated to the nominal share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Shares is evidenced to the undersigned notary by a certificate issued

on the date hereof by the management of the Sole Shareholder and acknowledged and approved by the management of
the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the Sole Shareholder is the legal and beneficial owner of the Shares;
- the Shares are fully paid-up and the Sole Shareholder is solely entitled to the Shares and possesses the power to

dispose of the Shares;

- based on generally accepted accounting principles, the fair market value of the Shares contributed to the Company

is, based on the attached balance sheet dated December 30, 2014 (the Balance Sheet), of at least two hundred fifty Euro
(EUR 250.-) and since the date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated
the contribution made to the Company;

- according to applicable law and the articles of association of Eos Products GmbH, the Shares contributed to the

Company are freely transferable by the Sole Shareholder to the Company;

- none of the Shares are encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on the Shares and none of the Shares are subject to any attachment;

- there exists no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that one or more of the Shares be transferred to him;

- all formalities required in Germany to transfer the legal and beneficial ownership of the Shares to the Company have

been or will be accomplished by the Sole Shareholder immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed
documenting the contribution of the Shares by the Sole Shareholder to the Company.

<i>Third resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article six (6) of the Articles

in order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. Share Capital. The subscribed share capital of the Company is set at twelve thousand seven hundred fifty Euro

(EUR 12,750.-), represented by twelve thousand seven hundred fifty (12,750) Shares, having a par value of one Euro (EUR
1.-) each.

The Company’s subscribed share capital may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting

in the manner required for the amendment to the Articles, as prescribed in article 11 below.”

45328

L

U X E M B O U R G

<i>Fourth Resolution:

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above

changes and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed in the name and on
behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the

day named at the beginning of this document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing party, who is known to the undersigned notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed
together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre,
par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) de l’associé unique de Eos Products S.à r.l., une société à res-

ponsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros
(EUR 12.500,-) et en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S.
Luxembourg) (la Société). La Société a été constituée le 19 décembre 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, non encore publié au Mémorial C, Recueil des So-
ciétés et Associations. Les statuts de la Société n’ont pas été modifiés depuis la date de constitution de la Société.

A comparu

Eos Products LLC, une société à responsabilité limitée (limited liability company) constituée et organisée selon les lois

de l’Etat de New York, Etats-Unis d’Amérique, ayant son siège social au 19 W 44 

th

 St.# 811, New York, NY 10036-5902,

Etats-Unis d’Amérique (l’Associé Unique),

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le 22 décembre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante ainsi que par le

notaire soussigné, restera annexée au présent acte notarié pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter ce qui suit:
I. Que l’Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-) afin de porter

le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), représenté par douze
mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) par part sociale à douze mille sept
cent cinquante Euros (EUR 12.750,-) par l’émission de deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales de la Société
ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes.

2. Souscription à et libération de l’augmentation du capital social telle que décrite au point 1. ci-dessus par un apport

en nature.

3. Modification subséquente de l’article six (6) des Statuts afin de refléter les modifications adoptées au point 1. ci-

dessus.

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun individuellement, afin de procéder au nom
et pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la
Société.

5. Divers.
III. Que l’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

45329

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux cent cinquante Euros (EUR

250,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-),
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) par part
sociale à douze mille sept cent cinquante Euros (EUR 12.750,-) par l’émission de deux cent cinquante (250) nouvelles
parts sociales de la Société ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes.

<i>Deuxième résolution:

L’Associé Unique décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante ainsi que la libération intégrale de l’aug-

mentation du capital comme suit:

<i>Souscription - Libération

L’Associé Unique déclare par la présente qu'il souscrit à deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales de la Société

ayant une valeur nominale d’un Euro (EUR 1,-) par part sociale, et libère intégralement ces parts sociales par un apport
en nature consistant en deux cent cinquante (250) parts sociales (les Parts Sociales) qu'il détient dans le capital social de
eos Products GmbH, une société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), ayant son siège à Berlin,
immatriculée au Registre Commerce de la cour locale de Berlin sous HRB 160929 B et ayant son siège social à Platz der
Einheit 1, 60327 Francfort sur le Main, Allemagne (Eos Products GmbH), ces Parts Sociales ayant une valeur marchande
totale de deux cent cinquante Euros (EUR 250,-).

L’apport en nature des Parts Sociales de l’Associé Unique à la Société d’un montant de deux cent cinquante Euros

(EUR 250,-) sera alloué au compte du capital social nominal de la Société.

L’évaluation de l’apport en nature des Parts Sociales est documentée au notaire soussigné par un certificat émis à la

date des présentes par la gérance de l’Associé Unique et pris en considération et approuvé par la gérance de la Société.
Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- l’Associé Unique est le propriétaire légal et économique des Parts Sociales;
- les Parts Sociales sont entièrement libérées et l’Associé Unique est le seul titulaire des Parts Sociales et possède le

droit d’en disposer;

- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la valeur marchande des Parts Sociales apportées à la

Société est, sur base du bilan en annexe daté du 30 décembre 2014 (le Bilan), d’au moins deux cent cinquante Euros (EUR
250,-) et depuis la date du Bilan, aucun changement substantiel n’est intervenu qui aurait pu déprécier l’apport fait à la
Société;

- conformément à la loi applicable et aux statuts de Eos Products GmbH, les Parts Sociales sont librement cessibles

par l’Associé Unique à la Société;

-  aucune  des  Parts  Sociales  n’est  grevée  d’aucun  nantissement  ou  usufruit,  il  n’existe  aucun  droit  d’acquérir  tout

nantissement ou usufruit sur les Parts Sociales et aucune des Parts Sociales n’est sujette à aucune saisie;

- il n’existe aucun droit de préemption ni aucun autre droit en vertu duquel une personne pourrait être autorisée à

demander qu'une ou plusieurs Parts Sociales lui soit cédée;

- toutes les formalités requises en Allemagne pour la cession de la propriété légale et économique des Parts Sociales

à la Société ont été ou seront accomplies par l’Associé Unique immédiatement suivant réception d’une copie certifiée de
l’acte notarié documentant l’apport des Parts Sociales par l’Associé Unique à la Société.

<i>Troisième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, l’Associé Unique décide de modifier l’article six (6) des Statuts afin de

refléter les modifications ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à douze mille sept cent cinquante Euros (EUR

12.750,-), représenté par douze mille sept cent cinquante (12.750) Parts Sociales ayant une valeur nominale d’un Euro
(EUR 1,-) chacune.

Le capital social souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution prise par l’Assemblée Générale

statuant de la manière requise en cas de modification des Statuts, dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessous.»

<i>Quatrième résolution:

L’Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, afin de procéder au nom et pour
le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

45330

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil et

demeure, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 janvier 2015. GAC/2015/269. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015034984/212.
(150039218) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Grove Holdings 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 120.674.

<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée statutaire des actionnaires tenue en date du 19 février 2015

La société à responsabilité limitée KPMG Luxembourg a été reconduite dans son mandat de réviseur d'entreprises

agréé chargée de l'audit des comptes de 2014.

Luxembourg, le 27 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Grove Holdings 2 S.A.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015034455/14.
(150038776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Dokumenta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1490 Luxembourg, 16, rue d'Epernay.

R.C.S. Luxembourg B 32.927.

Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den zwölften Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Versammelt sich die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Aktiengesellschaft DOKUMENTA S.A.,

mit Sitz in L-1490 Luxemburg, 16, rue d'Epernay, H.G.R. Luxemburg Nummer 32927, welche gegründet wurde gemäss
Urkunde aufgenommen durch den damals in Petingen residierenden Notar Georges d'HUART am 30. Dezember 1989,
veröffentlicht im Mémorial C Nummer 285 vom 18. August 1990, und deren Satzung abgeändert wurde gemäss Urkunde
aufgenommen durch:

- den vorgenannten Notar Georges d'HUART am 30. Dezember 1994, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 195

vom 2. Mai 1995, und

- den amtierenden Notar am 31. August 2012, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2585 vom 18. Oktober 2012.
Den Vorsitz der Versammlung führt Herr Bob PLEIN, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxem-

bourg.

Die Vorsitzende bestellt zum Sekretär und die Versammlung wählt zum Stimmzähler Herr Max MAYER, Angestellter,

berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg.

Die Vorsitzende gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden:
I.- Dass die vertretenen Aktionäre und die Zahl ihrer Aktien auf einer Anwesenheitsliste verzeichnet sind; diese An-

wesenheitsliste,  geprüft  und  „ne  varietur“  unterzeichnet  von  den  Mitgliedern  des  Büros  der  Versammlung  und  vom
amtierenden Notar, wird an dessen Amtssitz aufbewahrt werden.

Die Vollmachten der vertretenen Aktionäre, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch die erschienenen Parteien und

den Notar bleiben der gegenwärtigen Urkunde angeheftet, um mit derselben einregistriert zu werden.

II.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Vertretung sämtlicher Aktieninhaber rechtsmässig zusammen-

gesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschliessen kann.

III.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

45331

L

U X E M B O U R G

<i>Tagesordnung

1.- Komplett Neuformulierung der Satzung um diese in Einklang mit dem Gesetz über Handelsgesellschaften zu bringen.
2.- Verschiedenes.
Nach Diskussion fasst die Generalversammlung einstimmig und über jeden Punkt einzeln folgenden Beschluss:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst die Satzung komplett neuzuformulieren, um diese in Einklang mit dem Gesetz

über Handelsgesellschaften zu bringen, und ihnen folgenden Wortlaut zu geben:

„Titel I. - Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Unter der Bezeichnung “DOKUMENTA S.A.” wird hiermit eine Aktiengesellschaft gegründet.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Er darf durch Verwaltungsratsbeschluss an jeden anderen Ort innerhalb der Gemeinde verlegt werden.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse politischer oder wirtschaftlicher Natur eintreten oder bevorstehen, welche geei-

gnet wären, die normale Geschäftsabwicklung am Gesellschaftssitz oder den reibungslosen Verkehr zwischen diesem Sitz
und dem Ausland zu beeinträchtigen, so kann der Gesellschaftssitz vorübergehend bis zur endgültigen Wiederherstellung
normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden. Dieser Beschluss soll jedoch die luxemburgische Staatsangehörigkeit
nicht beeinflussen. Die Sitzverlegung soll Drittpersonen durch das Organ der Gesellschaft mitgeteilt werden, welches
unter den gegebenen Umständen hierzu am besten befähigt ist.

Art. 3. Die Dauer der Gesellschaft ist unbegrenzt.

Art. 4. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen der Dokumentation und Informationsverar-

beitung, sowie alle Tätigkeiten, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Die Gesellschaft kann außerdem alle anderen Operationen kommerzieller, industrieller, finanzieller, mobiliarer und

immobiliarer Art, welche sich direkt oder indirekt auf den Gesellschaftszweck beziehen oder denselben fördern, ausfüh-
ren.

Titel II. - Kapital, Aktien

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreissigtausendfünfhundert Euro (31.500,- EUR), eingeteilt in eintau-

sendzweihunderteinundfünfzig (1.251) Aktien ohne Bezeichnung des Nennwertes.

An  Stelle  von  Einzelaktien  können  Zertifikate  über  eine  Mehrzahl  von  Aktien  ausgestellt  werden,  nach  Wahl  der

Aktionäre.

Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre.
Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihre eigenen Aktien erwerben.
Das Gesellschaftskapital darf den gesetzlichen Bedingungen entsprechend erhöht oder reduziert werden.
Sofern und solange ein Gesellschafter alleiniger Inhaber aller Aktien ist, gilt die Gesellschaft als Einmannaktiengesell-

schaft im Sinne des Gesetzes vom 25. August 2006 über die europäische Gesellschaft (SE), die Aktiengesellschaft mit
Vorstand und Aufsichtsrat („société anonyme à directoire et conseil de surveillance“) und die Einmannaktiengesellschaft
(„société anonyme unipersonnelle“). Zählt die Gesellschaft nur eine Person, so wird diese als „Alleingesellschafter“ be-
zeichnet. Die Gesellschaft kann einen Alleingesellschafter bei ihrer Gründung oder als Folge der Vereinigung sämtlicher
Aktien in einer Hand haben. Das Ableben oder die Auflösung des Alleingesellschafters bewirkt nicht die Auflösung der
Gesellschaft.

Titel III. - Verwaltung

Art. 6. Die Gesellschaft wird verwaltet von einem Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern, Gesell-

schafter oder nicht, welche für eine Höchstdauer von sechs Jahren von der Generalversammlung der Aktionäre ernannt
werden und von ihr wieder abberufen werden können.

Besteht die Gesellschaft jedoch nur aus einem Alleingesellschafter oder wird anlässlich einer Generalversammlung der

Aktionäre festgestellt, dass sie nur noch einen Alleingesellschafter zählt, kann die Zusammensetzung des Verwaltungsrats
auf ein Mitglied beschränkt werden, welches als Alleinverwalter („administrateur unique“) bezeichnet wird, dies bis zur
nächsten auf die Feststellung der Existenz von mehr als einem Gesellschafter folgenden ordentlichen Generalversammlung.

Sie bestimmt die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder, ihre Amtszeit und ihre Vergütung.

Art. 7. Der Verwaltungsrat ernennt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden; in dessen Abwesenheit kann der

Vorsitz einer Veraltungsratssitzung einem Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

45332

L

U X E M B O U R G

Auf Antrag des Vorsitzenden kommt der Verwaltungsrat so oft zusammen, wie es das Interesse der Gesellschaft

erfordert. Er muss zusammenkommen, wenn zwei Verwaltungsratsmitglieder dies verlangen.

Der  Verwaltungsrat  ist  nur  beschlussfähig,  wenn  die  Mehrzahl  seiner  Mitglieder  anwesend  oder  vertreten  ist;  die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder per elek-
tronische Post erfolgen kann, ist gestattet.

In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm, Telekopie oder elektronische

Post erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Der Verwaltungsrat kann seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die diesbezügliche Ver-

tretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder andere
Bevollmächtigte übertragen; dieselben brauchen nicht Aktionäre zu sein.

Falls sich der Verwaltungsrat auf einen Alleinverwalter beschränkt, ist dieser Artikel nicht anwendbar.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Verwaltungs- und Veräusserungshandlungen im

Rahmen des Gesellschaftszweckes vorzunehmen. Alles was nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die gegenwärtige
Satzung der Generalversammlung der Aktionäre vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, unter den gesetzlichen Bedingungen Vorschüsse auf Dividenden auszuzahlen.

Art. 9. Die Gesellschaft wird durch die Kollektivunterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder durch die

Einzelunterschrift  des  delegierten  Verwaltungsratsmitgliedes  oder  durch  die  Einzelunterschrift  des  Alleinverwalters
rechtsgültig verpflichtet, unter der Bedingung, dass spezielle Beschlüsse vorliegen über die Unterschriftsberechtigung im
Falle  der  Befugnisübertragung  oder  Vollmachterteilung  durch  den  Verwaltungsrat  im  Rahmen  des  Artikels  10  dieser
Satzung.

Art. 10. Der Verwaltungsrat darf seine Befugnisse zur Führung der täglichen Geschäftsführung einem oder mehreren

Verwaltungsratsmitgliedern, welche delegierte Verwaltungsratsmitglieder genannt werden, übertragen.

Er darf ebenfalls die Führung der Gesellschaft oder einer Einzelabteilung einem oder mehreren Direktoren übertragen

und Spezialvollmachten für bestimmte Angelegenheiten einem oder mehreren Bevollmächtigen erteilen; dieselben brau-
chen nicht Aktionäre zu sein.

Art. 11. Streitfälle, an denen die Gesellschaft als Kläger oder Beklagter beteiligt ist, werden im Namen der Gesellschaft

vom Verwaltungsrat abgewickelt, welcher durch seinen Vorsitzenden oder durch das speziell für diesen Zweck bestimmte
Verwaltungsratsmitglied vertreten wird.

Titel IV. - Aufsicht

Art. 12. Die Aufsicht der Gesellschaft obliegt einem oder mehreren Kommissaren, welche die Generalversammlung

der Aktionäre ernennt. Die Generalversammlung bestimmt außerdem ihre Zahl und ihre Vergütung sowie ihre Amtszeit,
welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Titel V. - Generalversammlung

Art. 13. Die jährliche Generalversammlung findet rechtens statt am zweiten Dienstag des Monats November um 11.00

Uhr, am Gesellschaftssitz oder an einem anderen, in der Einberufung angegebenen Ort.

Sofern dieser Tag ein Feiertag ist, findet die Generalversammlung am ersten darauffolgenden Werktag statt.
Sofern die Gesellschaft einen Alleingesellschafter zählt, übt dieser die der Generalversammlung der Aktionäre zufal-

lenden Befugnisse aus.

Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinnverteilung

Art. 14. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Juli und endet am 30. Juni des folgenden Jahres.

Art. 15. Der positive Saldo der Gewinn- und Verlustrechnung nach Abzug der allgemeinen Unkosten und der Abs-

chreibungen bildet den Reingewinn der Gesellschaft. Jedes Jahr werden fünf Prozent des Reingewinns vorweggenommen
und der gesetzlichen Rücklage zugeführt. Diese Vorwegnahmen und Zuführungen sind nicht mehr zwingend vorgeschrie-
ben, wenn die Rücklage zehn Prozent des Kapitals erreicht hat, müssen jedoch wieder einsetzen bis zu seiner vollständigen
Wiederherstellung, wenn der Rücklagefonds zu einem gegeben Zeitpunkt aus welchem Grund auch immer in Anspruch
genommen worden ist.

Der Saldo steht zur freien Verfügung der Generalversammlung.

Titel VII. - Auflösung, Liquidation

Art. 16. Die Gesellschaft kann durch einen Generalversammlungsbeschluss der Aktionäre aufgelöst werden. Ein oder

mehrere Liquidatoren, natürliche oder juristische Personen, ernannt von der Generalversammlung der Aktionäre, welche
ihre Befugnisse und Vergütungen bestimmt, führen die Liquidation durch.

45333

L

U X E M B O U R G

Titel VIII. - Allgemeine Bestimmungen

Art. 17. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, einschließlich der

Änderungsgesetze, finden ihre Anwendung überall wo gegenwärtige Satzung keine Abweichung beinhaltet.“

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren, welche der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anerfallen, werden auf neunhundert

Euro abgeschätzt.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Herr Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.

WORÜBER Protokoll, aufgenommen in Junglinster, Im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten zusammen mit dem instrumentierenden Notar das vor-

liegende Protokoll unterschrieben.

Gezeichnet: Bob PLEIN, Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 17 février 2015. Relation GRE/2014/1321. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015034976/148.
(150039504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

Creation Julia S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1313 Luxembourg, 2A, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 148.665.

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunzehnten Tag des Monats Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar, Maître Edouard DELOSCH, mit Amtswohnsitz in Diekirch.

Sind erschienen:

1.- Herr Hans Theodor RÖHL, Rentner, geboren am 24. Januar 1936 in Duisburg (Deutschland), wohnhaft in D-54531

Manderscheid, 44, Kurfürstenstrasse.

2.- Herr Michael Hans RÖHL, Kaufmann, geboren am 7. August 1966 in Erlenbach/Main (Deutschland), wohnhaft in

D-48151 Münster (Deutschland), Goebenstrasse, 33, hier vertreten durch Herrn Hermann-Josef LENZ, Geschäftsmann,
geschäftlich wohnhaft in L-6450 Echternach, 21, Route de Luxembourg,

auf Grund einer ihm erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht, vom Bevollmächtigten und dem ins-

trumentierenden Notar ne varietur unterschrieben, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigebogen um mit derselben zur
Einregistrierung zu gelangen.

Welche Erschienenen, anwesend oder vertreten wie hiervor erwähnt, den instrumentierenden Notar ersuchen, fol-

gendes zu beurkunden:

I.- Die Erschienenen, vorbenannt, sind die einzigen Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Creation

Julia S.à r.l. ", mit Sitz in L-1313 Luxembourg, 2A, Rue des Capucins, eingetragen im Handels-und Gesellschaftsregister
von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 148.665 (die "Gesellschaft"), gegründet gemäß Urkunde aufgenommen
durch Notar Fernand UNSEN, mit dem damaligen Amtssitz in Diekirch, am 1. Oktober 2009, veröffentlicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2155 von 4. November 2009, ist. Die Satzung der Gesellschaft wurde
noch nicht abgeändert (hiernach „die Gesellschaft“).

II. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100) Ge-

schäftsanteile von jeweils einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125,-), welche den vorgenannten Gesellschaftern wie folgt
zugeteilt worden sind:

1.- Herr Michael Hans RÖHL, vorgenannt, neunundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

2.- Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

Total: EINHUNDERT Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Somit ist das gesamte Kapital hier vertreten.
III.- In ihrer Eigenschaft als Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen dem instrumentierenden Notar,

sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:

<i>Tagesordnung

1. Anteilsübertragungen von neunundvierzig (49) Anteilen von Herr Michael Hans RÖHL, vorgenannt, an Herr Karl-

Heinz HAMANNT;

2. Anteilsübertragungen von zwei (2) Anteilen von Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, an Herr Karl-Heinz HA-

MANNT;

3. Anteilsübertragungen von vierundzwanzig (24) Anteilen von Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, an Herr Ewald

SCHMITZ;

45334

L

U X E M B O U R G

4. Änderung des Gesellschaftszwecks der Gesellschaft und dementsprechende Neufassung des Artikels 2 der Satzung

der Gesellschaft, welcher ab sofort wie folgt lautet:

Art. 2. „Gegenstand der Gesellschaft ist der Groß- und Einzelhandel von Waren aller Art, insbesondere Schmuckwaren.
Die Gesellschaft kann des weiteren Internethandel mit Schmuck betreiben.
Desweiteren hat die Gesellschaft als Gegenstand die Ausführung der Reparatur von Schmuck und Uhren.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, handwerkliche, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf be-

wegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig
oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“

5. Streichung der Zeichnung der Gesellschaftanteile aus der Satzung der Gesellschaft und dementsprechend Artikel 6

der Satzung der Gesellschaft abzuändern;

6. Abänderung der Unterschriftsvollmacht der Gesellschaft in Artikel 12 der Satzung der Gesellschaft, welche rechts-

gültig durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder durch die gemeinsame Unterschriften von zwei
Geschäftsführern vertreten wird;

7. Amtsniederlegung von Herr Michael Hans RÖHL als administrativer Geschäftsführer und spezielle Wahl der Freis-

tellung;

8. Ernennung von Herr Karl-Heinz HAMANNT als Geschäftsführer;
9. Bestätigung und Ernennung vom Herr Hans Theodor RÖHL als Geschäftsführer;
10. Sonstiges.
III. Alsdann ersuchen die Gesellschafter den amtierenden Notar nachfolgende Beschlüsse, zu beurkunden, wie folgt:

<i>Erster Beschluss

Herr Michael Hans RÖHL, vorgenannt, vertreten wie hiervor erwähnt, überträgt und überlässt hiermit neunundvierzig

(49) ihm gehörende Anteile der Gesellschaft "Creation Julia S.à r.l." an Herrn Karl-Heinz HAMANNT, Kaufmann, geboren
am 25. August 1954 in Manderscheid (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Manderscheid, 18, Friedrichstrasse, für den
Preis von sechs tausend einhundert fünfundzwanzig Euro (EUR 6.125,-).

Herr Michael Hans RÖHL, vorgenannt, vertreten wie hiervor erwähnt, erklärt vor Unterschrift gegenwärtiger Urkunde

und ohne Beisein des Notars von Herrn Karl-Heinz HAMANNT den Betrag von sechs tausend einhundert fünfundzwanzig
Euro (EUR 6.125,-) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung, Titel und Entlastung.

Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran

verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

<i>Zweiter Beschluss

Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit zwei (2) ihm gehörende Anteile der Gesell-

schaft "Creation Julia S.à r.l." an Herrn Karl-Heinz HAMANNT, Kaufmann, geboren am 25 August 1954 in Manderscheid
(Deutschland), wohnhaft in D-54531 Manderscheid, 18, Friedrichstrasse, für den Preis von zweihundert fünfzig Euro (EUR
250,-).

Herr Hans Theodor RÖHL erklärt vor Unterschrift gegenwärtiger Urkunde und ohne Beisein des Notars von Herrn

Karl-Heinz HAMANNT den Betrag von zweihundert fünfzig Euro (EUR 250,-) erhalten zu haben, worüber hiermit Quit-
tung, Titel und Entlastung.

Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.
Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran

verbundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.

<i>Dritter Beschluss

Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, überträgt und überlässt hiermit vierundzwanzig (24) ihm gehörende Anteile

der Gesellschaft "Creation Julia S.à r.l." an Herrn Ewald SCHMITZ, Kaufmann, geboren am 15. November 1949 in Pan-
tenburg (Deutschland), wohnhaft in D-54531 Manderscheid, 44, Kurfürstenstrasse, für den Preis von drei tausend Euro
(EUR 3.000,-).

Herr Hans Theodor RÖHL erklärt vor Unterschrift gegenwärtiger Urkunde und ohne Beisein des Notars von Herrn

Ewald SCHMITZ den Betrag von drei tausend Euro (EUR 3.000,-) erhalten zu haben, worüber hiermit Quittung, Titel
und Entlastung.

Herr Ewald SCHMITZ, vorgenannt, erklärt die vorhergehende Anteilübertragung anzunehmen.

45335

L

U X E M B O U R G

Herr Ewald SCHMITZ, vorgenannt, ist von heute an Eigentümer der ihm übertragenen Anteile mit allen daran ver-

bundenen Rechten und Pflichten.

Er erklärt eine genaue Kenntnis sowohl der Statuten als auch der finanziellen Lage der Gesellschaft zu haben.
Aufgrund dieser vorangegangenen Anteilübertragungen, sind die Anteile der Gesellschaft somit wie folgt aufgeteilt:

1.- Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, fünfundzwanzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

2.- Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, einundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

3. - Herr Ewald SCHMITZ, vorgenannt, Vierundzwanzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Total: EINHUNDERT Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafter haben beschlossen, den Gesellschaftszweck der Gesellschaft zu erweitern und dementsprechend

den Artikel 2 der Satzung der Gesellschaft wie folgt zu ändern:

Art. 2. „Gegenstand der Gesellschaft ist der Groß- und Einzelhandel von Waren aller Art, insbesondere Schmuckwaren.
Die Gesellschaft kann des weiteren Internethandel mit Schmuck betreiben.
Desweiteren hat die Gesellschaft als Gegenstand die Ausführung der Reparatur von Schmuck und Uhren.
Im Rahmen ihrer Tätigkeit kann die Gesellschaft in Hypothekeneintragungen einwilligen, Darlehen aufnehmen, mit oder

ohne Garantie, und für andere Personen oder Gesellschaften Bürgschaften leisten, unter Vorbehalt der diesbezüglichen
gesetzlichen Bestimmungen.

Sie kann im Übrigen alle kaufmännischen, handwerkliche, industriellen und finanziellen Handlungen in Bezug auf be-

wegliche und unbewegliche Güter vollziehen, die für die Verwirklichung des Gegenstandes der Gesellschaft notwendig
oder auch nur nützlich sind oder welche die Entwicklung der Gesellschaft erleichtern können.“

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Zeichnung der Gesellschaftsanteile aus der Satzung der Gesellschaft herauszuneh-

men und demgemäß Artikel 6 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 6. „Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-), aufgeteilt in einhundert (100)

Anteile von je einhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 125.-), welche integral gezeichnet und voll eingezahlt wurden.“.

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen die Unterschriftsvollmacht der Gesellschaft abzuändern, welche in unter allen Ums-

tänden  verpflichtet  wird  durch  die  alleinige  Unterschrift  des  einzigen  Geschäftsführers  oder  durch  die  gemeinsame
Unterschriften von zwei Geschäftsführern.

Demgemäß beschließen die Gesellschafter Artikel 12 der Satzung wie folgt abzuändern:

Art. 12. „Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, welche nicht Gesellschafter sein müssen und

welche von der Gesellschaftsversammlung ernannt werden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.“

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die Amtsniederlegung von Herr Michael Hans RÖHL, administrativer Geschäftsführer

der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung anzuerkennen und ihm vollständige Entlastung (quitus) für die Ausübung seiner
Pflichten vom Datum seiner Ernennung bis zu diesem Datum zu gewähren.

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die folgende Person für einen unbestimmten Zeitraum als Geschäftsführer der Ge-

sellschaft zu ernennen:

Herr Karl-Heinz HAMANNT, Kaufmann, geboren am 25 August 1954 in Manderscheid (Deutschland), wohnhaft in

D-54531 Manderscheid, 18, Friedrichstrasse.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Geschäftsführern gebunden.

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, die folgende Person für einen unbestimmten Zeitraum als Geschäftsführer der Ge-

sellschaft zu bestätigen und zu ernennen:

Herr Hans Theodor RÖHL, Rentner, geboren am 24. Januar 1936 in Duisburg (Deutschland), wohnhaft in D-54531

Manderscheid, 44, Kurfürstenstrasse Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die gemeinsame Unterschrift von
zwei Geschäftsführern gebunden

45336

L

U X E M B O U R G

Herr Hans Theodor RÖHL, vorgenannt, und Herr Karl-Heinz HAMANNT, vorgenannt, handelnd in ihrer Eigenschaft

als Geschäftsführer der Gesellschaft "Creation Julia S.à r.l.", erklären im Namen der Gesellschaft diese Abtretungen von
Gesellschaftsanteilen anzunehmen, mit Freistellung von der in Artikel 1690 des Zivilgesetzbuches vorgesehenen Zustel-
lung.

<i>Kostenabschätzung

Die der Gesellschaft aus Anlass vorliegender Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf unge-

fähr eintausendvierhundert Euro (EUR 1.400,-) geschätzt.

Worüber Urkunde, geschehen und aufgenommen in Diekirch, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem

Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: H. T. RÖHL, H.-J. LENZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 20 février 2015. Relation: DAC/2015/3038. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015034317/163.
(150038433) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Groupe Leonard de Vinci International, Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 105.833.

<i>Extrait des résolutions de l'actionnaire unique prises en date du 5 mars 2014 et du 4 février 2015

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'actionnaire unique en date du 5 mars 2014:
1- Le mandat de l'administrateur Ensof Services S.à r.l. viendra à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra en 2020 pour approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019 avec effet au 5 mars 2014.

2- Monsieur Antoine Lam-Chok, né le 21 août 1965 à Port-Louis, Ile Maurice, ayant son adresse professionnelle au

6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, a été nommé représentant permanent de Ensof Services S.à r.l., avec effet
au 5 mars 2014. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2020 pour
approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'actionnaire unique en date du 4 février 2015:
3- Monsieur Adrian Braimer Jones, né le 16 septembre 1965 à Nairobi, Kenya, ayant son adresse professionnelle au

49, Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Royaume-Uni, a été nommé administrateur de la Société, avec effet au 4 février
2015;

4- Elah External Management Services Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au

Road Town, Palm Grove House, 4 

th

 Floor, P.O. Box 438, VG1110 Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès

du Companies Register sous le numéro 1719028, a été nommé administrateur de la Société, avec effet au 4 février 2015;

Monsieur Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Lièges, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 6A, route de

Trèves, L-2633 Senningerberg, a été nommé représentant permanent de Elah External Management Services Ltd, avec
effet au 4 février 2015.

Le mandat des nouveaux administrateurs viendra à échéance lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra

en 2020 pour approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.

5- KPMG Audit, une société dont le siège social est situé au 31 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg, immatriculée au

Registre du Commerce et des Sociétés, sous le numéro B 103590, a été nommé en tant que réviseur d'entreprises agréé
de la Société avec effet au 25 mai 2009. Il est noté que suite à plusieurs fusions, KPMG Luxembourg, une société en
coopérative, dont le siège est situé au 39, boulevard Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés, sous le numéro B 149133, ayant repris tous les droits et obligations de KMPG Audit, est devenu
le réviseur d'entreprises agréé de la Société.

6- Le mandat de KPMG Luxembourg, réviseur d'entreprises agréé de la Société a été prorogé jusqu'à l'assemblée

générale de la Société d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2014, devant se tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033694/38.
(150037463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

45337

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.835,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.474.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in

Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares and four hundred seventeen

(417) series A shares,

here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungbeschränkt))

incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) common share,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given;
3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstra.e
14b, 80801 Munich, Germany (hereinafter “Holtzbrinck”),

being the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A shares;
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given; and
4. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with

the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address at Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),

becoming the holder of eight hundred thirty-four (834) series A2 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1.,2. and 3. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XXX S.à r.l.

(the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.474 and incorporated pursuant
to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, on 18 June 2014, published in the Mémorial C,
Recueil  des  Sociétés  et  Associations  number  2514  dated  17  September  2014.  The  articles  of  association  have  been
amended pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, prenamed, dated 7 November 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Eiffel parti-
cipates and votes for the purpose of Agenda point 5 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have three (3) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”), series A shares (hereinafter “Series A Shares”) and series
A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”).

2. Conversion of the existing two thousand five hundred one (2,501) Series A Shares, with a nominal value of one euro

(EUR 1.00) each, into two thousand five hundred one (2,501) Series A1 Shares, with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each, without cancellation of shares.

3. Acceptance of Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands,

registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address
at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands, as new shareholder of the Company.

45338

L

U X E M B O U R G

4. Increase of the Company’s share capital by an amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834) so as to raise

it from its current amount of fifteen thousand one euros (EUR 15,001) up to fifteen thousand eight hundred thirty-five
euros (EUR 15,835) by issuing eight hundred thirty-four (834) Series A2 Shares with a nominal value of one euro (EUR
1.00) each.

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand eight hundred thirty-five euros (EUR 15,835.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares” and jointly with the Series A1

Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XXX S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-

45339

L

U X E M B O U R G

traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand eight hundred thirty-five euros (EUR 15,835.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares” and jointly with the Series A1

Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

("Rocket"), HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG ("Holtzbrinck"), and Netris B.V. (“Eiffel”, jointly with
Rocket and Holtzbrinck the "Investors" and each also an "Investor") to a company affiliated to such Investor within the
meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a calloption under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation
procedure.

45340

L

U X E M B O U R G

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.

45341

L

U X E M B O U R G

11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings.
Unless mandatory law prescribes another form, they can also be passed outside meetings in writing (including email

or fax) or telephone voting if such procedure is requested by a shareholder and no other shareholder declares its dissent
with the procedure within two (2) weeks towards the board of managers of the Company in written form. If no dissent
is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing sentence the votes of the shareholders which are not
participating in the voting shall be deemed to be abstention from voting. Written resolutions must be signed by each
shareholder and the written record must be sent to each shareholder without undue delay. Resolutions not passed in
writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has declaratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.

45342

L

U X E M B O U R G

16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

45343

L

U X E M B O U R G

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the advisory board for the legal transactions and measures specified

below in accordance with Articles 24.5, provided that at any time two (2) or more voting members have been appointed
to the advisory board in addition to the voting members nominated by Rocket, it includes the affirmative vote of at least
one voting member other than the voting members appointed by Rocket. No consent is required if such legal transactions
and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of
the advisory board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm’s length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders’ agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the advisory board. The advisory board may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

45344

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders may by

way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of the advisory board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a unanimous

shareholders’ consent.

24.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by Rocket in its sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the advisory board shall be nominated by Holtzbrinck in its sole discretion.
24.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
24.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

24.6 In addition to any consent or approvals otherwise required under these articles of association and/or any share-

holders’ agreement with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not
interfere in the management of the Company.

24.7 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit And Supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twentyfive (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

45345

L

U X E M B O U R G

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Messrs. Julien

De Mayer and Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders
register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have three (3) classes of shares, divided into Common Shares, Series A Shares and Series A2 Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to convert the existing two thousand five hundred one (2,501) Series A

Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, into two thousand five hundred one (2,501) Series A1 Shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, without cancellation of shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders accepts Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under

the  laws  of  the  Netherlands,  registered  with  the  commercial  register  of  the  Dutch  Trade  Register,  under  number
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands, as new shareholder
of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of eight hundred

thirty-four euros (EUR 834) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand one euros (EUR 15,001) up to

45346

L

U X E M B O U R G

fifteen thousand eight hundred thirty-five euros (EUR 15,835) by issuing eight hundred thirty-four (834) Series A2 Shares
with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

Eight hundred thirty-four (834) Series A2 Shares have been duly subscribed by Eiffel, aforementioned, for the price of

eight hundred thirtyfour euros (EUR 834).

<i>Payment

The eight hundred thirty-four (834) Series A2 Shares subscribed by Eiffel, aforementioned, have been entirely paid up

through a contribution in cash in an amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834).

The amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834.-) is as now available to the Company as has been proved

to the undersigned notary.

The contribution in the amount of eight hundred thirty-four euros (EUR 834) is entirely allocated to the share capital.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that Eiffel has now become the holder of eight hundred thirty-four

(834) Series A2 Shares.

As a consequence Eiffel, aforementioned, entitled to vote and here represented by Kristof De Wael, Lawyer, profes-

sionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxy, joins the general meeting of shareholders for the
purpose of the following resolutions.

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5 Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand eight hundred thirty-five euros (EUR 15,835.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one euro (EUR 1.00) each,

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) with a nominal value

of one euro (EUR 1.00) each, and

5.1.3 eight hundred thirty-four (834) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares” and together with the Series A1

Shares hereinafter referred to as the “Series A Shares”) with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Sixth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Messrs. Julien De Mayer and Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely,
the shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,000.-.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtzehnten Dezember.

45347

L

U X E M B O U R G

Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

Sind erschienen:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen und vierhundertsiebzehn (417) Anteilen

der Serie A,

hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihm ausgestellten Voll-

macht;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-

stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Stammanteils,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihm ausgestellten Voll-

macht;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstra.e 14b, 80801, München, Deutschland („Holtzbrinck“),

Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihm ausgestellten Voll-

macht; und

4. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-

register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),

zukünftiger Inhaber von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer ihm ausgestellten Voll-

macht.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1., 2. und 3. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services Holding

XXX S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.474, gegründet am 18. Juni 2014
gemäß  einer  Urkunde  des  Notars  Carlo  Wersandt,  mit  Amtssitz  in  Luxemburg,  welche  am  17.  September  2014  im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2514, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft
wurde zuletzt am 7. November 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, vorbenannt geändert, welche
noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet.

Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende Tages-

ordnung verhandeln, wobei Eiffel ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr drei (3) An-

teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile der Serie A (die „Anteile der Serie A“) und Anteile
der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“).

2. Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteile der Serie

A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) in zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteile der Serie A1 mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

3. Aufnahme von Netris B.V., einer Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, einge-

tragen  im  Handelsregister  des  Dutch  Trade  Register  unter  der  Nummer  60628022,  mit  Geschäftssitz  in  Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von fünfzehntausendeins Euro

(EUR 15.001) um einen Betrag von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) auf einen Betrag von fünfzehntausendach-
thundertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835) durch die Ausgabe von achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie
A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

45348

L

U X E M B O U R G

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendachthundertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835,00),

bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services Holding XXX S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

45349

L

U X E M B O U R G

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendachthundertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835,00),

bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“), HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG („Holtzbrinck“) und Netris B.V.
(„Eiffel“, gemeinschaftlich mit Rocket und Holtzbrinck die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit
einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

45350

L

U X E M B O U R G

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

45351

L

U X E M B O U R G

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11 Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist

45352

L

U X E M B O U R G

dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17 Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2 Für den Fall, dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

45353

L

U X E M B O U R G

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen im Einklang mit Artikel 24.5 sofern, wenn zu einem Zeitpunkt zwei (2) oder mehr stimmberechtigte Mitglieder
des Beirats zusätzlich zu den von Rocket ernannten stimmberechtigten Mitgliedern ernannt wurden, diese die Ja-Stimme
mindestens eines stimmberechtigten Mitglieds beinhaltet, bei welchem es sich nicht um die von Rocket ernannten stimm-
berechtigten Mitglieder handelt. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß

45354

L

U X E M B O U R G

§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen
den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter

können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats er-
höhen oder herabsetzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von Rocket nach eigenem Ermessen ernannt; und 24.3.2

ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen ernannt.

24.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder des Beirats als Beobachter haben.
24.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher Mehrheit
der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

45355

L

U X E M B O U R G

24.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

24.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

45356

L

U X E M B O U R G

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie die

Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr

drei (3) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile, Anteile der Serie A und Anteile der Serie A2.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteile der Serie A

mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) ohne Einziehung von Anteilen in zweitausendfünfhunderteins
(2.501) Anteile der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht

der  Niederlande,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Dutch  Trade  Register  unter  der  Nummer  60628022,  mit  Ge-
schäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

fünfzehntausendeins Euro (EUR 15.001) um einen Betrag von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) auf einen Betrag
von fünfzehntausendachthundertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835) durch die Ausgabe von achthundertvierunddreißig
(834) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Achthundertvierunddreißig (834) Anteile der Serie A2 wurden ordnungsgemäß von Eiffel, vorbenannt, zu einem Preis

von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Eiffel, vorbenannt, gezeichneten achthundertvierunddreißig (834) Anteile der Serie A2 wurden vollständig

eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834).

Die Summe von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung so wie es

dem amtierenden Notar erbracht wurde.

Die Einlage in Höhe von achthundertvierunddreißig Euro (EUR 834) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zuge-

führt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Eiffel nun der Inhaber von achthundertvierunddreißig (834)

Anteilen der Serie A2 geworden ist.

Demzufolge schließt sich Eiffel, vorbenannt, stimmberechtigt und hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, ge-

schäftsansässig  in  Luxemburg,  gemäß  der  vorbenannten  Vollmacht,  der  Gesellschafterversammlung  für  die  folgenden
Beschlüsse an.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendachthundertfünfunddreißig Euro (EUR 15.835,00),

bestehend aus

45357

L

U X E M B O U R G

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00),

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1,00), und

5.1.3 achthundertvierunddreißig (834) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“, gemeinsam mit den Anteilen

der Serie A1 die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  sowie  die  Herren  Julien  De  Mayer  und  Rüdiger  Trox  dazu  zu  ermächtigen,  das  Anteilsinhaberregister  der
Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen und geschlossen in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: K. DE WAEL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63714. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 13. Februar 2015.

Référence de publication: 2015033603/1139.
(150037371) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Brissond Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 44, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 127.195.

<i>Extrait de la décision prise lors du Conseil d'administration du 10 février 2015

L'administrateur unique décide, conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les Sociétés

Commerciales telle qu'adoptée par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, de
désigner en qualité de dépositaire agréé:

La société FIDUCIA GENERAL SERVICES, S.à.r.l., dont le siège social est sis 44, rue de la Vallée, L-2661, Luxembourg,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 117 940.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 2 mars 2015.

Référence de publication: 2015034891/16.
(150039445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.

45358

L

U X E M B O U R G

Setas International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 23.519.

L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “SETAS INTERNATIONAL SPF. ”, une société

anonyme, qualifiée comme société de gestion de patrimoine familial, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
établie et ayant son siège social à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 23519, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par Maître Emile
SCHLESSER, alors notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 8 novembre 1985,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 382 du 23 décembre 1985,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés:
- suivant acte reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, alors de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 29 décembre 1986, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 108 du 23
avril 1987;

- suivant résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 17 décembre

2001, contenant la conversion de la devise d'expression du capital social en euros, l'extrait afférent ayant été publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1092 du 17 juillet 2002; et

- suivant acte reçu par ledit notaire Emile SCHLESSER, de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

en date du 18 novembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 55 du 11 janvier 2011,
contenant notamment la transformation de la Société en une société de gestion de patrimoine familial (“SPF”) ainsi que
l'adoption par la Société de sa dénomination actuelle.

L'Assemblée  est  présidée  par  Madame  Laurence  MOSTADE,  employée,  demeurant  professionnellement  à  L-2086

Luxembourg, 412F, route d'Esch.

La Présidente désigne Madame Béatrice KSAISS-NOUSSE, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Lu-

xembourg, 412F, route d'Esch, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Madame Ariane VIGNERON, employée, demeurant professionnellement à L-2086 Luxembourg,

412F, route d'Esch, comme scrutatrice.

Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Modification de l'article 5 pour lui donner la teneur suivante:
“Le capital social est fixé à EUR 530.000,- (cinq cent trente mille euros) représenté par 12.500 (douze mille cinq cents)

actions de catégorie A et 199.255 (cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent cinquante-cinq actions de catégorie B, ces
dernières rachetables selon les dispositions de l'article 49-8 de la loi sur les sociétés commerciales. Les actions des deux
catégories sont sans désignation de valeur nominale et jouissent toutes des mêmes droits et avantages. Le capital social
peut être augmenté comme il est dit à l'article six.

Les actions sont au porteur ou nominatives selon le choix de l'actionnaire.
Les actions ont été entièrement libérées.”
2. Suppression du capital autorisé et adaptation de l'article 6.
3. Ajout des paragraphes suivants à l'article 11 des statuts:
“Tout administrateur peut se faire représenter en désignant par écrit ou par télégramme, télécopie ou e-mail un autre

administrateur comme son mandataire.

Tout administrateur peut prendre part à une réunion du Conseil d'Administration ou moyen d'une conférence télé-

phonique,  d'une  conférence  vidéo  ou  d'un  équipement  de  communication  similaire  par  lequel  toutes  les  personnes
participant à la réunion peuvent s'entendre; la participation à la réunion par de tels moyens vaut présence personnelle à
cette réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par

voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres
du Conseil d'Administration sans exception. La date d'une telle décision est celle de la dernière signature.”

4. Divers.

45359

L

U X E M B O U R G

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du

bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de lui donner la teneur comme ci-avant reproduite sous le

point 1) de l'ordre du jour.

<i>Deuxième résolution

Etant donné que l'autorisation, donnée au conseil d'administration d'augmenter le capital social dans le cadre du capital

autorisé, est venue à échéance, l'Assemblée décide de modifier l'article 6 des Statuts en supprimer de façon pure et simple
les alinéas 2 à 5 dudit article.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 11 des Statuts en y ajoutant in fine les paragraphes repris ci-avant sous le point

3) de l'ordre du jour.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente

a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent quarante euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdites

comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: L. MOSTADE, B. KSAISS-NOUSSE, A. VIGNERON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 février 2015. 2LAC/2015/3683. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015034703/91.
(150038183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Watchmoor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 177.654.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 26 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec avec effet du 31 janvier 2015
De nommer M. Paul Lawrence, né le 25 mai 1970 à Rotherham, (Royaume-Uni) ayant sa résidence professionnelle au

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 31 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Watchmoor Sàrl

Référence de publication: 2015034777/14.
(150038729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

45360


Document Outline

Brissond Investissements S.A.

Creation Julia S.à.r.l.

Damina S.A. S.P.F.

Dekra Automobil GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Digital Services XXX S.à r.l.

Dokumenta S.A.

Drive for Life

EFA Promo S.à.r.l.

Eos Products S.à.r.l.

European DSBK Holding S.à r.l.

European Property Services S.à r.l.

Fontainbleu S.A.

Groupe Leonard de Vinci International

Grove Holdings 2 S.A.

Hansteen Hannover S.à r.l.

IFS Capital Luxemburg II S.A.

Jezioro S.A.

Laccolith S.A.

Le Bistrot Gourmand S.à r.l.

Lombard Odier Funds

Lone Star Capital Investments S.à r.l.

LSREF3 Tiger Luxembourg S.à r.l.

Lux.G.L. S.A.

Lyrics Holding S.à r.l.

Mainpoint Invest S.A.

Malintra Holdings S.A.

Marzilux S.A.

Maximilian Centre

Mayfair Estates S.A., SPF

MCT Berlin Vier S.A.

Megapolis S.à r.l.

Methanex Luxembourg S.à r.l.

Neopolis Sàrl

Nucleus Management S.A.

Ocean Oil Construction and Services

OCM Starfish Debtco S.à r.l.

PK201 SA

Popken International G.m.b.H. &amp; Co

SAE S.à r.l.

Secufund S.A.

Sem International S.A.

Setas International SPF S.A.

Watchmoor S.à r.l.