This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 931
7 avril 2015
SOMMAIRE
Adler Toy Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
44687
ADM28 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44681
Afilor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44670
Afod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44670
Afod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44670
Apollinaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44679
Arnica Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44670
Arrena S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44669
ASSA ABLOY Branding S.à r.l. . . . . . . . . . .
44669
ASSA ABLOY Treasury S.à r.l. . . . . . . . . . .
44669
Atlas European Holdco I S.à.r.l. . . . . . . . . .
44669
Aureus IP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44670
Avenir Telecom International S.A. . . . . . .
44671
Avrim S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44671
Axus Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44671
AZIGEP Société de Participations Finan-
cières S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44672
Belair Lotissements S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44676
Belfond (Luxembourg) Sàrl . . . . . . . . . . . . .
44676
Benodec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44676
BlueBay Funds Management Company
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44672
Blue Flag SC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44674
BlueSPHERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44672
Bmax Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44672
Braincare International S.A. . . . . . . . . . . . .
44676
C&A Europe (Luxembourg) Scs . . . . . . . . .
44677
Carraig Beag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44677
Carraig Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
44678
Carraig Mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44678
Caymus Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
44679
Communauté d'Exploitation Agricole So-
ludi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44688
C.R.S.M. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44677
C.R.S.M. Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44677
Damovo Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
44668
Digital Services XXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
44666
Digital Services XXV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
44642
E.RE.A.S. Management S.à r.l. . . . . . . . . . . .
44688
European Meridien S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
44667
Evertrans S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44683
Fassaden-Rainbow-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
44667
Fassades-Rainbow-Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . .
44667
FG Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44681
Financière Viking S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44668
Finexis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44668
Finitech S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44683
Onixea Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44679
44641
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.486.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of January.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of six thousand two hundred fifty (6,250) shares and becoming the holder of six thousand two hundred
fifty (6,250) Series A1 Shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany,
on 12 January 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 January 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of three thousand one hundred twenty-five (3,125) shares and becoming the holder of three thousand
one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany,
on 12 January 2015,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of one thousand five hundred sixty-two (1,562) shares and becoming the holder of one thousand five
hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, the United
Kingdom, on 7 January 2015, and
4. TEC Global Invest VII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,
registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26063, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,
being the holder of one thousand five hundred sixty-three (1,563) shares and becoming the holder of one thousand
five hundred sixty-two (1,562) Series A4 Shares,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Mülheim an der
Ruhr, Germany, on 5 January 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties are all of the shareholders, representing the entire share capital of Digital Services XXV S.à r.l.
(hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Sen-
ningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number
B 188486, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations n° 2492 on 16 September 2014. The articles of incorporation have not been amended
since.
The appearing parties representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general meeting
of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Decision to create five (5) classes of shares, referred to as the common shares (hereinafter the “Common Shares”),
the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter the “Series A2 Shares”), the
series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and the series A4 shares (hereinafter the “Series A4 Shares”) and
to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each,
into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, without cancellation of shares.
2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR
12,500) up to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of six thousand two hundred fifty (6,250)
Series A1 Shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares, one thousand five hundred sixty-
44642
L
U X E M B O U R G
three (1,563) Series A3 Shares and one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 Shares, with a nominal value
of one euro (EUR 1) each.
3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth
read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”), and
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
“A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
XXV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
44643
L
U X E M B O U R G
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”), and
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
44644
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated
to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);
7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity
(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a Shareholder to the Company and/or
any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme;
7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the
shareholders' meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.
7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an
economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the Shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.
8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4
Shares shall receive per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being
subject to the Liquidity Event in the following table:
Share Class
Amount
per Share
in Euro
Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.00
Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,695.18
Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,599.49
Series A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,600.51
8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second
level (“Second Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any Investor on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such Investor on this Second Level provided
that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether or not the sale
of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions, no share-
44645
L
U X E M B O U R G
holder shall receive for the sale of all of its Shares (and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an
amount exceeding the higher of (i) its Share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a
common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second Level from
a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.
8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so
long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
44646
L
U X E M B O U R G
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.
Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the
consent of the Advisory Board:
17.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidat ion of the Company;
17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and
transformation of the Company;
44647
L
U X E M B O U R G
17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
17.1.4 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing
shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of
the Investors.
17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.
17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued Shares of that class.
D. Board of managers - Advisory board
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
44648
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions
and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros
(EUR 500,000.00) in aggregate;
22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,
however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two
hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;
22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in
controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;
22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary
course of business;
22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set
forth in any shareholders' agreement between the shareholders;
22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections
291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and
22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
44649
L
U X E M B O U R G
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an Advisory Board. It consists of four (4) voting members. The shareholders may by
way of unanimous Shareholders' Consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.
25.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a unanimous
shareholders' consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having four (4) votes, shall be nominated by the shareholder
AIH in its sole discretion;
25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder
LIH in its sole discretion;
25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder
Aismare in its sole discretion; and
25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder TEC
in its sole discretion.
25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by AIH shall be
the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast.
25.5 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions
of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders' resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.
25.6 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and Supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
44650
L
U X E M B O U R G
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
5. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr. Julien De
Mayer and Mr. Rüdiger Trox each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders
register of the Company.
6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires
the undersigned notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create five (5) classes of shares, referred to as the common shares
(hereinafter the “Common Shares”), the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares
44651
L
U X E M B O U R G
(hereinafter the “Series A2 Shares”), the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and the series A4 shares
(hereinafter the “Series A4 Shares”) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a
nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, without cancellation
of shares.
<i>Second Resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500) so as to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
up to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1
Shares, three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares, one thousand five hundred sixty-three (1,563)
Series A3 Shares and one thousand five hundred sixty-two (1.562) Series A4 Shares, with a nominal value of one euro
(EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The new Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares have been subscribed as follows:
1. six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1 Shares have been subscribed by Asia Internet Holding S.à r.l.,
aforementioned, for the subscription price of eighteen thousand seven hundred fifty euros (EUR 18,750);
2. three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares have been subscribed by MKC Brillant Services
GmbH, aforementioned, for the subscription price of eleven thousand two hundred twenty euros and sixty-eight cents
(EUR 11,220.68);
3. one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares have been subscribed by Aismare Lux Holdings S.à
r.l., aforementioned, for the subscription price of four thousand six hundred eighty-eight euros (EUR 4,688); and
4. one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 Shares have been subscribed by TEC Global Invest VII GmbH,
aforementioned, for the subscription price of four thousand six hundred eighty-seven euros (EUR 4,687).
<i>Paymenti>
1. The six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1 Shares have been subscribed for a total subscription price of
eighteen thousand seven hundred fifty euros (EUR 18,750) by Asia Internet Holding S.à r.l., aforementioned, and have
been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of six thousand two hundred fifty euros (EUR 6,250)
and (ii) a contribution in kind consisting of twelve thousand five hundred (12,500) common shares, having a nominal value
of one euro (EUR 1) each, of Classifieds Asia S.à r.l., a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 180.253, having its registered office
at 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having an aggregate value of at least twelve
thousand five hundred euros (EUR 12,500);
2. The three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares have been subscribed for a total subscription
price of eleven thousand two hundred twenty euros and sixty-eight (EUR 11,220.68) by MKC Brillant Services GmbH,
aforementioned, and have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of three thousand one
hundred twenty-five euros (EUR 3,125) and (ii) a contribution in kind consisting of a limited partnership interest of eight
thousand ninety-five euros and sixty-eight cents (EUR 8,095.68) in LIH Subholding Nr. 4 UG (haftungsbeschränkt) & Co.
KG, a limited partnership under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the
commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRA 46939 B, having an aggregate value
of at least eight thousand ninety-five euros and sixty-eight cents (EUR 8,095.68);
3. The one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares have been subscribed for a total subscription
price of four thousand six hundred eighty-eight euros (EUR 4,688) by Aismare Lux Holdings S.à r.l., aforementioned, and
have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand five hundred sixty-three euros
(EUR 1,563) and (ii) a contribution in kind consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A1 shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each, of Classifieds Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of
at least three thousand one hundred twenty-five euros (EUR 3,125).
4. The one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 Shares have been subscribed for a total subscription
price of four thousand six hundred eighty-seven euros (EUR 4,687) by TEC Global Invest VII GmbH, aforementioned,
and have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand five hundred sixty-two euros
(EUR 1,562) and (ii) a contribution in kind consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each, of Classifieds Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of
at least three thousand one hundred twenty-five euros (EUR 3,125).
Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned
notary.
The total contribution, in the amount of thirty-nine thousand three hundred forty-five euros and sixty-eight cents (EUR
39,345.68), consists of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) allocated to the share capital and twenty-six
thousand eight hundred forty-five euros and sixty-eight cents (EUR 26,845.68) allocated to the share premium of the
Company.
44652
L
U X E M B O U R G
<i>Third Resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5 of the
articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
" Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Common Shares”),
5.1.2 six thousand two hundred fifty (6,250) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A1 Shares”),
5.1.3 three thousand one hundred twenty-five (3,125) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A2 Shares”),
5.1.4 one thousand five hundred sixty-three (1,563) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)
each (hereinafter “Series A3 Shares”), and
5.1.5 one thousand five hundred sixty-two (1,562) Series A4 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each
(hereinafter “Series A4 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares, Series A3 Shares and Series A4 Shares collectively
“Series A Shares”).
The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent
otherwise provided by these articles of association or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings
S.à r.l. (“Aismare”) and (iv) TEC Global Invest VII GmbH (“TEC”, AIH, LIH, Aismare and TEC jointly the “Investors” and
each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further Shares to be issued in the course of a capital
increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated to a
shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third Party Investor”))
and which has been approved by the Advisory Board (a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the
Third Party Investor or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the
Company prior to such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is
based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare and (iv) TEC shall inform the Company by binding declaration within three
(3) weeks after it has been notified by the Company regarding the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare
and/or (iv) TEC intend/s to exercise its/their respective right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This
Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors subscribes for further Shares.”
<i>Fourth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the
articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Fifth Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Mr. Julien De Mayer and Mr. Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely,
the shareholders register of the Company.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at EUR 2,400.-.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Januar,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
44653
L
U X E M B O U R G
1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg,
Inhaber von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen und zukünftiger Inhaber von sechstausendzweihundert-
fünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in Berlin,
Deutschland, am 12 Januar 2015 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 5. Januar 2015,
2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen und zukünftiger Inhaber von dreitausendeinhun-
dertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12 Januar 2015,
ausgestellt in Berlin, Deutschland,
3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaber von eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhun-
dertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7. Januar 2015,
ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich, und
4. TEC Global Invest VII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem
Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26063, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,
Inhaber von eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhun-
dertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5. Januar 2015,
ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die besagten erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Digital
Services XXV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188486, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Carlo
Wersandt, welche am 16. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2492 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.
Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten ver-
zichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung von fünf (5) Anteilklassen, welche als Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile
der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der Serie A3 (die
„Anteile der Serie A3“) und Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) bezeichnet werden und bezüglich der
Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile.
2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von sechstau-
sendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1, dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie
A2, eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 und eintausendfünfhundertzweiundsechzig
(1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
44654
L
U X E M B O U R G
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A«bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren«und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)
LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services XXV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
44655
L
U X E M B O U R G
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A«bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren«und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)
LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
44656
L
U X E M B O U R G
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);
7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines
Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle«oder „Kontrolliert Wird«oder „Kontrolliert«die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.
7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren
Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.
7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der
Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,
wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer
Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis«bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich des Artikel 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.
8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2,
Anteilen der Serie A3 und Anteilen der Serie A4 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle
neben der entsprechenden vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse festgelegten Betrag:
Anteilsklasse
Betrag
pro Anteil
in Euro
Serie A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,00
Serie A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.695,18
Serie A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.599,49
Serie A4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600,51
44657
L
U X E M B O U R G
8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten
Ebene („Zweite Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem
Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene, mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf
der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines
Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für
den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zu-
rückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu
den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem
Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit
der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.
8.4 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie
dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
44658
L
U X E M B O U R G
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die
„Gesellschafterversammlung«in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusam-
menhang und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Allein-
gesellschafter ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
44659
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.
Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-
schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und
Umwandlung der Gesellschaft;
17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;
17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder
die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung der Investoren:
17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer - Beirat
Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger
Geschäftsführer«nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat
der Geschäftsführer«als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer«auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
44660
L
U X E M B O U R G
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte
und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-
derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;
22.8.3 Gewährung von Darlehen, die, im Einzelfall, einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00)
überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;
22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,
einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;
22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
44661
L
U X E M B O U R G
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-
wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;
22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des
gewöhnlichen Geschäftsgangs;
22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,
wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;
22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes
(AktG)); und 22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der
Gewährung jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteili-
gung, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart
wurde.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers, oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet. Dieser besteht aus vier (4) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Ge-
sellschafter können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder
herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur mit einstimmiger Zustimmung festlegen und/
oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit vier (4) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
44662
L
U X E M B O U R G
25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach
eigenem Ermessen ernannt;
25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach
eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem
Gesellschafter TEC nach eigenem Ermessen ernannt.
25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von AIH ernanntes stimmbe-
rechtigtes Mitglied ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats kann weitere Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
25.5 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft zuständig, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft,
(ii) dieser Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v)
entsprechender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten
können dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen
hat der Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund Ver-
lustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene
44663
L
U X E M B O U R G
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31 Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie die
Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, fünf (5) Anteilsklassen zu schaffen, welche als Stammanteile (die „Stamm-
anteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der
Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) und Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) bezeichnet werden und die
bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einzie-
hung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile umzuwandeln.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen
Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von sechstausendzweihundertfünfzig (6.250)
Anteilen der Serie A1, dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2, eintausendfünfhundertdrei-
undsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 und eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die neuen Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und Anteile der Serie A4 wurden wie folgt
gezeichnet:
1. sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt,
zu einem Bezugspreis von achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 18.750) gezeichnet;
2. dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH, vor-
benannt, zu einem Bezugspreis von elftausendzweihundertzwanzig Euro und achtundsechzig Cent (EUR 11.220,68)
gezeichnet;
3. eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l., vor-
benannt, zu einem Bezugspreis von viertausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR 4.688) gezeichnet; und
4. eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteile der Serie A4 wurden von TEC Global Invest VII GmbH, vor-
benannt, zu einem Bezugspreis von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
1. Die sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l., vorbe-
nannt, zu einem Gesamtbezugspreis von achtzehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 18.750) gezeichnet und voll-
ständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von sechstausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 6.250) und (ii) eine
44664
L
U X E M B O U R G
Sacheinlage bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1), der Classifieds Asia S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180.253, mit Sitz in 7, avenue J.P.
Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, mit einem Gesamtwert von mindestens zwölftausendfünf-
hundert Euro (EUR 12.500);
2. Die dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH,
vorbenannt, zu einem Gesamtbezugspreis von elftausendzweihundertzwanzig Euro und achtundsechzig Cent (EUR
11.220,68) gezeichnet und vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von dreitausendeinhundertfünfund-
zwanzig Euro (EUR 3.125) und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus einem Kommanditanteil von achttausendfünfundneunzig
Euro und achtundsechzig Cent (EUR 8.095,68) der LIH Subholding Nr. 4 UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, einer
Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRA 46939 B, mit einem Gesamtwert
von mindestens achttausendfünfundneunzig Euro und achtundsechzig Cent (EUR 8.095,68).
3. Die eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l.,
vorbenannt, zu einem Gesamtbezugspreis von viertausendsechshundertachtundachtzig Euro (EUR 4.688) gezeichnet und
vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertdreiundsechzig Euro (EUR 1.563) und
(ii) eine Sacheinlage bestehend aus dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A1, mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1), der Classifieds Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens
dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125).
4. Die eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteile der Serie A4 wurden von TEC Global Invest VII GmbH,
vorbenannt, zu einem Gesamtbezugspreis von viertausendsechshundertsiebenundachtzig Euro (EUR 4.687) gezeichnet
und vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertzweiundsechzig Euro (EUR 1.562)
und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2, mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), der Classifieds Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens
dreitausendeinhundertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125).
Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar
erbracht.
Die gesamte Einlage in Höhe von neununddreißigtausenddreihundertfünfundvierzig Euro und achtundsechzig Cent
(EUR 39.345,68) besteht aus zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden
und aus sechsundzwanzigtausendachthundertfünfundvierzig Euro und achtundsechzig Cent (EUR 26.845,68), die dem Agio
der Gesellschaft zugeführt werden.
<i>Dritter Beschlussi>
Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf der Satzung der Gesell-
schaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die
„Stammanteile“),
5.1.2 sechstausendzweihundertfünfzig (6.250) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00) (die „Anteile der Serie A1“),
5.1.3 dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),
5.1.4 eintausendfünfhundertdreiundsechzig (1.563) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“), und
5.1.5 eintausendfünfhundertzweiundsechzig (1.562) Anteilen der Serie A4 mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A4“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2, Anteile der Serie A3 und
Anteile der Serie A4 gemeinsam als „Anteile der Serie A«bezeichnet werden).
Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es
wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)
Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“) und (iv) TEC Global Invest VII GmbH („TEC“, AIH, LIH, Aismare und TEC
gemeinschaftlich die „Investoren«und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapital-
erhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es
sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15
ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat zugestimmt wurde (eine „Inves-
tition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren
44665
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitaler-
höhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Jede der Gesellschaften
(i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3)
Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesellschaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii)
LIH, (iii) Aismare und (iv) TEC ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e) gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben
möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-
fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung ermächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-
gorie, sowie die Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunter-
schrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden
Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.400,-. geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.
Gezeichnet: X. TANG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1159. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Februar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015034381/1380.
(150038772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Digital Services XXV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.486.
<i>Dépôt rectificatif concernant la modification déposée le 13 janvier 2015 sous la référence L150006609i>
Le présent document est établi en vue de corriger les informations inscrites auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg. En effet, une erreur matérielle s'est glissée lors du dépôt enregistré le 13 janvier 2015 sous la
référence L150006609.
Les informations correctes de TEC Global Invest VIII GmbH, associé de la Société, détenant 1.563 parts sociales au
sein de celle-ci, sont: TEC Global Invest VM GmbH, une Gesellschaft mit beschränkter Haftung, constituée et régie selon
les lois de l'Allemagne, ayant son siège social à l'adresse suivante: Wïssollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr,
Allemagne et immatriculée auprès du local court of Duisburg sous le numéro HRB 26063.
Toutes les autres dispositions de la publication demeurent inchangées.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Digital Services XXV S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015034380/21.
(150038287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
44666
L
U X E M B O U R G
European Meridien S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.094.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration tenu le 17 février 2015:i>
Le conseil d'Administration prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8,
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.
Luxembourg, le 17 février 2015.
<i>Pour EUROPEAN MERIDIEN S.A.
i>Signature
Référence de publication: 2015034413/13.
(150038222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Fassaden-Rainbow-Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Fassades-Rainbow-Lux S.à r.l.).
Siège social: L-5550 Remich, 20, rue de Macher.
R.C.S. Luxembourg B 113.343.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtzehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, im Amtssitz zu Remich.
Ist erschienen:
Herr Jürgen SCHWARZ, Maler, wohnhaft D-66706 Perl, Haus Biringer Straße 1e.
Welcher Komparent erklärt, dass er alleiniger Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung „Fassades-
Rainbow-Lux S.à r.l.“ mit Sitz in L-5550 Remich, 20, rue de Macher ist, welche gegründet wurde gemäß notarieller Urkunde
vom 4. Januar 2006, veröffentlicht im Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Mémorial C, Nummer 707 vom 6. April
2006.
Dies erläutert, hat der Komparent den amtierenden Notar ersucht, folgenden Beschluss zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft umzuändern in „Fassaden-Rainbow-Lux S.à r.l.“ und de-
mentsprechend Artikel 1 der Satzung umzuändern wie folgt:
„ Art. 1. Der Gesellschaftsname lautet “Fassaden-Rainbow-Lux S.à r.l.“.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der Gesellschafter beschließt den Gesellschaftszweck umzuändern und Artikel 2 der Satzung folgenden Wortlaut zu
geben:
„ Art. 2. Zweck der Gesellschaft sind Dachreinigung, Fassadensanierung, Anstriche, Unter- und Oberputz, Vollwär-
meschutz, Trockenausbau, Innenarbeiten, Bodenbeläge und Gerüstbau.
Die Gesellschaft kann sich an Geschäften sowohl im In- als auch im Ausland beteiligen; sie kann weiterhin sämtliche
handelsübliche, industrielle und finanzielle Operationen vornehmen, welche direkt oder indirekt auf den Hauptzweck
Bezug haben.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen sowohl im In- als auch im Ausland eröffnen.“
<i>Dritter Beschlussi>
Der Gesellschafter nimmt die Rücktritte der Herren Reinhard Biermann und Karl Alfred SCHWARZ als Geschäfts-
führer an und gibt ihnen Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.
Herr Jürgen SCHWARZ, Maler, wohnhaft D-66706 Perl, Haus Biringer Straße 1e, wird als Geschäftsführer der Ge-
sellschaft auf unbestimmte Dauer bestätigt. Die Gesellschaft wird nach außen verpflichtet durch die alleinige Unterschrift
des Geschäftsführers.
<i>Erklärungi>
Die erschienene Partei erklärt hiermit, dass sie selbst an den eingebrachten Vermögenswerten letztlich wirtschaftlich
berechtigt ist und bestätigt dass die Gelder und Vermögenswerte nicht aus einer Straftat herrühren.
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung von allem Vorstehenden an den Erschienenen, dem Notar nach Namen, Vornamen, Stand und
Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
44667
L
U X E M B O U R G
Gezeichnet: J. SCHWARZ, Patrick SERRES.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 février 2015. Relation: GAC/2015/1446. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. PIERRET.
Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, erteilt.
Remich, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015034415/49.
(150038897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Financière Viking S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 66.238.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 8 décembre 2014i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil décide de nommer la société Omnes & Partners S.A. en sa qualité d'expert-comptable, ayant son siège
social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159.142 en tant qu'agent dépositaire, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2015034423/12.
(150038486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Finexis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 154.916.
<i>Extrait procès-verbal du conseil d'administration du 24/10/2014i>
<i>Première résolutioni>
Par la présente réunion, le conseil d'administration de Finexis S.A. (ci-après la "Société ") décide de:
- Acter la démission de Madame Monica Bajan (épouse Waloszyk) aux fonctions d'administrateur de la société Finexis
SA.
- Acter la démission de Messieurs Frédéric Muller et Laurent Muller aux fonctions d'administrateur de la société Finexis
SA. avec effet au 9 octobre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Certifié sincère et conforme
Finexis S.A.
Référence de publication: 2015034424/17.
(150038879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Damovo Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 127.003.
Veuillez prendre note que:
Suite à la cession de parts intervenue en date du 18 July 2012 entre Damovo Group Limited, et Damovo Group
Holdings Limited, les 125 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
- Damovo Group Limited., domicilié 87 Mary Street, Walker House, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands,
et immatriculé sous le numéro WK-180695 auprès du Cayman Islands, ne détient plus aucune part de la Société.
- Damovo Group Holdings Limited., domicilié 95 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman, KY 1-1108 Cayman
Islands, et immatriculé sous le numéro QH-269836 auprès du Cayman Islands, détient 125 parts sociales d'une valeur
nominale de EUR 100 chacune.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
44668
L
U X E M B O U R G
Damovo Holdings S.à r.l.
Colm Smith
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015034375/20.
(150038770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Arrena S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 123.391.
Le bilan au 31/12/2013 été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015034858/10.
(150039574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
ASSA ABLOY Branding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.849.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Assa Abloy Branding S.àr.l.
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015034859/11.
(150039397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
ASSA ABLOY Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 172.813.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Assa Abloy Treasury S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Référence de publication: 2015034860/11.
(150039381) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Atlas European Holdco I S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 128.271.
Je, soussigné,
Paul Clarke, né le 16 Septembre 1970 à Montréal, Canada, ayant mon adresse professionnelle au 20 rue de la Poste,
L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,
déclare par la présente avoir démissionné en tant que Gérant de Atlas European Holdco I S.à r,l, à compter du 9 Février
2015
Signé à Luxembourg.
Paul Clarke.
Référence de publication: 2015034861/13.
(150039813) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
44669
L
U X E M B O U R G
Aureus IP S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 59, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 167.003.
<i>Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique de la Société en date du 27 janvier 2015i>
En date du 27 janvier 2015, l'administrateur unique de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société du
31, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg au:
- 59, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
AUREUS IPS.A.
Signature
Référence de publication: 2015034862/15.
(150039354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Afilor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3726 Rumelange, 7, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 56.058.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034838/9.
(150039764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Afod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.696.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034839/9.
(150039613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Afod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 165.696.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034840/9.
(150039614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Arnica Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 134.036.
EXTRAIT
L'assemblée générale du 13 février 2015 a renouvelé les mandats des administrateurs.
- Madame Michelle DELFOSSE, Administrateur, ingénieur civil, 12, rue des Champs, L-7435 Tuntange, Luxembourg;
- Madame Nathalie GAUTIER, Administrateur, Master Administration des Entreprises, 6, rue Adolphe, L-1116 Lu-
xembourg, Luxembourg;
- Monsieur Henri GRISIUS, Administrateur-Président, licencié en sciences économiques appliquées, 30, rue Joseph
Hansen, L-1716 Luxembourg, Luxembourg.
Leurs mandats prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
L'assemblée générale du 13 février 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.
44670
L
U X E M B O U R G
- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2015.
Luxembourg, le 13 février 2015.
<i>Pour ARNICA HOLDING S.A.
i>Société anonyme
Référence de publication: 2015034857/21.
(150039595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Avenir Telecom International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 67.886.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 20 février 2015i>
Est nommé administrateur, en remplacement de Madame Agnès TIXIER, administrateur démissionnaire en date du 19
décembre 2014:
- Madame Véronique BEAUME, directrice financière, demeurant 10 Allée des Platanes, Domaine du Lac Bleu, F-13480
Cabriès.
Madame Véronique BEAUME terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de
la prochaine assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 mars 2014 qui se tiendra exception-
nellement en 2015.
Cette cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine assemblée générale.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Pour extrait
Référence de publication: 2015034863/18.
(150039435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Avrim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 131.665.
Les comptes annuels au 30 avril 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015034864/10.
(150039255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Axus Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 270, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 23.299.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg au siège social le 15 janvieri>
<i>2015i>
L'Assemblée décide:
- de nommer, comme nouvel administrateur de la Société, Madame Véronique de la Bachèlerie, de nationalité française,
née le 10 octobre 1959 à Chambéry (France), ayant son domicile sis route d'Arlon 100C, L-1150 Luxembourg
- que le mandat du nouvel administrateur repris dans la première résolution ci-dessus sera d'une durée de six ans et
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en juin 2021.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 29 janvier 2015.
Dominique ROGER
<i>Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015034866/18.
(150039442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
44671
L
U X E M B O U R G
BlueBay Funds Management Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 24, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 88.445.
Les comptes de la Société au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015034868/10.
(150038663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
BlueSPHERE, Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 102.777.
Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015034869/10.
(150039756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Bmax Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.771.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015034870/12.
(150038971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
AZIGEP Société de Participations Financières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1148 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 158.490.
In the year two thousand and fifteen, on the eleventh of February.
Before Maître Henri Hellinckx, notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of "AZIGEP Société de Participations Financières S.à r.l.", a
"société à responsabilité limitée", having its registered office at 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. The said com-
pany transferred its registered office to Luxembourg and adopted the Luxembourgish nationality by a deed of the
undersigned notary, on December 28, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
818 dated April 27, 2011, page 39248, and registered with the Luxembourg Trade Register under section B 158.490.
The meeting is chaired by Marta André, lawyer, residing professionally at at Edificio Myriad Crystal Center- Cais das
Naus, Lote 2.15.02, 1990-173 Lisboa, Portugal.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Arlette Siebenaler, private employee,
residing professionally in Luxembourg, 101, rue Cents.
The chairman requests the notary to act that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares they own are shown on an attendance list. That
list and the proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the
minutes.
II. It appears from the attendance list attached that all the shareholders owing together 5,000,000 (five million) ordinary
shares representing the entire capital of the Company are present or represented at the meeting.
III. The shareholders being all present or represented the meeting may be held without prior notice.
44672
L
U X E M B O U R G
IV. The meeting can therefore consider and vote on the items concerned on the agenda of the meeting, which is as
follows:
<i>Agendai>
1) To ratify the resolutions of the General Meeting of Shareholders dated 18
th
November 2014 deciding to transfer,
with effect in the year of 2015, the registered office (siège statutaire) and the central administration (administration
centrale) of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Portugal.
2) To approve the resignation of Mr Christophe Gaul and to grant him discharge for the performance of his mandate
as director of the company.
3) To state that all necessary steps have already been taken in Portugal and that the Company may be striken off the
Trade and Companies’Register in Luxembourg.
After the foregoing was approved by the meeting, the shareholders decide what follows by unanimous vote:
<i>First resolution:i>
The meeting resolves to ratify the resolutions of the General Meeting of Shareholders dated 18
th
November 2014
deciding to transfer, with effect on January 1, 2015, the registered office (siège statutaire) and the central administration
(administration centrale) of the Company from the Grand-Duchy of Luxembourg to Portugal, at Edificio Myriad Crystal
Center- Cais das Naus, Lote 2.15.02, 1990-173 Lisboa, Portugal.
A copy of the minutes of the resolutions dated November 18, 2014 will remain attached to present deed.
<i>Second resolutioni>
The meeting approves the resignation of Mr Christophe Gaul and grants him discharge for the performance of his
mandate as director of the company.
<i>Third resolutioni>
The meeting states that all necessary steps have already been taken in Portugal to render effective such transfer of the
registered office and the central administration and that the Company has been inscribed in the Commercial Registry in
Portugal with effect on January 16, 2015, so that the Company has ceased to exist under Luxembourg law and may be
striken off the Trade and Companies’Register in Luxembourg.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,800-.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le onze février.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "AZIGEP Société de Partici-
pations Financières S.à r.l.", ayant son siège social au 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, immatriculée au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 158.490. La Société a transféré son siège social de Portugal
à Luxembourg et a adopté la nationalité luxembourgeoise suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 28 décembre
2010, publié au Mémorial C numéro 818 du 27 avril 2011, page 39248 et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 158.490.
L'assemblée est présidée par Madame Marta André, avocat, demeurant professionnellement à Edificio Myriad Crystal
Center- Cais das Naus, Lote 2.15.02, 1990-173 Lisboa, Portugal.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Madame Arlette Siebenaler, employée
privée, demeurant professionnellement à Luxembourg, 101, rue Cents.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- Les associés présents ou représentés et le nombre d’actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
44673
L
U X E M B O U R G
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, l’entièreté des associés détenant ensemble 5.000.000 (cinq millions)
d’actions ordinaires, représentant l’intégralité du capital souscrit, sont présents ou représentés à la présente assemblée
générale extraordinaire.
III.- Tous les associés étant présents ou représentés la présente assemblée générale extraordinaire peut être tenue
sans convocation préalable.
IV.- L'assemblée peut donc délibérer et voter sur les points suivants de l’ordre du jour de l’assemblée générale ex-
traordinaire:
<i>Ordre du jour:i>
1) Ratification des résolutions de l’assemblée générale des associés du 18 novembre 2014 décidant de tranférer le
siège statutaire et l’administration centrale de la Société de la Société de Luxembourg au Portugal avec effet en l’an 2015.
2) Approbation de la démission de Monsieur Christophe Gaul de gérant et décharge pour l’exécution de son mandat.
3) Constatation que toutes les démarches ont été prises au Portugal et que la Société pourra être rayée de du Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, les associés décident ce qui suit à l’unanimité des voix:
<i>Première résolution:i>
L’Assemblée ratifie les résolutions de l’assemblée générale des associés du 18 novembre 2014 décidant de tranférer
le siège statutaire et l’administration centrale de la Société de la Société de Luxembourg au Portugal, Edificio Myriad
Crystal Center- Cais das Naus, Lote 2.15.02, 1990-173 Lisboa, avec effet au 1
er
janvier 2015.
Une copie des minutes du 18 novembre 2014 restera annexée aux présentes.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée approuve la démission de Monsieur Christophe Gaul en tant que gérant et lui décharge pour l’exécution
de son mandat.
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée constate que toutes les démarches ont été prises au Portugal et que la Société a été inscrite au Registre
de Commerce au Portugal avec effet au 16 janvier 2015 et que dès lors elle pourra être rayée du Registre de Commerce
et des Sociétés à Luxembourg.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.800.-.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: M. ANDRÉ, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 13 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4701. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015034867/119.
(150038899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Blue Flag SC, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9711 Clervaux, 82, Grand rue.
R.C.S. Luxembourg E 5.571.
STATUTS
1. Monsieur LE MANACH Florent, né le 15 Juillet 1980 à Angers (France) demeurant au 1, Rue Pajou F-75016 PARIS
(France);
2. Madame MOREAU épouse LE MANACH Catherine, né le 11 Janvier 1954 à Angers (France), demeurant au 30,
Chemin Du Hutreau F-49130 SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE (France);
44674
L
U X E M B O U R G
Lesquels comparants ont décidé d’acter les statuts d’une Société Civile qu’ils déclarent constituer entre eux comme
suit le 26/02/2015:
Art. 1
er
. Il est formé une Société Civile régie par la loi de 1915 sur les Sociétés Commerciales et Civiles, telle qu’elle
a été modifiée par les lois subséquentes et par les articles 1832 et suivants du Code Civil Luxembourgeois.
Art. 2. La Société a pour objet la détention, l’utilisation et la mise à disposition de biens mobiliers à des fins privées.
La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.
La société pourra effectuer toutes opérations mobilières, immobilières et financières se rattachant directement ou indi-
rectement à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.
Art. 3. La dénomination est: BLUE FLAG SC.
Art. 4. Le siège social est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue, il pourra être transféré en toute autre localité du
Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision de l’assemblée générale.
Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée, elle pourra être dissoute par décision de la majorité
des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.
Art. 6. Le capital social est fixé à 100,00 EUR, répartis en 100 parts de 1,00 EUR chacune et constitué par l’apport en
numéraire sur un compte ouvert pour la société.
Art. 7. En raison de leur apport, il est attribué 99 parts à Monsieur LE MANACH Florent et 1 part à Madame LE
MANACH Catherine, les comparants ci-dessus mentionnés. La mise des associés ne pourra être augmentée que de leur
accord représentant au moins 50% des parts. L’intégralité de l’apport devra être libérée sur demande du gérant ou des
associés.
Art. 8. Les parts sociales sont cessibles entre associés. Elles sont incessibles entre vifs ou pour cause de mort à des
tiers non-associés sans l’accord unanime de tous les associés restants. En cas de transfert par l’un des associés de ses
parts sociales, les autres associés bénéficieront d’un droit de préemption sur ses parts, à un prix fixé entre associés et
agréé d’année en année lors de l’assemblée générale statuant le bilan et le résultat de chaque exercice. Le droit de
préemption s’exercera par chaque associé proportionnellement à sa participation au capital social. En cas de renonciation
d’un associé à ce droit de préemption, sa part profitera aux autres associés dans la mesure de leur quote-part dans le
capital restant.
Art. 9. Le décès ou la déconfiture de l’un des associés n’entraîne pas la dissolution de la société. Si les associés survivants
n’exercent pas leur droit de préemption en totalité, la société continuera entre les associés et les héritiers de l’associé
décédé. Toutefois, les héritiers devront, sous peine d’être exclus de la gestion et des bénéfices jusqu’à régularisation,
désigner dans les quatre mois du décès l’un d’eux ou un tiers qui les représentera dans tous les actes intéressant la Société.
Art. 10. La Société est administrée par un gérant nommé et révocable à l’unanimité de tous les associés.
Art. 11. Le gérant est investi de tous les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en nom et pour
compte de la Société. La Société se trouve valablement engagée à l’égard des tiers par la signature individuelle de son
gérant.
Art. 12. Le bilan est soumis à l’approbation des associés, qui décident de l’emploi des bénéfices.
Les bénéfices sont répartis entre les associés en proportion de leurs parts sociales.
Art. 13. Les engagements des associés à l’égard des tiers sont fixés conformément aux articles 1862, 1863 et 1864 du
Code Civil. Les pertes et dettes de la Société sont supportées par les associés en proportion du nombre de leurs parts
dans la Société.
Art. 14. L’assemblée des associés se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l’exigent sur convocation du
gérant ou sur convocation d’un des associés. Une assemblée statutaire aura lieu obligatoirement le troisième vendredi
de juin de chaque année à 15 heures afin de délibérer du bilan, du résultat de l’année écoulée et pour fixer la valeur des
parts conformément à l’article 6. L’assemblée statue valablement sur tous les points de l’ordre du jour et ses décisions
sont prises à la simple majorité des voix des associés présents ou représentés, chaque part donnant droit à une voix.
Toutes modifications des statuts doivent être décidées à l’unanimité des associés.
Art. 15. En cas de dissolution, la liquidation sera faite par le gérant ou par les associés selon le cas, à moins que
l’assemblée n’en décide autrement.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont à sa charge, en raison de sa constitution à 100 EUR.
44675
L
U X E M B O U R G
<i>Assemblée générale extraordinairei>
A l’instant, les parties comparantes représentant l’intégralité du capital social se sont réunies en assemblée générale
extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent comme dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement convoquée, et après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, elles ont pris les résolutions
suivantes:
1. Monsieur LE MANACH Florent, précité, est nommé gérant,
2. La société EDISYS SA, 65, Route d’Esch L-3340 Huncherange, RCS Luxembourg B139924, est nommée co-gérant,
3. Le siège de la Société est établi à L-9711 Clervaux, 82, Grand Rue.
Lu, accepté et signé par les parties intervenantes.
Référence de publication: 2015034885/71.
(150039565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Belair Lotissements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2370 Howald, 1, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 35.014.
<i>Extrait du conseil d'administration du 6 février 2015 tenu 1, rue Peternelchen, L-2370 Howaldi>
Le conseil d'administration a nommé la société
Grant Thornton ABAX Investment Services, 7A, rue Thomas Edisson, L-1445 Strassen, inscrite au registre de com-
merce de Luxembourg sous le numéro B 147.837,
dépositaire chargé de la conservation des actions au porteur conformément à la Loi du 28 juillet 2014.
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015034880/13.
(150039160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Belfond (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 61.050.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015034881/10.
(150039401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Benodec, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 21.979.
Les statuts coordonnés au 30/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015034882/12.
(150039279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Braincare International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2172 Luxembourg, 29, rue Alphonse Munchen.
R.C.S. Luxembourg B 134.332.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires qui a eu lieu au Luxembourg le 02 janvieri>
<i>2015.i>
<i>Première résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de révoquer le mandat du délégué à la gestion journalière avec effet immédiat à partir
du 02 janvier 2015:
44676
L
U X E M B O U R G
- M. Dimitrios ZOIS, administrateur de sociétés, de nationalité luxembourgeoise, résidant à 29, rue Alphonse München,
L-2172 Luxembourg.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de nommer la personne suivante, délégué à la gestion journalière, avec effet immédiat
à partir du 02 janvier 2015 et jusqu'à la prochaine assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017:
- M. Spyridon TZANIS, administrateur de sociétés, de nationalité hellénique, résidant à 8, Place Verte, L-8159, Bridel,
Luxembourg.
Extrait Conforme
<i>Un Administrateuri>
Référence de publication: 2015034888/21.
(150039576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
C.R.S.M. Sàrl, Société à responsabilité limitée,
(anc. C.R.S.M. S.A.).
Siège social: L-3896 Foetz, 4, Biirkewee.
R.C.S. Luxembourg B 53.210.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 4 février 2015.
<i>Pour la société
i>Anja HOLTZ
<i>Le notairei>
Référence de publication: 2015034898/13.
(150039775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
C&A Europe (Luxembourg) Scs, Société en Commandite simple.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 94.348.
EXTRAIT
Il résulte de l'Assemblée Générale Extraordinaire qui s'est réunie au siège social le 16 février 2015 que le montant du
capital social a été augmenté de EUR 11,116,122 pour le porter de son montant actuel de EUR 545,048,366 à EUR
556,164,488 par création et paiement en nature de 111,161 parts sociales à son associé commanditaire, Cofra Holding
AG.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015034900/13.
(150039579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Carraig Beag, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 21.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.905.
EXTRAIT
L'assemblé général des associés de la Société a décidé, en date du 26 février 2015:
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Gregor Dalrymple de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mme Clare Jenner de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Emile Habayeb de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Tawfiq Awwad de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
44677
L
U X E M B O U R G
- de nommer avec effet au 27 février 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Khalil Kachicho, né le 20 mars 1962
à Beyrouth, Liban, ayant pour adresse professionnelle: 111, Poseidonos Avenue, GR-16610 Glyfada, Grèce en tant que
gérant de classe B de la Société;
- de nommer avec effet au 9 mars 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Angelos Mylonas, né le 8 juillet 1983 à
Tripoli Arkadias, Grèce, ayant pour adresse privée: 8, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en tant que gérant de classe A de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Carraig Beag
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015034901/27.
(150039761) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Carraig Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 21.018,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.747.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a décidé, en date du 26 février 2015:
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Gregor Dalrymple de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mme Clare Jenner de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Emile Habayeb de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Tawfiq Awwad de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
- de nommer avec effet au 27 février 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Khalil Kachicho, né le 20 mars 1962
à Beyrouth, Liban, ayant pour adresse professionnelle: 111, Poseidonos Avenue, GR-16610 Glyfada, Grèce en tant que
gérant de classe B de la Société;
- de nommer avec effet au 9 mars 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Angelos Mylonas, né le 8 juillet 1983 à
Tripoli Arkadias, Grèce, ayant pour adresse privée: 8, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en tant que gérant de classe A de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Carraig Investments
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015034902/27.
(150039762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Carraig Mor, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 21.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.899.
EXTRAIT
L'assemblé général des associés de la Société a décidé, en date du 26 février 2015:
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Gregor Dalrymple de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mme Clare Jenner de ses fonctions de gérant de catégorie
A de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Emile Habayeb de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
- d'accepter avec effet au 27 février 2015, la démission de Mr Tawfiq Awwad de ses fonctions de gérant de catégorie
B de la Société;
44678
L
U X E M B O U R G
- de nommer avec effet au 27 février 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Khalil Kachicho, né le 20 mars 1962
à Beyrouth, Liban, ayant pour adresse professionnelle: 111, Poseidonos Avenue, GR-16610 Glyfada, Grèce en tant que
gérant de classe B de la Société;
- de nommer avec effet au 9 mars 2015 et pour une durée indéterminée, Mr Angelos Mylonas, né le 8 juillet 1983 à
Tripoli Arkadias, Grèce, ayant pour adresse privée: 8, rue de l'Ouest, L-2273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en tant que gérant de classe A de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Carraig Mor
Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015034903/27.
(150039760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Caymus Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: MXN 75.779.453,00.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2a, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 180.704.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 février 2015.
Référence de publication: 2015034904/11.
(150039121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Onixea Group S.A., Société Anonyme,
(anc. Apollinaire S.A.).
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 152.882.
L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Lu-
xembourg “APOLLINAIRE S.A.”, établie et ayant son siège social à L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 152882, (la “Société”), constituée
suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg), en
date du 30 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1048 du 19 mai 2010,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Yvon HELL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1930 Lu-
xembourg 16a, avenue de la Liberté.
Le Président désigne comme secrétaire et l’Assemblée choisit comme scrutateur Madame Nathalie OLLAGNIER,
employée privée, demeurant professionnellement L-1930 Luxembourg 16a, avenue de la Liberté.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jouri>
1. Changement de la dénomination sociale en “ONIXEA GROUP S.A.” et modification afférente de l’article 1
er
des
statuts;
2 Modification de l’objet social afin de donner à l’article 3 des statuts la teneur suivante:
“La Société a pour objet d’effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de
participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et
le développement de ces participations.
La Société a pour objet l’acquisition, la gestion pour son compte ou celui d'autrui, la constitution, l’enregistrement et
le dépôt, la valorisation, la vente, l’usage dans le cadre de son activité et la concession de l’usage de tous noms de domaines
et de tous droits de propriété intellectuelle, incluant notamment mais non exclusivement tous droits d'auteur sur des
logiciels informatiques, tous brevets, toutes marques de fabrique ou de commerce, ainsi que tous dessins et tous modèles.
44679
L
U X E M B O U R G
La Société aura également pour objet tous travaux de recherche et de développement liés à la création et à l’exploi-
tation de tous droits de propriété intellectuelle.
La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit.
La Société pourra, dans les limites fixées par la Loi, accorder à toute société du groupe ou à tout actionnaire tous
concours, prêts, avances ou garanties.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelcon-
ques, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet ou qui le favorisent et qui sont susceptibles de
promouvoir son développement ou extension.
La Société pourra généralement faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immo-
bilières au Grand-Duché de Luxembourg et à l’étranger qui se rattachent directement ou indirectement, en tout ou en
partie, à son objet social.
La Société pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour compte de tiers, seule ou
en association en effectuant toute opération de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle
détient des intérêts.”
3. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les mandataires et les membres du
bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Assemblée décide de changer la dénomination sociale en “ONIXEA GROUP S.A.” et de modifier subséquemment
l’article 1
er
des Statuts comme suit:
“ Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de “ONIXEA GROUP S.A.”, (la “Société”), régie par
les présents statuts ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.”
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’objet social et d'adopter en conséquence pour l’article 3 des Statuts la teneur comme
ci-avant reproduite dans l’ordre du jour sous le point 2).
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a
ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Y. HELL, N. OLLAGNIER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 24 février 2015. 2LAC/2015/3939. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 26 février 2015.
Référence de publication: 2015034851/85.
(150039114) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
44680
L
U X E M B O U R G
ADM28 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 20.000,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 174.159.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015034831/13.
(150038963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
FG Communication, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 9, Val Saint Croix.
R.C.S. Luxembourg B 194.921.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le treize février.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,
A comparu:
Monsieur Frédéric GOURDIN, né à Luxembourg, le 21 mars 1983, demeurant à L-1371 Luxembourg, 9, Val Saint
Croix,
Ici représenté par Madame Carole Mersch, demeurant à L-1371 Luxembourg, 9, Val Saint Croix,
en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera annexée aux présentes.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle qu'il déclare constituer par les présentes.
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes par le propriétaire des parts ci-après créées une société à responsabilité
limitée, qui sera régie par les lois y relatives et par les présents statuts.
Art. 2. La société a pour objet toutes opérations relatives à la mise en relation entre les éditeurs et imprimeurs au
Luxembourg et à l'étranger ainsi que:
- la représentation aux salons et foires en France, en Belgique et en Allemagne,
- la préparation et le suivi d'événements culturels ou publicitaires au Luxembourg et à l'étranger;
- la mise en place de vitrines commerciales,
- le conseil dans les domaines du marketing publicitaire.
La société pourra faire en outre toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-
mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.
Art. 3. La société prend la dénomination de "FG Communication".
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Art. 5. La durée de la société est illimitée.
Elle commence à compter du jour de sa constitution.
Art. 6. Le capital social est fixé à EUR 12.500.- (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales
d'une valeur nominale de EUR 125.- (cent vingt-cinq euros) chacune.
Art. 7. Les cessions de parts sociales sont constatées par un acte authentique ou sous seing privé. Elles se font en
conformité avec les dispositions légales afférentes.
Art. 8. La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.
Art. 9. Les créanciers personnels, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit,
faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société.
Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants qui sont nommés par l'assemblée générale des associés,
laquelle fixe la durée de leur mandat.
44681
L
U X E M B O U R G
A moins que l'assemblée n'en dispose autrement, le ou les gérants ont vis-à-vis des tiers les pouvoirs les plus étendus
pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à
l'accomplissement de son objet social.
En cas de gérant unique, la société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique et en
cas de pluralité de gérants, les pouvoirs de signature seront déterminés par l'assemblée générale des associés/par l'associé
unique lors de la nomination des gérants.
Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il
ne peut les déléguer.
Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre
tenu au siège social.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par lui (eux) au nom de la société.
Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 14. Chaque année, le trente-et-un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-
prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société.
Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.
Art. 16. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugés
nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.
Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition de l'assemblée des associés.
Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour finir le trente-et-un décembre deux mille quinze.
<i>Souscription et libérationi>
Les 100 (cent) parts sociales sont souscrites par l'associé unique Monsieur Frédéric GOURDIN, prénommé.
Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que la somme de EUR 12.500.-
(DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire soussigné qui le constate expressément
<i>Décision de l'associé uniquei>
Ensuite l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Est nommé gérant pour une durée indéterminée:
Monsieur Frédéric Gourdin, prénommé.
2. Le siège social est fixé à L-1371 Luxembourg, 9, Val Saint Croix.
<i>Remarquei>
Avant la clôture des présentes, le notaire instrumentant a attiré l'attention du constituant sur la nécessité d'obtenir
des autorités compétentes les autorisations requises pour exercer les activités plus amplement décrites comme objet
social à l'article deux des présents statuts.
<i>Evaluation des fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution à environ EUR 1.000.-.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: C. MERSCH et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 18 février 2015. Relation: 1LAC/2015/5144. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
44682
L
U X E M B O U R G
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015035035/92.
(150039665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Finitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4750 Pétange, 54, rue de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 53.083.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier du 24 février 2015 que je démissionne de ma fonction de gérant administratif de la société
FINITECH SARL, établie et ayant son siège social à L-4750 Pétange, 54, Route de Longwy, inscrite au Registre de com-
merce et des sociétés sous le numéro B 53 083, avec effet rétroactif à la date du 23.12.2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
<i>Pour la société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015035036/16.
(150038736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Evertrans S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 182.679.
In the year two thousand fifteen, on the twenty-second day of January.
Before Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg),
is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “EVERTRANS S.A.”, a “société anonyme” established and
having its registered office at 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 182.679 (hereafter the “Company”).
The Company has been incorporated pursuant to a deed enacted by the undersigned notary on December 12
th
,
2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 247 dated January 28
th
, 2014.
The Articles of Incorporation of the Company were for the last amended pursuant to a deed enacted by the under-
signed notary on December 23
rd
, 2014, under way of being published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations”.
The Extraordinary General Meeting is declared open with Mrs Danielle SCHROEDER, company manager, residing
professionally in Luxembourg, in the chair, who assumes also the function of scrutineer.
The Chairman appoints as secretary Mrs Annick Braquet, employee, residing professionally in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to state that:
I.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. To introduce the possibility of splitting the company's shares into bare ownership and usufruct by amending the
articles 1 and 15 of the articles of incorporation and by inserting additional paragraphs three and four to article 5, and an
additional paragraph six to article 12 of the articles of incorporation, in order to reflect such action.
2. Amendment of article 1 of the articles of association to read as follows:
“ Art. 1. There exists a public limited company (“Société Anonyme”), which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity (the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended
(the Law), as well as by the present articles of association (the Articles) and by potential shareholders' agreements
concluded under private seal conditionally on the approval of all the shareholders under the name of “EVERTRANS S.A.”
3. Amendment of article 5 of the articles of association by inserting two additional paragraphs after the second para-
graph to read as follows:
44683
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Paragraph three and four. “It is expressly provided that the ownership of each share representing the subscribed
share capital may be exercised either on a full-ownership basis, or by way of usufruct by a shareholder referred to as a
“usufructuary” and by way of bare-ownership by another shareholder referred to as a “bareowner.
In case a share is held in usufruct and in bare ownership, title to the usufruct and to the bare-ownership shall be
recorded in the register of shareholders: the term ‘usufruct' opposite the name of the usufructuary, the term ‘bare-
ownership' opposite the name of the bare-owner.”
4. Amendment of article 12 of the articles of association by inserting one additional paragraph after paragraph five to
read as follows:
Art. 12. Paragraph six. “The rights attached to the status of usufructuary and conferred by each share shall be deter-
mined as follows:
- corporate social rights in their entirety,
- right to vote at ordinary and extraordinary general meetings,
- right to dividends,
- preferential subscription right for the new shares in case of a capital increase.
The rights attached to the status of bare-owner and conferred by each share shall be those determined by the general
law and in particular the right to the liquidation proceeds of the Company.”
5. Amendment of article 15 of the articles of association to read as follows:
“ Art. 15. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Laws,
particularly the law on Commercial Companies dated 10
th
August 1915, as amended as well as any agreement (if any)
that may be concluded between the subscribers, the company and any future shareholders.”
II.- The shareholders present or represented, the proxy holders of the represented shareholders and the number of
their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders or their representatives and by the board
of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary,
will also remain annexed to the present deed.
III.- It appears from the said attendancelist that all the shares representing the total subscribed share capital are present
or represented at the meeting. The shareholders present or represented declare that they have had due notice and
knowledge of the agenda prior to this meeting, so that no convening notices were necessary.
IV.- The present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate
on the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to introduce the possibility of splitting the company's shares into bare ownership and usufruct
by amending the articles 1 and 15 of the articles of incorporation and by inserting additional paragraphs three and four
to article 5, and an additional paragraph six to article 12 of the articles of incorporation, in order to reflect such action.
<i>Second resolutioni>
The meeting decides to amend article one (1) of the articles of association to read as follows:
“ Art. 1. There exists a public limited company (“Société Anonyme”), which shall be governed by the laws pertaining
to such an entity (the Company), and in particular by the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended
(the Law), as well as by the present articles of association (the Articles) and by potential shareholders' agreements
concluded under private seal conditionally on the approval of all the shareholders under the name of “EVERTRANS S.A.”
<i>Third resolutioni>
The meeting decides to amend article five (5) of the articles of association by inserting two additional paragraphs after
the second paragraph to read as follows:
“It is expressly provided that the ownership of each share representing the subscribed share capital may be exercised
either on a full-ownership basis, or by way of usufruct by a shareholder referred to as a “usufructuary” and by way of
bare-ownership by another shareholder referred to as a “bareowner”.
In case a share is held in usufruct and in bare ownership, title to the usufruct and to the bare-ownership shall be
recorded in the register of shareholders: the term ‘usufruct' opposite the name of the usufructuary, the term ‘bare-
ownership' opposite the name of the bare-owner.”
<i>Fourth resolutioni>
The meeting decides to amend article twelve (12) of the articles of association by inserting one additional paragraph
after paragraph five to read as follows:
44684
L
U X E M B O U R G
“The rights attached to the status of usufructuary and conferred by each share shall be determined as follows:
- corporate/social rights in their entirety,
- right to vote at ordinary and extraordinary general meetings,
- right to dividends,
- preferential subscription right for the new shares in case of a capital increase.
The rights attached to the status of bare-owner and conferred by each share shall be those determined by the general
law and in particular the right to the liquidation proceeds of the Company.”
<i>Fifth resolutioni>
The meeting decides to amend article fifteen (15) of the articles of association to read as follows:
“ Art. 15. All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the Laws,
particularly the law on Commercial Companies dated 10
th
August 1915, as amended as well as any agreement (if any)
that may be concluded between the subscribers, the company and any future shareholders.”
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed
are estimated at EUR 1,200.-
Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; upon the request of the same appearing
parties and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, known to the notary, by their surnames, Christian names,
civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-deux janvier.
Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est réunie
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "EVERTRANS S.A.", dont le siège social
est établi à 21, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 182.679 (ci- après la «Société»).
La Société a été constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné, en date du 12 décembre 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 247 du 28 janvier 2014.
Les statuts de la Société ont été modifiés la dernières fois par acte du notaire soussigné en date du 23 décembre 2014,
en voie de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
La séance est ouverte sous la présidence de Madame Danielle SCHROEDER, directeur de société, demeurant pro-
fessionnellement à Luxembourg, qui assume également la fonction de scrutateur.
La présidente désigne comme secrétaire Madame Annick Braquet, employée privée, demeurant professionnellement
à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, la présidente expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Introduire la possibilité de la distinction entre l'usufruit et la nue propriété des actions et modification afférente de
l'article 1 et 15 des statuts et introduction de deux alinéas complémentaires 3 et 4 à l'article 5 des statuts et d'un alinéa
complémentaire 6 à l'article 12 des statuts pour en tenir compte.
2. Modification de l'article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la Société), et en
particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents
statuts (les Statuts) ou encore par des conventions éventuellement conclues sous seing privé, à la condition toutefois que
tous les actionnaires et la Société aient donné leur accord à ces conventions, sous la dénomination de «EVERTRANS
S.A:»»
3. Modification de l'article 5 des statuts par l'insertion de deux nouveaux paragraphes après le second paragraphe qui
ont la teneur suivante:
44685
L
U X E M B O U R G
Art. 5. Alinéa trois et quatre. «Il est expressément prévu que chaque action représentative du capital social souscrit
peut être détenue soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété
par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, l'usufruit et la nue-propriété des actions seront inscrites
au registre des actionnaires par la mention «usufruit» derrière le nom de l'usufruitier et par la mention «nue-propriété»
derrière le nom du nu-propriétaire.»
4. Modification de l'article 12 des statuts par l'insertion d'un nouveau paragraphe après le cinquième paragraphe qui a
la teneur suivante:
Art. 12. Alinéa six. «Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi
qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.»
5. Modification de l'article 15 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois,
en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à tout contrat (le cas
échéant) qui peut être conclu entre les souscripteurs, la Société et tout ceux qui en deviendront actionnaires.»
II. Les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détien-
nent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents,
les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-
verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-
phées "ne varietur" par les comparants.
III. Il résulte ainsi de la liste de présence que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée.
Les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connais-
sance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable, de sorte qu'aucune convocation n'était nécessaire.
IV. La présente assemblée, représentant l'intégralité du capital social, est ainsi régulièrement constituée et peut déli-
bérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée décide d'introduire la possibilité de la distinction entre l'usufruit et la nue propriété des actions et la
modification afférente de l'article 1 et 15 des statuts et l'introduction de deux alinéas complémentaires 3 et 4 à l'article
5 des statuts et d'un alinéa complémentaire 6 à l'article 12 des statuts pour en tenir compte.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article un (1) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme qui est régie par les lois relatives à une telle entité (la Société), et en
particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) ainsi que par les présents
statuts (les Statuts) ou encore par des conventions éventuellement conclues sous seing privé, à la condition toutefois que
tous les actionnaires et la Société aient donné leur accord à ces conventions, sous la dénomination de «EVERTRANS
S.A:»»
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article cinq (5) des statuts par l'insertion de deux nouveaux paragraphes après le
paragraphe 2 qui ont la teneur suivante:
Art. 5. Alinéas trois et quatre. «Il est expressément prévu que chaque action représentative du capital social souscrit
peut être détenue soit en pleine propriété, soit en usufruit par un actionnaire dénommé «usufruitier» et en nue-propriété
par un autre actionnaire dénommé «nu-propriétaire».
Au cas où l'action est détenue en usufruit et en nue-propriété, l'usufruit et la nue-propriété des actions seront inscrites
dans le registre des actionnaires par la mention «usufruit» derrière le nom de l'usufruitier et par la mention «nue-pro-
priété» derrière le nom du nu-propriétaire.»
44686
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article douze (12) des statuts par l'insertion d'un nouveau paragraphe après le para-
graphe 5 qui a la teneur suivante:
Art. 12. Alinéa six. «Les droits attachés à la qualité d'usufruitier et conférés par chaque action sont déterminés ainsi
qu'il suit:
- droits sociaux dans leur ensemble,
- droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires,
- droit aux dividendes,
- droit préférentiel de souscription des actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.
Les droits attachés à la qualité de nu-propriétaire et conférés par chaque action sont ceux qui sont déterminés par le
droit commun et en particulier le droit au produit de liquidation de la Société.»
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée décide de modifier l'article quinze (15) des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 15. Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément aux Lois,
en particulier la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi qu'à tout contrat (le cas
échéant) qui peut être conclu entre les souscripteurs, la Société et tout ceux qui en deviendront actionnaires.»
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève
approximativement à EUR 1.200.-.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance était levée.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des comparants, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: D. SCHROEDER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 26 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2243. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 2 mars 2015.
Référence de publication: 2015035025/221.
(150039741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Adler Toy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
R.C.S. Luxembourg B 115.826.
Il est dénoncé par la présente, de conformité avec la circulaire RCSL 10/02:
- que la convention de domiciliation de la société Adler Toy Holding S.à r.l., immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro B 115826, a été terminée en date du 26 février 2015.
- que l'adresse du siège concerné par la dénonciation est 47 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.
- que le domiciliataire était State Street Services (Luxembourg) S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034215/12.
(150038244) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
44687
L
U X E M B O U R G
E.RE.A.S. Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 157.566.
<i>Rectificatif de l'extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil de gérance tenue le 3 février 2015 à Luxembourg eni>
<i>remplacement de l'extrait déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 10 février 2015 Référence dei>
<i>publication N°L150026763.i>
Il résulte des résolutions prises le 10 février 2015 lors de la réunion du Conseil de gérance que:
Le Conseil de gérance reconnaît avoir publié par erreur la nomination de Monsieur Hassane DIABATE en remplace-
ment de Monsieur Franco TOSCANO.
La nomination de Monsieur Hassane DIABATE est annulée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034982/15.
(150039788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
Communauté d'Exploitation Agricole Soludi, Société Civile.
Siège social: L-9391 Reisdorf, 18, route de Larochette.
R.C.S. Luxembourg E 2.514.
In der außerordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft "COMMUNAUTE D'EXPLOITATION AGRICOLE
SOLUDI", mit Sitz 18 route de Larochette in Reisdorf, vom 05. Dezember 2014 wird folgendes beschlossen:
1: Die Gesellschafter Frau WEYDERT-LINCKELS Jeanne und Herr WEYDERT-LINCKELS Urbain verlassen die Ge-
sellschaft. Herr Weydert tritt seine Gesellschaftskapitalanteile an Herr Weydert Luc ab. Dazu wird Artikel 5 des
Gesellschaftsvertrages vom 08. Dezember 1999 geändert.
2. Laufzeit der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit verlängert.
Dazu wird Artikel 3 des Gesellschaftsvertrages vom 08. Dezember 1999 geändert.
3. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern. Dazu wird Artikel 17 des Gesellschaftsvertrages vom 08.
Dezember 1999 geändert und Beträge in Franken wurden in Euro umgewandert.
Neue Texte Artikel 5, 3 und 17:
Art. 5. Das gesamte Gesellschaftskapital beträgt demzufolge
vierhundertneunundzwanzigtausendachthundertfünfundzwanzig Euro (429.825,00 €) und ist eingeteilt in Anteile vonje
fünfundzwanzig Euro (25,00 €), welche wie folgt aufgeteilt sind:
a) An die Eheleute Ter Heegde-De Fouw
Fünftausenddreihundertsechzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.360
b) An Herrn Weydert Luc
Elftausendachthundertdreiunddreizig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.833
Zusammen : siebzehntausendeinhundert-dreiundneunzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.193
Art.3. Die Laufzeit der Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit verlängert.
Eine Verlängerung sowie eine vorzeitige Auflösung der Gesellschaft kann durch gemeinsamen Beschluss der Gesell-
schafter erfolgen.
Art 17. Die Gesellschaftsführung besteht aus zwei Verwaltern.
Zu Verwaltern der Gesellschaft werden ernannt:
a) Herr Dion Arian John Ter Heegde
b) Herr Luc Weydert
Einjeder dieser Verwalter hat die Befugnis allein im Namen der Gesellschaft zu handeln und dieselbe Dritten gegenüber
rechtskräftig zu verpflichten bis zu einem Betrag von dreitausendsiebenhundertfünfzig Euro (3.750,00€)
Für Verpflichtungen, welche den vorgenannten Betrag übersteigen, sind die Unterschriften der Verwalter erforderlich.
Den Verwaltern steht es frei vermittels Spezial- oder Generalvollmachten, Dritte mit den Geschäften der Gesellschaft
zu betrauen und deren Rechte, Entschädigungsansprüche und Tätigkeitsdauer zu bestimmen.
Référence de publication: 2015034357/37.
(150038987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
44688
Adler Toy Holding S.à r.l.
ADM28 S.à r.l.
Afilor S.A.
Afod S.A.
Afod S.A.
Apollinaire S.A.
Arnica Holding S.A.
Arrena S.A.
ASSA ABLOY Branding S.à r.l.
ASSA ABLOY Treasury S.à r.l.
Atlas European Holdco I S.à.r.l.
Aureus IP S.A.
Avenir Telecom International S.A.
Avrim S.à r.l.
Axus Luxembourg S.A.
AZIGEP Société de Participations Financières S.à r.l.
Belair Lotissements S.A.
Belfond (Luxembourg) Sàrl
Benodec
BlueBay Funds Management Company S.A.
Blue Flag SC
BlueSPHERE
Bmax Holding S.à r.l.
Braincare International S.A.
C&A Europe (Luxembourg) Scs
Carraig Beag
Carraig Investments S.à r.l.
Carraig Mor
Caymus Holding S.à r.l.
Communauté d'Exploitation Agricole Soludi
C.R.S.M. S.A.
C.R.S.M. Sàrl
Damovo Holdings S.à r.l.
Digital Services XXV S.à r.l.
Digital Services XXV S.à r.l.
E.RE.A.S. Management S.à r.l.
European Meridien S.A.
Evertrans S.A.
Fassaden-Rainbow-Lux S.à r.l.
Fassades-Rainbow-Lux S.à r.l.
FG Communication
Financière Viking S.A.
Finexis S.A.
Finitech S.à r.l.
Onixea Group S.A.