logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 918

3 avril 2015

SOMMAIRE

Accord International Holdings S.à.r.l.  . . . .

44042

Asia Global Invest S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

44026

Bilbao LuxCo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44020

Bilbao MidCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44026

Blicon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44019

CDPS S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44020

Dias et Muller S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44064

Eagle 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44023

Eagle 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44025

Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

44032

Flinders International SA  . . . . . . . . . . . . . . .

44019

Ginestra S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44018

GPE VI FIS GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44018

Greeneden Lux 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

44018

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l.  . .

44023

John Deere Funding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

44025

Jomeline Strategies S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

44019

Kikerono Konzern S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44023

Klee S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44024

MLUX Beauty Products S.à r.l.  . . . . . . . . . .

44037

MP B S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44064

Navan Patrimoine S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . .

44021

Oben der Kirch s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44025

Pacific Global Capital S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

44027

Padaro S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44021

Pasco Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44020

Peinture De Lorenzi Ed. et Fils Sàrl . . . . . .

44021

Printvenue Asia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44053

Quest Diagnostics Intermediate Holdings

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44033

Staples Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

44018

Stayrooms S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44018

Stericycle Europe S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

44021

Taurus Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44023

Tech Data Luxembourg S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

44022

TVA Trade S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44020

Twelve Magnolia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44030

Universe, The CMI Global Network Fund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44022

Vauban Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

44025

Virtuoso Investment Holdings Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44024

VSL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44019

Wirth Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

44038

WME Ventures S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44022

WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44049

Yorktown Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . .

44024

44017

L

U X E M B O U R G

Stayrooms S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1453 Luxembourg, 10-14, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 166.485.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033362/9.
(150036973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

GPE VI FIS GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 146.294.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033689/10.
(150037679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Greeneden Lux 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 164.868.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Séverine Michel
<i>Gérante

Référence de publication: 2015033678/11.
(150037865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Ginestra S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 116.162.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jan Willem Overheul
<i>Gérant

Référence de publication: 2015033687/11.
(150037779) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Staples Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 84.816,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 7B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 4.275.

Par résolutions circulaires signées en date du 24 février 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège

social de la Société du 10A, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange au 7B, Rue des Mérovingiens, L-8070 Bertrange avec
effet au 2 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033941/13.
(150038135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44018

L

U X E M B O U R G

Jomeline Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 143.320.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033734/10.
(150037735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Flinders International SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3480 Dudelange, 24, rue Gaffelt.

R.C.S. Luxembourg B 130.281.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015033664/10.
(150037573) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

VSL S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Belair, 4, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 147.560.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080

Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391

A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la

Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.

À Bertrange, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015033454/14.
(150037047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Blicon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.207.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement

L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du président du Conseil d'ad-

ministration et d'un administrateur, à savoir:

- Monsieur Claude ZIMMER, Président du Conseil d'administration - administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,

domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes,

à savoir:

- ZIMMER &amp; PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel

L-2134 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.

Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.

Extrait sincère et conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015033555/20.
(150037402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44019

L

U X E M B O U R G

TVA Trade S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033979/9.
(150037776) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Bilbao LuxCo S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.002,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 143.889.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Bilbao Luxco S.A.
Un Mandataire

Référence de publication: 2015033541/11.
(150037387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Pasco Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 64.082.

EXTRAIT

L'assemblée générale extraordinaire réunie en date du 25 février 2015 a accepté la démission des quatre membres du

Conseil d'administration, Messieurs Marc Koeune et Jean-Yves Nicolas et Mesdames Andrea Dany et Nicole Thommes.

L'assemblée générale des actionnaires a nommé comme nouvel administrateur Monsieur Edoardo Polli, citoyen suisse,

né le 16.12.1945 à Milan/Italie et demeurant à Cha Sur 1, 7502 Bever/Suisse. Son mandat viendra à échéance à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2020.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015033867/15.
(150037337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

CDPS S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8552 Oberpallen, 3, rue de Guirsch.

R.C.S. Luxembourg B 170.087.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2014

Il ressort de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2014 que:
L'assemblée accepte:
- la démission de Monsieur Jean-Marie Duvivier de son mandat d'administrateur;
- la démission de Monsieur Cédric Duvivier de son mandat de commissaire aux comptes.
L'assemblée désigne:
- Monsieur Cédric Duvivier, né à Braine l'Alleud (Belgique), le 26 août 1984 et demeurant à L-8410 Steinfort 55 route

d'Arlon, au poste d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2018.

- Madame Martine Hernalsteen, née à Uccle (Belgique), le 6 septembre 1953 et demeurant à L-8479 Eischen, 40 Cité

Bettenwies au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale à tenir en 2018.

Fait à Steinfort, le 26 février 2015.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015033572/19.
(150038113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44020

L

U X E M B O U R G

Peinture De Lorenzi Ed. et Fils Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4994 Schouweiler, 98, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 53.960.

Le Bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015033872/10.
(150037911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Padaro S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8325 Capellen, 98, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 180.240.

<i>Extrait de la résolution prise lors du Conseil d'Administration tenu à Capellen le 2 février 2015

Nomination de la société Anphiko Asset Management SA, (société de droit luxembourgeois, Professionnel du Secteur

Financier PSF, exerçant son activité avec le n° d'agrément 37/10, ayant son siège social situé à L-8325 Capellen 98 rue de
la Gare, et inscrite au registre de commerce sous le n° RCS Luxembourg B-139179) comme dépositaire pour les actions
au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033865/13.
(150037289) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Navan Patrimoine S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1628 Luxembourg, 7A, rue des Glacis.

R.C.S. Luxembourg B 163.591.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 12 février 2015

I
De nommer Madame Stéphanie LACROIX (née le 28 décembre 1976 à F - Epinal, demeurant professionnellement 7a

rue des Glacis à L - 1628 Luxembourg), en remplacement de Madame Johanna FISCHMANN, démissionnaire, adminis-
trateur pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, à savoir l'assemblée générale annuelle de 2017.

<i>Pour la Société
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015033816/15.
(150037688) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Stericycle Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 135.343.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 19 février 2015

1. M. Frank PLETSCH a démissionné de son mandat de gérant de classe B.
2. M. Pierre CLAUDEL, administrateur de sociétés, né le 23 mai 1978 à Schiltigheim (France), demeurant profession-

nellement au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de classe B pour une durée
indéterminée.

Luxembourg, le 26.2.2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Stericycle Europe S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015033917/16.
(150037784) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44021

L

U X E M B O U R G

Universe, The CMI Global Network Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 33.463.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision du conseil d'administration de la Société en date du 13 octobre 2014 et d'une décision de

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 30 décembre 2014 que le siège social de la
Société est transféré du 36, rue Rangwee, L-2412 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg au 106, route d'Arlon,
L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033981/14.
(150037886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

WME Ventures S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 193.798.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la société le 30 janvier 2015

En date du 30 Janvier 2015, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- D'accepter la démission de Mr Willem Matthijs Elias en tant que gérant de la société, avec effet au 31 décembre 2014;
- De nommer Luxembourg Corporation Company SA, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B 37 974 et ayant son siège social au 20, rue de la Poste, L-2356 Luxembourg, en tant
que gérant de la société avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures

Référence de publication: 2015034014/16.
(150037727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Tech Data Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Capital social: EUR 211.200,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 93.006.

Il résulte des résolutions écrites prises par l'associé unique de la Société en date du 20 février 2015 qu'il a été décidé

à l'unanimité:

- d'accepter la démission de Monsieur Charles Dannewitz en tant que gérant A de la Société avec effet immédiat au

20 février 2015; ainsi que

- de confirmer que le conseil de gérance de la Société est dorénavant composé comme suit:
* Monsieur Scott William Walker, gérant A;
* Monsieur Jeffery P. Howells, gérant A;
* Monsieur Jacob Mudde, gérant B;
* Monsieur Jorge Pérez Lozano, gérant B; et
* Madame Martha Caballero, gérant B,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Signataire autorisé

Référence de publication: 2015033966/24.
(150037436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44022

L

U X E M B O U R G

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 133.135.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Référence de publication: 2015033707/10.
(150038020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Eagle 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.057.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015033618/10.
(150037901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Kikerono Konzern S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 18.306.

En date du 17 février 2015, la Société a désigné la société Facts Services, ayant son siège social au 1, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire
et à l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

Certifié sincère et conforme
KIKERONO KONZERN S.A.
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015033742/14.
(150037770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Taurus Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.149.

Il est porté à la connaissance de tous qu'Ernst &amp; Young S.A., ayant son adresse professionnelle au 7, rue Gabriel

Lippmann L-5365 Munsbach, Luxembourg, a été nommé en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société par décision
du conseil d'administration de la Société en date du 29 octobre 2008 et que son mandat a été renouvelé pour des périodes
successives d'un an par les décisions du conseil d'administration de la Société en date du 13 mai 2009, 11 mai 2010, 20
avril 2011, 7 mai 2012, 24 avril 2013 et 27 mars 2014.

Le dernier renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé de la Société arrivera à échéance lors de l'as-

semblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

<i>Pour la Société
TMF Luxembourg S.A.
Signatures
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2015033962/20.
(150037461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44023

L

U X E M B O U R G

Yorktown Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.881.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 30 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Yorktown Luxembourg S.à r.l.
Johannes L. de Zwart
<i>Gérant

Référence de publication: 2015033466/14.
(150037270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Klee S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 150.547.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 9 février 2015

L'Actionnaire unique décide de révoquer avec effet immédiat la société FIDUCIAIRE MARC MULLER S.à r.l. de son

mandat de commissaire aux comptes.

L'Actionnaire unique décide de nommer avec effet immédiat en qualité de nouveau commissaire aux comptes, la société

MGI FISOGEST S.à r.l., sise 681, rue de Neudorf à L-2220 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés sous le numéro B20114.

Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin en 2021 à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur

les comptes clos au 31 décembre 2020.

L'Actionnaire unique constate que l'adresse de l'Administrateur unique a changé:
- Monsieur Marc WAGNER, Administrateur unique, demeure au 11, rue Jean Jacques Knepper à L-3389 Peppange
Référence de publication: 2015033743/17.
(150037654) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 179.780.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 12 février 2015

1. Mme Delphine ANDRE a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B, avec effet au 13 février 2015.
2. Mme Mélanie WILKIN a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B, avec effet au 13 février 2015.
3. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B, avec
effet au 13 février 2015, pour une durée indéterminée.

4. M. Joost TULKENS, administrateur de sociétés, né à Someren (Pays-Bas), le 26 avril 1973, demeurant profession-

nellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B, avec effet au 13
février 2015, pour une durée indéterminée.

<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date du 13 février 2015

Le siège social a été transféré de L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène

Ruppert.

Luxembourg, le 26 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015033991/23.
(150037961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44024

L

U X E M B O U R G

Oben der Kirch s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9640 Boulaide, 2, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 132.399.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033284/9.
(150037039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Eagle 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.052.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015033620/10.
(150037899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

John Deere Funding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 101.958.

Monsieur Jason P. Rogers a démissionné de ses fonctions d'administrateur de John Deere Funding S.A. (la «Société»)

avec effet au 1 

er

 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Thomas C. Spitzfaden
VP &amp; Treasurer
Deere &amp; Company
<i>Actionnaire principal

Référence de publication: 2015033729/15.
(150037963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Vauban Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 6, avenue Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 47.719.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société VAUBAN PROPERTIES SA qui s'est

tenue en date du 24 février 2015 à Luxembourg que:

1) Le mandat de Monsieur Guy Ludovissy, avec adresse professionnelle au L-2324 Luxembourg, 6 avenue Pescatore,

en tant que Administrateur de la société a été reconduit, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

2) Le mandat de Madame Catherine Manry, avec adresse professionnelle au L-2418 Luxembourg, 5 rue de la Reine,

en tant que Administrateur de la société a été reconduit, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

3) Le mandat de Madame Pascale Larrivière, avec adresse professionnelle a F-06250 Mougins, 16 impasse de l'avenue

des Chênes, en tant que Administrateur de la société a été reconduit, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se
tiendra en 2020.

4) Triton Auditors Limited, ayant son siège social à WX1U 7GB Londres, 64 Baker Street, a été nommé en tant que

Commissaire aux Comptes de la société, jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2020.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033994/20.
(150037523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44025

L

U X E M B O U R G

Bilbao MidCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 55.089.743,50.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2C, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 177.697.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Bilbao MidCo S.à r.l.
Un Mandataire

Référence de publication: 2015033542/11.
(150037385) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

Asia Global Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.211.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn, den dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange-sur-Attert, (Großherzogtum Lu-

xemburg), handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.

IST ERSCHIENEN:

STICHTING  EMUTO,  eine  nach  niederländischem  Recht  eingetragene  Gesellschaft,  mit  Sitz  in  Hemonystratt  11,

NL-1074BK Amsterdam, Niederlande, hier vertreten durch Herrn Marco BREHM, Angestellter, berufsansässig in Muns-
bach,  6B,  rue  Gabriel  Lippmann,  auf  Grund  einer  ihm  ausgestellten  Vollmacht,  welche  nach  «ne  varietur»  Signatur,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Welche Komparentin den amtierenden Notar, durch ihren Bevollmächtigten, ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung " Asia Global Invest S.à r.l.", mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 3, rue

Jean Monnet, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 130.211,
gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am
9. Juli 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1956 vom 12. September 2007, deren Satzung abgeändert wurde auf
Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am 6. September
2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2358 vom 19. Oktober 2007.

-  Dass  das  Gesellschaftskapital  USD  17.026,25  (siebzehntausend  sechsundzwanzig  US  Dollar  und  fünfundzwanzig

Cents), eingeteilt in 1.250 (eintausend zweihundertfünfzig) Anteile ohne Nennwert.

- Dass der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Asia Global Invest

S.à r.l." zu sein und dass er den amtierenden Notar ersucht, die von ihm in ausserordentlicher Generalversammlung
gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar 2015 nach L-5365 Munsbach,

6B, rue Gabriel Lippmann zu verlegen und dementsprechend Artikel vier (4) der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 4. Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg.
Der Sitz kann zu einem beliebig anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden aufgrund eines Beschlusses

im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter, in der für die Änderung der Satzung vorges-
chriebenen Art und Weise.

Eine Verlegung der Adresse des Firmensitzes innerhalb der Gemeinde kann durch Beschluss der Geschäftsleitung

erfolgen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Filialen in Luxemburg und anderswo haben.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse ein-

treten oder bevorstehen, die die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an deren Sitz oder die Kommunikation zwischen
den Niederlassungen am Firmensitz und den Personen außerhalb des Firmensitzes negativ beeinträchtigen würden, kann
der Firmensitz auch vorübergehend - bis zur vollständigen Beendigung dieser Umstände - ins Ausland verlegt werden.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

Derartige vorübergehende Maßnahmen werden von der Geschäftsleitung der Gesellschaft getroffen und interessierten

Gesellschaften mitgeteilt."

44026

L

U X E M B O U R G

Die englische Version wird wie folgt abgeändert:

Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr neun

hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Munsbach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Marco BREHM, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 février 2015. Relation GAC/2015/1152. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015032929/70.
(150036915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Pacific Global Capital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 192.910.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth of December.
Before us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Pacific Rubiales Energy Corp., a corporation incorporated and existing under the laws of the Province of British Co-

lumbia, Canada, registered with the Province of British Columbia, Canada, under number BC0961068, having its registered
office at 333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, Ontario M5H 2R2,

here  represented  by  Mrs  Sofia  AFONSO-DA  CHAO  CONDE,  private  employee,  professionally  residing  in  Esch/

Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of Pacific Global Capital, S.A., a société anonyme

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies’ register
under number B192910, incorporated pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on 12 December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations (hereinafter the “Company”). The articles of association have not been amended since then.

The Sole Shareholder takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the Company’s share capital by an amount of one million nine hundred and

eighty thousand and one US dollars (USD 1,980,001) so as to raise it from its current amount of sixty thousand US dollars
(USD 60,000) up to two million forty thousand and one US dollars (USD 2,040,001) through the issue of one million nine
hundred and eighty thousand and one (1,980,001) shares, all with a nominal value of one US dollar (USD 1) and having
the rights and obligations attached thereto in the Company’s articles of association.

44027

L

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder resolves to allocate the newly issued one million nine hundred and eighty thousand and one

(1,980,001) shares to the following classes of shares:

- nine hundred and ninety thousand and one (990,001) shares allocated to the ordinary shares (the “Ordinary Shares”)

with a nominal value of one US dollar (USD 1) each; and

- nine hundred and ninety thousand (990,000) shares allocated to the mandatorily redeemable preferred shares (the

“MRPS”) with a nominal value of one US dollar (USD 1) each.

The nine hundred and ninety thousand and one (990,001) new Ordinary Shares issued have been subscribed by the

Sole Shareholder for the price of one million US dollars (USD 1,000,000) and have been fully paid up by a contribution
in cash in an amount of one million US dollars (USD 1,000,000), which is entirely allocated as follows:

- nine hundred and ninety thousand and one US dollars (USD 990,001) to the share capital of the Company,
- nine thousand nine hundred and ninety-nine US dollars (USD 9,999) to the Ordinary Shares Premium Account of

the Company.

The nine hundred and ninety thousand (990,000) new MRPS issued have been subscribed by the Sole Shareholder for

the price of ninety-nine million US dollars (USD 99,000,000) and have been fully paid up by a contribution in cash in an
amount of ninety-nine million US dollars (USD 99,000,000), which is allocated as follows:

- nine hundred and ninety thousand US dollars (USD 990,000) to the share capital of the Company,
- ninety-seven million nine hundred and eleven thousand US dollars (USD 97,911,000) to the MRPS Premium Account

of the Company, and

- ninety-nine thousand US dollars (USD 99,000) to the legal reserve of the Company.
The amount of one hundred million US dollars (USD 100,000,000) is at the free disposal of the Company, as it has

been proved to the undersigned notary who expressly acknowledges it.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 5 of the articles of

association of the Company which shall now read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at two million forty thousand and one US dollars (USD 2,040,001), represented

by (i) one million fifty thousand and one (1,050,001) ordinary shares with a nominal value of one US dollar (USD 1) each
(the “Ordinary Shares”), and (ii) nine hundred and ninety thousand (990,000) mandatorily redeemable preferred shares
with a nominal value of one US dollar (USD 1) each (the “MRPS”). The MRPS and the Ordinary Shares are hereinafter
collectively referred to as the “Shares” and individually as a “Share”. The Ordinary Shares and the MRPS shall constitute
separate classes of shares in the Company. Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary
general meetings of shareholders. The MRPS are non-voting shares as provided for in article 44 of the Law.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at 7,000 euro.

<i>Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26

of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le vingt-neuf décembre.
Par-devant nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Pacific Rubiales Energy Corp., une société constituée et existant selon les lois de la Province de la Colombie Britannique,

Canada, immatriculée au registre de la Province de la Colombie Britannique, Canada, sous le numéro BC0961068, ayant
son siège social au 333 Bay Street, Suite 1100, Toronto, Ontario, M5H 2R2,

dûment représenté par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, résidant professionnellement

à Esch/Alzette, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

44028

L

U X E M B O U R G

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La partie comparante est l’actionnaire unique (l’«Actionnaire Unique») de Pacific Global Capital, S.A., une société

anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 3, rue Thomas
Edison, L-1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B192910, constituée selon acte reçu par Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 12 décembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (ci-après la “Société”). Les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

L’Actionnaire Unique adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Actionnaire Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un million neuf cent quatre-vingt mille un

dollars américains (1.980.001 USD) afin de le porter de son montant actuel de soixante mille dollars américains (60.000
USD) à deux millions quarante mille un dollars américains (2.040.001 USD) par l’émission d’un million neuf cent quatre-
vingt mille une (1.980.001) actions, d’une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) chacune, et auxquelles sont
associés les droits et obligations prévus par les statuts de la Société.

L’Actionnaire Unique décide d’affecter les un million neuf cent quatre-vingt mille une (1.980.001) actions nouvellement

émises aux classes d’actions suivantes:

- neuf cent quatre-vingt-dix mille une (990.001) actions affectées aux actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»)

ayant une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) chacune; et

- neuf cent quatre-vingt-dix mille (990.000) actions affectées aux actions privilégiées obligatoirement rachetables (les

«APOR») ayant une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) chacune.

Les neuf cent quatre-vingt-dix mille une (990.001) nouvelles Actions Ordinaires émises ont été souscrites par l’Ac-

tionnaire Unique au prix d’un million de dollars américains (1.000.000 USD) et ont été intégralement libérées par un
apport en numéraire d’un montant d’un million de dollars américains (1.000.000 USD), alloué comme suit:

- neuf cent quatre-vingt-dix mille un dollars américains (990.001 USD) au capital social de la Société, et
- neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf dollars américains (9.999 USD) au Compte de Prime d’Emission des Actions

Ordinaires de la Société.

Les neuf cent quatre-vingt-dix mille (990.000) nouvelles APOR émises ont été souscrites par l’Actionnaire Unique au

prix de quatre-vingt-dix-neuf millions de dollars américains (99.000.000 USD) et ont été intégralement libérées par un
apport en numéraire d’un montant de quatre-vingt-dix-neuf millions de dollars américains (99.000.000 USD), alloué com-
me suit:

- neuf cent quatre-vingt-dix mille dollars américains (990.000 USD) au capital social de la Société,
- quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent onze mille dollars américains (97.911.000 USD) au Compte de Prime d’Emis-

sion des APOR de la Société, et

- quatre-vingt-dix-neuf mille dollars américains (99.000 USD) à la réserve légale de la Société.
Le montant de cent millions de dollars américains (100.000.000 USD) est à la libre disposition de la Société comme il

a été démontré au notaire instrument qui le reconnaît expressément.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la

Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à deux millions quarante mille un dollars américains (2.040.001 USD), re-

présenté par (i) un million cinquante mille une (1.050.001) actions ordinaires d’une valeur nominale d’un dollar américain
(1 USD) chacune (les «Actions Ordinaires»), et par (ii) neuf cent quatre-vingt-dix mille (990.000) actions privilégiées
obligatoirement rachetables d’une valeur nominale d’un dollar américain (1 USD) chacune (les «APOR»). Les APOR et
les Actions Ordinaires sont ensemble dénommées les «Actions» et individuellement l’«Action». Les Actions Ordinaires
et les APOR constituent des classes d’actions distinctes dans la Société. Chaque Action Ordinaire donne droit à un vote
aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires des actionnaires. Les APOR sont des actions sans droit de vote,
tel que prévu par l’article 44 de la Loi.»

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte

est évalué à environ 7.000 euros.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales et en constate expressément l’accomplissement.

44029

L

U X E M B O U R G

Dont acte, fait et passé à Esch/Alzette, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation: EAC/2015/543. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015032662/149.
(150035972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Twelve Magnolia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 171.334.

In the year two thousand fifteen, on the twelfth day of February.
Before the undersigned Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Twelve Magnolia S.A." (the “Company”), a société anonyme

having its registered office in 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, constituted by a deed of Maître Roger
ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in
Luxembourg on 31 August 2012, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, number 2498 of 8
October 2012.

The meeting was opened by Mr Mustafa NEZAR, lawyer, residing professionally in Luxembourg, being in the chair,
who appointed as secretary Ms Rachida EL FARHANE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mrs Alida MUHOVIC, employee, residing professionally in Luxembourg
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Transfer of the registered office of the Company to 7, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof;
2. Subsequent amendment of the Articles of Association;
3. Resignation of a Director and discharge.
4. Appointment of a new Director.
5. Confirmation of the composition of the board of Directors.
6. Miscellaneous.
II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxyholders of the
represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed.
III. As appears from the said attendance list, all the shares in circulation are present or represented at the present

general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company to L-8399 Windhof, 7, rue des Trois

Cantons and decides the subsequent amendment of the first and second paragraph of article 4 of the articles of association,
which will henceforth have the following wording:

“ Art. 4. The registered office of the Company is established in the City of Koerich.
It may be transferred to any other address in the same municipality by a decision of the board of directors.”

<i>Second resolution

The general meeting decides to accept the resignation of Mr Jérôme Demimuid as Director of the Company and to

grant him full discharge for his mandate up to this date.

44030

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The general meeting decides to appoint as Director of the Company:
Ms. Aurélie PARAGE, employee, born in Virton (B) on 14 February 1983, residing professionally at L-8399 Windhof,

7, rue des Trois Cantons.

As a consequence of the previous resolutions, the Directors of the Company will henceforth be as follows:
Ms. Céline DOYEN, employee, born on June 24, 1972 in Huy Belgium, with professional address at L-8399 Windhof,

7, rue des Trois Cantons.

Ms Aurélie PARAGE, prenamed.
Mr. Olivier REVOL, companies director, born on April 21, 1972 in Sainte-Foy-Les-Lyons, France, residing at 480, avenue

Louise, B-1050 Ixelles, Belgium.

Their mandate will be ending at the end of the Annual General Meeting which will be held in 2018
There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Estimation - Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand euros (EUR
1,000.-).

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the board and to the proxyholder of the appearing parties, who

are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, they signed together with the notary the
present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le douze février.
Pardevant, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Twelve Magnolia S.A." (la «Société»),

avec siège social à 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, constituée par acte de Maître Roger ARRENSDORFF,
notaire de résidence à Luxembourg agissant en remplacement de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 31 août 2012, publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2498 du 8 octobre
2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Mustafa NEZAR, juriste, demeurant professionnellement à

Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Rachida EL FARHANE, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Alida MUHOVIC, salariée, demeurant professionnellement à Luxem-

bourg

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège social de la Société au 7, rue des Trois Cantons L-8399 Windhof;
2. Modification des statuts pour prendre en compte la résolution prise ci-avant;
3. Démission d'un administrateur et décharge à lui donner.
4. Nomination d'un nouvel administrateur.
5. Confirmation de la composition du conseil d'administration.
6. Divers.
II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

44031

L

U X E M B O U R G

III.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société au L-8399 Windhof, 7, rue des Trois Cantons

et de modifier en conséquence le premier et le deuxième alinéa de l'article 4 des statuts pour leur donner la teneur
suivante:

« Art. 4. Le siège social de la société est établi dans la commune de Koerich.
Il pourra être transféré à toute autre adresse dans la même commune par simple décision du conseil d'administration.»

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur Jérôme Demimuid de sa fonction d'administrateur

de la Société et décide de lui donner décharge pour son mandat jusqu'à ce jour.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale décide de nommer à la fonction d'administrateur de la Société:
Madame Aurélie PARAGE, salariée, née à Virton (B) le 14 février 1983, demeurant professionnellement à L-8399

Windhof, 7, rue des Trois Cantons.

Compte tenu des précédentes résolutions, le Conseil d'Administration sera composé comme suit:
Madame Céline DOYEN, salariée, née le 24 juin 1972 à Huy (B), demeurant professionnellement au L-8399 Windhof,

7, rue des Trois Cantons.

Madame Aurélie PARAGE, précitée.
Monsieur Olivier REVOL, administrateur de sociétés, né le 21 avril 1972 à Sainte-Foy-lès-Lyon, France, demeurant au

480, avenue Louise, B-1050 Ixelles, Belgique.

Leurs mandats prendront fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2018.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison du présent acte est évalué à environ mille euros (EUR 1.000.-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la comparante l'a requis

de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du bureau et au mandataire des comparants, connus du

notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Nezar, El Farhane, Muhovic, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4786. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur (signé): Carole Frising.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015032804/135.
(150036367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 129.721.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033626/10.
(150037691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44032

L

U X E M B O U R G

Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 29.896.099,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 193.528.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Quest Diagnostics Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under

the laws of Luxembourg, with registered office at 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, in the process of
registration with the Luxembourg Register of Commerce and Companies, hereby represented by Mrs. Sofia Afonso Da
Chao Conde, private employee, with professional address at Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private
seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed and shall be filed together with such deed with the registration
authorities.

The appearing party, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I. The appearing party is the sole shareholder of Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à r.l., a Luxembourg private

limited liability company ("société à responsabilité limitée"), having its registered office at 2-8 avenue Charles de Gaulle,
L-1653  Luxembourg,  Grand-Duchy  of  Luxembourg,  in  the  process  of  registration  with  the  Luxembourg  Register  of
Commerce and Companies, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary, on 2 December 2014, not yet
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Company”).

II. The 20,000 (twenty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (One United States Dollar) each, representing

the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the
agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III. The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 29,876,099 (twenty nine million eight hundred

and seventy-six thousand ninety nine United States Dollars) so as to raise it from its current amount of USD 20,000
(twenty thousand United States Dollars) to USD 29,896,099 (twenty-nine million eight hundred and ninety-six thousand
ninety-nine  United  States Dollars)  by  the issuance  of  29,876,099 (twenty  nine million  eight  hundred and  seventy-six
thousand ninety nine) new shares, each having a nominal value of USD 1 (one United States Dollar), subject to the payment
of a global share premium amounting to USD 169,297,897.07 (one hundred and sixty-nine million two hundred and ninety-
seven thousand eight hundred and ninety-seven United States Dollars and seven Cents) payable on the share premium
account of the Company, out of which an amount of USD 2,989,610 (two million nine hundred eighty-nine six hundred
and ten United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve account of the Company, the whole to be fully paid
up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the sole shareholder of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The sole shareholder waives his right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges

being sufficiently informed about the agenda and considers the current meeting validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It further resolves that all the relevant documentation has been put
at its disposal within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

<i>Second resolution:

The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 29,876,099 (twenty

nine million eight hundred and seventy-six thousand ninety nine United States Dollars) so as to raise it from its current
amount of USD 20,000 (twenty thousand Dollars) to USD 29,896,099 (twenty-nine million eight hundred and ninety-six
thousand ninety-nine United States Dollars) by the issuance of 29,876,099 (twenty nine million eight hundred and seventy-
six thousand ninety nine) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) (the “New Shares”),
subject to the payment of a global share premium amounting to USD 169,297,897.07 (one hundred and sixty-nine million

44033

L

U X E M B O U R G

two hundred and ninety-seven thousand eight hundred and ninety-seven United States Dollars and seven Cents) payable
on the share premium account of the Company (the “Share Premium”), out of which an amount of USD 2,989,610 (two
million nine hundred eighty-nine six hundred and ten United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve account
of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind by the sole shareholder of a global amount
of USD 199,173,996.07 (one hundred and ninety-nine million one hundred and seventy-three thousand nine hundred and
ninety-six United States Dollars and seven Cents), (the “Contribution”).

<i>Third resolution:

The sole shareholder resolves to subscribe and fully pay the New Shares and the Share Premium through the Con-

tribution.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the sole shareholder, here represented by Mrs. Sofia Afonso Da Chao Conde, prenamed, by

virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe for the New Shares. The issue of the New Shares
are also subject to the payment of the Share Premium. The New Shares as well as the Share Premium have been fully
paid up by the sole shareholder through the Contribution.

<i>Description of the Contribution

The Contribution consists of the following equity interests owned by the sole shareholder and contributed to the

Company:

(i) 1,000 (one thousand) shares of common stock without nominal value and 5,400 (five thousand four hundred) shares

of Class A preferred stock without nominal value in Lab One Canada Inc., a company existing under the laws of the
Canada;

(ii) 1000 (one thousand) shares without nominal value in Quest Diagnostics of Puerto Rico, Inc., a company existing

under the laws of Puerto Rico;

(iii) 10 (ten) shares with a nominal value per share of GBP 1 (one British Pound) in Quest Diagnostics Limited, a

company existing under the laws of England and Wales;

(iv) 100 (one hundred) shares with a nominal value per share of EUR 1 (one Euro) in Quest Diagnostics Ireland Limited,

a company existing under the laws of Ireland;

(v) 2,853,474 (two million eight hundred and fifty-three thousand four hundred and seventy-four) quotas with a nominal

value per share of REAL 1 (one Real) in Quest Diagnostics do Brasil Ltda., a company existing under the laws of the Brazil;
and

(vi) a claim the sole shareholder has against the Company for an amount of USD 40,000 (forty thousand United States

Dollars).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 199,173,996.07 (one hundred and ninety-nine million one hundred

and seventy-three thousand nine hundred and ninety-six United States Dollars and seven Cents).

Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value,

which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution’s existence

A proof of the Contribution has been given to the Company.

<i>Managers’ intervention

Thereupon intervene:
Mr. Stephen Andrew Calamari, manager, with professional address at 3 Giralda Square Farms, Madison, New Jersey,

NJ 07940, United States of America;

Mr. Paul Robert Berry, manager, with professional address at 125-135 Staines Road, Hounslow, Middlesex, TW3 3JB,

United Kingdom; and

Mr. Robert-Jan Jacob Herman Bertina, with professional address at Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
all  represented  here  by  Mrs.  Sofia  Afonso  Da  Chao  Conde,  prenamed,  in  accordance  with  the  provisions  of  the

statement of contribution value.

All acknowledge, having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of

the Company by reason of their approval of the Contribution, and expressly agree with the description of this Contri-
bution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed

of:

44034

L

U X E M B O U R G

- Quest Diagnostics Holdings S.à r.l.: 29,896,099 (twenty-nine million eight hundred and ninety-six thousand ninety-

nine) shares.

The notary acknowledges that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company,

are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the Company’s articles of association so that to read as follows:

“ Art. 8. The Company’s share capital is set at USD 29,896,099 (twenty-nine million eight hundred and ninety-six

thousand ninety-nine United States Dollars), represented by 29,896,099 (twenty-nine million eight hundred and ninety-
six thousand ninety-nine) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

No other amendment is to be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about 7,000- euro.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof  the  present  notarial  deed  was  drawn  up  in  Esch-sur-Alzette  on  the  day  named  at  the  beginning  of  this

document.

The document having been read to the person appearing, such person signed together with us, the notary, the present

original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Quest Diagnostics Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en cours d'immatriculation avec le Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, ici représentée par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, employée privée, en vertu d'une pro-
curation donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la partie comparante et le notaire soussigné, demeurera

annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est le seul associé de la société Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à r.l., une société

à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation avec le Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, constituée par un acte du notaire soussigné en date du 2 décembre 2014, pas encore publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (la "Société").

II. Les vingt-mille (vingt-mille) parts sociales, d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar américain) chacune, repré-

sentant l’entièreté du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement délibérer
sur tous les points figurant à l’ordre du jour, dont l’associé unique déclare avoir eu préalablement connaissance.

III. L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de USD 29.876.099 (vingt neuf million huit cent soixante-

seize mille quatre-vingt dix-neuf Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de USD 20.000 (vingt-mille
Dollars américains) à USD 29.896.099 (vingt-neuf million huit cent quatre-vingt seize mille quatre vingt dix-neuf Dollars
américains) par l’émission de 29.876.099 (vingt neuf million huit cent soixante-seize mille quatre-vingt dix-neuf) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar américain) chacune, sous réserve du paiement d'une prime
d'émission s'élevant à USD 169.297.897,07 (cent soixante neuf million deux cent quatre-vingt dix-sept mille huit cent
quatre-vingt dix-sept Dollars américains et sept Cents), de laquelle un montant de USD 2.989.610 (deux million neuf cent
quatre-vingt neuf mille six cent dix Dollars américains) sera alloué sur le compte de réserve légale de la Société, le tout
étant payé par un apport en nature;

3. Souscription et paiement par l’associé unique des nouvelles parts sociales par le biais d'un apport en nature;

44035

L

U X E M B O U R G

4. Nouvelle composition de l’actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’associé unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

<i>Première résolution:

L’associé unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît

avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence
accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation
produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l’associé unique dans un délai suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

<i>Seconde résolution:

L’associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de USD 29.876.099 (vingt neuf million

huit cent soixante-seize mille quatre-vingt dix-neuf Dollars américains) afin de le porter de son montant actuel de USD
20,000 (vingt-mille Dollars américains) à USD 29.896.099 (vingt-neuf million huit cent quatre-vingt seize mille quatre vingt
dix-neuf Dollars américains), par l’émission de 29.876.099 (vingt neuf million huit cent soixante-seize mille quatre-vingt
dix-neuf) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar américain) chacune (les "Nouvelles Parts
Sociales"), sous réserve du paiement d'une prime d'émission s'élevant à USD 169.297.897,07 (cent soixante neuf million
deux cent quatre-vingt dix-sept mille huit cent quatre-vingt dix-sept Dollars américains et sept Cents) payable sur le
compte de prime d'émission de la Société (la "Prime d'Emission"), de laquelle un montant de USD 2.989.610 (deux million
neuf cent quatre-vingt neuf mille six cent dix Dollars américains) sera alloué au compte de réserve légale de la Société,
l’ensemble étant libéré par un apport en nature de l’associé unique pour un montant global de USD 199.173.996,07 (cent
quatre-vingt dix-neuf million cent soixante-treize mille neuf cent quatre-vingt seize Dollars américains et sept Cents),
("l’Apport").

<i>Troisième résolution:

L’associé unique décide de souscrire et pleinement libérer les Nouvelles Parts Sociales par le biais de l’Apport.

<i>Intervention - Suscription - Paiement

Intervient ensuite l’associé unique, ici représenté par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, prénommée, en vertu d'une

procuration signée par acte sous seing privé, et déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales. L'émission des Nouvelles
Parts Sociales est également sujette au paiement de la Prime d'Emission. Les Nouvelles Parts Sociales ainsi que la Prime
d'Emission ont été entièrement souscrites et libérées par le biais de l’Apport.

<i>Description de l’Apport

L'apport consiste en des actions détenues comme suit par l’associé unique et contribuées à la Société:
(i) 1.000 (mille) actions ordinaires sans valeur nominales et 5.400 (cinq mille quatre-cent) actions préférentielles de

Classe A sans valeur nominale, émises par Lab One Canada Inc., une société de droit canadien;

(ii) 1.000 (mille) actions sans valeur nominale émises par Quest Diagnostics of Puerto Rico, Inc., une société de droit

portoricain;

(iii) 10 (dix) actions avec une valeur nominale par action de GBP 1 (une livre anglaise) émises par Quest Diagnostics

Holdings Limited, une société soumises aux lois d'Angleterre et du Pays de Galles;

(iv) 100 (cent) actions avec une valeur nominale par action de EUR 1 (un Euro) dans Quest Diagnostics Ireland Limited,

une société de droit irlandais;

(v) 2.853.474 (deux million huit cent cinquante-trois mille quatre cent soixante quatorze) actions avec une valeur

nominale par action de REAL 1 (un Real), émises par Quest Diagnostics do Brasil Ltda., une société de droit brésilien; et

(vi) une créance détenue par l’associé unique contre la Société pour un montant de USD 40,000 (quarante-mille Euro).

<i>Evaluation

La valeur nette de l’Apport s'élève à USD 199.173.996,07 (cent quatre-vingt dix-neuf million cent soixante-treize mille

neuf cent quatre-vingt seize Dollars américains et sept Cents).

Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de l’Apport

qui restera annexée à cet acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

<i>Preuve de l’existence de l’Apport

Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:

44036

L

U X E M B O U R G

M. Stephen Andrew Calamari, gérant, ayant son adresse professionnelle à 3 Giralda Square Farms, Madison, New

Jersey, NJ 07940, Etats-Unis d'Amérique;

M. Paul Robert Berry, gérant, ayant son adresse professionnelle à 125-135 Staines Road, Hounslow, Middlesex, TW3

3JB, Royaume Uni; et

M. Robert-Jan Jacob Herman Bertina, ayant son adresse professionnelle à Carré Bonn, 20 rue de la Poste, L-2346

Luxembourg;

tous ici représentés par Mme Sofia Afonso Da Chao Conde, prénommée, en vertu des dispositions de la déclaration

de valeur d’apport.

Reconnaissant avoir été préalablement informées de l’étendue de leur responsabilité, engagés juridiquement en tant

que gérants de la Société en raison de l’Apport, consentent expressément avec la description de l’Apport, avec son
évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

Suite aux déclarations et résolutions ci-dessus, l’actionnariat de la Société est désormais composé comme suit:
- Quest Diagnostics Holdings S.à r.l.: 29.896.099 (vingt neuf million huit cent quatre-vingt seize mille quatre-vingt dix-

neuf) parts sociales.

Le notaire atteste que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant l’intégralité du capital social total

de la Société, sont représentées de telle sorte que l’assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.

<i>Cinquième résolution:

Suite aux déclarations et résolutions ci-dessus et l’Apport ayant été réalisé, il est décidé de modifier le premier para-

graphe de l’article 8 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

Art. 8. Le capital social est fixé à USD 29.896.099 (vingt neuf million huit cent quatre-vingt seize mille quatre-vingt

dix-neuf Dollars américains) représenté par 29.896.099 (vingt neuf million huit cent quatre-vingt seize mille quatre-vingt
dix-neuf) parts sociales d'une valeur nominale de USD 1 (un Dollar américain) chacune."

Aucune autre modification n'est apportée à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, de quelque type que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ 7,000.- euros.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est clôturée.

Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, le présent acte, à la date figurant au commencement de ce document.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, ce dernier a signé avec nous, le notaire, le présent

acte original.

Le  notaire  soussigné  qui  comprend  et  parle  l’anglais  constate  par  le  présent  acte  qu'à  la  requête  de  la  personne

comparante mentionnée ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la requête de la
même partie comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation: EAC/2015/553. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015032702/257.
(150036004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

MLUX Beauty Products S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 117, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 140.076.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Mandataire

Référence de publication: 2015033802/10.
(150037551) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

44037

L

U X E M B O U R G

Wirth Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5371 Schuttrange, 4, rue Hoimesbuch.

R.C.S. Luxembourg B 89.880.

Im Jahre zweitausendfünfzehn,

am elften Tag des Monats Februar.

Vor Uns Notar Jean-Joseph WAGNER, im Amtssitze zu SASSENHEIM, Großherzogtum Luxemburg,

ist erschienen:

Frau Ursula GILPIN, geborene WIRTH, Gesellschaftsdirektorin, berufsansässig in 4, rue Hoimesbuch, L-5371 Schüt-

tringen,

hier vertreten durch:

Frau Séverine HACKEL, Angestellte, berufsansässig in 6, rue Adolphe, L-1116 Luxemburg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Schüttringen (Großherzogtum Luxemburg), am 05. Februar 2015.

Besagte Vollmacht nach "ne varietur" Unterzeichnung durch die Bevollmächtigte der Erschienene und den unterzeich-

nenden Notar bleibt gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Dieselbe Erschienene, vertreten wie vorerwähnt, handelnd in ihrer Eigenschaft als alleinige Aktionärin (der „Aktionär“)

der Gesellschaft „WIRTH INVESTMENTS S.A.“ (die „Gesellschaft“), eine Aktiengesellschaft bestehenden unter den Ge-
setzen  des  Großherzogtums  Luxemburg,  mit  einem  Gesellschaftskapital  in  Höhe  von  NEUNZIGTAUSEND  EURO
(90‘000.- EUR) eingeteilt in NEUNTAUSEND (9‘000) voll eingezahlten Aktien mit einem Nennwert von je ZEHN EURO
(10.- EUR), mit Gesellschaftssitz in 4, rue Hoimesbuch, L-5371 Schüttringen, gegründet gemäß einer notariellen Urkunde
aufgenommen am 11. November 2002, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémo-
rial“), am 13. Dezember 2002, unter Nummer 1776 und Seite 85221 und eingetragen im Handels- und Gesellschaftsre-
gister beim Bezirksgericht von und zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 89 880.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß einer notariellen Urkunde aufgenommen am 29. Juni

2005, welche Satzungsabänderungsurkunde am 20. Dezember 2005, unter Nummer 1423 und Seite 68265 im Mémorial
veröffentlicht wurde.

Mit dem Ziel, die Gesamtfassung der Satzung neu zu formulieren, hat der Aktionär, durch seine vorgenannte Vertre-

terin, nachfolgende Beschlüsse angenommen und ersucht den amtierenden Notar, diese notariell zu beurkunden.

<i>Erster Beschluss

Der Aktionär beschließt den Gesellschaftszweck abzuändern und wie folgt neu zu fassen:

„Zweck der Gesellschaft ist der  Erwerb  von Beteiligungen  jeder Art an in- und  ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum

Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der
direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist,
Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen
um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.“

<i>Zweiter Beschluss

Der Aktionär beschließt die gegenwärtige französische Fassung gefolgt von einer englischen Übersetzung der Gesell-

schaftssatzung durch eine deutsche Fassung zu ersetzen und beschließt demzufolge eine vollständige Neufassung der
Satzung der Gesellschaft in deutscher Sprache, infolge der vorerwähnten Änderung des Gesellschaftszweckes ohne jedoch
die Rechtsform der Gesellschaft abzuändern, welche weiterhin der Rechtsform einer Aktiengesellschaft unterliegt und
insbesondere um sie an das neue Gesetz vom 25. August 2006, welches das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915
abgeändert hat, anzupassen und verabschiedet sie mit der folgenden neuen deutschen Fassung:

44038

L

U X E M B O U R G

NEUE FASSUNG DER SATZUNG VON

„WIRTH INVESTMENTS S.A.“

„Name - Sitz - Zweck - Dauer

Art. 1. Es besteht eine luxemburgische Gesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft, die den Namen „WIRTH IN-

VESTMENTS S.A.“ führt.

Art. 2. Der Sitz der Gesellschaft ist in der Gemeinde Schüttringen, Großherzogtum Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates können Niederlassungen und Zweigstellen sowohl im Großherzog-

tum Luxemburg als auch im Ausland errichtet werden.

Innerhalb der Gemeinde Schüttringen kann der Sitz der Gesellschaft durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates

verlegt werden. Die Verlegung des Gesellschaftssitzes außerhalb der Gemeinde Schüttringen kann nur durch Gesell-
schafterbeschluss und zu den Voraussetzungen einer Satzungsänderung erfolgen.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen jeder Art an in- und ausländischen Gesellschaften und

sonstige Vermögensanlagen jeder Art, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere
Weise, die Übertragung von Wertpapieren durch Verkauf, Tausch oder auf andere Weise sowie die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb und Verkauf von Grundeigentum/Immobilien im Großherzogtum

Luxemburg oder im Ausland, sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Grundeigentum/Immobilien, einschließlich der
direkten oder indirekten Beteiligung an luxemburgischen oder ausländischen Gesellschaften, deren Hauptzweck es ist,
Grundeigentum/Immobilien zu erwerben, zu entwickeln, zu fördern, zu verkaufen, zu verwalten und/oder zu vermieten.

Die Gesellschaft kann ferner für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder welche

der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Dritten gegenüber Garantien geben, Sicherheiten einräumen
um ihre Verpflichtungen oder die Verpflichtungen dieser Gesellschaften zu sichern, ihnen Kredite gewähren oder sie auf
andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher und finanzieller Natur oder im Zusammenhang

mit gewerblichem Rechtsschutz vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 4. Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt.

Gesellschaftskapital

Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt NEUNZIGTAUSEND EURO (90‘000.- EUR) und ist eingeteilt in NEUNTAU-

SEND (9‘000) voll eingezahlte Aktien mit einem Nennwert von je ZEHN EURO (10.- EUR).

Das Gesellschaftskapital kann ein- oder mehrmals durch Ausgabe neuer Aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen oder

nach Umwandlung von freien Rücklagen in Aktienkapital durch Ausgabe von Gratisaktien beziehungsweise durch eine
Erhöhung des Nominalwertes bestehender Aktien erhöht werden.

Im Falle einer Ausgabe neuer Aktien haben die Aktionäre das Recht auf Zuteilung eines ihrem Anteil an dem bisherigen

Aktienkapital entsprechenden Teiles der neuen Aktien, sofern nicht ein entgegenstehender Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vorliegt. Dieses Recht wird bezüglich der Form, der Frist und der Bedingungen so ausgeübt, wie sie von
der Gesellschafterversammlung beschlossen worden ist.

Aktien

Art. 6. Die Aktien lauten auf den Namen oder den Inhaber, nach Wahl der Aktionäre, mit Ausnahme der Aktien, für

welche das Gesetz die Form von Namensaktien vorschreibt.

Im Falle von Namensaktien wird am Gesellschaftssitz ein Register der Namensaktien geführt, welches jedem Aktionär

zur Einsicht offen steht. Dieses Register enthält alle Angaben, welche von Artikel 39 des Gesetzes von 1915 vorgesehen
sind. Das Eigentum an Namensaktien wird durch die Eintragung in dieses Register festgestellt.

Die Gesellschaft erkennt nur einen Eigentümer pro Aktie an; sollte der Besitz einer Aktie geteilt oder streitig sein,

müssen diejenigen, die ein Recht auf die Aktie geltend machen, einen einzigen Bevollmächtigten ernennen um die Aktie
bei der Gesellschaft zu vertreten. Die Gesellschaft kann den Gebrauch aller Rechte bezüglich dieser Aktie einstellen,
solange nicht eine einzige Person zum Besitzer der Aktie im Verhältnis zur Gesellschaft ernannt worden ist.

Die Inhaberaktien unterliegen einer Hinterlegung gemäß Artikel 42 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften.

An Stelle von Einzelaktien können Zertifikate über eine Mehrzahl von Aktien aufgestellt werden, nach Wahl der Ak-

tionäre.

Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingung ihre eigenen Aktien

erwerben.

44039

L

U X E M B O U R G

Verwaltungsrat

Art. 7. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens drei Mitgliedern verwaltet, deren Mitglieder

nicht Aktionäre zu sein brauchen. Die Gesellschaft, die bei der Gründung nur einen Aktionär hat oder wo die Haupt-
versammlung später feststellt, dass nur noch ein Aktionär alle Aktien hält, kann durch einen Verwaltungsrat mit nur einem
Mitglied verwaltet werden.

Die  Amtszeit  der  Verwaltungsratsmitglieder  darf sechs  Jahre nicht überschreiten;  die Wiederwahl  ist zulässig. Sie

können von der Generalversammlung jederzeit abberufen werden.

Scheidet ein durch die Generalversammlung der Aktionäre ernanntes Verwaltungsratsmitglied vor Ablauf seiner Amts-

zeit  aus,  so  können  die  auf  gleiche  Art  ernannten  verbleibenden  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  einen  vorläufigen
Nachfolger bestellen. Die nächstfolgende Hauptversammlung nimmt die endgültige Wahl vor.

Art. 8. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirkli-

chung  des  Gesellschaftszweckes  notwendig  sind  oder  diesen  fördern.  Alles,  was  nicht  durch  das  Gesetz  oder  die
gegenwärtige Satzung der Hauptversammlung vorbehalten ist, fällt in den Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsrates.

Wenn die Gesellschaft einen Verwaltungsrat mit nur einem Mitglied hat, so hat auch dieses Mitglied allein die wei-

testgehenden Befugnisse, alle Handlungen vorzunehmen, welche zur Verwirklichung des Gesellschaftszweckes notwendig
sind oder diesen fördern.

Der Verwaltungsrat muss aus seiner Mitte einen Vorsitzenden bestellen; in dessen Abwesenheit muss der Vorsitz

einem anwesenden Verwaltungsratsmitglied übertragen werden.

Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrzahl seiner Mitglieder anwesend oder vertreten ist. Die

Vertretung durch ein entsprechend bevollmächtigtes Verwaltungsratsmitglied, die schriftlich, telegraphisch oder ferns-
chriftlich erfolgen kann, ist gestattet. In Dringlichkeitsfällen kann die Abstimmung auch durch einfachen Brief, Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopierer erfolgen.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates können einstimmig durch Zirkularbeschluss gefasst werden. Die Zustimmung

muss schriftlich erfolgen und wird dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung beigefügt.

Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die

Stimme des Vorsitzenden.

Gemäß Artikel 60 kann der Verwaltungsrat seine Befugnisse hinsichtlich der laufenden Geschäftsführung sowie die

diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft an einen oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäfts-
führer oder andere Bevollmächtigte übertragen, die einzeln oder gemeinschaftlich handeln können und nicht Aktionäre
zu sein brauchen. Der Verwaltungsrat beschließt ihre Ernennung, ihre Abberufung und ihre Befugnisse. Bei der Übertra-
gung der laufenden Geschäftsführung an einzelne seiner Mitglieder verpflichtet sich der Verwaltungsrat, der jährlichen
Hauptversammlung Bericht zu erstatten über alle Gehälter, Dienstbezüge und sonstige, dem Befugten zugestandenen
Vorteile. Die Gesellschaft kann auch spezielle Mandate durch beglaubigteoder Privatvollmacht übertragen.

Die Gesellschaft wird durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei Mitgliedern des Verwaltungsrates oder durch

die Einzelunterschrift des Bevollmächtigten des Verwaltungsrates rechtsgültig verpflichtet. Wenn die Gesellschaft einen
Verwaltungsrat mit nur einem (1) Mitglied hat, so ist dieses Mitglied alleine zeichnungsberechtigt.

Aufsicht

Art. 9. Mit der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Gesellschaft werden ein oder mehrere Kommissare

betraut, die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Generalversammlung bestellt den bzw. die Kommissare
und legt deren Amtsdauer fest, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.

Die  Generalversammlung  kann  den  bzw.  die  Kommissare  jederzeit  abberufen.  Der  bzw.  die  Kommissare  können

wiedergewählt werden.

Gesellschafterversammlung

Art. 10. Die Gesellschafterversammlung befindet über alle Angelegenheiten, die laut Gesetz oder Satzung in ihre Zus-

tändigkeit fallen.

Insbesondere sind der Gesellschafterversammlung folgende Befugnisse vorbehalten:
a) die Satzung zu ändern;
b) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu bestellen und abzuberufen und ihre Vergütungen festzusetzen;
c) die Berichte des Verwaltungsrats entgegenzunehmen;
d) die jährliche Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zu genehmigen;
e) die Mitglieder des Verwaltungsrats zu entlasten;
f) über die Verwendung des Jahresergebnisses zu beschließen;
g) die Gesellschaft aufzulösen.

Art. 11. Am zweiten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um 11.00 Uhr findet die ordentliche Gesellschafter-

versammlung der Aktionäre am Sitz der Gesellschaft oder an einem andern in der Einladung angegebenen Ort statt. Fällt

44040

L

U X E M B O U R G

dieser Tag auf einen Tag, der nicht Bankarbeitstag ist, wird die Gesellschafterversammlung am nächsten Bankarbeitstag
abgehalten.

Art. 12. Es können jederzeit weitere Gesellschafterversammlungen an beliebigen Orten innerhalb des Großherzogtums

Luxemburg einberufen werden.

Gesellschafterversammlungen einschließlich der jährlichen Gesellschafterversammlung können auch im Ausland abge-

halten werden, wenn die Geschäftsführung dies aus Gründen der höheren Gewalt beschließt; eine solche Entscheidung
ist unanfechtbar.

Art. 13. Die Gesellschafterversammlung kann durch den Verwaltungsrat einberufen werden. Sie muss mit einer Frist

von einem Monat einberufen werden, wenn Aktionäre, die mindestens ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals ver-
treten, dies in einem schriftlichen die Tagesordnung enthaltenden Gesuch an den Verwaltungsrat verlangen.

Art. 14. Die Einberufungen zu Gesellschafterversammlungen erfolgen gemäss Artikel 70 des Gesetzes über die Han-

delsgesellschaften vom 10. August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze.

Im Falle von Namensaktien können die Generalversammlungen durch Einschreibebriefe an alle Namensaktionäre ein-

berufen werden. Die Einberufungsfrist beträgt mindestens acht (8) Kalendertage.

Sind alle Aktionäre anwesend oder vertreten und verzichten auf das Einberufungsverfahren, so kann die Generalver-

sammlung auch ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Die Tagesordnung der Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat festgelegt. Aktionäre, die zusammen mindestens

ein Zehntel (1/10) des Gesellschaftskapitals vertreten, können vor der Einberufung der Generalversammlung die Auf-
nahme einzelner Punkte auf die Tagesordnung verlangen.

Vorsitzender der Generalversammlung ist der Vorsitzende des Verwaltungsrates oder, bei seiner Verhinderung, ein

stellvertretender Vorsitzender, ein sonstiges Mitglied des Verwaltungsrates oder eine sonst von der Generalversammlung
bestimmte Person. Der Vorsitzende ernennt einen Schriftführer und die Aktionäre wählen einen Stimmenprüfer.

Art. 15. Jeder Aktionär ist berechtigt, an der Gesellschafterversammlung teilzunehmen.
Ein Aktionär kann sich aufgrund einer Vollmacht, die auch privatschriftlich erteilt werden kann, durch einen anderen

Aktionär oder durch einen Dritten für eine beliebige Zahl von Aktien vertreten lassen.

Art. 16. Vorbehaltlich der durch das Gesetz vorgesehenen Einschränkungen gibt jede Aktie Anrecht auf eine Stimme.

Beschlüsse, die keine Satzungsänderung zum Gegenstand haben, können auch dann gültig gefasst werden, wenn nicht die
Hälfte der Aktionäre anwesend oder vertreten ist.

Mitglieder des Verwaltungsrates sind bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder nicht stimm-

berechtigt. Sie dürfen sich dabei auch nicht durch Dritte vertreten lassen.

Rechnungslegung - Jahresergebnis

Art. 17. Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember desselben Jahres.

Art. 18. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat ein Inventar mit der Angabe der beweglichen

und unbeweglichen Werte und ein Verzeichnis aller Forderungen und Verbindlichkeiten. Außerdem sind die Verbind-
lichkeiten der Geschäftsführer und der Mitglieder des Verwaltungsrats gegenüber der Gesellschaft anzugeben.

Der Verwaltungsrat stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung mit den erforderlichen Abschreibungen

auf.

Jährlich wird wenigsten ein Zwanzigstel des Reingewinns vorweg dem gesetzlichen Reservefonds zugewiesen, bis der

Reservefonds den zehnten Teil des Gesellschaftskapitals erreicht hat.

Art. 19. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung müssen binnen eines Monats nach ihrer Genehmigung durch

die Gesellschafterversammlung durch den Verwaltungsrat gemäss Artikel 75 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften
vom 10. August 1915 einschließlich der Änderungsgesetze zur Veröffentlichung eingereicht werden.

Im Anschluss an die Bilanz werden Namen, Vornamen, Beruf und Wohnsitz der zu diesem Zeitpunkt amtierenden

Mitglieder des Verwaltungsrats und etwaige Neuernennungen veröffentlicht sowie die von der Gesellschafterversammlung
beschlossene Verwendung des Gewinns.

Art. 20. Falls die Gesellschafterversammlung beschließt, ausschüttbare Beträge zu verteilen, so entfallen sie gleichmäßig

auf die ausgegebenen Aktien.

Liquidation

Art. 21. Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden, welcher

unter den gleichen Bedingungen gefaßt werden muß wie bei Satzungsänderungen.

Zur Liquidation wird ein oder werden mehrere Liquidator (en) durch die Gesellschafterversammlung bestellt, die

dessen/deren Befugnisse und Vergütung festsetzt.

Art. 22. Nach Zahlung aller Schulden und Lasten der Gesellschaft dient der verbleibende Restbetrag zur Rückzahlung

der auf die Aktien geleisteten Zahlungen.

44041

L

U X E M B O U R G

Schlussbestimmung

Art. 23. Ergänzend verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des Gesetzes über die Handelsgesellschaft vom 10.

August 1915, einschließlich der Änderungsgesetze.“

<i>Dritter Beschluss

Der Aktionär beschließt, mit sofortiger Wirkung, den Rücktritt der Herren Eric DUPHIL und Karl Heinz WIRTH, in

ihrer Eigenschaft als noch Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft anzunehmen und beschließt denselben volle und
gänzliche Entlastung für die Ausübung ihrer betreffenden Ämter, bis zum heutigen Tage, zu erteilen.

Demzufolge wird Frau Ursula GILPIN, geborene WIRTH, Gesellschaftsdirektorin, berufsansässig in 4, rue Hoimesbuch,

L-5371 Schüttringen, als alleinige Gesellschaftsverwalterin (“administrateur unique“) der Gesellschaft „WIRTH INVEST-
MENTS S.A.“ bestätigt; ihr Mandat endigt bei der ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2020.

Des Weiteren wird ihr Mandat als Delegiertes Verwaltungsratsmitglied („administrateur-délégué“) das noch bis zur

ordentlichen Gesellschafterversammlung der Aktionäre des Jahres 2020 laufen soll, ebenso, mit sofortiger Wirkung, nie-
dergelegt.

Das Mandat des alleinigen Verwalters (“administrateur unique“) endet jedoch bei der jährlichen Generalversammlung

nach der Feststellung und Bestätigung der Existenz von mehr als einem Aktionär.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg-Stadt, Großherzogtum Luxemburg, Im Jahre, Monate und am Tage,

wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung hat die vorgenannte Bevollmächtigte, zusammen mit Uns dem amtierenden Notar die vorliegende

Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: S. HACKEL, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 12. Februar 2015. Relation: EAC/2015/3630. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-

EUR).

<i>Der Einnehmer (gezeichnet): SANTIONI.

Référence de publication: 2015032881/238.
(150035976) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Accord International Holdings S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 48, boulevard Grande Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 193.393.

<i>Rectificatif du dépôt L150011209 déposé le 19/01/2015

In the year two thousand and fifteen, on the eleventh day of February.
Before Us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Accord Group Holdings LLC., a limited liability company incorporated and existing under the laws of Delaware,

having its principal address at 600 Montgomery Street, 17 

th

 Floor, San Francisco, CA 94111, and registered with the

State of Delaware, Division of Corporations, under number 5309314 (Accord LLC),

here represented by Solange Wolter-Schieres, notary’s clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal, and

2.  Lakestar  Capital  LLP,  a  limited  liability  partnership  registered  in  England  and  Wales  under  company  number

OC371829, whose registered office is at 30 Percy Street, London, W1T 2DB (Lakestar),

here represented by Solange Wolter-Schieres, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

(Accord LLC and Lakestar are collectively referred to as the Shareholders).
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following:

<i>Agenda

The agenda of the meeting is as follows:
1) Waiver of the convening notices;
2) Decision to correct the deed of Maître Henri Hellinckx of 17 December 2014 (the Deed) amending the articles of

association of Accord International Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsa-
bilité limitée), having its registered office at 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number 193.393 (the
Company); and

44042

L

U X E M B O U R G

3) Miscellaneous.
Now, therefore, the Shareholders, acting through their proxyholders, have requested the undersigned notary to record

the following resolutions:

<i>First resolution

The entirety of the share capital of the Company being represented at the present meeting, the Shareholders waive

any convening notice requirement, consider the meeting as duly convened, and declare having perfect knowledge of the
meeting’s agenda, which has been communicated to them in advance.

<i>Second resolution

The Shareholders note that the FOURTH RESOLUTION of the minute of the extraordinary general meeting held

before the undersigned notary on 17 December 2014, registered in Luxembourg, Actes Civils, on 29 December 2014,
Relation:LAC/2014/63692, filed with the Trade and Company Register on 19 January 2015 number L150011209, not yet
published in the Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C reads:

“The Meeting resolves to increase the share capital of the Company from its present amount of seventeen thousand

United States Dollars (USD 17,000), up to nineteen thousand one hundred and one United States Dollars (USD 19,101.-)
by way of issuance of:

- one hundred and ninety-six thousand two hundred and eight (196,208) class A2 shares with a nominal value of one

United States Dollars cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class B2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class C2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class D2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class E2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class F2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class G2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class H2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class I2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class J2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each,

all in registered form.”
The Shareholders note it was wrongly stated that the Company issued an amount of one hundred and ninety-six

thousand two hundred and eight (196,208) class A2 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD
0.01) each.

The Shareholders note that the amount of class A2 shares issued by the Company should be as follows: “one hundred

and ninety-six thousand one hundred and ninety-five (196,195) class A2 shares with a nominal value of one United States
Dollars cent (USD 0.01) each”.

Thereupon, the Shareholders decide to rectify the part “Subscription -Payment” in the Deed, to read, with effect ex

tunc (thus as of 17 December 2014, being the date of the amendment of the articles of association of the Company), as
follows:

“Lakestar  Capital  LLP,  a  limited  liability  partnership  registered  in  England  and  Wales  under  company  number

OC371829, whose registered office is at 30 Percy Street, London, W1T 2DB (Lakestar) declares to subscribe to:

- one hundred and ninety-six thousand one hundred and ninety-five (196,195) class A2 shares with a nominal value of

one United States Dollars cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class B2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class C2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class D2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

44043

L

U X E M B O U R G

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class E2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class F2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class G2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class H2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class I2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- one thousand five hundred and forty-five (1,545) class J2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each,

all in registered form, and to fully pay them up by way of a contribution in cash consisting of an amount of two thousand

one hundred and one United States Dollars (USD 2,101) (the Contribution), it being understood that the Contribution
shall be allocated to the nominal share capital of the Company.

The aggregate amount of two thousand one hundred and one United States Dollars (USD 2,101) is forthwith at the

free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, who expressly acknowledges
it, by way of a blocking certificate.”

<i>Third resolution

The Shareholders subsequently resolve to amend article 5.1 of the articles of association of the Company, which shall

henceforth read as follows:

“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at nineteen thousand one hundred and one United States Dollars (USD 19,101), represented

by one million nine hundred and ten thousand one hundred (1,910,100) shares with a nominal value of one United States
Dollars cent (USD 0.01) each, all subscribed and fully paid up, which are divided into:

- one million seven hundred and eighty-three thousand six hundred and ninety-five (1,783,695) class A shares with a

nominal value of one United States Dollars cent (USD 0.01) each (the Class A Shares) divided into two sub-classes being:

* one million five hundred and eighty-seven thousand five hundred (1,587,500) class A1 shares with a nominal value of

one United States Dollars cent (USD 0.01) each; and

* one hundred ninety-six thousand one hundred and ninety-five (196,195) class A2 shares with a nominal value of one

United States Dollars cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand fourty-five (14,045) class B shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class B Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class B1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class B2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class C shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class C Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class C1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class C2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class D shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class D Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class D1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class D2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class E shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class E Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class E1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class E2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

44044

L

U X E M B O U R G

- fourteen thousand forty-five (14,045) class F shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class F Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class F1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class F2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class G shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class G Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class G1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class G2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class H shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class H Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class H1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class H2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class I shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class I Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class I1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and forty-five (1,545) class I2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each;

- fourteen thousand forty-five (14,045) class J shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each (the Class J Shares) divided into two sub-classes being:

* twelve thousand five hundred (12,500) class J1 shares with a nominal value of one United States Dollars cent (USD

0.01) each; and

* one thousand five hundred and fourty-five (1,545) class J2 shares with a nominal value of one United States Dollars

cent (USD 0.01) each.”

<i>Declaration

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, such proxyholder signed together with

the undersigned notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le onze février.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1. Accord Group Holdings LLC., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Delaware,

ayant son adresse principale au 600 Montgomery Street, 17 

ème

 Etage, San Francisco, CA 94111, et enregistrée dans l’Etat

du Delaware, Division of Corporations, sous le numéro 5309314 (Accord LLC);

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.

2.  Lakestar  Capital  LLP,  une société  à  responsabilité  limitée  enregistrée  en Angleterre et  Ecosse sous le  numéro

OC371829, dont l’adresse professionnelle est au 30 Percy Street, London, W1T 2DB (Lakestar),

ici représentée par Solange Wolter-Schieres, prénommée, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Lesquelles procurations resteront, après avoir été signée ne varietur par le(s) mandataire(s) des parties comparantes

et le notaire instrumentant, annexées au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

(Accord LLC et Lakestar sont collectivement les Associés).
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:

44045

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

L’ordre du jour est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Décision de corriger l’acte de Maître Henri Hellinckx daté du 17 décembre 2014 (l’Acte) par lequel les statuts de

Accord International Holdings S.à r.l, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 48, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro 193.393 (la Société) ont été modifiés;

3. Divers.
A présent, les Associés, agissant par le biais de leurs représentants, ont requis le notaire instrumentant d’acter les

résolutions suivantes:

<i>Première résolution

La totalité du capital social de la Société étant représentée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, les

Associés représentés à l’assemblée se considérant eux-mêmes comme ayant été dûment convoqués et déclarant avoir
une parfaite connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution

Les Associés constatent que la Quatrième résolution du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire tenue

pardevant le notaire instrumentant en date du 17 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre
2014, Relation:LAC/2014/63692, déposée au Registre de Commerce et des Sociétés en date du 19 janvier 2015 numéro
L150011209, non encore publié au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations Cx-e l’Acte se lit comme suit:

«L’Assemblée décide d’augmenter capital social de la Société de son montant actuel de dix-sept mille Dollars Améri-

cains (USD 17.000), pour le porter à un montant de dix-neuf mille cent un Dollar Américain (USD 19.101) par l’émission
de:

- cent quatre-vingt-seize mille deux cent huit (196.208) parts sociales de classe A2 ayant une valeur nominale de un

cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe B2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe C2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe D2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe E2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe F2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe G2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe H2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe I2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune; et

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe J2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune,

toutes sous forme nominale.»
Les Associés constatent qu’il a été indiqué, de manière erronée, que la Société a émis un montant de cent quatre-

vingt-seize mille deux cent huit (196.208) parts sociales de classe A2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar
Américain (USD 0,01) chacune.

Les Associés constatent que le montant de parts sociales de classe A2 émis par la Société aurait dû être le suivant:

«cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-quinze (196.195) parts sociales de classe A2 ayant une valeur nominale
de un cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune».

En conséquent, les Associés décident de rectifier la partie «Souscription -Libération» de l’Acte, afin qu’il se lise comme

suit, avec effet ex tunc (donc avec effet au 17 décembre 2014, étant la date de modification des statuts de la Société):

«Lakestar Capital Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée en Angleterre et Ecosse sous le numéro

OC371829, dont l’adresse professionnelle est au 30 Percy Street, London, W1T 2DB (Lakestar), déclare souscrire à:

- cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-quinze (196.195) parts sociales de classe A2 ayant une valeur nominale

de un cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune;

44046

L

U X E M B O U R G

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe B2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe C2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe D2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe E2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe F2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe G2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe H2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe I2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune; et

- mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe J2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune,

toutes sous forme nominale, et les libérer entièrement par un apport en espèce consistant en un montant de deux

mille cent un Dollar Américain (USD 2.101) (l’Apport), étant entendu que l’Apport sera alloué au compte du capital social
nominal de la Société.

Le montant total de un montant de deux mille cent un Dollar Américain (USD 2.101) est immédiatement à la libre

disposition de la Société, dont la preuve a été apportée au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément, par un
certificat de blocage.»

<i>Troisième résolution

En conséquent, les Associés décident de modifier l’article 5.1 des statuts de la Sociétés, qui aura désormais la teneur

suivante:

« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à dix-neuf mille cent un Dollars Américains (USD 19.101), représenté par un million neuf

cent dix mille cent (1.910.100) parts sociales sous forme nominative ayant une valeur nominale de un cent de Dollar
Américain (USD 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, divisées en:

- un million sept cent quatre-vingt-trois mille six cent quatre-vingt-quinze (1.783.695) parts sociales de classe A ayant

une valeur nominale de un cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Class A), divisée en deux
sous-classes:

* un million cinq cent quatre-vingt-sept mille cinq cent (1.587.500) parts sociales de classe A1 ayant une valeur nominale

de un cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune; et

* cent quatre-vingt-seize mille cent quatre-vingt-quinze (196.195) parts sociales de classe A2 ayant une valeur nominale

de un cent de Dollar Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe B ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe B), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe B1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe B2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe C ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe C), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe C1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe C2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe D ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe D), divisée en deux sous-classes:

*douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe D1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe D2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

44047

L

U X E M B O U R G

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe E ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe E), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe E1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe E2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe F ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe F), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe F1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe F2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe G ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe G), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe G1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe G2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe H ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe H), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe H1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe H2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe I ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe I), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe I1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe I2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune;

- quatorze mille quarante-cinq (14.045) parts sociales de classe J ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune (les Parts Sociales de Classe J), divisée en deux sous-classes:

* douze mille cinq cents (12.500) parts sociales de classe J1 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar Américain

(USD 0,01) chacune; et

* mille cinq cent quarante-cinq (1.545) parts sociales de classe J2 ayant une valeur nominale de un cent de Dollar

Américain (USD 0,01) chacune.

5.2. Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l’associé unique ou, le cas échéant, de l’assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification
des Statuts.»

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la requête des parties

comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu’en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, rédigé et passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au représentant, ledit représentant a signé avec le notaire instrumentant, le

présent acte.

Signé: S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C. 1, le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4961. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015032911/356.
(150036987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

44048

L

U X E M B O U R G

WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 61.025.000,00.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 108.492.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of December,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l., a

private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 108.492 and having a share capital
of USD 56,025,000 (the Company). The Company was incorporated on 26 May 2005 pursuant to a deed of Maître Joseph
Elvinger, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed has been published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations C - N° 1086 of 24 October 2005 and whose articles of association (the Articles)
have been amended several times and for the last time on 4 November 2014 pursuant to a deed of Maître Marc Loesch,
notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et
Associations C - number 3817 of 10 December 2014.

THERE APPEARED:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated

under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 124, Boulevard de la Pétrusse in L-2330
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of USD 5,140,008,810 and registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under the number B 79018 (the Sole
Shareholder),

hereby represented by Adrien Pastorelli, Attorney-at-law, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given in Luxembourg, on 22 December 2014;
The power of attorney from the Sole Shareholder, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on

its behalf and by the undersigned notary, shall remain attached to the present deed, to be filed with such deed with the
registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all of the issued and subscribed share capital of the Company which is set at USD

56,025,000  (fifty-six  million  twenty-five  thousand  United  States  Dollars)  represented  by  560,250  (five  hundred  sixty
thousand two hundred fifty) shares, having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each; and
that the entirety of the share capital is thus duly represented at the Meeting which is consequently regularly constituted
and may deliberate upon the items on the agenda, reproduced hereinafter.

II. That the agenda of the meeting is the following:
1. Waiver of the convening notice;
2. Increase of the nominal share capital of the Company by a nominal amount USD 5,000,000 (five million United States

Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 56,025,000 (fifty-six million twenty-five
thousand United States Dollars), divided into 560,250 (five hundred sixty thousand two hundred fifty) shares having each
a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) to an amount of USD 61,025,000 (sixty-one million twenty-
five thousand United States Dollars), represented by 610,250 (six hundred ten thousand two hundred fifty) shares having
each a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) by way of the issuance of 50,000 (fifty thousand) new
shares of the Company, together with a share premium in an amount of USD 45,000,000 (forty-five million United States
Dollars);

3. Subscription to and payment by the Sole Shareholder of the share capital increase specified under item 2. above by

way of a contribution in cash of USD 50,000,000 (fifty million United States Dollars);

4. Subsequent amendment of article 4 of the Articles in order to reflect the above share capital increase; and
5. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above-mentioned changes with power and

authority given to any manager of the Company or any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société en commandite
simple, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company
of the newly issued shares, and to see to any formalities in connection therewith.

III. That the Sole Shareholder, after deliberation, passed the following resolutions:

44049

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening notice,

the Sole Shareholder considering itself as duly convened and declaring having perfect knowledge of the agenda which has
been communicated to it in advance.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to increase the nominal share capital of the Company by a nominal amount of USD 5,000,000

(five million United States Dollars) in order to bring the share capital from its present amount of USD 56,025,000 (fifty-
six million twenty-five thousand United States Dollars), divided into 560,250 (five hundred sixty thousand two hundred
fifty) shares having each a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars) to an amount of USD 61,025,000
(sixty-one million twenty-five thousand United States Dollars), represented by 610,250 (six hundred ten thousand two
hundred fifty) shares having each a par value of USD 100 (one hundred United States Dollars), by way of issuance of
50,000 (fifty thousand) new ordinary shares having a nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) each
(the New Shares), together with a share premium in an amount of USD 45,000,000 (forty-five million United States
Dollars); and the Meeting resolves to issue the New Shares.

<i>Third resolution

The Meeting resolves to record the subscription to and the full payment of the above share capital increase as follows:

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, prenamed, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to the New Shares

and (ii) to fully pay them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of USD 50,000,000 (fifty million
United States Dollars) (the Contribution in Cash).

The Contribution in Cash shall be allocated as follows:
(i) the amount of USD 5,000,000 (five million United States Dollars) is to be allocated to the nominal share capital

account of the Company;

(ii) the amount of USD 45,000,000 (forty-five million United States Dollars) is to be allocated to the share premium

reserve of the Company.

The amount of the Contribution in Cash is forthwith at the free disposal of the Company, evidence of which has been

given to the undersigned notary by means of a blocking certificate (the Blocking Certificate).

<i>Fourth resolution

The Meeting resolves to amend article 4 of the Articles in order to reflect the above resolutions so that it reads

henceforth as follows:

“ Art. 4. Capital. The Company's subscribed share capital is set at USD 61,025,000 (sixty-one million twenty-five

thousand United States Dollars), represented by 610,250 (six hundred ten thousand two hundred fifty) shares having a
nominal value of USD 100 (one hundred United States Dollars) per share.

The subscribed share capital may be changed at any time by resolution of the shareholders' meeting deliberating in

the manner provided for amendments to the Articles.”

<i>Fifth resolution

The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers

and authorizes any manager of the Company and any lawyer or employee of Allen &amp; Overy, société en commandite
simple, to proceed on behalf of the Company to the registration in the share register of the Company of the newly issued
shares and to see to any formalities in connection therewith.

<i>Estimate of costs

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately six thousand five hundred

euro (EUR 6,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same appearing party, it is stated
that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with us,

the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente décembre,
par devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

44050

L

U X E M B O U R G

s'est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social au 124, Boulevard de la Pétrusse in
L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 108.492 et ayant un capital social de 56.025.000 USD (la Société), constituée le 26 mai
2005 selon un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel
acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations - N° 1086 du 24 octobre 2005 et dont les statuts
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 4 novembre 2014 selon un acte de Maître Marc Loesch, notaire de
résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
- N° 3817 du 10 décembre 2014.

A COMPARU:

WPP Luxembourg Gamma S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

au 124, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et un capital social de 5.140.008.810
USD, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B79018 (l'Associé Unique),

ci-après représentée par Monsieur Adrien Pastorelli, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Luxembourg, le 22 décembre 2014.
La procuration de l'Associé Unique, après avoir été paraphée ne varietur par le mandataire agissant en son nom et

pour son compte et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec ledit acte
auprès des autorités compétentes.

L'Associé Unique, représenté tel que décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique détient la totalité du capital social de la Société s'élevant à 56.025.000 USD (cinquante-six

millions vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 560.250 (cinq cent soixante mille deux cent
cinquante) parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique)
chacune, l'intégralité du capital social de la Société est ainsi représentée, l'Assemblée Générale est par conséquent vala-
blement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour repris ci-après.

II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 5.000.000 USD (cinq millions de dollars des Etats-Unis

d'Amérique) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 56.025.000 USD (cinquante-six millions
vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 560.250 (cinq cent soixante mille deux cent cinquante)
parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) à un montant
de 61.025.000 USD (soixante-et-un millions vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique), représenté par 610.250
(six cent dix mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des
Etats-Unis d'Amérique) chacune, par voie d'émission de 50.000 (cinquante mille) nouvelles parts sociales de la Société,
ensemble avec une prime d'émission d'un montant de 45.000.000 USD (quarante-cinq millions de dollars des Etats Unis
d'Amérique);

3. Souscription et libération par l'Associé Unique de l'augmentation de capital social mentionnée ci-dessus au point 2

au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de 50.000.000 USD (cinquante millions de dollars des Etats-Unis
d'Amérique);

4. Modification consécutive de l'article 4 des statuts de la Société afin d'y refléter l'augmentation de capital social

mentionnée ci-dessus; et

5. Modification du registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et

autorité donnés à tout gérant de la Société et à tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy, société en commandite simple,
pour procéder au nom et pour le compte de la Société à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société des
parts sociales nouvellement émises, et d'accomplir toutes les formalités y relatives.

III. Qu'après délibération l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée renonce aux formalités de

convocation, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre
du jour qui leur a été communiqué à l'avance.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 5.000.000 USD (cinq millions de dollars

des  Etats-Unis  d'Amérique)  afin  de  porter  le  capital  social  de  la  Société  de  son  montant  actuel  de  56.025.000  USD
(cinquante-six millions vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 560.250 (cinq cent soixante
mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis
d'Amérique) à un montant de 61.025.000 USD (soixante et un millions vingt-cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique),
représenté par 610.250 (six cent dix mille deux cent cinquante) parts sociales ordinaires ayant une valeur nominale de

44051

L

U X E M B O U R G

100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune, par voie d'émission de 50.000 (cinquante mille) nouvelles
parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune (les
Nouvelles Parts Sociales), ensemble avec une prime d'émission d'un montant de 45.000.000 USD (quarante-cinq millions
de dollars des Etats Unis d'Amérique); et l'Assemblée décide d'émettre les Nouvelles Parts Sociales.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée approuve la souscription de l'augmentation de capital et sa libération de la manière suivante:

<i>Souscription - Libération

L'Associé Unique, susmentionné, représenté tel que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire aux Nouvelles Parts Sociales

et (ii) de les libérer entièrement au moyen d'un apport en numéraire de 50.000.000 USD (cinquante millions de dollars
des Etats-Unis d'Amérique) (l'Apport en Numéraire).

L'Apport en Numéraire devra être attribué comme suit:

(i) Un montant de 5.000.000 USD (cinq millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique) sera attribué au compte de

capital social de la Société;

(ii) Un montant de 45.000.000 USD (quarante-cinq millions de dollars des Etats Unis d'Amérique) sera attribué à la

réserve de prime d'émission de la Société.

Le montant total de l'Apport en Numéraire est par conséquent à l'entière disponibilité de la Société, comme en atteste

le certificat de blocage présenté au notaire instrumentaire (le Certificat de Blocage).

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide de modifier l'article 4 des Statuts afin d'y refléter les résolutions ci-dessus, de telle sorte qu'il aura

désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 61.025.000 USD (soixante et un millions vingt-

cinq mille dollars des Etats-Unis d'Amérique) représenté par 610.250 (six cent dix mille deux cent cinquante) parts sociales
ordinaires d'une valeur nominale de 100 USD (cent dollars des Etats-Unis d'Amérique) chacune.

Le capital souscrit pourra à tout moment être modifié moyennant résolution de l'assemblée générale des associés

délibérant comme en matière de modifications des Statuts»

<i>Cinquième résolution

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société de manière à refléter les modifications qui

précèdent et donne pouvoir et autorise tout gérant de la Société et tout avocat ou employé de Allen &amp; Overy, société
en commandite simple, afin de procéder individuellement, sous sa seule signature, au nom et pour le compte de la Société,
à l'inscription dans le registre des parts sociales de la Société des Nouvelles Parts Sociales et d'accomplir toutes les
formalités y relatives.

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais liés au présent acte s'élève à approximativement six mille cinq cents euros (EUR 6.500).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que le mandataire de l'Associé Unique l'a requis de

documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergences entre le texte anglais
et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiqué en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de l'Associé Unique, celui-ci a signé le présent acte original

avec le notaire soussigné.

Signé: A. Pastorelli, M. Loesch.

Enregistré à Grevenmacher A.C., le 8 janvier 2015. GAC/2015/265. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015032883/209.

(150035852) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

44052

L

U X E M B O U R G

Printvenue Asia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.763.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand

Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Trade and Companies’ Register under number B 177.038,

here represented by Mr Julien De Mayer, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany on 22 January 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 22 January 2015.

Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Printvenue Asia S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

44053

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

44054

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another 8 manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

44055

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

44056

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Asia Internet Holding S.à r.l., afo-

rementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.00).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.-.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of

Luxembourg.

2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited term:

44057

L

U X E M B O U R G

- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium, on 9 April 1982, residing professionally at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zweiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, avenue Pescatore, L-2324 Luxemburg,
eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177.038,

hier vertreten durch Herrn Julien De Mayer, private employee, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

ausgestellt in Berlin, Deutschland, am 22. Januar 2015 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 22. Januar 2015.

Besagte Vollmacht, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei und der Notarin ne varietur paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat die amtierende Notarin ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Printvenue Asia S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige
Artikel.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vorneh-

men, sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die
ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

44058

L

U X E M B O U R G

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder
jeden anderen gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und
übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss inner-

halb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Luxemburg
am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung zu
dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,

44059

L

U X E M B O U R G

welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder in schriftli-
chen Beschlussvorschlägen nicht erreicht wird, können die Gesellschafter ein weiteres Mal mit derselben Tagesordnung
einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Entscheidungen wer-
den  wirksam  mit  der  Mehrheit  der  wirksam  abgegebenen  Stimmen  gefasst,  unabhängig  vom  Anteil  des  durch  sie
vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die (ii) mindestens eine Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafter-
versammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige
Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Falle von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

44060

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit der
Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der Kate-
gorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

44061

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung,  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die Auflö-
sung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

44062

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft ist, ungeachtet seiner Kategorie, dazu ermächtigt, das Anteilin-

haberregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, im Namen des Alleingesellschafters alleine
zu unterzeichnen.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,00) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800,- geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und auf eine formelle Einberu-

fungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie B der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg;

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9. April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Partei und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welcher der Notarin mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2434. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 23. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015032673/588.
(150036084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

44063

L

U X E M B O U R G

Dias et Muller S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7450 Lintgen, 37, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 74.346.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Lintgen en date du 30 janvier

<i>2015

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires de la société Dias et Muller S.A.

qui s'est tenue en date du 30 janvier 2015, que:

L'assemblée Générale a décidé de nommer comme nouvel administrateur:
1. Madame Cindy GONCALVES AFONSO, salariée, née le 26 février 1987 à Luxembourg, demeurant à 39A, rue

Principale, L-7450 Lintgen.

Son mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2018.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour la société

Référence de publication: 2015033610/17.
(150038148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.

MP B S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 168.102.

EXTRAIT

Il résulte des délibérations et décisions de l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15

janvier 2015, que:

L’Assemblée générale prend acte de l’arrivée à échéance des mandats de tous les administrateurs à l’issue de la présente

réunion. Elle décide en conséquence de renouveler les mandats comme administrateurs de Monsieur Alain BERWICK,
ayant son adresse professionnelle au 45, boulevard Pierre Frieden L - 1543 Luxembourg et de Monsieur Marco GIOR-
GETTI ayant son adresse professionnelle au 3 rue Jean Piret L - 2350.

L'Assemblée générale décide de désigner comme nouvel administrateur Monsieur Paul Giorgetti ayant pour adresse

professionnelle L-2350 Luxembourg, 3 rue Jean Piret.

Les mandats des administrateurs prendront fin à l’issue de l’Assemblée générale statuant sur les comptes de l’exercice

2015.

L’Assemblée générale prend acte de l’arrivée à échéance du mandat de la société PricewaterhouseCoopers société

coopérative, en qualité de Réviseur d’entreprises agréé. Elle décide de nommer la société Fiduciaire d’Expertise Comp-
table  et  de  Révision  Everard-Klein  S.àr.l.,  domiciliée  83,  rue  de  la  Libération,  L  -  5969  Itzig,  en  qualité  de  Réviseur
d’entreprises agréé pour une période expirant à l’issue de l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes 2015.

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenue au siège social le 15 janvier 2015, que:
Le Conseil d’administration sur base de l’article 4 de statuts décide de transférer le siège social de la société au 3, rue

Jean Piret L - 2350 Luxembourg.

Il résulte des délibérations et décisions du Conseil d’administration tenue au siège social le 16 janvier 2015, que:
Le Conseil d’administration décide de désigner Monsieur Paul Giorgetti, ayant son adresse professionnelle au 3, rue

Jean Piret L - 2350 Luxembourg, comme Président du Conseil d’administration, pour une durée équivalente à celle de
son mandat d’administrateur..

Le Conseil d’administration décide de désigner Monsieur Marco Giorgetti, ayant son adresse professionnelle au 3, rue

Jean Piret L - 2350 Luxembourg, comme Administrateur-délégué de la société, pour une durée équivalente à celle de son
mandat d’administrateur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033255/34.
(150037286) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

44064


Document Outline

Accord International Holdings S.à.r.l.

Asia Global Invest S.à r.l.

Bilbao LuxCo S.A.

Bilbao MidCo S.à r.l.

Blicon S.A.

CDPS S.A.

Dias et Muller S.A.

Eagle 1 S.à r.l.

Eagle 3 S.à r.l.

Equiniti Group (Luxembourg) S.à r.l.

Flinders International SA

Ginestra S. à r.l.

GPE VI FIS GP S.à r.l.

Greeneden Lux 3 S.à r.l.

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l.

John Deere Funding S.A.

Jomeline Strategies S.A.

Kikerono Konzern S.A.

Klee S.A.

MLUX Beauty Products S.à r.l.

MP B S.A.

Navan Patrimoine S.A. SPF

Oben der Kirch s.à r.l.

Pacific Global Capital S.A.

Padaro S.A.

Pasco Immobilière S.A.

Peinture De Lorenzi Ed. et Fils Sàrl

Printvenue Asia S.à r.l.

Quest Diagnostics Intermediate Holdings S.à.r.l.

Staples Luxembourg S.à r.l.

Stayrooms S.à r.l.

Stericycle Europe S.à r.l.

Taurus Capital S.A.

Tech Data Luxembourg S.à.r.l.

TVA Trade S.à r.l.

Twelve Magnolia S.A.

Universe, The CMI Global Network Fund

Vauban Properties S.A.

Virtuoso Investment Holdings Luxembourg S.à r.l.

VSL S.A.

Wirth Investments S.A.

WME Ventures S.à.r.l.

WPP Luxembourg Gamma Three S.à r.l.

Yorktown Luxembourg S.à r.l.