This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 916
3 avril 2015
SOMMAIRE
Air International Thermal (Luxembourg)
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43932
Allamanda Investment S.A. . . . . . . . . . . . . .
43930
Alzette Securitisation S.A. . . . . . . . . . . . . . .
43931
Arenov S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43968
Arial Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43930
Aropa S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43929
Brehat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43968
Cavalli Room S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43929
CCIF Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43928
CIH Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43930
Dentsply SE S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43930
Digital Services Holding XXI s.à r.l. . . . . . .
43945
Duluth Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43942
Eagle 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43931
Etats d'Urgence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43940
Exair S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43922
Exair S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43922
Fondation pour la Promotion du Tennis au
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43931
Friolux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43925
GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l. . . . .
43925
G.M. Jardinage S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43925
Immobilière Ciel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43927
Immo Color S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43923
Impro Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43924
Jabil Luxembourg Manufacturing S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43926
JM' Agri Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43927
John Deere Funding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
43926
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A. . . . .
43935
Kehlen Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43923
Kepler Private Shareholders S.A. . . . . . . . .
43927
Kubrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43926
Latitude Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43922
Lingupedia Investments S. à r. l. . . . . . . . . .
43928
Logistis Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
43964
Maintenance and Technical Supplies and
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43928
Mangrove III S.C.A. SICAR . . . . . . . . . . . . . .
43933
Migan S.A.-SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43922
OCM Luxembourg ROF IV S.à r.l. . . . . . . .
43925
OCM Luxembourg SC Fund A S.à r.l. . . . .
43927
OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43963
Pepp2 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43929
Princess Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43924
Ratio Holdings Luxembourg S.C.A. . . . . . .
43924
Sete Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43923
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l. . . . .
43923
WAVECREST INTERNATIONAL LIMI-
TED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43929
43921
L
U X E M B O U R G
Exair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 116.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033644/10.
(150037549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Exair S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.
R.C.S. Luxembourg B 116.214.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033645/10.
(150037550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Migan S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-6783 Grevenmacher, 31, Op der Heckmill.
R.C.S. Luxembourg B 178.701.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue au siège de la société en date du 25 février 2015i>
LMS Services Sàrl, Société à responsabilité limitée, ayant son siège au 31, Op der Heckmill, L-6783 Grevenmacher,
inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B-169033 est nommée en tant que dé-
positaire des actions et parts au porteur.
Grevenmacher, le 25 février 2015.
Signature
<i>Administrateur Uniquei>
Référence de publication: 2015033798/14.
(150037755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Latitude Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 120.236.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairementi>
L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du président du Conseil d'ad-
ministration et d'un administrateur, à savoir:
- Monsieur Claude ZIMMER, Président du Conseil d'administration - administrateur, né le 18 juillet 1956 à Luxembourg,
domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
L'Assemblée Générale décide, à compter du 20 février 2015, de renouveler le mandat du commissaire aux comptes,
à savoir:
- ZIMMER & PARTNERS S.A., commissaire aux comptes, domicilié professionnellement au 50, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg, enregistré auprès du Registre de Commerce et de Sociétés Luxembourg sous le numéro B 151.507.
Son mandat expirera lors de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2017.
Extrait sincère et conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033753/20.
(150037412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43922
L
U X E M B O U R G
Immo Color S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2272 Howald, 27, rue Edouard Oster.
R.C.S. Luxembourg B 180.195.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033722/9.
(150037831) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Sete Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 166.382.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033912/9.
(150037800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Kehlen Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8290 Kehlen, 20, domaine de Brameschhof.
R.C.S. Luxembourg B 194.130.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 17 décembre 2014i>
<i>Décision:i>
Nommer Monsieur Philippe BUREL, né le 19 juin 1961 à Libourne (France), demeurant 20 Domaine du Brameschhof,
L-8290 Kehlen, Luxembourg, en tant que Président du Conseil d'Administration.
Philippe BUREL / Edouard BUREL
<i>Administrateur A / Administrateur Bi>
Référence de publication: 2015033736/13.
(150037425) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 262.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 132.498.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé uniquei>
L'associé unique accepte les démissions de Monsieur Jacob MUDDE, Monsieur Gérald WELVAERT, Monsieur Jorge
Lozano PEREZ et Monsieur Ian BAKER de leur mandat de gérant avec effet au 17 février 2015.
L'associé unique a décidé de nommer comme nouveaux gérants avec effet au 17 février 2015 pour une durée de six
ans:
- BALTISSIMO, sise au 29, Nijverheidslaan, B-8580 Avelgem, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises belges
sous le n° 0866.682.528;
- PARTICIMMO sise au 29, Nijverheidslaan, B-8580 Avelgem, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises belges
sous le n° 0838.744.449.
- Monsieur Filiep BALCAEN, entrepreneur, né à Waregem, Belgique, le 9 février 1960, demeurant au 52, Jacquet-
bosstraat, B-8587 Espierres-Helchin, Belgique
L'associé unique décide de transférer le siège social du 45, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg au 2, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
Luxembourg, le 17 février 2015.
Pour extrait
Référence de publication: 2015033948/23.
(150037558) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43923
L
U X E M B O U R G
Impro Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.
R.C.S. Luxembourg B 169.663.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la société Impro Europe S.à r.l. en date du 19 février 2015 que:
Monsieur Xiaodong ZHOU a démissionné de sa fonction de gérant de classe B et de gérant délégué à la gestion
journalière avec effet au 2 février 2015.
Madame Céline UMBDENSTOCK-BLANCHARD, née le 2 juin 1982 à Paris (France), demeurant professionnellement
à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, est nommée gérante de classe B et gérante déléguée à la gestion
journalière de la société en remplacement de Monsieur Xiaodong ZHOU avec effet au 2 février 2015 pour une durée
indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour IMPRO EUROPE S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015033709/17.
(150037375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Princess Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.
Capital social: EUR 131.250,00.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 62.055.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2015i>
- L'assemblée générale des actionnaires accepte à l'unanimité la démission de Monsieur Patrick WILWERT, né le 30
juillet 1977 à Luxembourg, demeurant professionnellement 10, rue Henri Schnadt à L-2530 Luxembourg de son poste
d'administrateur de la société.
- L'assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité de nommer au poste d'administrateur, en remplacement
de l'administrateur démissionnaire, Monsieur Stéphane DE MICHELE, né le 16 mars 1980 à Villerupt, demeurant profes-
sionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-Alzette pour une durée de 6 ans. Son mandat prendra fin à l'issue
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2021 statuant sur les comptes clos au 31.12.2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033881/18.
(150037578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Ratio Holdings Luxembourg S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 54.028.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 février 2015i>
- La démission de Monsieur Jean-Jacques GAASCH de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, avec effet
au 20 février 2015, est acceptée.
- Monsieur Serge VAN DE VELDE, né le 26 septembre 1974 à Wilrijk (Belgique), demeurant au 5 Minsaardstraat,
B-2000 Antwerpen est nommé nouveau membre du Conseil de Surveillance en remplacement de Monsieur Jean-Jacques
GAASCH. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.
- Les mandats des sociétés FIN-CONTROLE S.A., société anonyme, ayant son siège social au 12, rue Guillaume Kroll,
bâtiment F, L-1882 Luxembourg et FINDI SARL, société anonyme, ayant son siège social au 412F, Route d'Esch, L-2086
Luxembourg en tant que membres du Conseil de Surveillance sont reconduits pour une nouvelle période statutaire de
6 ans jusqu'à l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2021.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2015.
Certifié sincère et conforme
Référence de publication: 2015033891/19.
(150037373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43924
L
U X E M B O U R G
G.M. Jardinage S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4540 Differdange, 50, rue Dicks Lentz.
R.C.S. Luxembourg B 174.049.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033671/10.
(150037533) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Friolux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4437 Soleuvre, 11, rue de Differdange.
R.C.S. Luxembourg B 161.121.
Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033669/10.
(150037627) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
OCM Luxembourg ROF IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 153.334.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 25 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Callum Thorneycroft avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg ROF IV Sàrl
Référence de publication: 2015033834/12.
(150037472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.501,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 159.027.
<i>Résolutions prises par l'associé unique avec effet du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2015i>
Avec effet du 1
er
janvier 2015, l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
1. Approbation de la démission Mme. Jennika Temisa Enetiagi Lindholm comme gérante de la société avec effet du 1
er
janvier 2015.
2. Approbation de la démission Mr. Kemal Akyel comme gérant de la société avec effet du 1
er
janvier 2015.
3. Nomination de M. Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, dont l'adresse professionnelle est 12, rue
Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérant de la catégorie B de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015
pour une durée indéterminée.
4. Nomination de Mme. Elena Hadjifyntani, née le 2 octobre 1974 à Odessa, Ukraine, dont l'adresse professionnelle
est 12, rue Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérante de la catégorie A de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015pour une durée indéterminée.
5. Transfert du siège social de la société au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, avec effet immédiat.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015033680/22.
(150038005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43925
L
U X E M B O U R G
Jabil Luxembourg Manufacturing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.518.000,00.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 105.093.
En date du 23 février 2015, l'Associé Unique de la Société a pris les décisions suivantes:
- Réélection d'Ernst & Young S.A., ayant pour adresse professionnelle le 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall
2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché du Luxembourg, enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 47771, au poste de Réviseur d'Entreprise Agréé de la Société pour l'audit de l'année fiscale se terminant
au 31 August 2014 et qui auront lieu en 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Jabil Luxembourg Manufacturing S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015033726/17.
(150037390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
John Deere Funding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 101.958.
Madame Nathalie Prévost a démissionné de ses fonctions de commissaire aux comptes de John Deere Funding S.A.
(la «Société») avec effet au 31 octobre 2014.
Par décision en date du 03 février 2015, Monsieur Thierry Pierrette, avec adresse professionnelle au 43, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, a été désigné commissaire aux comptes de la Société avec effet au 31 octobre 2014
pour une durée se terminant à l'assemblée générale ordinaire qui doit se tenir en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 février 2015.
Thomas C. Spitzfaden
VP & Treasurer
Deere & Company
<i>Actionnaire principali>
Référence de publication: 2015033730/18.
(150037963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Kubrat, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 121.807.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 3 février 2015i>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de révoquer avec effet immédiat Mr Theo Uffing et Mr. Claude Zimmer de leur mandat de
gérants de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouveaux gérants de la société:
- Mr. Alexander Villaverde Zweegers, demeurant à 1 Hoeven, B-2275 Lille-Poederlee, Belgique.
- Mr. Hendrik Gerrit Brouwer, demeurant professionnellement à Antonio Vivaldistraat 60, 1083 HP Amsterdam, Pays-
Bas.
- Mr. Robert Shyirambere, demeurant professionnellement au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015033744/19.
(150038017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43926
L
U X E M B O U R G
JM' Agri Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3781 Tétange, 39, rue Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 172.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Référence de publication: 2015033733/10.
(150037819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
OCM Luxembourg SC Fund A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 189.893.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 4 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec et Mme Figen Eren avec effet du 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg SC Fund A Sàrl
Référence de publication: 2015033835/12.
(150038041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Immobilière Ciel S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 98.641.
RECTIFICATIF
Cette version remplace l'avis numéro L150000247 déposé en date du 2 janvier 2015.
Veuillez prendre note que la société à responsabilité limitée Intertrust (Luxembourg) S.à r.l., R.C.S. Luxembourg B
103123, a dénoncé le siège social établi dans ses locaux au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, de la société
anonyme IMMOBILIERE CIEL S.A., R.C.S. Luxembourg B 98641, avec effet au 2 janvier 2015.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Pour avis sincère et conforme
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015033724/15.
(150037669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Kepler Private Shareholders S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 143.014.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 16 décembre 2014, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
1. Nomination de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en
2020;
2. Acceptation de la démission d'Alan Dundon, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Lu-
xembourg de son mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Référence de publication: 2015033740/17.
(150038137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43927
L
U X E M B O U R G
M.T.S.S., Maintenance and Technical Supplies and Services, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 228-230, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 152.289.
EXTRAIT
Le conseil d'administration, en date du 13/02/2015, a nommé Monsieur Simon THEIS, expert-comptable, demeurant
professionnellement 39, Rue Haute à L-4963 Clémency à la fonction de dépositaire des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
M.T.S.S., Maintenance and Technical Supplies and Services, Société Anonyme
Thierry SCHREINER
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015033772/14.
(150037580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Lingupedia Investments S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.700,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 135.997.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 24 février 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Choui Min Kon Kam King, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, au mandat de gérant, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 31 décembre 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033759/15.
(150037338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
CCIF Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 185.274.
Il résulte des résolutions prises par les associés de la Société en date du 20 février 2015 que:
1. Les personnes suivantes ont démissionné de leur fonction de membres du conseil de gérance de la Société avec
effet au 20 février 2015:
- Monsieur Christopher Finn;
- Madame Barbara Imbs;
- CCIF GP, L.P.,
2. Les personnes suivantes ont été nommées en tant que nouveaux membres du conseil de gérance de la Société pour
une période illimitée, avec effet au 20 février 2015:
- Monsieur William Cagney, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- Monsieur Andrew Howlett-Bolton, avec adresse professionnelle au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
- CCIF Advisor S.à r.l., avec siège social au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg;
3. L'adresse de la Société est fixée au 2, avenue Charles de Gaulle, 4
ème
étage, L-1653 Luxembourg.
4. L'adresse professionnelle de Madame Erica K. Herberg, membre du conseil de gérance de la Société, est changée
comme suit: 57, Berkeley Square, Lansdowne House, W1J 6ER London, United Kingdom.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
CCIF Finance S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033571/25.
(150037999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43928
L
U X E M B O U R G
WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 193.395.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015034009/9.
(150037409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Aropa S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2167 Luxembourg, 21, rue des Muguets.
R.C.S. Luxembourg B 152.983.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015033520/11.
(150037440) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Pepp2 S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 248.794,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 112.497.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 de la société ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033874/12.
(150037991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Cavalli Room S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2552 Luxembourg, 5, rue de la Station.
R.C.S. Luxembourg B 124.557.
<i>Assemblée générale extraordinaire du 23.02.2015i>
A l'unanimité, les associés de la société précitée représentant l'intégralité du capital social se sont constitués en as-
semblée générale extraordinaire à laquelle ils se connaissent dûment convoqués, et après avoir constaté que celle-ci était
régulièrement constituée, ils ont pris à l'unanimité des voix les décisions suivantes:
1 -La vente de part de Monsieur CACCHIONE Marziale, pensionné, né à Serracapriola (Italie) le 26 février 1950,
demeurant à L-3321 Berchem 32, rue Oscar Roméro.
Soit quarante-cinq (45) parts sociales lui appartenant dans la Société à responsabilité limitée «Cavalli Room S.àR.L.»
à Monsieur LORUSSO Donato, salarié, né à Conversano (Italie) le 27 mai 1977, demeurant à L-1740 Luxembourg, 20,
rue d'Hollerich, qui accepte.
2 -Que suite à cette cession de parts sociales, les parts sociales sont réparties comme suit:
Monsieur LORUSSO Donato , prénommé, cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Total: cents parts sociales: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
3 - Monsieur CACCHIONE Marziale, prénommé démissionne de son poste de gérant technique.
4- La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée est clôturée.
Référence de publication: 2015033570/22.
(150037926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43929
L
U X E M B O U R G
Dentsply SE S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 182.101.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015033601/10.
(150037348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Arial Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.
R.C.S. Luxembourg B 144.956.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033518/10.
(150037815) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Allamanda Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 183.507.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société tenue le 10 décembre 2014i>
<i>Première résolutioni>
Le Conseil décide de nommer la société Omnes & Partners S.A. en sa qualité d'expert-comptable, ayant son siège
social au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 159.142 en tant qu'agent dépositaire, dans le cadre de la loi du 28 juillet 2014.
Référence de publication: 2015033509/12.
(150037561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
CIH Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.050,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 176.841.
EXTRAIT
Par résolutions prises en date du 9 février 2015, l'associé unique de la Société a décidé:
- d'accepter la démission d'Erik Adam de son poste de gérant de catégorie A de la Société avec effet immédiat; et
- de nommer Stéphanie Henrard, née le 4 avril 1984 à Verviers, Belgique, et ayant son adresse professionnelle au 75,
Parc d'Activités, 8308 Capellen, Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de catégorie A de la Société avec effet
immédiat et ce pour une durée indéterminée.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais constitué des personnes suivantes:
- Manfred Schneider, gérant de catégorie A;
- Nicolas Susgin, gérant de catégorie A;
- Stéphanie Henrard, gérant de catégorie A;
- David E. Klein, gérant de catégorie B; et
- Perry R. Humphrey, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033583/22.
(150037621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43930
L
U X E M B O U R G
Eagle 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1661 Luxembourg, 31, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 127.056.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033619/10.
(150037900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Alzette Securitisation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 190.961.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 24 février 2015i>
A3T S.A., RCSL B 158687, avec siège social au 44, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, est
nommée Réviseur de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de l'an 2017.
Pour extrait sincère et conforme
ALZETTE SECURITISATION S.A.
Référence de publication: 2015033490/12.
(150037667) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Fondation pour la Promotion du Tennis au Luxembourg, Fondation.
Siège social: Esch-sur-Alzette,
R.C.S. Luxembourg G 81.
<i>Bilan au 31 décembre 2014 (en EUR)i>
ACTIF
Notes
31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
C. ACTIF IMMOBILISE
II. Immobilisations corporelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(3)
1 673 426,35 1 857 186,22
D. ACTIF CIRCULANT
II. Créances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(4)
6 729,17
10 192,68
IV. Avoirs en banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(5)
1 771,41
7 721,46
8 500,58
17 914,14
1 681 926,93 1 875 100,36
PASSIF
A. CAPITAUX PROPRES
I. Capital souscrit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 478,94
2 478,94
V. Résultats reportés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-288 997,71 -300 479,72
VI. Résultat de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 325,25
11 482,01
VII. Subsides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(6)
1 688 178,17 1 875 12,46
VIII. Fonds social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134 949,42
134 949,42
1 551 934,07 1 723 743,11
C. DETTES
1. Dettes envers les établissements de crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(7)
90 398,21
125 409,64
2. Dettes sur achats et prestations de services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 258,34
17 864,70
3. Dettes fiscales et au titre de la Sécurité Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(8)
911,31
3 070,91
4. Autres dettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(9)
21 425,00
5 000,00
129 992,86
151 345,25
D. COMPTES DE REGULARISATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
12,00
1 681 926,93 1 875 100,36
43931
L
U X E M B O U R G
<i>Compte de Profits et Pertes du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier au 31 décembre 2014i>
A. CHARGES
Notes
2014
EUR
2013
EUR
2. b) Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(10)
60 255,25
63 220,65
3. Frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(11)
51 324,64
50 387,19
4. Corrections de valeur sur éléments de l'actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(12)
140,60
0,00
7. Intérêts et charges assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(13)
4 318,39
5 545,36
10. Charges exceptionnelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
13. Bénéfice de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 325,25
11 482,01
131 364,13 130 635,21
B. PRODUITS
2. Montant net du chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(14)
18 806,00
17 774,00
4. Autres produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(15)
112 500,00 112 500,00
7. Intérêts et produits assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(16)
58,13
0,00
9. Produits exceptionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
361,21
10. Perte de l'exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,00
0,00
131 364,13 130 635,21
<i>Budget 2015i>
Produits d'exploitation
Chiffre d'affaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 500,00€
Subventions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 500,00€
Subventions extraordinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PM
Total produits d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130 000,00€
Charges d'exploitation
Autres charges externes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 000,00€
Frais de Personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53 000,00€
Correct. de valeur s/frais d'établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PM
Total charges d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123 000,00€
Résultat d'exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 000,00€
Intérêts et charges assimilés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 000,00€
RESULTAT DE L'EXERCICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 000,00€
Esch/Alzette, le 26 janvier 2015.
Frenz Krecké / Chris Richartz
<i>Trésorier / Secrétairei>
Référence de publication: 2015032402/67.
(150035935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Air International Thermal (Luxembourg) Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.012.400,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 104.080.
<i>Extrait des résolutions d'associé unique du 26 février 2015i>
L'associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Jan Willem Overheul, né le 4 janvier 1982 à Neerijnen, Pays-Bas, demeurant professionnellement au 20
rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, en tant que gérant B de la Société avec effet au 26
février 2015 et pour une durée illimitée;
- d'attribuer une classe au mandat de gérance de Kei Hong Chua à savoir que Kei Hong Chua sera gérant de classe A
de la Société avec effet au 26 février 2015 et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Référence de publication: 2015033482/16.
(150037895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
43932
L
U X E M B O U R G
Mangrove III S.C.A. SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investis-
sement en Capital à Risque.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 140.749.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth of January.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Appears:
Frédérique Lefèvre, lawyer, residing professionally in Luxembourg, representing, by virtue of a proxy given under
private seal, MANGROVE III MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 140.594, a company organized and existing under
Luxembourg laws with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, in his capacity of “as-
socié-gérant-commandité” (the “Manager”) of the “société d’investissement en capital à risque” MANGROVE III S.C.A
SICAR, with registered office at L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, duly registered with the Luxem-
bourg Trade Register under section B number 140.749 (the “Company”). The Company was incorporated by a deed of
Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on July 17, 2008, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations dated August 22, 2008, number 2036 and modified by Extraordinary General Meetings by deeds of Maître
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, on September 2, 2008, on November 25, 2008, on June 25, 2009, on
September 16, 2009, on December 14, 2009, on July 6, 2010, on October 15, 2010, on April 18, 2011, on July 25, 2011,
on October 3, 2011, on December 15, 2011, October 3, 2012, February 19, 2013, May 16, 2013, August 12, 2013 and
April 30, 2014 published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 2361 dated September 26, 2008,
number 4 dated January 2, 2009, number 1458 dated July 25, 2009, number 2118 dated October 28, 2009, number 367
dated February 19, 2010, number 2137 dated October 11, 2010, number 2701 dated December 8, 2010, number 1481
dated July 6, 2011, number 2503 dated October 17, 2011, number 2915 dated November 29, 2011, number 456 dated
February 21, 2012, number 2690 dated November 3, 2012, number 932 dated April 19, 2013, number 1682 dated July
13, 2013, number 2559 dated October 15, 2013 and number 1856 dated July 17, 2014.
The Articles have been amended for the last time by a deed of the undersigned notary on November 13, 2014 published
in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 3909 dated December 17, 2014.
The Manager then declared and requested the notary to declare the following:
1. The issued capital of the Corporation is set at TWO HUNDRED ELEVEN THOUSAND EURO (EUR 211.000,-)
represented by ONE (1) fully paid-up Manager Share with a par value of THIRTY THOUSAND EURO (EUR 30.000),
ONE MILLION SEVEN HUNDRED TEN THOUSAND (1.710.000) fully paid-up Ordinary Shares, each with a par value
of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) per Share and by ONE HUNDRED THOUSAND (100.000) fully paid-up Participating
Shares with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) each.
2. According to Article 5 of the Articles of Incorporation, the authorized capital of the Company has been set up at
TWO HUNDRED TWENTY THOUSAND EURO (EUR 220.000.-) represented by ONE Manager’s Share held by the
Manager with a par value of THIRTY THOUSAND EURO (EUR 30.000.-), ONE MILLION EIGHT HUNDRED THOU-
SAND (1.800.000) Ordinary Shares with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) each and ONE HUNDRED
THOUSAND (100.000) Participating Shares, with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) each. The Manager has
been authorized to proceed to the increase in capital and Article 5 of the Articles of Incorporation will then be amended
in order to correspond to the increase in capital rendered effective.
3. In accordance with Article 5 of the Articles of Incorporation, the Manager has decided through the resolutions dated
November 27, 2014 to increase the issued capital of the Company by ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO
(EUR 1.800,-) to raise it from the present amount of TWO HUNDRED ELEVEN THOUSAND EURO (EUR 211.000,-)
to TWO HUNDRED TWELVE THOUSAND EIGHT HUNDRED EURO (EUR 212.800,-) through the issuance of EIGH-
TEEN THOUSAND (18.000) new Ordinary Shares with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) each, each entitled
to the same rights as the former ones, together with a total share premium of ONE MILLION SEVEN HUNDRED NINETY
EIGHT THOUSAND TWO HUNDRED EUROS (EUR 1.798.200.-).
The EIGHTEEN THOUSAND (18.000) new Ordinary Shares have been subscribed and fully paid in cash through
payment on a bank account in the name of MANGROVE III S.C.A., SICAR prenamed, so that the amount of ONE MILLION
EIGHT HUNDRED THOUSAND EUROS (EUR 1.800.000.-) has been put at the free disposal of the latter, evidence of
which has been given to the undersigned notary through the presentation of the supporting documents relating to such
payment.
Such increase having been effected within the limits of the authorized capital, the second paragraph of Article five of
the Articles of Incorporation shall be amended accordingly and shall read as follows:
“(b) the issued capital of the Corporation is set at TWO HUNDRED TWELVE THOUSAND EIGHT HUNDRED
EURO (EUR 212.800,-) represented by ONE (1) fully paid-up Manager Share with a par value of THIRTY THOUSAND
EURO (EUR 30.000), ONE MILLION SEVEN HUNDRED TWENTY EIGHT THOUSAND (1.728.000) fully paid-up Or-
dinary Shares, each with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) per Share and by ONE HUNDRED THOUSAND
(100.000) fully paid-up Participating Shares with a par value of TEN EURO CENTS (EUR 0,10) each.”
43933
L
U X E M B O U R G
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 4,500.-.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, the said person appearing signed together with the notary
the present deed.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt janvier.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
Frédérique Lefèvre, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, représentant, en vertu d’une procuration
sous seing-privé, MANGROVE III MANAGEMENT S.A., RCS Luxembourg B 140.594, une société régie par les lois du
Luxembourg avec siège social à L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, agissant en sa qualité d’associé-
gérant-commandité (le “Gérant”) de la société d’investissement en capital à risque MANGROVE III S.C.A. SICAR, ayant
son siège social à L-2535 Luxembourg, 20, Boulevard Emmanuel Servais, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés
à Luxembourg, Numéro B 140.749 (la “Société”). La Société a été constituée par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, le 17 juillet 2008, l’acte ayant été publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
en date du 22 août 2008, sous le numéro 2036 et les statuts en ont été modifiés par Assemblées Générales Extraordinaires
pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 2 septembre 2008, du 25 novembre
2008, du 25 juin 2009, du 16 septembre 2009, du 14 décembre 2009, du 6 juillet 2010, du 15 octobre 2010, du 18 avril
2011, du 25 Juillet 2011, du 3 octobre 2011, du 15 décembre 2011, du 3 octobre 2012, du 19 février 2013, du 16 mai
2013, du 12 août 2013 et du 30 avril 2014, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2361 daté
du 26 septembre 2008, numéro 4 du 2 janvier 2009, numéro 1458 du 25 juillet 2009, numéro 2118 du 28 octobre 2009,
numéro 367 du 19 février 2010, numéro 2137 du 11 Octobre 2010, numéro 2701 du 8 décembre 2010, numéro 1481
du 6 Juillet 2011, numéro 2503 du 17 octobre 2011, numéro 2915 du 29 novembre 2011, numéro 456 du 21 février 2012,
numéro 2690 du 3 novembre 2012, numéro 932 du 19 avril 2013, numéro 1682 du 13 juillet 2013, numéro 2559 du 15
octobre 2013 et numéro 1856 du 17 juillet 2014.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à
Luxembourg, le 13 nombre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 3909 du 17
décembre 2014.
Le Gérant expose et prie alors le notaire instrumentant d’acter comme suit:
1. Le capital émis de la Société est fixé à DEUX CENT ONZE MILLE EUROS (EUR 211.000,-) représenté par UNE
(1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de TRENTE MILLE EUROS (EUR 30.000.-), UN
MILLION SEPT CENT DIX MILLE (1.710.000) Actions Ordinaires entièrement libérées, d'une valeur nominale de DIX
CENTIMES D’ EURO (EUR 0,10.-) chacune et par CENT MILLE (100.000) Actions de Participation entièrement libérées,
d'une valeur nominale de DIX CENTIMES D’ EURO (EUR 0,10.-) chacune..
2. Aux termes de l’article cinq des statuts, le capital autorisé de la Société a été fixé à DEUX CENT VINGT MILLE
EUROS (EUR 220.000.-) représenté par une (1) action de Commandité détenue par le Gérant d’une valeur nominale de
TRENTE MILLE EURO (EUR 30.000.-), par UN MILLION HUIT CENT MILLE (1.800.000) Actions Ordinaires, d’une
valeur nominale de DIX CENTIMES D’EURO (EUR 0,10.-) chacune et par CENT MILLE (100.000) Actions de Participation,
d’une valeur nominale de DIX CENTIMES D’EURO (EUR 0,10.-) chacune. Le Gérant a été autorisé à procéder à la
réalisation de cette augmentation de capital, l’article cinq des statuts se trouvant alors modifié de manière à correspondre
à l’augmentation de capital intervenue.
3. Le Gérant, en conformité avec les pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l’article cinq des statuts, a décidé
par résolutions du 27 novembre 2014 d’augmenter le capital social de la Société à concurrence de MILLE HUIT CENTS
EUROS (EUR 1.800,-) pour le porter de son montant actuel de DEUX CENT ONZE MILLE EUROS (EUR 211.000,-) à
DEUX CENT DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 212.800,-) par la création de DIX HUIT MILLE (18.000) actions
nouvelles de catégorie “Actions Ordinaires” d’une valeur nominale de DIX CENTIMES D’EURO (EUR 0,10.-) chacune,
donnant les mêmes droits que les actions anciennes, émises avec une prime d’émission totale de UN MILLION SEPT
CENT QUATRE-VINGT DIX HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (EUR 1.798.200,-).
Les DIX HUIT MILLE (18.000) Actions Ordinaires nouvelles ont été souscrites et libérées intégralement en numéraire
par versement à un compte bancaire au nom de la société MANGROVE III S.C.A. SICAR, prédésignée, de sorte que la
somme totale de UN MILLION HUIT CENT MILLE EUROS (EUR 1.800.000,-) a été mise à la libre disposition de cette
dernière, ce dont il a été justifié au notaire instrumentant par la présentation des pièces justificatives de la libération.
43934
L
U X E M B O U R G
Suite à la réalisation de l’augmentation dans les limites du capital autorisé, le deuxième alinéa de l’article cinq des statuts
est modifié en conséquence et a désormais la teneur suivante:
«(b) Le capital émis de la Société est fixé à DEUX CENT DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (EUR 212.800,-)
représenté par UNE (1) action de Commandité entièrement libérée d'une valeur nominale de TRENTE MILLE EUROS
(EUR 30.000.-), UN MILLION SEPT CENT VINGT HUIT MILLE (1.728.000) Actions Ordinaires entièrement libérées,
d'une valeur nominale de DIX CENTIMES D’EURO (EUR 0,10.-) chacune et par CENT MILLE (100.000) Actions de
Participation entièrement libérées, d'une valeur nominale de DIX CENTIMES D’EURO (EUR 0,10.-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 4.500.-.
A la demande du comparant, le notaire, qui parle et comprend l’anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande du comparant, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fait foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: F. LEFEVRE et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 26 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2207. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015032593/139.
(150036068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 178.546.
In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of the month of February;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
Mr. Luis AGUERRE ENRÍQUEZ, Doctor en Derecho, residing professionally in Luxembourg, acting as the represen-
tative of the general partner of Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A. (hereinafter the “Company”), a société en
commandite par actions, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its regis-
tered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 178546,
pursuant to a power given by a resolution of the board of managers of the general partner of the Company dated 11
February 2015.
A copy of the minutes of said resolution, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary will remain
attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing person, acting in said capacity, has requested the undersigned notary to state his declarations as follows:
1) The Company has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 21 June 2013, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 8 August 2013, under number 1915. The articles of association
of the Company were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 5 March 2014, published
in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, on 27 May 2014 under number 1362.
2) According to article 5.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is set at four hundred
twenty-seven thousand four hundred sixteen United States Dollars and sixty-two cents (USD 427,416.62), represented
by (i) five million five hundred seventy-nine thousand five hundred sixty-one (5,579,561) redeemable class A shares (the
“Class A Redeemable Shares”), (ii) eight million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three
(8,338,873) redeemable class B1 shares (the “Class B1 Redeemable Shares”), (iii) eight million three hundred thirty-eight
thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B2 shares (the “Class B2 Redeemable Shares”), (iv)
eight million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B3 shares
(the “Class B3 Redeemable Shares”), (v) eight million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three
(8,338,873) redeemable class B4 shares (the “Class B4 Redeemable Shares” and together with the Class B1 Redeemable
Shares, the Class B2 Redeemable Shares and the Class B3 Redeemable Shares, the “Class B Redeemable Shares”), (vi)
nine hundred fifty-one thousand six hundred fifty-two (951,652) redeemable class C1 shares (the “Class C1 Redeemable
Shares”), (vii) nine hundred fifty-one thousand six hundred fifty-two (951,652) redeemable class C2 shares (the “Class
43935
L
U X E M B O U R G
C2 Redeemable Shares”), (viii) nine hundred fifty-one thousand six hundred fifty-two (951,652) redeemable class C3
shares (the “Class C3 Redeemable Shares”), (ix) nine hundred fifty-one thousand six hundred fifty-two (951,652) redee-
mable class C4 shares (the “Class C4 Redeemable Shares” and together with the Class C1 Redeemable Shares, the Class
C2 Redeemable Shares and the Class C3 Redeemable Shares, the “Class C Redeemable Shares” and together with the
Class A Redeemable Shares and the Class B Redeemable Shares, the “Redeemable Shares”) and one (1) unlimited share
(the “Unlimited Share”) with a nominal value of one cent (USD 0.01) each.
3) According to article 6.1 of the articles of association, the authorised capital, excluding the share capital, is set at
thirty-four million nine hundred eighty-seven thousand six hundred fifty-five United States Dollars and thirty-eight cents
(USD 34,987,655.38), consisting of four hundred ninety-nine million nine hundred twenty thousand four hundred thirty-
eight (499,920,438) Class A Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four (374,881,094) Class B1 Redeemable Shares with a nominal
value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four
(374,881,094) Class B2 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four (374,881,094) Class B3 Redeemable Shares with a nominal
value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four
(374,881,094) Class B4 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred thirty thousand one hundred eighty-one (374,830,181) Class C1 Redeemable Shares with a
nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred thirty thousand one hundred
eighty-one (374,830,181) Class C2 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred
seventy-four million eight hundred thirty thousand one hundred eighty-one (374,830,181) Class C3 Redeemable Shares
with a nominal value of one cent (USD 0.01) each and three hundred seventy-four million eight hundred thirty thousand
one hundred eighty-one (374,830,181) Class C4 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each.
4) Pursuant to article 6.1 of the articles of association of the Company, the general partner of the Company is authorised
to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within
the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to
such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders during a
period of five (5) years from the date of publication of the articles of association of the Company in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations.
5) In the resolutions of the board of managers of the general partner of the Company dated 11 February 2015, the
board of managers has resolved (a) to increase the Company’s share capital by an amount of two hundred thirty-five
United States Dollars (USD 235) so as to raise it from its current amount of four hundred twenty-seven thousand four
hundred sixteen United States Dollars and sixty-two cents (USD 427,416.62) up to four hundred twenty-seven thousand
six hundred fifty-one United States Dollars and sixty-two cents (USD 427,651.62) through the issue of (i) five thousand
eight hundred seventy-five (5,875) Class C1 Redeemable Shares, (ii) five thousand eight hundred seventy-five (5,875) Class
C2 Redeemable Shares, (iii) five thousand eight hundred seventy-five (5,875) Class C3 Redeemable shares and (iv) five
thousand eight hundred seventy-five (5,875) Class C4 Redeemable Shares, having a nominal value of one cent (USD 0.01)
each, and (b) to waive the preferential right of the existing shareholders to subscribe for such shares (the “Capital
Increase”).
6) The shares have been subscribed by Kaseya Global Ireland Limited, a limited liability company incorporated under
the laws of Ireland, registered under number 545037, having its registered office at 2
nd
Floor, Commerzbank House,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.
The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash.
The price payable for the shares, amounting to the aggregate amount of two hundred thirty-five United States Dollars
(USD 235) has been entirely allocated to the share capital of the Company.
7) As a consequence of the aforementioned Capital Increase, article 5.1 of the articles of association is amended and
shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The Company’s share capital is set at four hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-one United States
Dollars and sixty-two cents (USD 427,651.62, represented by (i) five million five hundred seventy-nine thousand five
hundred sixty-one (5,579,561) redeemable class A shares (the “Class A Redeemable Shares”), (ii) eight million three
hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B1 shares (the “Class B1 Re-
deemable Shares”), (iii) eight million three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873)
redeemable class B2 shares (the “Class B2 Redeemable Shares”), (iv) eight million three hundred thirty-eight thousand
eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B3 shares (the “Class B3 Redeemable Shares”), (v) eight million
three hundred thirty-eight thousand eight hundred seventy-three (8,338,873) redeemable class B4 shares (the “Class B4
Redeemable Shares” and together with the Class B1 Redeemable Shares, the Class B2 Redeemable Shares and the Class
B3 Redeemable Shares, the “Class B Redeemable Shares”), (vi) nine hundred fifty-seven thousand five hundred twenty-
seven (957,527) redeemable class C1 shares (the “Class C1 Redeemable Shares”), (vii) nine hundred fifty-seven thousand
five hundred twenty-seven (957,527) redeemable class C2 shares (the “Class C2 Redeemable Shares”), (viii) nine hundred
fifty-seven thousand five hundred twenty-seven (957,527) redeemable class C3 shares (the “Class C3 Redeemable Sha-
res”), (ix) nine hundred fifty-seven thousand five hundred twenty-seven (957,527) redeemable class C4 shares (the “Class
43936
L
U X E M B O U R G
C4 Redeemable Shares” and together with the Class C1 Redeemable Shares, the Class C2 Redeemable Shares and the
Class C3 Redeemable Shares, the “Class C Redeemable Shares” and together with the Class A Redeemable Shares and
the Class B Redeemable Shares, the “Redeemable Shares”) and one (1) unlimited share (the “Unlimited Share”) with a
nominal value of one cent (USD 0.01) each. The Unlimited Share is held by the general partner (associé commandité).
The Redeemable Shares and the Unlimited Share are hereafter together referred to as the “Shares”.”
8) As a consequence of the aforementioned Capital Increase, article 6.1 of the articles of association is amended and
shall henceforth read as follows:
“ 6.1. The authorised capital, excluding the share capital, is set at thirty-four million nine hundred eighty-seven thousand
four hundred twenty United States Dollars and thirty-eight cents (USD 34,987,420.38), consisting of four hundred ninety-
nine million nine hundred twenty thousand four hundred thirty-eight (499,920,438) Class A Redeemable Shares with a
nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred eighty-one thousand ninety-
four (374,881,094) Class B1 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four (374,881,094) Class B2 Redeemable Shares with a nominal
value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four
(374,881,094) Class B3 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred eighty-one thousand ninety-four (374,881,094) Class B4 Redeemable Shares with a nominal
value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred twenty-four thousand three hundred
six (374,824,306) Class C1 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-
four million eight hundred twenty-four thousand three hundred six (374,824,306) Class C2 Redeemable Shares with a
nominal value of one cent (USD 0.01) each, three hundred seventy-four million eight hundred twenty-four thousand three
hundred six (374,824,306) Class C3 Redeemable Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each and three
hundred seventy-four million eight hundred twenty-four thousand three hundred six (374,824,306) Class C4 Redeemable
Shares with a nominal value of one cent (USD 0.01) each. During a period of time of five (5) years from the date of the
publication of these articles of association or, as the case may be, of the resolution to renew or to increase the authorised
capital pursuant to this article, the General Partner is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe
for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limits of the authorised capital to such
persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential
right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders. Such authorisation may be renewed through a
resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association, each time for a period not exceeding five (5) years.”
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand one hundred and
fifty Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
person, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, said appearing person has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-septième jour du mois de février;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
Monsieur Luis AGUERRE ENRIQUEZ, Doctor en Derecho, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant
en tant que représentant de l’associé commandité de Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A. (ci-après la «Société»), une
société en commandite par actions, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social sis 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 178546,
en vertu d’un pouvoir donné par résolution du conseil de gérance de l’associé commandité de la Société en date du
11 février 2015.
Une copie du procès-verbal de ladite résolution, paraphée «ne varietur» par le comparant et le notaire, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
43937
L
U X E M B O U R G
Le comparant, agissant en la capacité mentionnée ci-dessus, a requis le notaire soussigné d’acter les déclarations
suivantes:
1) La Société a été constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 21 juin 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1915, le 8 août 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 5 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 1362, le 27 mai 2014.
2) Selon l’article 5.1 des statuts de la Société, le capital social émis de la Société est fixé à quatre cent vingt-sept mille
quatre cent seize dollars américains et soixante-deux cents (USD 427.416,62), représenté par (i) cinq millions cinq cent
soixante-dix-neuf mille cinq cent soixante et une (5.579.561) actions rachetables de catégorie A (les «Actions Rachetables
de Catégorie A»), (ii) huit millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions rachetables
de catégorie B1 (les «Actions Rachetables de Catégorie B1»), (iii) huit millions trois cent trente-huit mille huit cent
soixante-treize (8.338.873) actions rachetables de catégorie B2 (les «Actions Rachetables de Catégorie B2»), (iv) huit
millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions rachetables de catégorie B3 (les «Actions
Rachetables de Catégorie B3»), (v) huit millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions
rachetables de catégorie B4 (les «Actions Rachetables de Catégorie B4», désignées conjointement avec les Actions Ra-
chetables de Catégorie B1, les Actions Rachetables de Catégorie B2 et les Actions Rachetables de Catégorie B3, les
«Actions Rachetables de Catégorie B»), (vi) neuf cent cinquante et un mille six cent cinquante-deux (951.652) actions
rachetables de catégorie C1 (les «Actions Rachetables de Catégorie C1»), (vii) neuf cent cinquante et un mille six cent
cinquante-deux (951.652) actions rachetables de catégorie C2 (les «Actions Rachetables de Catégorie C2»), (viii) neuf
cent cinquante et un mille six cent cinquante-deux (951.652) actions rachetables de catégorie C3 (les «Actions Rachetables
de Catégorie C3»), (ix) neuf cent cinquante et un mille six cent cinquante-deux (951.652) actions rachetables de catégorie
C4 (les «Actions Rachetables de Catégorie C4», désignées conjointement avec les Actions Rachetables de Catégorie C1,
les Actions Rachetables de Catégorie C2 et les Actions Rachetables de Catégorie C3, les «Actions Rachetables de Ca-
tégorie C», désignées conjointement avec les Actions Rachetables de Catégorie A et les Actions Rachetables de Catégorie
B, les «Actions Rachetables») et une (1) action de commandité (l’«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale
d’un cent (USD 0,01) chacune.
3) Selon l’article 6.1 des statuts de la Société, le capital autorisé, excluant le capital social, est fixé à un montant de
trente-quatre millions neuf cent quatre-vingt-sept mille six cent cinquante-cinq dollars américains et trente-huit cents
(USD 34.987.655,38), représenté par quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent vingt mille quatre cent trente-
huit (499.920.438) Actions Rachetables de Catégorie A ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois
cent soixante-quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze (374.881.094) Actions Rachetables
de Catégorie B1 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent
quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze (374.881.094) Actions Rachetables de Catégorie B2 ayant une valeur nominale
d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent quatre-vingt- un mille quatre-vingt-quatorze
(374.881.094) Actions Rachetables de Catégorie B3 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent
soixante-quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze (374.881.094) Actions Rachetables de
Catégorie B4 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent
trente mille cent quatre-vingt-une (374.830.181) Actions Rachetables de Catégorie C1 ayant une valeur nominale d’un
cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent trente mille cent quatre-vingt-une (374.830.181)
Actions Rachetables de Catégorie C2 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-
quatorze millions huit cent trente mille cent quatre-vingt-une (374.830.181) Actions Rachetables de Catégorie C3 ayant
une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune et trois cent soixante-quatorze millions huit cent trente mille cent
quatre-vingt-une (374.830.181) Actions Rachetables de Catégorie C4 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01)
chacune.
4) Selon l’article 6.1 des statuts de la Société, l’associé commandité de la Société est autorisé, pendant une période de
cinq (5) ans à compter de la date de publication des statuts de la Société au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, à émettre des actions, à attribuer des bons de souscription d’actions et à émettre tout autre type d’instrument
convertible en actions dans les limites du capital autorisé au profit des personnes et aux conditions qu’il estimera op-
portunes lui permettant notamment de procéder à cette émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux actions
nouvellement émises ne soit réservé aux actionnaires existants.
5) Dans les résolutions du conseil de gérance de l’associé commandité de la Société en date du 11 février 2015, le
conseil de gérance a décidé (a) d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux cent trente-cinq dollars
américains (USD 235) afin de l’augmenter de son montant actuel de quatre cent vingt-sept mille quatre cent seize dollars
américains et soixante-deux cents (USD 427.416,62) à quatre cent vingt-sept mille six cent cinquante et un dollars amé-
ricains et soixante-deux cents (USD 427.651,62) par l’émission de (i) cinq mille huit cent soixante-quinze (5.875) Actions
Rachetables de Catégorie C1, (ii) cinq mille huit cent soixante-quinze (5.875) Actions Rachetables de Catégorie C2, (iii)
cinq mille huit cent soixante-quinze (5.875) Actions Rachetables de Catégorie C3 et (iv) cinq mille huit cent soixante-
quinze (5.875) Actions Rachetables de Catégorie C4, ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, et (b)
sans réserver un droit préférentiel de souscription de ces actions pour les actionnaires existants (l’«Augmentation de
Capital»).
43938
L
U X E M B O U R G
6) Les Actions ont été souscrites par Kaseya Global Ireland Limited, une société (limited liability company) constituée
selon les lois de l’Irlande, enregistrée sous le numéro 545037, ayant son siège social au 2
nd
Floor, Commerzbank House,
Guild Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.
Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par voie d’apport en numéraire.
Le prix payable pour les actions d’un montant total de deux cent trente-cinq dollars américains (USD 235) a été
entièrement affecté au capital social de la Société.
7) En conséquence de l’Augmentation de Capital susmentionnée, l’article 5.1 des statuts est modifié et sera désormais
rédigé comme suit:
« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent vingt-sept mille six cent cinquante et un dollars américains
et soixante-deux cents (USD 427.651,62), représenté par (i) cinq millions cinq cent soixante-dix-neuf mille cinq cent
soixante et une (5.579.561) actions rachetables de catégorie A (les «Actions Rachetables de Catégorie A»), (ii) huit millions
trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions rachetables de catégorie B1 (les «Actions Ra-
chetables de Catégorie B1»), (iii) huit millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions
rachetables de catégorie B2 (les «Actions Rachetables de Catégorie B2»), (iv) huit millions trois cent trente-huit mille
huit cent soixante-treize (8.338.873) actions rachetables de catégorie B3 (les «Actions Rachetables de Catégorie B3»),
(v) huit millions trois cent trente-huit mille huit cent soixante-treize (8.338.873) actions rachetables de catégorie B4 (les
«Actions Rachetables de Catégorie B4», désignées conjointement avec les Actions Rachetables de Catégorie B1, les
Actions Rachetables de Catégorie B2 et les Actions Rachetables de Catégorie B3, les «Actions Rachetables de Catégorie
B»), (vi) neuf cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-sept (957.527) actions rachetables de catégorie C1 (les «Actions
Rachetables de Catégorie C1»), (vii) neuf cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-sept (957.527) actions rachetables de
catégorie C2 (les «Actions Rachetables de Catégorie C2»), (viii) neuf cent cinquante-sept mille cinq cent vingt-sept
(957.527) actions rachetables de catégorie C3 (les «Actions Rachetables de Catégorie C3»), (ix) neuf cent cinquante-sept
mille cinq cent vingt-sept (957.527) actions rachetables de catégorie C4 (les «Actions Rachetables de Catégorie C4»,
désignées conjointement avec les Actions Rachetables de Catégorie C1, les Actions Rachetables de Catégorie C2 et les
Actions Rachetables de Catégorie C3, les «Actions Rachetables de Catégorie C», désignées conjointement avec les
Actions Rachetables de Catégorie A et les Actions Rachetables de Catégorie B, les «Actions Rachetables») et une (1)
action de commandité (l’«Action de Commandité»), ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune. L’Action
de Commandité est détenue par l’associé commandité. Les Actions Rachetables et l’Action de Commandité sont désignées
ensemble ci-après les «Actions».»
8) En conséquence de l’Augmentation de Capital susmentionnée, l’article 6.1 des statuts est modifié et sera désormais
rédigé comme suit:
« 6.1. Le capital autorisé, excluant le capital social, est fixé à un montant de trente-quatre millions neuf cent quatre-
vingt-sept mille quatre cent vingt dollars américains et trente-huit cents (USD 34.987.420,38), représenté par quatre cent
quatre-vingt- dix-neuf millions neuf cent vingt mille quatre cent trente-huit (499.920.438) Actions Rachetables de Caté-
gorie A ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent quatre-
vingt-un mille quatre-vingt- quatorze (374.881.094) Actions Rachetables de Catégorie B1 ayant une valeur nominale d’un
cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze
(374.881.094) Actions Rachetables de Catégorie B2 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent
soixante-quatorze millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze (374.881.094) Actions Rachetables de
Catégorie B3 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent
quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze (374.881.094) Actions Rachetables de Catégorie B4 ayant une valeur nominale
d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre mille trois cent six
(374.824.306) Actions Rachetables de Catégorie C1 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent
soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre mille trois cent six (374.824.306) Actions Rachetables de Catégorie C2
ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune, trois cent soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre
mille trois cent six (374.824.306) Actions Rachetables de Catégorie C3 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01)
chacune et trois cent soixante-quatorze millions huit cent vingt-quatre mille trois cent six (374.824.306) Actions Rache-
tables de Catégorie C4 ayant une valeur nominale d’un cent (USD 0,01) chacune. Pendant une période de cinq (5) ans à
compter de la date de publication des présents statuts ou, le cas échéant, de la décision de renouveler ou d’augmenter
le capital autorisé conformément à cet article, l’Associé Commandité est autorisé à émettre des actions, à attribuer des
bons de souscription d’actions et à émettre tout autre type d’instrument convertible en actions dans les limites du capital
autorisé au profit des personnes et aux conditions qu’il estimera opportunes lui permettant notamment de procéder à
cette émission sans qu’un droit préférentiel de souscription aux actions nouvellement émises ne soit réservé aux action-
naires existants. Cette autorisation pourra être renouvelée par une décision de l’assemblée générale des actionnaires,
prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder
une durée de cinq (5) ans.»
43939
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille cent cinquante
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même personne
comparante, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la personne comparante, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par son nom,
prénom, état civil et domicile, ladite personne comparante a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 19 février 2015. 2LAC/2015/3680. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;
Luxembourg, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015032521/283.
(150036633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Etats d'Urgence, Association sans but lucratif.
Siège social: L-2355 Luxembourg, 12, rue du Puits.
R.C.S. Luxembourg F 3.170.
STATUTS
Chapitre I
er
. Dénomination - Siège - Buts sociaux - Composition
Art. 1
er
. L'association porte la dénomination ETATS D'URGENCE. Son siège est établi à Luxembourg. Le siège peut
être transféré à n’importe quel autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du conseil d'administration.
L'association est créée pour une durée illimitée.
Art. 2. L'association a pour but l’animation du centre de production et de création artistique dit «Banannefabrik» sis
à Luxembourg 12, rue du Puits. L’association assure, en outre, en coopération avec les autres locataires et occupants, la
coordination de la programmation artistique dans ce lieu et organise des activités dans l’intérêt de ses membres.
Art. 3. L'association réalisera cet objet notamment:
- en créant, produisant et diffusant des spectacles, sans se limiter exclusivement sur les lieux précités
- en animant un centre vivant et en collaborant avec toute personne physique et morale de droit privé et de droit
public chaque fois qu'elle poursuit un but analogue à celui poursuivi par l’a.s.b.l. ETATS D'URGENCE.
Art. 4. L'association comprendra des membres actifs, donateurs et honoraires.
Art. 5. La qualité de membre actif s'acquiert par le paiement d'une cotisation annuelle, à fixer par l’assemblée générale,
qui ne peut être supérieure à 1000.- € (mille euros).
Peuvent devenir membres actifs, des personnes morales ayant la personnalité civile.
L'admission d'un membre actif est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale. Le nombre des membres actifs
est illimité sans pouvoir être inférieur à trois. Les personnes morales seront valablement représentées par leurs mandants.
La qualité de membre donateur est conférée aux personnes morales qui, sans devoir prendre part aux activités de
l’association, lui apporteront leur appui matériel ou moral et auront payé une cotisation supérieure à la cotisation annuelle
fixée par l’assemblée générale. Ils n’auront pas de droit de vote.
Les membres honoraires regroupent des personnalités ou des institutions qui ont acquis des mérites particuliers dans
la promotion des buts visés par l’association; ils sont dispensés de cotisations et n’auront pas de droit de vote.
Art. 6. Tout membre actif désirant perdre sa qualité de membre actif devra adresser un préavis écrit de deux mois au
Conseil d'Administration.
La qualité de membre actif se perd également par le non-paiement de la cotisation annuelle ou par la radiation pro-
noncée par le conseil d’administration pour motif grave de violation des présents statuts.
43940
L
U X E M B O U R G
Chapitre II. L'assemblée générale
Art. 7. L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an; la date, l’heure, le lieu et l’ordre du jour sont
portés à la connaissance des membres par simple lettre au moins dix jours à l’avance. Le délai de convocation pour
l’assemblée générale extraordinaire est pareil.
L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs. Chaque membre actif a une voix.
Il peut donner pouvoir par procuration écrite à un autre membre actif de le représenter lors des délibérations, sans
que celui-ci puisse détenir plus de deux procurations.
Art. 8. L'assemblée générale est notamment investie des pouvoirs suivants:
1) la modification des statuts,
2) la nomination et la révocation des administrateurs,
3) l’approbation des budgets et des comptes,
4) l’exercice de tous les autres pouvoirs découlant de la loi et des statuts,
5) la dissolution de l’association.
Art. 9. Une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée à toute époque sur décision du conseil d’admi-
nistration ou sur demande écrite et motivée de deux membres actifs au moins. Dans ce dernier cas, l’assemblée doit être
réunie dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande.
Art. 10. Les membres actifs ont un droit de vote égal dans l’assemblée générale et les résolutions sont prises à la
majorité des voix des membres présents ou représentés.
Tous les procès-verbaux et résolutions de l’assemblée générale sont consignés dans un registre spécial conservé au
siège de l’association où tous les membres peuvent en prendre connaissance.
Chapitre III. Conseil d’administration
Art. 11. L'association est administrée par un conseil d’administration composé de trois administrateurs au moins et
onze au plus. Chaque administrateur dispose d'une voix.
L'assemblée générale élit ce conseil d'administration parmi ses membres actifs et ce pour une durée de deux ans. Le
conseil d’administration choisit parmi ses membres son président, son secrétaire et son trésorier. Ils forment le bureau
exécutif de l’association.
Art. 12. Tous les membres du conseil d’administration sont élus séparément à la majorité simple des voix présentes
ou représentées. Les membres sont rééligibles.
Art. 13. Le conseil d'administration est tenu de présenter à l’assemblée générale annuelle des rapports détaillés sur la
gestion des affaires. Le rapport du trésorier doit être fait par écrit et il sera tout comme les livres soumis à l’examen de
deux réviseurs de caisse ou d'une fiduciaire agréée à désigner par l’assemblée générale.
Art. 14. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux membres aussi souvent que
l’intérêt de l’association l’exige. l ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou
représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président ou de son remplaçant
est prépondérante au second vote.
Art. 15. Le conseil d'administration représente l’association dans ses relations avec les particuliers et les pouvoirs
publics dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires et l’engage valablement à l’égard des tiers par la signature conjointe
de deux administrateurs mandatés.
Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité déléguer des pouvoirs à l’un ou plusieurs de ses membres ou
à des tiers pour les affaires courantes.
Art. 16. En cas de vacance de siège, il sera pourvu au remplacement lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Le conseil d'administration peut cependant coopter des administrateurs suivant une procédure à définir en assemblée
générale. En cas de vacance du siège du président, il sera pourvu à son remplacement lors d'une assemblée générale
extraordinaire convoquée à cet effet dans le mois suivant.
Art. 17. Un membre ne peut valablement se faire représenter au conseil d'administration que par une personne membre
munie d'une procuration écrite.
Art. 18. Le conseil d'administration peut s'associer, avec voix consultative, toute personne physique ou morale capable
de le soutenir dans la réalisation des buts déterminés ci-dessus.
Chapitre IV. Divers
Art. 19. Les recettes de l’association sont les suivantes:
- les dons et legs,
43941
L
U X E M B O U R G
- les cotisations annuelles,
- les recettes de toute nature provenant de l’activité de l’association,
- les subventions,
- toutes les ressources compatibles avec sa capacité civile.
Art. 20. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître un compte d'exploitation, le résultat de l’exercice et le bilan.
L'excédent favorable appartient à l’association. L’année sociale débute le premier janvier et se termine le trente et un
décembre de chaque année.
L'association ne peut être valablement engagée quant aux mouvements financiers que par la signature conjointe du
trésorier et du président pour toute dépense excédant le montant de 2'500.- € (deux mille cinq cent euros)
Art. 21. Les modifications des statuts et la dissolution de l’association se feront conformément aux prescriptions légales.
Art. 22. En cas de dissolution volontaire, l’actif sera affecté après liquidation du passif à une ou plusieurs oeuvres
poursuivant un but conforme aux objectifs de l’association. L'assemblée désignera le bénéficiaire à la majorité simple des
voix.
Art. 23. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est renvoyé aux dispositions de la loi modifiée du
21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif.
Fait à Luxembourg, en assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2011, en quatre exemplaires. Chaque membre
actif, repris ci-dessous, déclare avoir reçu un exemplaire.
<i>Les comparants:i>
Carlo HOURSCHT, mandaté par le Centre de Création Chorégraphique Luxembourgeois (Trois C-L) a.s.b.l.
Serge TONNAR, mandaté par Maskénada a.s.b.l.
Marja-Leena JUNKER, mandatée par le Théâtre du Centaure a.s.b.l.
Frank HOFFMANN, par procuration à Serge TONNAR pour le Théâtre National du Luxembourg a.s.b.l.
Référence de publication: 2015032907/108.
(150036928) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Duluth Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 40.001,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 188.789.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Tanker Opportunities, LLC, a limited liability company formed and existing under the laws of the State of Delaware,
having its registered office at 1209, Orange Street, Wilmington Delaware, 19801, United States of America, and registered
with the Delaware Secretary of State under number 5556818 (the "Sole Shareholder")
represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, private employee, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been initialled “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Duluth LU S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), organized and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 5C, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under number B 188.789, incorporated by a deed enacted by notary Martine Schaeffer, on 1 July 2014, published
in the Luxembourg official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations) number 2582 on 24 September
2014 (the “Company”). The articles of association of the Company have not been amended since then.
II.- The 40,000 (forty thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)
each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda, of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
43942
L
U X E M B O U R G
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United States Dollar), so as to raise it
from its current amount of USD 40,000 (forty thousand United States Dollars) to USD 40,001 (forty thousand one United
States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar);
3. Subscription and payment by the contributor of the new share by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Amendment of the first paragraph of article 5 of the articles of association of the Company in order to reflect such
action; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved, the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolved to waive its right to the prior notice of the current meeting, acknowledge being suffi-
ciently informed on the agenda, consider being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the
items of the agenda. The Sole Shareholder declares that all the relevant documentation has been put at the disposal of
the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 1 (one United
States Dollar), so as to raise it from its current amount of USD 40,000 (forty thousand United States Dollars) to USD
40,001 (forty thousand one United States Dollars) by the issuance of 1 (one) new share, with a nominal value of USD 1
(one United States Dollar) (the “New Share”), the whole to be fully paid up though a contribution in kind consisting in a
receivable against the Company having a principal amount of USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars)
(the “Contribution”).
The balance of the value of the Contribution of USD 24,999 (twenty-four thousand nine hundred ninety-nine United
States Dollars) exceeding the nominal value of the New Share shall be allocated to the share premium account of the
Company.
<i>Third resolution:i>
It is unanimously resolved to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New Share as
described below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, who declares to subscribe the New Share.
<i>Valuationi>
The fair market value of the Contribution amounts to USD 25,000 (twenty-five thousand United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 23 December 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the existence of the Contribution has been given to the Company.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed
of:
Sole Shareholder: 40,001 (forty thousand one) shares
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, the
Sole Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5 of the Company’s articles of association so as to read
as follows:
“ Art. 5. The Company share capital is set at USD 40,001 (forty thousand one United States Dollars), represented by
40,001 (forty thousand one) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”
No other amendment is to be made to this article.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
<i>Declarationi>
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette on the day named at the beginning of this
document.
43943
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-neuvième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Tanker Opportunities, LLC, une limited liability company, régie par les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège social
au 1209, Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801, United States of America, et enregistrée auprès du Delaware
Division of Corporations sous le numéro 5556818 (l’«Associé Unique»),
ici dûment représentée par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au
5, rue Zénon Bernard, L-4030 Eschsur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous
seing privé.
Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l’enregistrement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I - La partie comparante est l’associé unique de Duluth LU S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5C, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 188.789, constituée suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, le 1 juillet 2014, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 2582 le 24 septembre 2014 (la «Société»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés
depuis.
II - Que les 40.000 (quarante mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune,
représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valablement se
prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement informé.
III- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain) afin de le porter de son
montant actuel de 40.000 USD (quarante mille Dollars Américains) à 40.001 USD (quarante mille un Dollars Américains)
par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain);
3. Souscription et libération par l’apporteur de la nouvelle part sociale par voie d’un apport en nature;
4. Nouvelle composition du capital de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
l’Associé Unique décide de renoncer à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée;
l’Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère que l’assemblée a été vala-
blement convoquée et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est
en outre décidé que l’ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un
délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
L’Associé Unique décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 1 USD (un Dollar Américain) afin
de le porter de son montant actuel de 40.000 USD (quarante mille Dollars Américains) à 40.001 USD (quarante mille un
Dollars Américains) par l’émission de 1 (une) nouvelle part sociale d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain)
(la «Nouvelle Part Sociale»), le tout devant être entièrement libéré au moyen d’un apport en nature consistant en une
créance contre la Société d'un montant principal de 25.000 USD (vingt-cinq mille Dollars américains) (l’«Apport»).
Le solde de la valeur de l’Apport de 24.999 USD (vingt-quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Dollars Américains)
qui dépasse la valeur nominale de la Nouvelle Part Sociale est affecté au compte de prime d'émission de la Société.
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé à l’unanimité d’accepter la souscription et le paiement par l’Associé Unique de la Nouvelle Part Sociale
tel que décrit ci-après.
43944
L
U X E M B O U R G
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l’Associé Unique, qui déclare souscrire la Nouvelle Part Sociale.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l’Apport s’élève à 25.000 USD (vingt-cing mille Dollars Américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l’apport en date du 23 décembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d’enregistrement.
<i>Preuve de l’existence de l’Apporti>
Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée à la Société.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, la participation au capital social de la Société est désormais
composée de:
- L'Associé Unique: 40.001 (quarante mille un) parts sociales.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à 40.001 USD (quarante mille un Dollars Américains), représenté par
40.001 (quarante mille un) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune».
Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été ajournée.
<i>Déclarationi>
Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, au jour indiqué en tête du présent document.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation: EAC/2015/539. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015032324/165.
(150035998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Digital Services Holding XXI s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 13.195,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 188.604.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in
Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg (Amts-
gericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),
being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Berlin, Germany, on 16 December 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungbeschränkt))
incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),
43945
L
U X E M B O U R G
being the holder of one (1) share,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Berlin, Germany, on 16 December 2014;
3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, registered with
the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address at Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter “Eiffel”),
becoming the holder of six hundred ninety-five (695) series A1 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in
Schiphol, the Netherlands, on 17 December 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties under 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services Holding XXI S.à
r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.604 and incorporated pursuant
to a deed of the notary Henri Hellinckx, residing in Luxembourg, on 1 July 2014, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2447 dated 11 September 2014. The articles of association have not been amended
since.
The Existing Shareholders represent the entire share capital and have waived any notice requirement. The general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Eiffel parti-
cipates and votes for the purpose of Agenda point 5 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have two (2) classes of shares,
divided into common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”).
2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro (EUR
1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each,
without cancellation of shares.
3. Acceptance of Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands,
registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under number 60628022, having its business address
at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands, as new shareholder of the Company.
4. Increase of the Company’s share capital by an amount of six hundred ninety-five euros (EUR 695) so as to raise it
from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) up to thirteen thousand one hundred
ninety-five euros (EUR 13,195) by issuing six hundred ninety-five (695) Series A1 Shares with a nominal value of one euro
(EUR 1.00) each.
5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth
read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirteen thousand one hundred ninety-five euros (EUR 13,195.00), repre-
sented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services
Holding XXI S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
43946
L
U X E M B O U R G
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.1 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirteen thousand one hundred ninety-five euros (EUR 13,195.00), repre-
sented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
43947
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders’ agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG
("Rocket") and the shareholder Netris B.V. (“Eiffel”, jointly with Rocket the "Investors" and each also an "Investor") to a
company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is
directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified
employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a calloption under a vesting scheme;
7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation
procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50% in any surviving legal entity after such transformation
procedure.
7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third
parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).
Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date
is the date before the redemption resolution.
9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
43948
L
U X E M B O U R G
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an
auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
11.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including email or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
11.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
12.2 The shareholders’ meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
43949
L
U X E M B O U R G
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a
higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.
Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.
Art. 16. Shareholders’ resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders’ Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-
holders (ii) who also constitute a Super Majority:
16.1.1 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1 conclusion of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections 291 et seqq.
German Stock Corporation Act (AktG));
16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of
any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;
16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and
transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.
16.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers
Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
43950
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
21.8 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.9 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
43951
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 24. Auditor(s).
24.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
24.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
24.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
24.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
24.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 25. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.
26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
26.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
26.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
26.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
26.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
27.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.
27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 29. Governing law.
29.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders’ agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
43952
L
U X E M B O U R G
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders’ agreement, such shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.
29.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, as well as Messrs. Julien De Mayer and Ruediger
Trox, regardless of his category, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders
register of the Company.
8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will
hence have two (2) classes of shares, divided into Common Shares and Series A1 Shares.
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a
nominal value of one euro (EUR 1.00) each, without cancellation of shares.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders accepts Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under
the laws of the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under number
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands, as new shareholder
of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the Company’s share capital by an amount of six hundred
ninety-five euros (EUR 695) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
up to thirteen thousand one hundred ninety-five euros (EUR 13,195) by issuing six hundred ninety-five (695) Series A1
Shares with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
<i>Subscriptioni>
Six hundred ninety-five (695) Series A1 Shares have been duly subscribed by Eiffel, aforementioned, for the price of
six hundred ninety-five euros (EUR 695).
<i>Paymenti>
The six hundred ninety-five (695) Series A1 Shares subscribed by Eiffel, aforementioned, have been entirely paid up
through a contribution in cash in an amount of six hundred ninety-five euros (EUR 695).
The amount of six hundred and ninety-five Euro (EUR 695.-) is as now available to the company as has been proved
to the undersigned notary.
The contribution in the amount of six hundred ninety-five euros (EUR 695) is entirely allocated to the share capital.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders acknowledges that Eiffel has now become the holder of six hundred ninety-five
(695) Series A1 Shares.
As a consequence Eiffel, aforementioned, entitled to vote and here represented by Kristof De Wael, Lawyer, profes-
sionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxies, joins the general meeting of shareholders for
the purpose of the following resolutions.
The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the
Company so that it shall now henceforth read as follows:
“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at thirteen thousand one hundred ninety-five euros (EUR 13,195.00), repre-
sented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each, and
5.1.2 six hundred ninety-five (695) series A1 shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.00) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association or by the Law.
43953
L
U X E M B O U R G
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”
<i>Sixth Resolutioni>
Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of
association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well
as Messrs. Julien De Mayer and Ruediger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely,
the shareholders register of the Company.
<i>Costs and expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,000.-.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtzehnten Dezember,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg,
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),
Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Anteilen,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 16 De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und be-
stehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),
Inhaber eines (1) Anteils,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 16 De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, eingetragen im Handels-
register des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG
Schiphol, Niederlande („Eiffel“),
zukünftiger Inhaber von sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 17 De-
zember 2014, ausgestellt in Schiphol, Niederlande.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services Holding
XXI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, ein-
getragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.604, gegründet am 1. Juli 2014
gemäß einer Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 11. September 2014 im Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2447, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde
seitdem nicht geändert.
Die Bestehenden Gesellschafter vertreten das gesamte Gesellschaftskapital und haben auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet. Die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die folgende
43954
L
U X E M B O U R G
Tagesordnung verhandeln, wobei Eiffel ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberech-
tigt ist:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) An-
teilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“) und Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).
2. Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1).
3. Aufnahme von Netris B.V., einer Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, einge-
tragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz in Schiphol
Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert
Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695) auf einen Betrag von dreizehntau-
sendeinhundertfünfundneunzig Euro (EUR 13.195) durch die Ausgabe von sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen
der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinhundertfünfundneunzig Euro (EUR 13.195,00),
bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Digital Services Holding XXI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915
über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
43955
L
U X E M B O U R G
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinhundertfünfundneunzig Euro (EUR 13.195,00),
bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-
gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die
drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter
Rocket Internet AG („Rocket“) und den Gesellschafter Netris B.V. („Eiffel“, gemeinschaftlich mit Rocket die „Investoren“
und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch
einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
43956
L
U X E M B O U R G
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen (i) an einen Dritten,
welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;
7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-
wandlungsvorgängen gemäß des Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten
gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen
werden, wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-
schaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemeinschaftlich ernannt wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
43957
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.
10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-
zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in
der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
12.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
43958
L
U X E M B O U R G
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-
treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.
Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 15. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.
Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit
der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:
16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-
teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;
16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.
16.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer
Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.
17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
43959
L
U X E M B O U R G
19.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
20.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
21.8 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
21.9 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
43960
L
U X E M B O U R G
falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 24. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
24.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
24.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
24.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte
der Gesellschaft.
24.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
24.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 25. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 26. Jahresabschluss und Gewinne.
26.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
26.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
26.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
26.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
26.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.
26.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 27. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
27.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
43961
L
U X E M B O U R G
27.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-
mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 28. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht
Art. 29. Anwendbares Recht.
29.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
29.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie die
Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) weitere Anteilsklasse zu schaffen, sodass die Gesellschaft nunmehr
zwei (2) Anteilsklassen hat, aufgeteilt in Stammanteile und Anteile der Serie A1.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht
der Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Ge-
schäftssitz in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695) auf einen
Betrag von dreizehntausendeinhundertfünfundneunzig Euro (EUR 13.195) durch die Ausgabe von sechshundertfünfund-
neunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Sechshundertfünfundneunzig (695) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Eiffel, vorbenannt, zu einem Preis
von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695) gezeichnet.
<i>Zahlungi>
Die von Eiffel, vorbenannt, gezeichneten sechshundertfünfundneunzig (695) Anteile der Serie A1 wurden vollständig
eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695).
Die Summe von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien Verfügung,
so wie dies dem amtierenden Notar erbracht wurde.
Die Einlage in Höhe von sechshundertfünfundneunzig Euro (EUR 695) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zuge-
führt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass Eiffel nun der Inhaber von sechshundertfünfundneunzig (695)
Anteilen der Serie A1 geworden ist.
43962
L
U X E M B O U R G
Demzufolge schließt sich Eiffel, vorbenannt, stimmberechtigt und hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, ge-
schäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmachten der Gesellschafterversammlung für die folgenden
Beschlüsse an.
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr
wie folgt lautet:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendeinhundertfünfundneunzig Euro (EUR 13.195,00),
bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00), und
5.1.2 sechshundertfünfundneunzig (695) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder
durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der
Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-
gorie, sowie die Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der
Gesellschaft in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: K. DE WAEL und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63712. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Februar 2015.
Référence de publication: 2015033039/998.
(150037152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 175.449.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 20 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Callum Thorneycroft avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Wembley Holdings Sàrl
Référence de publication: 2015033293/12.
(150037035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
43963
L
U X E M B O U R G
Logistis Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.171.
In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of February,
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Isabelle MANGEL, employee of AEW Europe S.à r.l., residing in Luxembourg, acting as the representative of the board
of directors (the “Board of Directors”) of Logistis Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme),
having its registered office at 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 140.171, (the “Company”),
Duly authorised to represent the Company pursuant to the power granted in the minutes of the board of directors
of the Company dated 26 January 2015 (the “Minutes”).
A copy of the Minutes, initialled ne varietur by the appearing person and the notary, will remain attached to present
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The Company was incorporated on 27 June 2008 by a notarial deed drawn up by Maître Jean-Joseph Wagner, notary,
residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), and the articles of incorporation of which (the “Articles”) were pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial C") number 1904, page 91347 on 2 August
2008. The Articles have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 22 December 2014 drawn up
by Maître Danielle Kolbach, notary, residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg) not yet published in
the Mémorial C.
The appearing party has required the undersigned notary to state her declarations as follows:
1) Pursuant to article 6 of the Articles, the subscribed capital of the Company is presently set at forty-six million seven
hundred sixty-five thousand one hundred and thirty-one Euros (EUR 46,765,131.-), divided into forty-six million seven
hundred sixty-five thousand one hundred and eleven (46,765,111) class A shares (the “Class A Shares”), ten (10) class B
shares (the “Class B Shares”), four (4) class C shares (the “Class C Shares”) and six (6) class D shares (the “Class D
Shares”) with a nominal value of one Euro (EUR 1.-), fully paid up (by 100%).
2) Pursuant to article 7.1 of the Articles, the Company has an un-issued but authorised share capital of a maximum
amount of one hundred fifty-three million one hundred fifty-one thousand one hundred and fifty-three Euros (EUR
153,151,153.-) to be used in order to issue new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class
D Shares or to increase the nominal value of the Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or
Class D Shares.
The Sole purpose of the authorised capital is to allow the issue of new Class A Shares and/or Class B Shares and/or
Class C Shares and/or Class D Shares or the increase of the nominal value of the existing Class A Shares and/or Class B
Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares in exchange of contribution in cash made by the existing or future
shareholders of the Company in execution of the capital calls made by the Board of Directors in compliance with any
agreement possibly entered into, from time to time between, amongst others, the Company’s shareholders and the
Company (a “Shareholders’ Agreement”).
Within the limit of the authorised share capital, the Company’s share capital may be increased, from time to time, at
the initiative of the Board of Directors, with or without an issue premium, in accordance with the terms and conditions
set out below by creating and issuing new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D
Shares, it being understood that:
- the Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares may be subscribed in accor-
dance with the terms and conditions fixed by the Board of Directors within the strict limits stated in any Shareholders’
Agreement;
- the Board of Directors may also determine the date of issue and the number of Class A Shares and/or Class B Shares
and/or Class C Shares and/or Class D Shares having to be eventually subscribed and issued;
- the Board of Directors is especially authorised to issue such new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class
C Shares and/or Class D Shares without reserving (i.e. by cancelling or limiting) for the existing shareholders of the
Company the preferential right to subscribe for and to purchase the new Class A Shares and/or Class B Shares and/or
Class C Shares and/or Class D Shares;
- the rights attached to the new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares
will be strictly similar to the rights attached to the existing Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares
and/or Class D Shares;
- the authorisation will expire on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the
minutes of the general meeting of shareholders of the Company held on 20 March 2014, but at the end of such period a
new period of authorisation may be approved by resolution of the general meeting of shareholders of the Company.
43964
L
U X E M B O U R G
- the Board of Directors is authorised to do all things necessary to amend article 6 of the Articles in order to record
the change of the share capital following an increase pursuant to article 7 of the Articles; the Board of Directors is
empowered to take or authorise the actions required for the execution and publication of such amendment in accordance
with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended. Furthermore, the Board of Directors
may delegate to the Chairman of the Board of Directors (the “Chairman”) or any director of the Company or to any
other duly authorised person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Class A Shares and/or Class
B Shares representing part or all of such increased amounts of capital.
Finally, an increase of the Company’s share capital decided by the Board of Directors within the limitations of the
authorised share capital may be subscribed for, and Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or
Class D Shares may be issued with, or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or by incor-
poration of claims in any other way to be determined by the Board of Directors.
3) By resolutions dated 26 January 2015, the Board of Directors has resolved to approve the issuance of 4,439,401
new Class A Shares with a nominal value of EUR 1.- each (the “New shares”), by cancelling the preferential subscription
rights of the existing shareholders, pursuant to article 7.4.3 of the Articles, so as to increase the share capital of the
Company by a total amount of EUR 4,439,401.- (four million four hundred and thirty nine thousand four hundred and
one Euro) so as to raise it from its current amount of EUR 46,765,131.- (forty six million seven hundred and sixty five
thousand one hundred and thirty one Euro) to EUR 51,204,532.-(fifty one million two hundred and four thousand five
hundred and thirty two Euro), together with the payment of a share premium of a total amount of EUR 3,085,361.43
(three million eighty five thousand three hundred and sixty one Euro and forty three Cents).
The New Shares have been subscribed and fully paid up by CNP Assurances, Caisse des Dépôts et Consignation -
Direction des Fonds d’Epargne, Caisse Centrale de Réassurance, ABP Vie, Prédica (Prévoyance Dialogue du Crédit
Agricole), SAS Allianz Logistique and Logistis Luxembourg Feeder S.A., as indicated in the Minutes and the capital increase
and issuance of New shares took place on 26 January 2015.
The justifying documents for the issuance and subscription of the New Shares, such as bank excerpt indicating that
the funds for the subscription of the New Shares have been transferred to the Company’s bank account, have been shown
to the undersigned notary, who expressly acknowledges them.
4) As a consequence of the above mentioned capital increase, as of 26 January 2015 the subscribed share capital of
the Company amounts to EUR 51,204,532.- (fifty one million two hundred and four thousand five hundred and thirty two
Euro).
Therefore article 6 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:
“ 6. Capital. The subscribed capital is set at fifty-one million two hundred and four thousand five hundred and thirty-
two euros (EUR 51,204,532.-), divided into fifty-one million two hundred and four thousand five hundred and twelve
(51,204,512.-) class A shares (the “Class A Shares”), ten (10) class B shares (the “Class B Shares”), four (4) class C shares
(the “Class C Shares”) and six (6) class D shares (the “Class D Shares”), (herein defined as the “Shares”), with a nominal
value of one euro (EUR 1.-), each fully paid up (by 100%).”
Furthermore, consequently to the above mentioned capital increase within the framework of the authorised capital
clause, the amount of the authorised share capital as set out in the first paragraph of article 7.1 of the Articles has been
decreased to EUR 148,711,752.- so that article 7.1 of the Articles is amended accordingly and now reads as follows:
“ 7.1. The Company has an un-issued but authorised share capital of a maximum amount of one hundred forty-eight
million seven hundred eleven thousand seven hundred and fifty-two euros (EUR 148,711,752.-) to be used in order to
issue new Class A Shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares or to increase the nominal
value of the Class A shares and/or Class B Shares and/or Class C Shares and/or Class D Shares.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present stated increase of capital, are estimated at approximately four thousand five hundred Euros (EUR
4,500.-).
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date named at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by his surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l’an deux mille quinze, le douze février,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
A COMPARU:
43965
L
U X E M B O U R G
Isabelle MANGEL, employée de la société AEW Europe S.à r.l., ayant son adresse professionnelle au Luxembourg,
agissant en sa qualité de mandataire du conseil d'administration (le «Conseil d’Administration») de Logistis Luxembourg
S.A., une société anonyme, ayant son siège social au 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duché de Luxembourg),
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140.171 (la "Société"),
Dûment autorisée à représenter la Société conformément au pouvoir conféré en vertu des minutes du conseil d'ad-
ministration de la Société en date du 26 janvier 2015 (les «Minutes»).
Une copie des Minutes, signées ne varietur par le mandataire et le notaire, resteront annexées aux présentes pour
être enregistrée en même temps auprès des autorités d'enregistrement.
La Société a été constituée conformément à l’acte de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem (Grand-
Duché de Luxembourg) en date du 27 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial
C") numéro 1904, page 91347 du 2 août 2008. Ses statuts (les "Statuts") ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du 22 décembre 2014 par devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Redange-sur-Attert (Grand Duché de
Luxembourg), non encore publié au Mémorial C.
Laquelle comparante a requis le notaire instrumentant de prendre acte de ce qui suit:
1) Conformément à l’article 6 des statuts, le capital souscrit de la Société est fixé à quarante-six millions sept cent
soixante-cinq mille cent trente-et-un euros (EUR 46.765.131,-) représenté par quarante-six millions sept cent soixante-
cinq mille cent onze (46.765.111) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), dix (10) actions de catégorie B
(les "Actions de Catégorie B"), quatre (4) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C") et six (6) actions de
catégorie D (les "Actions de Catégorie D") ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune, toutes les actions
étant entièrement libérées (à 100%).
2) Conformément à l’article 7.1. des Statuts, la Société a un capital non-émis, mais autorisé d'un montant maximum
de cent cinquante-trois millions cent cinquante et un mille cent cinquante-trois euros (EUR 153.151.153) qui peut être
utilisé pour l’émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de catégorie C
et/ou Actions de Catégorie D pour l’augmentation de la valeur nominale des Actions de Catégorie A et/ou des Actions
de Catégorie B et/ou des Actions de Catégorie C et/ou des actions de Catégorie D.
Le capital autorisé a pour seul objectif de permettre l’émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de
Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D ou l’augmentation de la valeur nominale
des Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des Actions de Catégorie C et/ou des actions de
Catégorie D existantes en échange d’apport en argent fait par les actionnaires de la Société actuels et futurs en exécution
de l’appel en capital fait par le Conseil d’Administration conformément à tout pacte ayant pu être conclu, à tout moment,
entre, entre autre, les actionnaires de la Société et la Société (le «Pacte d’Actionnaire»).
Dans les limites du capital autorisé, le capital social de la Société peut être augmenté d’un montant, à tout moment, à
l’initiative du Conseil d’Administration, avec ou sans prime d’émission, conformément aux termes et conditions définis
ci-dessous par la création et l’émission de nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions
de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D, étant entendu que:
- Les Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de
Catégorie D pourront être souscrites conformément aux termes et conditions fixés par le Conseil d’Administration dans
les limites strictes stipulées dans le Pacte d’Actionnaire;
- Le Conseil d’Administration pourra également déterminer la date de l’émission et le nombre d’Actions de Catégorie
A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D devant être finalement
souscrites et émises;
- Le Conseil d’Administration est spécialement autorisé à émettre de telles nouvelles Actions de Catégorie A et/ou
Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D sans réserver (c’est-à-dire en
supprimant ou limitant) les droits préférentiels de souscription et d’achat des nouvelles Actions de Catégorie A et/ou
Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D aux actionnaires de la Société
existants;
- Les droits attachés aux nouvelles Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie
C et/ou des Actions de Catégorie D seront strictement similaires aux droits attachés aux Actions de Catégorie A et/ou
Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D existantes; et
- Cette autorisation expirera le cinquième anniversaire de la date de publication dans le journal officiel de Luxembourg
du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 20 mars 2014, mais à la fin d’une telle période une nouvelle période
d’autorisation peut être approuvée par résolution de l’assemblée générale des actionnaires de la Société.
- Le Conseil d’Administration est autorisé à procéder aux modifications nécessaires de l’article 6 des statuts pour
constater le changement de capital social suivant une augmentation conformément à l’article 7 des Statuts; le Conseil
d’Administration a le pouvoir d’exécuter ou d’autoriser tout acte requis par la loi nécessaire luxembourgeoise concernant
les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée. En outre, le Conseil d’Administration peut déléguer au
président du Conseil d’Administration (le «Président») ou à tout administrateur de la Société ou à toute autre personne
dûment autorisée, le pouvoir de recueillir les souscriptions et de recevoir paiement du prix des Actions de Catégorie A
43966
L
U X E M B O U R G
et/ou Actions de Catégorie B et/ou Actions de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D représentant tout ou
partie de cette augmentation de capital.
Finalement, une augmentation de capital social de la Société, décidée par le Conseil d’Administration dans les limites
du capital autorisé, peut être souscrite, et les Actions de Catégorie A et/ou Actions de Catégorie B et ou des Actions
de Catégorie C et/ou des Actions de Catégorie D peuvent être émises, avec ou sans prime d’émission et payées par
apport en nature, en numéraire ou par incorporation de créances de toute autre manière à déterminer par le Conseil
d’Administration.
3) Par des résolutions prises en date du 26 janvier 2015, le Conseil d'Administration a décidé d’approuver l’émission
de 4.439.401 nouvelles Actions de Catégorie A ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1) chacune (les "Nouvelles
Actions de Catégorie A") en annulant les droits préférentiels de souscription des actionnaires actuels, conformément à
l’article 7.4.3 des Statuts, de manière à augmenter le capital social de la Société d’un montant total de EUR 4.439.401,-
(quatre millions quatre cent trente-neuf mille quatre cent un Euro) afin de le porter de son montant de EUR 46.765.131,-
(quarante-six millions sept cent soixante-cinq mille cent trente et un Euro) à EUR 51.204.532,- (cinquante te un millions
deux cent quatre mille cinq cent trente-deux Euros), avec une prime d’émission d’un montant total de EUR 3.085.361,43
(trois millions quatre-vingt-cinq mille trois cent soixante te un Euros et quarante-trois Cents.
Les Nouvelles Actions ont été souscrites et entièrement libérées par CNP Assurances, Caisse des Dépôts et Consi-
gnation - Direction des Fonds d’Epargne, Caisse Centrale de Réassurance, ABP Vie, Prédica (Prévoyance Dialogue du
Crédit Agricole), SAS Allianz Logistique et Logistis Luxembourg Feeder S.A. tel qu’indiqué dans les Minutes et l’augmen-
tation de capital émission des Nouvelles Actions ont eu lieu le 26 janvier 2015.
Les documents justificatifs de l’émission et de la souscription des Nouvelles Actions, tel que le certificat de la banque
indiquant que les fonds pour la souscription des Nouvelles Actions ont bien été transférés sur le compte bancaire de la
Société, ont été montrés au notaire instrumentant, qui en prend acte expressément.
4) Suite à l’augmentation du capital social susmentionnée, avec effet au 26 janvier 2015, le capital souscrit de la société
s’élève à EUR 51.204.532,-.
Il s’ensuit que l’article 6 des Statuts est modifié et doit être lu comme suit:
" 6 Capital Social. Le capital social souscrit de la Société est fixé à cinquante et un millions deux cent quatre mille cinq
cent trente-deux Euros (EUR 51.204.532), divisé en cinquante et un millions deux cent quatre mille cinq cent douze
(51.204.512) actions de catégorie A (les "Actions de Catégorie A"), dix (10) actions de catégorie B (les "Actions de
Catégorie B"), quatre (4) actions de catégorie C (les "Actions de Catégorie C") et six (6) actions de catégorie D (les
"Actions de Catégorie D") (définies dans les présentes comme les "Actions") d’ une valeur nominale d’un Euro (EUR 1)
chacune, intégralement libérées (à 100%)".
De plus, en conséquence de l’augmentation de capital mentionnée ci-dessus intervenue dans le cadre de la clause de
capital autorisé, le montant du capital autorisé tel qu’il figure à l’article 7.1 des Statuts a été réduit à cent quarante huit
millions sept cent onze mille sept cent cinquante-deux euros (EUR 148.711.752,-), de telle sorte que le premier paragraphe
de l’article 7.1 des Statuts est modifié en conséquence et doit être lu comme suit:
" 7.1. La Société a un capital non émis mais autorisé d’un montant maximum de cent quarante huit millions sept cent
onze mille cent sept cinquante-deux euros (EUR 148.711.752) à utiliser afin d'émettre de nouvelles Actions de Catégorie
A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des actions de Catégorie C et/ou des actions de catégorie D ou d’augmenter
la valeur nominale des Actions de Catégorie A et/ou des Actions de Catégorie B et/ou des Actions de Catégorie C et/
ou des Actions de Catégorie D."
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations, et autres charges de quelque nature que ce soit, qui doivent être portés au compte
de la Société par suite de cette augmentation de capital, sont estimés à quatre mille cinq cents Euros.
DON’T ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date mentionnée au début de ce document.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-
parante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même personne et en cas
de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
Et après lecture faite à la comparante, connue du notaire par ses nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne
co-signe avec le notaire le présent acte.
Signé: I. MANGEL et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 13 février 2015. 1LAC / 2015 / 4631. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033211/228.
(150037248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
43967
L
U X E M B O U R G
Brehat, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 132.620.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 9 février 2015i>
<i>Première résolutioni>
L'associé unique a décidé de révoquer avec effet immédiat Mr. Claude Zimmer et Mr. Theo Uffing de leur mandat de
gérants de la société:
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique a décidé de nommer avec effet immédiat en tant que nouveaux gérants administratifs de la société:
Mr. Alexander Villaverde Zweegers, demeurant à 1 Hoeven, B-2275 Lille-Poederlee, Belgique,
Mr. Robert Shyiarambere, demeurant professionnellement au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015033544/18.
(150038018) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Arenov S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 165.170.
<i>Extrait de la convention de cession de partsi>
Conformément à la convention de cession de parts signée entre parties au siège social à Strassen en date du 15
décembre 2014, les associés ont décidé ce qui suit:
a) Premièrement, la société à responsabilité limitée «IMMO CONCEPT ESPACE SARL», établie et ayant son siège
social à L-8189 Kopstal, 15, rue de Saeul, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B,
sous le numéro 157895, déclare vouloir céder:
1) à la société anonyme «PARTHI SA», établie et ayant son siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125636, la pleine propriété de
soixante quinze (75) parts sociales de cent cinquante (150) parts qu'elle possède dans la société Arenov S.à r.l., prédite,
2) à la société anonyme «OL, 3 SA», établie et ayant son siège social à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125294, la pleine propriété
de soixante quinze (75) parts sociales de cent cinquante (150) parts qu'elle possède dans la société Arenov S.à r.l., prédite,
b) Ensuite, la société anonyme «KAPA PARTICIPATIONS SA», établie et ayant son siège social à L-1309 Luxembourg,
8, rue Charles IV, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 36959,
déclare vouloir céder:
1) à la société anonyme «PARTHI SA», établie et ayant son siège social à L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall, inscrite
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125636, la pleine propriété de vingt
cinq (25) parts sociales de cinquante (50) parts qu'elle possède dans la société Arenov S.à r.l., prédite,
2) à la société anonyme «OL, 3 SA», établie et ayant son siège social à L-2124 Luxembourg, 10, rue des Maraîchers,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 125294, la pleine propriété
de vingt cinq (25) parts sociales de cinquante (50) parts qu'elle possède dans la société Arenov S.à r.l., prédite,
Conformément aux dispositions qui précèdent, les parts sociales souscrites sont réparties comme suit:
- La société anonyme «PARTHI SA», prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
- La société anonyme «OL, 3 SA», prénommée, deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Strassen, le 15 décembre 2014.
Référence de publication: 2015032174/33.
(150035736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
43968
Air International Thermal (Luxembourg) Sàrl
Allamanda Investment S.A.
Alzette Securitisation S.A.
Arenov S.à r.l.
Arial Invest S.A.
Aropa S.A.
Brehat
Cavalli Room S. à r.l.
CCIF Finance S.à r.l.
CIH Holdings S.à r.l.
Dentsply SE S.à r.l.
Digital Services Holding XXI s.à r.l.
Duluth Lu S.à r.l.
Eagle 2 S.à r.l.
Etats d'Urgence
Exair S.à r.l.
Exair S.à r.l.
Fondation pour la Promotion du Tennis au Luxembourg
Friolux
GACEREF Luxco Netherlands S.à r.l.
G.M. Jardinage S. à r.l.
Immobilière Ciel S.A.
Immo Color S.à r.l.
Impro Europe S.à r.l.
Jabil Luxembourg Manufacturing S.à r.l.
JM' Agri Sàrl
John Deere Funding S.A.
Kaseya Luxembourg Holdings S.C.A.
Kehlen Capital S.à r.l.
Kepler Private Shareholders S.A.
Kubrat
Latitude Finance S.A.
Lingupedia Investments S. à r. l.
Logistis Luxembourg S.A.
Maintenance and Technical Supplies and Services
Mangrove III S.C.A. SICAR
Migan S.A.-SPF
OCM Luxembourg ROF IV S.à r.l.
OCM Luxembourg SC Fund A S.à r.l.
OCM Luxembourg Wembley Holdings S.à r.l.
Pepp2 S.A.
Princess Holding S.A.
Ratio Holdings Luxembourg S.C.A.
Sete Holdings S.à r.l.
Trans IV (Luxembourg) Retail S.à r.l.
WAVECREST INTERNATIONAL LIMITED