logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 893

1

er

 avril 2015

SOMMAIRE

AFTH S.C.Sp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42818

Akta S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42819

Albama S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42819

Albanel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42819

Alma Lasers Belux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

42819

Argo Services & Consulting S.A. . . . . . . . . .

42822

Bidibul Productions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42837

Business Development S.A.  . . . . . . . . . . . . .

42822

Caldwynn S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42825

Capellen Services Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42825

CCK Compta S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42827

ChaoriSky Solar Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . .

42823

Citruz Prop2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42824

Classifieds Asia Extra S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42824

CMC Mathias Import/Export S.A.  . . . . . . .

42827

Coiffure de Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42828

Colony Sardegna S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

42828

Compagnie Financière Européenne S.A.

SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42824

C. Prestige Investissements S.A. . . . . . . . . .

42823

C. Prestige Investissements S.A. . . . . . . . . .

42823

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . .

42828

Culligan Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

42825

Cynthya Infrastructures S.A.  . . . . . . . . . . . .

42830

Cypress Capital Investments Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42831

Danube SCA SICAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42831

Dengold Overseas S.A., SPF  . . . . . . . . . . . .

42834

Dewdrop Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

42834

DGM&C Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42834

Digital Services XXVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42839

DRS Consulting & Services S.A.  . . . . . . . . .

42834

EAE Négoce S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42837

EFR Services Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . .

42825

E-Media S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42835

E-Media S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42835

Emuto Global Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42835

Emuto Global Capital S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

42837

E.N.A. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42835

E.N.A. Consulting S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42835

Erbil Hotel Partners GP S.à r.l.  . . . . . . . . . .

42837

Goodman Cordovan Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42818

Humaniste Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .

42864

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l.  . .

42864

International Packaging Technologies

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42864

42817

L

U X E M B O U R G

AFTH S.C.Sp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 194.799.

Dénomination ou raison sociale AFTH S.C.Sp
Date de Constitution

23 Février 2015

Durée

illimitée

Indication de object social

Le business et l’objet social du Partenariat sera dans le Grand-Duché du Luxembourg
et ailleurs (i) d'acquérir et de détenir des actions dans des Sociétés de Portefeuille
avec la possibilité pour le commandité d’investir jusqu'à 25 % de la Contribution du
Capital dans des acquisitions de participations et de structures avec
demi-participations à intérêts en dehors des industries FINTECH et TECH sous
réserve des dispositions du présent Accord de Partenariat. Le Partenariat peut
chercher à rentabiliser son acquisition de Sociétés de Portefeuille en utilisant des
dettes de tierces parties au niveau de la Société Portefeuille, (ii) d'investir dans des
titres de créance de Sociétés de Portefeuille et d'acquérir des participations
minoritaires dans des société faisant appel à l’épargne publique où l’intention est de
prendre le contrôle des sociétés faisant appel à l’épargne publique et/ou comme une
opportunité de trading et (iii) de prendre part à de telles activités qui sont liées ou
accessoires à ce qui précède (l’«Affaire»). Le Partenariat a le pouvoir de procéder à
toutes les transactions et faire tout le nécessaire, adapté ou approprié à
l’accomplissement de ou dans la poursuite des objectifs énoncés, et de faire tout
autre acte ou des actes accessoires ou découlant de ou en relation avec ces buts.
Sans préjudice aux dispositions applicables pendant la Période de Montée en vertu
de la clause 23 ci-dessous, le Partenariat mettra en oeuvre son Affaire dans le cadre
de la Limite de Diversification.

Siège social

26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg

Associé Commandité

FT Sàrl, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 26-28 Rives de
Clausen, L-2165 Luxembourg et pas encore, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg

Gérant

FT Sàrl - Associé Commandité

Régime de signature statutaire A l’égard de tiers la Société est liée par (i) la signature de l’Associé Commandité ou

(i) la signature du mandataire auquel l’Associé Commandité à délégué un partie de
ses pouvoirs

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015032945/38.
(150037207) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Goodman Cordovan Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.126.359,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 191.025.

EXTRAIT

En date du 18 décembre 2014, Sugar Maple Logisitcs B.V. a transféré 7.126.358 parts sociales de la Société à GELF

Fizinvest (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au, 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg et 1 part sociale de la
Société à GELF FizPartner (Lux) S.à r.l. ayant son siège social au, 28, boulevard d'Avranches L-1160 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la Société
Christina Mouradian
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015033113/16.
(150036728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

42818

L

U X E M B O U R G

Akta S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 161.076.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080

Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391

A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la

Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.

À Bertrange, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015032948/14.
(150037011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Albama S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 150.979.

Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080

Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391

A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la

Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.

À Bertrange, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015032949/14.
(150037043) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Albanel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 20.230.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
ALBANEL S.A.

Référence de publication: 2015032950/11.
(150036826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Alma Lasers Belux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 194.793.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt janvier
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, soussignée.

A comparu:

La société MSplus S.A., ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, inscrite au Registre

de Commerce et des sociétés sous le numéro B 172.396, constituée suivant acte reçu en date du 24 octobre 2012, ici
représentée par Monsieur Fons MANGEN, Réviseur d’Entreprises, demeurant à Ettelbrück, en vertu d’une procuration
sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte

avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser l’acte constitutif

d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer et dont elle a arrêté les statuts comme suit:

42819

L

U X E M B O U R G

Titre I 

er

 . - Forme juridique - Objet - Dénomination - Siège social - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée unipersonnelle qui sera régie par les lois

en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933 sur les sociétés
à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la société à res-
ponsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

Art. 2. La société prend la dénomination de «ALMA LASERS BELUX S. à r. l.».

Art. 3. Le siège social est fixé à Luxembourg. II pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-duché de Luxembourg

par une décision de l’associé unique, ou en cas de pluralité des associés, par une résolution d’une assemblée générale des
associés. La société peut avoir d’autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à
la fois au Luxembourg et à l’étranger.

Art. 4. La société a pour objet principal la vente ou la location de matériels et de dispositifs médicaux et chirurgicaux,

la vente et la mise au point de produits destinés à la cosmétologie et la médecine esthétique et anti-âge ainsi que l’étude,
la promotion, la formation et l’enseignement dans le domaine du bien-être, de la cosmétologie et de la médecine esthétique
et anti-âge.

La société a également pour objet de prendre des participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes entre-

prises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, d'acquérir tous titres et droits
par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre
manière et notamment d'acquérir tous brevets et licences, les gérer et les mettre en valeur, d'octroyer aux entreprises
dans laquelle la Société a un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin de mener à bien toutes opérations
généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les secteurs pré-décrits et aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.
La dissolution de la Société peut être demandée en justice pour justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution

de la Société ne peut résulter que d'une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les
modifications des statuts.

Titre II. - Capital - Parts

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), divisé en cent vingt-cinq (125) parts

sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, toutes les parts sociales étant intégralement souscrites
et entièrement libérées.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société en proportion directe au nombre

des parts sociales existantes.

Art. 7. Toutes cessions entre vifs de parts sociales détenues par l’associé unique comme leur transmission par voie de

succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux, sont libres.

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne sont cessibles dans ce

même cas à des non-associés qu'avec le consentement préalable des associés représentant au moins les trois quarts du
capital social. Dans les limites légales, les parts sociales ne peuvent être dans le même cas transmises pour cause de mort
à des non-associés que moyennant l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits
appartenant aux survivants.

La société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves librement

distribuables.

L’acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts devront se faire par le biais d’une résolution d’une

assemblée générale des associés et sous les conditions à fixer par une telle assemblée générale des associés.

Titre III. - Gérance

Art. 8. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révoqués par l’associé unique ou

par les associés.

A l’égard des tiers, la Société sera engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants, la

société est, vis-à-vis des tiers, valablement engagée par les signatures conjointes de deux gérants.

Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis vis-à-vis des tiers des pouvoirs les

plus étendus.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de

pouvoirs, associés ou non.

42820

L

U X E M B O U R G

Titre IV. - Décisions des associés - Décisions collectives d'associés

Art. 9. Les associés exercent les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII de

la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée.

II s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.
Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont adoptées par une majorité

d’associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles pour dissoudre la Société ne pourront être prises que par

une majorité en nombre d’associés possédant au moins trois quarts du capital social.

Titre V. - Année sociale - Bilan - Répartitions

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année au trente et un décembre, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le

Conseil de gérance, prépare le bilan et le compte de pertes et profits qui est présenté aux associés en assemblée. L'ex-
cédent  favorable  du  compte  de  profits  et  pertes,  après  déduction  des  frais,  charges,  amortissements  et  provisions,
constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société sera transféré à la réserve légale de la Société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n'importe quelle
raison, la réserve légale représentait moins de un dixième du capital social, le prélèvement annuel de cinq pour cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.

Titre VI. - Dissolution

Art. 12. La Société n'est pas dissoute automatiquement par le décès, la faillite, l’interdiction ou la déconfiture d'un

associé.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par le ou les gérant(s) en fonctions ou, a défaut, par un ou

plusieurs liquidateurs nommé(s) par l’associé unique ou, selon le cas, par l’assemblée des associés. Le ou les liquidateurs
auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera attribué à l’associé unique ou, selon le cas, partagé entre les associés dans la

proportion des parts dont ils seront alors propriétaires.

Titre VII. - Dispositions générales

Art. 13. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou les associés s'en réfèrent à la loi

modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

<i>Disposition transitoire:

Par dérogation, le premier exercice social commencera à la date de constitution de la Société et s’achèvera le trente-

et-un décembre 2015.

<i>Souscription et libération:

Toutes les parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

MSplus S.A., pré-qualifiée, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 parts

La libération intégrale du capital social a été faite par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) se trouve à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
soussigné par certificat bancaire, qui le constate expressément.

<i>Evaluation des frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution au montant de EUR 1.100,-.

<i>Résolutions de l’associé unique suite à la constitution

Après que les statuts aient été rédigés, l’associé unique, représentant l’intégralité du capital social, a pris les résolutions

suivantes

1.- Le nombre des gérants est fixé à un (1).
2.- Est nommé gérant de la Société pour une durée indéterminée:

42821

L

U X E M B O U R G

Monsieur Mark LOGAN, gérant, né le 18 août 1964 à Hakney-London, demeurant à 30, avenue de Grande Bretagne,

MC- 98000 Monaco.

3.- La société est engagée, en toutes circonstances, y compris pour toutes opérations bancaires, par la seule signature

du gérant.

4.- L’adresse du siège social de la Société est fixée à L-1724 Luxembourg, 9b, boulevard Prince Henri, Grand Duché

de Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.

Et après information par le notaire de la comparante que la constitution de la présente société ne dispense pas, le cas

échéant, la société de l’obligation de demander une autorisation de commerce afin de pouvoir se livrer à l’exercice des
activités décrites à l’article 4 des présents statuts, respectivement après lecture faite et interprétation donnée à la com-
parante, connue du notaire par ses nom, prénoms usuels, état et demeure, de tout ce qui précède, elle a signé le présent
acte avec le notaire.

Signé: F. MANGEN, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1749. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015032951/144.

(150037209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Argo Services &amp; Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 278, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.250.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015032955/12.

(150036817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Business Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 74.712.

<i>Résolution de l'administrateur unique

- L'administrateur unique décide de transférer le siège social de la société BUSINESS DEVELOPMENT SA de L-1661

Luxembourg, 47 Grand Rue à l'adresse L-1661 Luxembourg, 1 Grand Rue.

La présente résolution est une version corrigée qui remplace la première version déposée au RCS sous le numéro

L150020149.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Emmanuelle Favreau
<i>L'administrateur unique

Référence de publication: 2015032988/15.

(150036883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

42822

L

U X E M B O U R G

C. Prestige Investissements S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 173.694.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 janvier 2013

Lors d'une Assemblée générale extraordinaire tenue en date du 15 janvier 2013 au siège social de la société C. PRES-

TIGE INVESTISSEMENTS S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer,
l'actionnaire unique de la Société a pris les résolutions suivantes:

1. Révocation de Monsieur Jean-Marc WANT, précité, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 21-25,

allée Scheffer, de son poste d'administrateur de la Société à la date de la présente Assemblée.

2. Nomination de Madame Sylvia ROZE, précitée, demeurant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée

Scheffer, en qualité d'administrateur de la Société, en lieu et place de Monsieur Jean-Marc WANT à la date de la présente
Assemblée.

3. Révocation de la société WANT BROTHERS ACCOUNTING S.A., en abrégée WBA S.A., société anonyme de

droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le matricule B 146.193, dont le siège social
est établi à L-1630 Luxembourg, 26, rue Glesener de sa qualité de commissaire aux comptes à la date de la présente
Assemblée.

4. Nomination de la société COMPAGNIE FINANCIERE ET COMMERCIALE TAMINO S.A., société anonyme de

droit luxembourgeois, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le matricule B 167.894, dont le siège social
est établi à L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer en qualité de commissaire aux comptes à la date de la présente
Assemblée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015032989/27.
(150036809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

C. Prestige Investissements S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 32.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 173.694.

<i>Extrait du conseil d'administration de la Société en date du 26 août 2014

Suivant les termes et conditions repris aux dispositions de l'article 2 des statuts de la Société, le Conseil d'Adminis-

tration a pris à l'unanimité des voix des membres présents et représentés, la décision de procéder au transfert du siège
social de la Société sur la commune de Luxembourg, de son adresse actuelle L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer
au L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri avec effet au 26 août 2014.

L'adresse professionnelle de Monsieur Fabrice Lallemand, administrateur de la Société, est transférée du L-2520 Lu-

xembourg, 21-25, allée Scheffer au L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, avec effet au 26 août 2014.

L'adresse professionnelle de Madame Sylvia Rozé, administrateur de la Société, est transférée du L-2520 Luxembourg,

21-25, allée Scheffer au L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri, avec effet au 26 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015032990/18.
(150036809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

ChaoriSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.011.800,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 163.085.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

42823

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 février 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015033000/14.
(150037121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Citruz Prop2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 190.060.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 20 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, M. Manish Desai et Mme. Figen Eren avec effet au 31 janvier 2015;
- De nommer M. Paul Lawrence, né le 25 mai 1970 à Rotherham, Royaume-Uni, ayant sa résidence professionnelle à

2-4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et M. Mark Hulbert, né le 15 décembre 1964 à Plymouth, Royaume Uni,
ayant sa résidence professionnelle à 27 Knightsbridge, London SW1 7LY, Royaume Uni comme gérants de la société avec
effet au 31 janvier 2015 et pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citruz Prop2 S.à r.l.

Référence de publication: 2015033001/16.
(150037236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Classifieds Asia Extra S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 181.092.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015033002/12.
(150036848) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF, Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 1, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 114.928.

<i>Résolution du conseil d'administration

- Il résulte d'une réunion du conseil d'administration que le siège social de la société Compagnie Financière Européenne

S.A. SPF est transféré de L-1661 Luxembourg, 47 Grand Rue à l'adresse L-1661 Luxembourg, 1 Grand Rue.

La présente résolution est une version corrigée qui remplace la première version déposée au RCS sous le numéro

L150020148.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Philippe Leroy
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015033005/15.
(150036884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

42824

L

U X E M B O U R G

Culligan Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 17.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 101.989.

EXTRAIT

En date du 10 février 2015, l'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- La démission de Erik Johan Cornelis Schoop, en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet de le 10 février

2015;

- Jean-Marc McLean, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est élu nouveau

gérant de la Société avec effet de le 10 février 2015 et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Référence de publication: 2015033011/16.
(150037203) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Caldwynn S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 147.709.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033012/10.
(150036797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

EFR Services Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Capellen Services Sàrl).

Siège social: L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss.

R.C.S. Luxembourg B 69.621.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third February,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,

There appeared

DELEK LUXEMBOURG S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at L-1141 Luxembourg,

103, Bei der Härewiss, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 4.427 (the
Shareholder),

hereby represented by Mr Mathieu GIROTTO, lawyer, residing professionally in 2, Place Winston Churchill, L-1340

Luxembourg,

by virtue of a proxy given in Cergy (France) on 20 

th

 February 2015.

The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached

to this deed in order to be registered therewith.

The appearing party is the sole shareholder of CAPELLEN SERVICES S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having

its registered office at L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 69.621 incorporated pursuant to a notarial deed dated 6 

th

 May 1999, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 529 of 10 

th

 July 1999 (hereafter the "Company").

The articles of incorporation have been amended by a notarial deed on 20 

th

 November 2014, published in the Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3865 of 13 

th

 December 2014.

The appearing party, represented as stated above, representing the entire share capital then deliberates upon the

following agenda:

<i>Agenda

1. Modification of the denomination of the Company into EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l. and subsequent

amendment  of  article  4  of  the  articles  of  incorporation  of  the  Company  in  order  to  reflect  the  modification  of  the
denomination;

42825

L

U X E M B O U R G

2. Statement of the name change o f the registered seat into “Bei der Härewiss”;
3. Modification of article 13 of the articles of incorporation;
4. Miscellaneous.
The appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution:

The general meeting resolves to change the denomination of the Company into “EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à

r.l.” and consequently to amend article 4 of the articles of incorporation of the Company, which will henceforth be read
as follows:

“ Art. 4. The Company exists under the name of “EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.”.”

<i>Second resolution:

The general meeting states that the name of the street of the registered office of the Company has changed into “Bei

der Härewiss”.

<i>Third resolution:

The general meeting resolves to add a paragraph onto article 13 of the articles of incorporation of the Company, which

will be read as follows:

“ Art. 13. (addition of a paragraph). Any manager may participate in any meeting of the board of managers by confe-

rence-call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the
meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting.”

There being no further business, the meeting is closed.

Whereof this deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date stated at the

beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the proxyholder

of the appearing party, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the same appearing
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, said proxyholder signed together with the

notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt-trois février,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,

A comparu:

DELEK LUXEMBOURG S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à L-1141 Luxembourg, 103,

Bei der Härewiss, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.427,

ici représentée par Monsieur Mathieu GIROTTO, avocat, résidant professionnellement à 2, Place Winston Churchill,

L-1340 Luxembourg,

en vertu d’une procuration sous seing privé donnée à Cergy (France), le 20 février 2015.
La procuration signée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

La comparante est l’associée unique de CAPELLEN SERVICES S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son

siège social à L-1141 Luxembourg, 103, Bei der Härewiss inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 69.621 constituée suivant acte notarié en date du 6 mai 1999, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Association, numéro 529 du 10 juillet 1999 (ci-après la «Société»).

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 20 novembre 2014, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Association, numéro 3865 du 13 décembre 2014.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, représentant la totalité du capital social, délibère selon l’ordre

du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1) Modification de la dénomination de la Société en EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l. et modification afférente

de l’article premier des statuts de la Société afin de tenir compte du changement de dénomination;

2) Constatation du changement du nom de la rue du siège social en «Bei der Härewiss»;
3) Modification de l’article 13 des statuts de la Société
4) Divers.

42826

L

U X E M B O U R G

L’associée unique, représentée comme indiqué ci-avant, a requis le notaire soussigné de prendre acte des résolutions

suivantes:

<i>Première résolution:

L’assemblée générale décide modifier la dénomination de la Société en «EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.» et

par conséquent de modifier l’article 4 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« Art. 4. La société prend la dénomination de «EFR SERVICES LUXEMBOURG S.à r.l.» (la Société).»

<i>Deuxième résolution:

L’assemblée générale constate que le nom de la rue du siège social de la Société a été changé en «Bei der Härewiss».

<i>Troisième résolution:

L’assemblée générale décide d’ajouter un paragraphe à l’article 13 des statuts de la Société, qui aura la teneur suivante:

« Art. 13. (ajout d’un paragraphe). Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence

téléphonique, visio-conférence ou d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à
cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une
présence en personne à une telle réunion.»

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la
version anglaise fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, ledit mandataire a signé avec le notaire

le présent acte.

Signé: M. GIROTTO et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 24 février 2015. 1LAC/2015/5669. Reçu soixante-quinze euros € 75,-

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033014/107.
(150036702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

CCK Compta S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 31, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 141.646.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033015/10.
(150036772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

CMC Mathias Import/Export S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8069 Bertrange, 19, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 161.142.

<i>Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 12/02/2015

<i>Résolutions

L'Assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions ci-dessous:
Madame Maria Albertina MENDES PRATES, demeurant à 132, Route d'Esch L-3922 Mondercange et Monsieur David

VEIGA, demeurant à 132, Route d'Esch L-3922 Mondercange, démissionnent de leurs fonctions d'Administrateurs de la
Société.

42827

L

U X E M B O U R G

La société sera engagée par l'unique signature de l'Administrateur délégué.

Bertrange, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015033022/15.
(150037056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Coiffure de Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2628 Luxembourg, 47, rue des Trévires.

R.C.S. Luxembourg B 160.193.

La société constate la rectification du nom d'un associé et la cession de parts sociales sur base d'un contrat de cession

sous seing privé en date du 03 février 2015 que ci-après:

- Le nom de l'associé Maria DE FATIMA SANTOS est Maria de Fatima SANTOS
- Monsieur Daniel LOPES, demeurant à L-4082 Esch-sur-Alzette, 107, rue Dicks, cède 25 parts sociales de la société:
à
* Madame Maria de Fatima SANTOS, demeurant à L-7450 Lintgen, 74, route Principale, qui accepte les 8 parts sociales.
* Madame Claudia Sofia MENDEZ VAZ, demeurant à D-66693 Orscholz, 50, zur Grosswies, qui accepte les 8 parts

sociales.

* Monsieur Lino Alberto SEMEDO VARELA, demeurant à L-4430 Belvaux, 43A, rue Grand-Duchesse, qui accepte les

9 parts sociales.

Luxembourg, le 03 février 2015.

SANTOS Maria De Fatima
<i>Gérant technique

Référence de publication: 2015033023/20.
(150036902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Colony Sardegna S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.482.100,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 2-4, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 94.362.

EXTRAIT

Il est à noter que le siège social de Colony Luxembourg S.à r.l., l'un des gérants de Colony Sardegna S.à r.l. a été

transféré du 2-4 avenue Marie-Thérèse L-2132 Luxembourg, au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, avec
effet au 1 

er

 août 2014.

Et il est à noter également, qu'il résulte de la lettre de démission en date du 17 juin 2014, que Mr Claude Baer a

démissionné de ses fonctions de gérant de la société avec effet au 1 

er

 juillet 2014.

Par suite, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Colony Luxembourg S.à r.l. sis au 121 avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg, Luxembourg
- Mr. Jonathan Grunzweig domicilié 2450 Broadway, 6 

th

 Floor CA-90404 Santa Monica, USA

- Mr. David James Monahan domicilié 3000 Paradise Road, NV-89109 Las Vegas, USA
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Véronique Réveilliez
<i>Responsable Juridique / Habilitée par la gérance

Référence de publication: 2015033024/21.
(150037099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 11.756.

In the year two thousand and fifteen, on the thirtieth day of January
Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A., a company limited

by shares (société anonyme), having its registered office in L - 2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet, registered with the

42828

L

U X E M B O U R G

Luxembourg Trade and Companies Register (RCS) under number B 11756, incorporated by deed of the notary Me Carlo
FUNCK, then residing in Luxembourg, on the 28 

th

 of January 1974, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations C of 15 

th

 February 1974 number 30 and amended several times and at the latest by deed of the undersigned

notary on the 30 January 2015, not yet published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C (the “Company”),

The meeting was opened at 3 pm, with Mr. Yves Maas, professionally residing in Luxembourg, in the chair,
who appointed as secretary Dr. Marion Rinke, with professional residence in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr. Michael Relke, with professional residence in Luxembourg.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the meeting is the following:
Amendment of Article 16 of the articles of incorporation of the Company with the following content: “The remune-

ration of the members of the Board of Directors is determined by the general meeting of shareholders.”

II.- That the sole shareholder represented, the proxy of the represented sole shareholder and the number of its shares

are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the proxyholder of the represented sole
shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

The proxy of the represented sole shareholder, if any, initialled “ne varietur” by the appearing parties and the under-

signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That the entire share capital being represented at the present Extraordinary General Meeting and the represented

sole shareholder declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this extraordinary general
meeting, no convening notices were necessary.

IV. That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and

may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The general meeting unanimously resolves to amend Article 16 of the articles of incorporation of the Company which

will have the following content:

“ Art. 16. The remuneration of the members of the Board of Directors is determined by the general meeting of

shareholders.”

There being no further business, the meeting is closed at 3.15 pm.

<i>Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at about EUR 1,200.

<i>Powers

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any clerc and / or employee of the firm

of the undersigned notary, acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to
the present deed.

Whereof, the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English

followed by a German version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and
the German text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil

status and residences, the members of the board of the meeting signed together with the notary the present deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung Vorangehenden Textes

Im Jahre zweitausendfünfzehn, den dreißigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtswohnsitze zu Niederanven, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Versammelten sich zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Aktionäre der Gesellschaft CREDIT SUISSE

(LUXEMBOURG) S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in L - 2180 Luxemburg, 5, rue Jean Monnet,
eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 11756, gegründet gemäß Urkunde,
aufgenommen durch den Notar Henri FUNCK, vormals mit Amtswohnsitz in Luxembourg, am 28. Januar 1974, veröf-
fentlicht im Mémorial Recueil des Sociétés et Associations C vom 15. Februar 1974, Nummer 30, zuletzt abgeändert
gemäß Urkunde, aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar am 30. Januar 2015, noch nicht veröffentlicht im
Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (die „Gesellschaft“).

Die Versammlung wurde um 15 Uhr mit Herrn Yves Maas, geschäftsansässig in Luxemburg, als Vorsitzendem eröffnet,

Der Vorsitzende beruft zur Schriftführerin Frau Dr. Marion Rinke, mit beruflicher Adresse in Luxemburg.

42829

L

U X E M B O U R G

Die Versammlung wählt einstimmig zum Stimmzähler Herrn Michael Relke, mit beruflicher Adresse in Luxemburg.
Da somit das Versammlungsbüro zusammengesetzt wurde, ersucht der Vorsitzende den unterzeichnenden Notar

folgendes zu beurkunden:

I.- Dass die Tagesordnung folgenden Wortlaut hat:
Änderung von Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft mit folgendem Wortlaut: “Die Vergütung der Verwaltungsrats-

mitglieder wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.”

II.- Dass der vertretene alleinige Aktionär, die Vollmacht des vertretenen alleinigen Aktionärs und die Stückzahl seiner

Aktien auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind; diese Anwesenheitsliste, nachdem sie durch den Bevollmächtigten
des alleinigen Aktionärs unterschrieben wurde, wird durch das Versammlungsbüro geprüft und unterschrieben.

Die Vollmacht des vertretenen alleinigen Aktionärs, wird, nach gehöriger „ne varietur“ Unterzeichnung durch die

Parteien und den instrumentierenden Notar, gegenwärtigem Protokolle, mit welchem sie einregistriert wird, als Anlage
beigebogen.

III.- Dass das gesamte Aktienkapital bei gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung vertreten ist and und

der vertretene alleinige Aktionär erklärte, dass er ordnungsgemäße Mitteilung und Kenntnis der Tagesordnung vor dieser
außerordentlichen Generalversammlung erlangt hatte, so dass kein Einberufungsschreiben notwendig war.

IV.- Dass in gegenwärtiger außerordentlicher Generalversammlung das gesamte Aktienkapital vertreten ist, dass somit

die Versammlung ordnungsgemäß zusammengetreten und befugt ist, über alle auf der Tagesordnung stehenden Punkte
zu beraten.

Sodann hat die Versammlung, nach Beratung, einstimmig folgenden einzigen Beschluss gefasst:

<i>Einziger Beschluss

Die Generalversammlung beschließt einstimmig Artikel 16 der Satzung der Gesellschaft abzuändern, welcher folgenden

Wortlaut haben wird:

“ Art. 16. Die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird durch die Gesellschafterversammlung bestimmt.”
Da somit die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung durch den Vorsitzenden geschlossen um 15 Uhr 15.

<i>Kosten

Die Kosten und Gebühren jeglicher Art, welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Beurkundung obliegen,

werden auf ungefähr EUR 1.200 veranschlagt.

<i>Bevollmächtigung

Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten

Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde (bezüglich Tippfehlern) gegenwärtiger
Urkunde aufzunehmen.

Worüber am eingangs erwähnten Datum zu Luxemburg Urkunde aufgenommen wurde.
Der unterzeichnete Notar, welcher die englische Sprache versteht und spricht, hat vorliegende Urkunde auf Wunsch

der vorbenannten Erschienenen in Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Im Falle von Unterschieden
zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll, laut den Erschienenen, der englische Text maßgebend sein.

Und nach Verlesung alles Vorstehenden an die Erschienenen, alle dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen,

Familienstand und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde gemeinsam mit dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet: Yves Maas, Marion Rinke, Michael Relke, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 1LAC / 2015 / 3002 Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, den 9. Februar 2015.

Référence de publication: 2015033032/108.
(150036787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Cynthya Infrastructures S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 193.418.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 février 2015

Il ressort des résolutions prises par le Conseil d'administration de la Société en date du 11 février 2015 que:
- Monsieur Christian MOGNOL, né le 15.01.1962 à Esch-sur-Alzette, demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L - 2086 Luxembourg, est nommé Président du Conseil d'Administration. Ce dernier assumera cette fonction
jusqu'à l'assemblée statutaire de 2020.

42830

L

U X E M B O U R G

Certifié sincère et conforme
<i>POUR LA SOCIETE
Signatures

Référence de publication: 2015033033/15.
(150037074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Cypress Capital Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 144.300.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 6 novembre 2013 and 4 février 2015

Les résolutions suivantes ont été adoptées par l'associé unique en date du 6 novembre 2013 et 4 février 2015:
1- M. Ely-Michel Ruimy, né le 31 décembre 1964, à Casablanca, Maroc, ayant son adresse au 49, Grosvenor Street,

W1K 3HP Londres, Royaume-Uni, a été nommé gérant de la Société au 6 novembre 2013 pour une durée indéterminée.

2- La démission de Monsieur Ely-Michel Ruimy et de Monsieur Adrian Braimer-Jones de leur mandats de gérant de la

Société est acceptée avec effet au 4 février 2015.

2- Ensof Services S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 6A,

route de Trèves, L- 2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.865, a été nommée gérant de la Société, avec effet au 4 février
2015, pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 20 février 2015.

Référence de publication: 2015033034/21.
(150037179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Danube SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement

en Capital à Risque.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 149.983.

In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of January
Before Maître Carlo Wersandt, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,

THERE APPEARED

Mrs Arlette Siebenaler, private employee, with professional address in Luxembourg,
acting by virtue of circular resolutions taken by the board of managers of Danube Management S.à r.l. acting in its

capacity as manager (gérant) of “Danube S.C.A., SICAR” (the “Manager”) on 8 December 2014, copy of said circular
resolutions, after having been signed ne varietur by the appearing person and the undersigned notary will be annexed to
this document to be filed with the registration authorities,

Who declared and required the notary to record that:
I. - The company “Danube S.C.A., SICAR”, an investment company in risk capital (société d’investissement en capital

à risque) (“SICAR”) under the form of a SCA (société en commandite par actions), having its registered office at Garden
Floor Forte F1, 2a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies under number B 149983 was incorporated by a notarial deed on 9 December 2009 (the “Company”)
published in the Mémorial C under number 74 of 12 January 2010 and as amended by a notarial deed on 2 February 2010
published in the Mémorial C on 30 March 2010 under number 669, amended again by a notarial deed on 31 March 2010,
published in the Mémorial C on 4 June 2010 under number 1171, amended again by a notarial deed on 17 June 2010,
published in the Mémorial C on 5 October 2010 under number 2082, amended by a notarial deed on 10 January 2011,
published in the Mémorial C on 17 May 2011 under number 1030, amended again by a notarial deed on 25 January 2011
published in the Mémorial C on 17 May 2011 under number 1110, and amended again by a notarial deed on 6 May 2011,
published in the Mémorial C on 14 July 2011 under number 1571, and amended again by a notarial deed on 8 June 2011,
published in the Mémorial C on 6 September 2011 under number 2068, amended again by a notarial deed on 7 December
2011, published in the Mémorial C on 31 January 2012 under number 257, amended again by a notarial deed on 13 January
2012, published in the Memorial C on 17 March 2012 under number 718, amended again by a notarial deed on 21 June
2012, published in the Memorial C on 3 August 2012 under number 1931, amended again by a notarial deed on 22

42831

L

U X E M B O U R G

November 2012, published in the Memorial C on 3 January 2013 under number 18, amended again by a notarial deed on
14 January 2013, published in the Memorial C on 10 April 2013 under number 846, amended again by a notarial deed on
20 June 2013, published in the Memorial C on 20 August 2013 under number 2018, amended again by a notarial deed on
8 October 2013, published in the Memorial C on 3 December 2013 under number 3052, amended again by a notarial
deed on 10 January 2014, published in the Mémorial C on 11 April 2014 under number 939, amended again by a notarial
deed on 6 June 2014, published in the Mémorial C on 21 August 2014 under number 2225.

II. - According to article 5 of the articles of association of the Company (the “Articles”), the Company has an issued

capital of FIFTEEN MILLION ONE HUNDRED AND EIGHTY ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY
THREE UNITED STATES DOLLARS AND TWENTY SIX CENTS (15,181,763.26-.USD) divided into:

i)  EIGHT  HUNDRED  AND  NINETY  ONE  THOUSAND  FOUR  HUNDRED  AND  FIFTY  NINE  POINT  THREE

HUNDRED AND TWENTY SEVEN (891,459.327) Class A Ordinary Shares (each a “Class A Ordinary Share”);

ii) ONE (1) Class B Ordinary Share (each a “Class B Ordinary Share”);
iii) SIX HUNDRED AND TWENTY SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED AND FOURTEEN POINT NINE HUN-

DRED AND NINETY NINE (626,714.999) Class C Ordinary Shares (each a “Class C Ordinary Share”); and

iv) ONE (1) Management Share (each a “Management Share”).
The  Company  has  an  authorised  share  capital  of  ONE  HUNDRED  MILLION  UNITED  STATES  DOLLARS

(100,000,000.-USD) divided into TEN MILLION (10,000,000) Shares, comprising;

i) NINE MILLION NINE HUNDRED AND NINETY NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND NINETY NINE

(9,999,999) Ordinary Shares; and

ii) ONE (1) Management Share.
The Manager is authorised by article 5 of the Articles to cause the Company to issue further Ordinary Shares and

Management Shares so as to bring the total capital of the Company up to the total authorised share capital from time to
time as it, in its discretion, may determine and to accept subscriptions for such Shares within a period of five (5) years as
from the date of incorporation of the Company such as determined by article 32 (5) of the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.

The Manager is further authorised by article 5 of the Articles to determine the conditions attaching to any subscription

for Ordinary Shares and Management Shares from time to time (including the payment of any share premium or sub-
scription surplus).

The Manager is further authorised to issue such Ordinary Shares and Management Shares under and during the period

referred to above without the Shareholders having any preferential subscription rights.

When the Manager effects an increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it is obliged under article

5 of the Articles to take steps to amend article 5 of the Articles in order to record the change and the Manager is further
authorised to take or to authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance
with Luxembourg law.

III. - Pursuant to this authorisation, the Manager has decided on 8 December 2014 to increase the share capital of the

Company by issuing further Class A Ordinary Shares (the “New Class A Ordinary Shares”) and further Class C Ordinary
Shares (the “New Class C Ordinary Shares”) by an amount of TWO HUNDRED AND SEVENTY SIX THOUSAND
THREE HUNDRED AND TWENTY ONE UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS (276,321.50 USD) so as to
bring the total capital of the Company from its present amount of FIFTEEN MILLION ONE HUNDRED AND EIGHTY
ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED AND SIXTY THREE UNITED STATES DOLLARS AND TWENTY SIX CENTS
(15,181,763.26-.USD) to FIFTEEN MILLION FOUR HUNDRED AND FIFTY EIGHT THOUSAND AND EIGHTY FOUR
UNITED STATES DOLLARS AND SEVENTY SIX CENTS (15,458,084.76.-USD) by the issue of SIXTEEN THOUSAND
FOUR HUNDRED AND THREE POINT FIVE HUNDRED (16,403.500) New Class A Ordinary Shares and ELEVEN
THOUSAND TWO HUNDRED TWENTY EIGHT POINT SIX HUNDRED AND FIFTY (11,228.650) New Class C
Ordinary Shares.

The Manager further resolved on 8 December 2014 to suppress the preferential rights of existing shareholders in

relation to the aforementioned increase of the share capital of the Company.

The new shares have been subscribed as follows:
(i) SIXTEEN THOUSAND FOUR HUNDRED AND THREE POINT FIVE HUNDRED (16,403.500) New Class A

Ordinary Shares have been subscribed by Danube Fund LP with registered office at c/o Walker SPV Limited, Walker
House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KYI-9002, Cayman Islands.

(ii) the New Class C Ordinary Shares have been subscribed as follows:

Nbr Name of Shareholders

No. of C

Shares

1

OTP Voluntary Pension Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,500

2

László Wolf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

3

Peter Holtzer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193.750

4

Specton Investments Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

625

42832

L

U X E M B O U R G

5

Valean Investments Limited

625

6

Karoly Radzik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127.5

7

Zsolt Kovács  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

8

Miklós Zsoldos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

157.4

9

György Zolnai  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-

10

MHS European Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,250

TOTAL

The total subscription amount of TWO HUNDRED AND SEVENTY SIX THOUSAND THREE HUNDRED AND

TWENTY ONE UNITED STATES DOLLARS AND FIFTY CENTS (276,321.50 USD) has been fully paid up by the abo-
vementioned shareholders and evidence of the aforementioned payment has been given to the undersigned notary who
acknowledges this expressly.

Following the realisation of the increase of capital, the sixth paragraph of article 5 of the Articles is amended to be

worded as follows:

English version:

“The Company has a subscribed share capital of fifteen million four hundred and fifty eight thousand and eighty four

united states dollars and seventy six cents (15,458,084.76.-USD) divided into:

(1) Nine hundred and seven thousand eight hundred and sixty two point eight hundred and twenty seven (907,862.827)

Class A Ordinary Shares issued to Danube Fund LP, a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered
office in the Cayman Islands c/o Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9002, Cayman Islands (the “Partnership”). The Class A Ordinary Shares are neither obliged to fund any portion of
the Management Fee nor subject to Carried Interest, as further described article 29.3.c below;

(2) One (1) Class B Ordinary Share, issued with respect to the interests of the Carried Interest Shareholder (as defined

below) which is not obliged to fund any portion of the Management Fee and which is entitled to receive Carried Interest
as further described in article 29.3.c. below;

(3) Six hundred and thirty seven thousand nine hundred and forty three point six hundred and forty nine (637,943.649)

Class C Ordinary Shares, issued with respect to direct Investors each of whom has not been designated to be an affiliate
by the Manager. The Class C Ordinary Shares will receive a Preferred Return (as defined below), are subject to Carried
Interest and will be obliged to pay a share of the Management Fee, as further described in article 29.3.c. below; and

(4) One (1) Management Share, issued with respect to the interest of the Unlimited Shareholder, which is not obliged

to fund any portion of the Management Fee.”

French version:

«La Société dispose d’un capital social souscrit de quinze millions quatre cent cinquante-huit mille quatre-vingt-quatre

dollars américains et soixante-seize centimes (15.458.084,76-.USD), répartis en:

(1) neuf cent sept mille huit cent soixante-deux virgule huit cent vingtsept (907.862,827) Actions Ordinaires de Ca-

tégorie A émises pour Danube Fund LP, une société en commandite exonérée d’impôts de droit des îles Cayman, ayant
son siège aux îles Cayman chez Walker SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman
KY1-9002, Cayman Islands, (l’«Entreprise»). Les Actions Ordinaires de Catégorie A ne financent pas obligatoirement une
partie des Frais de Gestion, et ne sont pas soumises au Carried Interest, tel que décrit ultérieurement dans l’article 29.3.c
ci-dessous;

(2) Une (1) Action Ordinaire de Catégorie B, émis en faveur du Carried Interest Shareholder (tel que défini ci-dessous)

qui n’est pas tenu de financer une partie des Frais de Gestion et qui est en droit de percevoir un Carried Interest tel que
décrit ultérieurement dans l’article 29.3.c ci-dessous;

(3) six cent trente-sept mille neuf cent quarante-trois virgule six cent quarante-neuf (637.943,649) Actions Ordinaires

de Catégorie C, émises en faveur des investisseurs directs qui n’ont pas été nommés comme affiliés par le Gérant. Les
Actions Ordinaires de Catégorie C recevront un Rendement Préférentiel (tel que décrit cidessous), sont soumises au
Carried Interest et entraîneront obligatoirement le paiement d’une partie des Frais de Gestion, tel que décrit ultérieu-
rement dans l’article 29.3.c ci-dessous; et

(4) Une (1) Action de Gestion, émise en faveur de l’Actionnaire Gérant Commandité, qui n’est pas obligé de financer

une partie des Frais de Gestion.»

<i>Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges in any form whatsoever incumbent to the corporation and charged to

it by reason of the present deed are assessed at EUR 2,200.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing

persons, this deed is worded in English only.

42833

L

U X E M B O U R G

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their names,

surnames, civil status and residences, the said persons appearing signed together with the notary, the present deed.

Signé: A. SIEBENALER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1166. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 25 février 2015.

Référence de publication: 2015033035/155.
(150036912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Dengold Overseas S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 76.796.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 11 février 2015

SGG S.A., Société Anonyme luxembourgeoise, ayant son siège au 412F, route d'Esch à L-2086 Luxembourg est nommée

Agent Dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 24 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur.

Référence de publication: 2015033046/11.
(150037330) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Dewdrop Holdings S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 146.064.

HRT FIDALUX S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen (anciennement 23, Val Fleuri, L-1526

Luxembourg), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 41.178, agent domiciliataire de
la société DEWDROP HOLDINGS S.A., une Société Anonyme, ayant son siège social au 23 Val Fleuri, L-1526 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 146.064
(la «Société»), a décidé de dénoncer le siège de la Société avec effet au 24 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033047/13.
(150036819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

DGM&amp;C Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 172.372.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033048/10.
(150037064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

DRS Consulting &amp; Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 44, rue Gabriel Lippman.

R.C.S. Luxembourg B 74.810.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033049/9.
(150036703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

42834

L

U X E M B O U R G

E.N.A. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 82.241.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033050/10.
(150037219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

E.N.A. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 11, rue des Trois Cantons.

R.C.S. Luxembourg B 82.241.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 2 février 2015

L'assemblée décide d'informer le Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg du changement d'adresse du

Commissaire aux Comptes de la Société, comme suit:

Tax Consult S.A., 6 Place de Nancy, L-2212 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

E.N.A. CONSULTING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015033051/14.
(150037272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

E-Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 64.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015033052/10.
(150037259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

E-Media S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 64.150.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2015033053/10.
(150037260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Emuto Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.172.

Im Jahre zwei tausend fünfzehn, den dreissigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Danielle KOLBACH, mit dem Amtssitz in Redange-sur-Attert, (Großherzogtum Lu-

xemburg), handelnd in Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit dem Amtssitz in Junglinster,
(Großherzogtum Luxemburg), welch letzt genannter Depositar der Urkunde bleibt.

IST ERSCHIENEN:

STICHTING  EMUTO,  eine  nach  niederländischem  Recht  eingetragene  Gesellschaft,  mit  Sitz  in  Hemonystratt  11,

NL-1074BK Amsterdam, Niederlande, hier vertreten durch Herrn Marco BREHM, Angestellter, berufsansässig in Muns-

42835

L

U X E M B O U R G

bach,  6B,  rue  Gabriel  Lippmann,  auf  Grund  einer  ihm  ausgestellten  Vollmacht,  welche  nach  «ne  varietur»  Signatur,
gegenwärtiger Urkunde beigebogen bleibt.

Welche Komparentin den amtierenden Notar, durch ihren Bevollmächtigten, ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Emuto Global Capital S.à r.l.", mit Sitz in L-2180 Luxembourg, 3,

rue  Jean  Monnet,  eingetragen  im  Handels-  und  Gesellschaftsregister  von  Luxemburg,  Sektion  B,  unter  der  Nummer
130.172, gegründet wurde gemäss Urkunde, aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Lu-
xemburg, am 13. Juni 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2268 vom 11. Oktober 2007, deren Satzung abgeändert
wurde auf Grund einer Urkunde aufgenommen durch Notar Henri HELLINCKX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, am
6. September 2007, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 2359 vom 19. Oktober 2007.

- Dass das Gesellschaftskapital AUD 19.786,25 (neunzehntausend siebenhundert sechsundachtzig Australische Dollar

und fünfundzwanzig Cents) eingeteilt in 1.250 (eintausend zweihundertfünfzig) Anteile ohne Nennwert.

- Dass der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Emuto Global

Capital S.à r.l." zu sein und dass er den amtierenden Notar ersucht, die von ihm in ausserordentlicher Generalversammlung
gefassten Beschluss zu dokumentieren wie folgt:

<i>Beschluss

Die Generalversammlung beschliesst den Sitz der Gesellschaft, mit Wirkung zum 1. Januar 2015 nach L-5365 Munsbach,

6B, rue Gabriel Lippmann zu verlegen und dementsprechend Artikel vier (4) der Satzungen abzuändern wie folgt:

Art. 4. Die Gesellschaft hat ihren eingetragenen Sitz in der Gemeinde Schuttrange, Großherzogtum Luxemburg.
Der Sitz kann zu einem beliebig anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden aufgrund eines Beschlusses

im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter, in der für die Änderung der Satzung vorges-
chriebenen Art und Weise.

Eine Verlegung der Adresse des Firmensitzes innerhalb der Gemeinde kann durch Beschluss der Geschäftsleitung

erfolgen.

Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Filialen in Luxemburg und anderswo haben.
Sollten nach Erachten der Geschäftsführung außerordentliche politische, wirtschaftliche oder soziale Ereignisse ein-

treten oder bevorstehen, die die normalen Aktivitäten der Gesellschaft an deren Sitz oder die Kommunikation zwischen
den Niederlassungen am Firmensitz und den Personen außerhalb des Firmensitzes negativ beeinträchtigen würden, kann
der Firmensitz auch vorübergehend - bis zur vollständigen Beendigung dieser Umstände - ins Ausland verlegt werden.
Diese provisorischen Maßnahmen werden die Staatsangehörigkeit der Gesellschaft keineswegs beeinträchtigen. Diese
bleibt, trotz der zeitweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes luxemburgischer Staatsangehörigkeit.

Derartige vorübergehende Maßnahmen werden von der Geschäftsleitung der Gesellschaft getroffen und interessierten

Gesellschaften mitgeteilt."

Die englische Version wird wie folgt abgeändert:

Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Schuttrange, Grand Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

<i>Kosten

Die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen werden auf ungefähr acht

hundert fünfzig Euro abgeschätzt.

WORÜBER URKUNDE Aufgenommen in Munsbach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach

Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, haben dieselben zusammen mit Uns dem Notar ge-
genwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: Marco BREHM, Danielle KOLBACH.

42836

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 12 février 2015. Relation GAC/2015/1200. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015033054/70.
(150036924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Emuto Global Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6B, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.172.

Koordinierte Satzung hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, den 25. Februar 2015.

<i>Für die Gesellschaft
Jean SECKLER
<i>Der Notar

Référence de publication: 2015033055/13.
(150037199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

EAE Négoce S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 87.492.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015033058/10.
(150037088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Erbil Hotel Partners GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 181.319.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033063/9.
(150036994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Bidibul Productions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter.

R.C.S. Luxembourg B 139.621.

L’an deux mille quinze, le six février.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg),

S'est réunie

l’assemblée générale rectificative des actionnaires de la société anonyme «BIDIBUL PRODUCTIONS S.A.», (ci-après

dénommée la «Société»), avec siège social à L-2730 Luxembourg, 67, rue Michel Welter, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 139.621,

L'assemblée est présidée par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.
Le Président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Henri DA CRUZ, employé,

demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente assemblée générale est uniquement tenue pour rectifier une erreur matérielle survenue dans

l’assemblée générale extraordinaire, ayant eu comme ordre de jour de rectifier l’objet social, tenue par devant le notaire
instrumentant, en date du 27 février 2014, enregistré à Grevenmacher, le 4 mars 2014, Relation GRE/2014/859, déposé
au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, en date du 7 mars 2014, sous la référence 140040397 et publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1128 du 5 mai 2014, ayant eu comme ordre de jour de

42837

L

U X E M B O U R G

modifier l’objet social, tenue par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en rem-
placement du notaire instrumentant en date du 8 avril 2010, enregistré à Grevenmacher, le 15 avril 2010. Relation GRE/
2010/1311, déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, en date du 29 avril 2010, sous la référence
100059578 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1171 du 4 juin 2010

B) Que les actionnaires représentés, le mandataire des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d’actions qu’ils

détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été contrôlée et signée par le
mandataire des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, sera conservée
à l’étude de celui-ci.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées ne varietur par les comparants et le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées ensemble avec lui.

C) Qu’il résulte de cette liste de présence que la présente assemblée réunit l’intégralité du capital social et est donc

régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu’elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée générale, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Unique résolution

L’assemblée générale décide de rectifier l’objet social ainsi que l’article 3 des statuts de l’assemblée générale extraor-

dinaire tenue par devant Maître Joseph ELVINGER, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement du
notaire instrumentant en date du 8 avril 2010, et rectifié suivant acte reçu par le notaire instrumentant le 27 février 2014
et donner à l’article 3 la teneur suivante:

« Art. 3. La Société a pour objet tant au Luxembourg qu'à l’étranger, directement ou indirectement:
- la réalisation en qualité de producteur d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
- les prestations dans la fabrication de dessins animés et multimédia; la production de dessins animés et multimédia,
- l’aide au développement de tous projets cinématographiques ou audiovisuels en vue d'assurer la meilleure qualité

finale et accroître ainsi les chances de réussite du film tant par la mise en place de conseils pendant la préparation de
l’oeuvre que pendant le montage et la réalisation

- la vente, l’échange, la distribution, l’importation, l’exportation, l’édition sous toutes formes de ces productions et de

leurs dérivés;

- l’édition musicale;
- la gestion des droits d'édition musicale;
- tous travaux sonores se rapportant à l’audiovisuel et au cinéma, création, achat, vente et traitements des sons;
- toutes activités à caractère artistique;
- toutes prestations de services, promotion, organisation, assistance et conseils en matière de spectacles artistiques;
- le négoce et la location de tout produit en relation avec les métiers de l’audiovisuel;
- la gestion de droits intellectuels, l’informatique: développement de Software;
- l’achat, la vente et la gestion de son propre patrimoine immobilier;
- toute activité commerciale;
- la prise de participation dans toutes sociétés
- le conseil et la formation en direction d'entreprises ainsi que l’assistance et l’exécution de toutes prestations dans le

domaine financier, administratif, informatique, technique, commercial, de marketing ou de gestion;

- l’acquisition, la propriété, l’administration, la gestion et la vente d'un portefeuille de valeurs mobilières;
- la prise de tous intérêts et participations de quelques façons qu'elles puissent se concevoir dans toutes les opérations

susceptibles de favoriser les affaires sociales sous quelque forme que ce soit, acquisition, création, location soit comme
preneur, soit comme bailleur de tous fonds de commerce, établissements commerciaux et succursales répondant à l’objet
social, création de sociétés nouvelles, apports, souscription, achats de titres et de droits sociaux, fusion;

- la location comme preneur ou bailleur de tous locaux avec ou sans promesse de vente, l’édification de toute cons-

truction nouvelle, l’acquisition de tous immeubles pouvant servir directement ou indirectement à tous objets de nature
à favoriser le commerce de la société; la cession desdits immeubles.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet

identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-

bilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.»

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

42838

L

U X E M B O U R G

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 11 février 2015. Relation GAC/2015/1120. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015032981/81.
(150036936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Digital Services XXVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1736 Luxembourg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.487.

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of January.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177.038,
having its registered office at 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of six thousand seventy-one (6,071) shares and becoming the holder of six thousand seventy-one

(6,071) Series A1 Shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany,

on 12 

th

 January 2015, and in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 5 January 2015,

2. MKC Brillant Services GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 139778 B, having
its registered office at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of one thousand eight hundred seventy-five (1,875) shares and becoming the holder of one thousand

eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Berlin, Germany,

on 12 

th

 January 2015,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 176.544,
having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and having a
share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) shares and becoming the holder of one thousand five

hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London, the United

Kingdom, on 7 January 2015,

4. TEC Global Invest VIII GmbH, a limited liability company incorporated and existing under the laws of Germany,

registered with Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg under number HRB 26060, having its registered office at
Wissollstrasse 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany,

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) shares and becoming the holder of one thousand five

hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Mülheim an der

Ruhr, Germany, on 5 January 2015, and

5. SHCO 57 S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B183425, having its regis-
tered office at 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

being the holder of one thousand five hundred eighteen (1,518) shares and becoming the holder of one thousand five

hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares,

here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg, on 5 January 2015.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all of the shareholders, representing the entire share capital of Digital Services XXVI S.à

r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736

42839

L

U X E M B O U R G

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under
number B 188487, incorporated pursuant to a deed of notary Carlo Wersandt on 18 June 2014, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 2516 on 17 September 2014. The articles of incorporation have not been
amended since.

The appearing parties representing the entire share capital having waived any notice requirement, the general meeting

of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Decision to create four (4) classes of shares, referred to as the common shares (hereinafter the “Common Shares”),

the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter the “Series A2 Shares”), the
series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500)
shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares,
without cancellation of shares.

2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of twelve thousand five hundred euros (EUR

12,500) up to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of six thousand seventy-one (6,071) Series
A1 Shares, one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares, four thousand five hundred fifty-four (4,554)
Series A3 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth

read as follows:

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”) and (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”; AIH, LIH, Aismare,
TEC and SHCO jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration  Act  (AktG)  (a  “Third  Party  Investor”))  and  which  has  been  approved  by  the  Advisory  Board  (a  “Third  Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO
shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified by the Company regarding
the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO intend/s to exercise its/their respective
right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of
the Investors subscribes for further Shares.”

4. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XXVI S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

42840

L

U X E M B O U R G

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”) and (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”; AIH, LIH, Aismare,
TEC and SHCO jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration  Act  (AktG)  (a  “Third  Party  Investor”))  and  which  has  been  approved  by  the  Advisory  Board  (a  “Third  Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO
shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified by the Company regarding
the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO intend/s to exercise its/their respective
right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of
the Investors subscribes for further Shares.

42841

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into Shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The Shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing Shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of Shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The Shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the Shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by shareholders holding at least three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions of
any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption
or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders agreement between the shareholders. To the extent
that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of Shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of Shares by an Investor to a company affiliated to such

Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (each an “Affiliate”);

7.4.2 in case of the transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares of one Investor to a company or entity

(x) which is directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by
one or more direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Con-
trol” or “Controlled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company or entity by way of
(a) managing the company or entity as managing shareholder, (b) holding the majority of Shares or (c) holding the majority
of voting rights by means of a contractual voting pool, or (y) in which the respective Investor or one or more shareholders
of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, sale, assignment or any other disposal of Shares by a shareholder to the Company and/or

any of the Investors pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.5 To the extent a sale, transfer, assignment or any other disposal of Shares requires no additional consent of the

shareholders' meeting pursuant to Article 7.4.1 through Article 7.4.3 above, neither duties to offer for sale, nor any rights
of first refusal, nor rights of pre-emption, nor tag-along rights, nor drag-along rights apply in favour of other Shareholders.

7.6 Any sale, transfer, assignment or other disposal of Shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification thereof to, or upon the acceptance thereof by the Company in accordance with Article
1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the Shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the Shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the Shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
shareholders that would result in either more than 50% of the share capital or more than 50 % of the voting rights being
owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each of the
events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) -
subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.2 to the Shareholders pro rata to their
participation in the Liquidity Event.

8.2 On a first level (“First Level”) the holders of Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares shall receive

per Share of the respective Share class an amount stipulated next to the relevant share class being subject to the Liquidity
Event in the following table:

42842

L

U X E M B O U R G

Share Class

Amount

per Share

in Euro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.06

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553.25

Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,646.90

8.3 After the payments on the First Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a second

level (“Second Level”) to all selling Shareholders pro rata to their participation in the Liquidity Event. Any amounts received
by any Investor on the First Level shall reduce the amount to be allocated to such Investor on this Second Level provided
that no Investor shall be obliged to repay any amount received on the First Level. Irrespective of whether or not the sale
of Shares is made in one Liquidity Event or after the Liquidity Event in one transaction or more transactions, no share-
holder shall receive for the sale of all of its Shares (and shall repay any exceeding amount to the other shareholders) an
amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds or proceeds pro rata to the Shares sold on a
common equivalent basis or (ii) the amount allocated to such shareholder on the First Level and/or Second Level from
a subsequent sale. All rights related to the liquidity preference stipulated herein can only be exercised once.

8.4 The preferred allocation of Exit Proceeds on the First Level applies for the benefit of the respective Investor so

long as the respective Investor has not yet received the full amount that is to be allocated to such Investor according to
the First Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own Shares. The voting rights of any of its Shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the Share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such Share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the Shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles of association together with
the declaration of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of Article 190 of the
Law and the Company hereby acknowledges and accepts the transfer of the Shares in such case and undertakes to register
the transfer in its share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed Shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the Shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the Shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the share to the Company or to a person named by the Company.

42843

L

U X E M B O U R G

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the Shares to be assigned is owed by the person acquiring the Shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of Shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds Shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

42844

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who are also a Super Majority.

Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the

consent of the Advisory Board:

17.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.1.2 amendment of these articles of association including the resolution with respect to the merger, separation and

transformation of the Company;

17.1.3 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

17.1.4  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.5 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of existing

shares or issuance of new shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other con-
tractual party is granted a participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the
Company's profit; this does not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agree-
ments concluded in light of a prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties
within the ordinary course of business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also requires the consent of

the Investors.

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own Shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association.

17.3 Whenever the capital of the Company is divided into different classes of Shares the special rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders' who hold
all the issued Shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

42845

L

U X E M B O U R G

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the advisory board (the “Advisory Board”) for the legal transactions

and measures specified below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined
and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

22.8.1 acquisition, sale and encumbrance of real estate and similar rights or rights in real estate;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of five hundred thousand Euros

(EUR 500,000.00) in aggregate;

22.8.3 granting of loans in excess of two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case, excluding,

however, such loans between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.4 conclusion and termination of credit and loan agreements and other financial agreements in excess of two

hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case and amendments to the credit framework, excluding,
however, such agreements between the Company and direct and indirect subsidiaries of the Company;

22.8.5 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.6 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.7 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.8 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than five hundred thousand Euros (EUR 500,000.00) in the individual case;

22.8.9 passing on of industrial property rights or know-how by the Company to a third party outside the ordinary

course of business;

22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals as set

forth in any shareholders' agreement between the shareholders;

42846

L

U X E M B O U R G

22.8.11 amendment and termination of intra-group agreements (Unternehmensverträge within the meaning of sections

291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)); and

22.8.12 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers) such minutes shall be signed by one (1) class A manager and
one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company shall have an Advisory Board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders may by

way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the Advisory Board.

25.2 The shareholders' meeting shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of a

unanimous shareholders' resolution.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 One (1) voting member of the Advisory Board, having five (5) votes, shall be nominated by the shareholder AIH

in its sole discretion;

25.3.2 One (1) voting member of the Advisory Board, having two (2) votes, shall be nominated by the shareholder

LIH in its sole discretion;

25.3.3 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder

Aismare in its sole discretion;

25.3.4 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder TEC

in its sole discretion; and

25.3.5 One (1) voting member of the Advisory Board, having one (1) vote, shall be nominated by the shareholder

SHCO in its sole discretion.

25.4 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by AIH shall be

the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the Advisory Board. The Advisory Board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast.

25.5 The objective and responsibility of the Advisory Board shall be the granting of consents to specific transactions

of the management of the Company which pursuant to (i) any shareholders' agreement relating to the Company, (ii) these
articles of association, (iii) the rules of procedure for the managers, (iv) the rules of procedure for the Advisory Board
or (v) respective shareholders' resolutions require the consent of the Advisory Board. Further powers and responsibilities
may be conferred on the Advisory Board by shareholders' resolution. In addition to those consent requirements, the
Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the management of the Company.

42847

L

U X E M B O U R G

25.6 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and Supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable in accordance with the provisions of Article 8 and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

42848

L

U X E M B O U R G

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

5. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, as well as Mr. Julien De

Mayer and Mr. Rüdiger Trox each acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders
register of the Company.

6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires

the undersigned notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The general meeting of shareholders decides to create four (4) classes of shares, referred to as the common shares

(hereinafter the “Common Shares”), the series A1 shares (hereinafter the “Series A1 Shares”), the series A2 shares
(hereinafter the “Series A2 Shares”), the series A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and to convert the existing
twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand
five hundred (12,500) Common Shares, without cancellation of shares.

<i>Second Resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand

five hundred euros (EUR 12,500) so as to raise it from the amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500)
up to twenty-five thousand euros (EUR 25,000) through the issuance of six thousand seventy-one (6,071) Series A1
Shares, one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares, four thousand five hundred fifty-four (4,554)
Series A3 Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The new Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares have been subscribed as follows:
1. six thousand seventy-one (6,071) Series A1 Shares have been subscribed by Asia Internet Holding S.à r.l., afore-

mentioned, for the subscription price of eighteen thousand five hundred seventy-one euros (EUR 18,571); and

2. one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares have been subscribed by MKC Brillant Services

GmbH, aforementioned, for the subscription price of nine thousand nine hundred forty-four euros and sixty-three cents
(EUR 9,944.63); and

3. one thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed by Aismare Lux Holdings S.à

r.l., aforementioned, for the subscription price of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643); and

4. one thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed by TEC Global Invest VIII GmbH,

aforementioned, for the subscription price of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643); and

5. one thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed by SHCO 57 S.à r.l., aforemen-

tioned, for the subscription price of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643).

<i>Payment

1. The six thousand seventy-one (6,071) Series A1 Shares have been subscribed for a total subscription price of eighteen

thousand five hundred seventy-one euros (EUR 18,571) by Asia Internet Holding S.à r.l., aforementioned, and have been
fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of six thousand seventy-one euros (EUR 6,071) and (ii) a
contribution in kind consisting of twelve thousand five hundred (12,500) common shares, having a nominal value of one
euro (EUR 1) each, of Car Classifieds Asia S.à r.l., a société à responsabilité limitée, registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 180.458, having its registered office
at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, having an aggregate value of at least twelve thousand
five hundred euros (EUR 12,500);

2. The one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares have been subscribed for a total subscription

price of nine thousand nine hundred forty-four euros and sixty-three cents (EUR 9,944.63) by MKC Brillant Services
GmbH, aforementioned, and have been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand
eight hundred seventy-five euros (EUR 1,875) and (ii) a contribution in kind consisting of a limited partnership interest
of eight thousand sixty-nine euros and sixty-three cents (EUR 8,069.63) in LIH Subholding Nr. 3 UG (haftungsbeschränkt)
&amp; Co. KG, a limited partnership under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with
the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRA 46940 B, having an aggregate
value of at least eight thousand sixty-nine euros and sixty-three cents (EUR 8,069.63);

3. One thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed for a total subscription price

of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643) by Aismare Lux Holdings S.à r.l., aforementioned, and have
been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand five hundred eighteen euros (EUR
1,518) and (ii) a contribution in kind consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A1 shares, having
a nominal value of one euro (EUR 1) each, of Car Classifieds Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of at
least three thousand one hundred twenty-five euros (EUR 3,125);

42849

L

U X E M B O U R G

4. One thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed for a total subscription price

of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643) by TEC Global Invest VIII GmbH, aforementioned, and have
been fully paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand five hundred eighteen euros (EUR
1,518) and (ii) a contribution in kind consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A2 shares, having
a nominal value of one euro (EUR 1) each, of Car Classifieds Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of at
least three thousand one hundred twenty-five euros (EUR 3,125);

5. One thousand five hundred eighteen (1,518) Series A3 Shares have been subscribed for a total subscription price

of four thousand six hundred forty-three euros (EUR 4,643) by SHCO 57 S.à r.l., aforementioned, and have been fully
paid-up through (i) a contribution in cash in the amount of one thousand five hundred eighteen euros (EUR 1,518) and
(ii) a contribution in kind consisting of three thousand one hundred twenty-five (3,125) series A3 shares, having a nominal
value of one euro (EUR 1) each, of Car Classifieds Asia S.à r.l., aforementioned, having an aggregate value of at least three
thousand one hundred twenty-five euros (EUR 3,125).

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution has been produced to the undersigned

notary.

The total contribution, in the amount of forty-two thousand four hundred forty-four euros and sixty-three cents (EUR

42,444.63), consists of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) allocated to the share capital and twenty-nine
thousand nine hundred forty-four euros and sixty-three cents (EUR 29,944.63) allocated to the share premium of the
Company.

<i>Third Resolution

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting of shareholders decides to amend article 5 of the

articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty-five thousand euro (EUR 25,000), represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Common Shares”),

5.1.2 six thousand seventy-one (6,071) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each (hereinafter

“Series A1 Shares”),

5.1.3 one thousand eight hundred seventy-five (1,875) Series A2 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00)

each (hereinafter “Series A2 Shares”),

5.1.4 four thousand five hundred fifty-four (4,554) Series A3 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each

(hereinafter “Series A3 Shares”, Series A1 Shares, Series A2 Shares and Series A3 Shares collectively “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares in the Company (the “Shares”) shall be identical except to the extent

otherwise provided by these articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of (i) Asia Internet Holding S.à r.l. (“AIH”), (ii) MKC Brillant Services GmbH (“LIH”) (iii) Aismare Lux Holdings

S.à r.l. (“Aismare”), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH (“TEC”) and (v) SHCO 57 S.à r.l (“SHCO”; AIH, LIH, Aismare,
TEC and SHCO jointly the “Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further
Shares to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a
shareholder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corpo-
ration  Act  (AktG)  (a  “Third  Party  Investor”))  and  which  has  been  approved  by  the  Advisory  Board  (a  “Third  Party
Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching shareholders - required
to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under the same terms and
conditions on which the Third Party Investment is based on. Each of (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO
shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks after it has been notified by the Company regarding
the Third Party Investment if (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC and (v) SHCO intend/s to exercise its/their respective
right/s pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of
the Investors subscribes for further Shares.”

<i>Fourth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders unanimously resolves to fully restate the

articles of association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Fifth Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, as well

as Mr. Julien De Mayer and Mr. Rüdiger Trox, each acting individually and with full power of substitution, to sign solely,
the shareholders register of the Company.

42850

L

U X E M B O U R G

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at EUR 2,400.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Januar,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Asia Internet Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 177.038, mit Sitz in 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxemburg, Großher-
zogtum Luxemburg,

Inhaber  von  sechstausendeinundsiebzig  (6.071)  Anteilen  und  zukünftiger  Inhaber  von  sechstausendeinundsiebzig

(6.071) Anteilen der Serie A1,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht ausgestellt in Berlin,

Deutschland, am 12. Januar 2015 und in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am 5. Januar 2015,

2. MKC Brillant Services GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 139778
B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendachthun-

dertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12. Januar 2015,

ausgestellt in Berlin, Deutschland,

3. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital in Höhe von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhundertacht-

zehn (1.518) Anteilen der Serie A3,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7. Januar 2015,

ausgestellt in London, Vereinigtes Königreich,

4. TEC Global Invest VIII GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und bestehend unter deutschem

Recht, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Duisburg unter der Nummer HRB 26060, mit Sitz in Wissoll-
straße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland,

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhundertacht-

zehn (1.518) Anteilen der Serie A3,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5. Januar 2015,

ausgestellt in Mülheim an der Ruhr, Deutschland, und

5. SHCO 57 S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und be-

stehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsre-
gister  unter  der  Nummer  B183425,  mit  Sitz  in  13-15,  avenue  de  la  Liberté,  L-1931  Luxemburg,  Großherzogtum
Luxemburg,

Inhaber von eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteilen und zukünftiger Inhaber von eintausendfünfhundertacht-

zehn (1.518) Anteilen der Serie A3,

hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5. Januar 2015,

ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Besagte Vollmachten, welche von der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

42851

L

U X E M B O U R G

Die besagten erschienenen Parteien sind alle Gesellschafter und vertreten das gesamte Gesellschaftskapital der Digital

Services XXVI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée),
mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188487, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Carlo
Wersandt, welche am 17. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2516 veröf-
fentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die erschienenen Parteien das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten ver-

zichtet  haben,  ist  die  Gesellschafterversammlung  ordnungsgemäß  zusammengekommen  und  kann  wirksam  über  alle
Punkte der folgenden Tagesordnung verhandeln:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung von vier (4) Anteilsklassen, welche als Stammanteile (die „Stammanteile“), Anteile

der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der Serie A3 (die
„Anteile der Serie A3“) bezeichnet werden und bezüglich der Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden
zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert
(12.500) Stammanteile.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) auf einen Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von sechstausen-
deinundsiebzig  (6.071)  Anteilen  der  Serie  A1,  eintausendachthundertfünfundsiebzig  (1.875)  Anteilen  der  Serie  A2,
viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Dementsprechende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“) und (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“;
AIH, LIH, Aismare, TEC und SHCO gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO hat die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesell-
schaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e)
gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der
Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

4. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XXVI S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder

42852

L

U X E M B O U R G

auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren oder
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen und Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapie-
ren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“) und (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“;
AIH, LIH, Aismare, TEC und SHCO gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft

42853

L

U X E M B O U R G

vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO hat die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesell-
schaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e)
gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der
Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) halten und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich
Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Über-
tragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch einen Investor an

eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)
(jeweils eine „Verbundene Gesellschaft“);

7.4.2 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen eines

Investors an eine Gesellschaft oder ein Unternehmen, (x) welche/s direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen
oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“)
Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte
„Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft oder
des Unternehmens bezeichnen, durch (a) die Leitung der Gesellschaft oder des Unternehmens als geschäftsführender
Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine
vertragliche Stimmvereinbarung, oder (y) in welcher/m der betreffende Investor oder ein oder mehrere Gesellschafter
dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung, einem Verkauf, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Gesellschafter an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang
mit einer Vesting-Regelung.

7.5 Sofern ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen keiner weiteren

Zustimmung als der der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 7.4.1 bis 7.4.3 bedarf, gelten weder Verpflichtungen
zu Verkaufsangeboten, noch Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesell-
schafter.

7.6 Ein Verkauf, eine Übertragung, eine Abtretung oder eine andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der

Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft darüber in Kenntnis
gesetzt wurde oder diesem/dieser zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zugestimmt hat (wobei die Anteile des verstorbenen Ge-
sellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich,

42854

L

U X E M B O U R G

wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen
Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren Transaktionen oder in zeit-
licher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) des Verkaufs oder der Übertragung von
Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder
mehr als 50% des Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw.
Parteien wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter
(i), (ii) und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiter-
löse“) - vorbehaltlich des Artikel 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.2 auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung
am Liquiditätsereignis an die Gesellschafter verteilt.

8.2 Auf einer ersten Ebene („Erste Ebene”) erhalten die Inhaber von Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2 und

Anteilen der Serie A3 pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse einen in der folgenden Tabelle neben der entsprechenden
vom Liquiditätsereignis betroffenen Anteilsklasse festgelegten Betrag:

Anteilsklasse

Betrag

pro Anteil

in Euro

Series A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,06

Series A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

553,25

Series A3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.646,90

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Ebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer zweiten

Ebene („Zweite Ebene”) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend ihrer Beteiligung am
Liquiditätsereignis verteilt. Sämtliche von einem Investor auf der Ersten Ebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem
Investor zu erhaltenden Betrag auf dieser Zweiten Ebene, mit der Maßgabe, dass kein Investor zur Rückzahlung eines auf
der Ersten Ebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen während eines
Liquiditätsereignisses oder danach in einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für
den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zu-
rückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse oder Erlöse auf einer pro rata-Basis zu
den Anteilen, die auf einer gemeinsamen und gleichwertigen Basis verkauft wurden oder (ii) als der Betrag, der diesem
Gesellschafter auf der Ersten Ebene und/oder Zweiten Ebene aus einem späteren Verkauf zugeteilt wurde. Sämtliche mit
der hierin festgelegten Liquiditätspräferenz verbundenen Rechte können nur einmal ausgeübt werden.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung der Exiterlöse auf der Ersten Ebene gilt zugunsten des jeweiligen Investors solange, wie

dieser den Gesamtbetrag, welcher diesem Investor gemäß der Ersten Ebene zuzuteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.

42855

L

U X E M B O U R G

10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

42856

L

U X E M B O U R G

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel
13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung
ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung ein-
berufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen.

Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Veräußerung des Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermögens, ein-

schließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.1.2 Änderung dieser Satzung, einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und

Umwandlung der Gesellschaft;

17.1.3 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;

17.1.4 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
17.1.5 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (zur Klarstellung, nicht durch die Veräußerung bestehender oder

die Ausgabe neuer Anteile) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die
andere Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag
der Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, ein-
schließlich Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abge-
schlossen wurden, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der
Gesellschaft und Werbepartnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-

stimmung der Investoren:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung.

17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

42857

L

U X E M B O U R G

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

42858

L

U X E M B O U R G

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats (der „Beirat“) für die untenstehenden Rechtsgeschäfte

und Maßnahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert
und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.8.1 Erwerb, Verkauf und Belastung von Immobilien und ähnlichen Rechten oder Rechten an Immobilien;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von fünfhun-

derttausend Euro (EUR 500.000,00) überschreiten;

22.8.3  Gewährung  von  Darlehen,  die,  im  Einzelfall,  einen  Betrag  von  zweihunderttausend  Euro  (EUR  200.000,00)

überschreiten, allerdings unter Ausschluss von Darlehen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Toch-
tergesellschaften der Gesellschaft;

22.8.4 Abschluss und Kündigung von Kredit- und Darlehensverträgen und anderen Finanzverträgen, die, im Einzelfall,

einen Betrag von zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten und Änderungen des Kreditrahmens, aller-
dings unter Ausschluss von Verträgen zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der
Gesellschaft;

22.8.5 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.6 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.7 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.8 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über fünfhunderttausend Euro (EUR 500.000,00) im Einzelfall;

22.8.9 Weitergabe von gewerblichen Schutzrechten oder Know-how von der Gesellschaft an Dritte außerhalb des

gewöhnlichen Geschäftsgangs;

22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen,

wie in Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern dargelegt;

22.8.11 Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes

(AktG)); und 22.8.12 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der
Gewährung jeglicher Anteilsoder Aktienoptionen) mit Ausnahme der Einführung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteili-
gung, die zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart
wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden, oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), werden Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

42859

L

U X E M B O U R G

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers,  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter

können die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats mit einstimmiger Zustimmung erhöhen oder herabset-
zen.

25.2 Die Gesellschafterversammlung kann die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einen einstimmigen Gesell-

schafterbeschluss festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit fünf (5) Stimmen wird von dem Gesellschafter AIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit zwei (2) Stimmen wird von dem Gesellschafter LIH nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter Aismare nach

eigenem Ermessen ernannt;

25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem Gesellschafter TEC nach

eigenem Ermessen ernannt; und 25.3.5 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats mit einer (1) Stimme wird von dem
Gesellschafter SHCO nach eigenem Ermessen ernannt.

25.4 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von AIH ernanntes stimmbe-

rechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  kann  weitere  Bestimmungen,
insbesondere  hinsichtlich  der  Selbstorganisation  des  Beirats,  zu  enthalten.  Der  Beirat  fasst  Beschlüsse  mit  einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

25.5 Ziel und Zuständigkeit des Beirats ist die Erteilung von Zustimmungen zu spezifischen Transaktionen der Ge-

schäftsführung der Gesellschaft zuständig, welche gemäß (i) einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft,
(ii) dieser Satzung, (iii) der Geschäftsordnung für die Geschäftsführer, (iv) der Geschäftsordnung für den Beirat oder (v)
entsprechender Gesellschafterbeschlüsse die Zustimmung des Beirats erfordern. Weitere Befugnisse und Zuständigkeiten
können dem Beirat durch einen Gesellschafterbeschluss übertragen werden. Neben diesen Zustimmungserfordernissen
hat der Beirat eine beratende Funktion und wird nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne der Artikel 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer (commissaire(s)) beaufsichtigt. Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

42860

L

U X E M B O U R G

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss – Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinnund Ver-
lustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 verteilt
und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls
erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch  vorgetragene
Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht
ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den
Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen
den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

5. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, sowie die

Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelun-
terschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht den unterzeichnenden Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, vier (4) Anteilsklassen zu schaffen, welche als Stammanteile (die „Stamm-

anteile“), Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteile der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“), Anteile der
Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) bezeichnet werden und die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile

42861

L

U X E M B O U R G

mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500)
Stammanteile umzuwandeln.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) auf einen
Betrag von fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000) durch die Ausgabe von sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen
der Serie A1, eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2, viertausendfünfhundertvierundfünfzig
(4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die neuen Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3 wurden wie folgt gezeichnet:
1. sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt, zu

einem Bezugspreis von achtzehntausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 18.571) gezeichnet; und

2. eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH, vor-

benannt, zu einem Bezugspreis von neuntausendneunhundertvierundvierzig Euro und dreiundsechzig Cent (EUR 9.944,63)
gezeichnet; und

3. eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l., vorbenannt,

zu einem Bezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet; und

4. eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von TEC Global Invest VIII GmbH, vorbenannt,

zu einem Bezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet; und

5. eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von SHCO 57 S.à r.l., vorbenannt, zu einem

Bezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet.

<i>Zahlung

1. Die sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteile der Serie A1 wurden von Asia Internet Holding S.à r.l., vorbenannt,

zu einem Gesamtbezugspreis von achtzehntausendfünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 18.571) gezeichnet und vollständig
eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von sechstausendeinundsiebzig Euro (EUR 6.071) und (ii) eine Sacheinlage
bestehend aus zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen, mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), der
Car Classifieds Asia S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 180.458, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Sennin-
gerberg,  Großherzogtum  Luxemburg,  mit  einem  Gesamtwert  von  mindestens  zwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR
12.500);

2. Die eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteile der Serie A2 wurden von MKC Brillant Services GmbH,

vorbenannt, zu einem Gesamtbezugspreis von neuntausendneunhundertvierundvierzig Euro und dreiundsechzig Cent
(EUR 9.944,63) gezeichnet und vollständig eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendachthundertfün-
fundsiebzig Euro (EUR 1.875) und (ii) eine Sacheinlage bestehend aus einem Kommanditanteil von achttausendneunund-
sechzig Euro und dreiundsechzig Cent (EUR 8.069,63) der LIH Subholding Nr. 3 UG (haftungsbeschränkt) &amp; Co. KG,
einer Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im
Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRA 46940 B, mit einem Gesamt-
wert von mindestens achttausendneunundsechzig Euro und dreiundsechzig Cent (EUR 8.069,63);

3. Eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von Aismare Lux Holdings S.à r.l., vorbenannt,

zu einem Gesamtbezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet und vollständig
eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertachtzehn Euro (EUR 1.518) und (ii) eine Sacheinlage
bestehend aus dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A1, mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1), der Car Classifieds Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens dreitausendeinhun-
dertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125).

4. Eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von TEC Global Invest VIII GmbH, vorbenannt,

zu einem Gesamtbezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet und vollständig
eingezahlt durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertachtzehn Euro (EUR 1.518) und (ii) eine Sacheinlage
bestehend aus dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A2, mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1), der Car Classifieds Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens dreitausendeinhun-
dertfünfundzwanzig Euro (EUR 3.125);

5. Eintausendfünfhundertachtzehn (1.518) Anteile der Serie A3 wurden von SHCO 57 S.à r.l., vorbenannt, zu einem

Gesamtbezugspreis von viertausendsechshundertdreiundvierzig Euro (EUR 4.643) gezeichnet und vollständig eingezahlt
durch (i) eine Bareinlage in Höhe von eintausendfünfhundertachtzehn Euro (EUR 1.518) und (ii) eine Sacheinlage beste-
hend aus dreitausendeinhundertfünfundzwanzig (3.125) Anteilen der Serie A3, mit einem Nominalwert von je einem Euro
(EUR 1), der Car Classifieds Asia S.à r.l., vorbenannt, mit einem Gesamtwert von mindestens dreitausendeinhundertfün-
fundzwanzig Euro (EUR 3.125).

42862

L

U X E M B O U R G

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die gesamte Einlage in Höhe von zweiundvierzigtausendvierhundertvierundvierzig Euro und dreiundsechzig Cent (EUR

42.444,63) besteht aus zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500), die dem Gesellschaftskapital zugeführt werden und
aus neunundzwanzigtausendneunhundertvierundvierzig Euro und dreiundsechzig Cent (EUR 29.944,63), die dem Agio der
Gesellschaft zugeführt werden.

<i>Dritter Beschluss

Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Gesellschafterversammlung, Artikel fünf der Satzung der Gesell-

schaft zu ändern, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend Euro (EUR 25.000), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00) (die

„Stammanteile“),

5.1.2 sechstausendeinundsiebzig (6.071) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00)

(die „Anteile der Serie A1“),

5.1.3 eintausendachthundertfünfundsiebzig (1.875) Anteilen der Serie A2 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A2“),

5.1.4 viertausendfünfhundertvierundfünfzig (4.554) Anteilen der Serie A3 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1,00) (die „Anteile der Serie A3“, wobei die Anteile der Serie A1, Anteile der Serie A2 und Anteile der Serie A3
gemeinsam als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen der Gesellschaft (die „Anteile“) verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es

wird in dieser Satzung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jede der Gesellschaften (i) Asia Internet Holding S.à r.l. („AIH“), (ii) MKC Brillant Services GmbH („LIH“), (iii)

Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), (iv) TEC Global Invest VIII GmbH („TEC“) und (v) SHCO 57 S.à r.l. („SHCO“;
AIH, LIH, Aismare, TEC und SHCO gemeinschaftlich die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer
Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Drit-
ten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene
Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der vom Beirat
zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem
oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft
vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition eines
Dritten. Jede der Gesellschaften (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO hat die Gesellschaft durch eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen nach Ankündigung der Investition eines Dritten durch die Gesell-
schaft darüber zu unterrichten, ob (i) AIH, (ii) LIH, (iii) Aismare, (iv) TEC und (v) SHCO ihr(e) jeweilige(s)/(n) Recht(e)
gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der
Investoren weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, einstimmig die gänzliche Neu-

fassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt
lautet.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung ermächtigt hiermit jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie, sowie die Herren Julien De Mayer und Rüdiger Trox, das Anteilsinhaberregister der Gesellschaft in Einzelunter-
schrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund der vorliegenden

Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 2.400,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

42863

L

U X E M B O U R G

Die vorstehende Urkunde ist der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit dieser Bevollmächtigten unterzeichnet worden.

Gezeichnet: X. TANG, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1160. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé) I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015032322/1398.
(150036103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

International Packaging Technologies S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 170.704.

Il résulte d'une lettre que Madame Sandrine Bruzzo a démissionné de son mandat en tant que gérante de classe A de

la Société avec effet au 28 novembre 2014, à la fin de la journée.

Il y a aussi lieu de noter le changement d'adresse professionnelle de Monsieur Philippe van den Avenne, gérant de

classe A de la Société comme suit: 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.

Depuis le 29 novembre 2014, le conseil de gérance de la Société se compose des personnes suivantes:

<i>Gérant de classe A:

Monsieur Philippe van den Avenne.

<i>Gérant de classe B:

Monsieur Everardus Antonius Ariëns.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 25 février 2015.

International Packaging Technologies S.à r.l.

Référence de publication: 2015033143/20.
(150037240) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Humaniste Conseil S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 117.404.

Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission de mon poste d'administrateur de votre société avec

effet immédiat.

Dublin, le 12 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015033136/10.
(150036823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 133.135.

<i>Extrait des résolutions du Conseil de Gérance, tenu à Luxembourg le 18 novembre 2014:

Le Conseil de Gérance décide de ratifier la démission de Marc Ambroisien en tant que Gérant de la société avec effet

au 4 mars 2013.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Référence de publication: 2015033139/11.
(150036866) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

42864


Document Outline

AFTH S.C.Sp

Akta S.A.

Albama S.A.

Albanel S.A.

Alma Lasers Belux S.à r.l.

Argo Services &amp; Consulting S.A.

Bidibul Productions S.A.

Business Development S.A.

Caldwynn S.A.

Capellen Services Sàrl

CCK Compta S.à r.l.

ChaoriSky Solar Energy S.à r.l.

Citruz Prop2 S.à r.l.

Classifieds Asia Extra S.à r.l.

CMC Mathias Import/Export S.A.

Coiffure de Lux S.à r.l.

Colony Sardegna S.à r.l.

Compagnie Financière Européenne S.A. SPF

C. Prestige Investissements S.A.

C. Prestige Investissements S.A.

Crédit Suisse (Luxembourg) S.A.

Culligan Investments S.à r.l.

Cynthya Infrastructures S.A.

Cypress Capital Investments Luxembourg S.à r.l.

Danube SCA SICAR

Dengold Overseas S.A., SPF

Dewdrop Holdings S.A.

DGM&amp;C Invest S.A.

Digital Services XXVI S.à r.l.

DRS Consulting &amp; Services S.A.

EAE Négoce S.A.

EFR Services Luxembourg S.à r.l.

E-Media S.A.

E-Media S.A.

Emuto Global Capital S.à r.l.

Emuto Global Capital S.à r.l.

E.N.A. Consulting S.A.

E.N.A. Consulting S.A.

Erbil Hotel Partners GP S.à r.l.

Goodman Cordovan Logistics (Lux) S.à r.l.

Humaniste Conseil S.A.

Iberian Renewable Energies GP, S.à r.l.

International Packaging Technologies S.à.r.l.