This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 890
1
er
avril 2015
SOMMAIRE
Actavis Luxembourg International S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42718
Alize Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42718
Auburn Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42719
AXL International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42690
AXL Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42691
B.R.C. Constructions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
42691
Centrum Development S.A. . . . . . . . . . . . .
42674
Conforama Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
42674
Dalba Partners S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
Energy Standard Group S.A., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
42686
Eresa S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
Farm Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42682
Felten Frères et Fils S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .
42683
Five Lions e-Solutions S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
42686
Fondation Francois-Elisabeth . . . . . . . . . . . .
42683
Franklin Templeton International Services
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42685
Fratelli S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42686
Freko Echafaudages S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
42682
Futuradent G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42683
Futuradent G.m.b.H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42685
Future Media International S.à r.l. . . . . . . .
42682
Gland Mortgage III S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
42685
Green Valley Services S.A. . . . . . . . . . . . . . .
42685
Helpling Group Holding S.à r.l. . . . . . . . . . .
42692
Hôpitaux Robert Schuman . . . . . . . . . . . . . .
42683
Humaniste Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
Humaniste Conseil S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42687
I.B.E. S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42688
Icon 1 S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42689
Icon 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42690
Icon Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
42689
Industrielle de Réassurance S.A. . . . . . . . . .
42674
Innova Financial Holding S.à r.l. . . . . . . . . .
42688
International Corporate Activities S.A. . .
42690
Inversiones Eneida S.à r.l., SPF . . . . . . . . . .
42689
Investment Interest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
42689
Jambo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42691
Jawhar Resort Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . .
42692
Join Expérience S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42691
Jordan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42692
KARBLUMM Alimentation Naturelle et
Biologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42674
Kinetic Partners (Luxembourg) Manage-
ment Company S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
42692
L.M.B.E. Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42688
Mica Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42720
Nord Point SCSp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42681
42673
L
U X E M B O U R G
Industrielle de Réassurance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 28.689.
Les statuts coordonnés au 29 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Marc Loesch
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015031827/11.
(150035432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.
KARBLUMM Alimentation Naturelle et Biologique, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7520 Mersch, 43, rue Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 28.518.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015031848/10.
(150035336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.
Conforama Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 48.369.
<i>Extrait des Résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à L-8010 Strassen, 296, route d'Arlon en date du 15i>
<i>décembre 2014.i>
Il résulte du procès-verbal que le mandat des administrateurs, CONFORAMA HOLDING S.A., CONFORAMA
FRANCE S.A. et Thierry GUIBERT, étant venus à échéance, ils sont renouvelés pour une durée de six ans, soit jusqu'à
l'issue de Assemblée Générale Ordinaire de 2019.
Il résulte du procès-verbal que le mandat de Réviseur d'entreprises de DELOITTE AUDIT s.àr.l., étant venu à échéance,
il est renouvelé pour une durée de six ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2019.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015032308/17.
(150035700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Centrum Development S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1417 Luxembourg, 4, rue Dicks.
R.C.S. Luxembourg B 105.723.
L'an deux mille quatorze, le quinze décembre.
Par-devant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des actionnaires (les Actionnaires) de Centrum Development
S.A., une société anonyme organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social au 4, rue Dicks
L-1417 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg (le R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 105.723 (la Société). La Société a été constituée le 19 janvier 2005 suivant
un acte de Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 23 mai
2005 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 479 page 22959. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois le 31 juillet 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié le 10 octobre 2014 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations numéro 2854 page 136966.
42674
L
U X E M B O U R G
L'Assemblée est présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant à Luxembourg (le Président) qui nomme en
tant que secrétaire (le Secrétaire) et l'Assemblée nomme Solange Wolter, clerc de notaire, de résidence à Luxembourg,
en tant que scrutateur (le Scrutateur) (le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le Bureau de l'Assemblée).
Les Actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir été signée par les mandataires des Actionnaires
représentés à l'Assemblée, les membres du Bureau et le notaire.
Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront annexées au présent procès-verbal
après avoir été signées par toutes les parties.
Le Bureau ayant été ainsi formé, le Président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. Il résulte de la liste de présence que les cent (100) actions ordinaires, cinq cent soixante et onze (571) actions de
classe A «traçantes», huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions de classe B «traçantes», deux cents (200) actions de
classe C «traçantes», deux cents (200) actions de classe E «traçantes», deux cents (200) actions de classe F «traçantes»
et deux cents (200) actions de classe G «traçantes» ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)
chacune représentant l'intégralité du capital social souscrit de la Société d'un montant de EUR 1.211.000 (un million deux
cent onze mille euros) sont présentes ou représentées à l'Assemblée, qui est dès lors régulièrement constituée et peut
délibérer sur tous les points figurant à l'ordre du jour, indiqués ci-après.
II. L'ordre du jour de l'Assemblée est libellé de la manière suivante:
1. Renonciations aux formalités de convocation;
2. Décision de créer une nouvelle classe d'action nommée «action de classe K «traçantes» en français, et «class K
tracker shares» en anglais;
3. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille deux cent cinquante Euro (EUR
25.250,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million deux cent onze mille euros (EUR
1.211.000,-) représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-)
chacune, cinq cent soixante et onze (571) actions de classe A «traçantes», huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions
de classe B «traçantes», deux cents (200) actions de classe C «traçantes», deux cents (200) actions de classe E «traçantes»,
deux cents (200) actions de classe F «traçantes» et deux cents (200) actions de classe G «traçantes» ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) à un million deux cent trente-six mille deux cent cinquante Euro (EUR
1.236.250-) par la création et l'émission de cent deux (102) nouvelles actions ordinaires et cent (100) actions de classe
K «traçantes» de la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, lesquelles ont les
droits et obligations respectifs mentionnés dans les articles 5 et 25 des Statuts reformulés ci-dessous;
4. Souscriptions à et libérations de l'augmentation du capital social par voie de paiements en numéraire;
5. Modification subséquente des articles 5 et 25 des statuts de la Société (les Statuts) en version anglaise et version
française afin de refléter l'augmentation du capital social et la création de la classe d'actions K «traçantes» adoptées aux
points 2. et 3 ci-dessus;
6. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus avec pouvoir et
autorité conférés à tout administrateur de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun agissant individuellement,
afin de procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires
de la Société; et
7. Divers.
III. Que l'Assemblée a pris les résolutions suivantes, unanimement:
<i>Première résolution:i>
L'entièreté du capital social étant représenté à la présente Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux convoca-
tions, les Actionnaires représentés se considérant eux-mêmes comme dûment convoqués et déclarent avoir une parfaite
connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolution:i>
L'Assemblée décide d'augmenter et ainsi augmente le capital social de la Société d'un montant de vingt-cinq mille deux
cent cinquante Euro (EUR 25.250,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel d'un million deux
cent onze mille euros (EUR 1.211.000,-) représenté par cent (100) actions ordinaires d'une valeur nominale de cent vingt-
cinq euros (EUR 125,-) chacune, cinq cent soixante et onze (571) actions de classe A «traçantes», huit mille deux cent
dix-sept (8.217) actions de classe B «traçantes», deux cents (200) actions de classe C «traçantes», deux cents (200) actions
de classe E «traçantes», deux cents (200) actions de classe F «traçantes» et deux cents (200) actions de classe G «tra-
çantes» ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) à un million deux cent trente-six mille deux cent
cinquante Euro (EUR 1.236.250-) par la création et l'émission de cent deux (102) nouvelles actions ordinaires et cent
(100) actions de classe K «traçantes» de la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune,
lesquelles ont les droits et obligations respectifs mentionnés dans les articles 5 et 25 des Statuts reformulés ci-dessous.
42675
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolution:i>
L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes ainsi que la libération partielle de l'aug-
mentation du capital social comme suit, il est entendu que les Actionnaires ne souscrivant pas aux nouvelles actions ont
renoncé à leurs droits préférentiels de souscription pour souscrire aux nouvelles actions émises en vertu des présentes:
<i>Souscriptions - Libérationsi>
Matignon Abbeville S.A.S., une société par actions simplifiée soumis au droit français, ayant son siège social au 83, rue
du Faubourg St Honoré 75008 Paris, ici représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration annexée
et signée par les parties, déclare qu'elle souscrit à une (1) nouvelle action ordinaire ayant une valeur nominale de cent
vingt-cinq euros (EUR 125,-) et de libérer entièrement cette action ordinaire par un apport en numéraire d'un montant
total de trois cent quarante-cinq mille huit cent soixante-quinze Euro (EUR 345.875,00,-), documenté au notaire instru-
mentant par un certificat de blocage et qui sera affecté de la manière suivante:
- Un montant de cent vingt-cinq euros (EUR 125) au compte capital social nominal de la Société; et
- Un montant de trois cent quatre-cinq mille sept cent cinquante euros (EUR 345.750) au compte prime d'émission
des actions ordinaires.
PARINVEST S.A.S., une société par actions simplifiée soumis au droit français, ayant son siège social au 83, rue du
Faubourg St Honoré 75008 Paris, ici représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration annexée et
signée par les parties, déclare qu'elle souscrit à cent une (101) nouvelles actions ordinaires ayant une valeur nominale de
cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune et de libérer entièrement lesdites actions par un apport en numéraire d'un
montant total de trois millions cent vingt-quatre mille trois cent soixante-quinze Euro (EUR 3.124.375,00), documenté
au notaire instrumentant par un certificat de blocage et qui sera affecté de la manière suivante:
- Un montant de douze mille six cent vingt-cinq euros (EUR 12.625) au compte capital social nominal de la Société; et
- Un montant de trois millions cent onze mille sept cent cinquante euros (3.111.750 EUR) au compte prime d'émission
des actions ordinaires.
MAT-BEL 2, une société par actions simplifiée soumis au droit français, ayant son siège social au 83, rue du Faubourg
St Honoré 75008 Paris, ici représentée par Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration annexée et signée par
les parties, déclare qu'elle souscrit à cent (100) actions de classe K «traçantes» ayant une valeur nominale de cent vingt-
cinq euros (EUR 125,-) chacune et de libérer entièrement lesdites actions de classe K «traçantes» par un apport en
numéraire d'un montant total de treize millions cinq cent mille Euro (EUR 13.500.000,-), documenté au notaire instru-
mentant par un certificat de blocage et qui sera affecté de la manière suivante:
- Un montant de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) au compte capital social nominal de la Société; et
- Un montant de treize millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cinq cent euros (13.487.500 EUR) au compte prime
d'émission des actions de classe K «traçantes».
Le montant total de l'augmentation de capital est mis à la libre disposition de la Société, preuve d'une telle disposition
a été donnée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des résolutions précédentes, l'Assemblée décide de modifier les articles 5 et 25 des Statuts en version
anglaise et version française afin de refléter les modifications ci-dessus et décide que ces articles auront la teneur suivante:
Art. 5.
Version anglaise:
« Art. 5. The corporate capital of the Company is fixed at one million two hundred thirty-six thousand two hundred
fifty Euros (EUR 1,236,250.,-) represented by two hundred two (202) ordinary shares (the “Ordinary Shares”), having a
nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each, five hundred seventy-one (571) class A “tracker” shares
(in case of plurality, “the Class A Shares” and individually, “a Class A Share”), (ii) eight thousand two hundred seventeen
(8,217) class B “tracker” shares (in case of plurality, “the Class B Shares” and individually, “a Class B Share”), two hundred
(200) class C “tracker” shares (in case of plurality,”the Class C Shares” and individually, “a Class C Share”), two hundred
(200) class E “tracker” shares (in case of plurality, “the Class E Shares” and individually, a” Class E Share»), two hundred
(200) class F “tracker” shares (in case of plurality, “the Class F Shares” and individually, “a Class F Share”), two hundred
(200) class G “tracker” shares (in case of plurality, “the Class G Shares” and individually, “a Class G Share”) and one
hundred (100) class K “tracker” shares (in case of plurality, “the Class K Shares” and individually, a” Class K Share»)
having a nominal value of one hundred twenty-five Euros (EUR 125,-) each (collectively, “the Tracker Shares”, and indi-
vidually, “a Tracker Share”) that will track the performance and the return of the underlying assets that they will track.
Thus each class (or category) of tracker shares will be allocated to a specific investment and will entitle to the Net
Result of such Investment as set out in article 25 of these Articles.
The Class A Shares shall track the performance and the return of Centrum Warta S.A.
The Class B Shares shall track the performance and the return of Centrum Gdynia S.à r.l. and Centrum Baltica S.A.
42676
L
U X E M B O U R G
The Class C Shares shall track the performance and the return of Centrum Wroclaw S.à r.l., merged with Centrum
Gdynia S.à r.l. on May 25, 2010, and Centrum Baltica S.A.
The Class E Shares shall track the performance and the return of Centrum Weiterstadt S.A.
The Class F Shares shall track the performance and the return of Centrum Alexa S.à r.l.
The Class G Shares shall track the performance and the return of Centrum Leto S.A.
The Class K Shares shall track the performance and the return of Centrum Krakow S.A.
The Company may also create and issue tracker shares of new class to be defined. Any issue of a new class of shares
will have to be approved by the sole shareholder or by the majority of shareholders representing one half of the share
capital in accordance with article 23 of these Articles.
The Ordinary Shares and the Tracker Shares shall collectively and irrespective of their class be designated as the Shares
and individually and irrespective of their class be designated as a Share.
The holders of the Shares are together referred to as the Shareholders.
Each Share entitles its holder to one vote.
In addition to the corporate capital, there may be set up a share premium account, into which any premium paid on
any share shall be transferred. Any share premium paid in interest of the subscription of any Tracker Share of a specific
class upon their issuance shall be allocated to a share premium reserve account corresponding to that specific class of
Tracker Shares, to be denominated by the corresponding letter.
Each share gives its holder a right over the assets and the profits of the Company, in proportion with the total of
shares representing the corporate capital subject to the provisions set out under Article 25 of these Articles.»
Version française:
« Art. 5. Le capital social est fixé à un million deux cent trente-six mille deux cent cinquante Euro (EUR 1.236.250-)
représenté par deux cent deux (202) actions ordinaires (les «Actions Ordinaires») d'une valeur nominale de cent vingt-
cinq euros (EUR 125,-) chacune, cinq cent soixante et onze (571) actions de classe A «traçantes» (en cas de pluralité «les
Actions de Classe A» et individuellement «une Action de Classe A»), huit mille deux cent dix-sept (8.217) actions de
classe B «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe B» et individuellement «une Action de Classe B»), deux
cents (200) actions de classe C «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe C» et individuellement «une Action
de Classe C»), deux cents (200) actions de classe E «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe E» et indivi-
duellement «une Action de Classe E)», deux cents (200) actions de classe F «traçantes» (en cas de pluralité «les Actions
de Classe F» et individuellement «une Action de Classe F») deux cents (200) actions de classe G «traçantes» (en cas de
pluralité «les Actions de Classe G» et individuellement «une Action de Classe G»), et cent (100) actions de classe K
«traçantes» (en cas de pluralité «les Actions de Classe K» et individuellement «une Action de Classe K)» ayant une valeur
nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune (collectivement les «Actions Traçantes» et individuellement une
«Action Traçante») qui traceront la performance et le rendement des actifs sous-jacents qu'elles suivront.
Ainsi, chaque classe (ou chaque catégorie) d'actions traçantes sera affectée à un investissement en particulier et don-
nera droit au Résultat Net de cet Investissement tel que défini à l'article 25 des présents statuts.
Les Actions de Classe A traceront la performance et le rendement de Centrum Warta S.A.
Les Actions de Classe B traceront la performance et le rendement de Centrum Gdynia S.à r.l. et Centrum Baltica S.A.
Les Actions de Classe C traceront la performance et le rendement de Centrum Wroclaw S.à r.l., fusionnée avec
Centrum Gdynia S.à r.l. le 25 mai 2010, et Centrum Baltica S.A.
Les Actions de Classe E traceront la performance et le rendement de Centrum Weiterstadt S.A.
Les Actions de Classe F traceront la performance et le rendement de Centrum Alexa S.à r.l.
Les Actions de Classe G traceront la performance et le rendement de Centrum Leto S.A.
Les Actions de Classe K traceront la performance et le rendement de Centrum Krakow S.A.
La Société peut également créer et émettre des actions traçantes d'une nouvelle catégorie à définir. Toute émission
de nouvelle catégorie d'actions devra être approuvée par l'actionnaire unique ou à la majorité des actionnaires repré-
sentant la moitié du capital social conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts.
Les Actions Ordinaires et les Actions Traçantes seront collectivement et sans tenir compte de leur classe désignées
les Actions, et individuellement et sans tenir compte de leur classe une Action.
Les détenteurs des Actions seront désignés ensemble les Actionnaires.
Chaque Action donne à son détenteur droit à un vote.
En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi, sur lequel toute prime payée sur quelque
action que ce soit sera transférée. Toute prime d'émission payée à l'égard de la souscription d'une Action «traçante»
d'une classe spécifique après son émission sera allouée au compte de prime d'émission de réserve correspondant à cette
classe particulière d'une Action «traçante», à nommer par la lettre correspondant.
Chaque action donne à son détenteur un droit sur les actifs et les bénéfices de la Société, proportionnellement à la
totalité des actions représentant le capital social conformément aux dispositions prévues à l'article 25 des présents
Statuts.»
42677
L
U X E M B O U R G
Art. 25.
Version Anglaise
Art. 25. Distribution of Profits. The profits in respect of a financial year, after deduction of general and operating
expenses, charges and depreciations, shall constitute the net profit of the Company in respect of that period.
From the net profit thus determined, five per cent (5%) shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That
deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's
nominal capital.
An extra accounting follow-up of this allocation to the legal reserve will be carried out in order to identify to which
class of Shares this reserve has been done (allocation arising from the ordinary shares and/or the tracker shares and
identification of the class).
After the allocation of any profits to the above statutory reserve account, all further profits shall be distributed and
paid as follows:
(a) The holders of the Shares of each class shall, pro rata the capital invested by each of them in respect of their Shares
(nominal value and, as the case may be, share premium), be entitled to a dividend equal to (i) any proceeds and income
derived by the Company (including, without limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any
other proceeds and income, notably the returns on credits linked to the investment or on assets owned through the
investment) from its direct investment in the assets acquired with the proceeds of the subscription for the Shares of such
class, minus (ii) any costs directly related to such investment (including, without limitation, capital losses, financial liabilities
linked to the financing of the investment, fees and other expenses directly deriving from the investment), items (i) and
(ii) to be determined by the Board of Directors;
(b) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class A Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
A Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM WARTA S.A. (the "Class A Investment Net Income"), minus (ii) any costs
directly related to the Class A Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors of the
Company;
(c) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class B Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
B Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM GDYNIA S.à r.l. and CENTRUM BALTICA S.A. (the "Class B Investment Net
Income"), minus (ii) any costs directly related to the Class B Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by
the Board of Directors of the Company;
(d) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class C Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
C Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM WROCLAW S.à r.l. merged with CENTRUM GDYNIA S.à r.l, and CENTRUM
BALTICA S.A. (the "Class C Investment Net Income"), minus (ii) any costs directly related to the Class C Investment
Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors of the Company;
(e) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class E Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
E Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM WEITERSTADT S.A. (the "Class E Investment Net Income"), minus (ii) any
costs directly related to the Class E Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors
of the Company;
(f) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class F Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
F Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM ALEXA S.à r.l. (the "Class F Investment Net Income"), minus (ii) any costs
directly related to the Class F Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors of the
Company;
(g) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class G Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
G Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
42678
L
U X E M B O U R G
Company in connection with CENTRUM LETO S.A. (the "Class G Investment Net Income"), minus (ii) any costs directly
related to the Class G Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors of the Company;
(h) for the avoidance of any doubt, the holders of the Class K Shares at the time of such distribution, pro rata in
accordance with the capital invested (nominal amount and, as the case may be, share premium) by each holder of Class
K Shares in the Company in respect of such shares, shall be entitled to (i) any proceeds and income (including, without
limitation, dividends, capital gains, liquidation profits, sale proceeds and any other proceeds and income) obtained by the
Company in connection with CENTRUM KRAKOW S.A. (the "Class K Investment Net Income"), minus (ii) any costs
directly related to the Class K Investment Net Income, as (i) and (ii) to be determined by the Board of Directors of the
Company;
(i) the distribution of a dividend in connection with tracker shares of one or more classes will only be paid to these
shares if the whole net distributable benefits exceed the amount of the envisaged benefits distribution.
(j) In so far as an Investment Net Income on one or several share classes will be observed, the general meeting of
shareholders will have the power to decide by the two third vote majority of the distribution of this or these Investment
Net Income(s) while privileging one or another share class, within the limits of the Investment Net Income available for
such share class. For the avoidance of doubt, if the aggregate distributable profit is minored by the negative net result on
an specified investment, the general meeting of shareholders will be entitled to decide upon the allocation of this loss
upon the positive Net Investment Income of one or more share classes rather than one or several share classes, without
allocating to the pro rata of the real net results for each share class, always within the limits of the positive net available
results.
The general meeting of the shareholders has discretionary power to dispose of the surplus, if any. It may in particular
allocate such profit to the payment of a dividend, transfer it to the reserve or carry it forward.
Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
1. Interim accounts are established by the Board of Directors.
2. These accounts show a profit including profits carried forward or transferred to an extraordinary reserve.
3. The interim dividends shall be paid in accordance with the rules set in this Article 25 (a) to (j).
4. The decision to pay interim dividends is taken by the Board of Directors in accordance with the terms prescribed
by law or, as the case may be, by an extraordinary general meeting of the shareholders.
5. The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the creditors of the Company
are not threatened.
Version Française
Art. 25. Les profits de l'exercice social, après déduction des frais généraux et opérationnels, des charges et des amor-
tissements, constituent le bénéfice net de la Société pour cette période.
Sur le bénéfice net ainsi déterminé, cinq pour cent (5%) seront prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce
prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le montant de celle-ci aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.
Un suivi extra comptable de cette affectation de la réserve légale sera effectué afin d'identifier à quelle catégorie de
parts cette réserve est imputable (affectation provenant des actions ordinaires et/ou des actions traçantes et identification
de la catégorie)
Après affectation des bénéfices à la réserve légale ci-dessus, tous les bénéfices restants seront distribués et payés
comme suit:
(a) les détenteurs des Actions de chaque classe auront, au pro rata du capital investi par chacun d'eux pour leurs
Actions (valeur nominale et, le cas échéant, prime d'émission), droit à un dividende égal à (i) tous les produits et tout
revenu réalisés par la Société (en ce compris, sans limitation, les dividendes, les gains sur capital, les boni de liquidation,
les produits d'une vente ou tout autre produit ou revenu, notamment les revenus sur créances rattachées à l'investisse-
ment ou aux actifs détenus par l'investissement) sur leur investissement direct dans les avoirs acquis grâce au produit de
la souscription aux Actions de cette classe, moins (ii) tous les coûts directement liés à cet investissement (en ce compris
sans limitation, les pertes en capital, les charges financières actionnaires au financement de l'investissement, les honoraires
et autres frais directement imputables à l'investissement), les points (i) et (ii) étant déterminés par le Conseil d'adminis-
tration;
(b) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe A au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
A dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM WARTA S.A. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe A"), moins (M) tous frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe A, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la Société;
(c) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe B au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
B dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et tout autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation avec
42679
L
U X E M B O U R G
CENTRUM GDYNIA S.à r.l. et CENTRUM BALTICA S.A. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe B"), moins (ii) tous
frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe B, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil
d'Administration de la Société;
(d) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe C au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
C dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tous bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM WROCLAW S.à.r.l. fusionnée avec CENTRUM GDYNIA S.à r.l., et CENTRUM BALTICA S.A. (le "Re-
venu Net d'Investissement de Classe C"), moins (ii) tous frais directement liés au Revenu Net d'Investissement de Classe
C, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la Société;
(e) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe E au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
E dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM WEITERSTADT S.A. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe E"), moins (ii) tout frais directement
liés au Revenu Net d'Investissement de Classe E, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la
Société;
(f) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe F au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
F dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM ALEXA S.à.r.l. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe F"), moins (ii) tout frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe F, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la Société;
(g) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe G au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
G dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM LETO S.A. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe G"), moins (ii) tout frais directement liés au
Revenu Net d'Investissement de Classe G, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la Société;
(h) pour éviter tout doute les détenteurs d'Actions de Classe K au moment d'une telle distribution, au prorata, sur
base du capital investi (montant nominal et, le cas échéant, prime d'émission) par chaque détenteur d'Actions de Classe
K dans la Société relativement à de telles actions, auront le droit à (i) tout bénéfices et revenus (en ce compris, dividendes,
plus-value, boni de liquidation, bénéfices de vente et toute autre bénéfice et revenu) obtenu par la Société en relation
avec CENTRUM KRAKOW S.A. (le "Revenu Net d'Investissement de Classe K"), moins (ii) tout frais directement liés
au Revenu Net d'Investissement de Classe K, tels que (i) et (ii) sont déterminés par le Conseil d'Administration de la
Société;
(i) Le versement d'un dividende actionnaire à des actions traçantes d'une ou plusieurs catégories ne pourra être versé
à ces actions que si l'ensemble du bénéfice net distribuable est supérieur au montant de la distribution envisagée;
(j) Dès lors qu'un Revenu Net d'Investissement sera constaté sur une ou plusieurs classes d'actions, l'Assemblée
Générale aura la faculté de décider, à la majorité des deux tiers de la distribution de ce ou ces Revenu(s) Net(s) d'Inves-
tissement en privilégiant l'une ou l'autre des classes d'actions, dans la limite du Revenu Net d'investissement disponible
pour telle classe d'actions. Pour éviter tout doute, si le bénéfice distribuable total est minoré par le résultat net négatif
dégagé sur un investissement en particulier, l'Assemblée Générale des actionnaires aura la faculté de décider d'affecter
cette perte sur le Revenu Net d'Investissement positif d'une ou plusieurs classes d'actions, plutôt qu'une ou plusieurs
autres, sans qu'il soit nécessaire de faire une affectation au prorata des résultats nets constatés pour chaque catégorie
d'actions, toujours dans la limite du résultat net positif disponible;
L'Assemblée Générale peut disposer du surplus, s'il y en a, à sa discrétion. Elle peut, en particulier, affecter ce bénéfice
au paiement d'un dividende, le transférer à une réserve ou le reporter.
Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par l'administrateur unique ou par le Conseil d'Administration.
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître
un bénéfice.
3. Les acomptes sur dividendes doivent être versés conformément aux stipulations de l'article 25 (a) à (j).
4. La décision de distribuer un acompte sur dividende est prise par le Conseil d'Administration conformément aux
dispositions légales, ou le cas échéant, par L'Assemblée Générale extraordinaire.
5. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l'assurance que les droits des créanciers ne sont pas
menacés.
42680
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus et
donne pouvoir et autorité à tout Représentant Autorisé, chacun agissant individuellement, selon leur seule signature, avec
pouvoir de substitution total, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription des modifications ci-dessus dans
le registre des actionnaires de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, sont estimés approximativement à la somme de cinq mille huit
cents Euros (5.800.-EUR).
Dont acte, fait et passé, même date qu'en tête des présentes à Luxembourg.
Et après lecture faite au représentant des parties comparantes, connues du notaire soussigné par leurs noms, prénoms
usuels, état civil et demeure, ledit représentant des parties comparantes a signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63015. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015032248/378.
(150036232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Nord Point SCSp, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 194.768.
Il résulte d'un contrat social sous seing privé du 10 février 2015 que la société en commandite spéciale Nord Point
SCSp a été constituée à cette même date pour une durée illimitée.
L'associé-commandité gérant de la Société est Nord Point Management S.à r.l, une société à responsabilité limitée de
droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro
B193064 et ayant son siège social au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
La Société a son siège social au 412 F, Route d'Esch, L-2086 Luxembourg.
Vis-à-vis de tiers, la Société est engagée par la signature de l'associé commandité ou par la signature individuelle ou
conjointe de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs spéciaux ont été expressément délégués par l'associé commandité.
L'objet de la Société est le suivant:
«L'objet de la Société est l'acquisition de participations, au Luxembourg ou à l'étranger, dans toutes sociétés, sociétés
en commandite ou entreprises sous quelque forme que ce soit, ainsi que la gestion de ces participations. La Société peut
en particulier acquérir par voie de souscription, achat ou échange ou par tout autre moyen, des actions, parts, ou tout
autre instrument participatifs, obligations, instruments de dette, certificats de dépôt ou autre titre de créance et, de
manière générale, toute valeur mobilière et instrument financier émis par une entité publique ou privée. Elle peut participer
à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toute société, société en commandite ou entreprise. De plus
elle peut investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle
de toute nature ou origine.
La Société peut procéder à des emprunts sous toute forme. Elle peut émettre des titres d'emprunts et des obligations
et tout autre instrument de dette. Elle peut avancer des fonds, y compris et sans limitation les produits d'emprunts, à ses
filiales, sociétés affiliées et autres sociétés. Elle peut aussi octroyer des garanties et engager, transférer, grever, créer ou
octroyer de toute autre manière des garanties sur tout ou parties de ses avoirs afin de garantir ses propres obligations,
celles de toute autre société dans laquelle elle détient des participations ou qui fait partie du même groupe de sociétés
auquel la Société appartient ou à toute autre société ou entité pour lesquelles elle le juge opportun, et, de manière
générale, pour son propre bénéfice et celui de toute autre société ou personne.
Cependant, la Société ne peut pas s'engager dans des opérations qui pourrait l'amener à être qualifiée de commerçante
ou à être engagée dans des activités pouvant être considérées comme une activité réglementée du secteur financier
conformément à la loi du 5 avril 1993, telle que modifiée, sur le secteur financier ou toute autre règlement modifiant ou
remplaçant cette loi.
La Société peut faire usage de toutes techniques, moyens légaux et instruments pour gérer ses investissements de
manière efficace et pour se protéger des risques de crédit, des risques connexes au cours du change, risques de taux
d'intérêt et autres risques.
42681
L
U X E M B O U R G
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, financières ou techniques et, en général, toutes opérations
relatives à des biens immobiliers ou mobiliers, qui, directement ou indirectement facilitent ou sont en lien avec son objet
social.»
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20 février 2015.
<i>Pour Nord Point SCSpi>
Référence de publication: 2015032626/44.
(150036435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Freko Echafaudages S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6868 Wecker, 18, Duchscherstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 105.785.
<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung der Freko Echafaudages S.à r.l.i>
Unter Verzicht auf jegliche Form- und Fristerfordernisse treten wir zu einer Geselischafterversammlung zusammen
und beschließen folgendes:
Mit Wirkung ab dem 01.01.2014 wird Frau Edith Frechen von ihrem Amt als Geschäftsführerin abberufen. Herr Franz
Dieter FRECHEN, wohnhaft in D-54338 Schweich, Bei den Weiden 8, wird zum heutigen Tage zum Geschäftsführer
ernannt.
Der Geschäftsführer kann die Gesellschaft rechtskräftig durch seine alleinige Unterschrift verpflichten bis zu einem
Betrag von ein tausend zwei hundert fünfzig Euro (EUR 1.250,-). Für alle Verpflichtungen die über diesen Betrag hinaus-
gehen, bedarf es der gemeinsamen Unterschrift mit einer weiteren Geschäftsführerin.
Wecker, den 31.12.2013.
Edith Frechen / Doris Kordel
<i>Gesellschafterin / Gesellschafterini>
Référence de publication: 2015033083/19.
(150036725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Future Media International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 300.000,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 168.480.
Il est à noter que:
1. Suite au transfert des parts sociales, l'associé unique de FUTURE MEDIA INTERNATIONAL S.à r.l. est désormais
le suivant:
BLUETOUCH INVESTMENTS (LUXEMBOURG) NUMBER 2 S.à r.l.
62, Avenue Guillaume
L-1650 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B-117.191 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300.000
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000 parts sociales
2. Le siège social de la société a été transféré au 62, Avenue Guillaume, L-1650 Luxembourg
Luxembourg, le 25 février 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015033084/20.
(150036909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Farm Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3353 Leudelange, 1, rue d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 190.877.
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080
Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391
42682
L
U X E M B O U R G
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la
Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.
À Bertrange, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015033085/14.
(150036971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Felten Frères et Fils S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9775 Weicherdange, Zone Artisanale.
R.C.S. Luxembourg B 106.458.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033086/10.
(150036718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Hôpitaux Robert Schuman, Fondation,
(anc. Fondation Francois-Elisabeth).
Siège social: L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg G 86.
<i>Résolutions prises par le conseil d'administration lors de sa réunion du 26 novembre 2014i>
1) Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité des membres présents, de coopter Monsieur Robert Steinmetzer,
demeurant à F-75116 Paris, 14, avenue du Président Wilson, avec effet immédiat et pour une durée de 6 ans.
2) Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité des membres présents, de fixer à 4 ans la durée des mandats
d'administrateurs de Monsieur Jean-Louis Schiltz et de Monsieur Michel Wurth, et à 5 ans la durée des mandats de Madame
Marie-Josée Jacobs et de Monsieur Frank Wagener, chaque fois à partir des dates de cooptation respectives.
3) Le conseil d'administration a décidé, à l'unanimité des membres présents, de fixer les pouvoirs de signature au sein
du conseil d'administration et du comité de direction comme suit:
En toutes circonstances, la Fondation est engagée envers les tiers par la signature conjointe de deux administrateurs
dont celle du président ou, à défaut, celle du vice-président.
Dans le cadre des fonctions déléguées au comité de direction, la Fondation est engagée par la signature conjointe de
deux membres du comité de direction dont celle du Directeur général ou, à défaut, celle de l'un des Directeurs adjoints.
La Fondation est encore engagée par la ou les signature(s) de toute(s) personne(s) à qui un pouvoir de signature aura
spécialement été délégué pour des opérations ponctuelles.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033096/24.
(150036716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Futuradent G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3337 Hellange, 26, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 39.551.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten Tag des Monats Februar;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);
IST ERSCHIENEN:
Herr Claude LESS, Zahntechniker, geboren in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 18. November 1965,
wohnhaft in L-3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf.
Welcher Komparent den amtierenden Notar ersucht folgendes zu beurkunden:
- Dass die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter
Haftung „FUTURADENT G.M.B.H.“, mit Sitz in L-3337 Hellingen, 26, rue de Mondorf, eingetragen beim Handels- und
Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 39551, (hiernach die „Gesellschaft“), gegründet
worden ist gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Paul BETTINGEN, mit dem damaligen Amtssitz in Wiltz
42683
L
U X E M B O U R G
(Großherzogtum Luxemburg), am 11. Februar 1992, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Asso-
ciations, Nummer 325 vom 29. Juli 1992,
und dass deren Satzungen (die „Statuten“) abgeändert worden sind gemäß Urkunden aufgenommen:
* durch Notar Roger ARRENSDORFF, im damaligen Amtssitz in Wiltz (Großherzogtum Luxemburg), am 31. August
1995, veröffentlicht im Memorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 565 vom 6. November 1995,
* durch Notar Jean-Paul HENCKS, mit dem damaligen Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 25.
September 2003, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1120 vom 28. Oktober
2003,
* durch vorgenannten Notar Jean-Paul HENCKS, am 28. Juli 2005, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, Nummer 113 vom 17. Januar 2006, und
* durch Notarin Christine DOERNER, mit dem Amtssitz in Bettemburg (Großherzogtum Luxemburg), am 26. August
2013, veröffentlicht im Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2744 vom 4. November 2013;
- Dass der Komparent erklärt der einzige Gesellschafter (der „Alleingesellschafter“) der Gesellschaft zu sein und dass
er den amtierenden Notar ersucht, die von ihm gefassten Beschlüsse zu dokumentieren wie folgt:
<i>Erster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt das Gesellschaftskapital der Gesellschaft um den Betrag von zwölftausendvierhun-
dert Euro (12.400,- EUR) zu erhöhen, um es von seinem aktuellen Betrag von zwölftausendvierhundert Euro (12.400,-
EUR) auf den Betrag von vierundzwanzigtausendachthundert Euro (24.800,- EUR) zu bringen, durch die Schaffung und
Ausgabe von einhundert (100) neuen Anteile mit einem Nominalwert von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR),
welche dieselben Rechte und Vorteile genießen wie die schon bereits bestehenden Anteile und Recht auf Ausschüttung
von Dividenden ab dem heutigen Tag haben.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Alsdann erscheint die Alleingesellschafter, vorgenannt, und erklärt die einhundert (100) neuen Anteile zu zeichnen und
sie voll einzuzahlen durch Eingliederung ins Kapital von frei verfügbaren übertragenen Reserven in Höhe von zwölftau-
sendvierhundert Euro (12.400,- EUR).
Die Existenz dieser Reserven wurde dem Notar nachgewiesen mittels Vorlegen einer Kopie einer Bilanz zum 31.
Dezember 2014 und einer, vom Geschäftsführer am 13. Februar 2015 ausgestellten und unterzeichneten Bescheinigung.
Die vorgenannten Dokumente bleiben vorliegender Urkunde, nach „ne varietur” Unterzeichnung durch den Kompa-
renten und den amtierenden Notar, beigebogen, um mit derselben registriert zu werden.
Dem Geschäftsführer werden alle Vollmachten erteilt die notwendigen Umbuchungen vorzunehmen.
<i>Zweiter Beschlussi>
Zwecks Anpassung der Satzung an die hiervor genommenen Beschlüsse, beschließt die Versammlung Artikel 6 der
Satzungen abzuändern wie folgt:
„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt vierundzwanzigtausendachthundert Euro (24.800,- EUR), aufgeteilt in zwei-
hundert (200) Anteile mit einem Nominalwert von je hundertvierundzwanzig Euro (124,- EUR).
Das Kapital kann zu jedem Zeitpunkt erhöht oder herabgesetzt werden sowie dies in Artikel 199 des Gesellschafts-
rechts festgelegt ist.”
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der
Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr tausend Euro.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, dem instrumentierenden Notar nach
Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat besagter Komparent mit Uns dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Signé: C. LESS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 17 février 2015. 2LAC/2015/3522. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015033104/66.
(150036708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42684
L
U X E M B O U R G
Futuradent G.m.b.H., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3337 Hellange, 26, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 39.551.
Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Februar 2015.
Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
i>Maître Carlo WERSANDT
<i>Notari>
Référence de publication: 2015033105/14.
(150036806) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Green Valley Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6926 Flaxweiler, 33, ruer Berg.
R.C.S. Luxembourg B 156.063.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033117/10.
(150037063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Gland Mortgage III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 143.473.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la société en date du 20 février 2015i>
<i>(le «Conseil d'Administration»)i>
Le Conseil d'Administration de la Société décide de transférer le siège social de la Société du 5 Boulevard Royal, L -
2449 Luxembourg, au 7, Val Sainte-Croix, L - 1371 Luxembourg, et ce avec effet au 19 février 2015.
A Luxembourg, le 24 février 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
Référence de publication: 2015033109/15.
(150037324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Franklin Templeton International Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 8A, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 36.979.
Franklin Templeton International Services S.à r.l. prend note du changement de nom de son associé, Franklin Templeton
Luxembourg S.A. (anciennement Franklin Templeton Luxembourg Holding S.A.), 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Lu-
xembourg, suite à la modification des statuts de ce dernier en date du 8 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015033081/12.
(150036972) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42685
L
U X E M B O U R G
Fratelli S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 107.596.
<i>Extrait des résolutions de l’actionnaire unique prises en date du 4 février 2015i>
Les résolutions suivantes ont été adoptées par l’actionnaire unique en date du 4 février 2015:
1- Le mandat de l’administrateur Ensof Services S.à r.l. viendra à échéance lors de l’assemblée générale des actionnaires
qui se tiendra en 2020 pour approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.
2- Monsieur Antoine Lam-Chok, né le 21 août 1965 à Port-Louis, Iles Maurice, ayant son adresse professionnelle au
6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, a été nommé représentant permanent de Ensof Services S.à r.l., avec effet
au 5 mars 2014;
3- Monsieur Adrian Braimer Jones, né le 16 septembre 1965 à Nairobi, Kenya, ayant son adresse professionnelle au
49, Grosvenor Street, W1K 3HP Londres, Royaume-Uni, a été nommé administrateur de la Société, avec effet au 4 février
2015;
4- Elah External Management Services Ltd, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social au
Road Town, Palm Grove House, 4
th
Floor, P.O. Box 438, VG1110 Tortola, Iles Vierges Britanniques, enregistrée auprès
du Companies Register sous le numéro 1719028, a été nommée administrateur de la Société, avec effet au 4 février 2015.
Monsieur Grégory Noyen, né le 22 janvier 1980 à Lièges, Belgique, ayant son adresse professionnelle au 6A, route de
Trèves, L-2633 Senningerberg, a été nommé représentant permanent de Elah External Management Services Ltd, avec
effet au 4 février 2015.
5- Le mandat du commissaire aux comptes, ISIS Group Services Ltd, viendra à échéance lors de l’assemblée générale
des actionnaires qui se tiendra en 2020 pour approuver les comptes arrêtés au 31 décembre 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 23 février 2015.
Référence de publication: 2015033082/28.
(150037113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Five Lions e-Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 188.994.
EXTRAIT
Depuis le 10 octobre 2014, il résulte que la société «Five Lions Holding S.à r.l.», avec siège social à 12, rue Léandre
Lacroix, L-1913 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce, numéro B 191.257, est l'associée unique de la société
«Five Lions e-solutions S.à r.l.».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033079/14.
(150037233) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Energy Standard Group S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 75.466.
<i>Extrait de la Réunion du Conseil d'Administration tenue le 18 février 2015 au siège social de la sociétéi>
<i>Décisioni>
1. Le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des titres au porteur la société Jawer Luxembourg
immatriculé au Registre de Commerce sous le numéro B118 437 et ayant son siège au 241, route de Longwy L-1941
Luxembourg, conformément à l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur.
42686
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015033061/15.
(150036822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Eresa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 11, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 181.139.
En date du 11-02-2015,
Madame Sarah CARLETTI, née le 7 juin 1982 à Liège demeurant à L-7377 Lorentzweiler, 32, Rue Eugène Nickels.
A cédé 100 parts à MEMOLA&PARTNERS SA avec siège au 48, Esplanade, L-9227 Diekirch, B135134
Signature
<i>Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015033064/12.
(150036910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Dalba Partners S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 40.137,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 21-25, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 175.462.
Monsieur Patrice DEYGLUN, administrateur délégué de la Société DALBA PARTNERS S.A., société anonyme de droit
luxembourgeois, a été informé du changement de dénomination sociale de son commissaire aux comptes la société
anonyme COMPAGNIE FINANCIERE ET COMMERCIALE TAMINO S.A., société anonyme de droit luxembourgeois,
inscrite auprès du Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 167.894 en TAMINO: GROUPE LALLEMAND
S.A., société anonyme de droit luxembourgeois.
La société TAMINO: GROUPE LALLEMAND S.A. a également procédé au transfert de son siège social du L-2520
Luxembourg, 21-25, allée Scheffer à L-1724 Luxembourg, 33, boulevard Prince Henri.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015033042/16.
(150036808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Humaniste Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.404.
Par la présente, nous vous prions de prendre note de notre démission de notre poste de Commissaire aux Comptes
de votre société.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Jawer Consulting SA
Signature
Référence de publication: 2015033135/12.
(150036823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Humaniste Conseil S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1941 Luxembourg, 241, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 117.404.
Par la présente, je vous prie de prendre note de ma démission de mon poste d'administrateur de votre société avec
effet immédiat.
Dublin, le 12 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015033137/10.
(150036823) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42687
L
U X E M B O U R G
I.B.E. S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8049 Strassen, 2, rue Marie Curie.
R.C.S. Luxembourg B 65.709.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
<i>Pour la société
i>Jean-Michel Dangis
<i>Comptablei>
Référence de publication: 2015033138/13.
(150037137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Innova Financial Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 57.149.125,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.343.
En date du 20 février 2015, l'associé GESDORAS INVESTMENTS Limited, avec siège social au 5, Themistokli Dervi,
Elenion Building, 2
nd
Floor, 1066 Nicosia, Chypre, a cédé la totalité de ses 28.404 parts sociales à Truss Fundusz Inwes-
tycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych, avec siège social au 53 ul. Chlopska, 80-350 Gdansk, Pologne, qui les
acquiert.
En conséquence, les associés de la société sont les suivants:
- Truss Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Aktywow Niepublicznych, précité, avec 28.404 parts sociales
- Friends of Innova L.P., avec siège social au 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Ile Caïmans
avec 12.442 parts sociales
- INNOVA/4 L.P., avec siège social au 190, Elgin Avenue, KY1-9005 George Town, Grand Cayman, Ile Caïmans avec
414.779 parts sociales
- Slawomir Lukasiewicz, avec adresse au 8, Ul. Kasztanowa, 55-010 Zerniki Wroclawskie, Pologne avec 1.568 parts
sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033140/22.
(150037339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
L.M.B.E. Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 102.819.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 30 janvier 2015i>
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 janvier 2015, que:
1. L'assemblée prend acte de la démission de Madame Christine Lecas de son mandat d'Administrateur en date du 24
février 2014. Elle décide de ratifier la nomination, avec effet au 24 février 2014, de Monsieur Nicolas Mille, employé privé,
né le 8 février 1978 à Antony (France), demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach,
en qualité d'Administrateur de la Société, jusqu'à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2018.
2. L'assemblée accepte la démission de Monsieur François Georges de ses mandats d'Administrateur et d'Adminis-
trateur-délégué.
3. L'assemblée décide de nommer Monsieur Alexandre Taskiran, expert-comptable, né le 24 avril 1968 à Karaman
(Turquie), demeurant professionnellement à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, en qualité d'Administrateur
de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'issue de l' assemblée générale statutaire qui se tiendra en l'an 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
L.M.B.E. EUROPE S.A.
Référence de publication: 2015033171/20.
(150036990) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42688
L
U X E M B O U R G
Inversiones Eneida S.à r.l., SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 193.399.
Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033146/10.
(150037264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Investment Interest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 152.723.
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080
Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la
Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.
À Bertrange, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015033147/14.
(150037012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Icon 1 S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.612.
EXTRAIT
M. Jeremy Nicholas Hamilton Hood a démissionné de ses fonctions d'Administrateur Investisseur de la Société avec
effet au 23 février 2015.
Il en résulte que le conseil d'administration de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Pierre Stemper, Administrateur Investisseur;
- Mme Christelle Rétif, Administrateur Investisseur;
- M. Naïm Gjonaj, Administrateur Investisseur;
- M. Stefano Ferraresi, Administrateur Investisseur;
- M. Nikos Stathopoulos, Administrateur Investisseur;
- M. Alessandro Fogo, Administrateur de classe B;
- Mme Lori A. Hall-Kimm, Administrateur de classe C; et
- M. Stefano Beraldo, CEO
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015033150/23.
(150037093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Icon Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 50.025,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 66.588.
Les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2013 de la société ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
42689
L
U X E M B O U R G
Walferdange.
<i>Un géranti>
Référence de publication: 2015033149/12.
(150037361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Icon 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.837.787,00.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 159.611.
EXTRAIT
M. Jeremy Nicholas Hamilton Hood a démissionné de ses fonctions de Gérant Investisseur de la Société avec effet au
23 février 2015.
Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- M. Pierre Stemper, Gérant Investisseur;
- Mme Christelle Rétif, Gérant Investisseur;
- M. Naïm Gjonaj, Gérant Investisseur;
- M. Stefano Ferraresi, Gérant Investisseur;
- M. Nikos Stathopoulos, Gérant Investisseur;
- M. Alessandro Fogo, Gérant de classe B;
- Mme Lori A. Hall-Kimm, Gérant de classe C; et
- M. Stefano Beraldo, CEO
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 24 février 2015.
<i>Pour la Société
i>Signature
Référence de publication: 2015033151/24.
(150037144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
INTERCORP S.A, International Corporate Activities S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 10.548.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration et du comité de direction du 28 janvier 2015 que
l'administrateur, Monsieur Nicolas Schaeffer, décédé, ne sera pas remplacé.
Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Gabriele SCHNEIDER / Lou HUBY
<i>Administrateur et Directeur / Administrateur et Directeuri>
Référence de publication: 2015033155/15.
(150037360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
AXL International, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 59, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 152.256.
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080
Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391
42690
L
U X E M B O U R G
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la
Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.
À Bertrange, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015032964/14.
(150037048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
AXL Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 154.418.
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080
Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la
Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.
À Bertrange, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015032965/14.
(150037049) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
B.R.C. Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 2, rue des Tilleuls.
R.C.S. Luxembourg B 123.855.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015032966/10.
(150036694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Join Expérience S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 176.835.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015033159/10.
(150036686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Jambo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 61, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 183.553.
Il résulte d'une décision prise par le conseil d'administration de la Société en date du 2 février 2015 que:
TCA Domiciliation S.A R.L., une société à responsabilité limitée ayant son siège social à 61, route de Longwy, L-8080
Bertrange, enregistrée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 149391
A été nommée en qualité d'agent dépositaire des actions et titres représentatifs d'actions au porteur émises par la
Société, conformément à la loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014, entrée en vigueur le 18 août 2014, relative à l'immo-
bilisation des actions et parts au porteur.
À Bertrange, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015033160/14.
(150036968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42691
L
U X E M B O U R G
Jawhar Resort Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 147.295.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance des tiers, que l'adresse du siège social de l'associé, Aerium Atlas Management S.à r.l. (B
141575) est située au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015033161/14.
(150037225) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Jordan S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 51.864.
La convention de Domiciliation concernant la société Jordan S.A. ayant son siège social au 20, Rue de la Poste, L-2346
Luxembourg a été dénoncée, avec effet en date du 18/02/2015, par la société Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Citco C&T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015033162/11.
(150037117) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1461 Luxembourg, 65, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 112.519.
<i>Décision de l'associé unique en date du 23/10/2014i>
<i>Troisième Résolutioni>
L'associé unique accepte la démission de M. Stéphane Charlier de sa fonction à la délégation journalière et son rem-
placement par M. Giulio Senatore, avec adresse professionnelle au 65, Rue d'Eich - L-1461 Luxembourg.
Référence de publication: 2015033166/11.
(150037355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Helpling Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.795,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 184.677.
In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth day of December,
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the
laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
being the holder of ten thousand (10,000) common shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M. professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 4 November 2014;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbes-
chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B,
having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
42692
L
U X E M B O U R G
being the holder of two thousand five hundred (2,500) common shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany, on 4 December 2014;
3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands with its registered
office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under no.
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands,
being the holder of four hundred seventeen (417) series A1 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Schiphol, the Netherlands, on 28 November 2014 and 4 December 2014;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, and having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),
being the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series A1 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
London, England on 9 December 2014;
5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))
existing under the laws of Germany with its statutory seat in Wehingen, Germany, registered with the commercial register
(Handelsregister) at the local court of Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), Germany, under no. HRB 733673, having its
business address at Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen, Germany,
being the holder of forty-two (42) series A1 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M. professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Chicago, USA, on 8 December 2014;
6. Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered number 60595, having its business address at
Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,
being the holder of two thousand five hundred (2,500) series A2 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Jersey, on 4 December 2014;
7. Phenomen Ventures LP, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registration number OG -
66003, having its registered office at 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands,
being the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Moscow, Russia on 8 December 2014;
8. Mangrove IV Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 189.521, having its registered office at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg,
being the holder of three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on 8 December 2014;
9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., a limited liability company under the laws of Bermuda with its statutory
seat in Hamilton, Bermuda, having its business address at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda HM11,
participating and voting only for purposes of agenda point 8 et seqq.,
becoming the holder of four hundred seventeen (417) new created series A5 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Bermuda on 12 December 2014;
10. David W. Zalaznick, born on 16 April 1954, resident at 9 West 57
th
Street - 33
rd
Floor, New York, NY 10019,
United States of America, participating and voting only for purposes of agenda point 8 et seqq.,
becoming the holder of four hundred seventeen (417) new created series A5 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Miami, USA on 4 December 2014;
11. Luktev GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under the laws of Germany with
its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of
Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 119212 B, having its business address at Moh-
renstrasse 60, 10117 Berlin, Germany, participating and voting only for purposes of agenda point 8 et seqq.,
becoming the holder of four hundred seventeen (417) new created series A5 shares of the Company,
42693
L
U X E M B O U R G
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany on 4 December 2014;
12. Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of
Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local
court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45915 B, having its business address
at Jägerstrasse 65, 10117 Berlin, Germany, participating and voting only for purposes of agenda point 8 et seqq.,
becoming the holder of three hundred eighty-one (381) new created series A5 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Berlin, Germany on 4 December 2014;
13. Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany
with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court
of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRA 45911 B, having its business address at Jä-
gerstrasse 65, 10117 Berlin, Germany, participating and voting only for purposes of agenda point 8 et seqq.,
becoming the holder of thirty-six (36) new created series A5 shares of the Company,
here represented by Ms Xiaoshu Tang, LL.M., professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg on Berlin, Germany on 4 December 2014;
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The parties 1, 2., 3., 4., 5., 6., 7. and 8. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Helpling Group Holding
S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.677
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 February 2014, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1074 dated 28 April 2014. The articles of association were amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 November 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the parties
9., 10., 11., 12., 13. (the “New Investors”) participate and vote for the purpose of agenda point 8 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Decision to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company, namely the series A5 shares,
so that the Company will hence have six (6) series of shares, being the common shares (hereinafter “Common Shares”),
the series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), the series
A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”), the series A4 shares (hereinafter the “Series A4 Shares”) and the series
A5 shares (hereinafter the “Series A5 Shares”).
2. Acceptance of TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., aforementioned, as new shareholder of the Company.
3. Acceptance of Mr. David W. Zalaznick, aforementioned, as new shareholder of the Company.
4. Acceptance of Luktev GmbH, aforementioned, as new shareholder of the Company.
5. Acceptance of Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, aforementioned, as new shareholder of the Company.
6. Acceptance of Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, aforementioned, as new shareholder of the Company.
7. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 1,668)
so as to raise it from its current amount of twenty-two thousand one hundred twenty-seven euro (EUR 22,127) up to
twenty-three thousand seven hundred ninety-five euro (EUR 23,795) by issuing one thousand six hundred sixty-eight
(1,668) Series A5 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
8. Restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase as per the seventh
resolution as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of
the Company by the New Investors.
9. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company,
namely the Series A5 Shares, so that the Company will hence have six (6) series of shares, being the Common Shares,
the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares, the Series A4 Shares and Series A5 Shares.
42694
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., aforementioned,
as new shareholder of the Company.
<i>Third resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept Mr. David W. Zalaznick, aforementioned, as new shareholder
of the Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept Luktev GmbH, aforementioned, as new shareholder of the
Company.
<i>Fifth resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, aforementioned,
as new shareholder of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The general meeting of shareholders decides to accept Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, aforementioned, as
new shareholder of the Company.
<i>Seventh resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one
thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 1,668) so as to raise it from its current amount of twenty-two thousand one
hundred twenty-seven euro (EUR 22,127) up to twenty-three thousand seven hundred ninety-five euro (EUR 23,795) by
issuing one thousand six hundred sixty-eight (1,668) Series A5 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
<i>Subscriptioni>
The one thousand six hundred sixty-eight (1,668) Series A5 Shares have been duly subscribed as follows:
- four hundred seventeen (417) Series A5 Shares have been duly subscribed by TJT (B) (Bermuda) Investment Company
Ltd., prenamed, here represented as aforementioned;
- four hundred seventeen (417) Series A5 Shares have been duly subscribed by Mr. David W. Zalaznick, prenamed,
here represented as aforementioned;
- four hundred seventeen (417) Series A5 Shares have been duly subscribed by Luktev GmbH, prenamed, here re-
presented as aforementioned;
- three hundred eighty-one (381) Series A5 Shares have been duly subscribed by Point Nine Capital Fund II GmbH &
Co. KG, prenamed, here represented as aforementioned;
- thirty-six (36) Series A5 Shares have been duly subscribed by Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, prenamed,
here represented as aforementioned.
<i>Paymenti>
The one thousand six hundred sixty-eight (1,668) Series A5 Shares have been entirely paid up as follows:
- the four hundred seventeen (417) Series A5 Shares subscribed by TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd.,
aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four hundred seventeen euro
(EUR 417);
- the four hundred seventeen (417) Series A5 Shares subscribed by Mr. David W. Zalaznick, aforementioned, have
been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of four hundred seventeen euro (EUR 417);
- the four hundred seventeen (417) Series A5 Shares subscribed by Luktev GmbH, aforementioned, have been entirely
paid up through a contribution in cash in an amount of four hundred seventeen euro (EUR 417);
- the three hundred eighty-one (381) Series A5 Shares subscribed by Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG,
aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of three hundred eighty-one
euro (EUR 381);
- the thirty-six (36) Series A5 Shares subscribed by Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, aforementioned, have
been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of thirty-six euro (EUR 36);
The amount of one thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 1,668) is as now available to the company as has been
proved to the undersigned notary.
The contribution in the amount of one thousand six hundred sixty-eight euro (EUR 1,668) is entirely allocated to the
share capital.
42695
L
U X E M B O U R G
<i>Eighth resolutioni>
The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association of
the Company in order to reflect the capital increase as per the seventh resolution as well as to reflect several amendments
to the articles of association following the entry into the capital of the Company by the New Investors.
The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Helpling Group
Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.
2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It
may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twenty three thousand seven hundred ninety-five Euros (EUR 23,795.00),
represented by
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”) each with a nominal
value of one EUR (EUR 1.00),
5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) each with a nominal
value of one EUR (EUR 1.00),
5.1.3 two thousand five hundred (2,500) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) each with a nominal value
of one EUR (EUR 1.00),
5.1.4 two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”) each with a nominal value of
one EUR (EUR 1.00),
42696
L
U X E M B O U R G
5.1.5 three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares (hereinafter “Series A4 Shares”, each with a
nominal value of one EUR (EUR 1,00) and
5.1.6 one thousand six hundred sixty-eight (1,668) series A5 shares (hereinafter “Series A5 Shares”), each with a
nominal value of one EUR (EUR 1,00) jointly with the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and
the Series A4 Shares the "Series A Shares"; the Series A Shares hereinafter also referred to as “Preferred Shares”).
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these
articles of association, any shareholders' agreement or by the Law.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Netris B.V. (“Eiffel”), JP Ventures UG (haftungsbes-
chränkt) (“ES”), Aismare Lux Holdings S.à r.l. (“Aismare”), Kaltroco Limited ("Kaltroco"), Phenomen Ventures LP
(“Phenomen”), Mangrove IV Investments S.à.r.l. (“Mangrove”), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. (“TJT”),
David W. Zalaznick (“DZ”), Luktev GmbH (“Luktev”), Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG (“Point Nine Capital”)
and/or Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG ("Point Nine Co-Invest" jointly with Point Nine Capital “Point Nine”;
Point Nine, jointly with Rocket, ES, Eiffel, Aismare, Kaltroco, Phenomen, Mangrove, TJT, DZ, and Luktev the “Investors”
and each also an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the course
of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company affiliated
to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) (a “Third Party
Investor”) which has been approved with an Advisory Board Majority (as defined in Article 25.5 below) (such investment
being a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more matching
shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase under
the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall inform the
Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to the foregoing
sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors (or a company
affiliated to an Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG)) subscribe for
further shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate
such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.
Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders, subject to the provisions of any shareholders' agreement
between the shareholders of the Company, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-
along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders of the Company.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by a majority vote of seventy five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (such majority being a
“Super Majority”) and subject to the provisions of any shareholders' agreement between the shareholders of the Com-
pany, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights contained
in any shareholders' agreement between the shareholders of the Company. To the extent that such approval has been
granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:
7.4.1 in any case of a Transfer (as defined in Article 8.1 below) or any other disposal of shares by any Investor to a
company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);
7.4.2 in case of a Transfer or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is directly or indirectly
Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect
shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or “Con-
trolling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting
42697
L
U X E M B O U R G
pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person,
whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more
shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;
7.4.3 in case of a Transfer or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified employee
participation agreed upon between the shareholders of the Company in a shareholders' agreement, if any or (ii) to the
Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme implemented pursuant to such simplified
employee participation;
7.4.4 in case of any Transfer or any other disposal of shares within the framework of transformation procedures
pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company, if the
shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such transformation
procedure.
7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights
of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.
7.6 Any Transfer or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through
the notification of the Transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the Transfer, assignment
or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any Transfer of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of
the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to
one another, or (ii) Transfer of at least 50% of the Company's Assets or business of the Company, in a single or more
related transactions or (iii) Transfer of a material part of the Company's Intellectual Property Rights in a single or more
related transactions or (iv) of the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal)
or (v) of any sale or Transfer of shares in the Company either to third parties or other shareholders that would result
in either more than fifty per cent (50%) of the registered share capital or more than fifty per cent (50%) of the voting
rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each
of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”)
- subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in
case of an asset Transfer, their shareholding in the registered share capital of the Company or (ii) in case of a share
Transfer, the number of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).
“Transfer” means, with respect to any asset (including without limitation, shares and Intellectual Property Rights), any
transfer, assignment, sale, pledge, hypothecation, Encumbrance or other disposition of that asset or of any rights or
obligations associated with that asset, whether voluntary or involuntary, including an option to do any of the forgoing.
“Encumbrance”/“Encumbered” means any encumbrance whatsoever, including a mortgage, charge, debenture, pledge,
hypothecation, lien, security interest, title retention, option, right to acquire or purchase, restriction upon sale or transfer,
right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, claims, trust arrangement, agreement to confer
security, other encumbrance or security interest of any kind or other type of preferential arrangement or any equity or
other restriction or limitation of any nature whatsoever (including, without limitation, a title transfer or retention ar-
rangement, any preliminary agreement or other arrangement to create any of the above) having similar effect.
8.2 On a preferred level (“Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount equal to its
respective total investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (consisting of the nominal amount
of the Series A Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115)
paid by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the
Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata to the amounts that would
have been allocated to that holder on the Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.
8.3 After the payments on the Preferred Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a
common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective shares disposed of in connection
with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the Preferred Level shall reduce the amount to
be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall be obliged to repay any
amount received on the Preferred Level. Any Exit Proceeds remaining unallocated after allocation under this Article 8.3
shall also be allocated in accordance with this Article 8.3 by applying Article 8.3 repeatedly until all Exit Proceeds have
been allocated to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one or more transactions,
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and repay any exceeding amount to the other shareholder)
an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds pro rata to the Shares sold or (ii) the amount
of its investment in the Company (payment of purchase price for shelf company, payment of share capital, including
premium, if any, and payments into account 115 of the standard chart of accountants “apport en capitaux propres non
rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (additional amounts)) in respect of the
42698
L
U X E M B O U R G
shares sold. If shares in the Company are sold in more than one transaction, no shareholder shall receive less proceeds
than it would have received if the shares in the Company were sold in one transaction.
8.4 The preferred allocation on the Preferred Level applies for the benefit of the respective shareholder so long as
the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet received the full amount that is to
be allocated to such shareholder according to the Preferred Level.
Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,
for as long as they are held by the Company.
9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings
is rejected for lack of assets;
9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and
such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.
Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall
automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.
9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one
person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.
9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the
declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).
Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective
date is the date before the redemption resolution.
10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding
amounts including interest.
10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is
to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The shareholder shall bear the remaining costs in case the compensation for redemption does not cover the costs
allocated to the shareholder for the expert opinion.
Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a
person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.
11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of
association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.
C. Decisions of the shareholders
Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these
articles of association.
12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
42699
L
U X E M B O U R G
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can
also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.
12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution
passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.
12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may
be specified in the respective convening notices of meeting.
13.2 The shareholders' meeting is called by registered letter (registered personal delivery, registered delivery or
registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.
13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening
requirements, the meeting may be held without prior notice.
13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-
holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.
13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made
concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.
Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.
Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.
Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous
consent.
Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval
of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority, provided that it includes the consent
of all of the Investors. Any amendment of these articles of association that materially or adversely affects the rights of
the holders of Series A Shares require the consent of all of the holders of those Series A Shares.
Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the
consent of the Advisory Board:
42700
L
U X E M B O U R G
17.1.1 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge within
the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));
17.1.2 conclusion or amendment of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal
of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a
participation in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does
not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a
prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of
business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.
17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of
all of the Investors:
17.2.1 material changes to the business object of the Company or any material modification of the fields of business
of the Company or the termination of existing and commencement of new fields of business;
17.2.2 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.3 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and
transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;
17.2.4 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with
respect to the liquidation of the Company;
17.2.5 merger, separation and transformation of the Company.
17.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations
attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.
D. Board of managers
Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
42701
L
U X E M B O U R G
21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).
22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures specified
below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:
22.8.1 approval of the annual plan including the budget plan for each following year;
22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros
(EUR 200,000.00) in the individual case;
22.8.3 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other
transactions with derivative financial instruments;
22.8.4 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.5 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial
importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;
22.8.6 institution and termination of legal disputes, including arbitration proceedings, involving a judicial amount in
controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;
22.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals;
22.8.8 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party outside the
ordinary course of business;
22.8.9 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such
profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;
22.8.10 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)
other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.
22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also
required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.
22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same
manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.
42702
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).
23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an advisory board (the “Advisory Board”). It consists of seven (7) voting members. The
shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of
the Advisory Board.
25.2 The shareholders' shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of unanimous
shareholders' consent.
25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-
pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:
25.3.1 four (4) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket (“Rocket Mem-
bers”) in its sole discretion;
25.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare (“Aismare Mem-
ber”) in its sole discretion;
25.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen (“Phenomen
Member”) in its sole discretion; and
25.3.4 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mangrove (“Mangrove
Member”) in its sole discretion.
25.4 Each Investor other than those entitled to appoint a voting member of the Advisory Board pursuant to Article
25.3 shall be entitled to appoint a non-voting member to the Advisory Board as an observer.
25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman yet none of them shall have a casting vote and/
or any additional right and/or authority differing from the other members of the Advisory Board. One of the Rocket
Members shall be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for
further provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. Subject to any consents or approvals
otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agreement with respect to the Company, if any, the
Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast, provided that it includes (i) the affirmative
vote of the Aismare Member, the Phenomen Member or the Mangrove Member (the „Advisory Board Majority“) or (ii)
for certain measures required under a shareholders' agreement, the affirmative vote of two (2) of the Aismare Member
and/or the Phenomen Member and/or the Mangrove Member or any further member of the Advisory Board nominated
after the date hereof (the “Qualified Advisory Board Majority”). The Advisory Board shall hold meetings on a regular
basis, at least once every calendar quarter.
25.6 In addition to any consents or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agree-
ment with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the
management of the Company.
25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.
E. Audit and Supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
42703
L
U X E M B O U R G
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they
hold in the Company.
Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable - in accordance with the provisions of Article 8 - and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of
association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any
shareholders' agreement with respect to the Company which may be entered into from time to time between the
shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter con-
tained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement with respect to the Company, such
shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.
31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English
and the German text, the English version shall prevail.”
<i>Costs and Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at approximately EUR 2,500.-).
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
42704
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünfzehnten Dezember.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
SIND ERSCHIENEN:
1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht
mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von zehntausend (10.000) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. No-
vember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter
deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3. Netris B.V., eine Gesellschaft (Besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Schiphol,
Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz
in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande,
Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 28. No-
vember 2014 und 4. Dezember 2014, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée) gegründet
und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),
Inhaber von tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 9. De-
zember 2014, ausgestellt in London, England;
5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter deutsch-
em Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Wehingen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Stuttgart, Deutschland, unter der Nummer HRB 733673, mit Geschäftssitz in Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen,
Deutschland,
Inhaber von zweiundvierzig (42) Anteilen der Serie A1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8. De-
zember 2014, ausgestellt in Chicago, USA;
6. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft gegründet in Jersey, eingetragen unter der Nummer 60595, mit Geschäftssitz in
Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,
Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Jersey;
7.Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Kaimaninseln, Eintragungsnummer OG -
66003, mit Sitz in 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Kaimaninseln,
Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8. De-
zember 2014, ausgestellt in Moskau, Russland;
8. Mangrove IV Investments S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée),
gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.521, mit Sitz in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg,
42705
L
U X E M B O U R G
Inhaber von dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A4 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8. De-
zember 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg;
9. TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., eine Gesellschaft nach dem Recht der Bermuda-Inseln mit satzungs-
mäßigem Sitz in Hamilton, Bermuda-Inseln, mit Geschäftssitz in Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, Bermuda-
Inseln HM11, ausschließlich für die Punkte 8 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der neu geschaffenen Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12. De-
zember 2014, ausgestellt in Bermuda;
10. David W. Zalaznick, geboren am 16. April 1954, ansässig in 9 West 57
th
Street, 33
rd
Floor, New York, Vereinigte
Staaten von Amerika, ausschließlich für die Punkte 8 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der neu geschaffenen Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Miami, USA;
11. Luktev GmbH, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in
Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer
HRB 119212 B, mit Geschäftssitz in Mohrenstrasse 60, 10117 Berlin, Deutschland, ausschließlich für die Punkte 8 ff. der
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der neu geschaffenen Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
12. Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmä-
ßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRA 45915 B, mit Geschäftssitz in Jägerstrasse 65, 10117 Berlin, Deutschland, ausschließlich für die Punkte
8 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von dreihunderteinundachtzig (381) Anteilen der neu geschaffenen Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
13. Point Nine Capital Co-Invest II GmbH & Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-
zungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister des Amtsgerichts Charlot-
tenburg, Deutschland unter der Nummer HRA 45911 B, mit Geschäftssitz in Jägerstrasse 65, 10117 Berlin, Deutschland,
ausschließlich für die Punkte 8 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,
zukünftiger Inhaber von sechsunddreißig (36) Anteilen der neu geschaffenen Serie A5 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Frau Xiaoshu Tang, LL.M., geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 4. De-
zember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland.
Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-
phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die Parteien 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Helpling Group
Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 184.677, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden
Notars, welche am 28. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1074 veröffentlicht
wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 28. November 2014 gemäß einer Urkunde des unter-
zeichnenden Notars, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten
verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei die Parteien 9., 10., 11., 12., 13. (die „Neuen Investoren“) ausschließlich für
die Punkte 8 ff. der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:
<i>Tagesordnungi>
1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) neuen Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und
zwar der Anteile der Serie A5, sodass die Gesellschaft nunmehr sechs (6) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen
(die „Stammanteile“), Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“), Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie
A2“), Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“), Anteilen der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) und Anteilen
der Serie A5 (die „Anteile der Serie A5“).
2. Aufnahme von TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Aufnahme von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
42706
L
U X E M B O U R G
4. Aufnahme von Luktev GmbH, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
5. Aufnahme von Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
6. Aufnahme von Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.
7. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zweiundzwanzigtausendein-
hundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 22.127) um einen Betrag von tausendsechshundertachtundsechzig Euro (EUR 1.668)
auf einen Betrag von dreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro (EUR 23.795) durch die Ausgabe von
tausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).
8. Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapitalerhöhung gemäß des siebten Beschlusses, sowie weitere
Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch die Neuen Investoren wiederzugeben.
9. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-
genden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) neue Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft
zu schaffen, und zwar die Anteile der Serie A5, sodass die Gesellschaft nunmehr sechs (6) Anteilsklassen hat, bestehend
aus Stammanteilen, Anteilen der Serie A1, Anteilen der Serie A2, Anteilen der Serie A3, Anteilen der Serie A4 und Anteilen
der Serie A5.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., vorbenannt, als neuen Ge-
sellschafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Ge-
sellschaft anzunehmen.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Luktev GmbH, vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft an-
zunehmen.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, vorbenannt, als neuen Ge-
sellschafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, vorbenannt, als neuen Gesell-
schafter der Gesellschaft anzunehmen.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von
zweiundzwanzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 22.127) um einen Betrag von tausendsechshundertach-
tundsechzig Euro (EUR 1.668) auf einen Betrag von dreiundzwanzigtausend siebenhundertfünfundneunzig Euro (EUR
23.795) durch die Ausgabe von tausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteilen der Serie A5 mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.
<i>Zeichnungi>
Die tausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von TJT (B) (Bermuda) Investment Company
Ltd., vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet;
- vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt,
hier vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet;
- vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Luktev GmbH, vorbenannt, hier ver-
treten wie vorerwähnt, gezeichnet;
- dreihunderteinundachtzig (381) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Point Nine Capital Fund II GmbH
& Co. KG, vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet;
- sechsunddreißig (36) Anteile der Serie A5 wurden ordnungsgemäß von Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG,
vorbenannt, hier vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet.
42707
L
U X E M B O U R G
<i>Zahlungi>
Die tausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteile der Serie A5 wurden vollständig wie folgt eingezahlt:
- die von TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd., vorbenannt, gezeichneten vierhundertsiebzehn (417) Anteile
der Serie A5 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417) eingezahlt;
- die von Herrn David W. Zalaznick, vorbenannt, gezeichneten vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A5 wurden
vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417) eingezahlt;
- die von Luktev GmbH, vorbenannt, gezeichneten vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A5 wurden vollständig
durch eine Bareinlage in Höhe von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417) eingezahlt;
- die von Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG, vorbenannt, gezeichneten dreihunderteinundachtzig (381) Anteile
der Serie A5 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von dreihunderteinundachtzig Euro (EUR 381) eingezahlt;
- die von Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG, vorbenannt, gezeichneten sechsunddreißig (36) Anteile der Serie
A5 wurden vollständig durch eine Bareinlage in Höhe von sechsunddreißig Euro (EUR 36) eingezahlt.
Die Summe von tausendsechshundertachtundsechzig Euro (EUR 1.668) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung
so wie dies dem amtierenden Notar erbracht wurde.
Die Einlage in Höhe von tausendsechshundertachtundsechzig Euro (EUR 1.668) wird vollständig dem Gesellschafts-
kapital zugeführt.
<i>Achter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapital-
erhöhung gemäß des siebten Beschlusses, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch die Neuen
Investoren wiederzugeben.
Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:
„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen
Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die
Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.
2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
42708
L
U X E M B O U R G
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreiundzwanzigtausendsiebenhundertfünfundneunzig Euro (EUR
23.795,00), bestehend aus
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1),
5.1.2 tausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1),
5.1.3 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1),
5.1.4 zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) mit einem Nominalwert
von je einem Euro (EUR 1),
5.1.5 dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“) mit einem No-
minalwert von je einem Euro (EUR 1),
5.1.6 tausendsechshundertachtundsechzig (1.668) Anteile der Serie A5 (die „Anteile der Serie A5“) mit einem Nomi-
nalwert von je einem Euro (EUR 1), gemeinsam mit den Anteilen der Serie A1, den Anteilen der Serie A2, den Anteilen
der Serie A3 und den Anteilen der Serie A4 die „Anteile der Serie A“; die Anteile der Serie A im Folgenden auch die
„Vorzugsanteile“).
Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung, in einer
Gesellschaftervereinbarung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Netris B.V. („Eiffel“), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt)
(„ES“), Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), Kaltroco Limited („Kaltroco“), Phenomen Ventures LP („Phenomen“),
und/oder Mangrove Investments S.à r.l. („Mangrove“), TJT (B) (Bermuda) Investment Company Ltd. („TJT“), David W.
Zalaznick („DZ“), Luktev GmbH („Luktev“), Point Nine Capital Fund II GmbH & Co. KG („Point Nine Capital“) und /
oder Point Nine Co-Invest II GmbH & Co. KG („Point Nine Co-Invest“, gemeinschaftlich mit Point Nine Capital „Point
Nine“; Point Nine, gemeinschaftlich mit Rocket, ES, Eiffel, Aismare, Kaltroco, Phenomen, Mangrove, TJT, DZ, und Luktev
die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung ausgege-
bener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder um einen
Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5 definiert)
zugestimmt wurde (wobei eine solche Investition als „Investition eines Dritten“ bezeichnet wird) - unabhängig davon, ob
diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur Erhaltung
der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben
Bedingungen, wie bei einer Investition eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche
Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes
dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren (oder eine mit einem
Investor im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) verbundene Gesellschaft) weitere Anteile zeichnet,
entsprechend anwendbar.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-
venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen
und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.
42709
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaf-
tervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vor-
kaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechtenoder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft übertragen werden.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Mehrheit von fünf-
undsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft (wobei eine solche Mehrheit als „Qualifizierte
Mehrheit“ bezeichnet wird) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder
Mitverkaufsrechtenoder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft über-
tragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen
nicht erforderlich:
7.4.1 bei einer Übertragung (wie in Artikel 8.1 definiert) oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an
eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);
7.4.2 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche
direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreff-
enden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der
gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“
die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäfts-
führender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte
durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Ge-
schäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder
anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses
Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;
7.4.3 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung (i) an einen Dritten, welcher Anteile unter einer,
sofern von den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung beschlossen, vereinfachten Mitar-
beiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im
Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung, die gemäß einer solchen vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung eingeführt
wurde;
7.4.4 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung im Rahmen von Umwandlungsvorgängen gemäß des
Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung der Gesellschaft, so-
fern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer
überlebenden juristischen Person halten.
7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch
Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.
7.6 Eine Übertragung oder jegliche andere Veräußerung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel
1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in
Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.
7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,
wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.
Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines
Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) einer Übertragung von mindestens 50% des
Vermögens oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen oder (iii) einer
Übertragung eines wesentlichen Teils der Rechte des geistigen Eigentums der Gesellschaft in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft (insbesondere nach
einem Asset Deal) oder (v) eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte
oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen
42710
L
U X E M B O U R G
Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien
wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii)
und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) -
vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am
eingetragenen Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Falle einer Vermögensübertragung, oder (ii) entsprechend der
Anzahl der im Liquiditätsereignis verkauften Anteile (soweit anwendbar) im Falle einer Anteilsübertragung an die Gesell-
schafter verteilt.
„Übertragung“ meint, im Hinblick auf Vermögenswerte (einschließlich, ohne Beschränkung, Anteile und Rechte des
geistigen Eigentums), eine Übertragung, eine Abtretung, einen Verkauf, eine Verpfändung (pledge), eine Beleihung (hy-
pothecation), eine Belastung oder andere Veräußerung dieses Vermögenswertes oder damit verbundener Rechte und
Pflichten, ob absichtlich oder unabsichtlich, einschließlich einer Option hinsichtlich jeder der vorgenannten Handlungen.
„Belastung“/“Belastet“ meint Belastungen jedweder Art, einschließlich Hypotheken, Belastungen (charge), Obligatio-
nen, Verpfändungen, Beleihungen, Pfandrechte, Sicherungsrechte, Eigentumsvorbehalte, Optionsrechte, Erwerbs- oder
Bezugsrechte, Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Rechte oder Interessen eines
Dritten, Forderungen, Trust-Arrangements, Verträge bezüglich der Übertragung von Wertpapieren, anderer Belastungen
oder anderer Sicherungsrechte jeder Art oder anderer Vorzugsvereinbarungen oder Eigenkapital oder anderer Ein-
schränkungen oder Beschränkungen jedweder Art (einschließlich, ohne Beschränkung, Übertragungsabkommen von
Titeln oder Vorbehaltsvereinbarungen, Vorverträge oder andere Vereinbarungen bezüglich einer der vorgenannten
Handlungen) mit ähnlicher Wirkung;
8.2 Auf einer Vorzugsebene („Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher
dem Betrag seiner jeweiligen Gesamtinvestition entspricht, die er getätigt hat, um seine jeweiligen von ihm gehaltenen
Anteile der Serie A zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der
Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans),
die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen
auf der Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie A auf einer pro- rata
Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend
Exiterlöse vorhanden gewesen wären.
8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Vorzugsebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer gemein-
samen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend den
jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden, verteilt. Sämtliche von einem
Gesellschafter auf der Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag
auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Vorzugsebene
erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Exiterlöse, welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels 8.3 nicht zugeteilt wur-
den, werden auch im Einklang mit diesem Artikel 8.3 durch die wiederholte Anwendung des Artikels 8.3 verteilt, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in einer oder mehreren
Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und
übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit
der Exiterlöse auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner Investition in die Ge-
sellschaft (Zahlung des Kaufpreises für eine eventuelle Vorratsgesellschaft, Einzahlung des Gesellschaftskapitals, ein-
schließlich ggf. des Agios, und Einzahlungen auf Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans „apport
en capitaux propres non rémunérés par des titres“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (zusätzliche Be-
träge)) in Bezug auf die verkauften Anteile. Werden Anteile der Gesellschaft in mehr als einer Transaktion verkauft, so
hat kein Gesellschafter weniger Erlöse zu erhalten, als er erhalten hätte, wenn die Anteile der Gesellschaft in einer
Transaktion verkauft worden wären.
8.4 Die bevorzugte Zuteilung auf der Vorzugsebene gilt zugunsten des entsprechenden Investors solange, wie dieser
(einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen Betrag, der an diesen Gesellschafter gemäß
der Vorzugsebene zu verteilen ist, noch nicht erhalten hat.
Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen
Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.
9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:
9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;
9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil
eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.
Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile
automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.
42711
L
U X E M B O U R G
9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine
Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.
9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald
der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).
Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile
entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.
10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge
zuzüglich Zinsen zu verlangen.
10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-
gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern die Ausgleichszahlung für den Rückkauf
die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.
Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine
von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.
11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-
gleichszahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die
Gesellschaft als Garant haftet.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
ausdrücklich vorbehalten sind.
12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame
Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.
12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine
andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.
12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift
anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.
12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
42712
L
U X E M B O U R G
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche
in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.
13.2 Die Gesellschafterversammlung wird mittels Einschreiben (Zustellung zu eigenen Händen, Einschreiben oder
Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung, wobei bei ordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens vier (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.
13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-
formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.
13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei der Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine
schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.
13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.
Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-
schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen, die die Zustimmung aller Investoren
vorausgesetzt. Änderungen dieser Satzung, durch welche die Rechte der Inhaber der Anteile der Serie A erheblich oder
nachteilig beeinflusst werden, bedürfen der Zustimmung aller Inhaber dieser Anteile der Serie A.
Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und
zudem die Zustimmung des Beirats:
17.1.1 abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Akti-
engesetzes (AktG));
17.1.2 a bschluss oder Änderung von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Ver-
äußerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere
Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der
Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich
Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wur-
den, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und
Werbepartnern.
17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und zudem die Zu-
stimmung aller Investoren:
17.2.1 wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft oder jegliche wesentliche Modifikation der Ge-
schäftsfelder der Gesellschaft oder die Aufgabe bestehender und die Aufnahme neuer Geschäftsfelder;
17.2.2 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.3 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen
gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;
42713
L
U X E M B O U R G
17.2.4 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-
gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;
17.2.5 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3 Ist das Gesellschaftskapital in verschiedene Anteilsklassen unterteilt, so können die spezifischen Rechte und
Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.
D. Rat der Geschäftsführer
Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
ihre Amtszeit festlegt.
19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderem
Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.
20.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
21.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.
Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen
Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
42714
L
U X E M B O U R G
22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der
Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.
22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.
22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-
nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:
22.8.1 Genehmigung des Jahresplans, einschließlich des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von zweihundert-
tausend Euro (EUR 200.000,00) übersteigen;
22.8.3 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-
aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;
22.8.4 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-
cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;
22.8.6 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-
wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;
22.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen;
22.8.8 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder dokumentiertem Wissen durch die Gesellschaft an einen
Dritten, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegt;
22.8.9 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-
cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;
22.8.10 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung
jeglicher Aktienoptionen) mit Ausnahme der Schaffung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.
22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-
lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.
22.10 Die Gesellschafter können durcheinenGesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer
beschließen.
22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,
auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.
Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-
schäftsführers.
23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Ge-
42715
L
U X E M B O U R G
schäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).
23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen (i) durch die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft nur durch die gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.
Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet (der „Beirat“). Dieser besteht aus sieben (7) stimmberechtigten Mit-
gliedern. Die Gesellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen.
25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-
schafter festlegen und/oder verändern.
25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden
Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:
25.3.1 vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen
ernannt (die „Rocket-Mitglieder“);
25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen
ernannt (das „Aismare-Mitglied“);
25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen nach eigenem Ermessen
ernannt (das „Phenomen-Mitglied“); und 25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter
Mangrove nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mangrove-Mitglied“).
25.4 Jeder Investor, der nicht zur Ernennung eines stimmberechtigten Mitglieds des Beirats gemäß Artikel 25.3 be-
rechtigt ist, darf ein nichtstimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Beobachter ernennen.
25.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, wobei keiner von beiden eine
entscheidende Stimme und/oder zusätzliche Rechte und/oder Befugnisse hat, die sich von denen der anderen Mitglieder
des Beirats unterscheiden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats
hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Vorbehaltlich an-
derer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesellschaftervereinbarungen
bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, fasst der Beirat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, sofern (i) die Ja-Stimme des Aismare-Mitglieds, des Phenomen-Mitglieds oder des Mangrove-Mitglieds in dieser
Mehrheit (die „Mehrheit des Beirats“) eingeschlossen ist oder (ii) für bestimmte Maßnahmen, die sich aus einer Gesell-
schaftervereinbarung ergeben, zwei (2) Ja-Stimmen von dem Aismare-Mitglied und/oder dem Phenomen-Miglied und/oder
dem Mangrove-Mitglied oder jedem anderen Mitglied des Beirats, das ab dem Datum dieser Satzung ernannt wird, ein-
geschlossen sind (die „Qualifizierte Mehrheit des Beirats“). Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal
pro Kalenderquartal.
25.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-
schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.
25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
26.2 Ein Rechnungsprüferkann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
42716
L
U X E M B O U R G
26.3 Die Rechnungsprüferhaben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durcheinen Gesellschafter erbrachteEinlageninRücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls
der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-
mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-
stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen
an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls - im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 -
verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebe-
nenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch
vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser
Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-
gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-
dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Sat-
zung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft in Widerspruch stehen, so ist
die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.
31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen
zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“
<i>Kosten und Auslageni>
Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf
ungefähr EUR 2.500,-geschätzt.
42717
L
U X E M B O U R G
Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.
Die vorstehende Urkunde ist dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welcher dem Notar mit Namen,
Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.
Gezeichnet: X. TANG und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63010. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 13. Februar 2015.
Référence de publication: 2015032449/1431.
(150036136) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Alize Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 120.688,61.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.378.
<i>Extrait des résolutions écrites prises par les associés de la Société en date du 24 février 2015i>
En date du 24 février 2015, les associés de la Société ont pris les résolutions suivantes:
- de confirmer que la nomination du 1
er
décembre 2014 de Monsieur Damien SCHLUIND en tant que gérant B de
la Société est erronée et doit être considérée comme nulle;
- de nommer Monsieur Joost MEES, né le 27 septembre 1978 à Delft, Pays-Bas, résidant professionnellement à l'adresse
suivante: 8, rue de l'Industrie, L-7231 Helmsange, en tant que nouveau gérant B de la Société avec effet immédiat et ce
pour une durée déterminée de 5 ans.
En conséquence, le conseil de gérance de la Société est désormais composé comme suit:
- Monsieur Jean-Jacques LAFONT, gérant A
- Monsieur Raphaël de BOTTON, gérant A
- Monsieur Tony WHITEMAN, gérant B
- Monsieur John SUTHERLAND, gérant B
- Monsieur Joost MEES, gérant B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 février 2015.
Alize LuxCo 1 S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015032915/25.
(150037329) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Actavis Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 191.705.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 24 février 2015.
Référence de publication: 2015032913/10.
(150036696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42718
L
U X E M B O U R G
Auburn Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 129.194.
L’an deux mille quinze, le vingt-trois janvier,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de la société
AUBURN PROPERTIES S.à r.l.
une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2007,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 7 août 2007, numéro 1662, page 79.771.
A comparu à cet effet:
Dalor Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit de luxembourgeois, ayant son siège social à L-1610
Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 107.842
ici représentée par Madame Priscillia Clechet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1610 Luxem-
bourg, 4-6, avenue de la Gare, agissant en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associée unique de la dite société, et en sa qualité d’associée unique, la dite partie
comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’associée unique décide de changer le régime de signature sous lequel la société sera valablement engagée. Ainsi,
l’associée unique décide que dorénavant la société sera valablement engagée, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.
<i>Deuxième résolution:i>
En exécution de ce qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 12 alinéa 4 des statuts pour lui conférer
dorénavant la teneur suivante:
dans la version anglaise des statuts:
“ Art. 12. fourth paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of
plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.
The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole
signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.”
dans la version française des statuts:
« Art. 12. quatrième alinéa. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut
élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il
agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signés: P. CLECHET, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 février 2015. Relation: EAC/2015/2676. Soixante-quinze euros 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015032933/51.
(150037315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
42719
L
U X E M B O U R G
Mica Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 180.651.
L’an deux mille quinze, le vingt-trois janvier,
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de la société
MICA PROPERTIES S.à r.l.
une société à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare,
constituée suivant acte reçu par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, en date du 26 septembre 2013,
publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, en date du 14 novembre 2013, numéro 2860,
page 137.245.
A comparu à cet effet:
Bianchi Properties S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit de luxembourgeois, ayant son siège social à
L-1610 Luxembourg, 4-6, Avenue de la Gare, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 180.642
ici représentée par Madame Priscillia Clechet, employée privée, ayant son adresse professionnelle à L-1610 Luxem-
bourg, 4-6, avenue de la Gare, agissant en vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Laquelle partie comparante est l’associée unique de la dite société, et en sa qualité d’associée unique, la dite partie
comparante a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’associée unique décide de changer le régime de signature sous lequel la société sera valablement engagée. Ainsi,
l’associée unique décide que dorénavant la société sera valablement engagée, en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du Conseil de Gérance.
<i>Deuxième résolution:i>
En exécution de ce qui précède, l’associée unique décide de modifier l’article 12 alinéa 4 des statuts pour lui conférer
dorénavant la teneur suivante:
dans la version anglaise des statuts:
“ Art. 12. fourth paragraph. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of
plurality of managers, by the joint signature of two members of the board of managers.
The board of managers may elect among its members a general manager who may bind the Company by his sole
signature, provided he acts within the limits of the powers of the board of managers.”
dans la version française des statuts:
« Art. 12. quatrième alinéa. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas
de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux membres du Conseil de gérance. Le Conseil de gérance peut
élire parmi ses membres un gérant-délégué qui aura le pouvoir d’engager la Société par la seule signature, pourvu qu’il
agisse dans le cadre des compétences du Conseil de gérance.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signés: P. CLECHET, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 3 février 2015. Relation: EAC/2015/2668. Soixante-quinze euros 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME.
PETANGE, le 25 février 2015.
Référence de publication: 2015033223/52.
(150037287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
42720
Actavis Luxembourg International S.à r.l.
Alize Luxco 1 S.à r.l.
Auburn Properties S.à r.l.
AXL International
AXL Investments S.A.
B.R.C. Constructions S.à r.l.
Centrum Development S.A.
Conforama Luxembourg
Dalba Partners S.A.
Energy Standard Group S.A., société de gestion de patrimoine familial
Eresa S.à r.l.
Farm Immo S.A.
Felten Frères et Fils S.àr.l.
Five Lions e-Solutions S.à r.l.
Fondation Francois-Elisabeth
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fratelli S.A.
Freko Echafaudages S.à r.l.
Futuradent G.m.b.H.
Futuradent G.m.b.H.
Future Media International S.à r.l.
Gland Mortgage III S.à r.l.
Green Valley Services S.A.
Helpling Group Holding S.à r.l.
Hôpitaux Robert Schuman
Humaniste Conseil S.A.
Humaniste Conseil S.A.
I.B.E. S.à.r.l.
Icon 1 S.A.
Icon 2 S.à r.l.
Icon Luxembourg S.à r.l.
Industrielle de Réassurance S.A.
Innova Financial Holding S.à r.l.
International Corporate Activities S.A.
Inversiones Eneida S.à r.l., SPF
Investment Interest S.A.
Jambo S.A.
Jawhar Resort Holding S. à r.l.
Join Expérience S.A.
Jordan S.A.
KARBLUMM Alimentation Naturelle et Biologique
Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l.
L.M.B.E. Europe S.A.
Mica Properties S.à r.l.
Nord Point SCSp