logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 874

31 mars 2015

SOMMAIRE

Abelton Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41945

ACTIVE 21 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41946

Advanced Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41946

Advanced Research S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41949

AI Silver S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41915

Alceco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

41952

Almapa Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

AutoZone Luxembourg Investments S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41946

Azurestia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41946

BBH Luxembourg Funds . . . . . . . . . . . . . . . .

41948

Bioclina Belux Systèmes de Chauffage et

de Rafraîchissement Intégré S.à r.l.  . . . . .

41950

Blue Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41945

BMV Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41950

Boldam S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41949

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

41949

CEREP II Investment Fifteen S.à r.l.  . . . . .

41948

CEREP II Investment Ten S.à r.l.  . . . . . . . .

41948

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41948

CEREP Italy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41947

Cie Européenne Financière OMEGA de

Participation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41948

Confer Partnership, S.e.c.s.  . . . . . . . . . . . . .

41947

Day Dream SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41942

DG-Immo-Invest GmbH  . . . . . . . . . . . . . . . .

41947

DKHB Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

41947

Domexus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41947

EDEN LogCenter INTERNATIONAL Al-

pha S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41942

Electricité Nico May S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

41914

Europa Mallard S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41937

Europa Presov Park S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

41939

Farenzena Jules Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Farenzena Jules Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Finite Management Sarl  . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Foca Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41943

GECGE Kosik Investors S.à r.l.  . . . . . . . . . .

41943

GFRI 2010 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41943

Golden Eagle Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

41931

IK Investment Partners VII A S.à r.l.  . . . . .

41934

Kalchesbruck S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41943

Karolux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41945

Knaf-Buchler succ. Hans Adam Oeltges,

s.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41944

Knätsch S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

Komaco International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

41909

L&C LuxHoldCo Poland S.à r.l. . . . . . . . . . .

41909

L.E.S.S. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41909

London Acquisition Luxco S.à r.l.  . . . . . . . .

41944

Magnetar Solar Luxembourg S.à r.l.  . . . . .

41915

MD Mezzanine Treasury Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

Minerva Automobiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Mokastar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

Muno Charles et Fils S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . .

41909

Nadin-Lux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41911

Naturmaart S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41910

NaviTrans Schifffahrt S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

41909

Nextech IV GP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41952

Nile Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

41951

Noukbrit Holding S.A. SPF . . . . . . . . . . . . . .

41911

OCM Luxembourg EPF III London Proper-

ty Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

OCM Luxembourg EPF III Procurement

Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41908

OCM Luxembourg EPF III RCF S.à r.l.  . . .

41910

OCM Luxembourg EPF III Unicity Hol-

dings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41910

OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l.  . . . . . .

41911

OCM Luxembourg Flandre S.à r.l.  . . . . . . .

41911

Ocm Luxembourg George Street Apart-

Hotel S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41910

41905

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg HHL Holdco IV S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41911

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41951

OCM Luxembourg OPPS VIII Blocker S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41942

OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l.  . . .

41942

OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l.  . . . . . .

41951

OCM Luxembourg POF IV AIF (Delaware)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

OCM Luxembourg Seraphina S.à r.l. . . . . .

41945

OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

Oelschläger Properties International Inc.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41913

O-Two S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41910

Paneuropean Oil and Industrial Holdings

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41912

Participation Hispanolux GmbH . . . . . . . . .

41941

PETOSEVIC Group  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41942

Portman Group International S.à r.l. . . . . .

41950

Portofino Trust Inc.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41915

Private Debt Treasury II Management S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

Prointent S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41915

RCV Lease S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41916

Redalpine Capital II GP S.à r.l.  . . . . . . . . . .

41952

Redalpine Venture Partners S.à r.l.  . . . . . .

41941

Rege Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41949

Renex Management Company S.à r.l.  . . . .

41951

Safari Luxco 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41944

S&B Minerals Finance S.C.A.  . . . . . . . . . . . .

41950

Shinkin Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

41944

Slova S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41946

Speed World Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

41941

Stora Enso S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41927

Stora Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .

41927

Unicity II Acton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

Unicity III Bournemouth S.à r.l.  . . . . . . . . .

41907

Unicity IV BB S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41907

WP International IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

41913

WP International V S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

41913

41906

L

U X E M B O U R G

Unicity II Acton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 156.119.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unicity II Acton Sàrl

Référence de publication: 2015028857/12.
(150032997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

Unicity III Bournemouth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 157.609.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unicity III Bournemouth Sàrl

Référence de publication: 2015028858/12.
(150032998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

Unicity IV BB S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 159.623.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unicity IV BB Sàrl

Référence de publication: 2015028859/12.
(150033172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 février 2015.

Private Debt Treasury II Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 184.792.

Les statuts coordonnés au 11 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015030684/9.
(150034198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Knätsch S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4141 Esch-sur-Alzette, 59, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 177.986.

Les comptes annuels du 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031210/9.
(150034847) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41907

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg EPF III London Property Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 177.726.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Sava Savov avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPF III London Property Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015030647/12.
(150033767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

OCM Luxembourg EPF III Procurement Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.821.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Thomas Jaggers avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPF III Procurement Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015030648/12.
(150033448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 178.417.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015030649/12.
(150033449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

MD Mezzanine Treasury Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 184.823.

Les statuts coordonnés au 11 février 2015 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031269/9.
(150034273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Mokastar S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1616 Luxembourg, 9A, Place de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 67.692.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031281/9.
(150034283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41908

L

U X E M B O U R G

L.E.S.S. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 40.102.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenu en date du 18 février 2015 que la société LuxGlobal Trust

Services S.A., 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, Professionnel du Secteur Financier, est nommé dépositaire
des actions au porteur de la société avec date effective au 18 février 2015 conformément à l'article 42 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Référence de publication: 2015031216/12.
(150034315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

L&amp;C LuxHoldCo Poland S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 175.412.

Veuillez noter que:
- l'orthographe du nom de Monsieur Wim Rits a changé et est désormais Wim Ritz;
- l'adresse professionnelle de Monsieur Massey a changé et est désormais: LCP House, The Pensnett Estate, Kings-

winford, DY6 7NA, Royaume-Uni.

Référence de publication: 2015031218/12.
(150034671) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Komaco International S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 56.715.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenu en date du 16 février 2015 que la société LuxGlobal Trust

Services S.A., 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, Professionnel du Secteur Financier, est nommé dépositaire
des actions au porteur de la société avec date effective au 16 février 2015 conformément à l'article 42 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Référence de publication: 2015031201/12.
(150034300) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

NaviTrans Schifffahrt S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6617 Wasserbillig, 15A, route d'Echternach.

R.C.S. Luxembourg B 183.231.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031298/9.
(150034539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Muno Charles et Fils S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, Zone commerciale et artisanale.

R.C.S. Luxembourg B 68.345.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031294/9.
(150034598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41909

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.301.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015030652/12.
(150033450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Ocm Luxembourg George Street Apart-Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 188.471.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg George Street Apart-Hotel Sàrl

Référence de publication: 2015030654/12.
(150033826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

OCM Luxembourg EPF III RCF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 175.119.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 17 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPF III RCF Sàrl

Référence de publication: 2015030650/12.
(150033359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

O-Two S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 77.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031320/9.
(150034630) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Naturmaart S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7240 Bereldange, 23, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 50.843.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031314/9.
(150034544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41910

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 135.993.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg EPOF A Sàrl

Référence de publication: 2015031326/12.
(150034237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg Flandre S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 170.150.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Franck Laval avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Flandre Sàrl

Référence de publication: 2015031329/12.
(150034063) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg HHL Holdco IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 177.807.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg HHL Holdco IV Sàrl

Référence de publication: 2015031330/12.
(150034727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Nadin-Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8224 Mamer, 2, rue de Rome.

R.C.S. Luxembourg B 45.776.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031309/9.
(150034108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Noukbrit Holding S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.561.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031307/9.
(150034572) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41911

L

U X E M B O U R G

Farenzena Jules Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 73.366.

<i>Rectificatif L140229334 déposé le 23.12.2014

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015030412/12.
(150034011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Farenzena Jules Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3531 Dudelange, 81, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 73.366.

<i>Rectificatif L130094512 déposé le 12.06.2013

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Comptable B + C S.à.r.l.
Luxembourg

Référence de publication: 2015030413/12.
(150034012) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Finite Management Sarl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 178.311.

<i>Extrait des résolutions de l'Associé Unique de la Société prises en date du 24 septembre 2014

Il résulte des décisions écrites de l'Associé Unique de la Société les décisions suivantes:
- d'accepter la démission de Andrew Peat, en qualité de Gérant de la Société et ce avec effet au 24 septembre 2014
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 septembre 2014.

Référence de publication: 2015030408/12.
(150033620) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Minerva Automobiles, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8562 Schweich, 24, Bockwee.

R.C.S. Luxembourg B 161.276.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031278/9.
(150034785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 33.149.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031356/9.
(150034280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41912

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 149.223.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Yachts Holdings Sàrl

Référence de publication: 2015031338/12.
(150034612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg POF IV AIF (Delaware) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 133.367.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg POF IV AIF (Delaware) Sàrl

Référence de publication: 2015031336/12.
(150034236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Oelschläger Properties International Inc., Société Anonyme.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 61.159.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenu en date du 17 février 2015 que la société LuxGlobal Trust

Services S.A., 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, Professionnel du Secteur Financier, est nommé dépositaire
des actions au porteur de la société avec date effective au 17 février 2015 conformément à l'article 42 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Référence de publication: 2015031341/12.
(150034348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

WP International IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 147.809.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031516/9.
(150034859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

WP International V S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 149.030.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031517/9.
(150034858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41913

L

U X E M B O U R G

Electricité Nico May S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-1731 Luxembourg, 4, rue de Hesperange.

R.C.S. Luxembourg B 85.259.

L'an deux mille quinze, le douze février.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Ammar BOUTARENE, électricien, né le 9 janvier 1976 à Algrange, France, demeurant à L-1731 Luxembourg,

4, rue de Hesperange.

Lequel comparant a déclaré être l’associé unique de la société à responsabilité limitée "ELECTRICITE NICO MAY S.à

r.l.", ayant son siège social à L-7381 Bofferdange, 134, Cité Roger Schmitz, constituée suivant acte notarié de Maître Jean-
Paul HENCKS, notaire alors de résidence à Luxembourg, en date du 18 décembre 2001, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 592 du 16 avril 2002. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 juin 2010, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1720 du 24 août 2010.

Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (12.400.-EUR), représenté par cent (100) parts sociales d’une

valeur nominale de cent vingt-quatre euros (124.- EUR) chacune, entièrement libérées.

L’associé unique décide de prendre les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide de transférer avec effet rétroactif au 1 

er

 novembre 2014, le siège social de la société de L-7381

Bofferdange, 134, Cité Roger Schmitz à L-1731 Luxembourg, 4, rue de Hesperange et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts de la société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 4. Le siège social de la société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger par décision

du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du gérant unique, ou le cas échéant, par le conseil

de gérance. Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une
résolution des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.»

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent l’article 2 des statuts afin de lui donner

la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’une entreprise d’installation électriques et d’un atelier d’électricien,

ainsi que l’installation de câblage électronique de toute nature. Elle a encore pour objet l’achat et la vente de luminaires,
de matériels et d’appareils électriques et électroniques.

La société a également pour objet l’agencement d’intérieurs au sens le plus large ainsi que la rénovation en général.
La Société a ainsi pour objet d’investir dans des participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, dans toutes Sociétés

ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces
participations. La Société pourra en particulier acquérir par souscription, achat, et échange ou de toute autre manière
tous titres, actions et/ou autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et/ou autres instru-
ments de dette, et, en général toutes valeurs ou instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle
pourra participer à la création, le développement, la gestion et le contrôle de toutes Sociétés ou entreprises. Elle pourra
en outre effectuer directement ou indirectement des investissements immobiliers ou dans des droits immobiliers ainsi
que des investissements dans tout autre type de bien et investir dans l’acquisition et gérer un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit et pourra exercer toute activité relative
à l’administration, la gestion et le développement de ces biens immobiliers, ces brevets ou ces droits de propriété intel-
lectuelle.

Elle peut accomplir toutes opérations et passer toutes transactions généralement quelconques, commerciales, indus-

trielles, financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social de la
société ou qui sont de nature à en faciliter l’extension ou le développement.»

<i>Avertissement

Le notaire instrumentaire a rendu attentif le comparant au fait qu’avant toute activité commerciale de la Société dont

l’objet a été présentement changé, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due
forme en relation avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par le comparant.

41914

L

U X E M B O U R G

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été fermée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: A. Boutarene et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 13 février 2015. Relation: 2LAC/2015/3348. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015030385/68.
(150033814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Portofino Trust Inc., Société Anonyme.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 31, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 88.506.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031371/10.
(150034361) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Prointent S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6871 Wecker, 2, Op Huefdréisch.

R.C.S. Luxembourg B 87.719.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031374/10.
(150034396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Magnetar Solar Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 187.327.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031254/10.
(150034397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

AI Silver S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 104.776.

Je soussignée, Hélène Mercier, suis au regret de vous informer que, je ne serai plus en mesure d'assumer les fonctions

d'administrateur de votre société à compter de ce jour et vous présente donc ma démission.

Luxembourg, le 18 février 2015.

Hélène MERCIER.

Référence de publication: 2015031537/10.
(150035236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41915

L

U X E M B O U R G

RCV Lease S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 195.611.

STATUTES

In the year two thousand fifteen, on the thirteenth of March.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary, residing in Rambruch (Grand Duchy of Luxembourg).

THERE APPEARED:

RCV Lease Stichting, a foundation organised under the laws of The Netherlands with its official seat in Amsterdam,

and its address at Strawinskylaan 411, 1077XX Amsterdam;

represented by Claude CRAUSER, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Amsterdam; such proxy,

signed by the proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of
registration.

The following articles of incorporation of a company have then been drawn-up:

Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name. There is hereby established a société à responsabilité limitée (the "Company") governed by the

laws of the Grand Duchy of Luxembourg (the “Laws”) and by the present articles of incorporation (the "Articles of
Incorporation").

The Company may be composed of one single shareholder, owner of all the shares, or several shareholders, but not

exceeding forty (40) shareholders.

The Company will exist under the name of “RCV Lease S.à r.l.”.

Art. 2. Registered Office. The Company will have its registered office in Luxembourg-City.
The registered office may be transferred to any other place within Luxembourg-City by a resolution of the Manager

(s).

Branches or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the Manager(s).

Art. 3. Object. The object of the Company is the financing, leasing and remarketing of a Boeing, model 747-400F

aircraft, MSN 30400 (the "Airframe") together with four (4) Rolls-Royce model RB211-524 H2-T aircraft engines bearing
serial number 13745, 13758, 13803 and 13189 (the “Engines”; the Engines and the Airframe collectively the “Aircraft”)
and to undertake or procure to undertake any such other actions, matters or things as may be necessary to achieve, or
which are incidental or conductive to, any of the above purposes.

In order to accomplish its purpose, the Company may acquire, lease and sell the Aircraft and finance such acquisition

through loans or other financial arrangements, in whatever form, and issue guarantees and grant any form of security
interest or other liens over its assets, including mortgages and pledges, to secure the financing obligations entered into
by the Company or by Cargolux Airlines International S.A. with respect to the acquisition, financing or leasing of the
Aircraft.

The Company may further issue guarantees, and grant any form of security interest or other liens over its assets,

including mortgages and pledges, to secure any indebtedness.

Art. 4. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
It may be dissolved at any time by a resolution of the shareholder(s), voting with the quorum and majority rules set

by the Laws or by the Articles of Incorporation, as the case may be pursuant to article 29 of the Articles of Incorporation.

Chapter II. Capital, Shares

Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at twenty five thousand United States Dollars (USD

25,000.-) divided into one thousand two hundred fifty (2,500) shares with a nominal value of ten United States Dollars
(USD 10.-) each, all of which are fully paid up.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the

Articles of Incorporation or by the Laws.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in

addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

Art. 6. Shares. Each share entitles to one vote.
Each share is indivisible as far as the Company is concerned.
When the Company is composed of a single shareholder, the single shareholder may freely transfer its shares.

41916

L

U X E M B O U R G

When the Company is composed of several shareholders, the shares may be transferred freely amongst shareholders

but the shares may be transferred to non-shareholders only with the authorisation of shareholders representing at least
three quarters (3/4) of the capital.

The transfer of shares must be evidenced by a notarial deed or by a private contract. Any such transfer is not binding

upon the Company and upon third parties unless duly notified to the Company or accepted by the Company, in pursuance
of article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

The Company may acquire its own shares in view of their immediate cancellation.
Ownership of a share carries implicit acceptance of the Articles of Incorporation and of the resolutions validly adopted

by the shareholder(s).

Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The issued capital of the Company may be increased or reduced one or

several times by a resolution of the shareholder(s) adopted in compliance with the quorum and majority rules set by the
Articles of Incorporation or, as the case may be, by the Laws for any amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 8. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a Shareholder. The incapacity, bankruptcy, insolvency or any other

similar event affecting the shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

Chapter III. Managers, Auditors

Art. 9. Managers. The Company shall be managed by one or several managers who need not be shareholders themselves

(the “Manager(s)”).

If two (2) Managers are appointed, they shall jointly manage the Company.
If more than two (2) Managers are appointed, they shall form a board of managers (the "Board of Managers").
The Managers will be appointed by the shareholder(s), who will determine their number and the duration of their

mandate. The Managers are eligible for reappointment and may be removed at any time but only for cause by a resolution
of the shareholder(s).

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

Art. 10. Powers of the Managers. The Managers are vested with the broadest powers to perform all acts necessary

or useful for accomplishing the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Incorporation or by the Laws to the general meeting of shareholder

(s) or to the auditor(s) are in the competence of the Managers.

Art. 11. Delegation of Powers - Representation of the Company. The Manager(s) or the Board of Managers (if more

than two Managers have been appointed) may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or
temporary functions to persons or committees chosen by them.

The Company will be bound towards third parties by the individual signature of the sole Manager or by the joint

signatures of any two Manager(s) if more than one Manager has been appointed.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or sole signature of any person to

whom special power has been delegated by the Manager(s), or the Board of Managers (if more than two Managers have
been appointed), but only within the limits of such special power.

Art. 12. Meetings of the Board of Managers. In case a Board of Managers is formed, the following rules shall apply:
The Board of Managers may appoint from among its members a chairman (the "Chairman"). It may also appoint a

secretary, who need not be a Manager himself and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of
the Board of Managers (the “Secretary”).

The Board of Managers will meet upon call by the Chairman. A meeting of the Board of Managers must be convened

if any of its members so requires.

The Chairman will preside at all meetings of the Board of Managers, except that in his absence the Board of Managers

may appoint another member of the Board of Managers as chairman pro tempore by majority vote of the Managers
present or represented at such meeting.

Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, at least three (3) calendar days’

written notice of meetings of the Board of Managers shall be given in writing and transmitted by any means of commu-
nication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting
as well as the agenda and the nature of the business to be transacted. The notice may be waived by properly documented
consent of each member of the Board of Managers. No separate notice is required for meetings held at times and places
specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers.

All meetings of the Board of Managers shall be held in Luxembourg.
Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another Manager as his proxy.

A quorum of the Board of Managers shall be the presence of all Managers.
Decisions will be taken by the unanimous consent of the votes of the Managers present or represented at such meeting.

41917

L

U X E M B O U R G

In cases of urgency, one or more Managers may participate in a meeting by conference call, videoconference or any

other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate
with each other. Such participation shall be deemed equivalent to a physical presence at the meeting.

Art. 13. Resolutions of the Managers. The resolutions of the Manager(s) shall be recorded in writing.
The minutes of any meeting of the Board of Managers will be signed by the Chairman of the meeting and by the

secretary (if any). Any proxies will remain attached thereto.

A written decision, signed by all the Managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers which was duly convened and held. Such a decision may be documented in a single document or in
several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Managers.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be

signed by the sole Manager or by two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Art. 14. Management Fees and Expenses. Subject to approval by the shareholder(s), the Manager(s) may receive a

management fee in respect of the carrying out of their management of the Company and may, in addition, be reimbursed
for all other expenses whatsoever incurred by the Manager(s) in relation with such management of the Company or the
pursuit of the Company’s corporate object.

Art. 15. Conflicts of Interest. If any of the Managers of the Company has or may have any personal interest in any

transaction of the Company, such Manager shall disclose such personal interest to the other Manager(s) and shall not
consider or vote on any such transaction.

In case of a sole Manager it suffices that the transactions between the Company and its Manager, who has such an

opposing interest, be recorded in writing.

The foregoing paragraphs of this Article do not apply if (i) the relevant transaction is entered into under fair market

conditions and (ii) falls within the ordinary course of business of the Company.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the mere fact that any one or more of the Managers or any officer of the Company has a personal interest in, or is a
manager, associate, member, shareholder, officer or employee of such other company or firm. Any person related as
afore described to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall
not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be automatically prevented from considering, voting
or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

Art. 16. Managers’ Liability - Indemnification. No Manager commits himself, by reason of his functions, to any personal

obligation in relation to the commitments taken on behalf of the Company.

Manager(s) are only liable for the performance of their duties.
The Company shall indemnify any member of the Board of Managers, officer or employee of the Company and, if

applicable, their successors, heirs, executors and administrators, against damages and expenses reasonably incurred by
him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having
been Manager(s), officer or employee of the Company. The foregoing also applies if, at the request of the Company, he
incurs expenses for any other company of which the Company is a shareholder or a creditor and by which he is not
entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or
proceeding to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall be provided
only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by its legal counsel
that the person to be indemnified is not guilty of gross negligence or misconduct. The foregoing right of indemnification
shall not exclude other rights to which the persons to be indemnified pursuant to the Articles of Incorporation may be
entitled.

Art. 17. Auditors. Except where according to the Laws the Company’s annual statutory and/or consolidated accounts

must be audited by an approved independent auditor, the business of the Company and its financial situation, including
more in particular its books and accounts, may, and shall in the cases provided by law, be reviewed by one or more
statutory auditors who need not be shareholders themselves.

The approved statutory or independent auditors, if any, will be appointed by the shareholder(s), which will determine

the number of such auditors and the duration of their mandate. They are eligible for re-appointment. They may be
removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholder(s), save in such cases where the approved
independent auditor may, as a matter of the Laws, only be removed for serious cause or by mutual agreement.

Chapter IV. Shareholders

Art. 18. Powers of the Shareholders. The shareholder(s) shall have such powers as are vested with them pursuant to

the Articles of Incorporation and the Laws. The single shareholder carries out the powers bestowed on the general
meeting of shareholders.

Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company represents the entire body of shareholders.

41918

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Annual General Meeting. The annual general meeting of shareholders, of which one must be held in case the

Company has more than twenty-five (25) shareholders, will be held on the 10 May at 10 a.m. at the registered office of
the Company.

If such day is a day on which banks are not generally open for business in Luxembourg, the meeting will be held on

the next following business day.

Art. 20. Other General Meetings. If the Company is composed of several shareholders, but no more than twenty-five

(25) shareholders, resolutions of the shareholders may be passed in writing. Written resolutions may be documented in
a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several
shareholders. Should such written resolutions be sent by the Manager(s) to the shareholders for adoption, the share-
holders are under the obligation to, within a time period of fifteen (15) calendar days from the dispatch of the text of the
proposed resolutions, cast their written vote by returning it to the Company through any means of communication
allowing for the transmission of a written text. The quorum and majority requirements applicable to the adoption of
resolutions by the general meeting of shareholders shall mutatis mutandis apply to the adoption of written resolutions.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting of shareholders will be held at the registered

office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as designated by the Manager(s).

Art. 21. Notice of General Meetings. Unless there is only one single shareholder, the shareholders may also meet in

a general meeting of shareholders upon issuance of a convening notice in compliance with the Articles of Incorporation
or the Laws, by the Manager(s), subsidiarily, by the statutory auditor(s) (if any) or, more subsidiarily, by shareholders
representing more than half (1/2) of the capital.

The convening notice sent to the shareholders will specify the time and the place of the meeting as well as the agenda

and the nature of the business to be transacted at the relevant general meeting of shareholders. The agenda for a general
meeting of shareholders shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Incorporation
and, if applicable, set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.

If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they have

been duly informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Art. 22. Attendance - Representation. All shareholders are entitled to attend and speak at any general meeting of

shareholders.

A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing in writing, transmitted by any means of

communication allowing for the transmission of a written text, another person who need not be a shareholder himself,
as a proxy holder.

Art. 23. Proceedings. Any general meeting of shareholders shall be presided by the Chairman or by a person designated

by the Manager(s) or, in the absence of such designation, by the general meeting of shareholders.

The Chairman of the general meeting of shareholders shall appoint a secretary.
The general meeting of shareholders shall elect one (1) scrutineer to be chosen from the persons attending the general

meeting of shareholders.

The Chairman, the secretary and the scrutineer so appointed together form the board of the general meeting.

Art. 24. Vote. At any general meeting of shareholders other than a general meeting convened for the purpose of

amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject to the quorum
and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, as the case may be, resolutions shall be
adopted by shareholders representing more than half (1/2) of the capital. If such majority is not reached at the first meeting
(or consultation in writing), the shareholders shall be convened (or consulted) a second time and resolutions shall be
adopted, irrespective of the number of shares represented, by a simple majority of votes cast.

At any general meeting of shareholders, convened in accordance with the Articles of Incorporation or the Laws, for

the purpose of amending the Articles of Incorporation of the Company or voting on resolutions whose adoption is subject
to the quorum and majority requirements of an amendment to the Articles of Incorporation, the quorum shall be a
majority of shareholders in number representing at least three quarters (3/4) of the capital.

Art. 25. Minutes. The minutes of the general meeting of shareholders shall be signed by the shareholders present and

may be signed by any shareholders or proxies of shareholders, who so request.

The resolutions adopted by the single shareholder shall be documented in writing and signed by the single shareholder.
Copies or extracts of the written resolutions adopted by the shareholder(s) as well as of the minutes of the general

meeting of shareholders to be produced in judicial proceedings or otherwise may be signed by the sole Manager or by
two (2) Managers acting jointly if more than one Manager has been appointed.

Chapter V. Financial year, Financial statements, Distribution of profits

Art. 26. Financial Year. The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of

December of each year.

41919

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Adoption of Financial. Statements At the end of each financial year, the accounts are closed and the Manager

(s) draw up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss account, in accordance with
the Laws.

The annual statutory and/or consolidated accounts are submitted to the shareholder(s) for approval.
Each shareholder or its representative may peruse these financial documents at the registered office of the Company.

If the Company is composed of more than twenty-five (25) shareholders, such right may only be exercised within a time
period of fifteen (15) calendar days preceding the date set for the annual general meeting of shareholders.

Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each year

be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”).

That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to

ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s), each share entitling to the same proportion in such distributions.

Chapter VI. Dissolution, Liquidation

Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the sole shareholder or, as the

case may be, the shareholder(s) adopted by half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

After payment of all the debts of and charges against the Company, including the expenses of liquidation, the net

liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) so as to achieve on an aggregate basis the same economic
result as the distribution rules set out for dividend distributions.

Chapter VII. Applicable law

Art. 30. Applicable Law. All matters not governed by the Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Laws, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Subscription and Payment

The Articles of Incorporation of the Company having thus been recorded by the notary, the Company’s shares have

been subscribed and the nominal value of these shares, as well as a share premium, as the case may be, has been one
hundred per cent (100%) paid in cash as follows:

Shareholder

subscribed

capital

number

of shares

amount

paid-in

RCV Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-

2,500 USD 25,000.-

Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25,000.-

2,500 USD 25,000.-

The amount of twenty five thousand United States Dollars (USD 25,000.-) was thus as from that moment at the disposal

of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary who states that the conditions
provided for in article 183 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The amount of the costs, expenses, fees and charges, of any kind whatsoever, which are due from the Company or

charged to it as a result of its incorporation are estimated at approximately two thousand euros.

<i>Transitory Provisions

The first financial year of the Company will begin on the date of formation of the Company and will end on the last

day of December of 2015.

<i>Shareholders resolutions

<i>First Resolution

The sole shareholder resolved to establish the registered office at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,

Grand Duchy of Luxembourg.

<i>Second Resolution

The sole shareholder resolved to set at one (1) the number of Manager(s) and further resolved to appoint
Mr Claude CRAUSER, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg,
as manager for an undefined period.

41920

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who knows and speaks English, stated that on request of the appearing person, the present

deed has been worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case of divergences
between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person(s), who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die Deutsche Übersetzung des Vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreizehnten März.
Vor dem unterzeichnenden Notar Jean-Paul MEYERS, mit Amtssitz in Rambruch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

RCV Lease Stichting, eine Stiftung niederländischen Rechts mit Geschäftssitz in Amsterdam und mit Adresse in Stra-

winskylaan 411, 1077XX Amsterdam,

vertreten  durch  Herrn  Claude  CRAUSER  wohnhaft  in  Luxembourg,  kraft  der  in  Amsterdam  erteilten  Vollmacht;

welche Vollmacht, von dem Vollmachtnehmer und dem unterzeichneten Notar unterzeichnet wurde, und der vorliegen-
den notariellen Urkunde zum Zwecke der Registrierung beigefügt bleibt.

Daraufhin wurde die Satzung einer Gesellschaft wie folgt festgestellt:

Kapitel I. Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (die „Gesellschaft“) gegründet, die

den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg (den „Gesetzen“) und den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (die
„Satzung“) unterliegt.

Die Gesellschaft kann aus einem Alleingesellschafter, der Eigentümer aller Gesellschaftsanteile ist, oder aus mehreren

Gesellschaftern, deren Zahl jedoch vierzig (40) nicht überschreiten darf, bestehen.

Die Gesellschaft wird unter dem Namen „RCV Lease S.à r.l.“ firmieren.

Art. 2. Sitz. Die Gesellschaft wird ihren Sitz in der Stadt Luxemburg haben.
Der Gesellschaftssitz kann durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) an jeden anderen Ort innerhalb der

Stadt Luxemburg verlegt werden.

Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch einen Beschluss der (des) Geschäftsführer(s) im

Großherzogtum Luxemburg gegründet werden.

Art. 3. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung, das Leasing und die Weitervermarktung eines

Boeing Typ 747-400F Flugzeuges MSN 30400 (die „Flugzeugzelle“) zusammen mit vier (4) Rolls Royce Flugzeugmotoren
Typ RB211-524 H2-T mit den Seriennummern 13745, 13758, 13803 and 13189 (die „Motoren“; die Flugzeugzelle und
Motoren gemeinsam das „Flugzeug“) und alle Maßnahmen vorzunehmen oder deren Vornahme zu besorgen die für die
Erreichung des oben genannten Gesellschaftszwecks notwendig oder mit diesem verbunden sind oder diesen fördern.

Um den Gesellschaftszweck zu erreichen kann die Gesellschaft das Flugzeug mittels Kauf und Leasing erwerben oder

dieses verkaufen und einen Erwerb durch Kredite oder andere Finanzierungsverträge in jedweder Form finanzieren und
Garantien stellen und Sicherungsrechte jedweder Form gewähren oder andere Sicherheiten an ihrem Vermögen gewäh-
ren,  unter  anderem  Hypotheken  und  Pfandrechte,  um  die  durch  die  Gesellschaft  oder  durch  die  Cargolux  Airlines
International S.A. in Bezug auf den Kauf, die Finanzierung oder dem Leasing des Flugzeuges eingegangenen Finanzierungs-
verpflichtungen sicherzustellen.

Die  Gesellschaft  kann  des  Weiteren  Garantien  stellen  und  Sicherungsrechte  jedweder  Form  an  ihrem  Vermögen

gewähren, unter anderem Hypotheken und Pfandrechte, um ihre finanziellen Verpflichtungen abzusichern.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist für eine unbegrenzte Dauer gegründet.
Sie kann jederzeit aufgelöst werden durch einen Beschluss des/der Gesellschafter(s), der in Übereinstimmung mit dem

nach dem Gesetz oder dieser Satzung für die Änderung der Satzung erforderlichen Quorum und den erforderlichen
Mehrheiten gefasst wird, und in Übereinstimmung mit Artikel 29 dieser Satzung.

Kapitel II. Kapital, Anteile

Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend

Dollar (USD 25.000,-), und ist in zweitausendfünfhundert (2.500) Anteile mit einem Nennwert von je zehn Dollar (USD
10,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig eingezahlt.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen der Satzung oder des Gesetzes sind alle Anteile mit denselben Rechten und

Pflichten ausgestattet.

Zusätzlich zum ausgegebenen Gesellschaftskapital kann ein Aufgeldkonto eingerichtet werden auf dem alle Emissions-

aufgelder, die auf einen Anteil eingezahlt werden, verbucht werden. Der Betrag dieses Aufgeldkontos kann zur Zahlung

41921

L

U X E M B O U R G

von Anteilen, die die Gesellschaft von ihrem(n) Gesellschafter(n) zurückkauft, zum Ausgleich von realisierten Nettover-
lusten,  zur  Auszahlung  an  den/die  Gesellschafter  in  Form  von  Dividenden  oder  um  Mittel  zur  gesetzlichen  Rücklage
bereitzustellen, verwendet werden.

Art. 6. Anteile. Jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme.
Jeder Anteil ist der Gesellschaft gegenüber unteilbar.
Hat die Gesellschaft einen Alleingesellschafter, so kann dieser seine Anteile frei übertragen.
Besteht die Gesellschaft aus mehreren Gesellschaftern, so sind die Anteile unter ihnen frei übertragbar und die Anteile

können nur dann an Nicht-Gesellschafter übertragen werden, wenn die Gesellschafter mit einer Mehrheit, die mindestens
drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals darstellt, ihr Einverständnis erklären.

Die Übertragung von Anteilen muss durch notarielle Urkunde oder durch privatschriftlichen Vertrag belegt werden.

Eine solche Übertragung wird gemäß Artikel 1690 des Bürgerlichen Gesetzbuches Luxemburgs erst dann gegenüber der
Gesellschaft und Dritten bindend, wenn sie der Gesellschaft gegenüber ordnungsgemäß angezeigt oder von dieser ange-
nommen worden ist.

Die Gesellschaft ist dazu berechtigt, ihre eigenen Anteile im Hinblick auf deren sofortige Annullierung zurückzuer-

werben.

Anteilsbesitz führt die stillschweigende Akzeptanz der Satzung und der von den (dem) Gesellschafter(n) gültig getrof-

fenen Beschlüsse mit sich.

Art. 7. Kapitalerhöhung und Kapitalherabsetzung. Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der (des) Ge-

sellschafter(s), der mit Anwesenheits- und Mehrheitsverhältnissen, wie sie aufgrund der Gesetze oder der Satzung zur
Änderung der Satzung erforderlich sind, gefasst wird, einmal oder mehrmals erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 8. Handlungsunfähigkeit, Konkurs oder Insolvenz eines Gesellschafters. Die Handlungsunfähigkeit, der Konkurs

oder die Insolvenz oder ein vergleichbarer, die (den) Gesellschafter betreffender Umstand, hat nicht die Auflösung der
Gesellschaft zur Folge.

Kapitel III. Geschäftsführer, Wirtschaftsprüfer

Art. 9. Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche keine Gesellschaf-

ter sein müssen, geführt (die (der) „Geschäftsführer“).

Werden zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so verwalten sie die Gesellschaft gemeinschaftlich.
Werden mehr als zwei (2) Geschäftsführer bestellt, so wird ein Geschäftsführungsrat (der „Geschäftsführungsrat“)

gegründet.

Die Geschäftsführer werden durch die (den) Gesellschafter ernannt, welche(r) ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats

festlegt. Die (der) Geschäftsführer können (kann) wiederernannt werden und jederzeit, aber nur aus gutem Grund, durch
einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden.

Der/die Gesellschafter soll(en) weder an der Geschäftsführung teilnehmen, noch in diese eingreifen.

Art. 10. Befugnisse der (des) Geschäftsführer(s). Die (der) Geschäftsführer haben (hat) die weitestgehenden Befugnisse,

um alle zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendigen oder nützlichen Handlungen vorzunehmen.

Sämtliche Befugnisse, die die Satzung oder die Gesetze nicht ausdrücklich den Gesellschaftern oder den Wirtschafts-

prüfern vorbehalten, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführer.

Art. 11. Übertragung von Befugnissen - Vertretung der Gesellschaft. Die (der) Geschäftsführer oder der Geschäfts-

führungsrat (wenn mehr als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) können (kann) spezielle Befugnisse oder Vollmachten
an Personen oder Ausschüsse, die von ihnen gewählt werden, übertragen oder diese mit bestimmten ständigen oder
zeitweiligen Funktionen ausstatten.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber durch die alleinige Unterschrift des einzigen Geschäftsführers oder, wenn

mehr als ein Geschäftsführer ernannt worden ist, durch die gemeinsame Unterschriften von zwei Geschäftsführern, ge-
bunden.

Die Gesellschaft wird Dritten gegenüber auch durch die gemeinsame oder alleinige Unterschrift derjenigen Personen

gebunden, denen eine spezielle Vollmacht von dem (den) Geschäftsführer(n) oder dem Geschäftsführungsrat (wenn mehr
als zwei Geschäftsführer ernannt wurden) übertragen worden ist, jedoch nicht über die Grenzen dieser speziellen Voll-
macht hinaus.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführungsrates. Für den Fall, dass ein Geschäftsführungsrat bestellt wird, gelten folgende

Regeln:

Der Geschäftsführungsrat kann aus seiner Mitte einen Vorsitzenden benennen (der „Vorsitzende“). Er kann auch einen

Schriftführer  benennen,  welcher selbst  kein  Geschäftsführer sein muss und  für  die Protokollführung  der Sitzung  der
Geschäftsführung zuständig ist (der „Schriftführer“).

Der Geschäftsführungsrat tritt auf Einberufung durch den Vorsitzenden zusammen. Eine Versammlung des Geschäfts-

führungsrates muss einberufen werden, wenn eines seiner Mitglieder dies verlangt.

41922

L

U X E M B O U R G

Der Vorsitzende steht allen Versammlungen des Geschäftsführungsrates vor, es sei denn, dass der Geschäftsführungs-

rat in seiner Abwesenheit ein anderes Mitglied des Geschäftsführungsrates durch mehrheitliche Abstimmung durch die
anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennt.

Außer in Dringlichkeitsfällen oder mit vorheriger Zustimmung aller Teilnahmeberechtigten, werden die Sitzungen des

Geschäftsführungsrates mindestens drei (3) Kalendertage vor ihrem Termin schriftlich durch ein die Schriftlichkeit ge-
währleistendes  Kommunikationsmittel  einberufen.  Jede  dieser  Einladungen  soll  Ort  und  Zeit  der  Sitzung  sowie  die
Tagesordnung und die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit angeben. Auf die Einladung kann durch ordnungsgemäß
dokumentierten Beschluss jedes Geschäftsführungsmitglieds verzichtet werden. Für Sitzungen, deren Zeit und Ort in
einem zuvor von der Geschäftsführung angenommenen Beschluss festgelegt wurde, ist keine gesonderte Benachrichtigung
erforderlich.

Alle Sitzungen des Geschäftsführungsrates finden in Luxemburg statt.
Jeder Geschäftsführer kann sich bei den Sitzungen des Geschäftsführungsrates durch ein anderes Mitglied des Ge-

schäftsführungsrates vertreten lassen, indem er dieses hierzu schriftlich ermächtigt und diese Ermächtigung durch ein die
Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel übermittelt wurde.

Die Beschlussfähigkeit des Geschäftsführungsrates erfordert die Anwesenheit aller seiner Mitglieder.
Entscheidungen werden durch die einstimmige Zustimmung aller bei der Sitzung anwesenden oder vertretenen Mit-

glieder des Geschäftsführungsrates getroffen.

In dringenden Fällen können ein oder mehrere Mitglieder des Geschäftsführungsrates durch eine Telefonkonferenz-

schaltung oder durch ähnliche Mittel, welche die gleichzeitige Kommunikation zwischen den Teilnehmern sicherstellen,
teilnehmen. Diese Teilnahmeform wird der persönlichen Anwesenheit bei der Sitzung gleichgestellt.

Art. 13. Beschlüsse der Geschäftsführer. Die Beschlüsse der(s) Geschäftsführer(s) werden schriftlich festgehalten.
Alle Sitzungsprotokolle werden vom Vorsitzenden und vom Schriftführer (falls vorhanden) unterzeichnet. Alle Voll-

machten werden den betreffenden Sitzungsprotokollen beigefügt.

Eine von allen Geschäftsführern unterzeichnete Entscheidung steht einem Beschluss gleich, der in einer ordnungsgemäß

einberufenen und abgehaltenen Sitzung des Geschäftsführungsrates gefasst worden wäre. Eine solche Entscheidung kann
in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts festgehalten werden und wird
jeweils von einem oder mehreren Geschäftsführern unterzeichnet.

Kopien oder Auszüge schriftlicher Beschlüsse oder Sitzungsprotokolle, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig

übermittelt werden, können von einem Geschäftsführer oder von zwei (2) Geschäftsführern gemeinsam unterzeichnet
werden, sofern mehrere Geschäftsführer ernannt wurden.

Art. 14. Vergütung der Geschäftsführer und Ausgaben. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die (den) Gesellschafter,

können (kann) die (der) Geschäftsführer eine Vergütung hinsichtlich ihrer (seiner) Verwaltung der Gesellschaft erhalten.
Darüber hinaus können den Geschäftsführern sämtliche Ausgaben, die im Rahmen einer solchen Verwaltung oder zur
Verfolgung des Gesellschaftsgegenstandes getätigt wurden, zurückerstattet werden.

Art. 15. Interessenkonflikte. Sofern einer der Geschäftsführer der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einem

Rechtsgeschäft der Gesellschaft hat oder haben könnte, muss er dieses persönliche Interesse dem (den) anderen Ge-
schäftsführer(n) anzeigen und darf nicht an der Abstimmung über dieses Rechtsgeschäft teilnehmen.

Falls es nur einen Geschäftsführer gibt, genügt es, dass das Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und ihrem Ge-

schäftsführer, der ein entgegengesetztes Interesse hat, schriftlich festgehalten wird.

Die vorstehenden Bestimmungen sind nicht anwendbar wenn (i) das betreffende Rechtsgeschäft unter fairen Markt-

bedingungen eingegangen wurde und (ii) in die gewöhnlichen Geschäftsabläufe der Gesellschaft fällt.

Kein Vertrag oder sonstiges Rechtsgeschäft zwischen der Gesellschaft und irgendeiner anderen Gesellschaft oder

irgend einem anderen Unternehmen wird durch den bloßen Umstand beeinträchtigt oder ungültig, dass ein oder mehrere
Geschäftsführer  oder  Bevollmächtigte  der  Gesellschaft  persönlich  an  einer  solchen  Gesellschaft  oder  einem  solchen
Unternehmen beteiligt sind oder Geschäftsführer, Gesellschafter, Mitglieder, Bevollmächtigte oder Angestellte einer sol-
chen Gesellschaft oder eines solchen Unternehmens sind.

Keine Person, welche in einer der zuvor beschriebenen Weise mit einer Gesellschaft in Beziehung steht, mit der die

Gesellschaft vertragliche Beziehungen eingeht oder sonst wie Geschäfte tätigt, wird automatisch daran gehindert, über
solche Verträge oder andere Geschäfte zu beraten, abzustimmen oder zu handeln.

Art. 16. Haftung der Geschäftsführer - Freistellung. Die (der) Geschäftsführer treffen (trifft) keine persönliche Haftung

hinsichtlich der aufgrund ihrer (seiner) Funktion für die Gesellschaft eingegangenen Verpflichtungen.

Geschäftsführer haften ausschließlich für die Ausführung ihrer Aufgaben.
Die Gesellschaft stellt jedes Mitglied des Geschäftsführungsrates, Bevollmächtigten oder Angestellten und, gegebe-

nenfalls,  dessen  Erben,  Nachlassverwalter  und  Vermögensverwalter,  von  Schäden  und  Ausgaben  frei,  die  ihm  im
Zusammenhang eines Rechtsstreits oder eines Prozesses, an dem er aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer oder
früherer Geschäftsführer, Bevollmächtigter oder Angestellter der Gesellschaft beteiligt ist. Das Gleiche gilt, wenn er auf
Anfrage der Gesellschaft für eine andere Gesellschaft an der die Gesellschaft beteiligt ist oder von der sie Gläubigerin ist,

41923

L

U X E M B O U R G

Ausgaben tätigt und der gegenüber er nicht zur Freistellung berechtigt ist, außer bei Klagsachen in denen er schließlich
endgültig wegen grober Fahrlässigkeit oder Misswirtschaft verurteilt wurde. Im Falle eines Vergleichs wird Freistellung
nur für vom Vergleich umfasste Fragen gewährt, bei denen die Gesellschaft von ihrem Rechtsbeistand dahingehend beraten
worden ist, dass der freizustellenden Person keine grobe Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten vorzuwerfen ist. Das
vorgenannte Recht zur Freistellung schließt keine anderen Rechte aus zu denen die betreffende Person berechtigt ist.

Art. 17. Wirtschaftsprüfer. Außer in den Fällen, in denen die gesetzlichen Bestimmungen die Prüfung der Jahresab-

schlüsse und konsolidierten Jahresabschlüsse durch einen zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfer vorsehen, kann,
und in den gesetzlich vorgeschriebenen Fällen, muss, das Geschäft der Gesellschaft und deren finanzielle Situation, ein-
schließlich der Bücher und Konten durch statutorische Wirtschaftsprüfer, welche nicht Gesellschafter zu sein brauchen,
geprüft.

Die zugelassenen statutorischen oder unabhängigen Wirtschaftsprüfer, falls vorhanden, werden durch die (den) Ge-

sellschafter ernannt, der ihre Anzahl und die Dauer ihres Mandats festlegt. Die Wirtschaftsprüfer können wiederernannt
werden und können jederzeit, mit oder ohne Grund, durch einen Beschluss der (des) Gesellschafter(s) abberufen werden,
außer in Fällen, in denen das Gesetz vorschreibt, dass der unabhängige Wirtschaftsprüfer nur aus guten Gründen oder
einvernehmlich abberufen werden kann.

Kapitel IV. Gesellschafter

Art. 18. Befugnisse der Gesellschafter.  Die  Gesellschafter  haben  die  Rechte,  die  ihnen  nach  der  Satzung  und  den

Gesetzen zustehen. Besteht die Gesellschaft nur aus einem Gesellschafter, so übt dieser die Befugnisse aus, die das Gesetz
der Gesellschafterversammlung übertragen hat.

Jede ordnungsgemäß zusammengetretene Gesellschafterversammlung vertritt die Gesamtheit der Gesellschafter.

Art. 19. Jahresgesellschafterversammlung. Die Jahresgesellschafterversammlung, die verpflichtend abgehalten werden

muss, wenn die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, wird am 10. Mai um 10 Uhr am Gesell-
schaftssitz der Gesellschaft abgehalten.

Wenn dieser Tag ein Tag ist an dem Banken in Luxemburg nicht geöffnet sind, wird die Versammlung am darauffol-

genden Werktag abgehalten.

Art. 20. Andere Gesellschafterversammlungen. Besteht die Gesellschaft aus mehreren, jedoch nicht mehr als fünfund-

zwanzig (25) Gesellschaftern, können die Beschlüsse der Gesellschafter in schriftlicher Form gefasst werden. Schriftliche
Beschlüsse können in einem einzigen Dokument oder in mehreren getrennten Dokumenten desselben Inhalts und jeweils
von einem oder mehreren Gesellschaftern unterzeichnet festgehalten sein. Sind die zu fassenden Beschlüsse von den
Geschäftsführern an die Gesellschafter übermittelt worden, so sind die Gesellschafter verpflichtet innerhalb von fünfzehn
(15) Kalendertagen seit dem Eingang des Textes des vorgeschlagenen Beschlusses ihre Entscheidung zu treffen und sie
der Gesellschaft durch jedes, die Schriftlichkeit gewährleistendes Kommunikationsmittel, zukommen zu lassen. Die Be-
stimmungen zur Beschlussfähigkeit und den erforderlichen Mehrheiten bei Beschlüssen der Gesellschafterversammlung
sind sinngemäß auf die Beschlussfassung im schriftlichen Verfahren anwendbar.

Gesellschafterversammlungen, einschließlich der Jahresgesellschafterversammlung werden am Gesellschaftssitz abge-

halten oder an jedem anderen von den Geschäftsführern bestimmten Ort im Großherzogtum Luxemburg.

Art. 21. Einberufung von Gesellschafterversammlungen. Außer in den Fällen eines Alleingesellschafters, können sich

die Gesellschafter auch auf Einberufungsschreiben versammeln, das in Übereinstimmung mit der Satzung oder dem Gesetz
von den Geschäftsführern, oder andernfalls durch die statutorischen Wirtschaftsprüfer (falls vorhanden) ausgegeben wird
oder andernfalls durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentieren.

Das an die Gesellschafter gesendete Einberufungsschreiben gibt die Zeit, den Ort und die Tagesordnung der Gesell-

schafterversammlung an sowie die Art der zu behandelnden Geschäftstätigkeit. Die Tagesordnung soll gegebenenfalls eine
vorgeschlagene Satzungsänderung darlegen und gegebenenfalls die Änderungen angeben, die den Gesellschaftszweck oder
die Rechtsform der Gesellschaft betreffen.

Sind alle Gesellschafter bei der Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, dass sie über

die Tagesordnung ordnungsgemäß in Kenntnis gesetzt worden sind, so kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung
abgehalten werden.

Art. 22. Anwesenheit - Vertretung. Alle Gesellschafter besitzen bei jeder Gesellschafterversammlung ein Teilnahme-

und Rederecht.

Ein Gesellschafter kann sich durch schriftliche Ermächtigung, welche durch ein die Schriftlichkeit gewährleistendes

Kommunikationsmittel übermittelt wurde, bei jeder Gesellschafterversammlung durch eine andere Person, die nicht selbst
Gesellschafter sein muss, vertreten lassen.

Art. 23. Verfahren.  Gesellschafterversammlungen  werden  vom  Vorsitzenden  oder  von  einer  hierzu  von  den  Ge-

schäftsführern ernannten Person oder, in Ermangelung einer solchen Ernennung, durch die Gesellschafterversammlung
geleitet.

Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung ernennt einen Schriftführer.

41924

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschafterversammlung ernennt einen (1) Stimmzähler, der unter den Personen, die bei der Gesellschafter-

versammlung anwesend sind, gewählt wird.

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmzähler bilden zusammen den Vorstand der Gesellschafterversamm-

lung.

Art. 24. Abstimmung. Bei jeder Gesellschafterversammlung, die nicht zur Änderung der Satzung oder zur Fassung von

Beschlüssen, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der Satzung erforderlich sind, unterliegen, werden
Beschlüsse von Gesellschaftern gefasst, die mehr als die Hälfte (1/2) des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine solche
Mehrheit nicht bei der ersten Versammlung oder bei dem ersten Versuch einer schriftlichen Beschlussfassung erreicht,
so werden die Gesellschafter ein zweites Mal einberufen oder konsultiert; Beschlüsse werden dann unabhängig von der
Anzahl der vertretenen Anteile, durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Bei jeder Gesellschafterversammlung, die in Übereinstimmung mit der Satzung oder den Gesetzen zum Zwecke der

Satzungsänderung oder zur Abstimmung über Beschlüsse, die den Mehrheitsverhältnissen, wie sie zur Änderung der
Satzung erforderlich sind, unterliegen, einberufen werden, ist das Quorum die Mehrheit der Anzahl der Gesellschafter,
die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Art. 25. Protokolle. Das Protokoll der Gesellschafterversammlung wird von den anwesenden Gesellschaftern unter-

zeichnet und kann von Gesellschaftern, oder Vertretern von Gesellschaftern, die dies verlangen, unterzeichnet werden.

Die vom Alleingesellschafter gefassten Beschlüsse werden schriftlich festgehalten und vom Alleingesellschafter unter-

zeichnet.

Kopien oder Auszüge der von den (dem) Gesellschafter(n) angenommenen Beschlüsse sowie des Sitzungsprotokolls

der Gesellschafterversammlung, die in rechtlichen Verfahren oder anderweitig übermittelt werden, können von einem
Geschäftsführer oder von zwei (2) Geschäftsführern gemeinsam unterzeichnet, sofern mehrere Geschäftsführer ernannt
worden sind.

Kapitel V. Geschäftsjahr, Finanzberichte, Ausschüttung von Gewinnen

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am letzten Tag des

Monats Dezember eines jeden Jahres.

Art. 27. Annahme der Finanzberichte. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres werden die Konten geschlossen und die

Geschäftsführer erstellen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen ein Verzeichnis der Vermögensanlagen
und Verpflichtungen sowie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Jahresabschluss und/oder der konsolidierte Jahresabschluss (werden) wird den (dem) Gesellschafter(n) vorgelegt.
Jeder Gesellschafter kann in diese Finanzdokumente am Gesellschaftssitz einsehen. Besteht die Gesellschaft aus mehr

als fünfundzwanzig (25) Gesellschaftern, kann dieses Recht nur während einer Zeitspanne von fünfzehn (15) Kalendertagen
bis zum Datum der jährlichen Hauptversammlung ausgeübt werden.

Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der

gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“). Diese Verpflichtung entfällt sobald und solange diese
Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmt die Gesellschafter wie der verbleibende jährliche Reingewinn

verteilt werden soll indem sie diesen vollständige oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäftsjahr
vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die Akti-
onäre ausschütten, wobei jeder Anteil in gleichem Verhältnis zur Teilnahme an einer solchen Ausschüttung berechtigt.

Kapitel VI. Auflösung, Liquidation

Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der Gesellschafter, oder gegebenenfalls

des alleinigen Gesellschafters, aufgelöst werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei
Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals vertreten.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Nach Begleichung aller Schulden und sonstiger gegen die Gesellschaft bestehenden Ansprüche einschließlich der Li-

quidationskosten wird der Reinerlöse aus der Abwicklung an die Aktionäre so verteilt, dass das wirtschaftliche Ergebnis
den auf die Ausschüttung von Dividenden anwendbaren Regeln entspricht.

Kapitel VII. Geltendes Recht

Art. 30. Geltendes Recht. Sämtliche Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt sind, bestimmen

sich nach den Gesetzen, insbesondere dem Gesetz über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner aktuellen
Fassung.

41925

L

U X E M B O U R G

<i>Zeichnung und Zahlung

Die Satzung ist somit durch den Notar aufgenommen, die Anteile wurden gezeichnet und der Nennwert und gege-

benenfalls das Emmissionsaufgeld zu einhundert Prozent (100%) in bar wie folgt eingezahlt:

Gesellschafter

gezeichnetes

Kapitall

Anzahl der

Anteile

eingezahlter

Betrag

RCV Lease Stichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-

2.500 USD 25.000.-

Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 25.000,-

2.500 USD 25.000.-

Die Summe von fünfundzwanzigtausend Dollar (USD 25.000,-) stand der Gesellschaft daher von diesem Moment an

zur Verfügung. Beweis hierüber wurde dem unterzeichnenden Notar überbracht, welcher erklärt, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in seiner aktuellen Fassung,
gewahrt wurden.

<i>Kosten

Die Höhe der Auslagen, Kosten, Aufwendungen und Lasten jeglicher Art, die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung

entstehen, werden auf ungefähr zweitausend Euro geschätzt.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt am Gründungstag der Gesellschaft und endet am letzten Tag des Monats Dezember

2015.

<i>Gesellschafterbeschlüsse

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter hat beschlossen, den Sitz der Gesellschaft in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg, festzulegen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter hat beschlossen die Anzahl der Geschäftsführer wird auf einen (1) festzulegen und

Herrn Claude Crauser, geschäftlich ansässig in 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg auf unbegrenzte Zeit

als Geschäftsführer zu ernennen.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch spricht, erklärt, dass vorliegende Urkunde auf Antrag der oben genannten

Partei in englischer Sprache verfasst wurde, der eine deutsche Fassung folgt; auf Antrag derselben Personen und im Falle
von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text gilt der englische Text.

Woraufhin vorliegende Urkunde am eingangs erwähnten Datum von dem unterzeichnenden Notar in Luxemburg

aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den dem Notar nach Namen, Vornamen, Personenstand und Wohnort bekannten, erschie-

nenen Partei(en) vorgelesen worden ist, haben dieselben vorliegende urschriftliche Urkunde mit dem unterzeichnenden
Notar, unterzeichnet.

Signé: CRAUSER, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 mars 2015. Relation: DAC/2015/4422. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 26 mars 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015047335/587.

(150053911) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

41926

L

U X E M B O U R G

Stora Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.879.

Stora Enso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 500.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 67.934.

JOINT MERGER PROPOSAL

The board of managers of Stora Luxembourg S.à r.l., and the board of managers of Stora Enso S.à r.l. (the Boards and

individually a Board) have decided to draw up this joint merger proposal (the Joint Merger Proposal) in accordance with
the provisions of articles 261 and 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law),
and to present it to their respective general meeting of shareholders.

This merger is to be carried out by way of absorption by the private limited liability company (société à responsabilité

limitée) Stora Luxembourg S.à r.l. (the Acquiring Company), of its wholly-owned subsidiary, the private limited liability
company (société à responsabilité limitée) Stora Enso S.à r.l. (the Company Ceasing To Exist, together with the Acquiring
Company, the Merging Companies or individually each a Merging Company) in accordance with articles 261, 278 and 279
of the Law.

1. Description of the contemplated merger. The Boards propose carrying out a merger which will entail the transfer

of all assets and liabilities of the Company Ceasing To Exist to the Acquiring Company, in accordance with the provisions
of article 274 of the Law (the Merger).

The Boards mutually undertake to take all required steps in order to carry out the Merger, in accordance with the

terms and conditions set forth in this Joint Merger Proposal.

In accordance with article 272 of the Law, the Merger will become effective inter partes when the concurring decisions

to approve the Merger will have been adopted by the respective shareholder of the Merging Companies (the Effective
Date).

The Merger shall only be enforceable towards third parties after the publication of the minutes of the general meetings

of shareholders of each of the Merging Companies in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial),
pursuant to article 9 and article 273 (1) of the Law.

2. Information provided under article 261 (2) of the law.
a) Type of legal entity, name and registered office of the Merging Companies
- The Acquiring Company
The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Stora Luxembourg S.à r.l. has its registered office

at 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg under number B 67879.

The Acquiring Company has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant to a

deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated
December 23, 1998, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 186, dated March
19,1999, pages 8900 and seq..

The articles of association of the Acquiring Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître

Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated November 5, 2012, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et des Associations, number 3017, dated December 13, 2012, pages 144810 and seq..

- The Company Ceasing to Exist
The private limited liability company (société à responsabilité limitée) Stora Enso S.à r.l. has its registered office at 16

Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce
and Companies of Luxembourg under number B 67934.

The Company Ceasing to Exist has been incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pursuant

to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, then notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
dated December 23, 1998, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 194, dated
March 23, 1999, pages 9287 and seq..

The articles of association of the Company Ceasing to Exist have been amended for the last time pursuant to a deed

of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in replacement of Maître Henri

41927

L

U X E M B O U R G

Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated November 5, 2012, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations, number 3016, dated December 13, 2012, pages 144763 and seq..

b) Date as of which the operations of the Company Ceasing to Exist shall be treated, for accounting purposes, as being

carried out on behalf of the Acquiring Company

The operations of the Company Ceasing to Exist shall be treated, for accounting purposes, as being carried out on

behalf of the Acquiring Company as from January 1, 2015.

c) Rights conferred by the Acquiring Company to shareholders having special rights and to holders of securities other

than shares

All shares of the Company Ceasing to Exist are identical and confer the same rights and advantages to their holder so

that no special rights and no compensations will be granted at the expense of the Acquiring Company to anyone.

The Company Ceasing to Exist has not issued any securities other than the shares in the share capital of the Company

which are wholly owned by the Acquiring Company.

d) Special advantages granted to the experts referred to in article 266 of the Law, to the members of the Boards of

the Merging Companies and to any of the persons (if any) referred to in article 261 (2) g) of the Law

Neither the experts referred to in article 266 of the Law, nor the members of the Boards and any of the persons (if

any) referred to in article 261 (2) g) of the Law, shall be entitled to receive any special advantages in connection with or
as a result of the Merger.

3. Consequences of the merger.
3.1 The Merger will trigger ipso jure all the consequences detailed in article 274 of the Law and in particular, as a result

of the Merger, the Company Ceasing to Exist shall cease to exist and all the shares in issue shall be cancelled.

3.2 The Acquiring Company will become the owner of the assets of the Company Ceasing to Exist as they exist on

the Effective Date, with no right of recourse whatsoever against the Company Ceasing to Exist.

3.3 The Acquiring Company shall pay, as of the Effective Date, all taxes, contributions, duties, levies and insurance

premium which will or may become due with respect to the ownership of the assets which have been contributed.

3.4 As of the Effective Date, the Acquiring Company shall perform all agreements and obligations whatsoever of the

Company Ceasing to Exist.

3.5 The rights and claims comprised in the assets of the Company Ceasing to Exist shall be transferred to the Acquiring

Company with all the securities, either in rem or personal, attached thereto. The Acquiring Company shall thus be
subrogated, without novation, in all rights, whether in rem or personal, of the Company Ceasing to Exist with respect to
all assets and against all debtors, without any exception.

3.6 The Acquiring Company shall incur all debts and liabilities of any kind of the Company Ceasing to Exist. In particular,

it shall pay interest and principal on all debts and liabilities of any kind incurred by the Company Ceasing to Exist.

3.7 All corporate documents of the Company Ceasing to Exist shall be kept at the registered office of the Acquiring

Company for as long as prescribed by the Law.

3.8 The mandates of the members of the Board of the Company Ceasing to Exist will be terminated on the Effective

Date. Full discharge will be given to the members of the Board of the Company Ceasing to Exist for the performance of
their mandates.

3.9 The mandates of the members of the Board of the Acquiring Company will not be affected by the Merger.

4. Additional provisions.
4.1 The cost of the Merger will be incurred by the Acquiring Company.
4.2 The undersigned mutually undertake to take all steps in their power in order to carry out the Merger in accordance

with the legal and statutory requirements of the Merging Companies.

4.3 The Acquiring Company shall carry out all required and necessary formalities in order to carry out the Merger as

well as the transfer of all assets and liabilities of the Company Ceasing to Exist to the Acquiring Company.

4.4 The shareholder(s) of each of the Merging Companies shall be entitled to inspect the following documents at the

registered office of the said companies, at least one month before the date of the general meetings of the shareholder to
be called to decide on the terms of the Merger:

- the draft terms of the Merger; and
- the annual accounts of the Merging Companies for the last three financial years, if applicable.
A copy of the above mentioned documents will be granted free of charge upon request by a shareholder
4.5. The present document has been drawn up in Luxembourg on March 25, 2015, in original, in order to be registered

with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg and to be published in the Memorial, at least one month
prior to the date of the general meetings of the shareholder(s) of each of the Merging Companies to be called to decide
on the terms of the Merger, in accordance with article 262 of the Law.

41928

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

Le conseil de gérance de Stora Luxembourg S.à r.l.. et le conseil de gérance de Stora Enso S.à. r.l. (les Conseils de

Gérance et individuellement un Conseil de Gérance) ont décidé par les présentes d'établir ce projet commun de fusion
(le Projet Commun de Fusion) conformément aux dispositions des articles 261 et 278 de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et de le présenter à l’assemblée générale de leurs associés respectifs.

La fusion est à réaliser par l’absorption par la société à responsabilité limitée Stora Luxembourg S.à r.l. (la Société

Absorbante) de sa filiale détenue à 100%, la société à responsabilité limitée Stora Enso S.à r.l. (la Société Absorbée et
ensemble  avec  la  Société  Absorbante,  les  Sociétés  qui  Fusionnent  ou  individuellement  une  Société  qui  Fusionne)  en
conformité avec les articles 261, 278 et 279 de la Loi.

1. Description de la fusion envisagée. Les Conseils de Gérance proposent de réaliser une fusion qui entraînera le

transfert de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante en conformité avec les dispositions
de l’article 274 de la Loi (la Fusion).

Les Conseils de Gérance s'engagent mutuellement à accomplir toutes les démarches nécessaires à la réalisation de la

Fusion, conformément aux conditions détaillées dans ce Projet Commun de Fusion.

Conformément à l’article 272 de la Loi, la Fusion prendra effet entre les Sociétés qui Fusionnent lorsque les décisions

concordantes d'approbation de la Fusion auront été adoptées par les assemblées générales respectives des associés des
Sociétés qui Fusionnent (la Date de Prise d'Effet).

La Fusion prendra seulement effet envers les tiers après la publication du procès-verbal des assemblées générales des

associés des Sociétés qui Fusionnent au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), conformément
à l’article 9 et à l’article 273 (1) de la Loi.

2. Informations fournies en vertu de l'article 261 (2) de la loi.
a) Type de personne morale, dénomination sociale et siège social des Sociétés qui Fusionnent
- La Société Absorbante
La société à responsabilité limitée Stora Luxembourg S.à r.l. a son siège social au 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxem-

bourg, Grand-Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 67879.

La Société Absorbante a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Maître André-

Jean-Joseph  Schwachtgen,  alors  notaire  de  résidence  à  Luxembourg,  Grand-Duché  de  Luxembourg,  en  date  du  23
décembre 1998, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 19 mars 1999, sous le numéro 186,
pages 8900 et suivantes.

Les statuts de la Société Absorbante ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 novembre 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 13 décembre 2012, sous le numéro 3017, pages 144810 et suivantes.

- La Société Absorbée
La société à responsabilité limitée Stora Enso S.à r.l. a son siège social 16 Avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-

Duché de Luxembourg et est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
67934.

La Société Absorbée a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg suivant un acte de Maître André-

Jean-Joseph Schwachtgen, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 23 décembre 1998,
et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 23 mars 1999, sous le numéro 194, pages 9287 et
suivantes.

Les statuts de la Société Absorbée ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Martine Schaeffer,

notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 5 novembre 2012, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations le 13 décembre 2012, sous le numéro 3016, pages 144763 et suivantes.

b) Date à laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant

réalisées pour le compte de la Société Absorbante

Les opérations de la Société Absorbée seront considérées, à des fins comptables, comme étant réalisées pour le compte

de la Société Absorbante à compter du 1 janvier 2015.

c) Droits conférés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux détenteurs de titres autres

que des parts sociales

Toutes les parts sociales de la Société Absorbée sont identiques et confèrent les mêmes droits et avantages à leurs

détenteurs de sorte qu'il n'y aura pas de droits spéciaux ou de compensations accordées à quiconque aux frais de la
Société Absorbante.

La Société Absorbée n'a pas émis de titres autres que des parts sociales dans le capital social de la Société qui sont

entièrement détenues par la Société Absorbante.

41929

L

U X E M B O U R G

d) Avantages spéciaux accordés aux experts mentionnés à l’article 266 de la Loi, aux membres des Conseils de Gérance

des Sociétés qui Fusionnent et aux autres personnes, (le cas échéant), mentionnées à l’article 261 (2) g) de la Loi

Ni les experts mentionnés à l’article 266 de la Loi, ni les membres des Conseils de Gérance et les autres personnes

(le cas échéant) mentionnées à l’article 261 (2) g) de la Loi, ne recevront d'avantages spéciaux en rapport avec ou à la
suite de la Fusion.

3. Conséquences de la fusion.
3.1 La Fusion déclenchera de plein droit toutes les conséquences mentionnées à l’article 274 de la Loi et en particulier,

à la suite de la Fusion, la Société Absorbée cessera d'exister et toutes les parts sociales émises seront annulées.

3.2 La Société Absorbante deviendra le propriétaire de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Date de

Prise d'Effet, sans possibilité de recours que ce soit envers la Société Absorbée.

3.3 La Société Absorbante devra s'acquitter, à la Date de Prise d'Effet, de tous les impôts, cotisations, droits et pré-

lèvements et les primes d'assurance qui sont ou peuvent devenir exigibles à l’égard de la propriété des actifs qui ont été
apportées.

3.4 A compter de la Date de Prise d'Effet, la Société Absorbante accomplira tous les accords et obligations que ce

soit, de la Société Absorbée.

3.5 Les droits et créances compris dans les actifs de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante

avec tous les titres, qu'ils soient réels ou personnels qui y sont attachés. La Société Absorbante est donc subrogée, sans
novation, dans tous les droits, qu'ils soient réels ou personnels, de la Société Absorbée à l’égard de tous les actifs et
envers tous les débiteurs, sans aucune exception.

3.6 La Société Absorbante supportera toutes les dettes et passifs de toute nature de la Société Absorbée. En particulier,

elle devra s'acquitter des intérêts et du principal de toutes les dettes et passifs de toute nature à la charge de la Société
Absorbée.

3.7 Tous les documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante

pour aussi longtemps que la Loi le prévoit.

3.8 Les mandats des membres du Conseil de Gérance de la Société Absorbée prendront fin à la Date de Prise d'Effet.

Décharge complète sera accordée aux membres du Conseil de Gérance de la Société Absorbée dans le cadre de l’exercice
de leurs fonctions.

3.9 Les mandats des membres du Conseil de Gérance de la Société Absorbante ne seront pas affectés à la suite de la

Fusion.

4. Dispositions supplémentaires.
4.1 Le coût de la Fusion incombera à la Société Absorbante.
4.2 Les soussignés s'engagent réciproquement à prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de réaliser la Fusion

conformément aux exigences légales et statutaires des Sociétés qui Fusionnent.

4.3 La Société Absorbante accomplira toutes les démarches nécessaires et requises à la réalisation de cette Fusion

ainsi qu'au transfert de l’ensemble des actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante.

4.4 Le(s) associé(s) de chacune des Sociétés qui Fusionnent auront le droit d'inspecter les documents suivants au siège

social desdites sociétés, au moins un mois avant la date des assemblées générales des associés qui seront convoquées afin
de se prononcer sur la Fusion:

- le projet commun de Fusion; et
- les comptes annuels des Sociétés qui Fusionnent des trois derniers exercices sociaux, le cas échéant.
Une copie des documents susmentionnés sera délivrée gratuitement sur demande d'un actionnaire.
4.6 Le présent document a été établi le 25 mars 2015 à Luxembourg, en original, afin d'être déposé au Registre du

Commerce et des Sociétés de Luxembourg et publié au Mémorial, un mois au moins avant la date des assemblées générales
des associé(s) de chacune des Sociétés qui Fusionnent appelées à se prononcer sur le projet de Fusion conformément à
l’article 262 de la Loi.

SIGNATURE PAGE TO THE JOINT MERGER PROPOSAL BETWEEN STORA LUXEMBOURG S.A R.L. AND STORA

ENSO S.A R.L.

Stora Luxembourg S.à r.l. / Stora Enso S.à r.l.
Scott McKINLAY
<i>Proxyholder

Référence de publication: 2015048022/218.
(150054992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 mars 2015.

41930

L

U X E M B O U R G

Golden Eagle Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: MXN 238.641.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 175.924.

In the year two thousand and fifteen, on the seventeenth day of March,
Before us, Maître Jean-Paul MEYERS, public notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

The company Toucan Investments Ltd., a corporation duly incorporated and existing under the laws of the Province

of Alberta, Canada, having its Corporate Access Number: 2017253051 and with its registered office at 450-1 

st

 Street

S.W., Calgary, Alberta T2P 5H1 (hereafter referred to as the "Sole Shareholder");

duly represented by Mrs. Laurie-Anne TAKERKART-WOLF, lawyer, professionally residing at 69, boulevard de la

Pétrusse, L-2320, Luxembourg, by virtue of proxy given under private seal in Calgary, dated 12 March 2015.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here above, asked the notary public to state that it is the sole shareholder

(“Sole Shareholder”), holding all the issued and existing thirty-eight thousand three hundred twenty-one (38,321) ordinary
shares ("Ordinary Shares") and the one hundred ninety-eight thousand nine hundred twenty (198,920) Class A mandatory
redeemable preferred shares (the "Class A MRPS"), representing the entire share capital of the company Golden Eagle
Energy S.à r.l., a private limited liability company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, registered
with the Trade and Companies' Register of Luxembourg under the number B 175.924, having its registered address at
L-1610 Luxembourg, 8-10 Avenue de la Gare, incorporated pursuant to a deed received by Me Carlo WERSANDT, public
notary on 27 February 2013, published on 16 May 2013 in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations), number 1154, page 55373 (hereinafter referred to as the “Company”).

The articles of the Company were amended for the last time pursuant to a deed received by the undersigned on 14

January 2015, published on 25 February 2015 in the official gazette (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations),
number 527, page 25265.

Such appearing party, represented as stated here above, in its capacity as Sole Shareholder of the Company, then asked

the notary public to state its resolutions as follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolved to increase the share capital of the Company by an amount of one million four hundred

thousand Mexican Pesos (MXN 1,400,000.-) to bring it from its present amount of two hundred thirty-seven million two
hundred forty-one thousand Mexican Pesos (MXN 237,241,000.-) represented by (i) thirty-eight thousand three hundred
twenty-one (38,321) Ordinary Shares with a nominal value of one thousand Mexican Pesos (MXN 1,000.-) each and (ii)
one hundred ninety-eight thousand nine hundred twenty (198,920) Class A MRPS with a nominal value of one thousand
Mexican Pesos (MXN 1,000.-) each, to the amount of two hundred thirty-eight million six hundred forty-one thousand
Mexican Pesos (MXN 238,641,000.-) represented by (i) thirty-eight thousand three hundred twenty-one (38,321) Ordi-
nary Shares with a nominal value of one thousand Mexican Pesos (MXN 1,000.-) each and (ii) two hundred thousand
three hundred twenty (200,320) Class A MRPS with a nominal value of one thousand Mexican Pesos (MXN 1,000.-) each.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolved to issue one thousand four hundred (1,400) Class A MRPS with a nominal value of one

thousand Mexican Pesos (MXN 1,000.-) each. The one thousand four hundred (1,400) new Class A MRPS shall be issued
with  an  aggregate  share  premium  of  one  hundred  thirty-eight  million  six  hundred  thousand  Mexican  Pesos  (MXN
138,600,000.-). The issued Class A MRPS will have the rights and obligations as described in the Company’s articles of
association.

<i>Subscription and payment

The Sole Shareholder declared subscribing for the newly issued Class A MRPS, and paying up such newly issued Class

A MRPS and attached aggregate share premium by a contribution in cash in the total amount of one hundred forty million
Mexican Pesos (MXN 140,000,000.-).

Evidence of the payment was brought to the notary public by a bank certificate confirming that the whole amount has

been made available to the Company.

The share premium paid on the newly issued Class A MRPS shall be booked in the Class A MRPS share premium

account (the "Class A MRPS Share Premium Account") specific to the Class A MRPS and such share premium shall remain
attached to the Class A MRPS.

41931

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolved to reduce the Class A MRPS Share Premium Account by an amount of one hundred

forty thousand Mexican Pesos (MXN 140,000.-) and to allocate such amount to the Company’s legal reserve account.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolved to amend the first sentence of article 5.1 of the Company’s articles of association,

which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The Company's share capital is set at two hundred thirty-eight million six hundred forty-one thousand Mexican

Pesos (MXN 238,641,000.-) divided into (i) thirty-eight thousand three hundred twenty-one (38,321) ordinary shares
("Ordinary Shares") and (ii) two hundred thousand three hundred twenty (200,320) Class A mandatory redeemable
preferred Shares (the "Class A MRPS........

<i>Estimate of costs

For  information  purposes  only,  the  amount  of  one  hundred  forty  million  Mexican  Pesos  (MXN  140,000,000.-)  is

equivalent to nine million ninety thousand seven hundred thirty-two United States Dollars (USD 9,090,732), based on
the exchange rate set by the Mexican central bank, Banco de Mexico, for payments to be made on 17 March 2015.

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately six thousand Euros.

<i>Power

The above appearing party(ies) hereby give(s) power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed with the registration, listing, deletion, publication or any other useful or necessary operations
following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo to this deed.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing party,

the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After having read the present deed to the proxy holder, acting as said before, the said proxy holder has signed with

us the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix-sept mars,
Par devant, Nous, Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

A COMPARU:

La société Toucan Investments Ltd., une société valablement constituée et existant sous les lois de la Province d’Al-

berta, Canada, ayant le numéro d’accès social 2017253051 et son siège social au c/o 450-1 

st

 Street S.W., Calgary, Alberta,

Canada, T2P 5H1 (ci-après l’"Associé Unique"),

Ici  dûment  représentée  par  Maître  Laurie-Anne  TAKERKART-WOLF,  avocate,  demeurant  professionnellement  à

L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Calgary, le 12
mars 2015.

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée comme décrite ci-dessus, a demandé au notaire de constater qu’elle est l’associé

unique détenant à elle seule les trente-huit mille trois cent vingt-et-une (38.321) parts ordinaires émises et existantes (ci-
après les "Parts Ordinaires") et les cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent vingt (198.920) parts privilégiées obligatoi-
rement rachetables de catégorie A (les "PPOR A"), représentant l’intégralité du capital social de la société Golden Eagle
Energy S.à r.l., une société à responsabilité limité constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 175.924, ayant
son siège social à L-1610 Luxembourg, 8-10 Avenue de la Gare, constituée par acte reçu de Maître Carlo WERSANDT,
notaire, le 27 février 2013, publié en date du 16 mai 2013 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1154, page 55373 (ci-après la "Société").

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire soussigné, le 15 janvier 2015, publié

en date du 25 février 2015 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 527, page 25265.

La prédite comparante, représentée comme décrit ci-dessus, en sa qualité d'associé unique de la Société, a requis le

notaire d'acter ses résolutions comme suit:

41932

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’Associé Unique a décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million quatre cent mille Pesos

Mexicains (MXN 1.400.000,-) pour le porter de son montant actuel de deux cent trente-sept millions deux cent quarante
et un mille Pesos Mexicains (MXN 237.241.000,-) représenté par (i) trente-huit mille trois cent vingt-et-une (38.321)
Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille Pesos Mexicains (MXN 1.000,-) chacune et, (ii) cent quatre-vingt-
dix-huit mille neuf cent vingt (198.920) PPOR A ayant une valeur nominale de mille Pesos Mexicains (MXN 1.000,-)
chacune, à un montant de deux cent trente-huit millions six cent quarante et un mille Pesos Mexicains (MXN 238.641.000),
représenté par (i) trente-huit mille trois cent vingt-et-une (38.321) Parts Ordinaires ayant une valeur nominale de mille
Pesos Mexicains (MXN 1.000,-) chacune et (ii) deux cent mille trois cent vingt (200.320) PPOR A ayant une valeur nominale
de mille Pesos Mexicains (MXN 1.000,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L’Associé Unique a décidé d’émettre mille quatre cents (1.400) PPOR A ayant chacune une valeur nominale de mille

Pesos Mexicains (MXN 1.000,-). Les mille quatre cents (1.400) PPOR A sont émises avec une prime d’émission d’un
montant total de cent trente-huit millions six cent mille Pesos Mexicains (MXN 138.600.000,-). Les PPOR A nouvellement
émises auront les droits et obligations décrits aux statuts de la Société.

<i>Souscription et paiement

L’Associé Unique a déclaré souscrire aux PPOR A nouvellement émises et payer ces PPOR A et la prime d’émission

rattachée  par  un  apport  en  numéraire  d’un  montant  total  de  cent  quarante  millions  de  Pesos  Mexicains  (MXN
140.000.000,-).

Il résulte de la souscription et du paiement ci-dessus que le montant total est à la libre disposition de la Société ainsi

qu’il l’a été prouvé au notaire instrumentant par un certificat bancaire.

La prime d’émission payée en relation avec les PPOR A nouvellement émises sera comptabilisée dans le compte de

prime d’émission des PPOR A (ci-après le "Compte de Prime d’Emission des PPOR A") spécifique à la catégorie des PPOR
A et cette prime d’émission restera rattachée aux PPOR A.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique a décidé de réduire le Compte de Prime d’Emission des PPOR A d'un montant de cent quarante

mille Pesos Mexicains (MXN 140.000,-) et d’allouer ce montant au compte de la réserve légale de la Société.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique a décidé de modifier la première phrase de l’article 5.1 des statuts de la Société qui aura la teneur

suivante:

5.1. Le capital social est fixé à deux cent trente-huit millions six cent quarante et un mille Pesos Mexicains (MXN

238.641.000) représenté par (i) trente-huit mille trois cent vingt-et-une (38.321) parts ordinaires (ci-après les "Parts
Ordinaires"), et (ii) deux cent mille trois cent vingt (200.320) parts privilégiées obligatoirement rachetables de catégorie
A (ci-après les "PPOR A")."

<i>Estimation des frais

A titre d’information uniquement, le montant de cent quarante millions de Pesos Mexicains (MXN 140.000.000,-) est

équivalent à neuf millions quatre-vingt-dix mille sept cent trente-deux Dollars Américains (USD 9.090.732), sur base du
taux de change fixé par la Banque Centrale de Mexico pour les paiements au 17 mars 2015.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

en raison de la présente sont estimés à approximativement six mille euros.

<i>Pouvoirs

Le(s) comparant(s) donne(nt) par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné,

agissant individuellement, afin de procéder à l’enregistrement, l’immatriculation, la radiation, la publication ou toutes
autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger,
ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au présent acte.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais déclare qu’à la requête de la partie comparante, le présent acte a

été établi en anglais, suivi d’une version française. A la requête de la même partie comparante, et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, ledit mandataire a

signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Laurie-Anne TAKERKART-WOLF, Jean-Paul Meyers.

41933

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 18 mars 2015. Relation: DAC/2015/4534. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 26 mars 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015047054/168.
(150054179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

IK Investment Partners VII A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 166.977.

In the year two thousand fifteen, on the sixteenth of March.
Before Maître Danielle KOLBACH, notary public residing at Rédange, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of “IK Investment Partners VII A S.à r.l.”, (here after the “Com-

pany”),  a  “société  à  responsabilité  limitée”,  having  its  registered  office  at  412F,  route  d'Esch,  L-2086  Luxembourg,
incorporated pursuant a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, on January 18 

th

 , 2012,

published at the Mémorial C, Recueil des Associations et des Sociétés de Luxembourg n°861 of April 2 

nd

 , 2012, registered

with the Trade and Register Companies of Luxembourg B 166.977,

which articles have been amended for the last time by deed enacted on March 26 

th

 , 2014, published in the Mémorial

C, Recueil des Associations et des Sociétés de Luxembourg, n°1484 of June 10 

th

 , 2014.

The meeting is opened at 11.00 a.m., with Mrs. Catherine DESSOY, “avocat à la Cour”, residing professionally at

L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich in the chair.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs. Véronique PETIT, “employée privée”,

residing professionally at L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich The chairman requests the notary to record that:

I. The shareholders present or represented and the number of shares held by them is shown on an attendance list

which will be signed and here annexed as well as the proxy and registered with the minutes.

II. As appears from the attendance list, all the 152,000 (one hundred and fifty-two thousand) shares, representing the

whole capital of the corporation, are represented and the shareholders represented declare that they have had notice
and knowledge of the agenda prior to this meeting, and agree to waive the notices requirements.

III. The present meeting is duly constituted and can therefore validly deliberate on the following agenda:

<i>Agenda:

1. Reduction of the Company’s share capital by an amount of 1,911.80 EUR (one thousand nine hundred eleven euros

and eighty cents) in order to lower it from its present amount of 15,200 EUR (fifteen thousand two hundred euros) down
to 13,288.20 EUR (thirteen thousand two hundred eighty-eight euros twenty cents) by cancellation of a total of 15,725
(fifteen thousand seven hundred twenty-five) Class A Shares and 3,393 (three thousand three hundred ninety-three) Class
B to Class J (inclusive) Shares of a nominal value of 0.10 EUR (zero point ten euro) each;

2. Amendment of article 5 of the Articles of Association.
3. Miscellaneous.
After deliberation, the Meeting unanimously resolved to adopt the following resolutions:

<i>First resolution:

The meeting decides to decrease the Company’s share capital by an amount of 1,911.80-EUR (one thousand nine

hundred eleven euros and eighty cents) in order to lower it from its present amount of 15,200.- EUR (fifteen thousand
two hundred euros) down to 13,288.20 EUR (thirteen thousand two hundred eighty-eight euros twenty cents) by can-
cellation of a total of 15,725 (fifteen thousand seven hundred twenty-five) Class A Shares and 3,393 (three thousand three
hundred ninety-three) Class B to Class J (inclusive) Shares of a nominal value of 0.10-EUR (zero point ten euro) each,
currently held by the Company.

<i>Second resolution:

Following the aforesaid resolution, the meeting decides to amend first paragraph of article 5 of the Articles of Asso-

ciation of the Company, as follows:

41934

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at 13,288.20 EUR (thirteen thousand two hundred

eighty-eight euros twenty cents) divided into 132,882 (one hundred thirty-two thousand eight hundred eighty-two) Shares
with a nominal value of 0.10 EUR (zero point ten euro) each, which are divided into:

- 109,275 (one hundred nine thousand two hundred seventy-five) class A shares (the “Class A Shares”), all subscribed

and fully paid up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class B shares (the “Class B Shares”), all subscribed and fully paid

up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class C shares (the “Class C Shares”) all subscribed and fully paid

up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class D shares (the “Class D Shares”), all subscribed and fully paid

up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class E shares (the “Class E Shares”), all subscribed and fully paid up;
- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class F shares (the “Class F Shares”), all subscribed and fully paid up;
- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class G shares (the “Class G Shares”), all subscribed and fully paid

up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class H shares (the “Class H Shares”), all subscribed and fully paid

up;

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class I shares (the “Class I Shares”), all subscribed and fully paid up;

and

- 2,623 (two thousand six hundred twenty-three) class J shares (the “Class J Shares”), all subscribed and fully paid up.”

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a

result of the present deed, are estimated at approximately one thousand five hundred euros (EUR 1,500.-).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 11.15 a.m.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing person, the mandatory signed with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le seize mars.
Par devant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

soussignée.

Se réunit

l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "IK Investment Partners VII A

S.à r.l." (ci-après «la Société»), ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, le 18 janvier 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Associations et des Sociétés de Luxembourg n°861 le 2 avril 2012, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg B 166.977,

dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Joseph ELVINGER, alors notaire

de résidence à Luxembourg, le 26 mars 2014, publié au Mémorial C n° 1484 du 10 juin 2014.

La séance est ouverte à 11.00 heures et présidée par Maître Catherine DESSOY, avocat à la Cour, demeurant pro-

fessionnellement à L-1461 Luxembourg, 31, rue d’Eich, La présidente désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit
comme scrutateur Madame Véronique PETIT, employée privée, demeurant professionnellement à L-1461 Luxembourg,
31, rue d’Eich.

La présidente prie le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts qu’ils détiennent est renseigné sur une liste de présence,

qui sera signée, ci-annexée ainsi que la procuration, le tout enregistré avec l’acte.

II. Il appert de la liste de présence que toutes les 152.000 (cent cinquante deux mille) parts sociales, représentant

l’intégralité du capital social sont représentées à la présente assemblée et que les associés représentés reconnaissent
avoir eu connaissance de l’ordre du jour avant la présente assemblée; il a pu donc être fait abstraction des convocations
d'usage.

III. La présente assemblée est dûment constituée et peut dès lors valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant:

41935

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour:

1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de 1.911,80 EUR (mille neuf cent onze euros et quatre-

vingt cents) pour le porter de son montant actuel de 15.200 EUR (quinze mille deux cents euros) à 13.288,20 EUR (treize
mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt cents) par annulation de 15.725 (quinze mille sept cent vingt-cinq) Parts
Sociales de Classe A et 3.393 (trois mille trois cent quatre-vingt-treize) Parts Sociales de Classe B à J (inclus) d'une valeur
nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) chacune;

2. Modification de l’article 5. des Statuts.
3. Divers.
Après avoir délibéré, l’Assemblée prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

L'assemblée décide de diminuer le capital social à concurrence d'un montant de 1.911,80 EUR (mille neuf cent onze

euros et quatre-vingt cents) pour le porter de son montant actuel de 15.200 EUR (quinze mille deux cents euros) à
13.288,20 EUR (treize mille deux cent quatre-vingt huit euros et vingt cents) par annulation de 15.725 (quinze mille sept
cent vingt-cinq) parts sociales de classe A et 3.393 (trois mille trois cent quatre-vingt-treize) parts sociales de classe B à
J (inclus) d'une valeur nominale de 0,10- EUR (dix cents d’euros) chacune actuellement détenues par la Société.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution précédente, l’assemblée décide de modifier le premier paragraphe de l’article 5 des

statuts de la Société, comme suit:

« Art. 5. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à la somme de 13.288,20 EUR (treize mille deux cent

quatre-vingt huit euros et vingt cents) représenté par 132.882 (cent trente deux mille huit cent quatre-vingt deux) Parts
Sociales entièrement souscrites et libérées d'une valeur nominale de 0,10 EUR (dix cents d’euros) chacune, divisées en:

- 109.275 (cent neuf mille deux cent soixante-quinze) Parts Sociales de Classe A (les «Parts Sociales de Classe A»)

d'une valeur nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe B (les «Parts Sociales de Classe B») d'une valeur

nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe C (les «Parts Sociales de Classe C») dune valeur

nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe D (les «Parts Sociales de Classe D») dune valeur

nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe E (les «Parts Sociales de Classe E») dune valeur nominale

de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe F (les «Parts Sociales de Classe F») dune valeur nominale

de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe G (les «Parts Sociales de Classe G») dune valeur

nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe H (les «Parts Sociales de Classe H») dune valeur

nominale de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe I (les «Parts Sociales de Classe I») dune valeur nominale

de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;

- 2.623 (deux mille six cent vingt-trois) Parts Sociales de Classe J (les «Parts Sociales de Classe J») dune valeur nominale

de 0.10 EUR (dix cents d’euros) toutes souscrites et intégralement libérées;»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille cinq cents euros (1.500,- EUR).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 11.15 heures.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Et après lecture faite aux comparantes, elles ont toutes signé avec le Notaire la présente minute.
Signé: C.DESSOY, V.PETIT, D.KOLBACH.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils le 19 mars 2015. Relation: DAC/2015/4549. Reçu soixante-quinze euros (EUR

75,-).

<i>Le Receveur (signé): J.THOLL.

41936

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur sa demande.

Redange-sur-Attert, le 24 mars 2015.

Référence de publication: 2015045868/157.
(150052396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2015.

Europa Mallard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 770.150,00.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.355.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.
before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED

1. Europa Real Estate II S.à r.l., a société à responsabilité limitée (a private limited liability company), incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse,
L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number B 103.095;

2. Europa Real Estate II US S.à r.l., a société à responsabilité limitée (a private limited liability company), incorporated

and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under number B 103.096;

both companies are here represented by:
Mr Eric BIREN, company director, with professional address at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg,
acting in his capacity as member of the board of managers of both companies, with individual signing power.
3. KAZIMINGI Properties Ltd., a private limited liability company incorporated under the laws of the Isle of Man, having

its registered office at 62 Bucks Road, Douglas, Isle of Man IM1 3AE and registered with the Financial Supervision Com-
mission, Isle of Man under company registration number 117220C,

hereby represented by Mr Eric BIREN, previously named, by virtue of a proxy, hereto annexed.
Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of "Europa Mallard S.à r.l.", a société à responsabilité

limitée, governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 68-70, boulevard de la
Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under registration number B 112.355, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 28
November 2005 (the "Articles") published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), no. 434
on 28 February 2006 (the "Company"). The Articles of the Company were last amended by a deed of the undersigned
notary on 1 December 2011 and published in Mémorial C, no. 577 on 05 March 2012.

The appearing parties representing the whole corporate capital require the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to dissolve and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to fix the number of liquidators at one (1) and further resolves to appoint as sole liquidator

of the Company:

“SIGNES S.A.”, a public limited company (“société anonyme”) organized and existing under the Luxembourg law with

its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under section B number 46.251.

<i>Third resolution

The shareholders resolve to determine the powers of the liquidator in respect to the liquidation of the Company as

follows:

- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the General Meeting of
Partners in the cases provided for by law.

- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory, and the liquidator may refer to the books of

the Company.

- The liquidator may, under its own responsibility and for particular and specific acts, delegate to one (1) or several

third persons, who will act as its proxies, a part of its powers it determines and for the period it fixes.

41937

L

U X E M B O U R G

- Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorized and empowered to make at any time, in one

part or in several parts, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le dix-neuf mars.
Par-devant nous Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU

1. Europa Real Estate II S.à r.l., une société à responsabilité limitée (private limited liability company), constituée et

existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 103.095;

Europa Real Estate II US S.à r.l., une société à responsabilité limitée (private limited liability company), constituée et

existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 103.096;

les deux sociétés sont ici représentées par:
Monsieur Eric BIREN, administrateur de sociétés, avec adresse professionnelle au 68-70, boulevard de Pétrusse, L-2320

Luxembourg,

agissant en sa qualité de gérant des deux sociétés prénommées avec pouvoir de signature individuelle.
2. KAZIMINGI Properties Ltd., une private limited liability company constituée sous les lois de l’Ile de Man, ayant son

siège social au 62 Bucks Road, Douglas, Ile de Man IM1 3AE and immatriculée auprès du Financial Supervision Commission,
Isle of Man sous le numéro d'immatriculation 117220C.

ici représentées par Monsieur Eric BIREN, prénommé, en vertu d’une procuration, ci-annexée.
Lesquelles parties comparantes sont les associés (les "Associés") de "Europa Mallard S.à r.l.", une société à responsa-

bilité  limitée  régie  par  le  droit  luxembourgeois,  ayant  son  siège  social  au  68-70,  boulevard  de  la  Pétrusse,  L-2320
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 112.355, constituée en vertu d'un acte du notaire soussigné en date du 28 novembre 2005 (les
"Statuts") publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"), no. 434 le 28 février 2006 (la
"Société"). Les Statuts ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné le 1 

er

décembre 2011, publié au Mémorial C, no. 577 le 5 mars 2012.

Les comparantes représentant l’intégralité du capital social requièrent le notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de fixer le nombre de liquidateurs à un (1) et de nommer comme liquidateur unique de la Société:
«SIGNES S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au 68-70, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
46.251.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de déterminer les pouvoirs du liquidateur, dans le cadre de la liquidation de la Société, comme

suit:

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale des
Associés dans les cas prévus par la loi.

- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux livres de la Société.

41938

L

U X E M B O U R G

- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations particulières et spécifiques, déléguer à une ou plusieurs

tierces personnes, qui agiront comme son mandataire, telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la période
qu’il fixera.

- Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu’il juge appropriée, conformément toutefois aux dispositions de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le

présent acte est dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par ses noms,

prénoms usuels, états et demeures, ils ont signés avec le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2015. Relation: EAC/2015/6866. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015046997/119.
(150053710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Europa Presov Park S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 114.226.

In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of March.
before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

(1) “Europa Real Estate II S.à r.l.”, a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its

registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce under number B 103 095, here represented by Mr Eric BIREN, company director, with professional address
in 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, acting in his capacity as member of the board of managers,

(2) “Europa Real Estate II US S.à r.l.”, a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having

its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Commerce under number B 103 096, here represented by Mr Eric BIREN, previously named, acting in his capacity as
member of the board of managers,

(3) “Europa Capital S.à r.l.”, a limited liability company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered

office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with Luxembourg Register of Commerce under
number B 103 537, here represented by Mr Eric BIREN, previously named, acting in his capacity as member of the board
of managers,

The above named persons are all the shareholders of “Europa Presov Park S.à r.l.”, a ‘société à responsabilité limitée’

with registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce under number B 114 226 (the “Company”), incorporated on 9 February 2006 pursuant to a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 911 of 10 May 2006. The
articles of association of the Company have been amended for the last time on 28 December 2011, by a deed of the
undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 577 of 05 March 2012.

The appearing parties, represented as mentioned here above, and representing the whole corporate capital required

the undersigned notary to act the following resolutions:

<i>First resolution

The shareholders resolve to dissolve and to put the Company into liquidation.

<i>Second resolution

The shareholders resolve to fix the number of liquidators at one (1) and further resolves to appoint as sole liquidator

of the Company:

“SIGNES S.A.”, a public limited company (“société anonyme”) organized and existing under the Luxembourg law with

its registered office at 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under section B number 46.251.

41939

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The shareholders resolve to determine the powers of the liquidator in respect to the liquidation of the Company as

follows:

- The liquidator is vested with the broadest powers provided by the articles 144 and following of the law of August

10, 1915 on commercial companies, as amended, without having to ask for authorization of the General Meeting of
Partners in the cases provided for by law.

- There shall be no obligation for the liquidator to draw up an inventory, and the liquidator may refer to the books of

the Company.

The liquidator may, under its own responsibility and for particular and specific acts, delegate to one (1) or several third

persons, who will act as its proxies, a part of its powers it determines and for the period it fixes.

- Out of the net proceeds of the liquidation, the liquidator is authorized and empowered to make at any time, in one

part or in several parts, such distributions in cash as it deems fit, in accordance however with the provisions of the law
of August 10, 1915 on commercial companies, as amended.

Whereof this deed was drawn up in Luxembourg on the date set at the beginning of this deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the appearing person,

this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

This deed having been read to the appearing person, known to the notary by first and surnames, civil status and

residence, said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du procès-verbal qui précède:

L’an deux mille quinze, le dix-neuf mars.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire résidant à Sanem (Grand-Duché de Luxembourg).

Ont comparu:

(1) Europa Real Estate II S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103095, ici représentée par Monsieur Eric BIREN, dirigeant de
société, demeurant professionnellement au 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, en tant que gérant avec
pouvoir de signature individuelle,

(2) Europa Real Estate II US S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxem-

bourgeois, ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103096, ici représentée par Monsieur Eric BIREN,
prénommé, en tant que gérant avec pouvoir de signature individuelle,

(3) Europa Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée conformément au droit luxembourgeois,

ayant son siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 103537, ici représentée par Monsieur Eric BIREN, prénommé,
en tant que gérant avec pouvoir de signature individuelle,

Les comparants sont les seuls Associés de «Europa Presov Park S.à r.l.», une société à responsabilité limitée ayant son

siège social au 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 114 226 (la “Société”), constituée suivant acte du notaire instrumentaire le 9 février
2006, publiée au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 911 le 10 mai 2006. Les statuts ont été
modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 28 décembre 2011, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 577 du 05 mars 2012.

Les associés prénommés de la Société, représentant l’intégralité du capital de la Société, requièrent désormais le notaire

instrumentaire de prendre acte des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les Associés décident la dissolution et la mise en liquidation de la Société.

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident de fixer le nombre de liquidateurs à un (1) et de nommer comme liquidateur unique de la Société:
«SIGNES S.A.», société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est sis au 68-70, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro
46.251.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de déterminer les pouvoirs du liquidateur, dans le cadre de la liquidation de la Société, comme

suit:

41940

L

U X E M B O U R G

- Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle que modifiée, sans devoir recourir à l’autorisation préalable de l’Assemblée Générale des
Associés dans les cas prévus par la loi.

- Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s’en référer aux livres de la Société.
- Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations particulières et spécifiques, déléguer à une ou plusieurs

tierces personnes, qui agiront comme son mandataire, telle partie de ses pouvoirs qu’il déterminera et pour la période
qu’il fixera.

- Des bénéfices nets de la liquidation, le liquidateur est autorisé à effectuer, à tout moment, en une ou plusieurs fois,

toute distribution en espèces qu’il juge appropriée, conformément toutefois aux dispositions de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des personnes comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes
personnes comparantes, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux personnes comparantes, connues du notaire instrumentaire par

leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, elle a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: E. BIREN, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 mars 2015. Relation: EAC/2015/6865. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2015046998/111.
(150053684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 mars 2015.

Participation Hispanolux GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 137.480.

Suite au transfert des 125 parts sociales de Monsieur Jan SIMON à Madame Stefanie WEISSE, Madame WEISSE détient

maintenant 250 parts sociales de la société.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Participation Hispanolux GmbH
Signatures

Référence de publication: 2015031359/13.
(150034579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Redalpine Venture Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 130.663.

Die Bilanz zum 30. Juni 2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. Juni 2012 abgelaufene Geschäftsjahr

wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 19. Februar 2015.

<i>Für Redalpine Venture Partners S.à r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015031384/13.
(150034432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Speed World Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4831 Rodange, 146, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 52.990.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031447/9.
(150034634) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41941

L

U X E M B O U R G

Day Dream SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 40.325.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031694/9.
(150035554) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 164.690.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, Mme. Katherine Margaret Ralph et M. Franck Laval avec

effet du 31 janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg OPPS VIIIb Sàrl

Référence de publication: 2015031334/13.
(150034879) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg OPPS VIII Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.300.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, Mme. Katherine Margaret Ralph et M. Franck Laval avec

effet du 31 janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg OPPS VIII Blocker Sàrl

Référence de publication: 2015031333/13.
(150034856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

PETOSEVIC Group, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 149.107.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031365/10.
(150034408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

EDEN LogCenter INTERNATIONAL Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 121.921.

Les comptes annuels au 31 octobre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031732/9.
(150035735) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41942

L

U X E M B O U R G

Foca Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 131.810.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031758/9.
(150035516) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

GECGE Kosik Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 4.941.400,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 12-14, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 99.877.

Il résulte d'une résolution des associés prise en date du 1 

er

 octobre 2014 que:

- Monsieur Pierre DECLA a démissionné de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 octobre 2014,

-  Est  nommé  nouveau  gérant  pour  une  durée  indéterminée  Monsieur  Laurent  MUSIELAK  demeurant  à  D-60313

Frankfurt, Bleichstrasse 64.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015031782/14.
(150035166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

GFRI 2010 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.994.

RECTIFICATIF

<i>Extrait sur dépôt numéro L110144684 du 7 septembre 2011

Le dépôt L110144684 du 7 septembre 2011 mentionne, entre autre, que M. Hermann Moors, ayant pour adresse

professionnelle 240, rue de Luxembourg, L-2324 Luxembourg, est nommé en tant que gérant de la Société.

Or, il convient de modifier son adresse comme suit: 240, route de Luxembourg, L-8077 Bertrange.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015031787/15.
(150035355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Kalchesbruck S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 76.354.

Il résulte de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 08 janvier 2015 que:
Le mandat de réviseur d'entreprises de H.R.T. Révision S.A. avec adresse professionnelle 163, rue du Kiem, L-8030

Strassen, est reconduit jusqu'à la l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre
2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031846/13.
(150035195) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41943

L

U X E M B O U R G

Knaf-Buchler succ. Hans Adam Oeltges, s.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6315 Beaufort, 3, rue de l'Ecole.

R.C.S. Luxembourg B 99.932.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Knaf-Buchler succ. Hans Adam Oeltges, s.àr.l.
S.à.r.l. unipersonnelle
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA

Référence de publication: 2015031845/12.
(150035388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Safari Luxco 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.062.

Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 13 février 2015, les actionnaires ont décidé de renouveler le

mandat de réviseur d'entreprises agréé de PricewaterhouseCoopers, avec siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182
Luxembourg, pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de
l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2015.

Référence de publication: 2015031406/13.
(150034830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Shinkin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 142.391.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, et Mme. Katherine Margaret Ralph avec effet du 31

janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Shinkin Investments Sàrl

Référence de publication: 2015031410/13.
(150034421) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

London Acquisition Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 683.654,84.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46a, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 133.574.

Veuillez prendre note du changement suivant:
- L'associé Barons Financial Services Limited ayant désormais pour adresse professionnelle bâtiment Williams House,

20 Reid Street, Hamilton HM 11, Bermudes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Robert Jan Schol
<i>Gérant

Référence de publication: 2015031221/14.
(150034335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41944

L

U X E M B O U R G

Abelton Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 121.731.

En date du 4 février 2015, la Société a désigné la société SGG S.A., ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg, comme dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à
l'immobilisation des actions et des parts au porteur.

Certifié sincère et conforme
ABELTON INVEST S.A.
Signatures
<i>Administrateur/ Administrateur

Référence de publication: 2015030943/14.
(150034285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg Seraphina S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 170.235.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et Mme. Katherine Margaret Ralph avec effet du 31

janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg Seraphina Sàrl

Référence de publication: 2015030664/13.
(150033907) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.

Karolux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6183 Gonderange, 4, rue Hiel.

R.C.S. Luxembourg B 161.902.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031204/10.
(150034393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Blue Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 172.772.

La Société a été constituée à Luxembourg suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-

Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 22 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 3010 du 12 décembre 2012.

Les comptes annuels de la Société au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Blue Holdings
Signatures

Référence de publication: 2015032202/15.
(150036092) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

41945

L

U X E M B O U R G

ACTIVE 21 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9044 Ettelbruck, 16, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 161.060.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015031558/10.
(150035337) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Advanced Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 60.159.

<i>Rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2011 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 janvier

<i>2014 sous le n° L140004622

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031560/11.
(150035281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Azurestia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8151 Bridel, 51A, rue de Schoenfels.

R.C.S. Luxembourg B 157.054.

Il est signalé que l'adresse de Mme Sylvie RODRIGUES, gérante et associée de la société AZURESTIA Sàrl, est doré-

navant 51-A, rue de Schoenfels à L-8151 Bridel.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031554/10.
(150035054) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 160.687.

Le Bilan et l’affectation du résultat au 31 Août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 Février 2015.

Sébastien Rimlinger
<i>Gérant A

Référence de publication: 2015031552/13.
(150035503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Slova S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 146.493.

Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015031439/12.
(150034185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41946

L

U X E M B O U R G

CEREP Italy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 86.846.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 février 2015.

Référence de publication: 2015031658/10.
(150034995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

DG-Immo-Invest GmbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6688 Mertert, 1, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 151.061.

Les comptes annuels au 31/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031699/9.
(150035021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Domexus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 95.850.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Signatures

Référence de publication: 2015031702/12.
(150035185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

DKHB Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1242 Luxembourg, 3, rue des Bleuets.

R.C.S. Luxembourg B 172.571.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

SG AUDIT SARL

Référence de publication: 2015031701/11.
(150035103) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Confer Partnership, S.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 127.464.

Veuillez noter que l'associé Confer S.à r.l. a désormais son siège social au 121, avenue de la Faïencerie, L - 1511

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015031684/11.
(150035566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41947

L

U X E M B O U R G

CEREP II Investment Fifteen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 128.647.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031660/10.
(150035066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

CEREP II Investment Ten S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 126.036.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031661/10.
(150035065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

CEFO-P, Cie Européenne Financière OMEGA de Participation, Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 108.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour CIE EUROPEENNE FINANCIERE OMEGA DE PARTICIPATION
En abrégé (CEFO-P)

Référence de publication: 2015031627/11.
(150035557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 118.380.

Les comptes annuels au 30 juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031626/10.
(150035064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

BBH Luxembourg Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécia-

lisé.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 143.956.

Le Bilan au 31 octobre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 février 2015.

Référence de publication: 2015031603/11.
(150035430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41948

L

U X E M B O U R G

Advanced Research S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7243 Bereldange, 22-24, rue du X Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 60.159.

<i>Rectificatif du dépôt du bilan au 31 décembre 2012 déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 9 janvier

<i>2014 sous le n° L140004621

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031561/11.
(150035314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Boldam S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 78.954.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
BOLDAM S.A.

Référence de publication: 2015031614/11.
(150035204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 182.164.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 février 2015:

- M. Gilles Jacquet, employée privé, avec adresse professionnelle au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, a

démissionné de ses fonctions de gérante de classe A de la société avec effet au 19 février 2015.

- Nomination de M. Sean Murray , résidant professionnellement au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, né le

21 décembre 1976, Tipperary, Irlande en qualité de gérant de classe A avec effet au 19 février 2015 et pour une durée
indéterminée.

Le conseil de gérance se compose dorénavant comme suit:
- M. Onno Bouwmeister, gérant de classe A
- M. Sean Murray, gérant de classe A
- M. Jonathan Petit, gérant de classe B
- M. Fabrice de Clermont-Tonnerre, gérant de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015031623/20.
(150035299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Rege Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 50, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 158.226.

EXTRAIT

Il résulte de la décision du Conseil d'Administration tenu en date du 18 février 2015 que la société LuxGlobal Trust

Services S.A., 50, rue Charles Martel L-2134 Luxembourg, Professionnel du Secteur Financier, est nommé dépositaire
des actions au porteur de la société avec date effective au 18 février 2015 conformément à l'article 42 de la loi modifiée
du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Référence de publication: 2015031394/12.
(150034266) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41949

L

U X E M B O U R G

S&amp;B Minerals Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 178.488.

Statuts  coordonnés  rectifiés  déposés  au  registre  de  commerce  et  des  sociétés  de  Luxembourg,  le  5  août  2013

L130147492.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Belvaux, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031403/11.
(150034365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Portman Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 45.632,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.103.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 février 2015.

Référence de publication: 2015031370/11.
(150034695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

BMV Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 158.175.

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers, que l'adresse du siège social de l'associé unique, Serenity Hospitality Group

S.A., est située au 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 17 février 2015.

Référence de publication: 2015031613/14.
(150034975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Bioclina Belux Systèmes de Chauffage et de Rafraîchissement Intégré S.à r.l., Société à responsabilité

limitée.

Siège social: L-9749 Fischbach, 7, Z.I. Giällewee.

R.C.S. Luxembourg B 160.326.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour ordre
Belux comptafisc S.àR.L.
Rue du Moulin à vent, 28
9541 WILTZ

Référence de publication: 2015031610/14.
(150035168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

41950

L

U X E M B O U R G

Renex Management Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 174.108.

La convention de Domiciliation concernant la société Renex Management Company S.à r.l. ayant son siège social au

19-21 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg a été dénoncée avec effet en date du 10/02/2015 par la société
Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.
Société Anonyme
Signature

Référence de publication: 2015031386/13.
(150034423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 121.877.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 18 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, Mme. Katherine Margaret Ralph et M. Franck Laval avec

effet du 31 janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg OPPS VI Sàrl

Référence de publication: 2015031332/13.
(150034235) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 143.132.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 19 février 2015

L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren, Mme. Katherine Margaret Ralph et M. Franck Laval avec

effet du 31 janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker Sàrl

Référence de publication: 2015031331/13.
(150034613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Nile Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: SEK 20.597.240,00.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 178.638.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique en date du 10 Février 2015

L'Associé unique de la Société a décidé comme suit:
- de nommer Andrea Neuböck-Escher, née le 04 mars 1982 à Bad Ischl (Autriche) et résidant professionnellement au

23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg, aux fonctions de gérante de la Société avec effet au 02 février 2015 et ce pour
une durée illimitée.

Luxembourg, le 20 Février 2015.

Référence de publication: 2015031303/14.
(150034723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

41951

L

U X E M B O U R G

Nextech IV GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 189.785.

Die Adresse des Teilhabers Herrn Thilo Schroeder hat sich geändert und lautet nunmehr wie folgt: Ottenweg 16,

CH-8008 Zürich, Schweiz.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, den 20. Februar 2015.

<i>Für Nextech IV GP S.à r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015031302/14.
(150034484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.

Redalpine Capital II GP S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 161.025.

Die Bilanz zum 31. Dezember 2012 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2012 abgelaufene

Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2015.

<i>Für Redalpine Capital II GP S.à r.l.
Ein Beauftragter

Référence de publication: 2015031989/13.
(150034952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 février 2015.

Almapa Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.634.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014, ainsi que les informations et documents annexes ont été déposés au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 février 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015032166/13.
(150036602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Alceco International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 18-20, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 75.444.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Julian ALEKSOV
<i>Administrateur-Délégué

Référence de publication: 2015032164/12.
(150036457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

41952


Document Outline

Abelton Invest S.A.

ACTIVE 21 S.A.

Advanced Research S.A.

Advanced Research S.A.

AI Silver S.A.

Alceco International S.A.

Almapa Holding S.A.

AutoZone Luxembourg Investments S.à r.l.

Azurestia S.à r.l.

BBH Luxembourg Funds

Bioclina Belux Systèmes de Chauffage et de Rafraîchissement Intégré S.à r.l.

Blue Holdings

BMV Partners S.à r.l.

Boldam S.A.

Catalyst EPF II Lux 1 S.à r.l.

CEREP II Investment Fifteen S.à r.l.

CEREP II Investment Ten S.à r.l.

CEREP Investment Parc de Seine S.à r.l.

CEREP Italy S.à r.l.

Cie Européenne Financière OMEGA de Participation

Confer Partnership, S.e.c.s.

Day Dream SA

DG-Immo-Invest GmbH

DKHB Investments S.à r.l.

Domexus S.A.

EDEN LogCenter INTERNATIONAL Alpha S.à r.l.

Electricité Nico May S.à r.l.

Europa Mallard S.à r.l.

Europa Presov Park S.à r.l.

Farenzena Jules Sàrl

Farenzena Jules Sàrl

Finite Management Sarl

Foca Investments S.A.

GECGE Kosik Investors S.à r.l.

GFRI 2010 S.à r.l.

Golden Eagle Energy S.à r.l.

IK Investment Partners VII A S.à r.l.

Kalchesbruck S.A.

Karolux S.A.

Knaf-Buchler succ. Hans Adam Oeltges, s.àr.l.

Knätsch S.à r.l.

Komaco International S.A.

L&amp;C LuxHoldCo Poland S.à r.l.

L.E.S.S. S.A.

London Acquisition Luxco S.à r.l.

Magnetar Solar Luxembourg S.à r.l.

MD Mezzanine Treasury Management S.à r.l.

Minerva Automobiles

Mokastar S.A.

Muno Charles et Fils S.àr.l.

Nadin-Lux S.A.

Naturmaart S.à r.l.

NaviTrans Schifffahrt S.à r.l.

Nextech IV GP S.à r.l.

Nile Luxembourg S.à r.l.

Noukbrit Holding S.A. SPF

OCM Luxembourg EPF III London Property Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg EPF III Procurement Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg EPF III QIF Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg EPF III RCF S.à r.l.

OCM Luxembourg EPF III Unicity Holdings S.à r.l.

OCM Luxembourg EPOF A S.à r.l.

OCM Luxembourg Flandre S.à r.l.

Ocm Luxembourg George Street Apart-Hotel S.à r.l.

OCM Luxembourg HHL Holdco IV S.à r.l.

OCM Luxembourg OPPS VI Blocker S.à r.l.

OCM Luxembourg OPPS VIII Blocker S.à r.l.

OCM Luxembourg OPPS VIIIb S.à r.l.

OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l.

OCM Luxembourg POF IV AIF (Delaware) S.à r.l.

OCM Luxembourg Seraphina S.à r.l.

OCM Luxembourg Yachts Holdings S.à r.l.

Oelschläger Properties International Inc.

O-Two S.A.

Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.

Participation Hispanolux GmbH

PETOSEVIC Group

Portman Group International S.à r.l.

Portofino Trust Inc.

Private Debt Treasury II Management S.à r.l.

Prointent S.à r.l.

RCV Lease S.à r.l.

Redalpine Capital II GP S.à r.l.

Redalpine Venture Partners S.à r.l.

Rege Investment S.A.

Renex Management Company S.à r.l.

Safari Luxco 2 S.A.

S&amp;B Minerals Finance S.C.A.

Shinkin Investments S.à r.l.

Slova S.A.

Speed World Group S.A.

Stora Enso S.à r.l.

Stora Luxembourg S.à r.l.

Unicity II Acton S.à r.l.

Unicity III Bournemouth S.à r.l.

Unicity IV BB S.à r.l.

WP International IV S.à r.l.

WP International V S.à r.l.