logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 761

19 mars 2015

SOMMAIRE

Andelle SA, SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36490

Apollo Investment Europe III Holdings

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36490

Artaxerxes S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36484

Avalon Immobilière SCI  . . . . . . . . . . . . . . . .

36486

Bâloise Fund Invest (Lux)  . . . . . . . . . . . . . . .

36484

Casada Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36482

Casa Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36482

CCP Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36487

Centre de Coiffure Paola S.à r.l.  . . . . . . . . .

36483

CETP III Advisor S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

36487

Chartinvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36487

Ciancone S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36486

CIEP I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36486

Comacchio International S.A.  . . . . . . . . . . .

36483

Dani Real Estate  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36488

Dashabo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36488

DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l.  . . . .

36489

Dekan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36487

Delight Industrial Holdings S.à r.l.  . . . . . . .

36485

Desroches S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36484

DGC Constructions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36484

Digital Services XLIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

36492

E.C.G. S.A., Expertise Comptable & Ges-

tion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36491

Ecopro Lux Cad Systems and Services s.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36485

Ecotrade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36491

Egerton Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36489

Eisbach S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36488

Enim S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36489

Equus Investment Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .

36491

Euroamerican Finance S.A.  . . . . . . . . . . . . .

36490

Euroleague Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

36491

Guidalpa S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36528

Memora 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36503

Mitco Real Estate A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

36525

Mitco Resolution 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36523

Mitco Resolution 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36521

Mitco Resolution 3 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36517

Mitco Resolution 4 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

36519

Neyoris,, S.e.n.c.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36527

Pfaudler Midco S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36512

Pine River Fixed Income Lux Investments

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36516

Taurus Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36482

Techvest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36482

The Calypso Alternative Fund . . . . . . . . . . .

36485

Trampolini Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . .

36485

United Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36483

36481

L

U X E M B O U R G

Techvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 177.075.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 31 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024654/12.
(150027379) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Taurus Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 142.149.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 6 février 2015

<i>(l'«Assemblée»)

L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au

14 décembre 2014,

L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet au 30

décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018:

- Mr Hinnerk Koch, né le March 1963, à Brême, Allemagne, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince

Henri, L-1724 Luxembourg.

À Luxembourg, le 6 février 2015.

Pour extrait conforme
<i>Pour la Société
Signatures

Référence de publication: 2015024651/19.
(150027968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Casada Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 3, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 30.638.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 15 décembre 2014 que:
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt,

L-2450 Luxembourg.

Luxembourg, le 12 février 2015.

<i>Pour la société CASADA HOLDING S.A.
FIDUCIAIRE FERNAND FABER

Référence de publication: 2015024860/14.
(150028996) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Casa Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 84.022.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024859/9.
(150028785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36482

L

U X E M B O U R G

United Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 130.585.

<i>Résolutions d'actionnaires du 08 Décembre 2014

Les actionnaires ont ensuite pris la résolution suivante, avec effet au 08 Décembre 2014:
(A) accepter la démission du administrateur actuel Monsieur Alexander TKACHENKO, né à Moscou (Russie), le 05

Février 1974, demeurant professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg;

(B) accepter la démission du administrateur actuel Monsieur Mikhail KISELEV, né à Moscou région (Russie), le 21

Décembre 1971, demeurant professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg;

(C) accepter la démission du administrateur actuel Madame Kristine VANAGA-MIHAILOVA, né à Riga (Lettonie), le

08 Août 1979, demeurant professionnellement au 4, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg;

(D) accepter la démission du EZD S.à r.l., Commissaire de la Société, avec effet immédiate;
(E) nommer la société BERFOLL S.R.O., ayant son siège social au Konevova 2660/141, Zizkov, 13000, Prague 3, Ré-

publique Tchèque, numéro de registre de commerce C 214468, représenté par madame Zuzana KRATENOVA ayant
adresse au Konevova 2660/141, Zizkov, 13000, Prague 3, République Tchèque, comme nouveaux administrateur avec
effet immédiate et ce pour une durée de six années;

(F) nommer Monsieur Diyar YAKUBOV, né à Khorezm région,(Ouzbekistan), le 21 octobre 1981, demeurant pro-

fessionnellement au 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, comme nouveaux administrateur avec effet immédiate et
ce pour une durée de six années;

(G) nommer Monsieur Yan MARKOVSKI, né à St.Petersburg (Russie), le 28 Décembre 1980, demeurant profession-

nellement au 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg, comme nouveaux administrateur avec effet immédiate et ce pour
une durée de six années;

(H) nommer la société WETRUST LUXEMBOURG S.A., ayant son siège a 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg,

comme nouveaux Commissaire de la Société, avec effet immédiate et ce pour une durée de six années;

(I) D'approuver et de ratifier le transfert du siège social de la Société de son adresse actuelle 4, rue Jean Engling, L-1466,

Luxembourg à 14a, rue des Bains, L-1212 Luxembourg

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présents.

Mr. Igor SHAMIS / Norwood Enterprises Limited
Mr. Martin KARTNER / Mr. Martin KARTNER
<i>Le mandataire / Le mandataire

Référence de publication: 2015024674/34.
(150027437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Centre de Coiffure Paola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 109, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 49.066.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 12 février 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015024870/10.
(150028816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Comacchio International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 113.337.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024890/10.
(150028614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36483

L

U X E M B O U R G

Bâloise Fund Invest (Lux), Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 80.382.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration de la Société en date du 30 janvier 2015

En date du 30 janvier 2015, le conseil d'administration de la Société a décidé de nommer Arendt Services S.A., une

société anonyme, constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à l'adresse
suivante: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B145917, en tant que dépositaire des Actions au Porteur de la Société, conformément à
l'article premier de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Baloise Fund Invest (Lux)
Signature

Référence de publication: 2015024780/18.
(150028287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Artaxerxes S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 159.633.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société AR-
TAXERXES S.A., SPF (B159633) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015024764/15.
(150028283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Desroches S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 63.288.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015024931/12.
(150028101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

DGC Constructions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4530 Differdange, 7, avenue Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 162.999.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024933/9.
(150028856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36484

L

U X E M B O U R G

The Calypso Alternative Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 103.128.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Maître Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxem-

bourg, en date du 30 janvier 2015, enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 3 février 2015, 2LAC/2015/2476, aux droits
de soixante-quinze euro (75,- EUR), que la société THE CALYPSO ALTERNATIVE FUND (en liquidation volontaire),
ayant son siège social à 20,Carré Bonn - Rue de la Poste, L-2346 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés sous le numéro B 103.128, constitué en date du 28 septembre 2004 par acte de Maître Jean-Joseph WAGNER,
notaire de résidence à Sanem, publié au Mémorial C, numéro 1002 du 8 octobre 2004.

La société a été mise en liquidation par acte du même notaire en date du 31 mars 2010, publié au Mémorial C, numéro

817 du 21 avril 2010.

Après avoir approuvé le rapport du liquidateur, l'assemblée générale décide en conséquence, de clôturer la liquidation

de la Société.

L'assemblée générale décide que les livres et documents de la Société seront gardés pendant cinq (5) ans à l'adresse

suivante: 20, Carré Bonn - rue de la Poste, L-2346 Luxembourg.

L'Assemblée décide en outre, que les sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux membres à qui la remise

n'était pas possible, seront déposés en mains tierces de la Caisse de Consignation du Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024657/25.
(150027415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Trampolini Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8052 Bertrange, 23, rue des Aubépines.

R.C.S. Luxembourg B 139.376.

Les comptes annuels au 31.12.2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015024660/9.
(150028051) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Delight Industrial Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.087.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024909/10.
(150028902) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ecopro Lux Cad Systems and Services s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1121 Luxembourg, 7, rue des Alouettes.

R.C.S. Luxembourg B 66.376.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 févr 2015.

Référence de publication: 2015024952/10.
(150028632) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36485

L

U X E M B O U R G

Avalon Immobilière SCI, Société Civile Immobilière.

Siège social: L-2733 Luxembourg, 6, rue Wiltheim.

R.C.S. Luxembourg E 5.260.

EXTRAIT

I/ Il ressort d'une convention de cession de parts exécutée en date du 2 février 2015 entre:
- Monsieur Georges Lentz, demeurant au 3, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg,
et,
- Monsieur Christoph Ehinger, demeurant au 6, rue Wiltheim, L-2733 Luxembourg,
que la totalité des parts sociales détenues par Monsieur Georges Lentz, ont été transférées à Monsieur Christoph

Ehinger.

II/ Il ressort d'une convention de cession de parts exécutée en date du 2 février 2015 entre:
- Monsieur Christoph Ehinger, demeurant au 6, rue Wiltheim, L-2733 Luxembourg,
et,
- Mademoiselle Camille Leblanc, demeurant au 6, rue Wiltheim, L-2733 Luxembourg,
qu'une (1) part sociale détenue par Monsieur Christoph Ehinger a été transférée à Mademoiselle Camille Leblanc.
Depuis lors, les associés de la Société sont les suivants:
- Monsieur Christoph Ehinger
- Mademoiselle Camille Leblanc
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.

Senningerberg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024733/25.
(150028159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

CIEP I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 179.307.

Il résulte d'un contrat d'apport en nature daté du 24 décembre 2014 que:
- Carlyle International Energy Partners, L.P. détenteur de 300,560 parts sociales de la Société;
- CIEP Co-Investment, L.P., détenteur de 30,628 parts sociales de la Société; et
- CIEP Co-Investment B, L.P., détenteur de 1,560 parts sociales de la Société
Ont vendu l'intégralité de leurs parts sociales de la Société à CIEP Participations S.à r.l. SICAR dont le siège social est

situé au 2 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

CIEP I S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015024879/17.
(150028333) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ciancone S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 123.604.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 5 février 2015

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège

social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme
CIANCONE S.A.

Référence de publication: 2015024878/12.
(150028977) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36486

L

U X E M B O U R G

CETP III Advisor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 185.068.

<i>Dépôt rectificatif au dépôt initial du 22 mai 2014 N° L140084698

Le numéro d'enregistrement du membre du conseil de gérance CETP III Managing GP Holdings, L.L.C., à l'Office of

the Secretary of State of the State of Delaware est le 1207278.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 février 2015.

CETP III Advisor S.à r.l.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015024871/14.
(150028319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

CCP Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.400,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 166.445.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la société CCP Holding S.à r.l. en date du 4 septembre 2014

que Monsieur Sigthor Sigmarsson, avec adresse professionnelle au 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a été
nommé gérant avec prise d'effet immédiate et ce pour une durée indéterminée.

Suite à cette décision, le Conseil de Gérance est composé comme suit:
- Jan Rottiers
- Sigthor Sigmarsson
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme,

Fait à Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024868/18.
(150028997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Chartinvest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 87.859.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 30 décembre 2014 à Luxembourg

Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET

INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015024876/12.
(150028087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Dekan, Société Européenne.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 109.200.

Le bilan au 30/09/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/2/2015.

Signature.

Référence de publication: 2015024928/10.
(150028402) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36487

L

U X E M B O U R G

Dashabo S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 38, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 26.505.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2014:

L'Assemblée appelle aux fonctions d'administrateur Monsieur Enzo LIOTINO, 38, Boulevard Joseph II, L-1840, Lu-

xembourg en remplacement de Madame Efthalia DASKALIDES, 103, Avenue du Prince Orange, B- 1180 Bruxelles.

Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.
Après en avoir délibéré, l'Assemblée Générale renomme:
- Madame Georgette DASKALIDES, avec adresse professionnelle au 347, Avenue Louise, B- 1050 Bruxelles, aux fonc-

tions d'Administrateur et Administrateur-Délégué;

- Monsieur Aloyse SCHERER, demeurant à 16, rue Dante, L-1412 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.
Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 dé-

cembre 2016.

L'Assemblée Générale renomme comme commissaire aux comptes:
- FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG, société anonyme, 38, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2016.

Luxembourg.

FIDUCIAIRE DE LUXEMBOURG
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2015024925/24.
(150028144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Dani Real Estate, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 174.112.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015

Il résulte de ce Conseil d'administration:
Conformément à l'article 42 des Lois Coordonnées sur les Sociétés commerciales du 10 août 1915 tel que modifié

par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration décide,
à l'unanimité, de nommer comme dépositaire des actions au porteur, la société «Fiduciaire Internationale SA», ayant son
siège social à L-1470 Luxembourg, 7 route d'Esch, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
34813 et représentée par son administrateur-délégué, Monsieur Stéphan MOREAUX.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015024923/15.
(150029101) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Eisbach S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 154.410.

Il résulte des résolutions du conseil d'administration du 11/02/2015:
Il est décidé nommer la société à responsabilité limité UNCOS, avec siège social à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents,

immatriculée au RCSL sous le numéro B141298, en tant que dépositaire légal des actions au porteur de la société EISBACH
S.A., SPF (B154410) et ceci en vertu de la loi du 28 juillet 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11/02/2015.

Pour extrait conforme
<i>Le Conseil d'administration

Référence de publication: 2015024955/15.
(150028309) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36488

L

U X E M B O U R G

Enim S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 154.676.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 février 2015 que:
- Madame Elena LATORRE, employée privée, née le 6 décembre 1975 à Luxembourg et demeurant professionnelle-

ment  au  10,  rue  Antoine  Jans  L-1820  Luxembourg,  a  été  nommée  administrateur  en  remplacement  de  Lexington
Governance Limited, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020.
- Les mandats des administrateurs Monsieur Pier Luigi RUGGERI, administrateur de sociétés, né le 25 février 1936 à

Paradiso (Suisse) et demeurant au 23, via Ruvigliana à CH-6900 Lugano et Madame Orietta RIMI, employée privée, née
le 29 septembre 1976 à Erice (Italie) et demeurant professionnellement au 10, rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg, ont
été renouvelés jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

- Monsieur Pier Luigi RUGGERI a été nommé Président du Conseil d'administration.
- Le mandat du Commissaire SER.COM S.à r.l., ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19 boulevard Grande-

duchesse Charlotte, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

- Le siège social est transféré du 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxem-

bourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024959/24.
(150028994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Egerton Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 73.112.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 12 février 2015 à 09.45

Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège

social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Signatures
<i>Le conseil d'administration

Référence de publication: 2015024954/14.
(150029157) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.660.

<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 11 février 2015

1. M. Thomas R. SANDLER, administrateur de sociétés, né le 16 décembre 1946 à New York (USA), demeurant à

896, Anaconda CT, Castle Rock CO 80108, (USA), a été nommé comme gérant de catégorie A jusqu'à l'issue de l'as-
semblée générale ordinaire de 2019.

2. Le nombre des gérants a été augmenté de 5 à 6.

Luxembourg, le 12.2.2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour DayMen Group (Luxembourg) S.à.r.l.
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015024906/16.
(150028489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36489

L

U X E M B O U R G

Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 187.340.

RECTIFICATIF

Suite à une erreur matérielle survenue dans la publication datée du 30 janvier 2015 et déposée au Registre de Com-

merce et des Sociétés de Luxembourg le 2 février 2015, sous la référence L150020704:

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2.  Acceptation  de  la  démission  de  Robert  Kidd,  avec  adresse  professionnelle  au  44,  avenue  J.F.  Kennedy,  L-1855

Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 février 2015.

Référence de publication: 2015024727/18.
(150028711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Andelle SA, SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 11A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 142.208.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 05.11.2013

<i>Deuxième résolution

Les mandats des Administrateurs et du Commissaire étant arrivés à échéance à l'issue de la présente Assemblée,

l'Assemblée Générale décide de renouveler avec effet immédiat le mandat d'Administrateur et de Président du Conseil
d'Administration de Monsieur Claude SCHMITZ, Conseiller fiscal, né à Luxembourg le 23/09/1955, domicilié profession-
nellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, le mandat d'Administrateur de Monsieur
Pierre LENTZ, Expert-comptable, né à Luxembourg le 22.04.1959, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2,
Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg; Monsieur Gerdy ROOSE, Expert-comptable, né à Wevelgem (Belgique)
le 14.02.1966, domicilié professionnellement à Luxembourg au 2, Avenue Charles de Gaulle L-1653 Luxembourg, ainsi
que celui de Commissaire de la société AUDIEX S.A., ayant son siège social au 9, Rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B et le numéro 65.469, pour une
nouvelle période de six ans jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2019.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ANDELLE SA, SPF
Société Anonyme - Société de gestion de patrimoine familial

Référence de publication: 2015024756/22.
(150028680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Euroamerican Finance S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 139.304.

<i>Extrait de la décision sur la nomination d'un dépositaire des actions et parts sociales au porteur du 06.02.2015

Le Conseil d'Administration de la société EUROAMERICAN FINANCE SA décide de nommer
FIDUCIAIRE GLACIS SARL, experts comptables, demeurant au 18 A, boulevard de la Foire L-1528 Luxembourg
comme dépositaire des actions et parts sociales au porteur.

Junglinster, le 11 février 2015.

POUR EXTRAIT CONFORME
Paul LAPLUME

Référence de publication: 2015024974/14.
(150028495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36490

L

U X E M B O U R G

Euroleague Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 147.373.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2015

Gabriele BARTOLUCCI, Gonzalo PEREZ DE CASTRO, Fortunato CAUZZO et Mohammed KARA, tous professio-

nellement résidents à L-1660 Luxembourg au 60, Grand-rue et Jordi BERTOMEU, résident à E-08038 Barcelone, 5-7
Passeig Olimpic, sont renommés Administrateurs jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2020.

A3T SA, RC Luxembourg n° B158687, 44 Boulevard Grande Duchesse Charlotte à L-1330 Luxembourg, est renommée

Réviseur d'entreprise Agréé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2017.

Pour extrait sincère et conforme
EASIT S.A.

Référence de publication: 2015024975/15.
(150028707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Equus Investment Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 153.741.

<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue à Luxembourg le 13 janvier 2015

L'Assemblée Générale Ordinaire a décidé:
1. de réélire Messieurs Jean-Luc Neyens, Michael Stockford et Riccardo Millich, en qualité d'administrateurs pour le

terme d'un an, prenant fin à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire en 2016,

2. de réélire Ernst &amp; Young SA, en qualité de Réviseur d'Entreprises pour le terme d'un an, prenant fin à la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire en 2016.

Luxembourg, le 11 février 2015.

<i>Pour EQUUS INVESTMENT SICAV
Banque Degroof Luxembourg S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2015024964/17.
(150028336) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

E.C.G. S.A., Expertise Comptable &amp; Gestion, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 97.706.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015024942/10.
(150029166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Ecotrade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 46.186.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 février 2015

Le Conseil d'Administration décide de nommer Crédit Agricole Luxembourg Conseil S.A., ayant son siège social 3,

avenue  Pasteur,  L-2311  Luxembourg,  R.C.S.  Luxembourg  B  -  81.933  dépositaire  des  titres  au  porteur  de  la  Société
conformément au disposition de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des titres au porteur.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2015024953/12.
(150028547) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

36491

L

U X E M B O U R G

Digital Services XLIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.425.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory

seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin on 19 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XLIV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

36492

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)

shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

36493

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager  by  the  remaining  managers until  the  next meeting of shareholders  which shall  resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

36494

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

36495

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the

price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR

15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in Article 183 of the law on commercial companies

have been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

36496

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19.

Januar 2015, ausgestellt in Berlin.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XLIV S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Artikel

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser

36497

L

U X E M B O U R G

außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend

(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des  Abschnitts  XII  des  Gesetzes  von  1915  und  dieser  Satzung  aus.  In  diesem  Fall  ist  jeder  Bezug  auf  die
„Gesellschafterversammlung“in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer

36498

L

U X E M B O U R G

Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2  Falls  die  Gesellschaft  von  einem  einzelnen  Geschäftsführer  geleitet  wird  und  soweit  der  Begriff  „alleiniger

Geschäftsführer“nicht  ausdrücklich  verwendet  wird,  ist  jeder  Verweis  in  dieser  Satzung  auf  den  „Rat  der
Geschäftsführer“als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall,  dass der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

36499

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber. Dritten Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

36500

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

36501

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von

fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg,

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2440. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 11. Februar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015024159/585.
(150027878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

36502

L

U X E M B O U R G

Memora 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,02.

Siège social: L-2763 Luxembourg, 9, rue Sainte Zithe.

R.C.S. Luxembourg B 161.411.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of December,
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-

gned,

There appeared:

Memora S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), having its registered office at 9, rue

Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg and registered with the Luxembourg register of commerce and companies (registre de
commerce et des sociétés) under number B 130.913 (the "Sole Shareholder"),

here represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo, by virtue of proxy given under private seal, which, initialled "ne varietur" by the proxyholder and
the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities,

in its capacity as Sole Shareholder of Memora 2 S.à r.l. (the "Company"), a Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée), having its registered office at 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg and registered
with the Luxembourg register of commerce and companies (registre de commerce et des sociétés) under number B
161.411, incorporated by a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, dated 7 June 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1970 (page
94516) on 26 August 2011, and whose articles of association (the "Articles") have been amended for the last time pursuant
to a deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 27 February
2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1001 (page 48020) on 18 April 2012,

hereby takes the following resolutions in accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law of

10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"):

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create and issue a new specific class of shares in the share capital of the Company

referred to as the specific class shares 2 (the "Specific Class Shares 2"), with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01)
each, and each carrying such rights and obligations as are set out in the Articles, as amended pursuant to the following
resolutions.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one eurocent (EUR 0.01)

in order to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros and one cent (EUR 12,500.01) to
twelve thousand five hundred euros and two cents (EUR 12,500.02) by creating and issuing one (1) new specific class
share 2 with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) (the "New Share"), to be issued and fully paid up with a share
premium amounting to two hundred and forty-three million nine hundred and sixty-five thousand seven hundred and
nineteen euros and eighty-two cents (EUR 243,965,719.82) (the "Share Premium").

<i>Subscription of the New Share

The Sole Shareholder declares to subscribe for and fully pay up the New Share, together with the Share Premium, for

a total issue price of two hundred and forty-three million nine hundred and sixty-five thousand seven hundred and nineteen
euros and eighty-three cents (EUR 243,965,719.83), paid by it to the Company through a contribution in kind consisting
of the contribution of all the forty-eight million seven hundred and ninety-three thousand one hundred and forty-four
(48,793,144) class C shares which the Sole Shareholder holds in Mémora Servicios Funerarios, S.L., a company incorpo-
rated  under  the  laws  of  Spain,  having  its  address  at  Joaquim  Molins  n°5-7,  7a  planta,  08028  Barcelona,  Spain  (the
"Contribution in Kind").

As it appears from the valuation report presented to the notary, the management of the Company has valued the

Contribution in Kind at two hundred and forty-three million nine hundred and sixty-five thousand seven hundred and
nineteen euros and eighty-three cents (EUR 243,965,719.83), which in the reasonable belief of the management of the
Company (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution in Kind and (ii) is at least equal to the New
Share and Share Premium of the Company issued in exchange.

<i>Effective implementation of the contribution

The Sole Shareholder hereby declares that:
- it has the power to make the Contribution in Kind to the Company;

36503

L

U X E M B O U R G

- there exist no other pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand

that any part of the Contribution in Kind be transferred to it/him;

- the Contribution in Kind is hereby assigned and transferred to the Company;
- the transfer of the Contribution in Kind to the Company will be effective from the date of the notarial deed enacting

the increase of share capital of the Company by creating and issuing the New Share; and

- all other formalities shall be carried out in order to duly formalise the transfer of the Contribution in Kind to the

Company and to render it effective anywhere and towards any third party.

The amount of one eurocent (EUR 0.01) shall be allocated to the share capital of the Company.
The Share Premium amounting to two hundred and forty-three million nine hundred and sixty-five thousand seven

hundred and nineteen euros and eighty-two cents (EUR 243,965,719.82) attached to the New Share shall be allocated to
the Specific Class Shares 2 Premium Account (as defined in the Articles, as amended by the following resolutions).

<i>Third resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the Sole Shareholder resolves to amend and restate article 5

of the Articles of the Company as follows:

Art. 5. Share capital.
5.1 The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred euros and two cents (EUR 12,500.02) represented

by one million two hundred forty-one thousand ninety-five (1,241,095) shares with a nominal value of one eurocent (EUR
0.01) each (hereafter referred to as the "Ordinary Shares"), eight thousand nine hundred and six (8,906) shares with a
nominal value of one eurocent (EUR 0.01) each (hereafter referred to as the "Specific Class Shares") and one (1) share
with a nominal value of one eurocent (EUR 0.01) (hereafter referred to as the "Specific Class Share 2", and together with
the Ordinary Shares and the Specific Class Shares, the "Shares"), each having such rights and obligations as set out in the
Articles.

The holders of the Shares are together referred to as the "Shareholders".
5.2 The Specific Class Shares shall confer the holder(s) thereof the right to the Specific Class of Shares Privileged Right

as determined in article 18 (Definitions) of these Articles.

5.3 The Specific Class Share 2 shall confer the holder(s) thereof the right to the Specific Class of Share 2 Privileged

Right as determined in article 18 (Definitions) of these Articles.

5.4 The financial rights and conditions attached to the Ordinary Shares, to the Specific Class Shares and to the Specific

Class Share 2 are further detailed in article 15.

5.5 The share capital of the Company may also be reduced through the cancellation of Specific Class Shares and/or

Specific Class Share 2 by the cancellation of respectively the entire class of Specific Class Shares and/or Specific Class
Share 2 through the repurchase and cancellation of respectively all the Specific Class Shares and/or Specific Class Share
2 in issue in the respective class.

5.6 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of the Specific Class Shares

and/or Specific Class Share 2, such Specific Class Shares and/or Specific Class Share 2 give right to the holders thereof
pro rata to their holding in such class to the Specific Available Amount (with the limitation however to the Specific Total
Cancellation Amount as determined by the sole shareholder or, in case of several shareholders, the general meeting of
shareholders) and the holders of the repurchased and cancelled Specific Class Shares and/or Specific Class Share 2 shall
receive from the Company an amount equal to the Specific Cancellation Value Per Share for each Specific Class Share
and/or Specific Class Share 2 held by them and cancelled.

5.7 The Specific Cancellation Value Per Share for each Specific Class Share and/or Specific Class Share 2 shall be

calculated by dividing the relevant Specific Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the Specific
Class Share and/or Specific Class Share 2 to be repurchased and cancelled.

5.8 The Specific Total Cancellation Amount in relation to the Specific Class Share and/or Specific Class Share 2 shall

be an amount determined by the Board of Managers and approved by the sole shareholder or, in case of several share-
holders, the general meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts and in accordance with the
provisions of article 15 of the Articles. The Specific Total Cancellation Amount for the Specific Class Shares and/or Specific
Class Share 2 shall be the Specific Available Amount of the Specific Class Shares and/or Specific Class Share 2 at the time
of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the sole Shareholder or, in case of several Share-
holders, the general meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment to the Articles provided, however,
that the Specific Total Cancellation Amount shall never be higher than the relevant Specific Available Amount.

5.9 Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant Specific Class Shares and/or Specific Class Share

2, the Specific Cancellation Value Per Share and the related Specific Cancellation Value Per Share will become due and
payable by the Company."

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and restate article

15.5.1 of the Articles of the Company as follows:

36504

L

U X E M B O U R G

15.5.1. Specific Class Shares and Specific Class Share 2:
a) In addition to the legal reserve required by law, the Company shall have a reserve dedicated to the Specific Class

Shares, the balance of which shall be allocated exclusively to the holder(s) of the Specific Class Shares (the "Specific
Reserve 1") and a reserve dedicated to the Specific Class Share 2, the balance of which shall be allocated exclusively to
the holder(s) of the Specific Class Share 2 (the "Specific Reserve 2", together with the Specific Reserve 1, the "Specific
Reserve").

b) Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to the Specific Class Shares (in accordance

with the related Specific Class of Shares Privileged Right and article 15 of the Articles) for accounting and tax purposes
as if the Specific Asset 1 to which they refer were the sole investment held by the Company (the "Specific Profit and Loss
Account 1"). All expenses and incomes connected to the Specific Asset 1 shall be credited to or debited from the Specific
Profit and Loss Account 1.

c) Each year, the Company shall determine the profit and loss attributable to the Specific Class Share 2 (in accordance

with the related Specific Class of Shares Privileged Right and article 15 of the Articles) for accounting and tax purposes
as if the Specific Asset 2 to which it refers were the sole investment held by the Company (the "Specific Profit and Loss
Account 2"). All expenses and incomes connected to the Specific Asset 2 shall be credited to or debited from the Specific
Profit and Loss Account 2.

d) The balance of the Specific Profit and Loss Account 1 shall then be allocated to the Specific Reserve 1 and the

balance of the Specific Profit and Loss Account 2 shall then be allocated to the Specific Reserve 2.

e) If and insofar that legal reserve has to be formed or its balance has to be increased by the Company in any financial

year, the positive balance of the Specific Profit and Loss Account 1 and/or the Specific Profit and Loss Account 2 shall be
used proportionally for this purpose but in proportion to the percentage representing the positive balance of the Specific
Profit and Loss Account 1 and/or the Specific Profit and Loss Account 2 over the profit shown by the annual accounts.

f) If and insofar that a legal reserve becomes available for distribution, the amount released shall be added to the Specific

Profit and Loss Account 1 and/or the Specific Profit and Loss Account 2 against which the legal reserve was formed or
increased up to the proportion to which the proceeds of the Specific Profit and Loss Account 1 and/or the Specific Profit
and Loss Account 2 have contributed to the formation or increase in legal reserve.

g) There shall be, as the case may be, a share premium account for the Ordinary Shares (the "Ordinary Share Premium

Account"), a share premium account for the Specific Class Shares (the "Specific Class Share Premium Account") and a
share premium account for the Specific Class Share 2 (the "Specific Class Share 2 Premium Account"):

(i) A share premium account resulting from any contribution in kind or cash by the holder(s) of the Specific Class

Shares in relation to the Specific Class Shares and share premium account resulting from further contributions to be
made by the holder(s) of such Specific Class Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Specific
Class Share Premium Account;

(ii) A share premium account resulting from any contribution in kind or cash by the holder(s) of the Specific Class

Share 2 in relation to the Specific Class Share 2 and share premium account resulting from further contributions to be
made by the holder(s) of such Specific Class Share 2 is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Specific
Class Share 2 Premium Account;

(iii) A share premium account resulting from any contribution in kind or cash by the holder(s) of the Ordinary Shares

in relation to the Ordinary Shares and share premium account resulting from further contributions to be made by the
holder(s) of such Ordinary Shares is, or shall, as the case may be, allocated to the corresponding Ordinary Share Premium
Account.

h) Dividends shall be paid out of the Specific Reserve 1 or out of the Specific Class Share Premium Account 1 only to

the holder(s) of the Specific Class Shares and out of the Specific Reserve 2 or out of the Specific Class Share Premium
Account 2 only to the holder(s) of the Specific Class Share 2, and in case of a plurality of holders of Specific Class Shares
and/or Specific Class Shares 2, on a pro rata basis based on the proportion of Specific Class Shares and/or Specific Class
Shares 2 they hold."

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above-mentioned resolution, the Sole Shareholder resolves to amend and restate article 18

of the Articles of the Company as follows:

Art. 18. Definitions.

Mémora Spain (also

referred to as Gran

Aberland)

Mémora Servicios Funerarios, S.L. (formerly known as Gran Aberland S.L.), a company
incorporated under the laws of Spain, having its address at Joaquim Molins n°5-7, 7a planta,
08028 Barcelona, Spain (as such details may change from time to time), incorporated for
an indefinite duration;

Interim Accounts

means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date;

Interim Account Date

means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and
cancellation of the relevant class of Shares;

Specific Asset 1

means the class B shares in Mémora Spain held by the Company;

36505

L

U X E M B O U R G

Specific Asset 2

means the class C shares in Mémora Spain held by the Company;

Specific Available Amount means in relation to the Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case may

be) the total amount of net profits attributable to the Specific Class Shares or the Specific
Class Share 2 (as the case may be) (as determined in accordance with the Specific Class of
Shares Privileged Right and article 15 of the Articles) of the Company (including carried
forward profits) to the extend the shareholders would have been entitled to dividend
distributions according to article 15 of the Articles, increased by (i) any freely distributable
reserves attributable to the Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case
may be) in accordance with article 15 of the Articles and (ii) as the case may be by the
amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Specific
Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case may be) to be cancelled but reduced
by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve
(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the
relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so
that:
AA = (NP + P + CR) - (L+ LR)
Whereby:
AA = Specific Available Amount
NP = net profits attributable to the Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as
the case may be) in accordance with the definition of Specific Class of Shares Privileged
Right and article 15 of the Articles (including carried forward profits as determined for the
Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case may be) in accordance with
the definition of Specific Class of Shares Privileged Right and article 15 of the Articles)
P = distributable reserves attributable to the Specific Class Shares or the Specific Class
Share 2 (as the case may be) in accordance with article 15 of the Articles (including, for
the avoidance of doubt, the Specific Reserve 1 or the Specific Reserve 2 (as the case may
be) and the Specific Class Share Premium Account 1 or the Specific Class Share Premium
Account 2 (as the case may be))
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the
Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case may be) to be cancelled
L = losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the
Articles.

Specific Cancellation
Value Per Share

means the cancellation amount per Specific Class Share or the Specific Class Share 2 (as
the case may be) to be paid to the shareholder(s);

Specific Class of Shares
Privileged Right

The Specific Class Shares or the Specific Class Share 2 (as the case may be) shall be entitled
to the following rights:
(a) all dividends paid to the Company or declared (and therefore accrued and to be paid
to the Company) by Mémora Spain in relation to and deriving from the Specific Asset 1 or
the Specific Asset 2 (as the case may be) (the "Privileged Dividend") and,
(b) an amount resulting on the disposal of the Specific Asset 1 or the Specific Asset 2 (as
the case may be), which would result in an "Economic Privilege" as determined hereafter:
The Economic Privilege will consist of 17.5% of the share premium paid on the Specific
Asset 1 or the Specific Asset 2 (as the case may be) multiplied (on a compound financial
basis) by the number of financial years in which the Specific Asset 1 or the Specific Asset
2 (as the case may be) has not given rise to a declared, or if declared, and unpaid, Privileged
Dividend ("Economic Privilege on Redemption")
For the sake of clarity, the number of financial years to be considered for the purposes of
calculating the Economic Privilege shall commence on the date on which the Specific Asset
1 or the Specific Asset 2 (as the case may be) was issued.
The Economic Privilege on Redemption would be calculated in proportion to the holding
period of the Specific Asset 1 or the Specific Asset 2 (as the case may be) which will also
refer to the period elapsed in a given year.
Likewise, the Economic Privilege on Redemption should be reduced, where applicable, by
the amount of Privileged Dividend on the Specific Asset 1 or the Specific Asset 2 (as the
case may be) paid to the Company as per (a) above.
Notwithstanding the above, should the sale of Mémora Spain's shares determines a loss in
the Company, then the Economic Privilege on Redemption would not be accrued for the
purposes of this definition.

36506

L

U X E M B O U R G

In this event, the Economic Privilege on Redemption would be substituted by an "Economic
Privilege in a dissolution or liquidation event" which, without prejudice of clause 16 of the
Articles (dissolution &amp; liquidation), will be equal to the following:
the Economic Privilege on Redemption which would been accrued had no loss exist in the
Company
less
the loss incurred by all the shareholders on a proportional basis according to their
shareholding in the share capital of the Company.
For the avoidance of doubt, the outstanding proceeds would be distributed amongst the
holders of the Specific Class of Shares, the holder of the Specific Class of Share 2 and the
holders of Ordinary Shares on a prorata basis proportionally to the shares they hold in
share capital of the Company.

Specific Total
Cancellation Amount

means the amount to be paid as the redemption price for the Specific Class Shares or
Specific Class of Share 2 (as the case may be) so redeemed.

<i>Costs and notarial deed

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to seven thousand Euro (EUR 7,000.-).

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the Sole Shareholder and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the Sole Shareholder known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the Sole Shareholder signed together with the notary the present
deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre,
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

soussigné,

A comparu:

Memora S.A., une société anonyme luxembourgeoise, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg

et immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 130.913 (l’"Associé
Unique"),

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo, par une procuration sous seing privé donnée, laquelle, signée ne varietur par le mandataire et
par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement,

dans sa capacité d'Associé Unique de Memora 2 S.à r.l. (la "Société"), une société à responsabilité limitée luxembour-

geoise, ayant son siège social au 9, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg et immatriculée auprès du registre du commerce
et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161.411, constituée par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 7 juin 2011, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 1970 (page 94516) le 26 août 2011 et dont les statuts (les "Statuts") ont été modifiés
pour la dernière fois par un acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en date du 27 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1001 (page
48020) le 18 avril 2012,

requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes prises conformément aux dispositions de l’article 200-2 de la loi

luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée (la "Loi"):

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de créer et émettre une nouvelle catégorie de parts sociales spécifique dans le capital social

de la Société dénommée les parts sociales de catégorie spécifique 2 (les "Parts Sociales de Catégorie Spécifique 2"), ayant
une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, et chacune ayant les droits et obligations décrits dans les
Statuts, tels que modifiés suite aux résolutions suivantes.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un centime d'euro (EUR 0,01),

afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros et un centime d'euro (EUR 12.500,01) à douze
mille cinq cents euros et deux centimes d'euro (EUR 12.500,02) par la création et l’émission d'une (1) nouvelle part
sociale de catégorie spécifique 2 ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) (la "Nouvelle Part Sociale"),

36507

L

U X E M B O U R G

étant émise et entièrement libérée avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent quarante-trois millions
neuf cent soixante-cinq mille sept cent dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR 243.965.719,82) (la "Prime
d'Emission").

<i>Souscription de la Nouvelle Part Sociale

L'Associé Unique déclare souscrire à et d'entièrement libérer la Nouvelle Part Sociale, ensemble avec la Prime d'Emis-

sion, pour un prix total émis de deux cent quarante-trois millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent dix-neuf euros
et quatre-vingt-trois centimes (EUR 243.965.719,83), payée par l’Associé Unique à la Société par une contribution en
nature étant une contribution de tous les quarante-huit millions sept cent quatre-vingt-treize mille cent quarante-quatre
(48.793.144) actions de catégorie C détenues par l’Associé Unique dans Mémora Servicios Funerarios, S.L., une société
constituée sous le droit espagnol, ayant son siège social au 5-7, 7a planta, Joaquim Molins, 08028 Barcelona, Spain (l’"Ap-
port en Nature").

Comme il apparaît dans le rapport d'évaluation présenté au notaire le management de la Société a évalué l’Apport en

Nature à deux cent quarante-trois millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent dix-neuf euros et quatre-vingt-trois
centimes (EUR 243.965.719,83), ce qui est considéré raisonnable par le management de la Société en tant que (i) une
évaluation juste et raisonnable de l’Apport en Nature et (ii) au moins égale à la Nouvelle Part Sociale et la Prime d'Emission
émises en échange.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

L'Associé Unique déclare par la présente que:
- il a le pouvoir de transférer l’Apport en Nature à la Société;
- il n'existe aucun autre droit de préemption, ni tout autre droit en vertu de laquelle toute personne pourrait demander

que l’Apport en Nature lui soit transféré;

- l’Apport en Nature est assigné et transféré à la Société par les présentes;
- le transfert de l’Apport en Nature à la Société sera effectif à partir de la date de l’acte notarié adoptant l’augmentation

du capital social de la Société en créant et en émettant la Nouvelle Part Sociale; et

- toutes les autres formalités seront effectuées afin de dûment formaliser le transfert de l’Apport en Nature à la Société

et à le rendre effectif et vis-à-vis de toute tierce partie.

Le montant d'un centime d'euro (EUR 0,01) sera alloué au capital social de la Société.
La Prime d'Emission d'un montant total de deux cent quarante-trois millions neuf cent soixante-cinq mille sept cent

dix-neuf euros et quatre-vingt-deux centimes (EUR 243.965.719,82) attachée à la Nouvelle Part Sociale sera allouée au
Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales de Catégorie Spécifique 2 (tel que défini dans les Statuts, tels que modifiés
par les résolutions suivantes).

<i>Troisième résolution

A la suite de la résolution ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier et refondre l’article 5 des Statuts de la Société

comme suit:

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros et deux centimes (EUR 12.500,02) représenté par un million

deux cent quarante-et-un mille quatre-vingt-quinze (1.241.095) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime
d'euro (EUR 0,01) chacune (ci-après les "Parts Sociales Ordinaires"), huit mille neuf cent six (8.906) parts sociales ayant
une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (ci-après les "Parts Sociales de Catégorie Spécifique") et
une (1) part sociale ayant une valeur nominale d'une centime d'euro (EUR 0,01) (ci-après la "Part Sociale de Catégorie
Spécifique 2" et ensemble avec les Parts Sociales Ordinaires et les Parts Sociales de Catégorie Spécifique, les "Parts
Sociales"), chacune ayant les droits et obligations tels que décrits dans les Statuts.

Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les "Associés".
5.2 Les Parts Sociales de Catégorie Spécifique confèrent au(x) détenteur(s) le droit au Droit Privilégié sur les Parts

Sociales de Catégorie Spécifique ainsi que défini à l’article 18 (Définitions) des présents Statuts.

5.3 La Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 confèrent au(x) détenteur(s) le droit au Droits Privilégié sur la Part Sociale

de Catégorie Spécifique 2 ainsi que défini à l’article 18 (Définitions) des présents Statuts.

5.4 Les droits financiers et les conditions attachées aux Parts Sociales Ordinaires, aux Parts Sociales de Catégorie

Spécifique et à la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 sont décrits plus en détail à l’article 15.

5.5 Le capital social de la Société pourra également être réduit par l’annulation de Parts Sociales de Catégorie Spécifique

et/ou de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 par l’annulation de la totalité de la catégorie respective des l Parts
Sociales de Catégorie Spécifique et/ou la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 à travers le rachat et l’annulation de
respectivement toutes les Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/out la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 émises
dans la catégorie respective.

5.6 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l’annulation des Parts Sociales de Catégorie Spécifique

et/ou de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2, ces Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou de telle Part Sociale

36508

L

U X E M B O U R G

de Catégorie Spécifique 2 donnent droit aux détenteurs au pro rata de leur détention dans cette catégorie au Montant
Spécifique Disponible (dans la limite cependant du Montant Total Spécifique d'Annulation tel que déterminé par l’associé
unique, ou en cas de pluralité d'associés, par l’assemblée générale des associés) et les détenteurs de Parts Sociales de
Catégorie Spécifique et/ou de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 rachetées et annulées recevront de la Société un
montant égal à la Valeur d'Annulation Spécifique par Part Sociale pour chaque Part Sociale de Catégorie Spécifique et/ou
Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 détenue par eux et annulée.

5.7 La Valeur d'Annulation Spécifique par Part Sociale pour chaque Part Sociale de Catégorie Spécifique et/ou Part

Sociale de Catégorie Spécifique 2 sera calculée en divisant le Montant Total Spécifique d'Annulation par le nombre de
Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 émises devant être rachetées et
annulées.

5.8 Le Montant Total Spécifique d'Annulation par rapport aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou à la Part

Sociale de Catégorie Spécifique 2 sera un montant déterminé par le Conseil de Gérance et approuvé par l’associé unique
ou,  en  cas  de  pluralité  d'associés,  l’assemblée  générale  des  Associés  sur  la  base  de  Comptes  Intérimaires  relatifs  et
conformément aux dispositions de l’article 15 des Statuts. Le Montant Total Spécifique d'Annulation pour les Parts Sociales
de Catégorie Spécifique et/ou la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 sera le Montant Disponible de Parts Sociales de
Catégorie Spécifique et/ou de Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 au moment de l’annulation de la catégorie relative
sauf autrement décidé par l’Associé unique ou, en cas de pluralité d'Associés, l’assemblée générale des Associés selon la
procédure prévue pour une modification des Statuts à condition que le Montant Total Spécifique d'Annulation ne soit
jamais supérieur au Montant Spécifique Disponible.

5.9 A compter du rachat et de l’annulation des Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou de la Part Sociale de

Catégorie Spécifique 2 concernée, la Valeur d'Annulation Spécifique Par Part Sociale et la Valeur d'Annulation Spécifique
par Part Sociale sera due et payable par la Société."

<i>Quatrième résolution

A la suite des résolutions mentionnées ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier et refondre l’article 15.5.1 des

Statuts de la Société comme suit:

15.5.1 Parts Sociales de Catégorie Spécifique et Part Sociale de Catégorie Spécifique 2:
a) En complément de la réserve légale exigée par la loi, la Société devra avoir une réserve dédiée aux Parts Sociales

de Catégorie Spécifique, le solde de celle-ci devra être alloué exclusivement à/aux détenteur(s) des Parts Sociales de
Catégorie Spécifique (la "Réserve Spécifique 1") et une réserve dédiée à la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2, le solde
de celle-ci devra être alloué exclusivement à/aux détenteur(s) de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (la "Réserve
Spécifique 2", ensemble avec la Réserve Spécifique 1, la "Réserve Spécifique").

b) Chaque année, la Société devra déterminer les bénéfices et pertes attribuables aux Parts Sociales de Catégorie

Spécifique (conformément aux Droits Privilégiés sur les Parts Sociales de Catégorie Spécifique et à l’article 15 des Statuts)
pour des raisons comptables et fiscales, comme si l’Actif Spécifique 1 auquel elles se rapportent était le seul investissement
détenu par la Société (le "Compte de Résultats Spécifique 1"). Toutes les dépenses et revenus liés à l’Actif Spécifique 1
doivent être crédités au, ou débités du Compte de Résultats Spécifique 1.

c) Chaque année, la Société devra déterminer les bénéfices et pertes attribuables à la Part Sociale de Catégorie Spé-

cifique 2 (conformément aux Droits Privilégiés sur les Parts Sociales de Catégorie Spécifique et à l’article 15 des Statuts)
pour des raisons comptables et fiscales, comme si l’Actif Spécifique 2 auquel elle se rapporte était le seul investissement
détenu par la Société (le "Compte de Résultats Spécifique 2"). Toutes les dépenses et revenus liés à l’Actif Spécifique 2
doivent être crédités au, ou débités du Compte de Résultats Spécifique 2.

d) Le solde du Compte de Résultats Spécifique 1 devra ensuite être alloué à la Réserve Spécifique 1 et le solde du

Compte de Résultats Spécifique 2 devra ensuite être alloué à la Réserve Spécifique 2.

e) Si et pour autant que la réserve légale doive être formée ou que son solde doive être augmenté par la Société lors

d'une année sociale, le solde positif du Comptes de Résultats Spécifique 1 et/ou du Compte de Résultats Spécifique 2 doit
être utilisé proportionnellement à cette fin mais en proportion du pourcentage représentant le solde positif du Compte
de Résultats Spécifique 1 et/ou du Compte de Résultats Spécifique 2 sur les bénéfices montrés par les comptes annuels.

f) Si et pour autant que la réserve légale devienne disponible pour distribution, le montant libéré devra être ajouté au

Compte de Résultats Spécifique 1 et/ou au Compte de Résultats Spécifique 2 en vertu duquel la réserve légale a été
formée ou augmentée dans la proportion dans laquelle les produits du Compte de Résultats Spécifique 1 et/ou du Compte
de Résultats Spécifique 2 ont contribué à la formation et à l’augmentation de la réserve légale.

g) Il devra y avoir, le cas échéant, un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales Ordinaires (le "Compte de

Prime d'Emission de Parts Sociales Ordinaires"), un compte de prime d'émission pour les Parts Sociales de Catégorie
Spécifique (le "Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales de Catégorie Spécifique") et un compte de prime d'émission
pour les Parts Sociales de Catégorie Spécifique 2 (le "Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales de Catégorie Spé-
cifique 2"):

(i) Un compte de prime d'émission résultant de tout apport en nature ou en espèce par le(s) détenteur(s) de Parts

Sociales de Catégorie Spécifique en relation avec les Parts Sociales de Catégorie Spécifique et le compte de prime d'émis-

36509

L

U X E M B O U R G

sion résultant de tout apport ultérieur à faire par le(s) détenteur(s) de telles Parts Sociales de Catégorie Spécifique est
ou doit être, selon le cas, alloué au Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales de Catégorie Spécifique correspondant;

(ii) Un compte de prime d'émission résultant de tout apport en nature ou en espèce par le(s) détenteur(s) de la Part

Sociale  de  Catégorie  Spécifique  2  en  relation  avec  la  Part  Sociale  de  Catégorie  Spécifique  2  et  le  compte  de  prime
d'émission résultant de tout apport ultérieur à faire par le(s) détenteur(s) de telle Part Sociale de Catégorie Spécifique 2
est ou doit être, selon le cas, alloué au Compte de Prime d'Emission de Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 corres-
pondant;

(ii) Un compte de prime d'émission résultant de tout apport en nature ou en espèce par le(s) détenteur(s) de Parts

Sociales Ordinaires en relation avec les Parts Sociales Ordinaires et le compte de prime d'émission résultant de tout
apport ultérieur à faire par le(s) détenteur(s) de ces Parts Sociales Ordinaires est ou doit être, selon le cas, alloué au
Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales Ordinaires correspondant.

h) Des dividendes seront prélevés du Compte de Résultats Spécifique 1 ou du Compte de Prime d'Emission de Parts

Sociales de Catégorie Spécifique 1 seulement au(x) détenteur(s) de Parts Sociales de Catégorie Spécifique et des divi-
dendes devront être prélevés du Compte de Résultats Spécifique 2 ou du Compte de Prime d'Emission de Parts Sociales
de Catégorie Spécifique 2 seulement au(x) détenteur(s) de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2, et en cas de pluralité
de détenteurs de Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou de Parts Sociales de Catégorie Spécifique 2, au pro rata de
la proportion de Parts Sociales de Catégorie Spécifique et/ou de Parts Sociales de Catégorie Spécifique 2 qu'ils détiennent."

<i>Cinquième résolution

A la suite de la résolution mentionnée ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier et refondre l’article 18 des Statuts

de la Société comme suit:

Art. 18. Définitions.

Actif Spécifique 1

signifie les actions de catégorie B détenues par la Société dans Memora Espagne;

Actif Spécifique 2

signifie les actions de catégorie C détenues par la Société dans Memora Espagne;

Comptes Intérimaires

signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires
concernée;

Date des Comptes
Intérimaires

signifie la date pas avant huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie
de Parts Sociales concernée;

Droits Privilégiés sur les
Parts Sociales de
Catégorie Spécifique

les Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (selon
le cas) donneront droit aux droits suivants:
a) tous les dividendes payés par la Société ou déclarés (et par conséquent accumulés et
devant être payés à la Société) par Memora Espagne lié à et dérivant de l’Actif Spécifique
1 ou l’Actif Spécifique 2 (le cas échéant) (le "Dividende Privilégié") et,
b) un montant résultant de la disposition de l’Actif Spécifique 1 ou l’Actif Spécifique 2, qui
résulterait en un "Privilège Economique" ainsi que déterminé ci-après:
Le Privilège Economique consistera en 17.5% de la prime d'émission payée sur l’Actif
Spécifique 1 ou l’Actif Spécifique 2 (le cas échéant) multipliées (sur une base financière
composée) par le nombre d'années sociales au cours desquelles de l’Actif Spécifique 1 ou
l’Actif Spécifique 2 (le cas échéant) n'a pas donné lieu à une déclaration, ou si déclaré, et
non payé, un Dividende Privilégié ("Privilège Economique au Rachat").
Pour des besoins de clarté, le nombre d'années sociales devant être considérées pour les
besoins du calcul du Privilège Economique au Rachat devra commencer à la date à laquelle
l’Actif Spécifique 1 ou l’Actif Spécifique 2 (le cas échéant) a été émis.
Le Privilège Economique au Rachat devra être calculé proportionnellement à la période de
détention de l’Actif Spécifique 1 ou de l’Actif Spécifique 2 (le cas échéant) qui fera également
référence à la période écoulée durant une année donnée.
De même, le Privilège Economique au Rachat devra être réduit, quand cela est possible,
par le montant de Dividendes Privilégiés sur l’Actif Spécifique 1 ou l’Actif Spécifique 2 (le
cas échéant) payé à la Société en vertu du point (a) ci-dessus.
Contrairement à ce qui est disposé ci-dessus, si la vente des actions de Memora Espagne
détermine une perte dans la Société, alors le Privilège Economique au Rachat ne sera pas
cumulé pour les besoins de la présente définition.
Dans le cas où le Privilège Economique au Rachat devait être substitué par un "Privilège
Economique en cas d'événement de dissolution ou liquidation" qui, sans préjudice de la
clause 16 des Statuts
(dissolution et liquidation), sera égal à ce qui suit:
le Privilège Economique au Rachat qui aurait pu être cumulé s'il n'y avait pas eu de perte
dans la Société
moins

36510

L

U X E M B O U R G

la perte encourue par tous les Associés sur une base proportionnelle conformément à leur
détention dans le capital social de la Société.
Pour éviter tout doute, les profits restants seront distribués parmi les détenteurs de Parts
Sociales de Catégorie Spécifique, le détenteur de la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2
et les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires sur une base au pro rata proportionnelle
aux Parts Sociales qu'ils détiennent dans le capital social de la Société.

Mémora Espagne

(également dénommée

Gran Aberland)

signifie Mémora Servicios Funerarios, S.L. (anciennement dénomée Gran Aberland S.L.),
une société immatriculée en Espagne ayant son siège social à Joaquim Molins n°5-7, 7a
planta, 08028 Barcelona, Espagne (ainsi que de tels détails peuvent être modifiés de temps
en temps), constituée pour une durée indéterminée;

Montant Spécifique
Disponible

signifie en relation avec les Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou la Part Sociale de
Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant), le montant total de profits nets distribuables aux
Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas
échéant) (ainsi que déterminé conformément aux Droits Privilégiés de Parts Sociales de
Catégorie Spécifique et à l’article 15 des Statuts) de la Société (y compris les profits
reportés) dans la mesure où les associés auraient droit à des distributions de dividendes
conformément à l’article 15 des Statuts, augmenté par (i) toutes les réserves librement
distribuables aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à la Part Sociale de Catégorie
Spécifique 2 (le cas échéant) conformément à l’article 15 des Statuts et (ii) selon les cas
par le montant de réduction de capital social et de réduction de réserve légale liée aux
Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas
échéant) devant être annulées mais réduites par (i) toutes pertes (y compris les pertes
reportées) et (ii) toutes sommes placées en réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou
des Statuts, chaque fois ainsi que décrit dans les Comptes Intérimaires pertinents (pour
éviter tout doute, sans aucun double comptage), de sorte que:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR)
Dont:
AA= Montant Disponible Spécifique
NP= bénéfices nets attribuable aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à la Part
Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant) conformément à la définition aux Droits
Privilégiés des Parts Sociales de Catégorie Spécifique et à l’article 15 des Statuts (y compris
les bénéfices reportés ainsi que déterminés pour les Parts Sociales de Catégorie Spécifique
ou pour la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant) conformément aux
dispositions de l’article 15 des Statuts)
P= les réserves distribuables attribuables aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à
la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant) conformément à l’article 15 des
Statuts (y compris, pour éviter tout doute, la Réserve Spécifique 1 ou la Réserve Spécifique
2 (le cas échéant) et du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Catégorie
Spécifique ou du Compte de Prime d'Emission des Parts Sociales de Catégorie Spécifique
(le cas échéant))
CR = le montant de la réduction du capital social et la réduction de la réserve légale lié
aux Parts Sociales de Catégorie Spécifique ou à la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2
(le cas échéant) devant être annulées
L= pertes (y compris les pertes reportées)
LR = toutes sommes devant être mises en réserve conformément aux dispositions légales
ou aux Statuts;

Montant Total Spécifique
d'Annulation

signifie le montant à payer comme prix de rachat pour les Parts Sociales de Catégorie
Spécifique ou la Part Sociale de Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant) ainsi annulées;

Valeur d'Annulation
Spécifique par Part
Sociale

signifie le montant d'annulation par Part Sociale de Catégorie Spécifique ou Part Sociale de
Catégorie Spécifique 2 (le cas échéant) devant être payée aux associés.

<i>Frais et acte notarié

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge en raison des présentes, est évalué à sept mille Euros (EUR 7.000.-) euros.

Dont acte, fait et passé, à la date mentionnée en tête des présentes à Luxembourg.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que le présent acte est établi en langue

anglaise, suivi d’une version française; à la requête de l’Associé Unique, et qu’en cas de divergence entre le texte anglais
et le texte français, la version anglaise fera foi.

36511

L

U X E M B O U R G

Le document a été lu au mandataire de l’Associé Unique connu du notaire par son nom, prénom, état civil et domicile,

lequel mandataire de l’Associé Unique a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/65. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 11 février 2015.

Référence de publication: 2015024444/527.
(150028050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Pfaudler Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 38.900.000,00.

Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.

R.C.S. Luxembourg B 191.416.

In the year two thousand and fourteen, on twenty-third December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

Pfaudler Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital

of thirty-eight million seven hundred thousand United States Dollars (USD 38,700,000.-) having its registered office at
59, rue de Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Re-
gister of Commerce and Companies under number B 191383,

hereafter referred to as the “Shareholder”,
hereby represented by Me Stephan Weling, residing professionally in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on 23 December 2014,
The said proxy shall be annexed to the present deed.
The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of

Pfaudler Midco S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of Luxembourg, with a share capital of
twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) having its registered office at 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary on 17 October
2014, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3567 of 26 November 2014, registered
at the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191416 (the "Company"). The articles of association
of the Company have not yet been amended.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To create two new classes of shares, namely the “Class A Ordinary Shares” and the “Class B Preferred Shares”.
2 To convert the existing twenty thousand (20,000) ordinary shares into twenty thousand (20,000) Class A Ordinary

Shares.

3 To increase the issued capital of the Company by an amount of thirty-eight million eight hundred eighty thousand

United States Dollars (USD 38,880,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty thousand United States
Dollars  (USD  20,000.-)  to  an  amount  of  thirty-eight  million  nine  hundred  thousand  United  States  Dollars  (USD
38,900,000.-).

4 To issue nine million seven hundred and five thousand (9,705,000) new Class A Ordinary Shares with a nominal value

of one United States Dollar (USD 1.-) per share, and twenty-nine million one hundred seventy-five thousand (29,175,000)
Class B Preferred Shares, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share.

5 To accept subscription for these new Class A Ordinary Shares and Class B Preferred Shares by the sole shareholder

of the Company, and to accept payment in full of each such new Class A Ordinary Share and Class B Preferred Share by
contribution in cash.

6 To amend paragraph 1 of article 5 as well as articles 28 and 29 of the articles of association of the Company, in order

to reflect the foregoing agenda, and to define the respective financial rights of the Class A Ordinary Shares and the Class
B Preferred Shares.

7 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

36512

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Shareholder resolved to create two new classes of shares, namely the Class A Ordinary Shares and the Class B

Preferred Shares.

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to convert the existing twenty thousand (20,000) ordinary shares into twenty thousand

(20,000) Class A Ordinary Shares.

<i>Third resolution

The Shareholder resolved to increase the issued capital of the Company by an amount of thirty-eight million eight

hundred eighty thousand United States Dollars (USD 38,880,000.-) so as to raise it from its present amount of twenty
thousand United States Dollars (USD 20,000.-) to an amount of thirty-eight million nine hundred thousand United States
Dollars (USD 38,900,000.-).

<i>Fourth resolution

The Shareholder resolved to issue nine million seven hundred and five thousand (9,705,000) new Class A Ordinary

Shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, and twenty-nine million one hundred seventy-
five thousand (29,175,000) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per
share.

<i>Subscription - Payment

Thereupon appeared the Shareholder represented by the above mentioned proxy.
The Shareholder declared to subscribe for nine million seven hundred and five thirty thousand (9,705,000) new Class

A Ordinary Shares with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, and twenty-nine million one
hundred seventy-five thousand (29,175,000) Class B Preferred Shares, with a nominal value of one United States Dollar
(USD 1.-) per share, for a total amount of thirty-eight million eight hundred eighty thousand United States Dollars (USD
38,880,000.-), and to fully pay in cash for these shares.

The amount of thirty-eight million eight hundred eighty thousand United States Dollars (USD 38,880,000.-) was thus

as from that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.

<i>Fifth resolution

The Shareholder resolved to accept the above subscriptions and payments, and to allot the new shares to the Share-

holder as stated above, and resolved to acknowledge the effectiveness of the share capital increase.

<i>Sixth resolution

In view of the above, the Shareholder resolved to amend the first paragraph of article 5, and to restate article 28 and

article 29 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing resolutions, and to define the
respective rights of the Class A Ordinary Shares and the Class B Preferred Shares.

As a result, paragraph 1 of article 5 shall from now on read as follows:

“ Art. 5. Issued Capital. The issued capital of the Company is set at thirty-eight million nine hundred thousand United

States Dollars (USD 38,900,000.-) divided into nine million seven hundred twenty-five thousand (9,725,000) Class A
Ordinary Shares and twenty-nine million one hundred seventy-five thousand (29,175,000) Class B Preferred Shares, with
a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) per share each, all of which are fully paid up.”

As a result, article 28 shall from now on read as follows:

“ Art. 28. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each

year be allocated to the reserve required by law (the “Legal Reserve”). That allocation to the Legal Reserve will cease to
be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the issued capital of the Company.

After allocation to the Legal Reserve, the shareholder(s) shall determine how the remainder of the annual net profits

will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward
to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or
share premium to the shareholder(s).

In respect of each distribution of dividends, the amount allocated to this effect shall be distributed as follows. First,

the Class B Preferred Shares shall entitle on a pro rata basis to a preferred cumulative dividend in an amount of twelve
percent (12%) per annum of the aggregate nominal value of the Class B Preferred Shares and second, the Class A Ordinary
Shares shall entitle to any remaining dividend which shall be allocated pro rata among the Class A Ordinary Shares.

Subject to the conditions (if any) fixed by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s)

may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s) fix the amount and the date of payment
of any such advance payment.”

As a result, article 29 shall from now read as follows:

36513

L

U X E M B O U R G

“ Art. 29. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a resolution of the shareholder(s) adopted by

half of the shareholders holding three quarters (3/4) of the capital.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Manager(s) or such other persons (who

may be physical persons or legal entities) appointed by the shareholder(s), who will determine their powers and their
compensation.

In case of liquidation, all assets and cash of the Company shall be applied in the following order of priority:
(i) first, the creditors (whether by payment or the making of reasonable provision for payment thereof) for all the

Company's debts and liabilities;

(ii) second, to the holders of Class B Preferred Shares for the repayment of the nominal value of their Class B Preferred

Shares and for an amount corresponding (and in no case exceeding) to the entitlement of these Class B Preferred Shares
to preferred dividends in accordance with Article 28, third paragraph, above, on a pro rata basis;

(iii) third, to the holders of Class A Ordinary Shares for the repayment of the nominal value of their Class A Ordinary

Shares and for an amount corresponding to the remaining assets and cash to be distributed, on a pro rata basis.”

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed

are estimated at six thousand five hundred euro (EUR 6,500.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the German text, the English text will prevail.

Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreiundzwanzigsten Dezember,
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, (Großherzogtum Luxemburg),

ist erschienen:

Pfaudler Holding S.à r.l, eine nach dem luxemburgischen Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit

einem Gesellschaftskapital von achtunddreißig Millionen siebenhunderttausend (EUR 38.700.000,-) und Sitz in 59, rue de
Rollingergrund, L-2440 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, und eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsre-
gister Luxemburg unter Nummer B-191383,

hiernach der „Gesellschafter“genannt,
hier vertreten durch Maître Stephan Weling, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
kraft einer am 23. Dezember 2014 erteilten Vollmacht.
Die vorgenannte Vollmacht bleibt dieser Urkunde zum Zwecke der Eintragung dauerhaft beigefügt.
Der  Gesellschafter  hat  den  unterzeichnenden  Notar  gebeten  anzugeben,  dass  er  der  alleinige  Gesellschafter  von

Pfaudler Midco S.à r.l. ist, einer nach dem luxemburgischen Recht gegründeten Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
mit einem Gesellschaftskapital von zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,-) und Sitz in 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars vom 17. Ok-
tober 2014, welche im Mémorial C, Receuil des Sociétés et Associations Nummer 3567 am 26. November veröffentlicht
wurde,  und  eingetragen  beim  Handels-  und  Gesellschaftsregister  Luxemburg  unter  Nummer  B-191416  (die  „Gesell-
schaft“). Die Satzung der Gesellschaft wurde noch nicht abgeändert.

Der Gesellschafter, vertreten wie oben dargestellt, erklärte über die Beschlüsse ausführlich informiert zu sein, welche

auf Basis der folgenden Tagesordnung zu fassen sind:

<i>Tagesordnung

1. Schaffung von zwei neuen Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“und die „Vorzugsanteile der

Klasse B“.

2. Umwandlung der existierenden zwanzigtausend (20.000) Stammanteile in zwanzigtausend (20.000) Stammanteile

der Klasse A.

3. Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals um einen Betrag von achtunddreißig Millionen achthundertacht-

zigtausend US-Dollar (USD 38.880.000,-), um das bestehende Kapital von zwanzigtausend US-Dollar (USD 20.000,-) auf
achtunddreißig Millionen neunhunderttausend US-Dollar (USD 38.900.000,-) zu erhöhen.

4. Schaffung von neun Millionen siebenhundertfünftausend (9.705.000) Stammanteilen der Klasse A, und von neun-

undzwanzig Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend (29.175.000) Vorzugsanteilen der Klasse B, mit einem Nennwert
von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) pro Anteil.

36514

L

U X E M B O U R G

5. Zustimmung zur Zeichnung dieser neuen Stammanteile der Klasse A und dieser neuen Vorzugsanteile der Klasse B

durch den Gesellschafter, und Zustimmung zur vollständigen Zahlung dieser neuen Anteile in bar.

6.  Neufassung  des  ersten Absatzes  von Artikel  5 sowie  von  Artikel  28  und Artikel  29  der Satzung,  um  die oben

genannten Beschlüsse abzubilden und die jeweiligen finanziellen Rechte der Stammanteile der Klasse A und der Vorzugs-
anteile der Klasse B festzulegen.

7. Verschiedenes.
und forderte daraufhin den unterzeichnenden Notar auf, die folgenden Beschlüsse festzuhalten:

<i>Erster Beschluss

Der Gesellschafter beschloss, zwei neue Anteilsklassen, namentlich die „Stammanteile der Klasse A“ und die „Vor-

zugsanteile der Klasse B“, zu schaffen.

<i>Zweiter Beschluss

Der Gesellschafter beschloss, die existierenden zwanzigtausend (20.000) Stammanteile in zwanzigtausend (20.000)

Stammanteile der Klasse A umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Der  Gesellschafter  beschloss,  das  ausgegebene  Gesellschaftskapital  um  einen  Betrag  von  achtunddreißig  Millionen

achthundertachtzigtausend US-Dollar (USD 38.880.000,-) zu erhöhen, um das bestehende Kapital von zwanzigtausend
US-Dollar (USD 20.000,-) auf achtunddreißig Millionen neunhunderttausend US-Dollar (USD 38.900.000,-) zu erhöhen.

<i>Vierter Beschluss

Der Gesellschafter beschloss, neun Millionen siebenhundertfünftausend (9.705.000) Stammanteile der Klasse A, und

neunundzwanzig Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend (29.175.000) Vorzugsanteile der Klasse B, mit einem Nenn-
wert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) pro Anteil, auszugeben.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Daraufhin erschien der Gesellschafter gemäß der oben genannten Vertretungsmacht.
Der Gesellschafter erklärte die Zeichnung von neun Millionen siebenhundertfünftausend (9.705.000) Stammanteilen

der  Klasse  A,  und  von  neunundzwanzig  Millionen  einhundertfünfundsiebzigtausend  (29.175.000)  Vorzugsanteilen  der
Klasse B, mit einem Nennwert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) pro Anteil und die vollständige Zahlung dieser
neuen Anteile in bar.

Der Betrag von achtunddreißig Millionen achthundertachtzigtausend US-Dollar (USD 38.880.000,-) stand ab diesem

Zeitpunkt der Gesellschaft zur Verfügung, und der unterzeichnende Notar hat die notwendigen Dokumente dies belegend
erhalten.

<i>Fünfter Beschluss

Der Gesellschafter erkennt die Zeichnung dieser neuen Anteile, nimmt die vollständige Zahlung dieser neuen Anteile

in bar an und beschließt diese neuen Anteile wie oben aufgeführt an den Gesellschafter auszugeben.

<i>Sechster Beschluss

In Anbetracht der obigen Beschlüsse beschließt der Gesellschafter den ersten Absatz von Artikel 5 der Satzung der

Gesellschaft abzuändern, und den Artikel 28 sowie den Artikel 29 der Satzung der Gesellschaft neu zu verfassen, um diese
Beschlüsse widerzuspiegeln und die jeweiligen finanziellen Rechte der Stammanteile der Klasse A und der Vorzugsanteile
der Klasse B festzulegen.

Der erste Absatz von Artikel 5 der Satzung wird wie folgt abgeändert:

„ Art. 5. Ausgegebenes Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Kapital der Gesellschaft beträgt achtunddreißig Millionen

neunhunderttausend US-Dollar (38.900.000,-) und ist in neun Millionen siebenhundertfünfundzwanzigtausend (9.725.000)
Stammanteile der Klasse A, und in neunundzwanzig Millionen einhundertfünfundsiebzigtausend (29.175.000) Vorzugsan-
teile der Klasse B mit einem Nennwert von jeweils einem US-Dollar (USD 1,-) aufgeteilt. Alle Anteile sind vollständig
eingezahlt.“

Der Artikel 28 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:

„ Art. 28. Gewinnverteilung. Von dem jährlichen Reingewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%)

der gesetzlich vorgesehenen Rücklage zugewiesen (die „Rücklage“).

Diese Verpflichtung entfällt, sobald und solange diese Rücklage die Höhe von zehn Prozent (10%) des Gesellschafts-

kapitals erreicht.

Nach der Zuweisung zur gesetzlichen Rücklage bestimmen die Gesellschafter, wie der verbleibende jährliche Reinge-

winn verteilt werden soll, indem sie diesen vollständig oder teilweise einer Rücklage zuweisen, auf das nächste Geschäfts-

36515

L

U X E M B O U R G

jahr vortragen oder, zusammen mit vorgetragenen Gewinnen, ausschüttbaren Rücklagen oder Ausgabeprämien an die
Gesellschafter ausschütten.

Die für die Ausschüttung der Dividenden vorgesehene Summe wird wie folgt aufgeteilt. Zuerst vermitteln die Vor-

zugsanteile der Klasse B Anrecht auf eine kumulative Dividende in Höhe von zwölf Prozent (12%) pro Jahr bezogen auf
den Gesamtwert der Vorzugsanteile der Klasse B. Danach vermitteln die Stammanteile der Klasse A Anrecht auf jegliche
restlichen Dividenden, welche im pro rata Verhältnis zwischen den Stammanteilen der Klasse A verteilt werden.

Vorbehaltlich der (gegebenenfalls) gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen und unter Berücksichtigung der vorste-

henden Bestimmungen können die Geschäftsführer eine Abschlagsdividende an die Gesellschafter auszahlen. Die Ge-
schäftsführer legen die Summe und das Datum einer solchen Abschlagszahlung fest.“

Artikel 29 der Satzung wird wie folgt neu verfasst:

„ Art. 29. Auflösung, Liquidation. Die Gesellschaft kann durch einen Entschluss der (des) Gesellschafter(s) aufgelöst

werden, der durch die Hälfte der Gesellschafter gefasst wird, die mindestens drei Viertel (3/4) des Gesellschaftskapitals
repräsentieren.

Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird die Liquidation durch die (den) Geschäftsführer oder andere (natür-

liche oder juristische) Personen durchgeführt, deren Befugnisse und Vergütung von den (dem) Gesellschafter(n) bestimmt
werden.

Im Falle einer Liquidation werden alle Aktiva sowie die Barbestände der Gesellschaft in folgender Rangordnung aus-

geschüttet:

(i) zuerst, an die Gläubiger (durch Rückzahlung beziehungsweise durch angemessene Rückstellung zwecks Rückzahlung)

für alle Schulden und Passiva der Gesellschaft;

(ii) dann, an die Gesellschafter, welche Vorzugsanteile der Klasse B halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes

dieser Vorzugsanteile der Klasse B, erhöht durch einen Betrag, der dem Wert des Anspruchs dieser Anteile auf die in
den in Artikel 28, Paragraph 3, erwähnten Vorzugsdividenden entspricht, und auf keinen Fall höher als dieser ist, pro rata;

(iii) dann, an die Gesellschafter, welche Stammanteile der Klasse A halten, als Rückzahlung in Höhe des Nennwertes

dieser Stammanteile der Klasse A, erhöht durch einen Betrag, der den verbleibenden auszuschüttenden Aktiva und Bar-
geldbeständen entspricht.“

<i>Schätzung der kosten

Die Kosten, Auslagen, Aufwendungen und Honorare jeglicher Art, welche der Gesellschaft auf Grund dieser Urkunde

entstehen, werden auf sechstausendfünfhundert Euro (EUR 6.500,-) geschätzt.

Der unterzeichnende Notar, welcher der englischen Sprache mächtig ist, erklärte hierbei, dass auf Anfrage der obigen

genannten Person das vorliegende Dokument in englischer und deutscher Sprache verfasst wurde; auf Anfrage derselben
Person und im Falle verschiedener Auslegungen zwischen dem englischen und deutschen Text soll der englische Text
Vorrang haben.

Worüber Urkunde Aufgenommen wurde die Urkunde zu Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem das Dokument der dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Personenstand und Wohnort be-

kannten erschienenen Partei vorgelesen worden ist, hat dieselbe vorliegende Urkunde mit dem unterzeichnenden Notar
unterzeichnet.

Signé: S. Weling, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 6 janvier 2015. GAC/2015/145. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 9 février 2015.

Référence de publication: 2015024528/248.
(150027883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Pine River Fixed Income Lux Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 66.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 185.634.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 10 février 2015.

Référence de publication: 2015024529/10.
(150027781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

36516

L

U X E M B O U R G

Mitco Resolution 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

R.C.S. Luxembourg B 127.382.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AREX Real Estate UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, registered with the Commercial register of the local
court of Munich under number HRB 202830,

hereby represented by Mr Andreas EISELE, professionally residing in Munich (Germany), in his capacity as sole manager

of the Company;

2) REE Beteiligungs UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, registered with the Commercial register of the local court
of Ludwigshafen under number HRB 63364,

hereby represented by Mr Bernard TREINEN, chartered accountant, professionally residing in L-5411 Canach, 28, rue

de Lenningen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document that

they are the sole shareholders (the “Shareholders”) of MITCO RESOLUTION 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 29, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg on 18 April 2007, published in the Mémorial C no. 1251 on 25 June 2007 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.382. The articles of incorporation of
the Company have not been amended since his incorporation.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholders decide to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address:

L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association as follows:

Art. 5. (first paragraph). “The Registered Office of the Company is established in the municipality of Lenningen, Grand-

Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

36517

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AREX Real Estate UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemandes, ayant

son siège social au 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
local de Munich sous le numéro HRB 202830,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Andreas EISELE, demeurant professionnellement à Munich (Allema-

gne), en sa qualité de gérant unique de la Société;

2) REE Beteiligungs UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemande, ayant son

siège social au 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal local de
Munich sous le numéro HRB 63364,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard TREINEN, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-5411 Canach, 28, rue Lenningen, aux termes d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour

être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont

les seules et uniques associées (les «Associés») de MITCO RESOLUTION 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 18 avril
2007, publié au Mémorial C no 1251 le 25 juin 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, numéro 127.382 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés depuis sa
constitution.

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l’article correspondant des statuts;
3. Divers.
Les Associés demandent au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Les Associés décident, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l’article 5, premier paragraphe, des

statuts comme suit:

Art. 5. (premier paragraphe). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Lenningen, Grand-Duché

de Luxembourg.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Eisele, Treinen, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/756. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

36518

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015024476/111.
(150027313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Mitco Resolution 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

R.C.S. Luxembourg B 127.900.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AREX Real Estate UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, registered with the Commercial register of the local
court of Munich under number HRB 202830,

hereby represented by Mr Andreas EISELE, professionally residing in Munich (Germany), in his capacity as sole manager

of the Company;

2) REE Beteiligungs UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, registered with the Commercial register of the local court
of Ludwigshafen under number HRB 63364,

hereby represented by Mr Bernard TREINEN, chartered accountant, professionally residing in L-5411 Canach, 28, rue

de Lenningen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document that

they are the sole shareholders (the “Shareholders”) of MITCO RESOLUTION 4 S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 29, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg on 25 April 2007, published in the Mémorial C no. 1349 on 4 July 2007 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.900. The articles of incorporation of the
Company have not been amended since his incorporation.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholders decide to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address:

L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association as follows:

Art. 5. (first paragraph). “The Registered Office of the Company is established in the municipality of Lenningen, Grand-

Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

36519

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AREX Real Estate UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemandes, ayant

son siège social au 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
local de Munich sous le numéro HRB 202830,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Andreas EISELE, demeurant professionnellement à Munich (Allema-

gne), en sa qualité de gérant unique de la Société;

2) REE Beteiligungs UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemande, ayant son

siège social au 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal local de
Munich sous le numéro HRB 63364,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard TREINEN, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-5411 Canach, 28, rue Lenningen, aux termes d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour

être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont

les seules et uniques associées (les «Associés») de MITCO RESOLUTION 4 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 25 avril
2007, publié au Mémorial C no 1349 le 4 juillet 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, numéro 127.900 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés depuis sa
constitution.

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l’article correspondant des statuts;
3. Divers.
Les Associés demandent au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Les Associés décident, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l’article 5, premier paragraphe, des

statuts comme suit:

Art. 5. (premier paragraphe). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Lenningen, Grand-Duché

de Luxembourg.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

36520

L

U X E M B O U R G

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Eisele, Treinen, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/760. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015024477/111.
(150027312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Mitco Resolution 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

R.C.S. Luxembourg B 127.272.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AREX Real Estate UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, registered with the Commercial register of the local
court of Munich under number HRB 202830,

hereby represented by Mr Andreas EISELE, professionally residing in Munich (Germany), in his capacity as sole manager

of the Company;

2) REE Beteiligungs UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, registered with the Commercial register of the local court
of Ludwigshafen under number HRB 63364,

hereby represented by Mr Bernard TREINEN, chartered accountant, professionally residing in L-5411 Canach, 28, rue

de Lenningen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document that

they are the sole shareholders (the “Shareholders”) of MITCO RESOLUTION 2 S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 29, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg on 18 April 2007, published in the Mémorial C no. 1217 on 20 June 2007 and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 127.272. The articles of incorporation of
the Company have not been amended since his incorporation.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholders decide to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address:

L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association as follows:

Art. 5. (first paragraph). “The Registered Office of the Company is established in the municipality of Lenningen, Grand-

Duchy of Luxembourg.”

36521

L

U X E M B O U R G

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AREX Real Estate UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemandes, ayant

son siège social au 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
local de Munich sous le numéro HRB 202830,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Andreas EISELE, demeurant professionnellement à Munich (Allema-

gne), en sa qualité de gérant unique de la Société;

2) REE Beteiligungs UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemande, ayant son

siège social au 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal local de
Munich sous le numéro HRB 63364,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard TREINEN, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-5411 Canach, 28, rue Lenningen, aux termes d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour

être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont

les seules et uniques associées (les «Associés») de MITCO RESOLUTION 2 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 18 avril
2007, publié au Mémorial C no 1217 le 20 juin 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, Section B, numéro 127.272 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés depuis sa
constitution.

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l’article correspondant des statuts;
3. Divers.
Les Associés demandent au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Les Associés décident, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l’article 5, premier paragraphe, des

statuts comme suit:

Art. 5. (premier paragraphe). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Lenningen, Grand-Duché

de Luxembourg.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte

36522

L

U X E M B O U R G

et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Eisele, Treinen, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/751. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015024475/111.
(150027314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Mitco Resolution 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 125.490.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AREX Real Estate UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, registered with the Commercial register of the local
court of Munich under number HRB 202830,

hereby represented by Mr Andreas EISELE, professionally residing in Munich (Germany), in his capacity as sole manager

of the Company;

2) REE Beteiligungs UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, registered with the Commercial register of the local court
of Ludwigshafen under number HRB 63364,

hereby represented by Mr Bernard TREINEN, chartered accountant, professionally residing in L-5411 Canach, 28, rue

de Lenningen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document that

they are the sole shareholders (the “Shareholders”) of MITCO RESOLUTION 1 S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 29, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg on 8 mars 2007, published in the Mémorial C no. 979 on 25 mai 2007 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 125.490. The articles of incorporation of the
Company have not been amended since his incorporation.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.
The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholders decide to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address:

L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

36523

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association as follows:

Art. 5. (first paragraph). “The Registered Office of the Company is established in the municipality of Lenningen, Grand-

Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AREX Real Estate UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemandes, ayant

son siège social au 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
local de Munich sous le numéro HRB 202830,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Andreas EISELE, demeurant professionnellement à Munich (Allema-

gne), en sa qualité de gérant unique de la Société;

2) REE Beteiligungs UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemande, ayant son

siège social au 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal local de
Munich sous le numéro HRB 63364,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard TREINEN, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-5411 Canach, 28, rue Lenningen, aux termes d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour

être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont

les seules et uniques associées (les «Associés») de MITCO RESOLUTION 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg le 8 mars
2007, publié au Mémorial C no 979 le 25 mai 2007 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, Section B, numéro 125.490 (la «Société»). Les statuts de la Société n’ont pas encore été modifiés depuis sa
constitution.

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l’article correspondant des statuts;
3. Divers.
Les Associés demandent au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution:

Les Associés décident, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l’article 5, premier paragraphe, des

statuts comme suit:

36524

L

U X E M B O U R G

Art. 5. (premier paragraphe). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Lenningen, Grand-Duché

de Luxembourg.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Eisele, Treinen, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/750. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015024474/111.
(150027315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Mitco Real Estate A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

R.C.S. Luxembourg B 118.294.

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January.
Before us Maître Jean-Paul MEYERS, civil law notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

1) AREX Real Estate UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, registered with the Commercial register of the local
court of Munich under number HRB 202830,

hereby represented by Mr Andreas EISELE, professionally residing in Munich (Germany), in his capacity as sole manager

of the Company;

2) REE Beteiligungs UG, a haftungsbeschränkt company duly established and existing under the laws of the Germany,

with its registered office at 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, registered with the Commercial register of the local court
of Ludwigshafen under number HRB 63364,

hereby represented by Mr Bernard TREINEN, chartered accountant, professionally residing in L-5411 Canach, 28, rue

de Lenningen, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxies, signed by the proxyholder and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the

purpose of registration.

The appearing parties, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document that

they are the sole shareholders (the “Shareholders”) of MITCO REAL ESTATE A S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated in accordance with and governed by the laws of Luxembourg with registered office at 29, boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg, incorporated following a deed of Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-
Duchy of Luxembourg on 8 June 2006, published in the Mémorial C no. 1866 on 5 October 2006 and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 118.294. The articles of incorporation of the
Company have been amended for the last time pursuant a deed of Maître Henri HELLINCKX, then notary residing in
Mersch, on 21 December 2006, published in the Mémorial C no. 708 on 25 April 2007.

The Shareholders, represented as above mentioned, having recognised to be fully informed of the resolutions to be

taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda:

1. Transfer of registered office;
2. Amendment of the respective article of the articles of association;
3. Miscellaneous.

36525

L

U X E M B O U R G

The Shareholders, represented as above mentioned, have requested the undersigned notary to document the following

resolutions:

<i>First resolution:

The Shareholders decide to transfer the statutory seat of the company, with immediate effect, to following address:

L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Second resolution:

As a consequence of the above resolution, the Shareholders decide to amend article 5, first paragraph, of the articles

of association as follows:

Art. 5. (first paragraph). “The Registered Office of the Company is established in the municipality of Lenningen, Grand-

Duchy of Luxembourg.”

<i>Power

The above appearing parties hereby give power to any agent and / or employee of the office of the signing notary,

acting individually to proceed as the case may be with the registration, listing, modification, deletion, publication or any
other useful or necessary operations following this deed and possibly to draw, correct and sign any error, lapse or typo
in this deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up and duly enacted in Luxembourg, on the day named at the beginning

of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, he signed together with us, the notary,

the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le septième jour de janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

Ont comparu:

1) AREX Real Estate UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemandes, ayant

son siège social au 45, Maximilianstrasse, D-80538 Munich, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal
local de Munich sous le numéro HRB 202830,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Andreas EISELE, demeurant professionnellement à Munich (Allema-

gne), en sa qualité de gérant unique de la Société;

2) REE Beteiligungs UG, une Haftungsbeschränckt valablement constituée et existant sous les lois allemande, ayant son

siège social au 6, Mozartstrasse, D-67459 Böhl, immatriculée auprès du Registre de Commerce du Tribunal local de
Munich sous le numéro HRB 63364,

représentée aux fins des présentes par Monsieur Bernard TREINEN, expert-comptable, demeurant professionnelle-

ment à L-5411 Canach, 28, rue Lenningen, aux termes d’une procuration donnée sous seing privé.

Lesdites procurations, signées par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour

être enregistrées avec elles.

Les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter qu'elles sont

les seules et uniques associées (les «Associés») de MITCO REAL ESTATE A S.à r.l., une société à responsabilité limitée
régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social au 29, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, constituée
suivant acte de Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg le 8 juin 2006,
publié au Mémorial C no 1866 le 5 octobre 2006 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg, Section B, numéro 118.294 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte
reçu par Maître Henri HELLINCKX, alors notaire de résidence à Mersch, Grand-Duché de Luxembourg le 21 décembre
2006, publié au Mémorial C no 708 le 25 avril 2007.

Les Associés, représentés comme dit ci-avant, reconnaissant être parfaitement au courant des décisions à intervenir

sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert de siège;
2. Modification subséquente de l’article correspondant des statuts;
3. Divers.
Les Associés demandent au notaire instrumentant soussigné d’acter les résolutions suivantes:

36526

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

Les Associés décident, avec effet immédiat, de transférer le siège de la société à L-5411 Canach, 28, rue de Lenningen.

<i>Deuxième résolution:

En conséquence de la résolution qui précède, les Associés décident de modifier l’article 5, premier paragraphe, des

statuts comme suit:

Art. 5. (premier paragraphe). «Le siège social de la Société est établi dans la commune de Lenningen, Grand-Duché

de Luxembourg.».

<i>Pouvoirs

Les comparants donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l’étude du notaire soussigné, agissant

individuellement, afin de procéder suivant besoin à l’enregistrement, l’immatriculation, la modification, la radiation auprès
du Registre des Sociétés ou la publication ou toutes autres opérations utiles ou nécessaires dans la suite du présent acte
et, le cas échéant pour corriger, rectifier, rédiger, ratifier et signer toute erreur, omission ou faute(s) de frappe(s) au
présent acte.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: Eisele, Treinen, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 16 janvier 2015. Relation: DAC/2015/747. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 16 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015024473/113.
(150027316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Neyoris,, S.e.n.c., Société en nom collectif.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 50, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 194.419.

STATUTS

1. Monsieur Cari Bayard, directeur administratif, demeurant à 4 Rue Van der Meulen L-2152 Luxembourg
2. Madame Samira Maaoui, directrice d'entreprise, demeurant à 4 Rue Van der Meulen L-2152 Luxembourg
il a été constitué en date du 2/2/2015 une société en commandite simple dont les statuts ont été arrêtés comme suit.

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé entre les constituants et tous ceux qui pourraient devenir associés par la suite, une société en

nom collectif.

Art. 2. La dénomination de la société est NEYORIS,, S.e.n.c.

Art. 3. La société a pour objet, distribution et vente de mobiliers, objets de décoration et artistiques et d'une manière

générale, toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirec-
tement à cet objet ou pouvant en faciliter la réalisation.

Art. 4. Le siège social de la société est établi au 50 Rue Glesener L-1630 Luxembourg. Il pourra être transféré en tout

autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Art. 5. La société a été constituée pour une durée indéterminée. Elle ne sera pas dissoute par le décès, l'incapacité,

l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 6. Le capital social est fixé à mille Euros (1000 euros) représenté par cent (100) parts sociales de dix Euros (10

euros) chacune.

Ces parts sociales ont été souscrites comme suit:

36527

L

U X E M B O U R G

1) Madame Samira Maaoui, préqualifiée, 50 parts, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Euros

2) Monsieur Cari Bayard, préqualifié, 50 parts, soit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500 Euros

Total: 100 parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 Euros

Le capital social a été entièrement libéré et se trouve à la disposition de la société.

Art. 7. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément de tous les associés

représentant l'intégralité du capital social.

Elles ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'agrément de tous les associés

survivants.

En cas de cession de parts d'un associé, les associés restants ont un droit de préemption au prorata des parts en leur

possession.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 8. Madame Maaoui Samira, demeurant au 4 rue Antoine-François Van der Meulen L-2152 Luxembourg, préqua-

lifiée, en sa qualité d'administrateur, est chargé de la gestion de la société et peut accomplir tous les actes de gestion, qui
rentrent dans l'objet social de la société.

Tous les actes qui engagent la société, tous les pouvoirs et toutes les procurations doivent porter la signature de l'un

des deux associés.

Art. 9. Chaque part sociale donne droit à une voix dans les décisions collectives à prendre en assemblée générale.
Dans tous les cas où la loi ou les présents statuts ne prévoient une majorité plus grande, toutes les décisions, y compris

celles concernant la nomination, la révocation ou le remplacement d'un gérant, sont prises à la majorité simple.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 10. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Par déro-

gation, le premier exercice social commence à la date de la constitution et finit le trente-et-un décembre deux mille
quinze

Art. 11. Chaque année, au trente et un décembre, il sera dressé par la gérance un inventaire ainsi que le bilan et le

compte de profits et pertes.

Le bénéfice net, déduction faite de tous les frais généraux et des amortissements, est à la disposition de l'assemblée

générale des associés qui décidera de l'affectation du bénéfice net de la société.

Disposition Générale

Art. 12. Pour tous les points non prévus aux présents statuts, les parties déclarent se référer à la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Evaluation des Frais

Art. 13. Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à

la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de cinq cent
(500) Euros.

Samira Maaoui / Carl Bayard.

Référence de publication: 2015024497/60.
(150027750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.

Guidalpa S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 60.586.

EXTRAIT

Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 12 février 2015 que la société FIDUCENTER

S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.

Pour extrait conforme
Signature

Référence de publication: 2015025062/13.
(150029081) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

36528


Document Outline

Andelle SA, SPF

Apollo Investment Europe III Holdings (Lux) S.à r.l.

Artaxerxes S.A., SPF

Avalon Immobilière SCI

Bâloise Fund Invest (Lux)

Casada Holding S.A.

Casa Investments S.A.

CCP Holding S.à r.l.

Centre de Coiffure Paola S.à r.l.

CETP III Advisor S.à r.l.

Chartinvest S.A.

Ciancone S.A.

CIEP I S.à r.l.

Comacchio International S.A.

Dani Real Estate

Dashabo S.A.

DayMen Group (Luxembourg) S.à r.l.

Dekan

Delight Industrial Holdings S.à r.l.

Desroches S.A.

DGC Constructions S.à r.l.

Digital Services XLIV S.à r.l.

E.C.G. S.A., Expertise Comptable &amp; Gestion

Ecopro Lux Cad Systems and Services s.à r.l.

Ecotrade S.A.

Egerton Holding S.A.

Eisbach S.A., SPF

Enim S.A.

Equus Investment Sicav

Euroamerican Finance S.A.

Euroleague Properties S.A.

Guidalpa S.A.

Memora 2 S.à r.l.

Mitco Real Estate A S.à r.l.

Mitco Resolution 1 S.à r.l.

Mitco Resolution 2 S.à r.l.

Mitco Resolution 3 S.à r.l.

Mitco Resolution 4 S.à r.l.

Neyoris,, S.e.n.c.

Pfaudler Midco S.à r.l.

Pine River Fixed Income Lux Investments S.à r.l.

Taurus Capital S.A.

Techvest S.A.

The Calypso Alternative Fund

Trampolini Luxembourg S.A.

United Group S.A.