This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 757
19 mars 2015
SOMMAIRE
ATM S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36319
CLS Tangendis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36324
Dachstein S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36324
Darter Holdings II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
36326
Darter Holdings I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36319
Digital Services XLVI S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
36308
Digital Services XLV S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
36297
Fadeka S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36329
Florent S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36334
Grand City Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . .
36331
Maroquinerie du Centre Sàrl . . . . . . . . . . . .
36292
MCG - Change Management Consulting
Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36292
MEAG Luxembourg S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
36295
Mola Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36295
Monique Follmann-Fohl GCM S.àr.l. . . . . .
36292
MPI S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36295
Neerveld 101-103 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
36292
Omnium S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36291
Opensys S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36291
Origante Investments S.A., SPF . . . . . . . . .
36291
Promocom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36297
Ruffer SICAV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36294
Salon PS Pure Style s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
36291
Sanogreen S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36290
Santé Sécurité au Travail Luxembourg . .
36291
Savile Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36290
Schweich S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36291
Select Commerce S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36295
Silver Rose S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36296
Société de Financement Médical et Hospi-
talier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36290
Société de Financement Médical et Hospi-
talier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36290
Soluxtec Distribution S.A. . . . . . . . . . . . . . .
36336
Sotreca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36296
Spa Di Walla Invester S.C.A. . . . . . . . . . . . .
36296
STAR Agatha Investments S.à r.l. . . . . . . .
36294
Suki Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36290
Sun Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36296
Terra Finance Management S.A.-SPF . . . .
36293
Togiram S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36294
Truffle S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36293
Tuileries Participation S.A. . . . . . . . . . . . . .
36293
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
36292
Vinci I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36294
Vinci I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36294
Visago Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36293
Würzburg Estates S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
36294
36289
L
U X E M B O U R G
Société de Financement Médical et Hospitalier, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 11.770.
Les comptes annuels au 30 Juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026278/10.
(150029701) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Savile Capital S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 3, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 173.501.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026263/9.
(150029461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Sanogreen S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3327 Crauthem, Zone Industrielle Am Bruch.
R.C.S. Luxembourg B 61.455.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF EXPERTS COMPTABLES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015026261/12.
(150029704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Suki Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 166.176.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 janvier 2015.
Luxembourg Corporation Company S.A.
Signatures
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015026254/13.
(150029582) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Société de Financement Médical et Hospitalier, Société Anonyme.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 11.770.
Les comptes annuels au 30 Juin 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026279/10.
(150029702) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36290
L
U X E M B O U R G
Salon PS Pure Style s.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4018 Esch-sur-Alzette, 3, rue d'Audun.
R.C.S. Luxembourg B 165.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026259/9.
(150029587) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Schweich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 159.965.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026239/9.
(150029454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Santé Sécurité au Travail Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.
R.C.S. Luxembourg B 158.334.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026236/9.
(150029486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Origante Investments S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 181.436.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026162/9.
(150030104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Opensys S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3895 Foetz, 10, rue de l'avenir.
R.C.S. Luxembourg B 162.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026160/9.
(150029576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Omnium S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 117.871.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026158/9.
(150029574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36291
L
U X E M B O U R G
MCG - Change Management Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3861 Schifflange, 197, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 147.574.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026102/9.
(150029387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Maroquinerie du Centre Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3590 Dudelange, 35, place de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 78.035.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015026099/10.
(150030031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Monique Follmann-Fohl GCM S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3861 Schifflange, 197, rue de Noertzange.
R.C.S. Luxembourg B 140.369.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026091/9.
(150029390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Neerveld 101-103 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 32.617.500,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 34-38, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 123.778.
Les comptes annuels au 31 juillet 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015026132/10.
(150029292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.
R.C.S. Luxembourg B 105.894.
<i>Extrait des décisions prises par l'associée unique en date du 30 janvier 2015i>
1. Madame Linda HOHN a démissionné de son mandat de gérante.
2. Monsieur Stephen Warren RIES, administrateur de sociétés, né le 29 mars 1980 à Allentown, Pennsylvanie (USA),
demeurant professionnellement à 3, Bala Plaza East, suite 300, Pennsylvanie, 19004 Bala Cynwyd (USA), a été nommé
comme gérant pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 12.2.2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015025582/16.
(150029255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36292
L
U X E M B O U R G
Truffle S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 120.100.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 11/02/2015i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting SA. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11/02/2015.
Signature
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015025579/14.
(150029149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Tuileries Participation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.
R.C.S. Luxembourg B 104.501.
<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue au siège social le 12 février 2015i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolution:i>
L'Assemblée Générale accepte la démission de l'Administrateur Unique, Madame Johanna SCHADECK, avec effet
immédiat.
<i>2 i>
<i>èmei>
<i> résolution:i>
L'Assemblée Générale décide de nommer comme nouvel Administrateur Unique, avec effet immédiat, Madame GIO-
VANARDI Annabelle, employée privée, résidant professionnellement au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg. Son mandat
viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'an 2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour TUILERIES PARTICIPATION S.A.i>
Référence de publication: 2015025580/17.
(150029184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Visago Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 182.458.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du
06 février 2015 que:
La Fiduciaire Joseph Treis s.àr.l., établie à L-1510 Luxembourg, 57 avenue de la Faïencerie a été nommée dépositaire
des actions au porteur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025595/13.
(150028704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Terra Finance Management S.A.-SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1411 Luxembourg, 5A, rue des Dahlias.
R.C.S. Luxembourg B 68.259.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015025559/10.
(150028736) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36293
L
U X E M B O U R G
Vinci I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.781.
Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026357/9.
(150029639) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Würzburg Estates S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 115.724.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026375/9.
(150029946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Togiram S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 70.992.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026324/9.
(150029635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Vinci I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 145.781.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026356/9.
(150029462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
STAR Agatha Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 156.136.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026295/9.
(150029359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Ruffer SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 161.817.
Le Bilan au 15 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015026215/9.
(150029475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
36294
L
U X E M B O U R G
MPI S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 31, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 170.405.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF CORPORATE SERVICES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015026120/12.
(150029706) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Mola Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9053 Ettelbruck, 115, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 104.674.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour MOLA Sàrl
i>Société à responsabilité limitée
FIDUCIAIRE DES P.M.E. SA
Référence de publication: 2015026117/12.
(150029872) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
MEAG Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2240 Luxembourg, 15, rue Notre-Dame.
R.C.S. Luxembourg B 127.482.
Le bilan au 31 décembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 février 2015.
<i>Pour MEAG Luxembourg S.à.r.l.
i>Société à responsabilité limité
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015026107/14.
(150030115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2015.
Select Commerce S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4024 Esch-sur-Alzette, 371, route de Belval.
R.C.S. Luxembourg B 24.013.
Il résulte de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2014, que G.T. Fiduciaires S.A., inscrite au RCSL sous le
numéro B121820 et ayant son siège social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg, est nommée commissaire aux
comptes de la société, en remplacement de G.T. Experts Comptables S.à.r.l.
Le mandat du nouveau commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra
en l'année 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
G.T. Experts Comptables S.àr.l.
Luxembourg
Référence de publication: 2015025489/16.
(150028819) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36295
L
U X E M B O U R G
Spa Di Walla Invester S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 177.845.
<i>Extrait des résolutions prises le 05 février 2015 par le gérant unique:i>
Le gérant unique prend la décision de nommer la société L.M.C. GROUP S.A., dont le siège social est au 8, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, B-73897 comme dépositaire des titres au porteur de la société.
Luxembourg, le 05 février 2015.
<i>Pour SPA DI WALLA INVESTER S.C.A.
i>Signature
Référence de publication: 2015025522/13.
(150028669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Sotreca, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 26.396.
<i>Extrait des résolutions circulaires prises par le conseil d'administration en date du 4 février 2015i>
Le conseil d'administration a nommé, avec effet au 13 février 2015, European Fund Administration, ayant son siège
social au 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg et enregistré au registre de commerce de des sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 56.766, en tant que dépositaire au sens de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions
et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Extrait certifié sincère et conforme
<i>Pour SOTRECA
i>KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A.
Référence de publication: 2015025520/15.
(150028373) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Sun Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 79.438.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue le 29 janvier 2015 à Luxembourgi>
Le Conseil d'Administration décide de désigner la société EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES ET
INDUSTRIELLES (en abrégé PARFININDUS), 24, rue saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 56.469, en
tant que dépositaire des certificats représentatifs d'actions au porteur émis au nom de la société.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015025534/12.
(150028113) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Silver Rose S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 62.126.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la société tenu le 10 février 2015 à 16.00i>
Le Conseil d'administration décide de nommer Luxembourg International Consulting S.A. «Interconsult» avec siège
social au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg (RCS Luxembourg B40312) comme dépositaire des actions au porteur de
la Société.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Signatures
<i>Le conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015025503/14.
(150028888) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
36296
L
U X E M B O U R G
Promocom, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5318 Contern, 1, rue Beau Soleil.
R.C.S. Luxembourg B 62.687.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L’an deux mille quatorze, le 31 décembre à 15h, à Contern, au siège social,
s’est réunie
l’Assemblée Générale Extraordinaire de la S.à r.l. Promocom, société qui a été dissoute et mise en liquidation suivant
acte du 20 novembre 2014 reçu par Maître Urbain THOLL, notaire de résidence à Mersch.
<i>Ordre du jouri>
1. Rapport du commissaire-vérificateur et approbation des comptes de liquidation, clôturés au 31/12/2014;
2. Décharge à donner au liquidateur et au commissaire-vérificateur;
3. Définir l’endroit où seront archivés les livres et documents sociaux de la société pour une durée de 5ans;
4. Clôture de la liquidation:
L’associé unique de la société à responsabilité limitée Promocom, ici représentée par sa gérante, Madame SCHMITT
Danielle, demeurant à L-5318 Contern, 1, rue Beau Soleil prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire-vérificateur à la liquidation, à savoir la
société New Luxcompta Sàrl, 25, rue de la Libération, L-8245 Mamer, approuve le rapport du liquidateur ainsi que les
comptes de liquidation établis au 31/12/2014.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique donne décharge au liquidateur et au commissaire-vérificateur, concernant toute responsabilité ulté-
rieure.
<i>Troisième résolutioni>
L’associé unique décide que les livres et documents de la société dissoute resteront déposés et conservés pendant
cinq ans au moins au domicile privé de Madame SCHMITT Danielle, préqualifiée.
<i>Quatrième résolutioni>
L’associé unique décide la dissolution et la liquidation de la prédite société, il se déclare investi de tout actif de la société
et s’engage expressément à régler tout passif éventuel; que partant la société est à considérer comme définitivement
dissoute.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h, après lecture et approbation du présent procès-verbal.
Contern, le 31 décembre 2014.
<i>Pour Promocom S. à r.l., en liquidation
i>SCHMITT Danielle
<i>Gérantei>
Référence de publication: 2015024551/38.
(150027658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Digital Services XLV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.453.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory
seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;
36297
L
U X E M B O U R G
here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 19 January 2015.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose- Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XLV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
36298
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10 Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
36299
L
U X E M B O U R G
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
36300
L
U X E M B O U R G
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
36301
L
U X E M B O U R G
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the
price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have
been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole
shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
36302
L
U X E M B O U R G
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19.
Januar 2015, ausgestellt in Berlin.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XLV S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
36303
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7 Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
36304
L
U X E M B O U R G
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
36305
L
U X E M B O U R G
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
36306
L
U X E M B O U R G
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
36307
L
U X E M B O U R G
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.
<i>Beschlüsse des alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg,
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-
berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2441. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Februar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015024915/584.
(150028514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Digital Services XLVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.452.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory
seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;
here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 19 January 2015.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
36308
L
U X E M B O U R G
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XLVI S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
36309
L
U X E M B O U R G
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
36310
L
U X E M B O U R G
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
36311
L
U X E M B O U R G
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and Supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
36312
L
U X E M B O U R G
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the
price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have
been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole
shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am dreiundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 19.
Januar 2015, ausgestellt in Berlin.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
36313
L
U X E M B O U R G
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XLVI S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2 Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
36314
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die
„Gesellschafterversammlung«in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
36315
L
U X E M B O U R G
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger
Geschäftsführer«nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer«als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer«auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
36316
L
U X E M B O U R G
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
36317
L
U X E M B O U R G
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
36318
L
U X E M B O U R G
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg,
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-
berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2442. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 12. Februar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015024917/585.
(150028504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
ATM S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8437 Steinfort, 52, rue de Koerich.
R.C.S. Luxembourg B 80.346.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015024771/10.
(150028069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Darter Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 182.282.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of the month of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Was held
an extraordinary general meeting (the “Meeting”) of the shareholder of Darter Holdings I S.à r.l., (the “Company”), a
private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg by a deed of the undersigned on 27 November 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 61 of 8 January 2014, with a corporate capital of one million twenty-five thousand euros (EUR
1,025,000.-), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and registered with the Luxem-
bourg Trade and Company Register under number B 182.282.
THERE APPEARED:
Motor Holdings Limited, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at
Paget-Brown Trust Company Limited, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, Cayman
Islands, registered with the Cayman Islands Companies’ Register under number PB 285322 (hereafter referred to as “MH
Limited”) and
36319
L
U X E M B O U R G
Dr Mario Albert THEISSEN, a German citizen with address at Abensbergstr 51, Munich, Germany (hereafter referred
to as “Dr Theissen”).
All the appearing parties are here represented by Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally L-1466
Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (the “Proxy-holder”), by virtue of two proxies given under private seal; such proxies,
after having been signed “ne varietur” by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
MH Limited, the existing shareholder of the Company, representing the entire share capital declared, having waived
any notice requirement, that the Meeting was regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the
following agenda whereby Dr Theissen participated and voted for the purpose of point 3 et seqq. only:
<i>Agendai>
1. Increase of the share capital of the Company from its present amount of one million twenty-five thousand euros
(EUR 1,025,000.-) to one million twenty-five thousand and thirty-four euros (EUR 1,025,034.-), by the issuance of thirty-
four (34) ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as the
existing ordinary shares of the Company.
2. Subscription and payment of the newly issued shares as specified under item 1. above by a contribution in cash from
Dr Theissen.
3. Further increase of the share capital of the Company from one million twenty-five thousand and thirty-four euros
(EUR 1,025,034.-) to one million twenty-six thousand three hundred and eighty-four euros (EUR1,026,384.-) by the
issuance of one hundred and thirty-five (135) shares in each of the ten classes of preference shares, Class A Shares to
Class J Shares (the “Preference Shares”).
4. Subscription and payment of the newly issued Preference Shares as specified under item 3. above by a contribution
in cash received from Dr Theissen.
5. Amendment of the articles of association of the Company (the “Articles”) to reflect the increase of the share capital
of the Company specified under item 1. and 3. above.
6. Amendment of the share register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority
given to any manager of the Company to individually proceed to the registration in the share register of the Company
of (i) the above increase of the Company's share capital as well as (ii) to see to any formalities in connection therewith.
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Meeting unanimously took, and required the undersigned notary
to enact, the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to increase the share capital of the Company from its present amount of one million twenty-
five thousand euros (EUR 1,025,000.-) to one million twenty-five thousand and thirty-four euros (EUR 1,025,034.-), by
the issuance of thirty-four (34) ordinary shares having a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights and
obligations as the existing ordinary shares of the Company.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase
as follows:
<i>Subscription / paymenti>
Dr Theissen, declared to subscribe for the thirty-four (34) new shares in registered form, with a par value of one euro
(EUR 1.-) each, having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company and to fully
pay the par value of such shares by a contribution in cash amounting to thirty-four euros (EUR 34.-).
The amount of thirty four euros (EUR 34.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to further increase the share capital of the Company from one million twenty-five thousand and
thirty-four euros (EUR 1,025,034.-) to one million twenty-six thousand three hundred and eighty-four euros (EUR
1,026,384.-) by the issuance of one hundred and thirty-five (135) shares in each of the ten classes of preference shares,
Class A Shares to Class J Shares (the “Preference Shares”).
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to accept and record the following subscription for and full payment of the share capital increase
as follows:
36320
L
U X E M B O U R G
<i>Subscription / paymenti>
Dr Theissen declared to subscribe for one hundred and thirty-five (135) Preference Shares in each of the ten preference
share classes, which Preference Shares shall be in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each and issued
at a premium value of seventy-three euros zero four eight eight eight nine cents (EUR 73.048889.-) per share and to fully
pay for such Preference Shares by a contribution in cash amounting to ninety-nine thousand nine hundred and sixty-six
euros (EUR 99,966.-), out of which one thousand three hundred and fifty euros (EUR 1,350.-) shall be allocated to the
share capital of the Company and ninety-eight thousand six hundred and sixteen euros (EUR 98,616.-) shall be allocated
to the share premium account of the Company.
The amount of ninety-nine thousand nine hundred and sixty-six euros (EUR 99,966.-) is at the disposal of the Company,
as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Meeting decided to amend the Articles of the Company as follows:
1. Article 5.1 of the Company’s Articles shall be amended so that it shall henceforth read as follows:
“ 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at one million twenty-six thousand three hundred and eighty-four euros
(EUR 1,026,384.-) represented by:
5.1.1. twenty-five thousand and thirty-four (25,034) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) in registered form with
a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up;
5.1.2. one million one thousand three hundred and fifty (1,001,350) preference shares (the “Preference Shares”) in
registered form with a par value of one euro (EUR 1.-) each, all subscribed and fully paid-up, divided into ten classes to
be denominated “Class A Shares” to “Class J Shares” as set out below:
i) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class A Shares;
ii) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class B Shares;
iii) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class C Shares;
iv) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class D Shares;
v) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class E Shares;
vi) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class F Shares;
vii) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class G Shares;
viii) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class H Shares;
ix) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class I Shares;
x) one hundred thousand one hundred and thirty-five (100,135) Class J Shares;”
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolved to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Company to individually proceed to the registration in the share register of
the Company of (i) the above increase of the Company's share capital as well as (ii) to see to any formalities in connection
therewith.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand seven hundred
Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-troisième jour du mois de janvier;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est tenue
36321
L
U X E M B O U R G
une assemblée générale extraordinaire (l’«Assemblée») de l’associé de Darter Holdings I S. à r.l., (la «Société»), une
société à responsabilité limitée société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte du notaire
soussigné le 27 novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 61 du 8 janvier 2014,
et ayant un capital social d’un million vingt-cinq mille (EUR 1.025.000,-), ayant son siège social au 58, rue Charles Martel,
L-2134 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182.282.
ONT COMPARU:
Motor Holdings Limited., une société constituée selon les lois de Iles Caïmans, ayant son siège social à Paget-Brown
Trust Company Limited, Boundary Hall, Cricket Square, PO Box 1111, Grand Cayman, KY1-1102, Iles Caïmans, enre-
gistrée auprès du Registre des Sociétés des Iles Caïmans sous le numéro PB 285322 (“MH Limited”), et
Dr Mario Albert THEISSEN, un citoyen allemand, domicilié à Abensbergstr 51, Munich, Allemagne (“Dr Theissen”).
Toutes les parties comparantes sont ici représentées par Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant
professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling, (le “Mandataire”), en vertu de deux procurations sous
seing privé lui délivrées; lesquelles procurations, après avoir été signées “ne varietur” par le Mandataire et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte afin d'être enregistrées avec lui.
MH Limited, l’associé existant de la Société, représentant l’intégralité du capital social, déclare, après avoir renoncé à
toute exigence de préavis, que cette Assemblée a été valablement constituée et peut délibérer valablement sur tous les
points de l’ordre du jour suivant auquel Dr Theissen participa et vota les point 3 et suivants seulement:
<i>Ordre du jouri>
1. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel d’un million vingt-cinq mille euros (EUR
1.025.000.-) à un montant d’un million vingt-cinq mille trente-quatre euros (EUR 1.025.034,-) par l’émission de trente-
quatre (34) parts sociales ordinaires ayant chacune une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-), ayant les mêmes droits et
obligations que les parts sociales existantes de la Société.
2. Souscription et paiement des parts sociales nouvellement émises comme spécifié sous le point 1. ci-dessus par un
apport en numéraire de Dr Theissen.
3. Nouvelle augmentation du capital social de la Société, d’un montant d’un million vingt-cinq mille trente-quatre euros
(EUR 1.025.034,-) à un montant d’un million vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.026.384,-) par
l’émission de cent trente-cinq (135) parts sociales dans chacune des dix catégories de parts sociales préférentielles, à
savoir les catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J», (les Parts Sociales Préférentielles).
4. Souscription et paiement des Parts sociales Préférentielles nouvellement émises comme indiqué dans le point 3. ci-
dessus par un apport en numéraire reçu de Dr Theissen.
5. Modification des statuts de la Société (les «Statuts») afin de refléter l’augmentation du capital social de la Société
spécifiée dans les points 1 et 3 ci-dessus.
6. Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus, pouvoir et autorité
ayant été conférés à tout gérant de la Société afin de procéder individuellement à l’enregistrement dans le registre des
parts sociales de la Société de (i) l’augmentation du capital social de la Société mentionnée ci-dessus et (ii) de veiller à
effectuer toutes les formalités à cet égard.
7. Divers.
Après avoir passé en revue chaque point à l’ordre du jour, l’Assemblée a pris à l’unanimité, et prié le notaire d’ins-
trumenter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société de son montant actuel d’un million vingt-cinq mille euros
(EUR 1.025.000,-) à un montant d’un million vingt-cinq mille trente-quatre euros (EUR 1.025.034,-) par l’émission de
trente-quatre parts sociales ordinaires (34) ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes
droits et obligations que les parts sociales ordinaires existantes de la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante pour et l’entière libération de l’augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Dr Theissen déclare souscrire à trente-quatre (34) nouvelles parts sociales sous forme nominative d’une valeur no-
minale d’un euro (EUR 1,-) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes
de la Société et de libérer entièrement la valeur nominale desdites parts sociales par un apport en numéraire de trente-
quatre euros (EUR 34,-).
La somme de trente-quatre euros (EUR 34,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné,
lequel le reconnaît expressément.
36322
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant d’un million vingt-cinq mille trente-quatre
euros (EUR 1.025.034,-) à un montant d’un million vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.026.384,-)
par l’émission de cent trente-cinq (135) parts sociales dans chacune des dix catégories de parts sociales préférentielles,
à savoir les catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I, et J (les «Parts Sociales Préférentielles»).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Assemblée décide d’accepter et d’enregistrer la souscription suivante pour et l’entière libération de l’augmentation
du capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Dr Theissen déclare souscrire à cent trente-cinq (135) Parts sociales Préférentielles dans chacune des dix nouvelles
Catégories de parts sociales préférentielles, lesquelles seront sous forme nominative et ayant chacune une valeur nominale
d’un euro (EUR 1,-) et émises à une valeur prime de soixante-treize euros zéro quatre huit huit huit neuf centimes (EUR
73,048889) par part sociale et de libérer entièrement lesdites Parts sociales Préférentielles par un apport en espèces de
quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-six euros (EUR 99.966,-) desquels mille trois cent cinquante euros (EUR
1.350,-) seront alloués au capital social de la Société et quatre-vingt-dix-huit mille six cent seize euros (EUR 98.616,-)
seront alloués à la prime d’émission de la Société.
La somme de quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent soixante-six euros (EUR 99.966,-) est à la disposition de la Société,
ce qui a été prouvé au notaire soussigné, lequel le reconnaît expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, l’Assemblée décida de modifier les Statuts de la Société comme suit:
1. L’article 5.1 des Statuts de la Société est modifié de sorte qu'il se lit comme suit:
« 5. Capital.
5.1. Le capital de la Société est fixé à un million vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.026.384,-)
représenté par:
5.1.1. Vingt-cinq mille trente-quatre (25.034) parts sociales ordinaires (les «parts sociales ordinaires») sous forme
nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;
5.1.2. Un million mille trois cent cinquante (1.001.350) parts sociales préférentielles (les «Parts Sociales Préférentiel-
les») sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR. 1.-) chacune, toutes souscrites et entièrement
libérées, divisées en dix Catégories de «Parts sociales de Catégories A, B, C, D, E, F, G, H, I et J» comme défini ci-dessous:
i) Cent mille cent trente-cinq(100.135) parts sociales de Catégorie A;
ii) Cent mille cent trente-cinq(100.135) parts sociales de Catégorie B;
iii) Cent mille cent trente-cinq(100.135) parts sociales de Catégorie C;
iv) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie D;
v) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie E;
vi) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie F;
vii) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie G;
viii) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie H;
ix) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie I;
x) Cent mille cent trente-cinq (100.135) parts sociales de Catégorie J»;
<i>Sixième résolutioni>
L’Assemblée décida de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus,
pouvoir et autorité ayant été conférés à tout gérant de la Société afin de procéder individuellement à l’enregistrement
dans le registre des parts sociales de la Société de (i) l’augmentation du capital social de la Société mentionnée ci-dessus
et (ii) de veiller à effectuer toutes les formalités à cet égard.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de mille sept cents
euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des parties
comparantes le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes parties compa-
rantes, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
36323
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire des parties comparantes, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 janvier 2015. 2LAC/2015/1916. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015024903/239.
(150028991) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
CLS Tangendis S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Dachstein S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 115.721.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of January.
Before Us, Maître Martine SCAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
CLS Luxembourg, a "société à responsabilité limitée", having its registered office at 55, Avenue de la Gare, L-1611
Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg under the number B 110.163
(the “Sole Shareholder”),
hereby represented by Maître Benoît CAILLAUD, lawyer, with professional address at 8, rue Sainte Zithe, L-2763
Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal with power of substitution given in Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg on January 26
th
, 2015.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned
notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party is the sole shareholder of Dachstein S.à r.l., a "société à responsabilité limitée", having its registered
office at 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg under the number B 115.721, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard LECUIT, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on April 12
th
, 2006, published in the Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 1249 of June 28
th
, 2006. The articles of association of the Company have not yet been amended
since.
The Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the object of the Company and therefore resolves to amend Article 2 of the
articles of association of the Company, which shall read as follows:
“ Art. 2. The Company has as its main corporate object the investment in real estate or real estate related assets,
situated in Luxembourg or abroad, in order to derive income from its rental and management. This will be undertaken
through acquisition, option of purchase, development and construction of real estate or by any other means. The Company
may, from time to time, realise its investments in real estate by sale or any other means.
The Company may, by acquisition of holdings in whatever form or by any other type of investment or security, take
part in the establishment and development of any company, registered in Luxembourg or abroad, manufacturer or com-
mercial, having an identical, similar or related corporate purpose than the corporate purpose of the Company or which
can facilitate or promote the development of the Company, as well as administer, manage, develop financially, improve,
oversee and liquidate, permanently or temporarily, those interests or holdings. The Company can also give assistance to
any such company as well as to any company being part of the same group of companies as the Company by means of
loans, advances, guarantees or otherwise.
Finally, the Company may carry out, both in Luxembourg and abroad, any kind of general, industrial, commercial,
financial, movable or real estate operations as well as any measures of control or supervision relating directly or indirectly,
in all or in part, to the fulfillment of its corporate purpose as referred to in the above two paragraphs, including to request
financing in its favour from any Luxembourg or foreign credit institutions or from a different company or natural person
by means of loans, advances, guarantees, mortgage or by any other means.”
36324
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company into “CLS Tangendis S.à r.l.” and therefore decides
to amend Article 4 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:
“ Art. 4. The Company will have the name “CLS Tangendis S.à r.l.”.”
<i>Estimated costsi>
The aggregate amount of costs, remunerations or expenses which shall be charged to the Company by reason of this
deed, are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties it is
stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts, the English version shall prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The document having been read to the representative of the appearing party, the said person signed, together with
the notary, the present original deed.
Suit la traduction française
L'an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
CLS Luxembourg, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 55, Avenue de la Gare, L-1611 Lu-
xembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 110.163
(l'«Associé Unique»),
ici dûment représentée par Monsieur Benoît CAILLAUD, Avocat à la Cour, résidant professionnellement au 8, rue
Sainte Zithe, L-2763 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg le 26 janvier 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-
trumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
La partie comparante est l'Associé Unique de Dachstein S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège
social au 55, Avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 115.721, constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 avril 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 1249 du 28 juin 2006. Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés depuis.
L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société et décide de modifier l'article 2 des statuts de la Société
de la façon suivante:
« Art. 2. La Société a comme objet social principal l'investissement dans l'immobilier ou dans les actifs liés à l'immobilier,
situés à Luxembourg ou à l'étranger, afin de générer des revenus provenant de leur location et leur gestion. Cela pourra
se réaliser par l'acquisition, l'option d'achat, le développement et la construction d'immeubles ou par tout autre moyen.
La Société peut, de temps à autre, effectuer des investissements dans l'immobilier par la vente ou tout autre moyen.
La Société peut, par la prise de participations de quelque forme que ce soit ou par toute autre forme de placement
ou valeurs mobilières, prendre part à l'établissement et au développement de toute entreprise, immatriculée au Luxem-
bourg ou à l'étranger, industrielle ou commerciale, ayant un objet social identique, analogue ou connexe à l'objet social
de la Société ou qui est de nature à favoriser ou faciliter le développement de la Société, ainsi qu'administrer, gérer,
développer financièrement, mettre en valeur, superviser et liquider, à titre permanent ou temporaire, ces intérêts ou
participations. La Société peut également prêter assistance à une telle entreprise ainsi qu'à toute société faisant partie du
même groupe de sociétés que la Société au moyen de prêts, avances, garanties ou autrement.
Pour finir, la Société peut accomplir, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques,
industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières ainsi que toutes mesures de contrôle ou de surveil-
lance se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'accomplissement de son objet social tel que
défini aux deux paragraphes ci-dessus, parmi lesquelles solliciter des financements en sa faveur auprès de tout établisse-
ment de crédit luxembourgeois ou étranger ou de toute autre société ou personne physique au moyen de prêts, avances,
garanties, hypothèques ou de tout autre manière.»
36325
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société en «CLS Tangendis S.à r.l.» et décide de modifier
l'article 4 des statuts de la Société de la façon suivante:
« Art. 2. La Société aura la dénomination: «CLS Tangendis S.à r.l.».»
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations et charges, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge
à raison du présent acte s'élève à environ mille trois cents euros (1.300.- EUR).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle la langue anglaise, constate que les comparants ont requis de documenter
le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête desdits comparants, en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, celui-ci a signé le présent acte avec
le notaire.
Signé: B. Caillaud et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 09 février 2015. 2LAC/2015/2856. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-.
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024901/119.
(150029228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Darter Holdings II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 193.074.
In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of the month of January;
Before Us Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
undersigned;
THERE APPEARED:
Darter Holdings I S.à r.l. a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a corporate capital of one million twenty six thousand three hundred and
eighty four euros (EUR 1,026,384), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and regis-
tered with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 182.282.
(hereafter referred to as the “Sole Shareholder”),
here represented by Mr. Frank STOLZ, notary clerk, residing professionally 13, avenue François Clément, L-5612
Mondorf-les-Bains, Luxembourg (the “Proxy-holder”),
by virtue of a proxy given under private seal given on 12 January 2015; such proxy, after having been signed “ne varietur”
by the Proxy-holder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.
Such appearing party, declared that it currently holds all the shares issued by Darter Holdings II S.à r.l., (the “Company”),
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg by a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg on 16 December 2014, which deed is
yet to be published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, with a corporate capital of twelve thousand,
five hundred euros (EUR 12,500), having its registered office at 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Company Register under number B 193074:
The appearing party, represented as above stated, in its capacity of sole shareholder of the Company, then took the
following resolutions and made the following declarations:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to reduce the par value of the shares issued by the Company from their existing twenty-
five euros (EUR 25.-) per share to one euro (EUR 1.-) per share and to increase the number of shares accordingly, in
order to set the share capital of the Company at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-), represented by
twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.
36326
L
U X E M B O U R G
As a result of the above, the Sole Shareholder holds twelve thousand five hundred (12,500) shares with a par value of
one euro (EUR 1.-) each.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to increase the Company's share capital by an amount of twelve thousand five hundred
and thirty-four euros (EUR 12,534.-), so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euros
(EUR 12,500.-) to twenty-five thousand and thirty-four euros (EUR 25,034.-) by the issue of twelve thousand five hundred
and thirty-four (12,534) new shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each and issued at a premium
value of five thousand eight hundred and ninety-six euros and zero nine five three four cents (EUR 5,896.09534) each,
having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and to be paid up in full.
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for the twelve thousand five hundred and
thirty four (12,534) new shares in registered form, with a par value of one euro (EUR 1.-) each and issued at a premium
value of five thousand eight hundred and ninety-six euros and zero nine five three four cents (EUR 5,896.09534) each,
having the same rights and privileges as those attached to the existing shares of the Company and to fully pay for such
shares by a contribution in cash amounting to seventy-three million nine hundred and fourteen thousand one hundred
and ninety-three euros (EUR 73,914,193.-) out of which twelve thousand five hundred and thirty four euros (EUR 12,534.-)
shall be allocated to the share capital of the Company and seventy-three million nine hundred and one thousand six
hundred and fifty-nine euros (EUR 73,901,659.-) shall be allocated to the share premium account of the Company.
The amount of seventy-three million nine hundred and fourteen thousand one hundred and ninety three euros (EUR
73,914,193.-) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknow-
ledges it.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend article 5.1 of the Company's articles of association, to reflect the above
capital increase, as follows:
“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand and thirty-four euros (EUR 25,034), repre-
sented by twenty-five thousand and thirty- four (25,034) shares in registered form with a par value of one euro (EUR 1.-)
each, all subscribed and fully paid-up.”
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately seven thousand five hundred
Euros (EUR 7,500).
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
party, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, at the date
indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the Proxy-holder of the appearing party, acting as said before, known to the notary
by name, first name, civil status and residence, the said Proxy-holder has signed with us the notary the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Marc LOESCH, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Luxembourg (Grand-Duché de Lu-
xembourg), soussigné;
A COMPARU:
Darter Holdings I S. à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
ayant un capital social d’un million vingt-six mille trois cent quatre-vingt-quatre (EUR 1.026.384), ayant son siège social
au 58, rue Charles Martel, à L-2134 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés lu-
xembourgeois sous le numéro B 182.282 ((l’“Associé Unique”),
ici représentée par Monsieur Frank STOLZ, clerc de notaire, demeurant professionnellement à 13, avenue François
Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Luxembourg, (le “Mandataire”),
en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée en date du 12 janvier 2015; laquelle procuration, après avoir
été signée “ne varietur” par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enre-
gistrée avec lui.
36327
L
U X E M B O U R G
Laquelle comparante, dûment représentée, déclare détenir l’intégralité des parts sociales de Darter Holdings II S.à r.l.
(la “Société”), une société à responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par acte de
Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, le 16 décembre 2014, lequel acte doit être publié au Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations, ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12,500), ayant
son siège social au 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 193.074.
Laquelle partie comparante, dûment représentée, comme indiqué ci-dessus, en sa qualité d'associé unique de la Société
a adopté les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de réduire la valeur nominale des parts sociales émises par la Société de son montant actuel
de vingt-cinq euros (EUR. 25) par part sociale à un euro (EUR. 1,-) par part sociale et d’augmenter le nombre de parts
sociales en conséquence, afin d’établir le capital social de la Société à douze mille cinq cents euros (EUR. 12.500,-),
représenté par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune.
En raison de ce qui précède, l’Associé Unique détient douze mille cinq cents (12.500) parts sociales avec une valeur
nominale d’un euro (EUR. 1) chacune.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille cinq cent trente-
quatre euros (EUR 12.534,-) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à
un montant de vingt-cinq mille trente-quatre euros (EUR. 25.034,-), par l’émission de douze mille cinq cent trente-quatre
(12.534) nouvelles parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et émises à
une valeur prime de cinq mille huit cent quatre-vingt-seize euros et zéro neuf cinq trois quatre centimes (EUR 5.896,
09534) chacune, et conférant les mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes, devant être
libérées dans leur intégralité.
<i>Souscription - Libérationi>
Dès lors, l’Associé Unique déclara souscrire à douze mille cinq cent trente-quatre (12.534) nouvelles parts sociales
sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune, et émises à une valeur de prime de cinq mille
huit cent quatre-vingt-seize euros et zéro neuf cinq trois quatre centimes (EUR 5.896,09534 euros chacune et ayant les
mêmes droits et privilèges que ceux attachés aux parts sociales existantes de la Société et les libérer entièrement par un
apport en numéraire de soixante-treize millions neuf cent quatorze mille cent quatre-vingt-treize euros (EUR 73.914.193)
duquel douze mille cinq cent trente-quatre euros (12.534) seront alloués au capital social de la Société et soixante-treize
millions neuf cent un mille six cent cinquante-neuf euros (EUR. 73.901.659,-) seront alloués à la prime d’émission de la
Société.
La somme de soixante-treize millions neuf cent un mille six cent cinquante-neuf euros (EUR. 73.901.659,-) est à la
disposition de la Société, ce qui a été prouvé au notaire soussigné, lequel le reconnaît expressément.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décida de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l’augmentation de capital
susmentionnée:
“ 5.1. Le capital de la Société est fixé à vingt-cinq mille trente-quatre euros (EUR 25.034,-), représenté par vingt-cinq
mille trente-quatre (25.034) parts sociales sous forme nominative d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.”
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de sept mille cinq
cents euros (EUR 7.500).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête d de la
comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de la même comparante, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, à la date indiquée en tête des pré-
sentes.
Après lecture du présent acte au Mandataire de la partie comparante, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire
par nom, prénom, état civil et domicile, ledit Mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
36328
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 19 janvier 2015. GAC/2015/588. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024904/143.
(150028648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Fadeka S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Enseigne commerciale: MillionHair.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 194.454.
STATUTS
L'an deux mille quinze, le cinq février.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
ONT COMPARU:
1. Madame Ekaterina FADEEVA, coiffeuse, née à Ulyanovsk (Russie), le 29 septembre 1973, demeurant à L-4239 Esch-
sur-Alzette, 18, place Norbert Metz; et
2. Monsieur Alexey FADEEV, né à Ulyanovsk (Russie), le 15 septembre 1972, demeurant à L-4239 Esch-sur-Alzette,
18, place Norbert Metz.
Lesquelles comparants ont requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-
sabilité limitée qu'ils déclarent constituer par les présentes et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
Titre I
er
. - Dénomination - Objet - Durée - Siège social
Art. 1
er
. Il est formé par la présente, entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui
pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée dénommée FADEKA S.à r.l., (ci-après la "Société"),
exerçant son activité commerciale sous l’enseigne commerciale «MillionHair», laquelle société sera régie par les présents
statuts (les "Statuts") ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales.
Art. 2. La Société a pour objet l’exploitation d'un ou de plusieurs salons de coiffure ainsi que la vente d'articles de la
branche.
Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mo-
bilières, immobilières ou autres se rapportant directement ou indirectement, à son objet social ou susceptibles d'en
favoriser la réalisation.
Art. 3. La durée de la Société est illimitée.
Art. 4. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège
social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision de la gérance.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés
délibérant comme en matière de modification des statuts.
Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des filiales, succursales, agences ou sièges administratifs
aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger.
Titre II. - Capital social - Parts sociales
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR), représenté par cent (100) parts sociales
de cent vingt-cinq euros (125.- EUR) chacune, intégralement libérées.
Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de la
loi concernant les sociétés commerciales.
Art. 6. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime
de tous les associés.
En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les
trente (30) jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption,
36329
L
U X E M B O U R G
la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur
les sociétés commerciales.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des
scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.
Titre III. - Administration et gérance
Art. 8. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment
par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 10. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux Statuts doivent réunir la majorité des associés repré-
sentant les trois quarts (3/4) du capital social.
Art. 11. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les Statuts à l’assemblée
générale sont exercés par l’associé unique.
Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par
écrit.
De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-
verbal ou établis par écrit.
Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 12. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
Art. 13. Chaque année, le 31 décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.
Art. 15. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué à l’/aux associé(s) en proportion avec sa/leur participation dans le capital
de la Société.
La gérance est autorisée à décider et à distribuer des dividendes intérimaires, à tout moment, sous les conditions
suivantes:
1. la gérance préparera une situation intérimaire des comptes de la société qui constituera la base pour la distribution
des dividendes intérimaires;
2. ces comptes intérimaires devront montrer des fonds disponibles suffisants afin de permettre une distribution, étant
entendu que le montant à distribuer ne peut pas excéder les bénéfices réalisés à la clôture de l’exercice fiscal précédent,
augmenté du bénéfice reporté et réserves distribuables et diminué des pertes reportées et montants alloués à la réserve
légale, en conformité avec la Loi ou les présents Statuts.
Art. 16. L'année sociale commence le 1
er
janvier et finit le 31 décembre.
Titre IV. - Dissolution - Liquidation
Art. 17. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.
Titre V. - Dispositions générales
Art. 18. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur application
partout où il n'y est pas dérogé par les Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.
36330
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et libérationi>
Les Statuts ayant ainsi été arrêtés, les cent (100) parts sociales ont été souscrites comme suit:
1) Madame Ekaterina FADEEVA, pré-qualifiée,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
2) Monsieur Alexey FADEEV, pré-qualifié,
cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, est évalué à environ mille deux cents euros (1.200.- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et aussitôt, les associés, représentant l’intégralité du capital social, et se considérant comme dûment convoqués, se
sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
1. La personne suivante est nommée gérante de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Ekaterina FADEEVA, coiffeuse, née à Ulyanovsk (Russie), le 29 septembre 1973, demeurant à L-4239 Esch-
sur-Alzette, 18, place Norbert Metz, gérante technique.
2. La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature individuelle de la
gérante technique.
3. Le siège social est établi à L-1118 Luxembourg, 9A, rue Aldringen.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparantes au fait qu'avant toute activité commerciale de la Société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparantes.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparantes, connues du notaire par noms, prénoms usuels, états
et demeures, elles ont signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E. Fadeeva, A. Fadeev et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 9 février 2015. 2LAC/2015/2863. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 février 2015.
Référence de publication: 2015024993/135.
(150028534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Grand City Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1750 Luxembourg, 24, avenue Victor Hugo.
R.C.S. Luxembourg B 165.560.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth day of January,
Before the undersigned, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, acting in replacement of Maître
Henri HELLINCKX, notary residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed,
There appeared:
The board of directors of Grand City Properties S.A., a société anonyme, incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, regis-
tered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 under number B 165.560, incorporated
pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011 and published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association
of the Company have last been amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX on 22 December 2014, and
not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
36331
L
U X E M B O U R G
here represented by Tara Nestor, professionally residing in Luxembourg, acting as the representative of the board of
directors of Grand City Properties S.A. pursuant to a resolution of the board of directors taken on 31 December 2014.
An excerpt of the minutes of said board resolution, initialled “ne varietur” by the appearing person and the notary will
remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The proxyholder of the appearing person, acting in the aforementioned capacity, has requested the undersigned notary
to state the following declarations:
1) Grand City Properties S.A. (hereinafter the “Company”) was incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg pursuant to a deed of Maître Carlo WERSANDT, notary resident in Luxembourg, on 16 December 2011,
and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register on 23 December 2011 and published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745 on 2 February 2012. The articles of association of the Company
have last been amended pursuant to a deed of Maître Henri HELLINCKX on 22 December 2014, and not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
2) According to article 5.1 of the articles of association, the issued share capital of the Company is currently set at
eleven million eight hundred and forty nine thousand two euro and thirty cents (EUR 11,849,002.30), divided into one
hundred and eighteen million four hundred and ninety thousand and twenty-three (118,490,023) shares having a par value
of EUR 0.10 each, all of which are fully paid up.
3) Pursuant to article 5.2 of the articles of association, the authorized share capital is set at twenty million euro (EUR
20,000,000) and the board of directors is authorised to issue shares within the limit of the authorised share capital, to
such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed with such issue without reserving a preferential
subscription right for the existing shareholders.
4) The Company issued EUR 150,000,000 1.5% convertible bonds due 2019 on 24 February 2014 and EUR 125,000,000
1.5% convertible bonds due 2019 on 19 June 2014 (the “Series C Bonds”). The Company has received one conversion
notice from holders of the Series C Bonds from Bank Hapoalim B.M. Head Office Tel-Aviv, Israel dated 31 December
2014, in respect of the conversion of 5 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 500,000 with a
conversion price of EUR 9.7226 (the “Conversion Notice”).
5) In its resolutions dated 31 December 2014, the board of directors of the Company has decided to increase the
share capital of the Company by an amount of five thousand and one hundred forty-two euro and sixty cents (EUR
5,142.60) so as to raise it from its current amount of eleven million eight hundred forty nine thousand two euro and
thirty cents (EUR 11,849,002.30) to eleven million eight hundred and fifty four thousand one hundred forty four euro
and ninety cents (EUR 11,854,144.90) through the issuance of fifty one thousand four hundred and twenty six (51,426)
new shares of the Company with a par value of ten cents (EUR 0.10). In accordance with article 5.2 of the articles of
association, the board of directors has decided to suppress the preferential right of subscription of the existing share-
holders in relation to this capital increase.
6) The newly issued shares have been issued for an aggregate price of five hundred thousand euro (EUR 500,000) by
the conversion of the 5 Series C Bonds with an aggregate principal amount of EUR 500,000 (made sufficiently and com-
prehensively known to the board by the Conversion Notice), so that out of the amount of five hundred thousand euro
(EUR 500,000), five thousand one hundred and forty two euro and sixty cents (EUR 5,142.60) are allotted to the corporate
share capital of the Company and the amount of four hundred ninety four thousand eight hundred fifty seven euro and
forty cents (EUR 494,857.40) is allotted to the share premium account. The supporting documents of the conversion
have been produced to the undersigned notary.
As a consequence of the aforementioned capital increase, the first paragraph of article 5.1 of the articles of association
shall be amended, which shall henceforth read as follows:
“ 5.1. The subscribed capital of the Company is fixed at eleven million eight hundred fifty four thousand one hundred
forty four euro and ninety cents (EUR 11,854,144.90) represented by one hundred and eighteen million five hundred
forty one thousand four hundred and forty nine (118,541,449) shares of a par value of ten cents (EUR 0.10) each.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to EUR 2,200.--
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing party and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail. The
document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name, civil
status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en français du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huit janvier.
36332
L
U X E M B O U R G
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Henri
HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg, lequel dernier restera dépositaire de la présente minute,
A comparu:
Le Conseil d'Administration de Grand City Properties S.A., une société anonyme constituée et existante sous les lois
du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 sous le numéro B 165.560,
constituée suivant un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX le 22 décembre 2014, et non encore publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Représenté ici par Tara Nestor, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en qualité de représentant du
conseil d'administration de Grand City Properties S.A. en vertu d'une résolution du conseil d'administration prise le 31
décembre 2014.
Un extrait du procès-verbal dudit conseil d'administration, paraphé «ne varietur» par la personne comparante et le
notaire instrumentaire, restera annexé au présent acte pour être soumis avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Le mandataire de la personne comparante, agissant en la capacité susmentionnée, a requis le notaire instrumentaire
d'acter les déclarations suivantes:
1) Grand City Properties S.A. (ci-après la «Société») a été constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg
en vertu d'un acte de Maître Carlo WERSANDT, notaire résidant à Luxembourg, le 16 décembre 2011 et enregistré
auprès le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg le 23 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations n° 287, p.13745, du 2 février 2012. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois suivant un acte de Maître Henri HELLINCKX le 22 décembre 2014, et non encore publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.
2) Conformément à l'article 5.1 des statuts, le capital émis de la Société est actuellement fixé à onze millions huit cent
quarante-neuf mille deux euros et trente centimes (11.849.002,30 EUR), divisé en cent dix-huit millions quatre cent
quatre-vingt-dix mille vingt-trois (118.490.023) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euro (0,10 EUR)
chacune, toutes entièrement libérées.
3) En vertu de l'article 5.2 des statuts, le capital autorisé est fixé à vingt millions d'euros (20.000.000 EUR) et le conseil
d'administration est autorisé à émettre des actions endéans les limites du capital autorisé, au profit des personnes et dans
les conditions qu'il jugera appropriées, et spécifiquement de procéder à cette émission sans réserver un droit préférentiel
aux actionnaires existant.
4) La Société a émis 150.000.000 EUR 1,5% obligations convertibles en 2019 le 24 février 2014 et 125.000.000 EUR
1,5% obligations convertibles en 2019 le 19 juin 2014 (les «Obligations de Série C»). La Société a reçu un avis de conversion
des détenteurs des Obligations de Séries C de la Banque Hapoalim B.M. Head Office, Tel-Aviv, Israël daté du 31 décembre
2014, relatif à la conversion des 5 Obligations Séries C d'un montant principal de 500.000.- EUR chacune avec un prix de
conversion de 9,7226 EUR (l'"Avis de Conversion").
5) Dans les résolutions datées du 31 décembre 2014, le conseil d'administration de la Société a décidé d'augmenter
le capital social de la Société d'un montant de cinq mille cent quarante-deux euros et soixante cents (5.142,60 EUR) de
manière à le faire passer de son montant actuel de onze millions huit cent quarante-neuf mille deux euros et trente
centimes (11.849.002,30 EUR) à onze millions huit cent cinquante-quatre mille cent quarante-quatre euros et quatre-
vingt-dix centimes (EUR 11.854.144,90) par l'émission de cinquante-et-un mille quatre cent vingt-six (51.426) nouvelles
actions de la Société d'une valeur nominale de dix centimes d'euro (0.10 EUR).
Conformément à l'article 5.2 des statuts, le conseil d'administration a décidé de supprimer le droit de souscription
préférentiel des actionnaires existant dans le cadre de l'augmentation de capital.
6) Les actions nouvelles ont été émises pour un prix global de cinq cent mille euros (500.000 EUR) par la conversion
de 5 Obligations Séries C d'un montant principal de 500.000 EUR (portée à la connaissance de façon suffisante et complète
du conseil par les Avis de Conversion), de telle sorte que du montant de cinq cents mille euros (500.000 EUR), cinq mille
cent quarante-deux euros et soixante centimes (5.142,60 EUR) sont alloués au capital social de la Société et le montant
de quatre cent quatre-vingt quatorze mille huit cent cinquante-sept euros et quarante centimes (494.857,40 EUR) est
alloué au compte de prime d'émission. Les documents relatifs à la conversion des obligations en actions ont été présentés
au notaire soussigné.
En conséquence de l'augmentation de capital susmentionnée, le premier paragraphe de l'article 5.1 des statuts est
modifié, lequel se lit désormais comme suit:
« 5.1. Le capital souscrit de la Société est fixé à onze millions huit cent cinquante-quatre mille cent quarante-quatre
euros et quatre-vingt-dix centimes (EUR 11.854.144,90) représenté par cent dix-huit millions cinq cent quarante-et-un
mille quatre cent et quarante-neuf (118.541.449) actions d'une valeur de dix centimes d'euro (0,10 EUR) chacune.»
36333
L
U X E M B O U R G
<i>Frais et Dépensesi>
Les frais, dépenses, rémunération et charges de quelque forme que ce soit incombant à la Société et chargés à raison
du présent acte sont évalués à EUR 2.200.-
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la demande des mêmes comparantes et en cas de
divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: T. NESTOR et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 12 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/851. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): C. FRISING.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015025034/144.
(150028025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Florent S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8081 Bertrange, 32, route de Mamer.
R.C.S. Luxembourg B 194.465.
STATUTS
L'an deux mil quinze, le vingt-six janvier.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
1) Monsieur Safet ADROVIC, commerçant, né le 2 novembre 1967 à Pec (Yougoslavie), demeurant à L-5825 Fentange,
25 rue Victor Feyder,
2) Monsieur Naser KUQI, commerçant, né le 27 septembre 1969 à Lutogllavië (Yougoslavie), demeurant à L-2272
Howald, 30 rue Edouard Oster,
3) Monsieur Shaip ZENELI, commerçant, né le 5 mars 1967 à Mazhiq (Kosovo), demeurant à L-2272 Howald, 22, rue
Edouard Oster,
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à responsabilité limitée dont
ils ont arrêté les statuts comme suit:
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-
après la “Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après
la “Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les “Statuts”).
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d’un restaurant-brasserie avec débit de boissons alcooliques et non-
alcooliques.
Dans le cadre de son activité, la société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter
caution pour d’autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.
Elle pourra effectuer toutes opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se rapportant directe-
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus et susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. La Société aura la dénomination «FLORENT S.à r.l.».
Art. 5. Le siège social est établi à BERTRANGE.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.
Art. 6. Le capital social est fixé à VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000,- EUR) représenté par deux cent cinquante
parts sociales (250) parts sociales d’une valeur nominale de cent euros (100,- EUR) chacune, entièrement libérées.
Art. 7. Le capital peut être modifié à tout moment par une décision de l’associé unique ou par une décision de l’as-
semblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents Statuts.
36334
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec
le nombre des parts sociales existantes.
Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.
Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-
missibles.
Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles
que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.
Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la
faillite de l’associé unique ou d’un des associés.
Art. 12. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. S’il y a deux gérants ou plus, les gérants
formeront un conseil de gérance composé de gérants de catégorie A et de gérants de catégorie B. Le(s) gérant(s) sont
révocables ad nutum.
Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer
et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.
Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts
seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.
La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de conseil de gérance composé de deux
membres ou plus par la signature conjointe d’un gérant A et d’un gérant B.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour
des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération
(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.
En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées par tous les gérants présents ou
représentés.
Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs qui lui sont conférés par l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de
part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.
Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité d’associés
détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.
Art. 15. L’année sociale commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de
pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.
Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaire et bilan au siège social.
Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-
sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.
Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la
Société.
Le Gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance est autorisé à verser des acomptes sur dividendes, sous
condition que des comptes intérimaires aient été établis et fassent apparaître assez de fonds disponibles pour une telle
distribution, en respect des conditions prévues par la loi.
Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés
ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.
Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la
Loi.
36335
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription - Libérationi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, les comparants déclarent souscrire le capital comme suit:
* Monsieur Safet ADROVIC, prénommé
Quatre-vingt-six parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
* Monsieur Naser KUQI, prénommé
Quatre-vingt-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
* Monsieur Shaip ZENELI, prénommé
Quatre-vingt-deux parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
TOTAL DEUX CENT CINQUANTE PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées, de sorte que la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS
(25.000,- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
Le notaire instrumentant constate que les conditions prévues à l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été respectées.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.
<i>Fraisi>
Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ neuf cent soixante-quinze euros
(975,- EUR).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit et se considérant comme dûment convoqués,
se sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.
Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité des voix les
résolutions suivantes:
1) La Société est administrée:
Monsieur Naser KUQI, prénommé.
La société sera engagée en toutes circonstances par sa seule signature.
2) L'adresse de la Société est fixée à 32, route de Mamer, L-8081 BERTRANGE.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant a rendu attentif les comparants au fait qu'avant toute activité commerciale de la société
présentement fondée, celle-ci doit être en possession d'une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par les comparants.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant par son
nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. ADROVIC, N. KUQI, S. ZENELI, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 28 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/2546. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 février 2015.
Référence de publication: 2015025010/133.
(150028749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Soluxtec Distribution S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 74, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 153.306.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015025456/9.
(150028486) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
36336
ATM S.A.
CLS Tangendis S.à r.l.
Dachstein S.à r.l.
Darter Holdings II S.à.r.l.
Darter Holdings I S.à r.l.
Digital Services XLVI S.à r.l.
Digital Services XLV S.à r.l.
Fadeka S.à.r.l.
Florent S.à.r.l.
Grand City Properties S.A.
Maroquinerie du Centre Sàrl
MCG - Change Management Consulting Sàrl
MEAG Luxembourg S.à r.l.
Mola Sàrl
Monique Follmann-Fohl GCM S.àr.l.
MPI S.à r.l.
Neerveld 101-103 S.à r.l.
Omnium S.A.
Opensys S.à r.l.
Origante Investments S.A., SPF
Promocom
Ruffer SICAV
Salon PS Pure Style s.à r.l.
Sanogreen S.à.r.l.
Santé Sécurité au Travail Luxembourg
Savile Capital S.A.
Schweich S.à r.l.
Select Commerce S.A.
Silver Rose S.A.
Société de Financement Médical et Hospitalier
Société de Financement Médical et Hospitalier
Soluxtec Distribution S.A.
Sotreca
Spa Di Walla Invester S.C.A.
STAR Agatha Investments S.à r.l.
Suki Finance S.à r.l.
Sun Investments
Terra Finance Management S.A.-SPF
Togiram S.A.
Truffle S.A.
Tuileries Participation S.A.
U.A.I. (Luxembourg) II S.à r.l.
Vinci I S.A.
Vinci I S.A.
Visago Holding S.A.
Würzburg Estates S.A.