This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 738
18 mars 2015
SOMMAIRE
Abengoa Concessions Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35388
Atlantas Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35380
Aurea Finance Company . . . . . . . . . . . . . . . .
35383
Axxion Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35386
Brindleyplace Partner S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
35389
Brugama SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35381
Capale S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35380
Cordalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35378
CoreCommodity Strategy Fund . . . . . . . . .
35385
EDO Berlin Office S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
35411
EDO Treptower S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35415
Ely International SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . .
35378
Expert Petroleum Holdings S.à r.l. . . . . . . .
35407
Expert Petroleum SPV S.à r.l. . . . . . . . . . . .
35407
Financial China S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35388
Fundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35379
Germany White Invest S.A. . . . . . . . . . . . . .
35388
Global Diversified Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . .
35378
Goldman Sachs Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35385
Immobilière Bless S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
35386
ING Life Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
35423
ING Lux Insurance International S.A. . . . .
35421
Ipsila S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35379
Isaias S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35381
J.A.F. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35379
Kavialux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35384
Kortstrukt S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35384
Longview Partners Investments . . . . . . . . .
35384
Luxbond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35382
Luxcash . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35381
Mapicius S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35382
Micheline Invest S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . .
35383
Nacaza S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35383
NN Life Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . .
35423
NN Lux Insurance International S.A. . . . .
35421
Pharus Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35424
Pioneer Institutional Funds . . . . . . . . . . . . .
35386
SEB FS Fund Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . .
35387
Sodexo Senior Service S.A. . . . . . . . . . . . . .
35387
SODIMEG S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35388
SR Portfolio Holding (C) S.à r.l. . . . . . . . . .
35419
S&S Fonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35386
Torcos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35382
Triple A Trading S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35387
Tyack S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35385
VPF International S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
35402
Watford S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35387
35377
L
U X E M B O U R G
Global Diversified Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 80.775.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le <i>8 avril 2015i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2014.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les propriétaires d'actions au porteur et nominatives désirant être présents ou représentés à l'Assemblée Générale
devront en aviser la Société au moins cinq jours francs avant l'Assemblée.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2015042113/755/23.
Ely International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.357.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2015i> à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042111/795/16.
Cordalia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.741.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2015i> à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042110/795/15.
35378
L
U X E M B O U R G
Fundo, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 107.368.
Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de FUNDO à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le <i>7 avril 2015i> à 11.00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires
Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions,
pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procu-
rations sont disponibles au siège social de la SICAV. Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité,
à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bdl.lu) de
leur intention d'assister à l'Assemblée.
Référence de publication: 2015042112/755/21.
J.A.F. S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 77.459.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>7 avril 2015i> à 10.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042115/833/18.
Ipsila S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.742.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2015i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042114/795/15.
35379
L
U X E M B O U R G
Capale S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 3, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 57.276.
Messieurs les Actionnaires sont priés de bien vouloir assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra en date du <i>27 mars 2015i> à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation et approbation du rapport du commissaire aux comptes,
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice clôturant au 30 septembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge au conseil d'administration et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015037517/506/16.
Atlantas Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 33.188.
Le conseil d'administration de la Société a l'honneur de vous convoquer à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires qui se tiendra au siège social de la Société à Luxembourg, le <i>26 mars 2015i> à 14h30, avec l'Ordre du
Jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Compte rendu d'activité pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
2. Rapport du réviseur d'entreprises agréé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
3. Adoption des comptes de l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
4. Accumulation du résultat de l'exercice se terminant le 31 décembre 2014 de tous les compartiments de la Société.
5. Décharge aux Administrateurs pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2014.
6. Nomination, pour une période se terminant avec l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui se tiendra en
2016, des administrateurs suivants :
• Madame Diane de Galard Terraube, administrateur et président du conseil d'administration
• Monsieur Thierry Schaffhauser, administrateur
• Monsieur Geoffroy Linard de Guertechin, administrateur
• Monsieur Guy Verhoustraeten, administrateur
• Monsieur Philippe Visconti, administrateur
• Monsieur Edward de Burlet, administrateur
7. Renouvellement du mandat du réviseur d'entreprises agréé.
8. Divers.
Les actionnaires sont informés qu'aucun quorum n'est requis pour cette assemblée et que les décisions seront prises
à la majorité simple des voix exprimées.
Chaque action a un droit de vote.
Tout actionnaire peut voter par mandataire. A cette fin, des procurations sont disponibles au siège social de la Société
et seront envoyées aux actionnaires sur demande.
Afin d'être valables, les procurations dûment signées par les actionnaires devront être envoyées au siège social de la
Société afin d'être reçues le jour précédant l'assemblée à 17 heures au plus tard.
Les propriétaires d'actions au porteur, désirant participer à cette assemblée, devront déposer leurs actions cinq jours
ouvrables avant l'assemblée au siège social de la Société.
Les actionnaires désireux d'obtenir le rapport annuel révisé au 31 décembre 2014 peuvent s'adresser au siège social
de la Société.
<i>Pour le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015038356/755/38.
35380
L
U X E M B O U R G
Luxcash, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 2, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 33.614.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le mardi <i>7 avril 2015i> à 11.30 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2014.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les actionnaires inscrits au registre des actionnaires nominatifs respectivement au registre des parts au porteur à la
date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'As-
semblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2015042118/755/24.
Brugama SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 10.599.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui se tiendra le <i>3 avril 2015i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
6. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042109/795/18.
Isaias S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 65.538.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Extrait sincère et conforme
ISAIAS S.A.
Signature
Référence de publication: 2015024357/12.
(150027282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
35381
L
U X E M B O U R G
Mapicius S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 86.847.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2015i> à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015042119/795/15.
Luxbond, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 30.521.
Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Sainte
Zithe, le jeudi <i>9 avril 2015i> à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 31
décembre 2014.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises.
6. Divers.
Les actionnaires inscrits au registre des actionnaires nominatifs respectivement au registre des parts au porteur à la
date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'As-
semblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.
Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront
adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.i>
Référence de publication: 2015042117/755/24.
Torcos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8413 Steinfort, 12, rue du Cimetière.
R.C.S. Luxembourg B 163.960.
<i>Extrait du conseil de l'organe de gestion du 20/12/2014i>
<i>Cession de parts socialesi>
A l'unanimité, l'organe de gestion accepte la cession de 60 parts sociales appartenant à la société SAG INDUSTRIES
SA, demeurant 47 Grand Rue à L-1661 Luxembourg au profit de Monsieur Jérôme BUTRYN demeurant 1 Grand Rue à
F-08450 LA BESACE qui accepte la pleine propriété de ces parts sociales lui appartenant dans la société TORCOS S.à.r.l.
Fait à Luxembourg, le 20/12/2014 en trois exemplaires.
Jérôme BUTRYN
<i>Le Géranti>
Référence de publication: 2015023166/15.
(150025930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
35382
L
U X E M B O U R G
Micheline Invest S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 53.372.
Les actionnaires sont priés d'assister à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le <i>27 mars 2015i> à 11.00 heures, pour délibérer sur
l'ordre du jour conçu comme suit:
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comp-
tes pour l'exercice clos au 31 décembre 2014,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2014 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015036716/833/18.
Aurea Finance Company, Société Anonyme.
Siège social: L-7307 Steinsel, 50, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 47.028.
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
des actionnaires d'Aurea Finance Company se tiendra le vendredi <i>27 mars 2015i> à 16 heures au siège de la société, 50,
rue Basse à Steinsel avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice écoulé
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014
3. Approbation des comptes arrêtés au 31 décembre 2014 et quitus aux administrateurs pour leur gestion
4. Répartition du bénéfice net distribuable
5. Renouvellement des mandats d'administrateur et de réviseur d'entreprises
6. Divers
Les actionnaires ayant l'intention d'assister à cette assemblée sont priés de bien vouloir en aviser la société par lettre,
télécopie ou téléphone au moins une heure avant l'ouverture de ladite assemblée.
Référence de publication: 2015031527/18.
Nacaza S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 82.999.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue de manière extraordinaire le 9 février 2015i>
<i>Résolutions:i>
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Antonio Mafrica en date du 9 janvier 2015 et nomme comme
nouvel administrateur avec effet immédiat CL Management S.A. ayant son siège social au Carré Bonn, 20, rue de la poste
L-2346 Luxembourg, son mandat ayant la même échéance que celui de son prédécesseur.
L'assemblée prend acte que le commissaire aux comptes Comco S.A., en date du 30 décembre 2014, a fusionné avec
H.R.T. REVISION S.A., ayant son siège social au 163, rue du Kiem L-8030 Strassen, cette dernière reprenant le mandat
de Commissaire jusqu'ici exercé par Comco S.A.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
NACAZA S.A.
Signatures
Référence de publication: 2015024496/18.
(150027933) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
35383
L
U X E M B O U R G
Longview Partners Investments, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 112.878.
The Board of Directors convenes the Shareholders of the SICAV to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
to be held at the registered office of the company on <i>7 April 2015i> at 11.00 a.m. with the following agenda:
<i>Agenda:i>
1. Report of the Board of Directors and of the Authorised Auditor
2. Approval of the Financial Statements as at 31 December 2014
3. Allocation of Results
4. Discharge to the Directors
5. Appointment of the Authorised Auditor
6. Statutory Elections
The Shareholders are advised that no quorum is required and that decisions will be taken by a simple majority of the
votes cast. Proxies are available at the registered office of the SICAV. The Shareholders who wish to attend the Meeting
must inform the Board of Directors (ifs.fds@bdl.lu) at least five calendar days before the Meeting.
Référence de publication: 2015042116/755/19.
Kortstrukt S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 55.229.
Le quorum requis par l'article 67-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales n'ayant pas été
atteint lors de l'Assemblée Générale Statutaire tenue anticipativement le 23 février 2015, l'assemblée n'a pas pu statuer
sur l'ordre du jour.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
qui aura lieu le <i>3 avril 2015i> à 10.30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jour:i>
•
Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Les décisions sur l'ordre du jour seront prises quelle que soit la portion des actions présentes ou représentées et
pour autant qu'au moins les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés se soient prononcés en faveur
de telles décisions.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015034038/795/19.
Kavialux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 23.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 180.514.
<i>Extrait des décisions de l'associée unique prises en date du 5 février 2015i>
1. Mme Virginie GUILLAUME a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. M. David SANA, administrateur de sociétés, né à Forbach (France), le 10 avril 1974, demeurant professionnellement
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Kavialux S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015024384/16.
(150027636) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
35384
L
U X E M B O U R G
CoreCommodity Strategy Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1115 Luxembourg, 2, boulevard Konrad Adenauer.
R.C.S. Luxembourg B 171.519.
Gemäß Art. 22 ff. der Statuten ergeht hiermit die Einladung zur
ORDENTLICHEN JÄHRLICHEN GENERALVERSAMMLUNG
der Aktionäre am <i>26. März 2015i> um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrats und des Wirtschaftsprüfers über das zum 31. Dezember 2014 abgelaufene Geschäfts-
jahr.
2. Genehmigung der Bilanz zum 31. Dezember 2014 samt Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang sowie Be-
schlussfassung über die Ergebnisverwendung.
3. Beschlussfassung über die Verlängerung der Mandate sowie über die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Tätigkeit während des zum 31. Dezember 2014 abgelaufenen
Geschäftsjahres.
5. Beschlussfassung über die Verlängerung des Mandats des Wirtschaftsprüfers.
6. Verschiedenes.
Aktionäre können sich auch von einer Person vertreten lassen, die hierzu schriftlich bevollmächtigt ist. Die Vollmachten
müssen spätestens am Tag vor der Versammlung am Sitz der Gesellschaft hinterlegt werden. Dies sollte vorab per Fax
(+ 352221522- 500) oder E-Mail (d_FundSetUpOpam@oppenheim.lu), gefolgt durch die Übersendung der Originale er-
folgen. Hinsichtlich der Anwesenheit einer Mindestanzahl von Aktionären gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
Luxemburg, im März 2015
Der Verwaltungsrat..
Référence de publication: 2015038358/755/24.
Goldman Sachs Funds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Further to the last remaining unitholder having redeemed from the Fund on 15
th
September 2014, the Board of
Managers of Northern Trust Luxembourg Management Company S.A., having its registered address at 6, rue Lou Hemmer,
L-1748 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg (the “Management Company”) the Fund's Custodian and the Fund's
Investment Manager have decided by mutual agreement to liquidate the Fund.
The Board of Managers resolved to:
1. Appoint AIM Services S.à r.l. as liquidator in order to proceed with the liquidation of the Fund in accordance with
Luxembourg laws and regulations;
2. Put the Fund into liquidation with effect on 15
th
October 2014.
Luxembourg, 16
th
March 2015.
<i>Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.i>
Référence de publication: 2015042121/755/14.
Tyack S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 77.590.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue en date du 6 février 2015 que:
- La démission de M. Patrick MOINET, administrateur de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée administrateur de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'assemblée générale
qui statuera sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2014:
* Mme Katia CAMBON, née le 24 mai 1972 à Le Raincy, France, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015024667/16.
(150027809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
35385
L
U X E M B O U R G
Axxion Focus, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Axxion S.A.
Unterschrift
<i>Verwaltungsgesellschafti>
Référence de publication: 2015033497/10.
(150037781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Pioneer Institutional Funds, Fonds Commun de Placement.
The amended management regulations with respect to the fund PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS have been filed
with the Luxembourg Trade and Companies Register.
Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS a
été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 février 2015.
Pioneer Asset Management S.A.
Signature
Référence de publication: 2015034629/13.
(150038197) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2015.
S&S Fonder, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 149.434.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises par le liquidateur de la Société le 21 janvier 2015i>
Le liquidateur de la Société, SEB Fund Services S.A., avec siège social au 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, (le
«liquidateur») a pris la résolution de clôturer la liquidation de la Société avec effet immédiat.
Les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant cinq ans au siège social de SEB Fund Services
S.A., 4, rue Peternelchen, L-2370 Howald.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015023064/14.
(150026822) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Immobilière Bless S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 98.078.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 10 décembre 2014 que
l'assemblée a décidé d'accepter la démission de Monsieur Edouard Maire de son mandat de commissaire aux comptes
avec effet au 22 novembre 2013 et de nommer la société à responsabilité limitée Read S.à R.L., établie et ayant son siège
social à L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard Prince Henri, immatriculée au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B 45.083,
en tant que nouveau commissaire aux comptes en remplacement du commissaire aux comptes démissionnaire, avec effet
au 22 novembre 2013.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos
au 31 décembre 2014.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015022721/17.
(150026199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
35386
L
U X E M B O U R G
SEB FS Fund Solutions, Fonds Commun de Placement.
The Board of Directors of SEB Fund Services S.A., acting as the Management Company of SEB FS Fund Solutions, a
fonds commun de placement (FCP) under Part I of the Luxembourg law of 17 December 2010 on undertakings for
collective investment (the “Fund”), an umbrella with one active sub-fund, has decided in accordance with article 17 of the
management regulations of the Fund, to put the Fund into liquidation with effect on 21 October 2014.
The Management Company has decided to appoint Deloitte Tax & Consulting S.à.r.l. with its registered office at 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Fund represented by Mr. Michael
JJ Martin and Mr. Eric Collard (the “Liquidator”).
The Liquidator has been approved by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on 20 November
2014.
The Fund has been put into liquidation due to the fact that the investment manager of the Fund which is also the
placement and distribution agent is no longer under the supervision of the Swedish Financial Supervisory Authority
(Finansinspektionen) and has no longer any staff.
The NAV as of 21 October 2014 was the last NAV of the Fund.
The liquidation costs will be borne by the Fund with effect on 21 October 2014.
The issue and redemption of units has ceased on 20 October 2014.
Unclaimed liquidation proceeds will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg until the applicable
prescription period shall have elapsed.
Howald, 12 March 2015.
<i>The Board of Directors of SEB Fund Services S.A.i>
Référence de publication: 2015042120/755/23.
Watford S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 33.595.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration de la société qui s'est tenue en date du
19 janvier 2015 que:
l'étude d'avocats DURO & GOEBEL établit à L-1325 Luxembourg 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg)
a été nommée dépositaire des actions au porteur de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015023202/13.
(150026838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Triple A Trading S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 70.950.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015023174/9.
(150026501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Sodexo Senior Service S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8070 Bertrange, 39, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 26.039.
Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015023115/9.
(150026102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
35387
L
U X E M B O U R G
SODIMEG S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 298.930,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 154.853.
EXTRAIT
Au 1
er
février 2015, la société DGFD S.A. a transféré son siège social du 40, rue Glesener, L-1630 Luxembourg au
45, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015023116/13.
(150027023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Abengoa Concessions Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 183.030.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions de l'associé unique prises en date du 6 février 2015:
1. que la démission de M. Erik Johan SCHOOP en tant que gérant de classe B est acceptée avec effet au 9 janvier 2015;
2. que Mme. Federica SAMUELLI avec adresse professionnelle au 15 Rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est
nommée nouvelle gérante de classe B avec effet au 9 janvier 2015 et ce pour une durée indéterminée;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 11 février 2015.
Référence de publication: 2015023982/15.
(150027917) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Financial China S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 55.594.
EXTRAIT
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 11 février 2015 que la société FIDUCENTER
S.A., ayant son siège social au 18, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg, a été nommée comme dépositaire des actions au
porteur.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015024237/13.
(150028034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
Germany White Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon Ier.
R.C.S. Luxembourg B 125.007.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 6 février 2015i>
En accord avec la loi du 28 juillet 2014, le conseil d'administration a décidé de nommer comme dépositaire des actions
au porteur de la société
UHY Fibetrust S.àr.l., 38, boulevard Napoléon I
er
, L-2210 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Germany White Invest S.A.i>
Référence de publication: 2015024272/13.
(150027753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 février 2015.
35388
L
U X E M B O U R G
Brindleyplace Partner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 195.159.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the tenth day of February.
Before the undersigned Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BAEK SICAV FIS, an investment company with variable capital - specialised investment fund in the form of a public
limited company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 2, place Francois-Joseph Dargent, L-1413 Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies
register under number B127.242, acting in its own name but for the account of its subfunds BAEK SICAV FIS IF II and
BAEK SICAV FIS IF III,
duly represented by Mrs Corinna Schibgilla, lawyer professionally residing in Luxembourg, b virtue of a proxy given in
Luxembourg, on 10 Februar 2015.
Said proxy, initialled ne varietur by the proxyholders of the appearing parties and the notary, shall remain annexed to
this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing party has requested the notary to document the deed of incorporation of a société à responsabilité
limitée, which it wishes to incorporate and the articles of association of which shall be as follows:
A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. Name. There hereby exists among the current owner(s) of the shares and/or anyone who may be a shareholder
in the future, a company in the form of a société à responsabilité limitée under the name of “Brindleyplace Partner S.à
r.l.” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. Duration. The Company is incorporated for an unlimited duration. It may be dissolved at any time and without
cause by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these
articles of association.
Art. 3. Purpose.
3.1 The Company's purpose is:
- buying or holding shares or units in one or more companies;
- granting financing to companies provided they are, directly or indirectly, controlled by the Company; and/or
- buying real estate and developing, administering, operating, renting and selling real estate held by it as well as carrying
out all operations relating to real estate properties.
3.2 The Company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfill its object as well as
all operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including but not limited to
borrowing money in any form or obtaining any form of credit facility, entering into any guarantee, pledge or any other
form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any direct or indirect
subsidiary of the Company, the majority of the capital of such companies being held directly or indirectly by the Company,
in each case in relation to the financing of real estate acquisitions, as well as entering into transactions to hedge interest
and/ or currency exchange risks.
Art. 4. Registered office.
4.1 The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the Company’s registered office may be transferred by a resolution of the board of
managers.
4.3 It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of
the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.4 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at ten thousand pounds sterling (GBP 10,000), represented by ten thousand
(10,000) shares, having a par value of one pound sterling (GBP 1) each. The shares are collectively referred to as the
“Shares” and individually a “Share”.
35389
L
U X E M B O U R G
5.2 Under the terms and conditions provided by law, the Company’s share capital may be increased or reduced by a
resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles
of association.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into Shares, each of them having the same par value.
6.2 The Company may have one or several shareholders, whereby the number of shareholders is limited to forty (40),
unless otherwise provided for by law.
6.3 The death, legal incapacity, dissolution, bankruptcy or any other similar event regarding the sole shareholder or
any other shareholder, as the case may be, shall not cause the Company’s dissolution.
6.4 The Company may, to the extent permitted by law, redeem its own shares at any time.
6.5 The Company’s Shares are in registered form.
Art. 7. Register of shareholders.
7.1 A register of shareholders will be kept at the Company’s registered office, where it will be available for inspection
by any shareholder. This register of shareholders will in particular contain the name of each shareholder, his/her/its
residence or registered or principal office, the number of Shares held by such shareholder, any transfers of Shares, the
date of notification to or acceptance by the Company of such Share transfers pursuant to these articles of association as
well as any security rights granted on shares.
7.2 Each shareholder will notify the Company by registered letter of his/her/its address and any change thereof. The
Company may rely on the last address of a shareholder received by it.
Art. 8. Ownership and transfer of Shares.
8.1 Proof of ownership of Shares may be established through the recording of a shareholder in the register of share-
holders. Certificates of the recordings in the register of shareholders will be issued and signed by the chairman of the
board of managers, by any two of its members or by the sole manager, as the case may be, upon request and at the
expense of the relevant shareholder.
8.2 The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they must
designate a single person to be considered the sole owner of that Share in relation to the Company. The Company is
entitled to suspend the exercise of all rights attached to a share held by several owners until one owner has been
designated.
8.3 The Company’s Shares are freely transferable among existing shareholders. Inter vivos, they may only be transferred
to new shareholders subject to the approval of such transfer given by the shareholders, including the transferor, repre-
senting in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least. Unless otherwise provided for by law or
in the present Articles of Association, the Shares may not be transmitted by reason of death to non-shareholders, except
with the approval of shareholders representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the voting rights of the
surviving shareholders at least. Further, Shares held directly or indirectly (i) in the committed assets (gebundenes Ver-
mögen) of a German Insurance Company or (ii) by a German capital management company (Kapitalverwaltungsgesell-
schaft) for the account of a German open-ended fund subject to the provisions of the German Capital Investment Act
(Kapitalanlagegesetzbuch), regardless of the transfer restrictions applicable to other shareholders, may be transferred at
any time without the consent of the other shareholders to a transferee having duly executed a subscription agreement
substantially similar to the original subscription agreement of the transferor, insofar as the transferee is (i) an insurance
company, a social insurance agency, a pension fund, an investment company, a foundation or a bank or (ii) another
institutional investor which either has an adequate credit (investment grade) rating or adequate appropriate collateral,
unless the transfer would result in persons not qualifying as eligible Investors holding Shares. On the transfer of Shares
by a German Insurance Company or German capital management company, the transferee shall accept and become solely
liable for all liabilities and obligations relating to such Shares and the transferring German Insurance Company or German
capital management company shall be released from (and shall have no further liability of any nature, not even a secondary
or joint and several liability, for) such liabilities and obligations.
8.4 Any transfer of Shares will need to be documented through a transfer agreement in writing under private seal or
in notarized form, as the case may be, and such transfer will become effective towards the Company and third parties
upon notification of the transfer to or upon the acceptance of the transfer by the Company, pursuant to which any
member of the board of managers may record the transfer in the register of shareholders.
8.5 The Company, through any of its managers, may also accept and enter into the register of shareholders any transfer
referred to in any correspondence or in any other document which establishes the transferor’s and the transferee’s
consent.
C. General meeting of shareholders
Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders.
9.1 The Shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders, which constitutes one of
the Company’s corporate bodies.
35390
L
U X E M B O U R G
9.2 If the Company has only one shareholder, such shareholder shall exercise the powers of the general meeting of
shareholders. In such case and to the extent applicable and where the term “sole shareholder” is not expressly mentioned
in these articles of association, a reference to the “general meeting of shareholders” or the “shareholders” used in these
articles of association shall be read as a reference to the “sole shareholder”.
9.3 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
9.4 If the number of shareholders does not exceed twenty-five (25), instead of holding general meetings of shareholders,
the shareholders may also vote by resolution in writing, subject to the terms and conditions of the law. To the extent
applicable, the provisions of these articles of association regarding general meetings of shareholders shall apply with
respect to such vote by resolution in writing.
Art. 10. Convening general meetings of shareholders.
10.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of managers,
by the statutory auditor or by the board of statutory auditors, if any, or by shareholders representing in the aggregate
more than fifty per cent (50%) of the Company’s share capital, as the case may be, to be held at such place and on such
date as specified in the notice of such meeting.
10.2 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, an annual general meeting must be held in the
municipality where the Company’s registered office is located or at such other place as may be specified in the notice of
such meeting. The annual general meeting of shareholders must be convened within a period of six (6) months from
closing the Company’s accounts.
10.3 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place,
date and time of the meeting, and such notice is to be sent to each shareholder by registered letter at least eight (8) days
prior to the date scheduled for the meeting.
10.4 If all the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and if they state that they
have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.
Art. 11. Conduct of general meetings of shareholders - vote by resolution(s) in writing.
11.1 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer, each of whom shall be appointed by the general meeting of shareholders and who need neither
be shareholders, nor members of the board of managers. The board of the meeting shall especially ensure that the meeting
is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority
requirements, vote tallying and representation of shareholders.
11.2 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.
11.3 Quorum and vote
11.3.1 Each Share entitles to one (1) vote.
11.3.2 Unless otherwise provided for by law or by these articles of association, resolutions of the shareholders are
validly adopted when approved by shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the Company’s share
capital on first call. If such majority has not been reached on first call, the shareholders shall be convened or consulted
for a second time. On second call, the resolutions will be validly adopted with a majority of votes validly cast, regardless
of the portion of capital represented.
11.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not,
as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means
of communication, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even
all shareholders.
11.5 Any shareholder who participates in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or
by any other means of communication which allow such shareholder’s identification and which allow that all the persons
taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed
to be present for the computation of quorum and majority.
11.6 Each shareholder may vote at a general meeting of shareholders through a signed voting form sent by mail,
facsimile, electronic mail or by any other means of communication to the Company’s registered office or to the address
specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain
at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of
the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favour of or against the proposed
resolution or to abstain from voting thereon by marking with a cross the appropriate box. The Company will only take
into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.
11.7 The board of managers may determine all other conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to
take part in any general meeting of shareholders.
Art. 12. Amendment of the articles of association. Subject to the terms and conditions provided by law, these articles
of association may be amended by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted by a (i) majority of
shareholders (ii) representing in the aggregate seventy-five per cent (75%) of the share capital at least.
35391
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Minutes of general meetings of shareholders.
13.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw minutes of the meeting which shall be signed by the
members of the board of the meeting as well as by any shareholder who requests to do so.
13.2 The sole shareholder, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
13.3 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified conforming to the original by the notary having had custody of the original deed, in case the
meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two
of its members or by the sole manager, as the case may be.
D. Management
Art. 14. Powers of the board of managers.
14.1 The Company shall be managed by one or several managers, who need not be shareholders of the Company. In
case of plurality of managers, the managers shall form a board of managers being the corporate body in charge of the
Company’s management and representation. The Company may have several classes of managers. To the extent applicable
and where the term “sole manager” is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board
of managers” used in these articles of association shall be read as a reference to the “sole manager”.
14.2 The board of managers is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the
corporate object, with the exception of the actions reserved by law or by these articles of association to the shareholder
(s).
14.3 The Company’s daily management and the Company’s representation in connection with such daily management
may be delegated to one or several managers or to any other person, shareholder or not, acting alone or jointly as agent
of the Company. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of managers.
14.4 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument to any persons acting alone
or jointly as agents of the Company.
Art. 15. Composition of the board of managers. The board of managers must choose from among its members a
chairman of the board of managers. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a member
of the board of managers.
Art. 16. Election and removal of managers and term of office.
16.1 Managers shall be elected by the general meeting of shareholders, which shall determine their remuneration and
term of office.
16.2 Any manager may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of share-
holders. A manager to be revoked, who is also shareholder of the Company, shall not be excluded from voting on his/
her/its own revocation.
16.3 Any manager may be re-elected for successive terms.
Art. 17. Convening meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers shall meet upon call by its chairman or by any two (2) of its members at the place indicated
in the notice of the meeting as described in the next paragraph.
17.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four (24) hours
at least in advance of the date scheduled for the meeting by mail, facsimile, electronic mail or any other means of com-
munication, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be indicated
in the notice. Such convening notice is not necessary in case of assent of each manager in writing by mail, facsimile,
electronic mail or by any other means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof.
Also, a convening notice is not required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior
resolution adopted by the board of managers. No convening notice shall furthermore be required in case all members
of the board of managers are present or represented at a meeting of the board of managers or in the case of resolutions
in writing pursuant to these articles of association.
Art. 18. Conduct of meetings of the board of managers.
18.1 The chairman of the board of managers shall preside at all meetings of the board of managers. In his/her/its absence,
the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore.
18.2 Quorum
The board of managers can deliberate or act validly only if at least half of its members are present or represented at
a meeting of the board of managers.
18.3 Vote
Resolutions are adopted with the approval of a majority of votes of the members present or represented at a meeting
of the board of managers. The chairman shall not have a casting vote.
35392
L
U X E M B O U R G
18.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing any other manager as his/her/its
proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment
being sufficient proof thereof. Any manager may represent one or several of his/her/its colleagues.
18.5 Any manager who participates in a meeting of the board of managers by conference-call, video-conference or by
any other means of communication which allow such manager’s identification and which allow that all the persons taking
part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to
be present for the computation of quorum and majority. A meeting of the board of managers held through such means
of communication is deemed to be held at the Company’s registered office.
18.6 The board of managers may unanimously pass resolutions in writing which shall have the same effect as resolutions
passed at a meeting of the board of managers duly convened and held. Such resolutions in writing are passed when dated
and signed by all managers on a single document or on multiple counterparts, a copy of a signature sent by mail, facsimile,
e-mail or any other means of communication being sufficient proof thereof. The single document showing all the signatures
or the entirety of signed counterparts, as the case may be, will form the instrument giving evidence of the passing of the
resolutions, and the date of such resolutions shall be the date of the last signature.
18.7 Any manager who has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction submitted to the approval of
the board of managers which conflicts with the Company’s interest, must inform the board of managers of such conflict
of interest and must have his/her/its declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager
may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Where the Company has a sole
manager and the sole manager has, directly or indirectly, a proprietary interest in a transaction entered into between the
sole manager and the Company, which conflicts with the Company’s interest, such conflicting interest must be disclosed
in the minutes recording the relevant transaction.
Art. 19. Minutes of meetings of the board of managers.
19.1 The secretary, or if no secretary has been appointed, the chairman, shall draw minutes of any meeting of the
board of managers, which shall be signed by the chairman and by the secretary, as the case may be.
19.2 The sole manager, as the case may be, shall also draw and sign minutes of his/her/its resolutions.
19.3 Any copy and excerpt of any such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to
any third party shall be signed by the chairman of the board of managers, by any two of its members or by the sole
manager, as the case may be.
Art. 20. Dealings with third parties. The Company will be bound towards third parties in all circumstances by the joint
signature of two members of the board of managers. The Company will be bound towards third parties by the signature
of any agent(s) to whom the power in relation to the Company’s daily management has been delegated acting alone or
jointly in accordance with and subject to the limits of such delegation.
E. Supervision
Art. 21. Statutory auditor(s) - independent auditor(s).
21.1 In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, its operations shall be supervised by one or
several statutory auditors, who may be shareholders or not.
21.2 The general meeting of shareholders shall determine the number of statutory auditors, shall appoint them and
shall fix their remuneration and term of office. A former or current statutory auditor may be reappointed by the general
meeting of shareholders.
21.3 Any statutory auditor may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of
shareholders.
21.4 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
21.5 The statutory auditors may be assisted by an expert in order to verify the Company’s books and accounts. Such
expert must be approved by the Company.
21.6 In case of plurality of statutory auditors, they will form a board of statutory auditors, which must choose from
among its members a chairman. It may also choose a secretary, who needs neither be a shareholder, nor a statutory
auditor. Regarding the convening and conduct of meetings of the board of statutory auditors the rules provided in these
articles of association relating to the convening and conduct of meetings of the board of managers shall apply.
21.7 If the Company exceeds two (2) of the three (3) criteria provided for in the first paragraph of article 35 of the
law of 19 December 2002 regarding the register of commerce and companies and the accounting and annual accounts of
undertakings for the period of time as provided in article 36 of the same law, the statutory auditors will be replaced by
one or several independent auditors, chosen among the members of the Institut des réviseurs d’entreprises, to be ap-
pointed by the general meeting of shareholders, which determines the duration of his/her/their office.
F. Financial year - Profits - Interim dividends
Art. 22. Financial year. The Company’s financial year shall begin on January first of each year and shall terminate on
December thirty-first of the same year.
35393
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Profits.
23.1 From the Company’s annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company’s legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company’s reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company’s share capital.
23.2 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing
shareholder agrees with such allocation.
23.3 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
23.4 Under the terms and conditions provided for by law, the general meeting of shareholders will determine how
the remainder of the Company’s annual net profits will be used in accordance with the law, these articles of association
and any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.
Art. 24. Interim dividends.
24.1 The board of managers or the general meeting of shareholders may proceed to the payment of interim dividends
in accordance with any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the
Company, under the reservation that (i) interim accounts have been drawn-up showing that sufficient funds are available
and (ii) the amount to be distributed does not exceed total profits made since the end of the last financial year for which
the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from reserves available for
this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the requirements of the law
or of these articles of association.
24.2 The share premium may be freely distributed to the shareholder(s) by a resolution of the shareholder(s) or of
the manager(s), subject to any legal provisions regarding the inalienability of the share capital and of the legal reserve and
in accordance with any shareholders’ agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the
Company.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. In the event of the Company’s dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several
liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company’s
dissolution which shall determine the liquidators’/liquidator’s powers and remuneration, in accordance with any share-
holders’ agreement that may be entered into from time to time by the shareholders of the Company.
H. Governing law
Art. 26. Governing law. These articles of association shall be construed and interpreted under and shall be governed
by Luxembourg law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of the Company’s incorporation and shall end on 31 December
2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Shares to be issued have been subscribed and paid-in in cash as follows:
- Eight thousand (8,000) Shares have been subscribed by BAEK SICAV FIS, acting for the account of its sub-fund BAEK
SICAV FIS IF II for the price of eight thousand pounds sterling (GBP 8,000),
- Two thousand (2,000) Shares have been subscribed by BAEK SICAV FIS, acting for the account of its sub-fund BAEK
SICAV FIS IF III for the price of two thousand pounds sterling (GBP 2,000)
All the Shares have been entirely paid-in in cash, so that the amount of ten thousand pounds sterling (GBP 10,000) is
as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated to be EUR 1,500.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
BAEK SICAV FIS, aforementioned, representing the entire subscribed capital and considering itself as duly convened,
has immediately passed the following resolutions:
1. The number of members of the board of managers is fixed at three (3).
2. The following persons are appointed managers of the Company with immediate effect and for an indefinite period
of time:
35394
L
U X E M B O U R G
a. Eric Christian Raphael Pierre Daniel Binon, born on 17 March 1977 in Liège, professional address 26-28, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg;
b. Daniel Michael Laurencin, born on 8 October 1969 in Bastogne, professional address 26-28, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg; and
c. Harald Flöer, born on 7 June 1971 in Lippstadt, professional address Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt.
3. The following entity is appointed as independent auditor of the Company with immediate effect and for an indefinite
period of time, but may be removed at any time, without notice and without cause by the general meeting of shareholders:
BDO Audit, Société Anonyme, “Le Dôme” Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, B.P. 351,L-2013 Luxembourg.
4. The address of the Company’s registered office is set at 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation. On the request of the same appearing party and in case
of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.
Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, the appearing party signed together with the notary, this
original deed.
Folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Texts
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zehnten Februar.
Vor dem unterzeichneten Notar Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz im Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
BAEK SICAV FIS, eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital - spezialisierter Investmentfonds in der Form einer
Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht, mit Sitz in 2, Place Dargent, L-1413 Luxembourg,
eingetragen im luxemburgischem Handelsregister unter der Nummer B 127.242, handelnd in eigenem Namen aber für
Rechnung ihrer Teilfonds BAEK SICAV FIS IF II und BAEK SICAV FIS IF III,
vertreten durch Frau Corinna Schibgilla, lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ihr ausge-
stellt in Luxemburg, am 10. Februar 2015.
Die genannte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird dieser Urkunde beigefügt, um gleichzeitig mit der vorliegenden Urkunde zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den Notar ersucht, die Gründungsurkunde einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) aufzunehmen, welche gegründet werden soll und deren Satzung wie folgt lautet:
A. Name - Dauer - Zweck - Sitz
Art. 1. Name. Nunmehr besteht zwischen dem(n) jetzigen Eigentümer(n) der Geschäftsanteile und/oder jedem zu-
künftigen Gesellschafter eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter dem Namen
„Brindleyplace Partner S.à r.l.“(die “Gesellschaft”).
Art. 2. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet. Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch
einen Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter aufgelöst werden, welcher in gleicher Weise gefasst wird, wie
für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.
Art. 3. Zweck.
3.1 Der Gesellschaftszweck ist:
- der Erwerb oder das Halten von Aktien oder Anteilen einer oder mehrerer Gesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen für Gesellschaften vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt von der Gesellschaft
kontrolliert werden; und/oder
- der Erwerb von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, Betrieb, Vermietung oder der Verkauf von Immobilien,
die im Besitz der Gesellschaft sind, sowie die Durchführung aller Maßnahmen im Zusammenhang mit diesen Immobilien.
3.2 Die Gesellschaft kann jegliche Maßnahmen und Transaktionen durchführen, die sie zur Erfüllung des Gesellschafts-
zweckes als notwendig erachtet sowie alle direkten oder indirekten Maßnehmen zur Erleichterung der Erfüllung des
Gesellschaftszecks, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Kreditaufnahme in jeglicher Form oder jegliche Form
von Dispositionskrediten, Bürgschaften, Verpfändungen oder jegliche andere Form der Sicherheit hinsichtlich der Erfüllung
von Verträgen oder Verpflichtungen der Gesellschaft und der direkten oder indirekten Konzerngesellschaften, der Mehr-
heit des Kapitals dieser Gesellschaften, welches direkt oder indirekt von der Gesellschaft gehalten wird im Zusammenhang
mit der Finanzierung des Immobilienerwerbs als auch der Abschluss von Transaktionen zur Absicherung von Zins- und
Währungsrisiken.
35395
L
U X E M B O U R G
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist die Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss der Geschäftsführer verlegt wer-
den.
4.3 Er kann durch Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter in jede andere Gemeinde des Großherzogtums
Luxemburg verlegt werden, welcher in der Weise gefasst wird, wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.
4.4 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland durch
Beschluss der Geschäftsführer errichtet werden.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zehntausend Pfund Sterling (GBP 10,000) bestehend aus zehn-
tausend (10,000) Geschäftsanteilen mit einem Nominalwert von einem Pfund Sterling (GBP 1) pro Gesellschaftsanteil.
Die Geschäftsanteile werden insgesamt mit „Geschäftsanteilen“und einzeln als „Gesellschaftsanteil“bezeichnet.
5.2 Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann, gemäß der gesetzlichen Regelungen, durch einen Be-
schluss der Hauptversammlung der Gesellschafter erhöht oder herabgesetzt werden, welcher in der Weise gefasst wird,
wie für eine Änderung dieser Satzung erforderlich.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Geschäftsanteile mit jeweils demselben Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) Gesellschafter
nicht überschreiten darf, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt
6.3 Die Gesellschaft wird weder durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Auflösung, Konkurs, Insolvenz oder ein anderes
ähnliches einen oder mehrere Gesellschafter betreffendes Ereignis aufgelöst.
6.4 Die Gesellschaft kann, soweit gesetzlich zulässig, ihre eigenen Geschäftsanteile zu jeder Zeit zurückkaufen.
6.5 Die Anteile der Gesellschaft sind in Namensanteile.
Art. 7. Anteilsregister der Gesellschafter.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister der Gesellschafter aufbewahrt, wo es durch jeden Gesellschafter
eingesehen werden kann. Dieses Anteilsregister der Gesellschafter enthält insbesondere den Namen jedes Gesellschaf-
ters, den Wohnsitz oder Sitz oder Hauptsitz der Gesellschaft, die Anzahl der Geschäftsanteile welche durch den jeweiligen
Gesellschafter gehalten werden, alle Übertragungen von Geschäftsanteilen, den Zeitpunkt der Bekanntgabe oder Annah-
me dieser Übertragungen von Geschäftsanteilen durch die Gesellschaft gemäß dieser Satzung sowie jegliche Sicherheiten
welche auf Geschäftsanteile gewährt wurden.
7.2 Jeder Gesellschafter wird der Gesellschaft per Einschreiben seine / ihre Adresse und jede Änderung derselben
mitteilen. Die Gesellschaft kann sich auf die letzte angegebene Adresse des Gesellschafters verlassen.
Art. 8. Eigentum und Übertragung von Anteilen.
8.1 Der Nachweis des Eigentums an Anteilen kann durch die Aufnahme eines Gesellschafters in das Anteilsregister
der Gesellschafter geschaffen werden. Auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Gesellschafters können Zertifikate
über die genannte Eintragung in dem Anteilsregister der Gesellschafter herausgeben und von dem leitenden Geschäfts-
führer, von zwei Geschäftsführern oder dem Einzelgeschäftsführer, den Umständen entsprechend, unterschrieben
werden.
8.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sobald ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft als alleinigen Inhaber vertritt.
Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem von mehreren Personen gehalt-
enen Anteil auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
8.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar. Die Anteile dürfen inter vivos neuen Gesellschaftern
nur mit Zustimmung der Gesellschafter, einschließlich des Übertragenden, die mit einer Mehrheit von mindestens fünf-
undsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals zu beschließen hat, übertragen werden. Es sei denn es wird gesetzlich
oder in der vorliegenden Satzung anderweitig bestimmt, dürfen die Anteile nicht von Todes wegen an Nicht-Gesellschafter
übertragen werden, außer mit der Genehmigung der Gesellschafter, welche eine Mehrheit von mindestens fünfundsiebzig
Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals (der Stimmrechte) der überlebenden Gesellschafter repräsentieren. Weiterhin
können Anteile, welche direkt oder indirekt (i) in gebundenen Vermögen einer deutschen Versicherungsgesellschaft oder
(ii) von einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft für einen deutschen offenen Fonds gemäß dem deutschen Kapi-
talanlagegesetzbuch gehalten werden, unabhängig von den Übertragungsbeschränkungen anderer Anteilinhaber, jederzeit
und ohne die Zustimmung der anderen Anteilinhaber an denjenigen Erwerber übertragen werden, der eine Zeichnungs-
erklärung ordnungsmäßig unterzeichnet hat, welche grundsätzlich ähnlich der ursprünglichen Zeichnungserklärung des
Übertragenden ist. Dies gilt insofern, der Erwerber (i) ein Versicherungsunternehmen, ein Sozialversicherungsträger, ein
Pensionsfonds, eine Investmentgesellschaft, eine Stiftung oder eine Bank oder (ii) ein anderer institutioneller Investor,
welcher entweder über einen entsprechenden Kredit (Investment Grade) oder über entsprechende Sicherheiten verfügt,
35396
L
U X E M B O U R G
es sei denn, der Erwerber qualifiziert sich nicht als geeigneter Investor. Bei der Übertragung von Anteilen von einer
deutschen Versicherungsgesellschaft oder einer deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaft haftet der Erwerber allein für
sämtlicher Verbindlichkeiten und Verpflichtungen in Bezug auf diese Anteile. Die übertragende deutsche Versicherungs-
gesellschaft oder deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft wird von jeglicher Haftung in diesem Zusammenhang freigestellt.
Dies gilt ebenfalls für jegliche sekundäre oder gesamtschuldnerische Haftung der übertragenden deutschen Versiche-
rungsgesellschaft oder deutsche Kapitalverwaltungsgesellschaft.
8.4 Jede Übertragung von Anteilen muss durch einen Übertragungsvertrag dokumentiert werden durch schriftliche
Beurkundung oder bedarf notarieller Form, je nach Sachlage, und eine solche Übertragung wird gegenüber der Gesellschaft
und Dritten wirksam durch Mitteilung der Übertragung an oder mit der Genehmigung der Übertragung durch die Ge-
sellschaft, gemäß der jedes Mitglied der Geschäftsführung die Übertragung in das Anteilsregister der Gesellschafter
aufzeichnen kann.
8.5 Die Gesellschaft kann, durch jeden ihrer Geschäftsführer, auch jede Übertragung, welche aus Schriftverkehr oder
einem anderen Dokument die Zustimmung des Veräußerers und des Erwerbers ersichtlich werden lässt, akzeptieren und
in das Anteilsregister der Gesellschafter eintragen.
C. Hauptversammlung der Gesellschafter
Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Gesellschafter.
9.1 Die Gesellschafter üben ihre gemeinschaftlichen Rechte in der Hauptversammlung der Gesellschafter aus, welche
ein Organ der Gesellschaft darstellt.
9.2 Wenn die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Gesell-
schafter aus. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo der Begriff “alleiniger Gesellschafter” nicht ausdrücklich in
dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser Satzung genannter Verweis auf die “Hauptversammlung der Gesellschafter”
als Verweis auf den „alleinigen Gesellschafter“gelesen werden.
9.3 Die Hauptversammlung der Gesellschafter hat die ihr durch Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verlie-
henen Befugnisse.
9.4 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, anstatt eine Hauptver-
sammlung der Gesellschafter abzuhalten, können die Gesellschafter auch per schriftlichen Beschluss abstimmen, vorbe-
haltlich der Bestimmungen des Gesetzes. Soweit anwendbar, gelten die Bestimmungen dieser Satzung über
Hauptversammlungen der Gesellschafter hinsichtlich eines solchen Beschlusses in schriftlicher Form.
Art. 10. Ladung der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter kann jederzeit durch die Geschäftsführer oder den/die satzungsmäßi-
gen Buchprüfer oder die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, falls vorhanden, oder durch die Gesellschafter die
zusammen insgesamt mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals halten, soweit zutreffend, einberufen
werden. Die Ladung zu der Hauptversammlung der Gesellschafter muss den Ort und das Datum enthalten.
10.2 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss eine jährliche Hauptver-
sammlung in Luxembourg am eingetragenem Sitz der Gesellschaft, oder an jedem anderen in der Ladung bezeichneten
Ort stattfinden. Die jährliche Hauptversammlung der Gesellschafter muss innerhalb von sechs (6) Monaten, nach dem
die Konten der Gesellschaft geschlossen wurden, einberufen werden.
10.3 Die Ladung zu jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss die Tagesordnung der Versammlung, den Ort
und das Datum und die Uhrzeit der Versammlung enthalten und diese Ladung muss per Einschreiben mindestens acht (8)
Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum an jeden Gesellschafter versendet werden.
10.4 Wenn in einer Hauptversammlung der Gesellschafter alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind und er-
klären, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert worden sind, kann die Hauptversammlung der
Gesellschafter ohne vorherige Ladung abgehalten werden.
Art. 11. Durchführung von Hauptversammlungen der Gesellschafter - Abstimmung durch schriftlichen Beschluss.
11.1 In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter soll ein Rat der Versammlung gebildet werden bestehend aus
einem Vorsitzenden, einem Schriftführer und einem Stimmzähler, die durch die Hauptversammlung der Gesellschafter
ernannt werden und welche weder Gesellschafter noch Mitglieder der Geschäftsführung sein müssen. Der Rat der Ver-
sammlung soll insbesondere sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und speziell im Einklang
mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von Gesellschaftern
abgehalten wird.
11.2 In jeder Hauptversammlung der Gesellschafter muss eine Anwesenheitsliste geführt werden.
11.3 Quorum und Abstimmung
11.3.1 Jeder Anteil berechtigt zu einer (1) Stimme.
11.3.2 Sofern nicht anders durch das Gesetz oder diese Satzung bestimmt ist, werden die Beschlüsse der Gesellschafter
rechtmäßig erlassen, wenn sie von Gesellschaftern, welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Gesellschaftskapitals der
Gesellschaft halten nach erster Abstimmung genehmigt. Wenn diese Mehrheit nicht mit der ersten Abstimmung erreicht
wird, werden die Gesellschafter für eine zweite Abstimmung vertagt oder befragt. Bei der zweiten Abstimmung werden
35397
L
U X E M B O U R G
die Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig von dem vertretenen Anteil
am Gesellschaftskapital.
11.4 Ein Gesellschafter kann an jeder Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen, indem sie/er eine andere
Person, Gesellschafter oder NichtGesellschafter, als ihren/seinen Vertreter schriftlich durch ein unterzeichnetes Doku-
ment, das per Post, Telefax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt wird, bevollmächtigt.
Eine Person kann mehrere oder sogar alle Gesellschafter vertreten.
11.5 Gesellschafter, die an einer Hauptversammlung der Gesellschafter per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel teilnehmen, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gelten als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der
Mehrheit.
11.6 Jeder Gesellschafter kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Gesellschafter durch ein unterzeichnetes
Stimmformular, welches per Post, EMail, Faxschreiben, oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der
Gesellschaft oder an die in der Ladung genannte Adresse gesendet wird, abgeben. Die Gesellschafter können nur solche
Stimmformulare verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum
und die Uhrzeit der Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge an die Versammlung sowie für jeden Vor-
schlag drei Kästchen enthalten, die es dem Gesellschafter ermöglichen, seine Stimme zugunsten oder gegen den
vorgeschlagenen Beschluss abzugeben, indem das entsprechenden Kästchen ankreuzt wird. Die Gesellschaft wird nur
solche Stimmformulare berücksichtigen, die sie vor der Hauptversammlung der Gesellschafter, auf die sie sich beziehen,
erhalten hat.
11.7 Die Geschäftsführung kann alle weiteren Bedingungen festlegen, die von den Gesellschaftern erfüllt werden müs-
sen, um an einer Hauptversammlung der Gesellschafter teilnehmen zu können.
Art. 12. Änderung der Satzung. Vorbehaltlich gesetzlicher Regelungen und Bestimmungen, kann diese Satzung mit
einem Beschluss der Hauptversammlung der Gesellschafter geändert werden, soweit (i) eine Mehrheit der Gesellschafter
vorhanden ist (ii) welche mindestens fünfundsiebzig Prozent (75%) des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft vertreten.
Art. 13. Protokoll von Hauptversammlungen der Gesellschafter.
13.1 Die Hauptversammlung der Gesellschafter muss ein Protokoll der Versammlung anfertigen, welches von den
Mitgliedern des Rates der Versammlung, sowie von jedem Gesellschafter, der dies ersucht, unterzeichnet wird.
13.2 Der alleinige Gesellschafter, soweit zutreffend, wird auch ein Protokoll seiner Beschlüsse anfertigen und diese
unterzeichnen.
13.3 Kopien oder Abschriften solcher Originalprotokolle, welche in gerichtlichen Verfahren verwendet werden sollen
oder welche einem Dritten zugänglich gemacht werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Ur-
kunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der die Originalurkunde aufgenommen hat, beglaubigt werden, oder durch
den leitenden Geschäftsführer oder durch zwei beliebige Geschäftsführer oder den Einzelgeschäftsführer unterzeichnet
werden.
D. Geschäftsführung
Art. 14. Befugnisse des Geschäftsführerversammlung.
14.1 Die Gesellschaft soll durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten werden, welche nicht Gesellschafter
der Gesellschaft sein müssen. Sollten mehrere Geschäftsführer bestellt werden, bilden diese Geschäftsführer eine Ge-
schäftsführerversammlung, welche die juristische Einheit bildet, die für die Geschäftsführung und Vertretung der Gesell-
schaft zuständig ist. Die Gesellschaft kann mehrere Arten von Geschäftsführern haben. In einem solchen Fall, soweit
anwendbar und wo der Begriff “Einzelgeschäftsführer” nicht ausdrücklich in dieser Satzung erwähnt ist, soll ein in dieser
Satzung genannter Verweis auf die “Geschäftsführerversammlung” als Verweis auf den „Einzelgeschäftsführer” gelesen
werden.
14.2 Die Geschäftsführerversammlung verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu
handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit
Ausnahme der von Gesetzes wegen oder durch diese Satzung den Gesellschaftern vorbehaltenen Handlungen.
14.3 Die tägliche Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft im Zusammenhang mit dieser täglichen Geschäfts-
führung/Verwaltung kann auf einen oder mehrere Geschäftsführer oder an eine andere Person, Gesellschafter oder Nicht-
Gesellschafter, allein oder gemeinsam als Vertreter der Gesellschaft handelnd, delegiert werden. Ihre Ernennung,
Abberufung und Befugnisse werden durch Beschluss der Geschäftsführerversammlung festgelegt.
14.4 Die Gesellschaft kann auch besondere Rechte durch notarielle Bevollmächtigung oder privatschriftliche Urkunde
allen Personen, allein oder gemeinsam als Vertreter der Gesellschaft handelnd, gewähren.
Art. 15. Zusammensetzung der Geschäftsführerversammlung. Die Geschäftsführerversammlung wählt unter ihren
Mitgliedern einen leitenden Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung aus. Die Geschäftsführerversammlung kann
auch einen Schriftführer ernennen, der weder Gesellschafter noch Mitglied der Geschäftsführerversammlung sein muss.
35398
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Wahl und Abberufung von Geschäftsführern und Amtszeit.
16.1 Geschäftsführer werden durch die Hauptversammlung der Gesellschafter gewählt, welche ihre Bezüge und Amts-
zeit festlegt.
16.2 Jeder Geschäftsführer kann jederzeit, ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen durch die
Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden. Ein Geschäftsführer der abberufen werden soll, der gleichzeitig
Gesellschafter der Gesellschaft ist, darf nicht von der Abstimmung über die eigene Abberufung ausgeschlossen werden.
16.3 Jeder Geschäftsführer kann in aufeinander folgenden Zeiträumen wiedergewählt werden.
Art. 17. Einberufung der Geschäftsführerversammlung.
17.1 Die Geschäftsführerversammlung versammelt sich auf Einberufung durch ihren leitenden Geschäftsführer oder
durch zwei Geschäftsführer an dem in der Ladung zu der Versammlung angegebenen Ort, wie in dem folgenden Absatz
beschrieben wird.
17.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Datum zu jeder Sitzung des Geschäftsführerversammlung per Post, Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren
Kommunikationsmittels schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe der Dringlichkeit in der Ladung
zu bezeichnen sind. Eine solche Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer per Post, Faxschreiben, E-Mail oder
mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels, ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei eine Kopie des unter-
zeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist.
Eine solche Bekanntmachung/Einberufung/Ladung ist nicht notwendig, falls alle Geschäftsführer, ihre Zustimmung ab-
gegeben haben, wobei eine Kopie des unterzeichneten schriftlichen Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist.
Auch ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung zu einer Geschäftsführerversammlung dann nicht erforderlich, wenn
Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss der Geschäftsführerversammlung bestimmt worden sind. Des Weiteren
ist eine Bekanntmachung/Einberufung/Ladung nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer bei der Geschäftsführerver-
sammlung anwesend oder vertreten sind oder im Falle von schriftlichen Beschlüssen gemäß dieser Satzung.
Art. 18. Durchführung von Geschäftsführerversammlung.
18.1 Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung führt den Vorsitz aller Geschäftsführerversamm-
lungen. In dessen Abwesenheit kann die Geschäftsführerversammlung jedoch einen anderen Geschäftsführer als leitenden
Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung pro tempore ernennen.
18.2 Quorum
Die Geschäftsführerversammlung kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn mindestens die Hälfte ihrer
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
18.3 Abstimmung
Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an einer Geschäftsführerversammlung teilnehm-
enden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der leitende Geschäftsführer der Geschäftsführerversammlung hat im
Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme.
18.4 Ein Geschäftsführer kann an einer Geschäftsführerversammlung teilnehmen, indem er einen anderen Geschäfts-
führer durch ein unterzeichnetes Dokument, welches per Faxschreiben, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kom-
munikationsmittel übermittelt wird, schriftlich bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung hinreichender
Beweis dafür ist. Jeder Geschäftsführer kann einen oder mehrere seiner Kollegen vertreten.
18.5 Jeder Geschäftsführer, der an einer Geschäftsführerversammlung mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch ein anderes Kommunikationsmittel, welches das Identifizieren eines solchen Geschäftsführers ermöglicht, teilnimmt
und es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und effektiv an der Versammlung teilzunehmen, gilt
als anwesend für die Bestimmung des Quorums und der Mehrheit. Eine solche Geschäftsführerversammlung, die mittels
solcher Kommunikationsmittel durchgeführt wurde, wird als am Sitz der Gesellschaft abgehalten erachtet.
18.6 Der Geschäftsführerversammlung kann einstimmig schriftliche Beschlüsse fassen, die wirkungsgleich mit Be-
schlüssen sind, welche an ordnungsgemäß abgehaltenen Geschäftsführerversammlungen verabschiedet wurden. Solche
schriftlichen Beschlüsse werden verabschiedet, wenn sie von allen Geschäftsführern auf einem einzigen Dokument oder
auf mehreren Duplikaten datiert und unterzeichnet wurden, eine Kopie der Unterschrift per Post, Fax, E-Mail oder mittels
anderer Kommunikation ist hinreichender Beweis dafür. Das einzige Dokument, das alle Unterschriften oder die Ge-
samtheit aller Duplikate, den Umständen entsprechend, bildet den Beschluss, der als Nachweis der Verabschiedung des
Beschlusses gilt und das Datum der Beschlussfassung ist das Datum der letzten Unterschrift.
18.7 Jedes Geschäftsführer, der an einer Transaktion, die der Geschäftsführerversammlung zur Entscheidung vorliegt,
direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse hat, welches dem Interesse der Gesellschaft entgegen steht, die
Geschäftsführerversammlung über diesen Interessenkonflikt informieren, und seine Erklärung muss im Protokoll der
betreffenden Sitzung aufgenommen werden. Der betreffende Geschäftsführer kann weder an der Beratung über die in
Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Wenn die Gesellschaft einen Einzelgeschäftsführer hat
und dieser Einzelgeschäftsführer direkt oder indirekt ein vermögensrechtliches Interesse an einer Transaktion hat, die
zwischen dem alleinigen Gesellschafter und der Gesellschaft eingegangen wurde, welche dem Interesse der Gesellschaft
35399
L
U X E M B O U R G
entgegensteht, muss solch ein entgegenstehendes Interesse im Protokoll der betreffenden Transaktion aufgenommen
werden.
Art. 19. Protokoll der Geschäftsführerversammlung.
19.1 Der Schriftführer oder falls kein Schriftführer ernannt wurde, fertigt der leitende Geschäftsführer ein Protokoll
jeder Geschäftsführerversammlung an, welches vom Schriftführer oder dem leitenden Geschäftsführer unterzeichnet
werden soll.
19.2 Der Einzelgeschäftsführer soll ebenfalls Protokolle seiner Beschlüsse anfertigen und diese unterzeichnen.
19.3 Jede Kopie oder Ausfertigung eines jeden Originalprotokolls das im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens an-
gefertigt wird oder für die Weitergabe an Dritte bestimmt ist, soll vom leitenden Geschäftsführer, von zwei Geschäfts-
führern oder vom Einzelgeschäftsführer unterzeichnet werden, sofern zutreffend.
Art. 20. Beziehungen zu Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Fällen durch die gemeinsame Un-
terschrift zweier Geschäftsführer verpflichtet. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten verpflichtet mit der Unterschrift
eines jeden Bevollmächtigten/mehrerer Bevollmächtigter dem/denen die tägliche Geschäftsführung übertragen worden
ist, alleine oder gemeinschaftlich handelnd; dies im Einklang mit und im Rahmen der Beschränkungen einer solchen Über-
tragung.
E. Supervision
Art. 21. Satzungsmäßige Buchprüfer- unabhängige Wirtschaftsprüfer.
21.1. Im Falle dass die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, soll sie von einem oder mehreren
satzungsmäßigen Buchprüfern beaufsichtigt werden, die Gesellschafter sein dürfen, aber keine Gesellschafter sein müssen.
21.2 Die Hauptversammlung der Gesellschafter soll die Anzahl der satzungsmäßigen Buchprüfer festlegen, sie ernennen,
ihre Bezahlung und die Dauer ihres Mandates festlegen.
21.3 Jeder satzungsmäßige Buchprüfer kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen von
der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden.
21.4 Die satzungsmäßigen Buchprüfer haben unbeschränkte Rechte in Bezug auf die permanente Aufsicht und Kontrolle
aller Tätigkeiten der Gesellschaft.
21.5 Die satzungsmäßigen Buchprüfer dürfen sich bezüglich der Überprüfung der Konten und Bücher der Gesellschaft
eines Experten bedienen. Ein solcher Experte muss von der Gesellschaft anerkannt werden.
21.6 Im Falle mehrerer satzungsmäßiger Buchprüfer bilden diese die satzungsmäßige Buchprüferversammlung, die unter
ihren Mitgliedern einen Vorsitzenden bestimmen muss. Die satzungsmäßige Buchprüferversammlung kann auch einen
Schriftführer bestimmen, der weder ein Gesellschafter, noch ein satzungsmäßiger Buchprüfer sein muss. Betreffend die
Einberufung und Abhaltung der Sitzungen der satzungsmäßigen Buchprüferversammlung, werden die Regeln angewendet,
die gemäß dieser Satzung auch auf die Einberufung und Abhaltung der Geschäftsführerversammlung Anwendung finden.
21.7 Für den Fall dass die Gesellschaft zwei der drei im ersten Absatz des Artikels 35 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen für die Zeitspanne,
die in Artikel 36 desselben Gesetzes genannt ist, überschreitet, werden die satzungsmäßigen Buchprüfer durch einen oder
mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer ersetzt, ausgewählt aus den Mitgliedern des Institutes der unabhängigen Wirt-
schaftsprüfer („Institut des réviseurs d`entreprises“), die von der Hauptversammlung der Gesellschafter ernannt werden,
die die Dauer ihres Mandates festlegt.
F. Geschäftsjahr - Gewinne - Zwischendividenden
Art. 22. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 23. Gewinne.
23.1 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung soll dann nicht mehr verpflichtend sein, sobald und solange die Gesamtsumme
der Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Kapitals der Gesellschaft beträgt.
23.2 Die durch einen Gesellschafter an die Gesellschaft erbrachten Einlagen können mit Zustimmung dieses Gesell-
schafters ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
23.3 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann im Verhältnis dazu die gesetzliche Rücklage der Ge-
sellschaft herabgesetzt werden, so dass sie stets zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
23.4 Im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften wird die Hauptversammlung der Gesellschafter darüber bestimmen,
wie der verbleibende Rest des jährlichen Nettogewinnes der Gesellschaft verwendet werden soll; dies im Einklang mit
dem Gesetz, dieser Satzung und sämtlicher Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesell-
schaftern der Gesellschaft eingegangen werden können
35400
L
U X E M B O U R G
Art. 24. Zwischendividenden - Ausgabeagio.
24.1 Die Geschäftsführer oder die Hauptversammlung der Gesellschafter können im Einklang mit sämtlichen Gesell-
schaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können,
Zwischendividenden zahlen unter der Voraussetzung, dass (i) Zwischenabschlüsse erstellt wurden, welche belegen, dass
ausreichende Mittel für eine Zwischendividende zur Verfügung stehen und (ii) der ausgegebene Betrag die seit Ende des
vergangenen Geschäftsjahres, für das der Jahresabschluss genehmigt wurde, angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht
durch vorgetragene Gewinne und Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Beiträge,
welche nach den Regelungen dieser Satzung und des Gesetzes einer Rücklage zugeführt werden müssen, nicht übersteigt
24.2 Das Ausgabeagio kann frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden durch einen Gesellschafterbeschluss oder
Geschäftsführerbeschluss, gemäß den gesetzlichen Regelungen betreffend die Unveräußerlichkeit des Gesellschaftskapi-
tales und die gesetzlichen Rücklagen der Gesellschaft und im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die
von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft eingegangen werden können.
G. Liquidation
Art. 25. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquida-
toren, natürliche Personen oder juristische Personen ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Gesellschafter
ernannt werden, die die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Bezahlung der Liquidatoren be-
stimmt; dies im Einklang mit sämtlichen Gesellschaftervereinbarungen, die von Zeit zu Zeit zwischen den Gesellschaftern
der Gesellschaft eingegangen werden können.
H. Anwendbares recht
Art. 26. Anwendbares Recht. Diese Satzung soll ausgelegt und interpretiert, sowie von den Regelungen des luxem-
burgischen Rechtes bestimmt werden. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen
des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils aktuellen Fassung.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die auszugebenden Anteile wurden wie folgt gezeichnet und bar eingezahlt:
- Achttausend (8,000) Anteile wurden von vorbenannter BAEK SICAV FIS in eigenem Namen, aber für Rechnung des
Teilfonds BAEK SICAV FIS IF II für einen Preis in Höhe von achttausend Pfund Sterling (GBP 8,000) gezeichnet;
- Zweitausend (2,000) Anteile wurden von vorbenannter BAEK SICAV FIS in eigenem Namen, aber für Rechnung des
Teilfonds BAEK SICAV FIS IF III für einen Preis in Höhe von zweitausend Pfund Sterling (GBP 2,000) gezeichnet.
Alle Anteile wurden voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von zehntausend Pfund Sterling
(GBP 10,000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.500,-geschätzt.
<i>Hauptversammlung des Gesellschaftersi>
Die vorbenannte BAEK SICAV FIS, die das gesamte Gesellschaftskapital vertritt und die sich als ordnungsgemäß geladen
erachtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Die Anzahl der Geschäftsführer wird mit drei (3) festgelegt.
2. Die folgenden natürlichen Personen werden mit sofortiger Wirkung und für unbestimmte Zeit zu Geschäftsführern
der Gesellschaft ernannt:
a. Eric Christian Raphael Pierre Daniel Binon, geboren am 17. März 1977 in Lüttich, Geschäftsadresse 26-28, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxemburg;
b. Daniel Michael Laurencin, geboren am 8. Oktober 1969 in Bastogne, Geschäftsadresse 26-28, rue Edward Steichen,
L-2540 Luxemburg; und
c. Harald Flöer, geboren am 7. Juni 1971 in Lippstadt, Geschäftsadresse Friedrich-Ebert-Anlage 35-37, 60327 Frankfurt.
3. Die folgende juristische Person wird zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung
und für eine unbestimmte Zeit ernannt, die aber jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen
von der Hauptversammlung der Gesellschafter abberufen werden kann:
BDO Audit, Société Anonyme, “Le Dôme” Espace Pétrusse, 2, avenue Charles de Gaulle, B.P. 351, L-2013 Luxembourg.
4. Die Anschrift des Gesellschaftssitzes ist 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxemburg, Großherzogtum Luxem-
burg.
35401
L
U X E M B O U R G
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Ersuchen
der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Auf Ersuchen derselben
erschienenen Partei und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text soll die englische
Fassung vorrangig sein.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem Tag, der zu Beginn dieser Ur-
kunde genannt wurde.
Nachdem das Dokument der erschienenen Partei verlesen wurde, unterzeichnete die erschienene Partei diese Ori-
ginalurkunde zusammen mit dem Notar.
Gezeichnet: C. SCHIBGILLA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 17 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4953. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR)
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 5. März 2015.
Référence de publication: 2015038430/732.
(150043931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 mars 2015.
VPF International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 195.228.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of February.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing at Rambruch, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Vente-privee.com S.A., a company incorporated and existing under the laws of France, having its registered office at
249 avenue du President Wilson, F - 93210 La Pleine Saint Denis, France, duly represented by the president of its board
of directors, Mr. Jacques Antoine GRANJON, born at Marseille (France), on August 9
th
1962, residing at 127, avenue
Malakoff, F-75116 Paris, France,
here represented by Mr Cornelius Martin BECHTEL, residing professionally at 5, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg by virtue of a proxy, given in Paris.
The said proxy, initialed ne varietur by the appearing party and the notary, will remain annexed to the present deed
to be filed at the same time with the registration authorities.
This appearing attorney, acting as said before, requested the undersigned notary to draw up the Constitutive Deed of
a private limited company, ("société à responsabilité limitée"), as follows:
Art. 1. There is hereby established a private limited company ("société à responsabilité limitée") which will be governed
by the laws in force, namely the Companies' Act of August 10, 1915 and by the present articles of association.
Art. 2. The company's name is “VPF International S.à r.l.”.
Art. 3. The purpose of the company is the acquisition, the management, the enhancement and the disposal of partici-
pations in whichever form in domestic and foreign companies. The company may also contract loans and grant all kinds
of support, loans, advances and guarantees to companies, in which it has a direct or indirect participation or which are
members of the same group. It can perform any services or advice including to companies it controls or that control it.
It may open branches in Luxembourg and abroad.
Furthermore, the company may acquire and dispose of all other securities by way of subscription, purchase, exchange,
sale or otherwise.
Art. 4. The registered office of the company is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place of the Grand Duchy of Luxembourg by simple decision of the shareholders.
If extraordinary events of a political or economic nature which might jeopardize the normal activity at the registered
office or the easy communication of this registered office with foreign countries occur or are imminent, the registered
office may be transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision
will have no effect on the company's nationality. The declaration of the transfer of the registered office will be made and
brought to the attention of third parties by the organ of the company which is best situated for this purpose under the
given circumstances.
Art. 5. The company is established for an unlimited duration.
35402
L
U X E M B O U R G
Art. 6. The corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (12,500.- EUR) represented by twelve
thousand five hundred (12,500) sharequotas of one Euro (1.- EUR) each.
When and as long as all the sharequotas are held by one person, the articles 200-1 and 200-2 among others of the
amended law concerning trade companies are applicable, i.e. any decision of the single shareholder as well as any contract
between the latter and the company must be recorded in writing and the provisions regarding the general shareholders'
meeting are not applicable.
The company may acquire its own sharequotas provided that they be cancelled and the capital reduced proportionally.
Art. 7. The sharequotas are indivisible with respect to the company, which recognizes only one owner per sharequota.
If a sharequota is owned by several persons, the company is entitled to suspend the related rights until one person has
been designated as being with respect to the company the owner of the sharequota. The same applies in case of a conflict
between the usufructuary and the bare owner or a debtor whose debt is encumbered by a pledge and his creditor.
Nevertheless, the voting rights attached to the sharequotas encumbered by usufruct are exercised by the usufructuary
only.
Art. 8. The transfer of sharequotas inter vivos to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval
of the general shareholders' meeting representing at least three quarter of the corporate capital. The transfer of share-
quotas mortis causa to other shareholders or to third parties is conditional upon the approval of the general shareholders'
meeting representing at least three quarter of the corporate capital belonging to the survivors.
This approval is not required when the sharequotas are transferred to heirs entitled to a compulsory portion or to
the surviving spouse. If the transfer is not approved in either case, the remaining shareholders have a preemption right
proportional to their participation in the remaining corporate capital.
Each unexercised preemption right inures proportionally to the benefit of the other shareholders for a duration of
three months after the refusal of approval. If the preemption right is not exercised, the initial transfer offer is automatically
approved.
Art. 9. Apart from his capital contribution, each shareholder may with the previous approval of the other shareholders
make cash advances to the company through the current account. The advances will be recorded on a specific current
account between the shareholder who has made the cash advance and the company. They will bear interest at a rate
fixed by the general shareholders' meeting with a two third majority. These interests are recorded as general expenses.
The cash advances granted by a shareholder in the form determined by this article shall not be considered as an
additional contribution and the shareholder will be recognized as a creditor of the company with respect to the advance
and interests accrued thereon.
Art. 10. The death, the declaration of minority, the bankruptcy or the insolvency of a shareholder will not put an end
to the company. In case of the death of a shareholder, the company will survive between his legal heirs and the remaining
shareholders.
Art. 11. The creditors, assigns and heirs of the shareholders may neither, for whatever reason, affix seals on the assets
and the documents of the company nor interfere in any manner in the management of the company. They have to refer
to the company's inventories.
Art. 12. The company is managed and administered by one or several managers, whether shareholders or third parties.
The power of a manager is determined by the general shareholders' meeting when he is appointed. The mandate of
manager is entrusted to him until his dismissal ad nutum by the general shareholders' meeting deliberating with a majority
of votes.
The manager(s) has (have) the broadest power to deal with the company's transactions and to represent the company
in and out of court.
The manager(s) may appoint attorneys of the company, who are entitled to bind the company by their sole signatures,
but only within the limits to be determined by the power of attorney.
Art. 13. No manager enters into a personal obligation because of his function and with respect to commitments
regularly contracted in the name of the company; as an agent, he is liable only for the performance of his mandate.
Art. 14. The collective resolutions are validly taken only if they are adopted by shareholders representing more than
half of the corporate capital. Nevertheless, decisions amending the articles of association can be taken only by the majority
of the shareholders representing three quarter of the corporate capital. Interim dividends may be distributed under the
following conditions:
- interim accounts are drafted on a quarterly or semi-annual basis,
- these accounts must show a sufficient profit including profits carried forward,
- the decision to pay interim dividends is taken by an extraordinary general meeting of the shareholders.
Art. 15. The company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the
following year.
35403
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Each year, as of the thirty-first day of December, the management will draw up the annual accounts and will
submit them to the shareholders.
Art. 17. Each shareholder may inspect the annual accounts at the registered office of the company during the fifteen
days preceding their approval.
Art. 18. The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the general expenses, the social charges,
the amortizations and the provisions represents the net profit of the company. Each year five percent (5 %) of the net
profit will be deducted and appropriated to the legal reserve. These deductions and appropriations will cease to be
compulsory when the reserve amounts to ten percent (10 %) of the corporate capital, but they will be resumed until the
complete reconstitution of the reserve, if at a given moment and for whatever reason the latter has been touched. The
balance is at the shareholders' free disposal.
Art. 19. In the event of the dissolution of the company for whatever reason, the liquidation will be carried out by the
management or any other person appointed by the shareholders.
When the company's liquidation is closed, the company's assets will be distributed to the shareholders proportionally
to the sharequotas they are holding.
Losses, if any, are apportioned similarly, provided nevertheless that no shareholder shall be forced to make payments
exceeding his contribution.
Art. 20. With respect to all matters not provided for by these articles of association, the shareholders refer to the
legal provisions in force.
Art. 21. Any litigation which will occur during the liquidation of the company, either between the shareholders them-
selves or between the manager(s) and the company, will be settled, insofar as the company's business is concerned, by
arbitration in compliance with the civil procedure.
<i>Subscription and paymenti>
The articles of association having thus been established, the party appearing, declares to subscribe all the twelve
thousand five hundred (12,500) share quotas with a par value of one Euro (EUR 1.-) each.
All the twelve thousand five hundred (12,500) share quotas have been paid up in cash to the extent of one hundred
percent (100%) so that the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is now at the free disposal of
the company, evidence hereof having been given to the undersigned notary.
<i>Transitory dispositioni>
The first fiscal year will begin now and will end on December 31
st
, 2015.
<i>Expensesi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately 1.400,- Euro.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the company, the sole shareholder representing the entire corporate capital
takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The following persons are appointed as managers for an undetermined duration:
- Mr. Eddie Fernand Victor TURCON, born at Marseille (France), on May 3
rd
, 1960, residing at 11bis, rue Saint
Augustin, F-92600 Asnières sur Seine, France.
- Mr. Cornelius Martin BECHTEL, born at Emmerich (Germany), on March 11
th
, 1968, residing professionally at 5,
avenue Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.
The company is bound in all circumstances by the joint signature of the managers.
<i>Second resolutioni>
The registered office of the company is established at L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who knows English and French, states herewith that on request of the attorney, the present
incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same attorney and in case of
divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this
document.
35404
L
U X E M B O U R G
The document having been read to the attorney, known to the notary by his name, first name, civil status and residence,
the latter signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-trois février.
Pardevant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambruch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Vente-privee.com S.A., une société régie par les lois de la France, établie et ayant son siège social à 249 avenue du
President Wilson, F - 93210 La Pleine Saint Denis, France, dûment représentée par le président de son conseil d'admi-
nistration Monsieur Jacques Antoine GRANJON, né à Marseille (France), le 9 août 1962, demeurant à F-75116 Paris, 127,
avenue Malakoff,
ici représentée par Mr Cornelius Martin BECHTEL, demeurant professionnellement à 5, avenue Gaston Diderich, L -
1420 Luxembourg en vertu d'une procuration donnée à Paris.
Laquelle procuration, rédigée ne varietur par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent
acte et soumise en même temps aux formalités d'enregistrement.
Lequel mandataire, ès-qualité qu'il agit, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une
société à responsabilité limitée qu'il constitue par la présente:
Art. 1
er
. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et
notamment par celle modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
Art. 2. La société prend la dénomination de “VPF International S.à r.l.”.
Art. 3. La société a pour objet l'acquisition, la gestion, la mise en valeur et l'aliénation de participations, de quelque
manière que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères. La société pourra aussi contracter des
emprunts et accorder aux sociétés, dans lesquelles elle a une participation directe ou indirecte ou qui sont membres du
même groupe, toutes sortes d'aides, de prêts, d'avances et de garanties. Elle peut effectuer toutes prestations de services
ou de conseils notamment auprès des sociétés qu'elle contrôle ou qui la contrôlent.
Elle peut créer des succursales au Luxembourg et à l'étranger.
Par ailleurs, la société pourra acquérir et aliéner toutes autres valeurs mobilières par souscription, achat, échange,
vente ou autrement.
Art. 4. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité
normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.
Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.
Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cent Euros (12.500,- EUR), représenté par douze mille cinq cent
(12.500) parts sociales de un euro (1,- EUR) chacune.
Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et
200-2, entre autres, de la loi modifiée sur les sociétés commerciales sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de
l'associé unique ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant
les assemblées générales des associés ne sont pas applicables.
La société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.
Art. 7. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune
d'elles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,
jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.
Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.
Art. 8. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en
assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.
Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption
proportionnel à leur participation dans le capital social restant.
35405
L
U X E M B O U R G
Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il
doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.
Art. 9. A côté de son apport, chaque associé pourra, avec l'accord préalable des autres associés, faire des avances en
compte-courant de la société. Ces avances seront comptabilisées sur un compte-courant spécial entre l'associé, qui a fait
l'avance, et la société. Elles porteront intérêt à un taux fixé par l'assemblée générale des associés à une majorité des deux
tiers. Ces intérêts seront comptabilisés comme frais généraux.
Les avances accordées par un associé dans la forme déterminée par cet article ne sont pas à considérer comme un
apport supplémentaire et l'associé sera reconnu comme créancier de la société en ce qui concerne ce montant et les
intérêts.
Art. 10. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la société. En cas de
décès d'un associé, la société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.
Art. 11. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.
Art. 12. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant
seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.
Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la société et pour représenter la
société judiciairement et extrajudiciairement.
Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la société, qui peuvent engager la société par leurs
signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.
Art. 13. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.
Art. 14. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social. Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne
pourront être prises qu'à la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.
Des dividendes intérimaires peuvent être distribués dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont établis sur une base trimestrielle ou semestrielle,
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.
Art. 15. L'exercice social court du premier janvier de chaque année au trente-et-un décembre de l'année suivante.
Art. 16. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.
Art. 17. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication des comptes annuels pendant les quinze
jours qui précéderont son approbation.
Art. 18. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,
amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la société.
Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements
et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.
Art. 19. En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou
par toute personne désignée par les associés.
La liquidation de la société terminée, les avoirs de la société seront attribués aux associés en proportion des parts
sociales qu'ils détiennent.
Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des
paiements dépassant ses apports.
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en
vigueur.
Art. 21. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre
le ou les gérants et la société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.
35406
L
U X E M B O U R G
<i>Souscription et paiementi>
Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, la comparante, déclare souscrire toutes les douze mille cinq cent
(12.500) parts sociales d'une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune.
Toutes les douze mille cinq cent (12.500) parts sociales ont été intégralement libérées en espèces de sorte que la
somme de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commencera aujourd'hui et se terminera le 31 décembre 2015.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ 1.400,- Euros.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la société l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social, a pris
les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Sont nommés gérants pour une durée indéterminée:
- Monsieur Eddie Fernand Victor TURCON, né à Marseille (France), le 3 mai 1960, demeurant à 11bis, rue Saint
Augustin, F-92600 Asnières sur Seine, France.
- Monsieur Cornelius Martin BECHTEL, né à Emmerich (Allemagne) le 11 mars 1968, demeurant professionnellement
au 5, avenue Gaston Diderich, L - 1420 Luxembourg.
La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des gérants.
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la société est établi à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
Le notaire soussigné qui comprend l'anglais et le français, déclare par la présente, qu'à la demande du mandataire, le
présent document est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; en cas de divergence entre les deux textes, le
texte anglais l'emportera.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu au notaire par son nom, prénom, état civil et
domicile, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Bechtel, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 05 mars 2015. Relation: DAC/2015/3787. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Rambrouch, le 10 mars 2015.
Référence de publication: 2015040082/286.
(150045345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 mars 2015.
Expert Petroleum Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 11.823.791,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 147.929.
Expert Petroleum SPV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 24.728,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 186.995.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty second day of January.
Before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxembourg).
Was held
35407
L
U X E M B O U R G
an extraordinary general meeting of the shareholders of Expert Petroleum Holdings S.à r.l., a private limited liability
company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies
under number B 147.929 (hereinafter the Company). The Company has been incorporated pursuant to a deed of the
undersigned notary, dated August 20
th
2009 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the
Mémorial) on September 25
th
2009 number 1865 page 89513. The articles of incorporation of the Company have been
amended several times and for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 27
th
of March 2013,
published in the Mémorial on June 27
th
2013, number 1537, page 73757.
The meeting was presided by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in
Esch/Alzette.
The chairman appointed as secretary Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/
Alzette.
The meeting elected as scrutineer Mrs Claudia ROUCKERT, private employee, residing professionally in Esch/Alzette.
The chairman declared and requested the notary to state that:
I. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance
list, signed by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies
will be annexed to this document to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the attendance list that all the six million seven hundred sixty-nine thousand eight hundred sixty
(6,769,860) class A shares and five million fifty-three thousand nine hundred thirty-one (5,053,931) class B shares, having
a voting right and representing 100% of the share capital of the Company are represented at the present extraordinary
general meeting, so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholders have
been informed before the meeting and have waived any and all the convening formalities or others.
III. The agenda of the extraordinary general meeting is the following:
1. Decision to approve the merger, whereby the Company, as absorbed company, shall merge into Expert Petroleum
SPV S.à r.l., a société à responsabilité limitée, organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its
registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and
Companies under number B 186.995, having a share capital of EUR 24,728.- (the Absorbing Company), by way of ab-
sorption by the Absorbing Company of the Company and without liquidation of the Company (the Merger), as
contemplated by the joint merger proposal, as enacted by a notarial deed drawn up by the undersigned notary on No-
vember 26
th
2014, published in the Mémorial on December 6
th
2014, number 3751, page 180023 (the Merger Proposal),
and as deposited, together with the applicable documents, at the registered office of the Company and the Absorbing
Company.
2. Decision to acknowledge the waiver by all the shareholders of the Company and the Absorbing Company, to (i)
the requirement to have the Merger Proposal examined by one or several independent expert(s) and to have a report
established by such independent expert(s) on the Merger Proposal in accordance with Article 266 (1) of the law of August
10
th
1915 on commercial companies, as amended (the Law) and (ii) have a detailed written report established by the
boards of managers of Company and the Absorbing Company in accordance with Article 265 (1) of the Law and to receive
an information on any material change in the assets and liabilities in accordance with Article 265 (2) of the Law.
3. Discharge of the members of the board of managers of the Company for the proper performance of their activities
until the date of the general meeting and determination of the place where the books and records of the Company shall
be kept for the duration prescribed by law.
4. Effectiveness of the Merger as well as of the other items on the agenda.
IV. The undersigned notary confirms that the provisions of the Law relating to the mergers have been respected as
follows:
1. The Merger Proposal, jointly drawn up by the board of managers of the Absorbing Company and of the Company
on November 26
th
2014, has been filed with the Luxembourg Register of Trade and Companies and published in the
Mémorial on December 6
th
2014, number 3751 page 180023, i.e. at least one month before the date hereof and the date
of the resolutions taken by the sole shareholder of the Absorbing Company in connection with the Merger.
2. On November 26
th
2014 all the shareholders of the Company and the Absorbing Company have waived (i) in
accordance with Article 266 (5) of the Law, to the requirement to have the Merger Proposal examined by one or several
independent expert(s) and to have a report established by such independent expert(s) on the Merger Proposal in accor-
dance with Article 266 (1) of the Law, and (ii) in accordance with Article 265 (3) of the Law, to have a detailed written
report established by the boards of managers of Company and the Absorbing Company in accordance with Article 265
(1) of the Law and to receive an information on any material change in the assets and liabilities in accordance with Article
265 (2) of the Law.
3. The Merger Proposal, together with the respective documents required pursuant to Article 267 of the Law have
been deposited at the registered office of each of the Absorbing Company and the Company, for inspection by the
shareholders, at least one month prior to the date hereof and the date of the resolutions taken by the sole shareholder
35408
L
U X E M B O U R G
of the Absorbing Company in connection with the Merger. An attestation from the Company and the Absorbing Company
certifying as to the availability of these documents, after having been signed ne varietur by the chairman, the secretary,
the scrutineer and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed with the registration
authorities.
V. Thereupon, the following resolutions are taken:
<i>First resolutioni>
The general meeting, after having reviewed the Merger Proposal, decides to approve the Merger, as contemplated by
the Merger Proposal, and the Merger Proposal, as deposited together with the applicable documents at the registered
office of the Company and the Absorbing Company.
The general meeting further decides, subject to the approval of the Merger as contemplated by the Merger Proposal,
by the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company, to transfer all the assets and liabilities
of the Company to the Absorbing Company.
The general meeting further decides, subject to the approval of the Merger, as contemplated by the Merger Proposal,
by the extraordinary general meeting of shareholders of the Absorbing Company, that the Company shall be dissolved
without liquidation, and all the assets and liabilities of the Company being transferred to the Absorbing Company on the
date, on which the Merger will be effective.
<i>Second resolutioni>
The general meeting acknowledges the waiver by all the shareholders of the Company and the Absorbing Company
to (i) the requirement to have the Merger Proposal examined by one or several independent expert(s) and to have a
report established by such independent expert(s) on the Merger Proposal in accordance with Article 266 (1) of the Law,
and (ii) have a detailed written report established by the boards of managers of Company and the Absorbing Company
in accordance with Article 265 (1) of the Law and to receive an information on any material change in the assets and
liabilities in accordance with Article 265 (2) of the Law.
<i>Third resolutioni>
The general meeting resolves to discharge the members of the board of managers of the Company for the proper
performance of their activities until the date of the general meeting, and decides that the books and records of the
Company shall be kept for the duration prescribed by law at the registered office of the Absorbing Company.
<i>Fourth resolutioni>
The general meeting decides that the Merger and all other matters referred to in the foregoing resolutions shall be
effective between the Company and the Absorbing Company on January 22
nd
2015 and vis-à-vis third parties upon the
publication of this notarial deed in the Mémorial.
<i>Declarationi>
In accordance with Article 271 (2) of the Law, the undersigned notary declares having verified and certifies the existence
and validity, under Luxembourg law, of the legal acts and formalities imposed on the Company in order to render the
Merger effective.
Nothing being in the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that on request of the above-named
persons, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing persons,
in case of divergences between the English text and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof, this notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date named at the beginning of this deed.
This deed having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their name, surname,
occupation and residence, said persons signed together with the notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
En l'an deux mille quinze, le vingt-deux janvier,
Par-devant Maître Francis KESSELER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg),
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire de Expert Petroleum Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée,
constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453,
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg
sous le numéro B. 147.929 (ci-après la Société). La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en
date du 20 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial), le 25 septembre 2009,
numéro 1865, page 89513. Les statuts de la Société ont été modifiés plusieurs fois, et pour la dernière fois suivant un
acte reçu par le notaire soussigné en date du 27 mars 2013, publié au Mémorial le 27 juin 2013, numéro 1537, page 73757.
35409
L
U X E M B O U R G
La séance est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, avec adresse profession-
nelle à Esch/Alzette.
Le président désigne comme secrétaire Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle
à Esch/Alzette.
L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Claudia ROUCKERT, employée privée, avec adresse professionnelle
à Esch/Alzette.
Le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I. Les associés présents ou représentés et le nombre de parts sociales détenues par chacun d'entre eux sont exposés
sur la liste de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence,
ainsi que toutes les procurations seront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
II. Il ressort de la liste de présence que l'ensemble des six millions sept cent soixante-neuf mille huit cent soixante
(6.769.860) parts sociales de catégorie A et les cinq millions cinquante-trois mille neuf cent trente et une (5.053.931)
parts sociales de catégorie B, ayant droit de vote et représentant 100% du capital social émis de la Société est représenté
à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut valablement décider sur tous les points
à l'ordre du jour. Tous les associés ont été informés de l'ordre du jour avant l'assemblée et ont renoncé à toutes
procédures de convocation ou autres.
III. L'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire est le suivant:
1. Décision d'approuver la fusion, par laquelle Expert Petroleum SPV S. à r.l., une société à responsabilité limitée, avec
siège social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du
Registre de Commerce sous les numéro B 186.995, ayant un capital social de EUR 24.728,- en tant que société absorbante
(la Société Absorbante)fusionnera avec la Société, en tant que société absorbée, par absorption par la Société Absorbante
de la Société et sans liquidation de la Société (la Fusion), tel que prévu dans la projet de fusion commun acté par un acte
notarié reçu par le notaire soussigné le 26 novembre 2014, publié au Mémorial le 6 décembre 2014, numéro 3751, page
180023 (le Projet de Fusion), et tel que déposé, ensemble avec les documents y relatifs au siège social respectif de la
Société et de la Société Absorbante.
2. Décision de constater la renonciation par tous les associés de la Société et la Société Absorbante à l'exigence (i) de
procéder à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et d'obtenir un rapport établi par de
ce/ces expert(s) indépendants quant au Projet de Fusion conformément aux dispositions de l'Article 266 (1) de la loi du
10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), et (ii) obtenir un rapport écrit détaillé, établi par
les conseils de gestion de la Société et de la Société Absorbante conformément aux dispositions de l'Article 265 (1) de
la Loi et recevoir toute information concernant tout changement important de l'actif et du passif conformément à l'Article
265 (2) de la Loi.
3. Décharge des membres du conseil de gestion de la Société pour la bonne exécution des leurs activités jusqu'à la
date de l'assemblée générale et détermination du lieu où seront conservés tous les documents sociaux de la Société pour
la durée prescrite par la Loi.
4. Date d'effet de la Fusion ainsi que d'autres éléments présents à l'ordre du jour.
IV. Le notaire soussigné confirme que les dispositions de la Loi relatives aux fusions ont été respectées tel que suit:
1. Le Projet de Fusion, tel qu'établi conjointement par les conseils de gestion de la Société et de la Société Absorbante,
acté par un acte notarié établi par le notaire soussigné le 26 novembre 2014, publié au Mémorial le 6 décembre 2014,
numéro 3751, page 180023, c'est-à-dire au moins un mois avant la date qu'en tête des présentes et la date de l'assemblée
générale extraordinaire des associés de la Société Absorbante en relation avec la Fusion.
2. Le 26 novembre 2014 l'ensemble des associés de la Société et de la Société Absorbante ont renoncé (i) conformé-
ment à l'Article 266 (5) de la Loi à l'exigence de procéder à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts
indépendants et d'obtenir un rapport établi par de ce/ces expert(s) indépendants quant au Projet de Fusion conformément
aux dispositions de l'Article 266 (1) de la Loi, et (ii) conformément à l'Article 265 (3) de la Loi, à l'exigence d'obtenir un
rapport écrit détaillé, établi par les conseils de gestion de la Société et de la Société Absorbante conformément aux
dispositions de l'Article 265 (1) de la Loi et à recevoir toute information concernant tout changement important de l'actif
et du passif conformément à l'Article 265 (2) de la Loi.
3. Le Projet de Fusion, ensemble avec les documents y relatifs requis par l'Article 267 de la Loi ont été déposés aux
siège sociaux respectifs de la Société et de la Société Absorbante, afin d'être inspectés par les associés, au moins un mois
avant la date qu'en tête des présentes et la date de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Ab-
sorbante en relation avec la Fusion. Une attestation par la Société et la Société Absorbante certifiant la disponibilité de
ces documents, après avoir été signe ne varietur par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné
resteront attachés au présent acte afin d'être enregistré avec lui.
V. A la suite de cela, les résolutions suivantes sont prises:
35410
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale, après avoir revu le Projet de Fusion, décide d'approuver la Fusion telle que prévue dans le Projet
de Fusion, et le Projet de Fusion, tel que déposé, ensemble avec les documents y relatifs, aux sièges sociaux respectifs de
la Société et de la Société Absorbante.
L'assemblée générale décide ensuite, sous condition de l'approbation de la Fusion, telle que prévue dans le Projet de
Fusion, par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, de transférer tous les actifs et les passifs de la
Société à la Société Absorbante.
L'assemblée générale décide par ailleurs, sous condition de l'approbation de la Fusion, telle que prévue dans le Projet
de Fusion, par l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbante, que la Société sera dissoute sans liquidation,
et que tous les actifs et les passifs de la Société seront transférés à la Société Absorbante à la date à laquelle la Fusion
sera effective.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale constate la renonciation par tous les associés de la Société et de la Société Absorbante à l'exigence
(i) de procéder à l'examen du Projet de Fusion par un ou plusieurs experts indépendants et obtenir un rapport établi par
de ce/ces expert(s) indépendants quant au Projet de Fusion conformément aux dispositions de l'Article 266 (1) de la Loi
et (ii) obtenir un rapport écrit détaillé, établi par les conseils de gestion de la Société et de la Société Absorbante con-
formément aux dispositions de l'Article 265 (1) de la Loi et à recevoir toute information concernant tout changement
important de l'actif et du passif conformément à l'Article 265 (2) de la Loi.
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale décide de donner la décharge aux membres du conseil de gestion de la Société pour la bonne
exécution des leurs activités jusqu'à la date de l'assemblée générale et décide que tous les documents sociaux de la Société
seront conservés pour la durée prescrite par la Loi au siège social de la Société Absorbante.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale décide que la Fusion et toutes les autres points mentionnés dans les résolutions qui précèdent
seront effectives entre la Société et la Société Absorbante le 22 janvier 2015 et envers les tiers lors de la publication de
cet acte notarié au Mémorial.
<i>Déclarationi>
Conformément à l'Article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné déclare avoir vérifié et certifie l'existence et la validité,
en vertu des lois luxembourgeoises, des actes légaux et des formalités imposées à la Société de façon à rendre la Fusion
effective.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française; à la demande des mêmes parties comparantes, en
cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à la partie comparante, connue par le notaire soussigné par son nom, prénom, état civil et lieu
de résidence, ladite partie comparante a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Conde, Rouckert, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 janvier 2015. Relation: EAC/2015/2256. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015040936/222.
(150047210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
EDO Berlin Office S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 179.837.
In the year two thousand and fifteen, on the second March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
35411
L
U X E M B O U R G
REInvest Germany S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, Millewee, L- 7257 Walferdange - Grand-Duchy of Lu-
xembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115331,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee with professional address at Esch/Alzette
(the Attorney), by virtue of one (1) power of attorney given under private seal on December 18, 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company incorporated and existing in the
Grand Duchy of Luxembourg under the name “EDO Berlin Office S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered
office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 179837, pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 16, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2565, dated October 15, 2013.
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
III. The Company adopted a merger proposal (the Merger Proposal), according to which the Company shall be abrorbed
by EDO Treptower S.à r.l. (the Absorbing Company, and collectively referred to with the Company as the Merging
Companies), a private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing under the laws
of Luxembourg, having its registered office at 2, Millewee, L- 7257 Walferdange - Grand-Duchy of Luxembourg, with a
share capital of EUR 12.500,00 and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B
159709 (hereafter the Merger).
The Merger Proposal was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 179, dated January
23, 2015.
IV. The sole shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder acknowledges and ratifies the completion of the following preliminary conditions to the Merger:
a) The managing bodies of the Merging Companies have adopted the Merger Proposal, which has been published
pursuant to Article 262 of the Luxembourg law of August 10, 1915 relating to commercial companies (the Law) in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 179, dated January 23, 2015;
b) The sole shareholder has resolved, in accordance with Article 266 (5) of the Law, to waive the right to the exami-
nation of the Merger Proposal and to the certification of the exchange ratio by an independent expert and the
establishment of a report by such expert in relation to article 266 (2) points a) and b) of the Luxembourg Law;
c) The sole shareholder has resolved, in accordance with Article 265 (3) of the Law, to waive the right to receive (i)
the managers' report and (ii) the information referred into article 265 (2) of the Law;
d) The sole shareholder has resolved, in accordance with Article 267 (1) second paragraph of the Law, to waive the
right to receive the accounting statement referred into article 267 (1) c) of the Law;
e) The documents, provided for by article 267 of the Law have been deposited at the Company's registered office one
month prior to the date of the present resolutions.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder approves the Merger Proposal, pursuant to which the Company will be merged and acquired by
the Absorbing Company and will transfer to the Absorbing Company all its assets and all its liabilities, without any
restriction or limitation.
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder acknowledges that the Merger shall become effective under the provisions of the Law as per the
date after the execution of the deed of Merger in front of a notary in Luxembourg. The Merger shall have the following
consequences ipso jure, as per the date after the execution of the deed of Merger in front of a Luxembourg notary in
compliance with article 274 of the Luxembourg Law:
a) the universal transfer, both between the Company and the Absorbing Company and towards third parties, of all of
the assets and liabilities of the Company being transferred to the Absorbing Company;
b) the Company ceases to exist;
c) the cancellation of the shares of the Company;
d) all other consequences, as listed in the Merger Proposal.
As a result, the sole shareholder acknowledges that the Absorbing Company is the full and only legal owner of all the
assets and liabilities transferred by the Company by virtue of the Merger as per the date after the execution of the deed
35412
L
U X E M B O U R G
of Merger in front of a Luxembourg notary, and that it has the legal and beneficial enjoyment of the same assets and
liabilities as from the date of recording as well.
<i>Fourth resolutioni>
The Absorbing Company will cancel the 11.862 shares by the Company and will issue 11.862 new share at nominal
value of EUR 1,00 each to the sole profit of REInvest Germany S.à r.l., prenamed.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder grants full and complete discharge to the members of the board of managers of the Company
for the performance of their duties until the effective date of the Merger.
<i>Sixth resolutioni>
The accounting books and documents of the Company will be kept during a period of five (5) years at the registered
office of the Absorbing Company.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder acknowledges that the articles of the Absorbing Company after the Merger will remain unchan-
ged.
<i>Eighth resolutioni>
The sole shareholder acknowledges that the board of managers of the Absorbing Company shall retain its composition
and its rights as they presently exist and are entered.
<i>Certificate of Merger fulfilmenti>
The undersigned notary certifies that, pursuant to Article 271 (2), first paragraph of the Luxembourg Law:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,
- all formalities, bailments or publications (except the publication of this deed) relating thereto have been lawfully and
completely fulfilled.
Towards third parties, the Merger will be binding as from the date of its publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, in compliance with article 273 (1) of the Law.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
person and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deux mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esh-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
REInvest Germany S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2,
Millewee, L- 7257 Walferdange - Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115331,
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette (le Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 décembre 2014.
Laquelle procuration, après avoir été signées ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire instrumen-
taire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La comparante, représentée par son Mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg
sous la dénomination «EDO Berlin Office S.à r.l.» (ci-après, la Société), une société à responsabilité limitée établie et
existante selon les lois Luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee, L- 7257 Walferdange, ayant un capital social
de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
179837, constituée par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 août 2013,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2565 en date du 15 octobre 2013.
II. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq
cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
35413
L
U X E M B O U R G
III. La Société a adopté un projet de fusion (le Projet de Fusion), selon lequel la Société sera absorbée par EDO
Treptower S.à r.l. (la Société Absorbante, collectivement désignée avec la Société, les Sociétés Fusionnantes), une société
à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois (société à responsabilité limitée) ayant son adresse au 2, Millewee, L-
7257 Walferdange - Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 159709 (la Fusion).
Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 179 en date du
23 janvier 2015.
V. L'associé unique adopte les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique prend note et ratifient l'accomplissement des conditions suivantes, préliminaires à la Fusion:
a) Les organes d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes ont adopté le Projet de Fusion, qui a été publié
conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi) au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 179 en date du 23 janvier 2015.
b) L'associé unique a décidé, en conformité avec l'article 266 (5) de la Loi de renoncer à l'examen du Projet de Fusion
et à la certification du rapport d'échange par un expert indépendant et à l'établissement d'un rapport par un tel expert
en relation avec article 266 (2) points a) et b) de la Loi;
c) L'associé unique a décidé, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, de renoncer au droit de recevoir (i) le rapport
des organes d'administration et (ii) les informations visées à l'article 265 (2) de la Loi;
d) L'associé unique a décidé, conformément à l'article 267 (1), deuxième alinéa, de la Loi, de renoncer au droit de
recevoir l'état comptable visé dans l'article 267 (1) c) de la Loi;
e) Les documents prévus à l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège de la Société un mois précédant la date des
présentes résolutions.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique approuve le Projet de Fusion, aux termes desquels la Société fusionne et est absorbée par la Société
Absorbante, et transfert à la Société Absorbante tous ses actifs et tous ses passifs, sans restriction ni limitation.
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique reconnaît que la Fusion prendra effet en accord avec les dispositions de la Loi et qu'elle entraîne de
plein droit les effets suivants à compter du jour de la signature de l'acte de fusion par devant le notaire luxembourgeois,
conformément à l'article 274 de la Loi:
a) la transmission universelle, tant entre la Société et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du
patrimoine actif et passif la Société à la Société Absorbante;
b) la Société cesse d'exister;
c) l'annulation des parts sociales de la Société;
d) toutes autres conséquences énumérées dans le Projet de Fusion.
Par suite l'associé unique reconnaît que la Société Absorbante est définitivement propriétaire des actifs et passifs qui
lui ont été transmis par la Société dans le cadre de la Fusion à compter du jour de la signature de l'acte de Fusion par
devant le notaire luxembourgeois et qu'elle a la jouissance desdits actifs et passifs à compter également du jour de
l'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique reconnaît que les associés de la Société Absorbante procéderons à l'annulation des 11.862 parts
sociales détenues par la Société dans le capital social de la Société Absorbante et émettront 11.862 nouvelles parts sociales
à valeur nominale d'un Euro chacune, au seul profit de REInvest Germany S.à r.l.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique accorde pleine et entière décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l'exercice
de leurs mandats jusqu'à la date d'effet de la Fusion.
<i>Sixième résolutioni>
Les documents et pièces comptables relatifs à la Société resteront conservés pendant une période de cinq (5) ans au
siège social de la Société Absorbante.
<i>Septième résolutioni>
L'associé unique reconnaît que les statuts de la Société Absorbante après la Fusion, resteront inchangés.
35414
L
U X E M B O U R G
<i>Huitième résolutioni>
L'associé unique reconnaît que le conseil d'administration de la Société Absorbante conservera sa composition et que
tous les droits de celui-ci, tels qu'ils existent actuellement.
<i>Certificat de réalisation définitive de la Fusioni>
Le notaire instrumentaire certifie que, conformément à l'article 271 (2), premier alinéa de la Loi:
- la Fusion a été régulièrement réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxem-
bourg,
- toutes les formalités, dépôts ou publications (à l'exception de la publication du présent acte) y relatives ont été
régulièrement accomplis.
A l'égard des tiers, la Fusion sera régulièrement opposable à compter de la date de sa publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 273 (1) de la Loi.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du Mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch-Sur-Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au Mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 mars 2015. Relation: EAC/2015/5621. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015040941/190.
(150047178) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
EDO Treptower S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-7257 Walferdange, 2, Millewee.
R.C.S. Luxembourg B 159.709.
In the year two thousand and fifteen, on the second day of March.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. EDO Berlin Office S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange and registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register of Luxembourg under number B 179.837,
here represented by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee with professional address at Esch/Alzette
(the Attorney), by virtue of one (1) power of attorney given under private seal on December 18, 2014, and
2. NIS Ganesha S.A., a joint stock company (société anonyme), established and existing under the laws of Luxembourg,
having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register of Luxembourg under number B 156.279,
here represented by the Attorney, by virtue of one (1) power of attorney given under private seal on December 18,
2014.
The said proxies, signed ne varietur by the proxy holder of the appearing person and the undersigned notary, will
remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing persons, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing persons are the shareholders of the private limited liability company incorporated and existing in the
Grand Duchy of Luxembourg under the name “EDO Treptower S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered
office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies Register under number B 159.709, pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated March 14, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1277, dated June 14, 2011 and whose articles of association have been last amended pursuant
to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, dated October 25, 2013, published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3205, dated December 17, 2013.
35415
L
U X E M B O U R G
II. The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500,00) represented by twelve
thousand five hundred (12.500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1,00) each.
III. The Company adopted a merger proposal (the Merger Proposal), according to which the Company shall absorb
EDO Berlin Office S.à r.l. (the Absorbed Company, and together with the Company being collectively referred to he-
reunder as the Merging Companies), above mentioned (hereafter the Merger).
The Merger Proposal was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 179, dated January
23, 2015.
IV. The shareholders take the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The shareholders acknowledge and ratify the completion of the following preliminary conditions to the Merger:
a) The managing bodies of the Merging Companies have adopted the Merger Proposal, which has been published
pursuant to Article 262 of the Luxembourg law of August 10, 1915 relating to commercial companies (the Law) in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 179, dated January 23, 2015;
b) The shareholders have resolved, in accordance with Article 266 (5) of the Law, to waive the right to the examination
of the Merger Proposal and to the certification of the exchange ratio by an independent expert and the establishment of
a report by such expert in relation to article 266 (2) points a) and b) of the Luxembourg Law;
c) The shareholders have resolved, in accordance with Article 265 (3) of the Law, to waive the right to receive (i) the
managers' report and (ii) the information referred into article 265 (2) of the Law;
d) The shareholders have resolved, in accordance with Article 267 (1) second paragraph of the Law, to waive the right
to receive the accounting statement referred into article 267 (1) c) of the Law;
e) The documents, provided for by article 267 of the Law have been deposited at the Company's registered office one
month prior to the date of the present resolutions.
<i>Second resolutioni>
The shareholders approve the Merger Proposal, pursuant to which the Company will merge with and acquire the
Absorbed Company and the Absorbed Company will transfer to the Company all its assets and all its liabilities, without
any restriction or limitation.
<i>Third resolutioni>
The shareholders acknowledge that the Merger shall become effective under the provisions of the Law as per the date
after the execution of the deed of Merger in front of a notary in Luxembourg. The Merger shall have the following
consequences ipso jure, as per the date after the execution of the deed of Merger in front of a notary in compliance with
article 274 of the Law:
a) the universal transfer, both between the Company and the Absorbed Company and towards third parties, of all of
the assets and liabilities of the Absorbed Company being transferred to the Company;
b) the Absorbed Company ceases to exist;
c) the cancellation of the shares of the Absorbed Company;
d) all other consequences, as listed in the Merger Proposal.
As a result, the shareholders acknowledge that the Company is the full and only legal owner of all the assets and
liabilities transferred by the Absorbed Company by virtue of the Merger as per the date after the execution of the deed
of Merger in front of a Luxembourg notary, and that it has the legal and beneficial enjoyment of the same assets and
liabilities as from the date of recording as well.
<i>Fourth resolutioni>
The shareholders resolve to cancel the 11.862 shares in the capital of the Company currently held by EDO Berlin
Office S.à r.l., above mentioned, and to issue 11.862 new share at nominal value of EUR 1,00 each to the sole profit of
REInvest Germany S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), established and existing
under the laws of Luxembourg, having its registered office at 2, Millewee, L-7257 Walferdange - Grand Duchy of Lu-
xembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 115.331.
<i>Fifth resolutioni>
The accounting books and documents of the Absorbed Company will be kept during a period of five (5) years at the
registered office of the Company.
<i>Sixth resolutioni>
The shareholders acknowledge that the articles of the Company after the Merger will remain unchanged.
35416
L
U X E M B O U R G
<i>Seventh resolutioni>
The shareholders acknowledge that the board of managers of the Company shall retain its composition and its rights
as they presently exist and are entered.
<i>Certificate of Merger fulfilmenti>
The undersigned notary certifies that, pursuant to article 271 (2), first paragraph of the Law:
- the Merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg,
- all formalities, bailments or publications (except the publication of this deed) relating thereto have been lawfully and
completely fulfilled.
Towards third parties, the Merger will be binding as from the date of its publication in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, in compliance with article 273 (1) of the Law.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing persons, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the
same persons and in case of divergences between the English and the French text, the French version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Esch/Alzette, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing persons, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le deux mars.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esh-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
1) EDO Berlin Office S.à r.l., une société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois Luxembourgeois,
ayant son siège social au 2, Millewee, L- 7257 Walferdange, ayant un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 179.837 (ci-après désignée comme
la Société Absorbée),
ici représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, avec adresse professionnelle à Esch/
Alzette (le Mandataire), en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 décembre 2014, et
2) NIS Ganesha S.A., une société anonyme établie et existante selon les lois Luxembourgeois, ayant son siège social
au 2, Millewee, L-7257 Walferdange, ayant un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.279,
ici représenté par le Mandataire, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé le 18 décembre 2014.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le Mandataire des comparantes et le notaire instru-
mentaire, demeureront annexées aux présentes pour être enregistrées avec elles.
Les comparantes, représentée par leur Mandataire, ont requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. Les comparantes sont les associés de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg
sous la dénomination «EDO Treptower S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2, Millewee, L-7257
Walferdange, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 159.709, constituée par acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 14 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1277 en date du 14 juin
2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence
à Esch-sur-Alzette, en date du 25 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3205
du 17 décembre 2013.
II. Le capital social de la Société est fixé douze mille cinq cent Euro (EUR 12.500,00) représenté par douze mille cinq
cent (12.500) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1,00) chacune.
III. La Société a adopté un projet de fusion (le Projet de Fusion), selon lequel la Société va absorber EDO Berlin Office
S.à r.l. (la Société Absorbée, et ensemble avec la Société Absorbante, les Sociétés Fusionnantes), nommé ci-dessus (la
Fusion).
Le Projet de Fusion a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 179 en date du
23 janvier 2015.
V. Les associés adoptent les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les associés prennent note et ratifient l'accomplissement des conditions suivantes, préliminaires à la Fusion:
35417
L
U X E M B O U R G
a) Les organes d'administration de chacune des Sociétés Fusionnantes ont adopté le Projet de Fusion, qui a été publié
conformément aux dispositions de l'article 262 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (la Loi) au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 179 en date du 23 janvier 2015.
b) Les associés ont décidé, en conformité avec l'article 266 (5) de la Loi de renoncer à l'examen du Projet de Fusion
et à la certification du rapport d'échange par un expert indépendant et à l'établissement d'un rapport par un tel expert
en relation avec article 266 (2) points a) et b) de la Loi;
c) Les associés ont décidé, conformément à l'article 265 (3) de la Loi, de renoncer au droit de recevoir (i) le rapport
des organes d'administration et (ii) les informations visées à l'article 265 (2) de la Loi;
d) Les associés ont décidé, conformément à l'article 267 (1), deuxième alinéa, de la Loi, de renoncer au droit de
recevoir l'état comptable visé dans l'article 267 (1) c) de la Loi;
e) Les documents prévus à l'article 267 de la Loi ont été déposés au siège de la Société un mois précédant la date des
présentes résolutions.
<i>Deuxième résolutioni>
Les associés approuvent le Projet de Fusion, aux termes desquels la Société fusionne et absorbe la Société Absorbée,
et la Société Absorbée transfère à la Société tous ses actifs et tous ses passifs, sans restriction ni limitation.
<i>Troisième résolutioni>
Les associés reconnaissent que la Fusion prendra effet en accord avec les dispositions de la Loi et elle entraîne de plein
droit les effets suivants à compter du jour de la signature de l'acte de Fusion par devant le notaire luxembourgeois,
conformément à l'article 274 de la Loi:
a) la transmission universelle, tant entre la Société et la Société Absorbée qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du
patrimoine actif et passif la Société Absorbée à la Société;
b) la Société Absorbée cesse d'exister;
c) l'annulation des parts sociales de la Société Absorbée;
d) toutes autres conséquences énumérées dans le Projet de Fusion.
Par suite les associés reconnaissent que la Société est définitivement propriétaire des actifs et passifs qui lui ont été
transmis par la Société Absorbée dans le cadre de la Fusion à compter du jour de la signature de l'acte de Fusion par
devant le notaire luxembourgeois et qu'elle a la jouissance desdits actifs et passifs à compter également du jour de
l'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
Les associés décident d'annuler les 11.862 parts sociales détenues par EDO Berlin Office S.à r.l. dans le capital social
de la Société et d'émettre 11.862 nouvelles parts sociales à valeur nominale d'un Euro chacune, au seul profit de REInvest
Germany S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 2, Millewee,
L-7257 Walferdange - Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 115.331.
<i>Cinquième résolutioni>
Les documents et pièces comptables relatifs à la Société Absorbée resteront conservés pendant une période de cinq
(5) ans au siège social de la Société Absorbante.
<i>Sixième résolutioni>
Les associés reconnaissent que les statuts de la Société après la Fusion restent inchangés.
<i>Septième résolutioni>
Les associés reconnaissent que le conseil d'administration de la Société conservera sa composition et que tous les
droits de celui-ci, tels qu'ils existent actuellement.
<i>Certificat de réalisation définitive de la Fusioni>
Le notaire instrumentaire certifie que, conformément à l'article 271 (2), premier alinéa de la Loi:
- la Fusion a été régulièrement réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxem-
bourg,
- toutes les formalités, dépôts ou publications (à l'exception de la publication du présent acte) y relatives ont été
régulièrement accomplis.
A l'égard des tiers, la Fusion sera régulièrement opposable à compter de la date de sa publication au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 273 (1) de la Loi.
35418
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du Mandataire des
personnes comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête des mêmes
personnes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version française fera foi.
DONT PROCES-VERBAL, fait et passé à Esch/Alzette, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au Mandataire des personnes comparantes, connue du notaire par ses nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 10 mars 2015. Relation: EAC/2015/5623. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): M. Halsdorf.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015040942/197.
(150047180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
SR Portfolio Holding (C) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 59, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 88.926.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am vierten Februar.
vor dem unterzeichnenden Notar, Maître Cosita Delvaux, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
fand die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschafter der SR Portfolio Holding (C) S.àr.l. (die „Gesell-
schaft“) statt, einer société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts mit Sitz in 59, rue de Rollingergrund, L-2440
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die am 30. August 2002, gemäß notarieller Urkunde aufgenommen durch Maître
Joseph Elvinger, damaliger Notar mit Amtssitz in Luxemburg, welche im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(das „Mémorial“) Nummer 1538 vom 24. Oktober 2002 veröffentlicht wurde, gegründet wurde und im Handels- und
Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 88926 eingetragen ist.
Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 26. September 2008 durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, mit
Amtssitz in Luxemburg, im Mémorial C Nummer 2708 vom 6. November 2008 veröffentlicht.
Als Vorsitzender der Versammlung amtierte Namik Ramic, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg.
Die Generalversammlung ernannte Darya Spivak, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Protokollführer
und Stimmenzähler.
Der Vorsitzende erklärte und beauftragte den Notar, Folgendes festzustellen:
I. Die vertretenen Gesellschafter sowie die Anzahl der gehaltenen Gesellschaftsanteile sind auf einer Anwesenheitsliste
eingetragen, welche von den Bevollmächtigten, dem Vorsitzenden, dem Protokollführer und Stimmenzähler und dem
unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde. Diese Anwesenheitsliste bleibt, ebenso wie die Vollmachten, diesem Pro-
tokoll beigefügt, um mit demselben registriert zu werden.
II. Aus dieser Anwesenheitsliste geht hervor, dass sämtliche ausgegebenen fünfhundert (500) Gesellschaftsanteile der
Klasse Z, mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig Euro (25,- EUR), der Gesellschaft, bei dieser Versammlung vertreten
sind, so dass das gesamte ausgegebene Gesellschaftskapital und alle Gesellschafter der Gesellschaft bei dieser Versamm-
lung vertreten sind. Die Gesellschafter erklärten, dass ihnen die nachstehende Tagesordnung bekannt ist.
III. Obenstehendem zufolge ist diese Versammlung ordnungsgemäß einberufen und ist hinsichtlich der nachstehenden
Tagesordnungspunkte beschlussfähig.
IV. Die Punkte, über die Beschlüsse getroffen werden sollen, sind die folgenden:
<i>Tagesordnungi>
1. Billigung des Entwurfs des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 28. Oktober 2014 veröffentlicht am 13. No-
vember 2014 im Mémorial C, Nummer 3367 betreffend die Verschmelzung der Demag Management Equity Participation
Verwaltungs GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in Grafenberger Allee 87, D-40237 Düsseldorf,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 48160 („DEMAG Verwaltung“), auf die Gesell-
schaft.
2. Billigung der Verschmelzung der Gesellschaft mit der DEMAG Verwaltung durch eine grenzüberschreitende Versch-
melzung durch Übertragung des gesamten Unternehmens der DEMAG Verwaltung auf die Gesellschaft gemäß Artikel
274 des luxemburgischen Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften (wie abgeändert) (das „Gesetz“).
3. Zurkenntnisnahme des Verschmelzungsstichtages.
35419
L
U X E M B O U R G
4. Bestätigung der Veröffentlichung des Entwurfs des Verschmelzungsplans am 13. November 2014 im Mémorial C,
Nummer 3367, mindestens einen Monat vor dem Datum der Gesellschafterversammlung welche der Verschmelzung
zustimmt.
5. Verzicht der Gesellschafter auf den in Artikel 265 (1) des Gesetzes vorgesehenen Bericht welcher den Verschmel-
zungsplan aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht erklärt und begründen soll, gemäß schriftlichem Beschluss der
Gesellschafter vom 28. Oktober 2014.
V. Die Gesellschafterversammlung bestätigt hiermit die Hinterlegung der folgenden gemäß Artikel 267 des Gesetzes
erforderlichen Unterlagen mindestens einen Monat vor der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft am Sitz der
Gesellschaft:
a. Der Entwurf des gemeinsamen Verschmelzungsplans vom 28. Oktober 2014 (mit der Satzung der aufnehmenden
Gesellschaft),
b. Die Bilanzen der letzten 3 Geschäftsjahre (2012, 2013 und 2014) der Gesellschaft,
Nach Erläuterung der Gesellschafterversammlung bekannten Entwurfes des Verschmelzungsplans vom 28. Oktober
2014 sowie der rechtlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der beabsichtigten grenzüberschreitenden Verschmelzung
fasste die Versammlung der Gesellschafter die nachfolgenden Beschlüsse.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Entwurf des Verschmelzungsplans am 28. Oktober 2014
von der Geschäftsführung der DEMAG Verwaltung als übertragende Gesellschaft und der Geschäftsführung der Gesell-
schaft als übernehmende Gesellschaft aufgestellt wurde und am 13. November 2014 im Mémorial C, Nummer 3367,
veröffentlicht wurde (eine Kopie dieser Veröffentlichung liegt dieser Urkunde bei).
Die Gesellschafterversammlung stimmt hiermit einstimmig dem von der DEMAG Verwaltung und der Gesellschaft am
28. Oktober 2014 aufgestellten Verschmelzungsplan zu.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung stimmt hiermit einstimmig der Verschmelzung der DEMAG Verwaltung durch Über-
tragung ihres Unternehmens auf die Gesellschaft im Wege der Gesamtrechtsnachfolge gemäß Artikel 274 (1) des
Gesetzes, nach Maßgabe des Verschmelzungsplans vom 28. Oktober 2014 ohne jeglichen Vorbehalt und Voraussetzung
zu.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bestätigt, dass die Übernahme des Vermögens der DEMAG Verwaltung durch die
Gesellschaft für die Zwecke der Rechnungslegung mit Wirkung zum 1. Oktober 2014, 0:00 Uhr (Verschmelzungsstichtag)
erfolgt.
<i>Vierter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bestätigt die Veröffentlichung des Entwurfes des Verschmelzungsplans am 13. No-
vember 2014 im Mémorial C, Nummer 3367, mindestens einen Monat vor dem Datum der Gesellschafterversammlung,
welche der Verschmelzung zustimmt.
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafterversammlung bestätigt hiermit den schriftlich gefassten Beschluss der Gesellschafter der Gesellschaft
vom 28. Oktober 2014, auf den in Artikel 265 (1) des Gesetzes vorgesehenen Bericht, welcher den Verschmelzungsplan
aus rechtlicher und wirtschaftlicher Sicht erklärt und begründen soll, zu verzichten.
<i>Festellungi>
Der unterzeichnende Notar bestätigt die Bescheinigung gemäß Artikel 271 (2) des Gesetzes seitens des Amtsgerichts
Düsseldorf - Handelsregister erhalten zu haben, welche die rechtmäßige Durchführung gemäß dem deutschen Recht der
Verschmelzung vorangehenden Urkunden und Formalitäten in Bezug auf den Verschmelzungsvorgang welcher die DE-
MAG Verwaltung betrifft, bescheinigt.
Der unterzeichnende Notar bestätigt den Verschmelzungsplan, welchem die DEMAG Verwaltung zugestimmt hat,
erhalten zu haben und dass die Gesellschaft dem Verschmelzungsplan in gleicher Fassung zugestimmt hat.
Der unterzeichnende Notar bestätigt hiermit den Bestand und die Rechtswirksamkeit des Verschmelzungsplans sowie
alle Formalitäten im Zusammenhang mit den verschmelzenden Parteien nach den Bestimmungen von Artikel 271 des
Gesetzes.
<i>Kosteni>
Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass des Gegenwärtigen entstehen werden, werden auf EUR 1.500,- geschätzt.
Dem Vorgenannten entsprechend wurde die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am Tag des zu Beginn
genannten Datums erstellt.
35420
L
U X E M B O U R G
Nachdem das Dokument der erschienenen Person, welche dem Notar durch ihren Namen, Vornamen, Stand und
ihrer Herkunft nach bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese zusammen mit uns, Notar, die hier vorliegende Urkunde
unterzeichnet.
Gezeichnet: N. RAMIC, D. SPIVAK, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 11 février 2015. Relation: 1LAC/2015/4352. Reçu douze euros 12,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 18. Februar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015030799/105.
(150033423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 février 2015.
NN Lux Insurance International S.A., Société Anonyme,
(anc. ING Lux Insurance International S.A.).
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 135.305.
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE CINQ MARS.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«ING Continental Europe Holdings B.V.», une société de droit néerlandais, avec siége social au Amstelveenseweg 500,
1081 Amsterdam, KL, Pays-Bas, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés d’Amsterdam sous le numéro
33002024,
ici représentée par Monsieur Bruno GOSSART, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, 3, rue Jean
Piret,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 4 mars 2015,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement,
déclarant agir en sa qualité d’actionnaire unique de "ING LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.", une société
anonyme ayant son siège social au 3, Rue Jean Piret, à L 2350 Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 21 décembre
2007, publié au Mémorial C n°341 du 9 février 2008, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte
du notaire soussigné alors de résidence à Redange-sur-Attert en date du 15 décembre 2011, publié au Mémorial C n°
249 du 30 janvier 2012, page 11.950.
L’actionnaire unique, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la société en «NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.».
2. Modification conséquente de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.»
3. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts, l’actionnaire unique a pris la résolution suivante:
<i>Unique résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en «NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL
S.A.» et décide en conséquence de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur
suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.»
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.200,-.
Le notaire soussignée qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est
rédigé en langue française suivi d’une version anglaise; sur demande du même comparant, le texte anglais fera foi en cas
de divergences entre les deux versions.
35421
L
U X E M B O U R G
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Suit la traduction anglaise
IN THE YEAR TWO THOUSAND AND FIFTEEN, ON THE FIFTH DAY OF MARCH.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Appeared
«ING Continental Europe Holdings B.V.», a company incorporated under the laws of the Netherlands, with registered
office in Amstelveenseweg 500, 1081 Amsterdam KL, Netherlands, registered in the Amsterdam Trade and Companies
Register under number 33002024,
duly represented by Mr Bruno GOSSART, lawyer, residing professionally in Luxembourg, 3, Rue J. Piret,
by virtue of a proxy dated 4 March 2015,
said proxy, signed "ne varietur" by the appearing proxy holder and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed for the purpose of registration,
acting as sole shareholder of “ING LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.”, a "société anonyme", having its reg-
istered office at 3, Rue JeanPiret in L- 2350 Luxembourg,
incorporated by deed of Me Gérard Lecuit, notary residing in Luxembourg on December 21, 2007, published in the
Mémorial C n° 341 of February 9, 2008, and the articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a
deed of the undersigned notary, residing then in Redange-sur-Attert, on 15 December 2011, published in the Mémorial
C n° 249 on 30 January 2012, page 11.950.
The sole member, represented as above stated, requested the undersigned notary to document the following:
The agenda of the meeting is the following:
1. Amendment of the denomination of the company into NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL S.A.
2. Amendment of article 1 of the statutes wich will be read as follows:
Art. 1. There exist a stock company (société anonyme) under the name NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL
S.A.
3. Miscellaneous.
The sole shareholder decides what follows:
<i>Sole resolutioni>
The sole shareholder decides to modify the denomination of the company into NN LUX INSURANCE INTERNA-
TIONAL S.A., and decides to amend as a consequence article 1
st
of the articles of incorporation which will be read as
follows:
“ Art. 1. There exist a stock company (société anonyme) under the name NN LUX INSURANCE INTERNATIONAL
S.A.“
There being no further business, the meeting is closed.
<i>Costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its capital decrease, have been estimated at about EUR 1,200.-
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in French followed by a English translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the French and the English texts, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Signé: B. GOSSART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7248. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015041061/94.
(150046966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
35422
L
U X E M B O U R G
NN Life Luxembourg S.A., Société Anonyme,
(anc. ING Life Luxembourg S.A.).
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 46.425.
L'AN DEUX MILLE QUINZE, LE CINQ MARS.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
«ING LUX INSURANCE INTERNATIONAL SA», société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à
L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite au RCS Luxembourg B135305,
ici représentée par Monsieur Bruno GOSSART, juriste, demeurant professionnellement à L-2350 Luxembourg, 3, rue
Jean Piret,
spécialement mandaté à cet effet par procuration en date du 2 mars 2015,
laquelle procuration, paraphée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant,
restera annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement,
déclarant agir en sa qualité d’actionnaire unique de "ING LIFE LUXEMBOURG S.A.", une société anonyme ayant son
siège social à L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret, inscrite au R.C.S. Luxembourg B46425,
constituée sous la dénomination de «DE VADERLANDSCHE Luxembourg-PATRIOTIQUE Luxembourg S.A.», suivant
acte notarié du 11 janvier 1994, publié au Mémorial C n°99 de 1994, page 4711, et les statuts et la dénomination ont été
modifiés par acte de réalisation de fusion reçu par le notaire Reginald NEUMAN en date du 28 janvier 2000, publié au
Mémorial C n°205 du 13 mars 2000, page 9813, et pour la dernière fois par acte reçu par le notaire soussigné alors de
résidence à Redange-sur-Attert, en date du 15 décembre 2011, publié au Mémorial C n° 246 du 30 janvier 2012, page
11.801.
L’actionnaire unique, représenté comme dit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Modification de la dénomination de la société en «NN LIFE LUXEMBOURG S.A.».
2. Modification conséquente de l’article 1
er
des statuts pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «NN LIFE LUXEMBOURG S.A.»
3. Modification de l’article 11 des statuts par insertion d’un nouvel alinéa entre les actuels 1
er
et 2
ème
alinéa, qui aura
la teneur suivante:
Art. 11. Alinéa 2 nouveau. Les administrateurs peuvent être soit liés aux sociétés du groupe dont fait partie la société
soit indépendants.
4. Modification du dernier alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. dernier alinéa. Les copies ou extraits sont signés par le président ou par le dirigeant agréé ayant la qualité
d’administrateur ou par deux administrateurs.
5. Modification de l’article 19 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 19. Les administrateurs liés aux sociétés du groupe dont fait partie la société exercent leur mandat gratuitement.
Les administrateurs indépendants peuvent toutefois être rémunérés.
Le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs chargés de fonctions et de missions spéciales des indem-
nités à prélever sur les frais généraux.
6. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts, l’actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier la dénomination de la société en «NN LIFE LUXEMBOURG S.A.» et décide
en conséquence de modifier l’article 1
er
des statuts de la société pour lui donner la nouvelle teneur suivante:
« Art. 1
er
. Il existe une société anonyme sous la dénomination de «NN LIFE LUXEMBOURG S.A.»
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 11 des statuts par insertion d’un nouvel alinéa entre les actuels 1
er
et 2
ème
alinéas de cet article, alinéa qui aura la teneur suivante:
Art. 11. Alinéa 2 nouveau. Les administrateurs peuvent être soit liés aux sociétés du groupe dont fait partie la société
soit indépendants.
35423
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier le dernier alinéa de l’article 15 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 15. dernier alinéa. Les copies ou extraits sont signés par le président ou par le dirigeant agréé ayant la qualité
d’administrateur ou par deux administrateurs.
<i>Quatrième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier l’article 19 des statuts, pour lui donner la teneur suivante:
Art. 19. Les administrateurs liés aux sociétés du groupe dont fait partie la société exercent leur mandat gratuitement.
Les administrateurs indépendants peuvent toutefois être rémunérés.
Le conseil d'administration peut allouer aux administrateurs chargés de fonctions et de missions spéciales des indem-
nités à prélever sur les frais généraux.
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ EUR 1.200,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: B. GOSSART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 mars 2015. Relation: 1LAC/2015/7247. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 mars 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015041060/77.
(150047008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 mars 2015.
Pharus Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 90.212.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire, tenue à Luxembourg, le 23 janvier 2015:i>
L'Assemblée Générale Ordinaire décide:
- De nommer, pour une période d'un an allant jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016, laquelle
approuvera le Rapport Annuel et les Etats financiers révisés de l'exercice sociale se terminant le 30 septembre 2015, les
Administrateurs suivants:
* Monsieur Davide PASQUALI, Administrateur et Président du Conseil d'Administration;
* Madame Lidia PALUMBO, Administrateur du Conseil d'Administration;
* Monsieur Roberto COLAPINTO, Administrateur du Conseil d'Administration.
- La nomination du Réviseur d'Entreprises Agréé, PricewaterhouseCoopers, pour une nouvelle période d'un an prenant
fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2016.
A l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire, le Conseil d'Administration est composé de:
<i>Président du Conseil d'Administration:i>
- Monsieur Davide PASQUALI, 7, Via Pollini, CH-6850 Mendrisio
<i>Administrateurs:i>
- Madame Lidia PALUMBO, 32-36, Boulevard d'Avranches, L-1160, Luxembourg
- Monsieur Roberto COLAPINTO, 45 rue Siggy vu Letzebuerg, L-1933 Luxembourg
<i>Réviseur d'Entreprises Agréé:i>
PricewaterhouseCoopers, ayant son siège social à L - 1471 Luxembourg, 400, route d'Esch.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015022999/26.
(150026228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
35424
Abengoa Concessions Investments S.à r.l.
Atlantas Sicav
Aurea Finance Company
Axxion Focus
Brindleyplace Partner S.à r.l.
Brugama SPF S.A.
Capale S.A.
Cordalia S.A.
CoreCommodity Strategy Fund
EDO Berlin Office S.à r.l.
EDO Treptower S.à r.l.
Ely International SPF S.A.
Expert Petroleum Holdings S.à r.l.
Expert Petroleum SPV S.à r.l.
Financial China S.A.
Fundo
Germany White Invest S.A.
Global Diversified Sicav
Goldman Sachs Funds
Immobilière Bless S.A.
ING Life Luxembourg S.A.
ING Lux Insurance International S.A.
Ipsila S.A.
Isaias S.A.
J.A.F. S.A.
Kavialux S.à r.l.
Kortstrukt S.A.
Longview Partners Investments
Luxbond
Luxcash
Mapicius S.A.
Micheline Invest S.A. - SPF
Nacaza S.A.
NN Life Luxembourg S.A.
NN Lux Insurance International S.A.
Pharus Sicav
Pioneer Institutional Funds
SEB FS Fund Solutions
Sodexo Senior Service S.A.
SODIMEG S.àr.l.
SR Portfolio Holding (C) S.à r.l.
S&S Fonder
Torcos S.à r.l.
Triple A Trading S.A.
Tyack S.A.
VPF International S.à r.l.
Watford S.A.