This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 726
17 mars 2015
SOMMAIRE
Corelux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34804
Corning International Luxembourg S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34804
Corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires
Mondercange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34803
Cuny Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34804
Curzon 50 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34802
CVM SPF S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34803
Cyclon S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34803
Delta AK S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34809
Derceto Management . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34809
Desalline S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34810
D.H. Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34803
Dodo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34809
Do Way S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34809
Engineering S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34811
Euro Equity Management S.à r.l. . . . . . . . .
34810
Euro Equity Management S.à r.l. . . . . . . . .
34810
Eurozone Development S.A. . . . . . . . . . . . .
34811
Eurozone Development S.à r.l. . . . . . . . . . .
34811
Firewall Management Mip S.A. . . . . . . . . . .
34812
Firewall Management Mip S.à r.l. . . . . . . . .
34812
Hydra Luxembourg Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34811
Iberian Hod S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34840
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l. . . . . . . .
34839
JENSAL Spf S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34802
Johnson Controls Interiors Holding EU S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34802
Kaderma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34805
Knowles Luxembourg International S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34806
Konoco.M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34839
Laurent Properties S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
34811
Lava Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
34839
LSREF3 Tiger Grays S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
34840
Lysys Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
34848
MC Car Loans Finance I S.à r.l. . . . . . . . . . .
34848
OCM Luxembourg Leman Street Apart-
Hotel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34805
OCM Luxembourg Olivers Yard Apart-Ho-
tel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34805
OCM Luxembourg POF IV Herkules Hol-
dings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34805
OCM Luxembourg Stilo Investment S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34804
Sea View Residence S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
34807
Sheet Anchor Properties France S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34806
Sheet Anchor Properties Lux Holding S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34806
Shessen Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34807
Sofidra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34808
Sogin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34808
TCS II Lu S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34807
Utilicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34808
Würth Reinsurance Company S.A. . . . . . .
34840
34801
L
U X E M B O U R G
Johnson Controls Interiors Holding EU S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 189.517.
EXTRAIT
En date du 30 janvier 2015, Johnson Controls Holding Company, Inc., associé unique de la Société, a transféré les
12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à Johnson Controls Romania S.R.L., ayant son siège social au Route
nationale 65B KM.2+770, n 16, zone commerciale Geamana, OB.3, JIT, 117140, Bradu, Arges, Roumanie, immatriculée
auprès de registre de commerce sous le numéro J3/340/2002.
En conséquence de ce transfert, Johnson Controls Romania S.R.L. est devenu l'associé unique de la Société et détient
l'intégralité des 12.500 parts sociales composant son capital.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2015.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021831/19.
(150025263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
JENSAL Spf S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 180.508.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 26 janvier 2015i>
Le Conseil d'administration a nommé Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à
L-2163 Luxembourg, agent dépositaire des actions au porteur de la Société.
Luxembourg, le 26 janvier 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021832/14.
(150025238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Curzon 50 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.664,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 173.695.
<i>Extrait des résolutions de l'associé uniquei>
Suite aux résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 4 février 2015, il a été décidé de nommer
Elah External Management Services Ltd, une société constituée et régie selon les lois des îles Vierges Britanniques, ayant
son siège social à Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110, Iles Vierges Britanniques et enregistrée
au Registre du Commerce des Iles vierges Britannique sous le numéro 1719028, en tant que gérant de catégorie B de la
Société pour une durée illimitée.
Traduction pour les besoins de l'enregistrement
Further to the resolutions taken by the sole shareholder of the Company on February 4, 2015, it has been resolved
to appoint Elah External Management Services Ltd, a limited company incorporated and existing under the laws of the
British Virgin Islands, having its registered office at Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VG 1110,
British Virgin Islands and registered with the company number 1719028, as class B manager of the Company for an
unlimited period.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015022477/21.
(150026177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34802
L
U X E M B O U R G
CVM SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 60.388.
EXTRAIT
Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel
qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil
d'Administration décide, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, G.T. Fiduciaires S.A. avec siège
social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL sous le numéro B 121820.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 09.02.2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015022478/16.
(150026865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Cyclon S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 98.470.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 30 Janvier 2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société CYCLON
S.A., la Fiduciaire Benoy Kartheiser Management Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 33849, inscrite à l'Ordre
des Expert-Comptables de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015022479/13.
(150027150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
D.H. Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.
R.C.S. Luxembourg B 172.326.
EXTRAIT
Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel
qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (la «Loi»), le Conseil
d'Administration décide, après délibération, de désigner en qualité de dépositaire agréé, G.T. Fiduciaires S.A. avec siège
social à L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg et inscrite au RCSL sous le numéro B 121820.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 21.01.2015.
G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg
Référence de publication: 2015022480/16.
(150026860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires Mondercange, Association sans but lucratif.
Siège social: L-4393 Pontpierre, 6A, Grand Rue.
R.C.S. Luxembourg F 9.925.
Les statuts coordonnés au 03.02.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015022429/9.
(150027094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34803
L
U X E M B O U R G
Corelux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.493.
<i>Extrait des minutes du conseil d'administration de la société en date du 4 février 2015i>
Le conseil d'administration décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, ayant son siège social au 560, Rue de
Neudorf L - 2220 Luxembourg, enregistré sous le numéro B67895 au Registre de Commerce et des Sociétés, en tant
que réviseur externe de la Société et ce, concernant l'audit des comptes se clôturant au 31 décembre 2014.
A Luxembourg, le 4 février 2015.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2015022426/15.
(150027060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Corning International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 1.043.707,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.100.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015022428/10.
(150026250) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Cuny Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6750 Grevenmacher, 13, rue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 165.189.
Conformément à la loi du 28 Juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur (Mémorial A-N°
161 du 14 Août 2014) Le conseil d'administration de CUNY INVEST S.A. décide de Nommer comme dépositaire des
actions de la société CUNY INVEST SA:
Maître Michel Schwartz
Avocat à la Cour
11 rue Glesener
L-1631 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015022431/15.
(150027047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
OCM Luxembourg Stilo Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 155.455.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 30 janvier 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, avec effet du 31 janvier 2015
- De nommer M. Hugo Neuman, né le 21 octobre 1960 à Amsterdam (The Netherlands) ayant sa résidence profes-
sionnelle au 26A boulevard Royal, L-2449, Luxembourg comme Gérant de la société avec effet au 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Stilo Investment Sàrl
Référence de publication: 2015022955/14.
(150026126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34804
L
U X E M B O U R G
OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 121.749.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 6 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings Sàrl
Référence de publication: 2015022953/12.
(150025962) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
OCM Luxembourg Olivers Yard Apart-Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 179.166.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 6 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Olivers Yard Apart-Hotel Sàrl
Référence de publication: 2015022950/12.
(150025947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
OCM Luxembourg Leman Street Apart-Hotel S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 181.067.
<i>Extrait des résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la Société prises le 6 février 2015i>
L'Assemblée Générale Extraordinaire de la Société a décidé:
- D'accepter la démission de M. Szymon Dec, Mme. Figen Eren et M. Martin Graham avec effet du 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
OCM Luxembourg Leman Street Apart-Hotel Sàrl
Référence de publication: 2015022949/12.
(150026057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Kaderma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4963 Clemency, 9bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 169.004.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 26 janvier 2015i>
Le Conseil d'Administration a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
- Acceptation de la nomination de Monsieur Michel Antolinos, né le 24 novembre 1941 à Lyon, demeurant au 21, Quai
du Mont Blanc, CH-1201 Genève, Suisse, à la fonction d'Administrateur-délégué. Il pourra engager la société vis-à-vis des
tiers par sa seule signature. Son mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale annuelle de 2019.
Pour extrait conforme
Le 06 février 2015.
Référence de publication: 2015021839/14.
(150025315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
34805
L
U X E M B O U R G
Sheet Anchor Properties France S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 179.276.
EXTRAIT
La résolution suivante a été adoptée par l'Associé unique en date du 6 février 2015:
- La démission de Madame Caroline Vander Meersch en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet au 30
janvier 2015.
A partir du 6 février 2015, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Virginia Strelen, gérant A
- Madame Barbara Neuerburg, gérant A
- Monsieur Adrian Brindley, gérant B
- Monsieur Maxime Giraud, gérant B
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015022079/18.
(150025150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Sheet Anchor Properties Lux Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.069.
EXTRAIT
La résolution suivante a été adoptée par l'Associé unique en date du 6 février 2015:
- La démission de Madame Caroline Vander Meersch en tant que gérant B de la Société est acceptée avec effet au 30
janvier 2015.
A partir du 6 février 2015, le conseil de gérance est composé comme suit:
- Madame Virginia Strelen, gérant A
- Madame Barbara Neuerburg, gérant A
- Monsieur Adrian Brindley, gérant B
- Monsieur Maxime Giraud, gérant B
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015022080/18.
(150025152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Knowles Luxembourg International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 107.725,00.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 54-56, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 160.769.
EXTRAIT
L'associé unique de la Société a accepté la démission de Monsieur Jeffrey S. Niew de son mandat de gérant de la Société
avec effet au 15 janvier 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Knowles Luxembourg International S.à r.l.
i>United International Management S.A.
Référence de publication: 2015021838/14.
(150024941) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
34806
L
U X E M B O U R G
Sea View Residence S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 129.366.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 2 février 2015, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société SEA VIEWi>
<i>RESIDENCE S.A.i>
- La démission de Mme Noeleen GOES-FARRELL de son mandat d'administrateur de la Société a été acceptée avec
effet au 31 janvier 2015.
- Monsieur Nicolas MILLE, employé privé, né le 8 février 1978 à Antony (France), résidant professionnellement au 127
rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, a été nommé administrateur de la Société avec effet au 31 janvier 2015. Son
mandat prendra fin le 29 novembre 2018.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SEA VIEW RESIDENCE S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015022101/18.
(150025738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Shessen Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 149.655.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale annuelle du 10 décembre 2014, tenue au siège de la sociétéi>
Le mandat de l'Administrateur unique, à savoir KRONOS MANAGEMENT S.A., ayant son siège social au 56 E, Urba-
nizacion Obarrio, Edif Enid, PA- Ciudad de Panama, Panama, enregistrée au Registro Publico de Panama sous le numéro
682850 est reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2020.
Le mandat du Commissaire aux Comptes, à savoir la Fiduciaire Jean-Marc Faber & Cie Sàrl, ayant son siège au 63-65
rue de Merl, L-2146 Luxembourg, est également reconduit jusqu'à l'Assemblée Générale Annuelle de 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SHESSEN HOLDING S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015022109/18.
(150025544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
TCS II Lu S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.074.
<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 19 décembre 2014i>
Au 19 décembre 2014, l'associé unique a pris la résolution suivante:
- Approuver la démission de Pedro Fernandes das Neves, né le 15 Octobre 1974 à Lisbonne, Portugal, ayant comme
adresse professionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 19
décembre 2014.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Julie K.Braun (gérant)
- Herve Marsot (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 19 décembre 2014.
Castlelake II, LP
Référence de publication: 2015022153/19.
(150025849) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
34807
L
U X E M B O U R G
Utilicom, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 193.509.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des résolutions prises par l'associé unique en date du 05 février 2015 que
L'associé unique a pris note de la démission de ses fonctions de gérant unique de Monsieur Anar Mahmudov, dirigeant
de sociétés, né le 29 janvier 1984 à Bakou (Azerbaïdjan), demeurant au 528, avenue H. Javid, AZ-1073 Bakou (Azerbaïdjan).
L'associé unique a décidé de nommer comme gérant unique Monsieur Philippe Dauvergne, dirigeant de société, né le
20 mai 1972 à Fontenay-aux Roses demeurant professionnellement au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 février 2015.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015022183/17.
(150025090) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Sogin, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 24.407.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 30 janvier 2015 que
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société SOGIN pour une durée indéterminée, en
application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015022117/17.
(150025626) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Sofidra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8308 Capellen, 34-36, Parc d'Activités Capellen.
R.C.S. Luxembourg B 73.723.
EXTRAIT
Le 13 janvier 2015 s'est tenue de manière ordinaire un conseil d'administration au siège social de la société durant
laquelle la résolution suivante a été prise:
Le Conseil décide de désigner ING Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social, 52 route d'Esch à L-2965
Luxembourg, en tant que dépositaire au sens de la loi du 28 Juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions au porteur
modifiant l'article 42 de la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales. ING Luxembourg S.A. en tant
qu'établissement de crédit remplit les conditions requises pour une telle désignation conformément aux dispositions du
nouvel article 42 de la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015022084/19.
(150025508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
34808
L
U X E M B O U R G
Do Way S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 28B, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 186.425.
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales en date du 30 janvier 2015 que Monsieur Wenjiang DU, propriétaire
de 6.250 parts sociales de la Société, les a cédées à Monsieur Wei Du.
Monsieur Wei DU qui détenait 6.250 parts sociales devient associé unique et dispose de la totalité des 12.500 parts
sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société.
Le même jour, l'associée unique a accepté la démission de Monsieur Wenjiang DU de son poste de gérant de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 février 2015.
<i>Pour la Société
i>Shaohui ZHANG
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015022491/18.
(150026474) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Delta AK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 8A, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 123.626.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance de tous:
Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015 que:
Le siège social a été transféré du: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la foire au 8A, boulevard de la foire L-1528
Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015022482/13.
(150027160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Derceto Management, Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-8009 Strassen, 165, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 166.265.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 10 février 2015.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015022483/12.
(150026880) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Dodo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 76.853.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 9 février 2015i>
La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.
Pour extrait sincère et conforme
DODO S.A.
Référence de publication: 2015022511/12.
(150027126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34809
L
U X E M B O U R G
Desalline S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 49.195.
EXTRAIT
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 4 février 2015 que
CF Corporate Services
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 165872
a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la Société DESALLINE S.A. pour une durée indéter-
minée, en application de l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015022505/17.
(150026799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Euro Equity Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1342 Luxembourg, 30, rue de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 150.398.
En date du 9 Février 2015, les Gérants de la société ont pris la décision suivante:
- Le siège social de la société Euro Equity Management S.à r.l. est transféré de son adresse actuelle au 30, rue de
Clausen; L-1342 Luxembourg avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un géranti>
Référence de publication: 2015022526/14.
(150027038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Euro Equity Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 150.398.
L'Assemblée générale extraordinaire des Associés tenue en date du 3 Février 2015, les Associés de la société ont pris
les décisions suivantes:
- Les démissions de Mme Charlotte LAHAIJE-HULTMAN et de M. Asa ALUND sont acceptées avec effet immédiat.
- M. Jimmy TONG SAM avec adresse professionnelle à L-7257 Walferdange; 2, Millewee est nommé nouveau gérant
de la société avec effet immédiat.
- M. Philippe CHAN avec adresse professionnelle à L-7257 Walferdange; 2, Millewee est nommé nouveau gérant de
la société avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015022525/17.
(150027038) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34810
L
U X E M B O U R G
Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 116.571.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 02 février 2015:i>
«Le Conseil d'Administration décide de nommer en qualité de dépositaire des actions au porteur de la société CASHEL
LIMITED S.A. la Fiduciaire Mevea Luxembourg Sàrl ayant son siège social au 45-47 route d'Arlon, L-1140 Luxembourg,
R.C.S. B 156455 inscrite à l'ordre des expert-comptables de Luxembourg».
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
ENGINEERING S.A.
Référence de publication: 2015022542/13.
(150026142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Eurozone Development S.A., Société Anonyme,
(anc. Eurozone Development S.à r.l.).
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 123.031.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Belvaux, le 10 février 2015.
Référence de publication: 2015022557/10.
(150026910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
Laurent Properties S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.
R.C.S. Luxembourg B 118.781.
<i>Extrait des résolutions adoptées en date du 2 février 2015, lors de l'assemblée générale extraordinaire de la société LAURENTi>
<i>PROPERTIES S.A.i>
- La démission de Mme Noeleen GOES-FARRELL de son mandat d'administrateur de la Société a été acceptée avec
effet au 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LAURENT PROPERTIES S.A.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021863/15.
(150025727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Hydra Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.010,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 180.805.
EXTRAIT
En date du 6 février 2015, l'associé unique de la Société a approuvé les résolutions suivantes:
- La démission de M. Erik Johan Cornelis Schoop, en tant que gérant B de la Société, est acceptée avec effet immédiat.
- Mme Thuy Uyen Nguyen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommée
gérante B de la société avec effet immédiat et Pour une durée indéterminée.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 9 février 2015.
Référence de publication: 2015021781/15.
(150025690) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
34811
L
U X E M B O U R G
Firewall Management Mip S.A., Société Anonyme,
(anc. Firewall Management Mip S.à r.l.).
Capital social: EUR 103.611,56.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 191.637.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth day of January.
Before us, Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Firewall Investments, S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, having a share capital of one million thirty one thousand euro (EUR 1,031,000.-), and registered
with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191622,
here represented by Mr. Fabio DE TOMMASI, lawyer professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, on 19 January 2015,
The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder, representing the entire share capital of Firewall Management MIP, S.à r.l.
(hereinafter the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and go-
verned by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528
Luxembourg, having a share capital of one million twelve thousand five hundred euro (EUR 1,012,500.-), registered with
the Luxembourg Company and Trade Register under number B 191637 incorporated pursuant to a deed of Maître
Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, on 6 November 2014. The articles of as-
sociation have last been amended on 18 December 2014 pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, not yet published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Change of the legal form of the Company in order to transform it from a société à responsabilité limitée into a
société anonyme;
2. Change of the name of the Company from Firewall Management MIP, S.à r.l. into Firewall Management MIP, S.A.;
3. Confirmation of the mandates of the current managers (gérants) of the Company as directors (administrateurs) of
the Company and modification of the duration of their mandate, further to the conversion of the Company into a société
anonyme and appointment of additional directors of the Company;
4. Appointment of an external auditor of the Company;
5. Creation of new categories of shares, being class A shares, class B1 redeemable shares, class B2 redeemable shares,
class B3 redeemable shares, class B4 redeemable shares, class B5 redeemable shares, class B6 redeemable shares, class
B7 redeemable shares, class B8 redeemable shares, class B9 redeemable shares and class B10 redeemable shares.
6. Split of each share into ten shares of the same class, decrease of the nominal value of the shares from one cent (EUR
0.01) to one tenth of a cent (EUR 0.001) and reduction of the share capital by an amount of nine hundred eight thousand
eight hundred eighty-eight euro and forty-four cents (EUR 908,888.44) to one hundred three thousand six hundred eleven
euro and fifty-six cents (EUR 103,611.56) through a cancellation of certain shares, whereby the existing shares (parts
sociales) shall be partially converted, partially redeemed and cancelled, all without payments to the shareholders. Allo-
cation of the amounts resulting from the foregoing cancellation of shares as well as all existing share premium pro rata
to each Premium Account of a share of a Class (i.e. without allocation to the Class A Shares).
7. Acknowledgement of the special report of the board of managers of the Company regarding the creation of an
authorized capital, creation of the authorized capital in an amount of two million two hundred thousand euro (EUR
2,200,000), represented by two billion (2.000.000.000) Class A Shares, two billion (2.000.000.000) Class B1 Shares, two
billion (2.000.000.000) Class B2 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B3 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B4
Shares, two billion (2.000.000.000) Class B5 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B6 Shares, two billion
(2.000.000.000) Class B7 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B8 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B9 Shares
and two billion (2.000.000.000) Class B10 Shares, and waiver of the decision that during the period of five years from the
publication of the resolutions of this general meeting, the board of directors is authorised to issue shares, to grant options
to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised capital
to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a
preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders in accordance with any shareholders’
agreement.
34812
L
U X E M B O U R G
8. Conversion of three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B1 redeemable shares, three
hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B2 redeemable shares, three hundred sixty-one thou-
sand one hundred fifty-six (361,156) class B3 redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-
six (361,156) class B4 redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B5
redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B6 redeemable shares, three
hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B7 redeemable shares, three hundred sixty-one thou-
sand one hundred fifty-six (361,156) class B8 redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-
six (361,156) class B9 redeemable shares three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B10
redeemable shares into non-voting shares.
9. Subscription and payment in relation to the issuance of the founder shares.
10. Full restatement of the articles of association of the Company;
11. Miscellaneous.
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to change with immediate effect the legal form of the Company from its original form
of a société à responsabilité limitée into the form of a société anonyme, in accordance with article 3 paragraph 5 of the
law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the “Law”) (the “Conversion”).
The Conversion is made on basis of a report in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the Law established by Ernst
& Young Luxembourg S.A., réviseur d’entreprises agrée, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under Section
B, number 88019, on the date hereof that has verified the value of the net assets of the Company and confirmed the
minimum value of the share capital of the Company to the notary.
The conclusion of the valuation report is the following:
“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention which causes us to believe
that the net asset value of the Company as at 13 January 2015, amounting to EUR 3,609,588, does not correspond at
least to the amount of the subscribed capital, being EUR 1,012,500, which is above the minimum capital required for the
incorporation of a société anonyme.”
This report will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
<i>Second Resolutioni>
The sole shareholder resolves to change the name of the Company from Firewall Management MIP, S.à r.l. into Firewall
Management MIP, S.A.
<i>Third Resolutioni>
The sole shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mrs. Catherine Koch and Mr. Geoffrey Henry, as
managers of the Company, with effect as from 15 February 2015 and decides to grant them discharge for the due per-
formance of their duties which discharge will have to be confirmed at the next annual general meeting approving the next
Company’s annual accounts.
The sole shareholder resolves to confirm the mandates of the following managers (gérants) of the Company as di-
rectors (administrateurs) starting with immediate effect and to modify the duration of their mandates as follows:
1. Michael Phillips, professionally residing at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
is appointed until the annual meeting of the Company taking place in the year 2020;
2. Geoffrey Henry, professionally residing at Boulevard de la Foire 1, L-1528, Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg is appointed until 15 February 2015;
3. Catherine Koch, professionally residing at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
is appointed until 15 February 2015.
The sole shareholder further appoints as directors (administrateurs) starting with immediate effect:
4. Mr. Dan Arendt, born on 15 May 1961, in Luxembourg, professionally residing at 42, op Fankenacker, L-3265
Bettembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed until the annual meeting of the Company taking place in the year
2020;
5. Mr. Hubert Jacobs van Merlen, born on 27 August 1953, in Buenos Aires, Argentina, professionally residing at 3,
rue Belair, L-5318 Contern, Grand Duchy of Luxembourg is appointed until the annual meeting of the Company taking
place in the year 2020;
6. Mr. Francois Pauly, born on 30 June 1964, in Luxembourg, professionally residing at 57, rue Jean Schoetter, L-2523
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg is appointed until the annual meeting of the Company taking place in the year
2020.
<i>Fourth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to set the number of external auditor(s) of the Company to one (1).
34813
L
U X E M B O U R G
The following entity is appointed as external auditor (réviseur d’entreprises agréé) with immediate effect and until the
annual general meeting of the shareholders of the Company convened to resolve upon the annual accounts of the Com-
pany for the financial year ending 31 December 2015:
Ernst & Young Luxembourg S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated and existing under
the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B88019, having
its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Fifth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to create new categories of shares, being class A shares, class B1 redeemable shares,
class B2 redeemable shares, class B3 redeemable shares, class B4 redeemable shares, class B5 redeemable shares, class
B6 redeemable shares, class B7 redeemable shares, class B8 redeemable shares, class B9 redeemable shares and class B10
redeemable shares.
<i>Sixth Resolutioni>
The sole shareholder resolves (i) to split each share into ten shares of the same class (ii) to decrease the nominal value
of the shares from one cent (EUR 0.01) to one tenth of a cent (EUR 0.001) and (iii) to reduce the share capital by an
amount of nine hundred eight thousand eight hundred eighty-eight euro and forty-four cents (EUR 908,888.44) to one
hundred three thousand six hundred eleven euro and fifty-six cents (EUR 103,611.56) through a cancellation of certain
shares, whereby the existing shares (parts sociales) are treated as follows:
(i) All 12,500,000 Ordinary Shares (parts sociales) are converted into new Class A Shares (actions);
(ii) eighty-seven million five hundred thousand (87,500,000) Class A Shares (parts sociales) are converted into new
Class A Shares (actions);
(iii) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class A Shares (parts sociales) are converted
into Class B1 Shares (actions);
(iv) twelve million one hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (12,138,844) Class A Shares (parts
sociales) are cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(v) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class B Shares (parts sociales) are converted
into Class B2 Shares (actions);
(vi) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class B Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(vii) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156)Class C Shares (parts sociales) are converted
into Class B3 Shares (actions);
(viii) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class C Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(ix) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class D Shares (parts sociales) are converted
into Class B4 Shares (actions);
(x) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class D Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(xi) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156)Class E Shares (parts sociales) are converted
into Class B5 Shares (actions);
(xii) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class E Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(xiii) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class F Shares (parts sociales) are converted
into Class B6 Shares (actions);
(xiv) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class F Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(xv) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class G Shares (parts sociales) are converted
into Class B7 Shares (actions);
(xvi) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class G Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(xvii) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class H Shares (parts sociales) are converted
into Class B8 Shares (actions);
(xviii) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class H Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
(xix) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156)Class I Shares (parts sociales) are converted
into Class B9 Shares (actions);
(xx) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class I Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder;
34814
L
U X E M B O U R G
(xxi) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) Class J Shares (parts sociales) are converted
into Class B10 Shares (actions);
(xxii) ninety-nine million six hundred thirty-eight thousand eight hundred forty-four (99,638,844) Class J Shares are
cancelled. No amount is paid to the shareholder.
The amounts resulting from the foregoing cancellation of shares are allocated pro rata to each Premium Account of
a share of a Class (i.e. without allocation to the Class A Shares).
The Shareholder expressly resolves that the existing premium of two million six hundred eleven thousand five hundred
seventy-one euro (EUR 2,611,571) shall be allocated pro rata to each Premium Account of a share of a Class (i.e. without
allocation to the Class A Shares).
<i>Seventh Resolutioni>
The general meeting acknowledges the special report of the board of managers in respect of the creation of the
authorised capital.
The sole shareholder resolves to create an authorised capital in an amount of two million two hundred thousand euro
(EUR 2,200,000), represented by two billion (2.000.000.000) Class A Shares, two billion (2.000.000.000) Class B1 Shares,
two billion (2.000.000.000) Class B2 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B3 Shares, two billion (2.000.000.000) Class
B4 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B5 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B6 Shares, two billion
(2.000.000.000) Class B7 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B8 Shares, two billion (2.000.000.000) Class B9 Shares
and two billion (2.000.000.000) Class B10 Shares, and waiver of the decision that during the period of five years from the
publication of the resolutions of this general meeting, the board of directors is authorised to issue shares, to grant options
to subscribe for shares and to issue any other instruments convertible into shares within the limit of the authorised capital
to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue without reserving a
preferential right to subscribe to the shares issued for the existing shareholders in accordance with any shareholders’
agreement.
<i>Eighth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to convert three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B1
redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B2 redeemable shares, three
hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B3 redeemable shares, three hundred sixty-one thou-
sand one hundred fifty-six (361,156) class B4 redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-
six (361,156) class B5 redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B6
redeemable shares, three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B7 redeemable shares, three
hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B8 redeemable shares, three hundred sixty-one thou-
sand one hundred fifty-six (361,156) class B9 redeemable shares and three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-
six (361,156) class B10 redeemable shares into non-voting shares.
<i>Subscriptioni>
The one hundred (100) founder shares issued have been subscribed as follows:
One hundred (100) founder shares have been subscribed by Firewall Investments, S.A., aforementioned for the price
of one euro (EUR 1).
The founder shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of one euro
(EUR 1) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
<i>Tenth Resolutioni>
The sole shareholder resolves to fully restate the articles of association of the Company, which shall now be read as
follows:
“Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Firewall Mana-
gement MIP S.A. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning
commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
34815
L
U X E M B O U R G
2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities
or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of directors.
4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share capital.
5.1 The Company’s share capital is set at one hundred three thousand six hundred eleven euro and fifty-six cents (EUR
103,611.56), represented by one hundred three million six hundred eleven thousand five hundred sixty (103,611,560)
shares having nominal value of one tenth of a cent (EUR 0.001) split as follows:
(a) one hundred million (100,000,000) A shares (the “A Shares”);
(b) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B1 redeemable shares (the “Class B1
Shares”);
(c) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B2 redeemable shares (the “Class B2
Shares”);
(d) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B3 redeemable shares (the “Class B3
Shares”);
(e) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B4 redeemable shares (the “Class B4
Shares”);
(f) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B5 redeemable shares (the “Class B5 Sha-
res”);
(g) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B6 redeemable shares (the “Class B6
Shares”);
(h) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B7 redeemable shares (the “Class B7
Shares”);
(i) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B8 redeemable shares (the “Class B8 Sha-
res”);
(j) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B9 redeemable shares (the “Class B9 Sha-
res”); and
(k) three hundred sixty-one thousand one hundred fifty-six (361,156) class B10 redeemable shares (the “Class B10
Shares”)(the Class B10 Shares together with Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares, Class B4 Shares, Class
B5 Shares, Class B6 Shares, Class B7 Shares, Class B8 Shares, Class B9 Shares, are collectively called the “Classes”).
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as s et out in article 6 hereof.
5.3 Subject to Article 7, any new shares shall be offered by preference to the existing shareholders within the same
Class and/or holders of the A Shares, as the case may be. In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered
to the shareholders in proportion to the number of shares held in each Class and/or the number of the A Shares held
by them in the Company’s share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such
preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch
of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting
34816
L
U X E M B O U R G
of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner
required for an amendment of these articles of association.
5.4 The Company shall establish separate equity contribution accounts for the A Shares and the Classes (the "Premium
Accounts"), on which any share premium paid on the respective class, as well as any assimilated premium resulting from
contributions to the Company without issuance of shares by holders of such class which were declared to be made to
such Premium Account shall be accounted for. Notwithstanding anything to the contrary herein, any distributions of such
amounts may only be made pro rata to the holders of the respective class.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
6.5 No Shares in a particular Class may be converted into shares of a different Class.
6.6 The shares of the Classes are redeemable shares in the sense of article 49-8 of the Law. Any redemption is subject
to the provisions of the Law and the following conditions:
- only fully paid up shares may be redeemed;
- the conditions set out in articles 6.7 to 6.12 of these articles of association are respected;
- the redemption can only be made by using sums available for distribution in accordance with Article 72-1 of the Law
or the proceeds of a new issue made for the purpose of such redemption;
- an amount equal to the nominal value, or, in the absence thereof, the par value, of all the shares redeemed must be
included in a reserve which cannot be distributed to the shareholders except in the event of a capital reduction of the
share capital; such reserve may only be used to increase the issued share capital by capitalisation of reserves (such reserve
is not required in case of a redemption using the proceeds of a new issue made with a view to carry out such redemption);
and
- the redemption is published in accordance with the Law.
6.7 The share capital of the Company may be reduced through the redemption and cancellation of one or more Classes,
in whole but not in part, consisting of the redemption and cancellation of all shares in issue in such Class.
6.8 A reduction of share capital through the redemption and cancellation of a Class may only be made within the
respective Class Periods (as defined below):
i. The period for the Class B1 Shares is the period starting on the date of the notarial deed of 29 January 2015 and
ending no later than on 31 December 2015 (the “Class B1 Period”).
ii. The period for the Class B2 Shares is the period starting on the day after the Class B2 Period and ending on no
later than 31 December 2016 (the “Class B2 Period”).
iii. The period for the Class B3 Shares is the period starting on the day after the Class B3 Period and ending no later
than on 31 December 2017 (the “Class B3 Period”).
iv. The period for the Class B4 Shares is the period starting on the day after the Class B4 Period and ending no later
than on 31 December 2018 (the “Class B4 Period”).
v. The period for the Class B5 Shares is the period starting on the day after the Class B5 Period and ending on no
later than 31 December 2019 (the “Class B5 Period”).
vi. The period for the Class B6 Shares is the period starting on the day after the Class B6 Period and ending on no
later than 31 December 2020 (the “Class B6 Period”).
vii. The period for the Class B7 Shares is the period starting on the day after the Class B7 Period and ending on no
later than 31 December 2021 (the “Class B7 Period”).
viii. The period for the Class B8 Shares is the period starting on the day after the Class B8 Period and ending no later
than on 31 December 2022 (the “Class B8 Period”).
ix. The period for the Class B9 Shares is the period starting on the day after the Class B9 Period and ending no later
than on 31 December 2023 (the “Class B9 Period”).
x. The period for the Class B10 Shares is the period starting on the day after the Class B10 Period and ending no later
than on 31 December 2024 (the “Class B10 Period”).
6.9 Where a Class has not been repurchased and cancelled within the relevant Class Period, the redemption and
cancellation of such Class(es) can be made during a new period (the “New Period”) which shall start on the date after
the last Class Period (or as the case may be, the date after the end of the immediately preceding New Period of another
class) and end no later than one year after the start date of such New Period. The first New Period shall start on the day
after the Class B10 Period and the Class(es) not repurchased and not cancelled in their respective Class Period shall
come in the order from class B1 to class B10 (to the extent not previously repurchased and cancelled).
34817
L
U X E M B O U R G
6.10 For the avoidance of doubt, in the event that a repurchase and cancellation of a Class shall take place prior to
the last day of its respective Class Period (or as the case may be, New Period), the following Class Period (or as the case
may be, New Period) shall start on the day after the repurchase and cancellation of such Class and shall continue to end
on the day such as initially defined in the Articles above.
6.11 Upon the repurchase and cancellation of the entire relevant class(es), the Cancellation Amount will become due
and payable by the Company to the Shareholder(s) pro-rata to their holding in such class(es). For the avoidance of doubt
the Company may discharge its payment obligation in cash, in kind or by way of set-off.
6.12 For the purposes of these Articles, the following capitalised terms shall have the following meanings:
“Available Amount” shall mean the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits)
increased by (i) any freely distributable reserves (taking into accont article 5.4 hereof) and (ii) as the case may be, by the
amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class to be cancelled but reduced by (i) any
losses (included carried forward losses) expressed as a positive, (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to
the requirements of Law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance
of doubt, any double counting), (iii) any dividends to which the holders of the A Shares and the Founder Shares are entitled
pursuant to the Articles and (iv) any Profit Entitlement so that:
AA = (NP + P+ CR) - (L + LR+OD+PE)
Whereby:
AA = Available Amount.
NP = net profits (including carried forward profits).
P = any freely distributable reserves.
CR = the amount of the capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Preference Shares to be
cancelled.
L = losses (including carried forward losses) expressed as a positive.
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of Law or of the Articles.
OD = any dividends to which the holders of the A Shares and the Founder Shares are entitled pursuant to the Articles.
PE = Profit Entitlement.
The Available Amount must be set out in the Interim Accounts of the respective Class Period and shall be assessed
by the board of directors in good faith and with the view to the Company’s ability to continue as a going concern.
“Available Liquidities” shall mean (i) all the cash held by the Company (except for cash on term deposits with a remaining
maturity exceeding six (6) months), (ii) any readily marketable money market instruments, bonds and notes and any
receivable which in the opinion of the board of directors will be paid to the Company in the short term less any indeb-
tedness or other debt of the Company payable in less than six (6) months determined on the basis of the Interim Accounts
relating to the relevant Class Period (or New Period, as the case may be) and (iii) any assets such as shares, stock or
securities of other kind held by the Company.
“Cancellation Amount” shall mean an amount not exceeding the Available Amount relating to the relevant Class Period
(or New Period, as the case may be) provided that such Cancellation Amount cannot be higher than the Available
Liquidities relating to the relevant Class Period (or New Period). The Cancellation Amount shall be determined by the
board of directors in the best corporate interest of the Company. For the avoidance of doubt, the holders of the Founder
Shares shall only be entitled to the amounts in accordance with these articles, in particular described in section 28.7 and
30.2. The board of directors can choose at its sole discretion to include or exclude in its determination of the Cancellation
Amount the freely distributable reserves either in part or in totality (always subject to taking into accont article 5.4
hereof).
“Class Period” shall mean each of the Class B1 Period, the Class B2 Period, the Class B3 Period, the Class B4 Period,
the Class B5 Period, the Class B6 Period, the Class B7 Period, the Class B8 Period, the Class B9 Period and the Class B
10 Period.
“Interim Accounts” shall mean the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date.
“Interim Account Date” shall mean the date no earlier than thirty (30) days but not later than ten (10) days before
the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class.
- “Profit Entitlement” shall mean the fixed preferred dividend amounts payable to the holders of Classes in accordance
with article 28.6 hereof.
Art. 7. Authorised capital.
7.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at two million two hundred thousand euro (EUR 2,200,000)
represented by twenty-two billion (22,000,000,000) shares having nominal value of one tenth of a cent (EUR 0.001)
(excluding the issued share capital), consisting of:
(a) two billion (2.000.000.000) the A Shares;
(b) two billion (2.000.000.000) Class B1 Shares;
(c) two billion (2.000.000.000) Class B2 Shares;
34818
L
U X E M B O U R G
(d) two billion (2.000.000.000) Class B3 Shares;
(e) two billion (2.000.000.000) Class B4 Shares;
(f) two billion (2.000.000.000) Class B5 Shares;
(g) two billion (2.000.000.000) Class B6 Shares;
(h) two billion (2.000.000.000) Class B7 Shares;
(i) two billion (2.000.000.000) Class B8 Shares;
(j) two billion (2.000.000.000) Class B9 Shares; and
(k) two billion (2.000.000.000) Class B10 Shares.
During a period of time of five (5) years from the date of the publication of these articles of association or, as the case
may be, of the resolution to renew or to increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors
is hereby authorised to issue shares, to grant options to subscribe for shares and to issue any other instruments con-
vertible into shares within the limits of the authorised capital to such persons and on such terms as they shall see fit and
specifically to proceed to such issue without reserving a preferential right to subscribe to the shares issued for the existing
shareholders in accordance with any shareholders agreement. Such authorisation may be renewed through a resolution
of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of asso-
ciation, each time for a period not exceeding five (5) years.
7.2 The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of
shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.
Art. 8. Founder shares.
8.1 The Company has issued one hundred (100) founder shares (parts bénéficiaires), each having a nominal value of
one cent (EUR 0.01) which do not represent the share capital of the Company and which do not confer any rights to the
holders thereof save for the ones set out in these Articles in particular in article 8, 13, 14 and 15 as well as in sect ion
11.4, 20.4, 28.7 and 30.2 (the “Founder Shares”).
8.2 The Founder Shares are issued in registered form. The number of Founder Shares issued shall be registered in a
register of Founder Shares held at the registered office of the Company, which will show the name and residence of the
holders of Founder Shares as well as the number of Founder Shares held by them. Ownership of Founder Shares is
established by registration in said register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense
of the relevant holder with such certificates, however, not serving as evidence of ownership. Any such certificate of
Founder Shares shall be signed by any director of the Company.
8.3 All notices and announcements to holders of Founder Shares shall be sent to the address detailed in the above
mentioned register. In the event that a holder of a Founder Share does not provide an address, the Company may permit
a note to this effect to be entered in the register and the holder of the Founder Share’s address will be deemed to be at
the registered office of the Company or at such other address as may be so inscribed in the register by the Company
from time to time, until another address shall be provided to the Company by the holder of the Founder Share.
8.4 Holders of Founder Shares shall be entitled to participate in any general meeting of shareholders and be convened
in the same manner as shareholders. Notwithstanding anything to the contrary herein, Founder Shares are required to
be present for any quorum of any general meetings of shareholders. The Founder Shares shall (i) carry the equal number
of votes, as all the shares entitled to vote in the Company from time to time for every proposed resolution of the Company
taken in any ordinary or extraordinary general meeting of shareholders of the Company (ii) for any resolutions of sha-
reholders in connection with matters referred to in article 44 of the Law, the Founder Shares shall carry a number of
votes which, together with the number of votes to which the B Shares are entitled, correspond to 50% of the voting
rights, which can be exercised for such resolution, it being understood that the Founder Shares shall at any time and
notwithstanding anything to the contrary herein shall carry at least 34% of the votes available for any proposed share-
holders’ resolution.
8.5 Articles 12.3, 12.4, 12.5 apply mutatis mutandis:
Art. 9. Register of shares - Transfer of shares.
9.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established
by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of
the relevant shareholder.
9.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
9.3 Subject to the transfer rules (i.e. mandatory transfer, tag-along rights and tag-along rights) in any shareholders
agreement, the shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.
9.4 Any transfer of registered shares shall become effective (opposable) towards the Company and third parties either
(i) through a declaration of transfer recorded in the register of shares, signed and dated by the transferor and the
34819
L
U X E M B O U R G
transferee or their representatives, or (ii) upon notification of a transfer to, or upon the acceptance of the transfer by
the Company.
C. General meetings of shareholders
Art. 10. Powers of the general meeting of shareholders.
10.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted
general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The
general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of
association.
10.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the “general meeting of shareholders”
shall be construed as a reference to the “sole shareholder”, depending on the context and as applicable and powers
conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.
Art. 11. Convening of general meetings of shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or,
as the case may be, by the internal auditor(s).
11.2 It must be convened by the board of directors or the internal auditor(s) upon written request of one or several
shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting
of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.
11.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of
the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of ten (10) days, and
ten (10) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper.
Notices by mail shall be sent ten (10) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this
formality has been complied with need be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may
be made by registered letter only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days
before the date scheduled for the meeting.
11.4 If all of the shareholders and holders of Founder Shares are present or represented at a general meeting of
shareholders and have waived any convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 12. Conduct of general meetings of shareholders.
12.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company
or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 15
th
of April at
10 AM. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other
meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.
12.2 A board of the meeting shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a
secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the
meeting shall especially ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance
with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.
12.3 An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.
12.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing
or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even
all shareholders.
12.5 Each shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile
or any other means of communication to the Company’s registered office or to the address specified in the convening
notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and
time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal
three boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate
box.
12.6 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the
proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into
account voting forms received prior to the general meeting to which they relate.
Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each of the A Shares entitles to one (1) vote per share in general meetings of shareholders.
13.2 The Classes are non-voting shares subject to article 8.4 and in accordance with article 44 of the Law.
13.3 For the avoidance of doubt, the Founder Shares entitle their holders to the rights and carry the number of votes
as listed in article 8.4 in general meetings of shareholders.
13.4 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of
shareholders duly convened shall not require any presence quorum (except for the presence of the holders of Founder
34820
L
U X E M B O U R G
Shares), and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented.
Abstentions and nil votes shall not be taken into account.
Art. 14. Amendments of the articles of association. Except as otherwise provided herein, these articles of association
may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of
more than half of the Company’s share capital and the Founder Shares are present or represented. If no quorum is reached
in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may
deliberate regardless of the quorum (except that the presence of the holders of the Founder Shares is required) and at
which resolutions are taken at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall
not be taken into account.
Art. 15. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent
(including the consent of the holders of Founder Shares).
Art. 16. Adjournment of general meeting of shareholders. Subject to the provisions of the Law, the board of directors
may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request
of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an
adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.
Art. 17. Minutes of general meetings of shareholders.
17.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by
the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
17.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any
third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case
the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any
two of its members.
D. Management
Art. 18. Composition and powers of the board of directors.
18.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) and up to six (6) members.
However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders’
meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a
sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such
case, to the extent applicable and where the term “sole director” is not expressly mentioned in these articles of asso-
ciation, a reference to the “board of directors” used in these articles of association is to be construed as a reference to
the “sole director”.
18.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfill the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by
the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
18.3 The Company grants a power of attorney to EPIC I GP S.à r.l., a private limited liability company (société à
responsabilité limitée), incorporated and exiting under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
address at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with Luxembourg
Company and Trade Register under number B186222 (the “Proxyholder”), acting individually and with full power of
substitution, to act on behalf of and represent the Company at any shareholders or interest holders’ meeting or resolution
in writing of any company, corporation, partnership or any other entity and/or any subsidiary thereof in which the Com-
pany holds directly or indirectly shares, interests or any other participation in respect of (and only in this respect) (i) the
appointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing, governing and/or supervisory body
for which the Company is entitled to vote, and (ii) the amendment of the articles, partnership agreement or bylaws, as
the case may be, with respect to the appointment or dismissal of directors, managers or other members of any managing,
governing and/or supervisory body for which the Company is entitled to vote.
Art. 19. Daily management.
19.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily
management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other
agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the
board of directors.
19.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.
Art. 20. Appointment, removal and term of office of directors.
20.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration
and term of office.
20.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years. Directors may be re-appointed for successive terms.
20.3 Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.
34821
L
U X E M B O U R G
20.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders
at a simple majority of the votes validly cast, taking into account the voting rights of the Founder Shares set out in these
articles.
20.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as
permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal
entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only
be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the
same time.
Art. 21. Vacancy in the office of a director.
21.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the per-
manent appointment in compliance with the applicable legal provisions and article 20.3.
21.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole director, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders in compliance with article 20.3.
Art. 22. Convening meetings of the board of directors.
22.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors
shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
22.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.
22.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented
at a board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed
by all members of the board of directors.
Art. 23. Conduct of meetings of the board of directors.
23.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not
need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.
23.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may
appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.
23.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in
writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.
23.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means
of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing
an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person
at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
23.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or
represented at a meeting of the board of directors.
23.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. The chairman
shall not have a casting vote.
23.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction
submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company’s interest, must inform the board
of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The
relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict
of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on
any other item.
23.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director
having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.
23.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director
relates to current operations entered into under normal conditions.
23.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
34822
L
U X E M B O U R G
23.11 The majority of the meetings of the board of directors shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg at the
registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of
such meeting.
Art. 24. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.
24.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the
chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial
proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.
24.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or
excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.
Art. 25. Dealing with third parties.
25.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director,
or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the signature of any
person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.
25.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of
any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits
of such delegation.
E. Audit and supervision
Art. 26. Auditor(s).
26.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The
general meeting of shareholders shall appoint the internal auditor(s) and shall determine their term of office, which may
not exceed six (6) years.
26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
26.3 The internal auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the
Company.
26.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur
(s) d’entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies
register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is
suppressed.
26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 27. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 28. Annual accounts and allocation of profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of
the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
28.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.
28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees to such allocation.
28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
28.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
28.6 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid in the following order:
First to:
i. the holder(s) of the Class B1 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.10% (zero point ten percent) of the
nominal value of the Class B1 Shares (rounded, if necessary);
ii. the holder(s) of the Class B2 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.15% (zero point fifteen percent) of the
nominal value of the Class B2 Shares (rounded, if necessary);
iii. the holder(s) of the Class B3 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.20% (zero point twenty percent) of
the nominal value of the Class B3 Shares (rounded, if necessary);
34823
L
U X E M B O U R G
iv. the holder(s) of the Class B4 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.25% (zero point twenty-five percent)
of the nominal value of the Class B4 Shares (rounded, if necessary);
v. the holder(s) of the Class B5 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.30% (zero point thirty percent) of the
nominal value of the Class B5 Shares (rounded, if necessary);
vi. the holder(s) of the Class B6 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.35% (zero point thirty-five percent)
of the nominal value of the Class B6 Shares (rounded, if necessary);
vii. the holder(s) of the Class B7 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.40% (zero point forty percent) of the
nominal value of the Class B7 Shares (rounded, if necessary);
viii. the holder(s) of the Class B8 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.45% (zero point forty-five percent)
of the nominal value of the Class B8 Shares (rounded, if necessary);
ix. the holder(s) of the Class B9 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.50% (zero point fifty percent)of the
nominal value of the Class B9 Shares (rounded, if necessary);
x. the holder(s) of the Class B10 Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.55% (zero point fifty-five percent)of
the nominal value of the Class B10 Shares (rounded, if necessary);
Second to:
xi. the holder(s) of the A Shares shall be entitled to a dividend equal to 0.05% (zero point zero five percent) of the
nominal value of the A Shares (rounded, if necessary)
Third to:
the balance (less any amounts paid to the holders of Founder Shares) shall be allocated to the holder(s) of the relevant
Class the Class Period of which is currently running.
28.7 In case of distribution, the holders of Founder Shares shall be entitled pro rata to zero point zero one per cent
(0.01 %) of the Company’s annual net profits it being provided that such distribution shall be capped at ten (10) times of
the aggregate nominal value of the Founder Shares.
Art. 29. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
29.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law
and these articles of association.
29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation.
30.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
30.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders as follows:
i. first each holder of the Classes shall receive an amount corresponding to the contribution (apport) of the Classes;
ii. second the holders of the A Shares and the holder of the Founder Shares shall receive an amount corresponding
to the nominal value of the A Shares and the nominal value of the Founder Shares respectively;
iii. out of the remaining surplus, the holders of A Shares shall receive an amount corresponding to the higher of 0.60%
of the nominal value of the A Shares (rounded, if necessary), or twenty-five thousand euro (EUR 25,000);
iv. the remainder shall be distributed to holders of the Classes in proportion to the number of shares of the Company
held by them. For the avoidance of doubt, the holders of the Founder Shares shall not be entitled to any distribution as
described in this article 30.2 (ii) and (iii).
H. Final clause - Governing law
Art. 31. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law and any agreement among shareholders. Inter partes any agreement among shareholders shall prevail to
the extent permitted by law.”
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500,-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
34824
L
U X E M B O U R G
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
Ist ERSCHIENEN:
Firewall Investments S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Grundkapital von einer Million einunddreißigtausend Euro (EUR 1.031.000,-) und eingetragen im
Gesellschafts- und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191622,
hier vertreten durch Mr. Fabio DE TOMMASI, Anwalt, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht
ausgestellt in Luxembourg, am 19. Januar 2015.
Diese Vollmacht, unterzeichnet mit ne varietur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Partei und den Notar,
verbleibt als Anhang bei dieser Urkunde um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
Die erschienene Partei ist der einzige Gesellschafter der Firewall Management MIP, S.à r.l., einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung (société à responsabilitée limitée) (nachfolgend die “Gesellschaft”) gegründet und bestehend nach
dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg mit
einem Stammkapital von einer Million zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 1.012.500,-) und eingetragen im Gesellschafts-
und Handelsregister von Luxemburg unter der Nummer B 191637, gegründet entsprechend einer Urkunde des Maître
Edouard Delosch, Notar mit Sitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, am 6. November 2014. Die Satzung der Ge-
sellschaft wurde zuletzt entsprechend einer notariellen Urkunde des Notars Maître Edouard Delosch am 18. Dezember
2014 geändert, was noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.
Die erschienene Partei, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, erklärt, unter Verzicht auf sämtliche
Benachrichtigungserfordernisse, die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengetreten, und kann wirk-
sam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:
<i>Tagesordnungi>
1. Umwandlung der Gesellschaft von einer société à responsabilitée limitée in eine société anonyme;
2. Namensänderung der Gesellschaft von Firewall Management MIP, S.à r.l. in Firewall Management MIP, S.A.;
3. Bestätigung der Mandate der derzeitigen Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft als Verwaltungsratsmitglieder
(administrateurs) der Gesellschaft und Anpassung der Dauer der Mandate, in Bezug auf die Umwandlung der Gesellschaft
in eine société anonyme und Bestellung von zusätzlichen Verwaltungsratsmitgliedern;
4. Bestellung eines externen Abschlussprüfers der Gesellschaft;
5. Schaffung neuer Kategorien von Aktien und zwar die Klasse A Aktien, Klasse B1 rücknehmbare Aktien, Klasse B2
rücknehmbare Aktien, Klasse B3 rücknehmbare Aktien, Klasse B4 rücknehmbare Aktien, Klasse B5 rücknehmbare Aktien,
Klasse B6 rücknehmbare Aktien, Klasse B7 rücknehmbare Aktien, Klasse B8 rücknehmbare Aktien, Klasse B9 rücknehm-
bare Aktien und Klasse B10 rücknehmbare Aktien;
6. Aktiensplit von jeder Aktie in zehn Aktien der gleichen Klasse, Herabsetzung des Nominalwerts der Aktien von
einem Cent (EUR 0,01) zu einem Zehntel eines Cents (EUR 0,001) und Herabsetzung des Grundkapitals durch einen
Betrag von neunhundertachttausendachthundertachtundachzig Euro und vierundvierzig Cent (EUR 908.888,44) auf ein-
hundertdreitausendsechshundertelf Euro und sechundfènfzig Cent (EUR 103.611,56) durch die Löschung von bestimmten
Aktien, wobei die bestehenden Anteile (parts sociales) teilweise umgewandelt und teilweise zurückgenommen und ge-
löscht werden sollen, alle aber ohne Zahlungen an die Gesellschafter. Zuweisung von den Beträgen, die aus vorangehender
Löschung von Aktien stammen, als auch jedes Agio pro rata zu jedem Einlagekonto einer Aktie einer Klasse (d.h. ohne
Zuweisung an die Klasse A Aktien);
7. Bestätigung des Spezialberichts des Geschäftsführerrates der Gesellschaft in Bezug auf die Schaffung von genehmigten
Kapital, Schaffung von genehmigten Kapital in Höhe von zwei Millionen zweihunderttausend Euro (EUR 2.200.000), dar-
gestellt durch zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse A Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B1 Aktien, zwei
Milliarden (2.000.000.000) Klasse B2 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B3 Aktien, zwei Milliarden
(2.000.000.000) Klasse B4 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B5 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse
B6 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B7 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B8 Aktien, zwei
Milliarden (2.000.000.000) Klasse B9 Aktien und zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B10 Aktien und Verzicht auf die
Entscheidung, dass während einer Periode von fünf Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung der Beschlüsse dieser
Generalversammlung, der Verwaltungsrat berechtigt ist Aktien auszugeben, Zeichnungsoptionen zu gewähren und jedes
andere in Aktien umwandelbare Instrument innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals an solche Personen und
34825
L
U X E M B O U R G
unter solchen Bedingungen auszugeben, die einer solchen Ausgabe entsprechen ohne dabei den bestehenden Aktionären
ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der auszugebenden Aktien einzuräumen und vorbehaltlich jeglicher Aktionärsvereinba-
rungen sind;
8. Umwandlung von dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B1 rücknehmbare
Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B2 rücknehmbare Aktien, dreihun-
derteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B3 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsech-
zigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B4 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendein-
hundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B5 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsech-
sundfünzig (361.156) Klasse B6 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig
(361.156) Klasse B7 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse
B8 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B9 rücknehmbare
Aktien in dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünzig (361.156) Klasse B10 rücknehmbare Aktien in nicht
stimmberechtigte Aktien.
9. Zeichnung und Einzahlung in Bezug auf die Ausgabe der Gründeraktien.
10. Vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft;
11. Verschiedenes.
<i>Erster Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt mit sofortiger Wirkung die Umwandlung der Gesellschaft von ihrer jetzigen Form
der société à responsabilitée limitée in eine société anonyme, im Einklang mit Artikel 3 Absatz 5 des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner derzeit gültigen Fassung (das „Gesetz von 1915“) (die „Umwandlung“).
Die Umwandlung wird auf Grundlage eines Berichts durchgeführt, der im Einklang mit Artikel 26-1 und 32-1 des
Gesetzes von 1915 am heutigen Tag erstellt worden ist, von Ernst & Young Luxembourg S.A., réviseur d’entreprises
agrée, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxembourg, eingetragen im
Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg in der Sektion B unter der Nummer 88019 und der den Wert des
Nettovermögens versichert und den Minimalbetrag des Gesellschaftskapitals bestätigt.
Das Ergebnis des Bewertungsberichts ist folgendes:
„Basierend auf der durchgeführten und oben beschriebenen Arbeit, hat nichts unsere Aufmerksamkeit erweckt, dass
uns daran zweifeln lassen würde, dass das Nettovermögen der Gesellschaft am 13. Januar 2015 mit einem Betrag von
EUR 3.609.588 nicht mindestens dem gezeichneten Kapital von EUR 1.012.500 entspricht, was über dem Mindestkapital
für die Gründung einer soceété anonyme liegt.“
Dieser Bericht wird als Anhang bei dieser Urkunde verbleiben um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde
eingereicht zu werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt den Namen der Gesellschaft von Firewall Management MIP, S.à r.l. in Firewall
Management MIP, S.A. zu ändern.
<i>Dritter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt das Rücktrittsgesuch von Frau Catherine Koch und Herrn Geoffrey Henry als
Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 15. Februar 2015 anzuerkennen und entscheidet ihnen die Entlastung
für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten zu erteilen, was auf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung, die
über die Jahresabschlüsse beschließt, bestätigt werden muss.
Der einzige Gesellschafter beschließt die Mandate der folgenden Geschäftsführer (gérants) der Gesellschaft mit so-
fortiger Wirkung als Verwaltungsratsmitglieder (administrateurs) zu bestätigen und die Dauer der Mandate wie folgt
anzupassen:
1. Michael Phillips, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, ist
bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 2020;
2. Geoffrey Henry, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg,
ist bestellt bis zum 15 Februar 2015;
3. Catherine Koch, geschäftsansässig in 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, ist
bestellt bis zum 15 Februar 2015;
Der einzige Gesellschafter bestellt darüber hinaus als Verwaltungsratsmitglieder (administrateurs) mit sofortiger Wir-
kung:
4. Herrn Dan Arendt, geschäftsansässig in 42, op Frankenacker, L-3265 Bettembourg, Großherzogtum Luxembourg,
ist bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahre 2020;
5. Herrn Hubert Jacobs van Merlen, geboren am 27. August 1953 in Buenos Aires, Argentinien, geschäftsansässig in 3,
rue Belair, L-5318 Contern, Großherzogtum Luxembourg, ist bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Ge-
sellschaft im Jahre 2020;
34826
L
U X E M B O U R G
6. Herrn Francois Pauly, geboren am 30. Juni 1964 in Luxembourg, geschäftsansässig in 57, rue Jean Schoetter, L-2523
Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, ist bestellt bis zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft im Jahre
2020.
<i>Vierter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt die Anzahl der externen Abschlussprüfer auf einen (1) festzulegen.
Die folgende Gesellschaft wird mit sofortiger Wirkung und bis zur Zusammenkunft der ordentlichen Hauptversamm-
lung der Aktionäre der Gesellschaft, wo über die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für das Finanzjahr endend am 31
Dezember 2015 entschieden wird, als externer Abschlussprüfer (réviseur d’entreprises agréé) bestellt:
Ernst & Young Luxembourg S.A., eine Aktiengesellschaft (société anonyme), gegründet und bestehend nach dem Recht
des Großherzogtums Luxembourg, eingetragen im Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter der Nummer
B88019, mit Gesellschaftssitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxembourg.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt neue Kategorien von Aktien, und zwar die Klasse A Aktien, Klasse B1 rück-
nehmbare Aktien, Klasse B2 rücknehmbare Aktien, Klasse B3 rücknehmbare Aktien, Klasse B4 rücknehmbare Aktien,
Klasse B5 rücknehmbare Aktien, Klasse B6 rücknehmbare Aktien, Klasse B7 rücknehmbare Aktien, Klasse B8 rücknehm-
bare Aktien, Klasse B9 rücknehmbare Aktien und Klasse B10 rücknehmbare Aktien zu schaffen.
<i>Sechster Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt (i) jede Aktie in zehn Aktien der gleichen Klasse zu teilen, (iii) den Nominalwert
der Aktien von einem Cent (EUR 0,01) auf ein Zehntel eines Cents (EUR 0,001) herabzusetzen und (ii) das Grundkapital
durch einen Betrag von neunhundertachttausendachthundertachtundachzig Euro und vierundvierzig Cent (EUR
908.888,44) auf einhundertdreitausendsechshundertelf Euro und sechsundfünfzig Cent (EUR 103.611,56) durch die Lö-
schung von bestimmten Aktien herabzusetzen, wobei die bestehenden Anteile (parts sociales) folgendermaßen behandelt
werden:
(i) Alle 12.500.000 Gewöhnlichen Anteile (parts sociales) werden umgewandelt in neue Klasse A Aktien (actions);
(ii) Achtundsiebzig Millionen fünfhunderttausend (87.500.000) Klasse A Anteile (parts sociales) werden umgewandelt
in neue Klasse A Aktien (actions);
(iii) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse A Anteile (parts sociales) werden
umgewandelt in Klasse B1 Aktien (actions);
(iv) zwölf Millionen einhundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (12.138.844) Klasse A Anteile (parts
sociales) werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(v) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse B Anteile (parts sociales) werden umgewan-
delt in Klasse B2 Aktien (actions);
(vi) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse B
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(vii) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse C Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B3 Aktien (actions);
(viii) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse C
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(ix) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse D Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B4 Aktien (actions);
(x) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse D
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xi) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse E Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B5 Aktien (actions);
(xii) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse E
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xiii) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse F Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B6 Aktien (actions);
(xiv) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse F
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xv) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse G Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B7 Aktien (actions);
(xvi) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse G
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xvii) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse H Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B8 Aktien (actions);
34827
L
U X E M B O U R G
(xviii) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse H
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xix) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse I Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B9 Aktien (actions);
(xx) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse I
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt;
(xxi) Dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechzig (361.156) Klasse J Anteile (parts sociales) werden umge-
wandelt in Klasse B10 Aktien (actions);
(xxii) neunundneunzig Millionen sechshundertachtunddreißigtausendachthundertvierundvierzig (99.638.844) Klasse J
Anteile werden gelöscht. Kein Betrag wird an die Gesellschafter ausgezahlt.
Die Beträge, die aus der vorangehenden Löschung von Aktien stammen, werden pro rata jedem Einlagekonto einer
Aktie einer Klasse zugewiesen (d.h. ohne Verteilung an die Klasse A Aktien.
Der Gesellschafter beschließt ausdrücklich, dass das bestehende Aufgeld von zwei Millionen sechshundertelftausend-
fünfhunderteinundsiebzig Euro (EUR 2.611.571) pro rata jedem Einlagekonto einer Aktie einer Klasse zugewiesen wird
(d.h. ohne Zuweisung an die Klasse A Aktien.
<i>Siebter Beschlussi>
Die Generalversammlung erkennt den Spezialbericht des Verwaltungsrats in Bezug auf die Schaffung des genehmigten
Kapitals an.
Der einzige Gesellschafter beschließt genehmigtes Kapital mit einem Betrag in Höhe von zwei Millionen zweihundert-
tausend Euro (EUR 2.200.000) zu schaffen, dargestellt durch zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse A Aktien, zwei
Milliarden (2.000.000.000) Klasse B1 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B2 Aktien, zwei Milliarden
(2.000.000.000) Klasse B3 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B4 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse
B5 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B6 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B7 Aktien, zwei
Milliarden (2.000.000.000) Klasse B8 Aktien, zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B9 Aktien und zwei Milliarden
(2.000.000.000) Klasse B10 Aktien und auf die Entscheidung zu verzichten, dass während einer Periode von fünf Jahren
ab dem Datum der Veröffentlichung der Beschlüsse dieser Generalversammlung, der Verwaltungsrat berechtigt ist Aktien
auszugeben, Zeichnungsoptionen zu gewähren und jedes andere in Aktien umwandelbare Instrument innerhalb der Gren-
zen des genehmigten Kapitals an solche Personen und unter solchen Bedingungen auszugeben, die einer solchen Ausgabe
entsprechen ohne dabei ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der auszugebenden Aktien für die bestehenden Aktionäre ein-
zuräumen.
<i>Achter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B1
rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B2 rücknehmbare
Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B3 rücknehmbare Aktien, dreihun-
derteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B4 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsech-
zigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B5 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendein-
hundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B6 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsech-
sundfünfzig (361.156) Klasse B7 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig
(361.156) Klasse B8 rücknehmbare Aktien, dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse
B9 rücknehmbare Aktien und dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B10 rück-
nehmbare Aktien.
<i>Zeichnungi>
Die einhundert (100) ausgegebenen Gründeraktien wurden wie folgt gezeichnet:
Einhundert (100) Gründeraktien wurden gezeichnet von Firewall Investments S.A., wie vorbenannt für den Preis von
einem Euro (EUR 1,-).
Die so gezeichneten Gründeraktien wurden vollständig durch Bareinlage eingezahlt, sodass der Betrag von einem Euro
(EUR 1,-) von nun an der Gesellschaft zur Verfügung steht, wie dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
<i>Zehnter Beschlussi>
Der einzige Gesellschafter beschließt die vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, die von nun ab wie
folgt lauten soll:
„Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Firewall Management
MIP, S.A. (nachfolgend die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handels-
gesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
34828
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher
Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur sowie
solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst
werden, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt
werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit der für eine Satzungsänderung er-
forderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt
werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-
zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Verwaltungsrat entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklun-
gen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an ihrem
Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser außerge-
wöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben keine
Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beträgt einhundertdreitausendsechshundertelf Euro und sechsundfünfzig Cent (EUR
103.611,56), bestehend aus einhundertdrei Millionen sechshundertelftausendfünfhundertsechzig (103.611.560) Aktien mit
einem Nominalwert von einem Zehntel Cent (EUR 0,001) und unterteilen sich wie folgt:
(a) einhundert Millionen (100.000.000) A Aktien (die „A Aktien“);
(b) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B1 rücknehmbare Aktien (die „Klas-
se B1 Aktien“);
(c) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B2 rücknehmbare Aktien (die „Klasse
B2 Aktien“);
(d) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B3 rücknehmbare Aktien (die „Klas-
se B3 Aktien“);
(e) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B4 rücknehmbare Aktien (die „Klas-
se B4 Aktien“);
(f) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B5 rücknehmbare Aktien (die „Klasse
B5 Aktien“);
(g) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B6 rücknehmbare Aktien (die „Klasse
B6 Aktien“);
(h) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B7 rücknehmbare Aktien (die „Klas-
se B7 Aktien“);
(i) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B8 rücknehmbare Aktien (die „Klasse
B8 Aktien“);
(j) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B9 rücknehmbare Aktien (die „Klasse
B9 Aktien“) und
34829
L
U X E M B O U R G
(k) dreihunderteinundsechzigtausendeinhundertsechsundfünfzig (361.156) Klasse B10 rücknehmbare Aktien (die „Klas-
se B10 Aktien“ (die Klasse B10 Aktien zusammen mit den Klasse B1 Aktien, Klasse B2 Aktien, Klasse B3 Aktien, Klasse
B4 Aktien, Klasse B5 Aktien, Klasse B6 Aktien, Klasse B7 Aktien, Klasse B8 Aktien und Klasse B9 Aktien, werden kollektiv
die „Klassen“ genannt).
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in und mit
der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, oder im Einklang mit Artikel 6 dieser
Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Vorbehaltlich Artikel 7, alle neuen Aktien, werden bevorzugt den bestehenden Aktionären innerhalb der jeweiligen
Klasse angeboten und/oder Inhabern von A Aktien, falls dies der Fall ist. Im Falle einer Mehrheit von Aktionären werden
diese Aktien den Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen in der jeweiligen Klasse gehaltenen Aktien und/oder
der Anzahl der A Aktien vom Gesellschaftskapital angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum in dem dieses
Vorzugsrecht ausgeübt werden kann und welcher nicht weniger als dreißig (30) Tage vom Datum der Absendung eines
an die Aktionäre gesendeten Einschreibens, welches die Eröffnung der Zeichnungsfrist ankündigt, beträgt. Die Hauptver-
sammlung der Aktionäre kann das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss, welcher in und mit
der für eine Satzungsänderung erforderlichen Form und Mehrheit gefasst wird, begrenzen oder aufheben.
5.4 Die Gesellschaft soll separate Einlagekonten für die A Aktien und die Klassen errichten (die „Einlagekonten“), in
welche jedes auf die jeweilige Klasse bezahlte Agio, als auch andere Kapitalreserven eingezahlt werden sollen, die aus
Gesellschaftseinlagen ohne Ausgabe von Aktien stammen, die von den Aktionären einer solchen Klasse gemacht worden
sind mit der vorherigen Bestimmung auf ein solches Einlagekonto eingezahlt zu werden. Unabhängig davon, sollen Aus-
zahlungen solcher Beträge nur pro rata an die Inhaber der betreffenden Klasse gemacht werden.
Art. 6. Aktien.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien mit dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.
6.5 Keine Aktie einer bestimmten Klasse soll in eine Aktie einer anderen Klasse umgewandelt werden.
6.6 Die Aktien der Klassen sind rücknehmbare Aktien in der Bedeutung von Artikel 49-9 des Gesetzes von 1915. Jede
Rücknahme unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und folgenden Bedingungen:
- nur vollständig bezahlte Aktien sollen zurückgenommen werden;
- die Bedingungen in Artikel 6.7 bis 7.12 dieser Satzung sind zu beachten;
- die Rücknahme kann nur durch Ausschüttungen getätigt werden, welche im Einklang mit Art. 72-1 des Gesetzes von
1915 ausgeschüttet worden sind oder durch Kapital, welches genau für diesen Zweck zur Verfügung gestellt worden ist;
- es soll ein Betrag, der dem Nominalwert oder im Falle eines Fehlens dem Nennwert aller zurückgenommen Aktien
entspricht in eine Reserve eingestellt werden, welche nicht an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann, außer im Falle
einer Kapitalherabsetzung des Gesellschaftsvermögens. Diese Reserve soll dazu verwendet werden das Gesellschafts-
vermögen durch Kapitalisierung der Reserven zu erhöhen (diese Reserve ist für den Fall einer Rücknahme nicht notwendig
sofern für die Rücknahme die Erträge aus einer neuen Angelegenheit stammen, welche zum Zwecke der Rücknahme
bereitgestellt worden sind);
- die Rücknahme wird im Einklang mit dem Gesetz von 1915 veröffentlicht.
6.7 Das Grundkapital der Gesellschaft kann nur durch vollständige Rücknahme und Löschung einer oder mehrerer
gesamten Klassen herabgesetzt werden, was durch Rücknahme und Löschung aller Aktien dieser Klasse geschieht.
6.8 Eine Kapitalherabsetzung durch Rücknahme und Löschung einer Klasse soll nur innerhalb der dafür vorgesehenen
jeweiligen Klassenperiode (wie unten definiert) erfolgen:
(i) Die Periode für die Klasse B1 Aktien ist der Zeitraum beginnend mit dem Tag dieser notariellen Urkunde vom 29.
Januar 2015 und endend nicht später als am 31 Dezember 2015 (die “Klasse B1 Periode").
(ii) Die Periode für die Klasse B2 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B1 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2016 (die “Klasse B2 Periode").
(iii) Die Periode für die Klasse B3 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B2 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2017 (die “Klasse B3 Periode").
(iv) Die Periode für die Klasse B4 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B3 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2018 (die “Klasse B4 Periode").
(v) Die Periode für die Klasse B5 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B4 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2019 (die “Klasse B5 Periode").
(vi) Die Periode für die Klasse B6 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B5 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2020 (die “Klasse B6 Periode").
34830
L
U X E M B O U R G
(vii) Die Periode für die Klasse B7 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B6 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2021 (die “Klasse B7 Periode").
(viii) Die Periode für die Klasse B8 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B7 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2022 (die “Klasse B8 Periode").
(ix) Die Periode für die Klasse B9 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B8 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2023 (die “Klasse B9 Periode").
(x) Die Periode für die Klasse B10 Aktien ist der Zeitraum beginnend nach der Klasse B9 Periode und endend nicht
später als am 31 Dezember 2024 (die “Klasse B10 Periode").
6.9 Wenn eine Klasse nicht innerhalb der jeweiligen Klassenperiode zurückgekauft und eingezogen wurde, kann der
Rückkauf und der Einzug einer solchen Klasse während einer neuen Periode (die „Neue Periode“) erfolgen, welche am
Tag nach der letzten Klassenperiode beginnt (oder falls dies der Fall ist, der Tag nach dem Ende der direkt vorangegan-
genen Neuen Periode einer anderen Klasse) und nicht später als ein Jahr nach dem Beginn dieser Neuen Periode endet.
Die erste Neue Periode soll am Tag nach der Klasse B10 Periode beginnen und die noch nicht zurückgekaufte(n) und
eigezogene(n) Klasse(n) richten sich nach der Reihenfolge von Klasse B1 bis Klasse B10 (bis zu dem Maße, dass sie noch
nicht zurückgekauft und eingezogen sind), sofern sie Teil der beginnenden Neuen Periode sind.
6.10 Um Zweifel auszuschießen, im Falle, dass ein Rückkauf und Einzug einer Klasse einen Tag vor dem letzten Tag
der jeweiligen Klassenperiode (oder falls dies der Fall ist, Neuen Periode) stattfindet, soll die sich anschließende Klas-
senperiode (oder falls dies der Fall ist, Neuen Periode) am Tag nach dem Rückkauf und Einzug der jeweiligen Klasse
beginnen und soll weiterhin am Tage enden, wie in den Artikeln zuvor bestimmt.
6.11 Der Einziehungsbetrag wird für die Gesellschaft fällig und zahlbar an die Gesellschafter pro rata zu ihrem Anteil
an der jeweiligen Klasse(n) nach Rückkauf und Einzug der gesamten jeweiligen Klasse(n). Um Zweifel auszuschließen
erlischt die Verbindlichkeit der Gesellschaft durch Aufrechnung, Bar- oder Sachzahlung.
6.12 Für den Zweck dieser Satzung, sollen die folgenden Begriffe folgende Bedeutung haben:
- „Verfügbarer Betrag“ meint den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich Gewinnvorträgen)
erhöht durch (i) jede frei ausschüttbare Rücklage (hiervon unter Beachtung von Artikel 5.4) und (ii) falls dies der Fall ist,
um den Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehende Klas-
se, aber herabgesetzt um (i) jegliche Verluste (einschließlich Verlustvorträgen) dargestellt als Pluswert, (ii) jegliche Beträge,
die gemäß der jeweiligen Zwischenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der Satzung in die Rücklage
eingestellt werden müssen (um Zweifel auszuschließen, ohne doppelte Buchführung), (iii) jegliche Ausschüttungen, die
den Inhaber(n) von A Aktien und Gründeraktien nach der Satzung zustehen und (iv) jegliche Gewinnbeteiligung, so dass
gilt:
AA = (NP + P + CR) - (L + LR + OD + PE)
Wobei gilt:
AA = Verfügbarer Betrag
NP = Nettogewinn (einschließlich Gewinnvorträgen)
P = jede frei ausschüttbare Rücklage
CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage hinsichtlich der einzuziehende
Klasse von Vorzugsaktien
L = Verluste (einschließlich Verlustvorträgen), dargestellt als Pluswert
LR = jegliche Beträge, die gemäß der jeweiligen Zwischenabschlüsse entsprechend dem Gesetz von 1915 oder der
Satzung in die Rücklage einzustellen sind
OD = jegliche Ausschüttungen, die den Inhaber(n) von A Aktien und Gründeraktien nach der Satzung zustehen
PE = jegliche Gewinnbeteiligung
Der Verfügbare Betrag muss in den Zwischenabschlüssen für die jeweilige Klassenperiode festgelegt werden und soll
vom Verwaltungsrat im guten Glauben und mit Blick auf die Unternehmensfortführung bewertet werden.
- „Verfügbare Liquide Mittel“ meinen (i) das gesamte Geld der Gesellschaft (mit Ausnahme von Geld in Termineinlagen
mit einer Restlaufzeit von mehr als sechs (6) Monaten), (ii) jegliche marktgängige Geldmarktinstrumente, Anleihen und
Schuldverschreibungen und jede Forderung, welche nach Ansicht des Verwaltungsrats innerhalb naher Zukunft an die
Gesellschaft gezahlt werden abzüglich jeglicher Verschuldung oder anderen Schulden der Gesellschaft, welche auf Grund-
lage des Zwischenabschlusses in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode (oder Neuen Periode, sofern vorhanden) innerhalb
von weniger als sechs (6) Monaten zu zahlen sind und (iii) alle Vermögenswerte wie Anteile, Aktien oder Wertpapiere
anderer Art, die von der Gesellschaft gehalten werden.
- „Einziehungsbetrag“ meint einen Wert, welcher den Verfügbaren Betrag in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode
(oder Neuen Periode, wenn dies der Fall ist) nicht übersteigt, vorausgesetzt, dass der Einziehungsbetrag nicht höher sein
kann als die Verfügbaren Liquiden Mittel in Bezug auf die jeweilige Klassenperiode (oder Neue Periode). Der Einzie-
hungsbetrag soll vom Verwaltungsrat im besten Interesse der Gesellschaft festgelegt werden. Um Zweifel auszuschließen,
sollen die Inhaber von Gründeraktien nur zu solchen Beträgen berechtigt werden, die Im Einklang mit dieser Satzung
stehen, genauer festgelegt in Sektion 28.7 und 30.2. Der Verwaltungsrat kann nach eigenem Ermessen entscheiden ob er
34831
L
U X E M B O U R G
bei der Festlegung des Einziehungsbetrags die frei verfügbaren Reserven vollständig oder teilweise einbezieht oder he-
rausnimmt (immer unter Einbeziehung von Artikel 5.4).
- “Klassenperiode” meint jeweils die Klasse B1 Periode, die Klasse B2 Periode, die Klasse B3 Periode, die Klasse B4
Periode, die Klasse B5 Periode, die Klasse B6 Periode, die Klasse B7 Periode, die Klasse B8 Periode, die Klasse B9 Periode
und die Klasse B10 Periode.
- “Zwischenabschluss” meint Zwischenanschlüsse der Gesellschaft am jeweiligen Zwischenabschlussdatum.
- „Zwischenabschlussdatum“ meint das Datum, welches nicht früher als dreißig (30) Tage, aber nicht später als zehn
(10) Tage vor dem Tag des Rückkaufs und Einziehung der jeweiligen Klasse liegt.
- „Gewinnbeteiligung“ meint die festen Beträge der Vorzugsdividenden, zahlbar an die Aktionäre der Klassen im Ein-
klang mit Artikel 28.6 von hier an.
Art. 7. Genehmigtes Kapital.
7.1 Das genehmigte Kapital, mit Ausnahme des Grundkapitals, beträgt zwei Millionen zweihunderttausend Euro (EUR
2.200.000), dargestellt durch zweiundzwanzig Milliarden (22.000.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von einem
Zehntel Cent (EUR 0,001) (exklusive des gezeichneten Grundkapitals) und besteht aus:
(a) zwei Milliarden (2.000.000.000) A Aktien,
(b) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B1 Aktien,
(c) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B2 Aktien,
(d) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B3 Aktien,
(e) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B4 Aktien,
(f) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B5 Aktien,
(g) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B6 Aktien,
(h) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B7 Aktien,
(i) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B8 Aktien,
(j) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B9 Aktien und
(k) zwei Milliarden (2.000.000.000) Klasse B10 Aktien.
Während einer Zeit von fünf (5) Jahren ab dem Tag der Veröffentlichung dieser Satzung oder, gegebenenfalls dem Tag
des Beschlusses zur Erneuerung oder Erhöhung des genehmigten Kapitals gemäß diesen Artikels, wird der Verwaltungsrat
hiermit ermächtigt, Aktien auszugeben, Zeichnungsoptionen für Aktien und jegliche andere in Aktien wandelbare Instru-
mente, an solche Personen und unter solchen Bedingungen, innerhalb der Grenzen des genehmigten Kapitals zu erteilen,
die einer solchen Ausgabe entsprechen ohne aber den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung für die
zu zeichnenden Aktien einzuräumen und vorbehaltlich jegliche Aktionärsvereinbarungen sind. Diese Ermächtigung kann
durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in der für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Form
und Mehrheit für jeweils einen Zeitraum von nicht mehr als fünf (5) Jahren verlängert werden.
7.2 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre in der
für eine Satzungsänderung vorgeschriebenen Form erhöht oder herabgesetzt werden.
Art. 8. Gründeraktien.
8.1 Die Gesellschaft hat einhundert (100) Gründeraktien ausgegeben (parts bénéficiaires), wovon jede einen Nomi-
nalwert von einem Cent (EUR 0,01) hat. Diese ergeben nicht das Gesellschaftsvermögen und geben dem Inhaber keine
weitergehende Rechte als die in dieser Satzung Festgelegten, speziell in Artikel 8, 13, 14 und 15, wie auch Sektion 11.4,
20.4, 28.7 und 30.2 (“Gründeraktien“).
8.2 Die Gründeraktien sind Namensaktien. Die Anzahl der ausgegebenen Gründeraktien werden in einem am Sitz der
Gesellschaft geführten Register eingetragen. Dieses soll auch die Namen und Adressen der Inhaber, sowie die Anzahl der
von ihnen gehaltenen Aktien umfassen. Das Eigentum an Gründeraktien entsteht durch Eintragung im besagten Register.
Auszüge der Eintragung sollen auf Antrag und Kosten des jeweiligen Inhabers eines solchen Auszugs herausgegeben
werden ohne aber als Beweis für das Eigentum zu dienen. Jeder Auszug von Gründeraktien bedarf der Unterschrift eines
Verwaltungsratsmitglieds der Gesellschaft.
8.3 Jegliche Mitteilungen und Bekanntmachungen gerichtet an die Inhaber von Gründeraktien werden an die im oben-
genannten Register eingetragene Adressen versandt. Im Falle dessen, dass der Inhaber einer Gründeraktie keine Adresse
angegeben hat, gilt der Sitz der Gesellschaft oder jede andere Adresse als die maßgebliche Adresse, wobei die Gesellschaft
diesen Umstand im Register eintragen lassen kann. Dies gilt solange wie der Gesellschaft gegenüber keine andere Adresse
von Seiten des Inhabers bekanntgemacht worden ist.
8.4 Inhaber von Gründeraktien haben das Recht zur Teilnahme an jeder Hauptversammlung der Aktionäre und sollen
auf dem gleichem Wege wie Aktionäre geladen werden. Ungeachtet davon, müssen Gründeraktien für jegliches Quorum
jeder Hauptversammlung anwesend sein. Die Gründeraktien tragen (i) dieselbe Anzahl von Stimmen wie alle von Zeit zu
Zeit in der Gesellschaft stimmberechtigten Aktien bei jedem von der Gesellschaft vorgeschlagenen Beschluss während
jeder ordentlichen oder außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft (ii) für jegliche Aktionärs-
beschlüsse in Bezug auf in Artikel 44 des Gesetzes von 1915 genannten Angelegenheiten, sollen die Gründeraktien eine
34832
L
U X E M B O U R G
Anzahl von Stimmen haben, welcher zusammen mit der Anzahl der Stimmen zu welcher die B Aktien berechtigen, 50%
der Stimmrechte entsprechen, die für solch einen Beschluss ausgeübt werden können, wobei darüber Einvernehmen
besteht, dass Gründeraktien zu jeder Zeit und ungeachtet von Gegenteiligem hierin mindestens 34% der verfügbaren
Stimmen für jeden vorgeschlagenen Aktionärsbeschluss tragen sollen.
8.5 Die Artikel 12.3, 12.4, 12.5 gelten entsprechend.
Art. 9. Aktienregister - Übertragung von Aktien.
9.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.
Dieses Aktienregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Ei-
gentum an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Aktionärs werden Zertifikate über die Eintragung ausgegeben.
9.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Aktie von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
9.3 Vorbehaltlich der Übertragungsbestimmungen (d.h. Pflichtübertragung, tag-along-Rechte und tag-along-Rechte)
sind die Aktien im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 frei übertragbar.
9.4 Jede Übertragung von Aktien wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten durch (i) Eintragung einer vom Zedenten
und vom Zessionar oder deren Vertretern datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister
oder (ii) Eintragung einer von der Gesellschaft datierten und unterschriebenen Übertragungserklärung im Aktienregister,
nachdem sie von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder dieser zugestimmt hat, wirksam.
C. Hauptversammlung der Aktionäre
Art. 10. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre.
10.1 Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig
einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Haupt-
versammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.
10.2 Hat die Gesellschaft nur einen Aktionär, so ist jeder Bezug auf die „Hauptversammlung der Aktionäre“ in der
vorliegenden Satzung je nach Zusammenhang und soweit anwendbar als Bezug auf den „alleinigen Aktionär“ zu verstehen
und alle Befugnisse der Hauptversammlung werden vom alleinigen Aktionär ausgeübt.
Art. 11. Einberufung der Hauptversammlung der Aktionäre.
11.1 Die Hauptversammlung der Aktionäre kann jederzeit durch den Verwaltungsrat oder, soweit vorhanden, durch
den/die Rechnungsprüfer einberufen werden.
11.2 Sie muss auf schriftliche Aufforderung von einem oder mehreren Aktionären, die zusammen mindestens 10 Pro-
zent (10%) des Gesellschaftskapitals halten, vom Verwaltungsrat oder vom Rechnungsprüfer/den Rechnungsprüfern
einberufen werden. In einem derartigen Fall muss die Hauptversammlung der Aktionäre innerhalb eines (1) Monats ab
Zugang des Ersuchens abgehalten werden.
11.3 Die Einberufung zu jeder Hauptversammlung der Aktionäre muss das Datum, die Uhrzeit, den Ort und die Ta-
gesordnung der Versammlung enthalten und zweimal in Form einer Einberufung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations und in einer Luxemburger Tageszeitung mit einem Zeitabstand von mindestens zehn (10) Tagen und zehn
(10) Tage vor dem für die Hauptversammlung anberaumten Datum erfolgen. Einberufungen per Post sind zehn (10) Tage
vor dem für die Versammlung anberaumten Datum an jeden Inhaber von Namensaktien zu versenden, wobei kein Beweis
der Einhaltung dieser Formvorschrift erbracht werden muss. Handelt es sich bei allen Aktien um Namensaktien, so kann
die Einberufung ausschließlich durch Einschreiben erfolgen, die mindestens acht (8) Tage vor dem für die Versammlung
anberaumten Datum an jeden Aktionär zu versenden sind.
11.4 Falls alle Aktionäre und die Inhaber von Gründeraktien in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und
auf Ladungsformalitäten verzichtet haben, kann die Hauptversammlung auch ohne vorherige Einladung oder Veröffentli-
chung abgehalten werden.
Art. 12. Durchführung der Hauptversammlung der Aktionäre.
12.1 Die Jahreshauptversammlung der Aktionäre wird in der Gemeinde, in der sich der Gesellschaftssitz befindet, oder
an einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort am 15. April um 10:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag ein gesetzlicher
Feiertag, so ist die Jahreshauptversammlung der Aktionäre am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Haupt-
versammlungen der Aktionäre können an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit
abgehalten werden.
12.2 In jeder Hauptversammlung der Aktionäre wird ein Rat der Versammlung bestimmt, der aus einem Vorsitzenden,
einem Schriftführer und einem Stimmzähler besteht, die weder Aktionäre, noch Mitglieder des Verwaltungsrats sein
müssen. Der Rat der Versammlung soll sicherstellen, dass die Versammlung gemäß den anwendbaren Regeln und vor
allem im Einklang mit den Regeln betreffend die Ladung, Mehrheitserfordernisse, Stimmauszählung und Vertretung von
Aktionären abgehalten wird.
34833
L
U X E M B O U R G
12.3 In jeder Hauptversammlung wird eine Anwesenheitsliste geführt.
12.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person durch
ein unterzeichnetes Dokument, das per Post, Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel übermittelt
wird, schriftlich bevollmächtigt. Eine Person kann mehrere oder sogar alle Aktionäre vertreten.
12.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme in einer Hauptversammlung der Aktionäre durch eine unterzeichnete Stimm-
karte abgeben, welche per Post, E-Mail, Fax oder durch jedes andere Kommunikationsmittel an den Sitz der Gesellschaft
oder an die in der Einberufung genannte Adresse gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten ver-
wenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden und zumindest den Ort, das Datum und die Uhrzeit der
Versammlung, die Tagesordnung, die Beschlussvorschläge sowie für jeden Vorschlag drei Kästchen enthalten, die es dem
Aktionären ermöglichen, seine Stimme für oder gegen den vorgeschlagenen Beschluss abzugeben oder sich zu enthalten,
indem er das entsprechende Kästchen ankreuzt.
12.6 Stimmkarten, die für einen vorgeschlagenen Beschluss nicht nur (i) eine Stimme für oder (ii) eine Stimme gegen
den vorgeschlagenen Beschluss oder (iii) eine Enthaltung beinhalten, sind in Bezug auf diesen Beschluss ungültig. Die
Gesellschaft wird nur Stimmkarten berücksichtigen, die sie vor der entsprechenden Hauptversammlung der Aktionäre
erhalten hat.
Art. 13. Quorum und Stimmrecht.
13.1 Jede von den A Aktien gewährt eine (1) Stimme pro Aktie in Hauptversammlungen der Aktionäre.
13.2 Die Klassen sind nicht stimmberechtigte Aktien vorbehaltlich Artikel 8.4 und im Sinne des Artikels 44 des Gesetzes
von 1915.
13.3 Um Zweifel auszuschließen, berechtigen Gründeraktien ihre Inhaber zu den in Artikel 8.4 festgelegten Rechten
und tragen die dort genannte Anzahl an Stimmen bei Hauptversammlungen der Aktionäre.
13.4 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in
einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums (mit
Ausnahme der Anwesenheit der Inhaber von Gründeraktien) mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen
gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden
bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 14. Änderungen der Satzung. Vorbehaltlich anderer Regelungen in dieser Satzung erfordert die Änderung der
Satzung einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3)
der abgegebenen gültigen Stimmen, in der mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals und die Gründeraktien anwe-
send oder vertreten ist. Falls die zweite Bedingung nicht erfüllt ist, kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes
von 1915 und dieser Satzung eine zweite Hauptversammlung der Aktionäre einberufen werden, die unabhängig von einem
Anwesenheitsquorum (mit Ausnahme, dass die Anwesenheit der Inhaber der Gründeraktien notwendig ist) beschlussfähig
ist und in welcher Beschlüsse mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln (2/3) der abgegebenen gültigen Stimmen
gefasst werden. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig (ein-
schließlich der Zustimmung der Inhaber der Gründeraktien) ändern.
Art. 16. Vertagung von Hauptversammlungen der Aktionäre. Vorbehaltlich der Bestimmungen des Gesetzes von 1915
kann der Verwaltungsrat jede Hauptversammlung der Aktionäre um vier (4) Wochen vertagen. Der Verwaltungsrat muss
eine Hauptversammlung der Aktionäre vertagen, wenn dies von einem oder mehreren Aktionären, die mindestens zwan-
zig Prozent (20%) des Gesellschaftskapitals halten, gefordert wird. Durch derartige Vertagung wird jeder bereits gefasste
Beschluss in dieser Versammlung annulliert.
Art. 17. Protokoll von Hauptversammlungen der Aktionäre.
17.1 Der Rat der Versammlung nimmt ein Protokoll jeder Versammlung auf, welches vom Rat der Versammlung sowie
von jedem Aktionär, der darum ersucht, unterzeichnet wird.
17.2 Kopien und Auszüge dieser Protokolle, die in Gerichtsverfahren verwendet oder Dritten zugänglich gemacht
werden sollen, müssen, wenn die Versammlung in einer notariellen Urkunde aufgenommen wurde, von dem Notar, der
die Originalurkunde verwahrt, beglaubigt werden, oder ansonsten vom Verwaltungsratsvorsitzenden oder von zwei be-
liebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden.
D. Geschäftsführung
Art. 18. Zusammensetzung und Befugnisse des Verwaltungsrates.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet, der sich aus mindestens drei (3) und bis zu sechs (6)
Mitgliedern zusammensetzt. Sollte die Gesellschaft durch einen einzigen Aktionären gegründet worden sein oder wird in
einer Hauptversammlung der Aktionäre festgestellt, dass die Gesellschaft nur einen einzigen Aktionären hat, so kann die
Gesellschaft bis zu der Hauptversammlung der Aktionäre durch ein einziges Verwaltungsratsmitglied geleitet werden, die
auf die Feststellung folgt, dass es wieder mehr als einen Aktionär gibt. In einem solchen Fall, soweit anwendbar und wo
der Begriff „einziges Verwaltungsratsmitglied“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf
den „Verwaltungsrat“ als Verweis auf das „einzige Verwaltungsratsmitglied“ auszulegen.
34834
L
U X E M B O U R G
18.2 Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle
Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der
durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.
18.3 Die Gesellschaft bevollmächtigt die EPIC I GP S.à r.l., eine GmbH (société à responsabilité limitée) mit Sitz am
Boulevard de la Foire 1, L-1528 Großherzogtum Luxembourg eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B186222
(die „Bevollmächtigte“) die Gesellschaft selbst in ihrem Namen bei jeder Aktionärs- oder Interessenversammlung oder
schriftlichen Beschlüssen von Unternehmen, Gesellschaften oder anderen juristischen Personen an denen die Gesellschaft
Aktien, Aktien oder andere Interessen hält nur in Bezug auf (i) die Bestellung und Abberufung von Verwaltungsratsmit-
gliedern, Geschäftsführern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden oder überwachenden Organen an
deren Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat und (ii) Änderungen von diesen Satzungen, von Gesellschaftsver-
trägen oder Geschäftsordnungen, welche die Bestellung oder Abberufung von Verwaltungsratsmitgliedern, Geschäfts-
führern oder anderen Mitgliedern von führenden, beherrschenden oder überwachenden Organen betreffen und an deren
Entscheidung die Gesellschaft mitzuwirken hat, zu vertreten.
Art. 19. Tägliche Geschäftsführung.
19.1 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung
der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, leitenden Angestellten oder anderen Personen, mit
gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse wer-
den durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.
19.2 Die Gesellschaft kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
Art. 20. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
20.1 Verwaltungsratsmitglieder werden durch die Hauptversammlung der Aktionäre ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
20.2 Die Amtszeit eines Verwaltungsratsmitglieds darf sechs (6) Jahre nicht überschreiten. Jedes Verwaltungsratsmit-
glied kann wiederernannt werden.
20.3 Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen in einer Hauptversamm-
lung ernannt.
20.4 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund mit einfacher Mehrheit der in einer Hauptver-
sammlung der Aktionäre abgegebenen Stimmen abberufen werden, unter Beachtung der Wahlrechte der Gründeraktien,
wie in diesem Artikel bestimmt.
20.5 Wird eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied ernannt, so muss diese eine rechtsfähige Person als ihren
ständigen Vertreter benennen, die ihr Mandat in ihrem Namen und für ihre Rechnung ausübt. Die betreffende juristische
Person kann nur dann ihren ständigen Vertreter abberufen, wenn sie gleichzeitig einen Nachfolger ernennt. Eine natürliche
Person kann nur ständiger Vertreter eines (1) Verwaltungsratsmitglieds und nicht gleichzeitig persönlich Verwaltungs-
ratsmitglied sein.
Art. 21. Vakanz des Amtes eines Verwaltungsratsmitglieds.
21.1 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen
Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Verwaltungsratsmitglieder bis zur nächsten
Hauptversammlung der Aktionäre vorübergehend für einen die ursprüngliche Amtszeit des zu ersetzenden Verwaltungs-
ratsmitglieds nicht übersteigenden Zeitraum bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre ausgefüllt werden, welche
im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften und Artikel 20.3 über die endgültige Neubesetzung entschei-
det.
21.2 Für den Fall, dass das einzige Verwaltungsratsmitglied aus seinem Amt scheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit Artik el 20.3 neu besetzt werden.
Art. 22. Einladung zu Verwaltungsratssitzungen.
22.1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einberufung des Vorsitzenden oder eines beliebigen Verwaltungsrats-
mitglieds. Die Verwaltungsratssitzungen finden, soweit in der Einladung nicht anders bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft
statt.
22.2 Die Verwaltungsratsmitglieder werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anbe-
raumten Datum zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, wenn alle Verwaltungs-
ratsmitglieder schriftlich, per Fax, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung
abgegeben haben, wobei eine Kopie einer solchen unterzeichneten Zustimmung ein hinreichender Nachweis ist. Eine
Einladung zu Sitzungen des Verwaltungsrats ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Verwaltungsrats bestimmt worden sind, welcher allen Verwaltungsratsmitgliedern übermittelt wurde.
22.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Verwaltungsratsmitglieder anwesend oder vertreten sind und diese
alle Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des
Verwaltungsrats diesen zugestimmt und sie unterzeichnet haben.
34835
L
U X E M B O U R G
Art. 23. Durchführung von Verwaltungsratssitzungen.
23.1 Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen
Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise Mitglied des Verwaltungsrats sein muss und der für die Protokoll-
führung der Verwaltungsratssitzungen verantwortlich ist.
23.2 Verwaltungsratssitzungen werden durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats geleitet. In dessen Abwesenheit
kann der Verwaltungsrat ein anderes Mitglied des Verwaltungsrats durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder
vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.
23.3 Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann an einer Verwaltungsratssitzung teilnehmen, indem es ein anderes Mitglied
des Verwaltungsrats schriftlich, per Fax, E-Mail oder ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigt,
wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Mitglied des Verwaltungsrats kann ein oder
mehrere, aber nicht alle anderen Verwaltungsratsmitglieder vertreten.
23.4 Eine Verwaltungsratssitzung kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein anderes Kom-
munikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu hören und
tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel ist gleich-
bedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung wird als am Sitz der Gesellschaft
abgehalten erachtet.
23.5 Der Verwaltungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner Mit-
glieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
23.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Verwaltungsratssitzung teilnehmenden
oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats hat im Falle von Stimmgleich-
heit keine entscheidende Stimme.
23.7 Soweit nicht gesetzlich anders bestimmt muss jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einem Geschäft, das dem
Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft
entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenskonflikt informieren; die Erklärung wird im Protokoll der
betreffenden Sitzung aufgenommen. Das betreffende Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über das in
Frage stehende Geschäft teilnehmen, noch darüber abstimmen. Die nächste Hauptversammlung der Aktionäre muss von
derartigen Interessenkonflikten informiert werden, bevor Beschlüsse zu anderen Tagesordnungspunkten gefasst werden.
23.8 Hat die Gesellschaft nur ein einziges Verwaltungsratsmitglied, so werden Geschäfte zwischen der Gesellschaft
und dem Verwaltungsratsmitglied, welches daran ein der Gesellschaft entgegenstehendes Interesse hat, nur im Beschluss
des einzigen Verwaltungsratsmitglieds erwähnt.
23.9 Regeln zum Interessenkonflikt finden keine Anwendung, sofern sich die Entscheidung des Verwaltungsrats oder
des einzigen Verwaltungsratsmitglieds auf gängige Geschäfte bezieht, die unter normalen Bedingungen eingegangen wur-
den.
23.10 Der Verwaltungsrat kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,
E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustim-
mung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden Beschlus-
ses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
23.11 Der Großteil aller Verwaltungsratssitzungen werden am eingetragenen Sitz der Gesellschaft im Großherzogtum
Luxembourg abgehalten oder aber an jedem anderen Ort in Luxembourg, wie in der Ladung zur Sitzung angegeben.
Art. 24. Protokoll von Verwaltungsratssitzungen - Protokoll der Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds.
24.1 Das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder, im Falle seiner
Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder anderweitig vorzulegen sind, werden vom
Vorsitzenden oder von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.
24.2 Die Entscheidungen des einzigen Verwaltungsratsmitglieds werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom
einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom einzigen Verwaltungsratsmitglied unterzeichnet.
Art. 25. Geschäfte mit Dritten.
25.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Unterschrift des einzigen Verwal-
tungsratsmitglieds oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Verwaltungsratsmitglieder hat, durch die gemeinsame
Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch (ii) die Unterschrift jedweder Person(en),
der/denen eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis verpflichtet.
25.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder
Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der/denen diese Vollmacht übertragen wurde.
34836
L
U X E M B O U R G
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Die Geschäfte der Gesellschaft werden durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire
(s)). Die Hauptversammlung der Aktionäre ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest, die sechs (6) Jahre
nicht überschreiten darf.
26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Hauptversammlung der Aktionäre abberufen wer-
den.
26.3 Der Rechnungsprüfer hat ein unbeschränktes Recht der permanenten Prüfung und Kontrolle aller Geschäfte der
Gesellschaft.
26.4 Wenn die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2002 betreffend das Handels- und Gesellschaftsregister sowie zur Buchhaltung und zum Jahresab-
schluss von Unternehmen in seiner geänderten Fassung einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs
d’entreprises agréé(s)) ernennt, entfällt die Funktion des Rechnungsprüfers.
26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit
den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.
28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
28.3 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der
gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
28.5 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Hauptversammlung der Aktionäre im Einklang mit dem Gesetz
von 1915 und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft verwendet werden
soll.
28.6 Im Falle einer Dividendenausschüttung, soll die Dividende nach folgender Reihenfolge verteilt und ausgeschüttet
werden:
Zuerst an:
i. die Inhaber von Klasse B1 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,10% (Null Komma zehn
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B1 Aktien (gerundet, wenn nötig);
ii. die Inhaber von Klasse B2 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,15% (Null Komma fünfzehn
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B2 Aktien (gerundet, wenn nötig);
iii. die Inhaber von Klasse B3 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,20% (Null Komma zwanzig
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B3 Aktien (gerundet, wenn nötig);
iv. die Inhaber von Klasse B4 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,25% (Null Komma fünf-
undzwanzig Prozent) des Nominalwert der Klasse B4 Aktien (gerundet, wenn nötig);
v. die Inhaber von Klasse B5 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,30% (Null Komma dreißig
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B5 Aktien (gerundet, wenn nötig);
vi. die Inhaber von Klasse B6 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,35% (Null Komma fünf-
unddreißig Prozent) des Nominalwerts der Klasse B6 Aktien (gerundet, wenn nötig);
vii. die Inhaber von Klasse B7 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,40% (Null Komma vierzig
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B7 Aktien (gerundet, wenn nötig);
viii. die Inhaber von Klasse B8 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,45% (Null Komma fünf-
undvierzig Prozent) des Nominalwerts der Klasse B8 Aktien (gerundet, wenn nötig);
ix. die Inhaber von Klasse B9 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,50% (Null Komma fünfzig
Prozent) des Nominalwerts der Klasse B9 Aktien (gerundet, wenn nötig);
x. die Inhaber von Klasse B10 Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,55% (Null Komma fünf-
undfünfzig Prozent) des Nominalwerts der Klasse B10 Aktien (gerundet, wenn nötig);
Zweitens an:
34837
L
U X E M B O U R G
xi. die Inhaber von A Aktien werden berechtigt zu einer Dividende entsprechend 0,05% (Null Komma null Fünf Prozent)
des Nominalwerts der A Aktien (gerundet, wenn nötig);
Drittens an:
der Rest (abzüglich der Beträge welche an die Inhaber von Gründeraktien gezahlt worden sind) wird an die Inhaber
der betreffenden Klasse der Klassenperiode, welche dann läuft, gezahlt.
28.7 Im Falle einer Ausschüttung erhalten die Inhaber von Gründeraktien pro rata Null Komma null eins Prozent]
(0,01%) des jährlichen Nettogewinns der Gesellschaft, wobei diese Ausschüttung auf einen Betrag entsprechend dem
zehnfachen (10) Nominalwert der Gründeraktien gedeckelt ist.
Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung Ab-
schlagsdividenden auszahlen.
29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 30. Liquidation.
30.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liquidation durch einen
oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
30.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Aktionäre wie folgt verteilt:
i. zuerst soll jeder Inhaber der Klassen einen Betrag erhalten, der der Auszahlung (apport) der Klassen entspricht;
ii. zweitens sollen die Inhaber von den A Aktien und die Inhaber von Gründeraktien einen Betrag erhalten der dem
Nominalwert der A Aktien und dem Nominalwert der Gründeraktien entspricht;
iii. von dem Rest des Überschusses, erhalten die Inhaber von A Aktien einen Betrag der entweder 0,60% (Null Komma
Sechzig Prozent) des Nominalwerts von A Aktien (gerundet, wenn nötig), oder mindestens fünfundzwanzigtausend Euro
(EUR 25.000) entspricht;
iv. der Rest soll an die Inhaber von den Klassen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen
Aktien verteilt werden.
Um Zweifel auszuschließen, die Inhaber von Gründeraktien werden zu keiner in diesem Artikel 30.2 (ii) und (iii)
beschriebenen Ausschüttung berechtigt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht
Art. 31. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.“
<i>Kosten und Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
dieser Beschlüsse entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
Die notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.
Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Partei auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und auf Anfrage derselben
erschienenen Partei im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
vorrangig sein soll.
Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Partei, welche dem Notar mit Namen, Vornamen
und Wohnort bekannt ist, vorgelesen worden ist, unterzeichnete die Bevollmächtigte der erschienenen Partei dieses
Dokument zusammen mit dem Notar.
Gezeichnet: F. DE TOMMASI, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 février 2015. Relation: DAC/2015/1827. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.
Diekirch, den 04. Februar 2015.
Référence de publication: 2015022569/1506.
(150026787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 février 2015.
34838
L
U X E M B O U R G
Konoco.M, Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 193.505.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement à la date du 05 février 2015
que
1. L'assemblée a pris note de la démission de ses fonctions d'administrateur unique avec effet au 4 février 2015, de
Monsieur Anar Mahmudov, né le 29 janvier 1984 à Bakou (Azerbaïdjan), dirigeant de société, demeurant au 528 Avenue
H. Javid, AZ-1073 Bakou, Azerbaïdjan.
2. L'assemblée a décidé de nommer comme nouvel administrateur unique, à partir du 5 février 2015, Monsieur Philippe
Dauvergne, né le 20 mai 1972 à Fontenay-aux-Roses, dirigeant de société, demeurant professionnellement au 51, rue de
Strasbourg, L-2561 Luxembourg.
Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale de l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 05 février 2015.
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015021849/20.
(150024994) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Lava Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4240 Esch-sur-Alzette, 36, rue Emile Mayrisch.
R.C.S. Luxembourg B 166.359.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire le 4 février 2015i>
1. L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission du mandat d'administrateur et d'administrateur délégué
de Monsieur Patrick WILWERT.
2. L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission du mandat d'administrateur de Monsieur Romain KET-
TEL
3. L'assemblée générale des actionnaires accepte la démission de Monsieur Norbert MEISCH de son poste d'adminis-
trateur.
4. L'assemblée générale des actionnaires approuve la nomination de la société W.M.A. World Management Assistance
SARL, sise 4, rue Jean-Pierre Brasseur à L-1258 Luxembourg, représentée par Monsieur Norbert MEISCH, demeurant
professionnellement 36, rue Emile Mayrisch à L-4240 Esch-sur-AIzette, à la fonction d'administrateur unique pour une
durée de 5 ans, son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale qui aura lieu en 2020 statuant sur les comptes de
l'exercice clos au 31.12.2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 4 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021864/23.
(150025170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 97.835.
<i>Extrait des décisions prises par le conseil de gérance en date 3 février 2015i>
Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte à L-2453 Luxem-
bourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet au 1
er
janvier 2015.
Veuillez noter que l'adresse professionnelle de Monsieur Georges SCHEUER, gérant B, Mr Arnaud DELVIGNE, gérant
B et Mme Virginie DECONINCK, gérant B, se situe désormais au L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, avec effet
au 1
er
janvier 2015.
34839
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 6 février 2015.
Pour extrait et avis sincères et conformes
<i>Pour IFCO SYSTEMS LUXEMBOURG, S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021815/17.
(150024974) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Iberian Hod S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.375.
<i>Extrait de la résolution prise par le Conseil d'administration en date du 5 février 2015i>
- Madame Régine DUMONT-BARBIER, née le 25 octobre 1964 à Saint-Mard (B), demeurant professionnellement au
412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg est cooptée, avec effet au 9 décembre 2014, en tant qu'administrateur de catégorie
B en remplacement de Monsieur Christian FRANÇOIS démissionnaire.
Son mandat viendra à échéance à l'assemblée générale statutaire de l'an 2016.
Certifié sincère et conforme
IBERIAN HOD S.A.
Référence de publication: 2015021812/14.
(150025062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Würth Reinsurance Company S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 46.463.
<i>Auszug des Protokolls der Verwaltungsratssitzung der Würth Reinsurance Company S.A. vom 31 Januar 2014 in Luxemburg umi>
<i>12.30 Uhri>
<i>Beschluss 2:i>
Der Verwaltungsrat beschliesst Herrn Joachim Kaltmaier, mit Wohnhsitz in Weilersbach 6, 74542, Braunsbach Deuts-
chland, als Vorsitzenden zu ernennen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Für gleichlautenden Auszug
Unterschrift
<i>Der Beauftragei>
Référence de publication: 2015022214/16.
(150025598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
LSREF3 Tiger Grays S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.900,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 194.312.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-eighth day of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated
under the laws of Luxembourg, with registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070
Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 192.147,
hereby represented by Mrs Corinne PETIT, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given in Bertrange, Grand-Duchy of Luxembourg, on 27 January 2015.
Said proxy, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned
notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.
34840
L
U X E M B O U R G
Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to draw up as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Form. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) (hereafter the Company)
which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity (the Laws), and in
particular the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act), as well as by the
present articles (the Articles of Association).
Art. 2. Object. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acquisition,
holding and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of, any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or deve-
lopment of those participations, rights, interests and obligations.
In addition, the Company may acquire, hold, administrate, manage, enhance and dispose of real estate (in particular
land and buildings as well as rights related to real property such as leasehold and partownership rights) located in Lu-
xembourg or abroad and may hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg or
foreign entities the object of which is, according to their articles, (i) to acquire, hold, administrate, manage and dispose
of the real estate and/or to acquire, hold, administrate, manage and dispose of interests and participations in Luxembourg
or foreign real estate companies.
In a general fashion, the Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or
dispose of all of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds
of property, tangible and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/
or control of any form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own,
manage, develop and/or dispose of any portfolio of securities, real estate and intellectual property rights of whatever
origin and to realise them by way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.
The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsi-
diaries, affiliated companies and third parties.
The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial
and financial operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the development of, its corporate
purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Name. The Company will have the name of "LSREF3 Tiger Grays S.à r.l.".
Art. 5. Registered Office. The registered office is established in the municipality of Bertrange, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single
shareholder, or in case of plurality, of an extraordinary general meeting of its shareholders.
It may be transferred within the boundaries of the municipality of Bertrange by a resolution of the sole manager or,
in case of plurality, the Board of Managers of the Company.
The Company may establish other offices and/or branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by
resolution of sole manager or, in case of plurality, the Board of Managers.
Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 10,900 (ten thousand nine hundred
pound sterling), represented by 1,090,000 (one million ninety thousand) ordinary shares having a nominal value of GBP
0.01 (one penny) each.
The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Association or by the Laws.
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make
distributions to the shareholder(s) in any form whatsoever including but not limited to dividend payments or reimbur-
sement or to allocate funds to the legal reserve.
Any contribution in cash or in kind made as capital contributions without the issuance of new shares will be booked
in a "capital surplus" account (the Capital Surplus) pursuant to a resolution of the general meeting of shareholder(s). The
Capital Surplus will only be available (i) for the purpose of distributions, whether by dividend, share redemption, reim-
bursement or otherwise, to the holder(s) of the shares which ha(s/ve) paid the Capital Surplus pro rata to its/their
respective contribution(s), (ii) to be incorporated in the share capital to issue shares to the holder(s) of shares which ha
(s/ve) paid the Capital Surplus pro rata to its/their respective contribution(s), (iii) to offset any net realised losses or (iv)
to be allocated to the legal reserve.
34841
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Increase and Reduction of Capital. The capital may be increased or reduced at any time by a decision of the
single shareholder or, as the case may be, by a resolution of the general meeting of shareholders voting with the quorum
and majority rules set by these Articles of Association or, as the case may be, by the Companies Act for any amendment
of these Articles of Association.
Art. 8. Shares. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence and entitles to one vote at the general meetings of shareholders, as the case may
be.
As far as the Company is concerned, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share.
Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
In case of a single shareholder, the transfer of the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised
by the sole manager or the Board of Managers, as the case may be.
In case of plurality of shareholders, the transfer of the Company's shares inter vivos to third parties must be authorised
by (i) the sole manager or, as the case may be, the Board of Managers and (ii) the general meeting of shareholders by an
unanimous vote of all the shareholders of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among
the shareholders of the Company.
Art. 9. Incapacity, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder. The death, suspension of civil rights, insolvency or
bankruptcy of the single shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders, does not put the Company into
liquidation.
Art. 10. Board of Managers. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been
appointed, they will constitute a board of managers (the Board of Managers). The manager(s) need not be shareholder
(s). The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the single shareholder, or as the case may
be, of the general meeting of the shareholders owning more than half of the share capital, which will determine their
number and the period of their mandate.
The single shareholder or, as the case may be, the general meeting of shareholders may at any time and ad nutum
(without cause) dismiss and replace the sole manager or, in case of plurality, any member of the Board of Managers.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances
and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article 10 shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles of Association to the single shareholder, or, as the
case may be, the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole manager, or in case of plurality
of managers, of the Board of Managers.
Art. 11. Representation of the Company. The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and,
in case of plurality of managers, by the sole signature of any manager.
Art. 12. Delegation of Powers. The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or
the sole manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers, may sub-delegate his powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
The sole shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders or the sole manager, or in case of
plurality of managers, the Board of Managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 13. Meetings of the Board of Managers. Every board meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg or
such other place in Luxembourg as the Board of Managers may from time to time determine.
Written notices of any meeting of the Board of Managers will be given to all managers, in writing or by cable, telegram,
telefax or telex, at least 24 (twenty-four) hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of
emergency. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have
been informed on the agenda of the meeting beforehand. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the Board of Managers.
Any manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by cable, telegram, telefax
or telex another manager as his proxy. Managers may also cast their votes by telephone confirmed in writing. The Board
of Managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members are present or represented at a
meeting of the Board of Managers.
The resolutions of the Board of Managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Notwithstanding the foregoing, resolutions of the Board of Managers may also be passed in writing which resolutions
will be proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Managers which was duly convened
and held. Such resolutions shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and
every manager, with a majority signed in Luxembourg. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.
Art. 14. Responsibilities. The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position,
no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
34842
L
U X E M B O U R G
Art. 15. General Meeting of Shareholders. If the Company is composed of one single shareholder, the latter assumes
all powers conferred by Laws to the general meeting of shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing in writing, by fax or e-mail as his proxy another
person who need not be a shareholder.
Resolutions whose purpose is to amend the Articles of Association of the Company may only be adopted by a majority
of shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the
Companies Act.
If the Company is composed of no more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the general meeting of
shareholders may be taken by a vote in writing on the text of the resolutions to be adopted which will be sent by the
Board of Managers or, as the case may be, the sole manager to the shareholders.
Art. 16. Financial Year. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of
December of each year.
Art. 17. Adoption of annual accounts. At the end of each financial year, with reference to thirty-first December, the
Company's accounts are closed and are drawn up by the manager, or in case of plurality of managers, by the Board of
Managers, in accordance with the Laws, who prepares, among others, an inventory including an indication of the value of
the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
The annual accounts are submitted to the single shareholder or, as the case may be, to the general meeting of share-
holders for approval.
Art. 18. Appropriation of Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of
general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the annual
net profits of the Company is allocated to a statutory reserve required by law. Such allocation will cease to be required
as soon as and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's subscribed share capital.
Subject to the following, the single shareholder or the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to
a reserve or to a provision reserve, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it to the
shareholders as dividend.
Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the sole manager or, as the
case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholder(s). The sole manager
or, as the case may be, the Board of Managers determines the amount and the date of payment of any such advance
payment.
Art. 19. Dissolution, Liquidation. The Company may be dissolved by a decision of the single shareholder or by a decision
of the general meeting of shareholders voting with the same quorum and majority as set out in these Articles of Asso-
ciation, unless otherwise provided by Laws.
At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders
or not, appointed by the single shareholder, or as the case may be, the general meeting of shareholders who shall de-
termine their powers and remuneration.
Art. 20. Applicable Law. Reference is made to the provisions of the Laws, and in particular the Companies Act, for all
matters for which no specific provision is made in these Articles of Association.
<i>Subscription and Paymenti>
All the 1,090,000 (one million ninety thousand) shares have been subscribed and fully paid-up via contribution in cash
by LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., prequalified, so that the sum of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred pound
sterling) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
<i>Transitory Provisionsi>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated at approximately EUR 1,400 (one thousand four hundred euro).
The amount of GBP 10,900 (ten thousand nine hundred pound sterling) corresponds to the amount of EUR 14,564.16
(fourteen thousand five hundred sixty-four Euro and sixteen Eurocent) according to the exchange rate published on
XE.COM on January 28
th
, 2015.
34843
L
U X E M B O U R G
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers is set at 3 (three).
2. The meeting appoints as managers of the Company for an unlimited period of time:
- Mr. Patrick STEINHAUSER, legal counsel, born on 21 April 1975 in Baden-Baden, Germany, whose professional
address is at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr. Philippe DETOURNAY, company director, born on 9 April 1966 in Hal, Belgium, whose professional address is
at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Mr. Philippe JUSSEAU, accountant, born on 16 September 1979 in Strasbourg, France, whose professional address
is at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg.
3. The registered office is established at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.
Whereof the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove
mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder signed together with Us,
the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg et immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B 192.147,
ici représentée par Madame Corinne PETIT, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une
procuration donnée à Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Ladite procuration, après signature «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire soussigné,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi
qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elle déclare constituer:
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (ci-après, la Société) qui sera régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg y relatives (les Lois), et notamment celle du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915) ainsi que les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
constitution, l’acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de
participations, droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise et étrangère, ainsi que
l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.
De plus, la Société peut acquérir, détenir, administrer, gérer, mettre en valeur et transférer des biens immobiliers (en
particulier des terrains et bâtiments, de même que des droits liés à la propriété immobilière tels que les baux et les
démembrements du droit de propriété) situés à Luxembourg ou à l’étranger et peut détenir, administrer, gérer et trans-
férer des intérêts et des participations dans des entités luxembourgeoises ou étrangères dont l’objet est, selon leurs
statuts, (i) d'acquérir, détenir, administrer, gérer et transférer des biens immobiliers et/ou (ii) d'acquérir, détenir, admi-
nistrer, gérer et transférer des intérêts et participations dans des entités immobilières luxembourgeoises ou étrangères.
De manière générale, la Société peut utiliser ses fonds par tous les moyens pour constituer, administrer, développer
et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, pour acquérir, investir dans et/ou vendre
toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer à la création, l’ac-
quisition, le développement et/ou le contrôle de toute forme de sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères,
pour acquérir par tout moyen, établir, détenir, gérer, développer et/ou vendre tout portefeuille de valeurs mobilières,
biens immobiliers et de brevets de n'importe quelle origine, et pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou
autrement.
34844
L
U X E M B O U R G
La Société peut également consentir des garanties et/ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations et/ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, nantir, céder, grever de charges
ou créer des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs et accorder des prêts, avances et/ou assistance, sous
n’importe quelle forme, à ses filiales, sociétés affiliées et tierces parties.
La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant mais n’étant pas limité à des opéra-
tions commerciales, industrielles et financières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou
susceptibles de favoriser son développement.
Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.
Art. 4. Dénomination. La société est dénommée «LSREF3 Tiger Grays S.à r.l.»
Art. 5. Siège Social. Le siège social est établi dans la commune de Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l’associé unique, ou en cas
de pluralité, de l’assemblée générale des associés de la Société.
Il peut être transféré dans la commune de Bertrange par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil
de Gérance de la Société.
La Société peut établir d’autres bureaux et/ou succursales à la fois dans le Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à
l’étranger par une décision du gérant unique ou, le cas échéant, du Conseil de Gérance.
Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social de la Société est fixé à la somme de GBP 10.900 (dix mille neuf cents
livres sterling), représenté par 1.090.000 (un million quatre-vingt-dix mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
de GBP 0,01 (un penny) chacune.
Les droits et obligations inhérents aux parts sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel sera transféré toute prime d’émission
payée sur toute part sociale en plus de sa valeur nominale. Le solde de ce compte prime d’émission peut être utilisé pour
régler le prix des parts sociales que la Société peut racheter à son/ses associé(s), pour compenser toutes pertes nettes
réalisées, pour distribuer des dividendes à/aux (l’) associé(s), de quelque manière que ce soit, incluant mais n’étant pas
limité à des paiements de dividendes ou remboursement ou pour affecter des fonds à la réserve légale.
Tout apport en numéraire ou en nature opéré en tant qu’apport en capital sans émission de nouvelles parts sociales
sera inscrit à un compte de contribution au capital non rémunéré par des titres («Contribution au Capital») suivant une
résolution de l’assemblée générale de(s) (l’) associé(s). La Contribution au Capital sera uniquement disponible (i) pour
des distributions, soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat de parts sociales, remboursement ou autre-
ment, au(x) détenteur(s) des parts sociales qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs
contributions respectives, (ii) pour être incorporé au capital social afin d’émettre des parts sociales au(x) détenteur(s)
des parts sociales qui a/ont payé la Contribution au Capital au prorata de sa contribution / leurs contributions respectives,
(iii) pour compenser toutes pertes nettes réalisées ou (iv) pour être alloué à la réserve légale.
Art. 7. Augmentation et Réduction de Capital. Le capital social pourra à tout moment être augmenté ou réduit suivant
une décision de l’associé unique ou, le cas échéant, par une résolution des associés adoptée aux conditions de quorum
et de majorité requises par ces Statuts ou, le cas échéant, par les Lois pour toute modification des Statuts.
Art. 8. Parts Sociales. Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes,
de l’actif social ainsi que des bénéfices de la Société et donne droit à une voix dans les assemblées générales d’associés,
le cas échéant.
A l’égard de la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour
chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par
une seule et même personne.
En cas d’associé unique, le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé par le gérant unique ou,
le cas échéant, par le Conseil de Gérance.
En cas de pluralité d'associés, le transfert de parts sociales entre vifs à des tiers doit être autorisé par (i) le gérant
unique ou, le cas échéant, par le Conseil de Gérance et (ii) l’assemblée des associés par une décision unanime de tous les
associés de la Société. Cette autorisation n'est pas requise en cas de transfert de parts sociales à des associés de la Société.
Art. 9. Incapacité, Faillite ou Insolvabilité d’un Associé. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’associé
unique, ou le cas échéant d'un des associés, n’entraînent pas la mise en liquidation de la Société.
Art. 10. Conseil de Gérance. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants ont été nommés,
ils formeront un conseil de gérance (le Conseil de Gérance). Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associé(s). Le ou
les gérant(s) sont nommés, révoqués et remplacés par une décision de l’associé unique, ou le cas échéant de l’assemblée
générale des associés, adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social, qui détermine leur nombre
et la durée de leur mandat.
34845
L
U X E M B O U R G
L’associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier
d'une raison) révoquer et remplacer le gérant unique, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des
membres du Conseil de Gérance.
Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes
circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l’objet social et sous réserve du
respect des dispositions du présent article 10.
Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l’associé unique, ou le cas échéant,
à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du Conseil
de Gérance.
Art. 11. Représentation de la Société. En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant
unique, et en cas de pluralité de gérants, par la seule signature d'un gérant quelconque.
Art. 12. Délégation de Pouvoirs. L'associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée des associés ou le gérant unique ou,
en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à
un ou plusieurs mandataires ad hoc.
L'associé unique, ou le cas échéant, l’assemblée des associés ou le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le
conseil de gérance déterminera la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période
de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
Art. 13. Réunions du Conseil de Gérance. Toute réunion du Conseil de Gérance se tient au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à tout autre endroit à Luxembourg que le Conseil de Gérance peut de temps à autres déterminer.
Des notifications écrites de toute réunion du Conseil de Gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou par câble,
télégramme, télex ou télécopie, au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l’heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a
urgence. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au Conseil de Gérance
et s'ils déclarent avoir été informés de l’ordre du jour auparavant. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour
une réunion du Conseil de Gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement
adoptée par le Conseil de Gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre
gérant comme son mandataire. Les gérants peuvent également émettre leur vote par téléphone, moyennant une confir-
mation écrite. Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir validement que si au moins la majorité des membres du
conseil est présente ou représentée au conseil de gérance.
Les décisions du Conseil de Gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, des décisions du Conseil de Gérance peuvent également être prises par
écrit, lesquelles décisions seront régulières et valables comme si elles avaient été adoptées à une réunion du Conseil de
Gérance dûment convoquée et tenue. De telles décisions résulteront d'un seul ou de plusieurs documents contenant les
résolutions et signés par tous les membres du Conseil de Gérance sans exception, avec une majorité signée à Luxembourg.
La date de telles résolutions circulaires sera la date de la dernière signature.
Art. 14. Responsabilités. Le ou les gérant(s) ne contracte(nt), à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.
Art. 15. Assemblée Générale des Associés. Si la Société comporte un associé unique, l’associé unique exerce tous les
pouvoirs qui sont dévolus à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts
qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas
de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par
des associés représentant plus de la moitié du capital social.
Un associé peut agir à toute assemble des associés en nommant par écrit, par fax ou par e-mail en qualité de mandataire
une autre personne qui n’a pas besoin d’être associé.
Les résolutions dont l’objet est de modifier les statuts de la Société ne pourront être prises que de l’accord de la
majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, sous réserve des dispositions de la Loi de
1915.
Si la Société ne comporte pas plus de vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés peuvent être prises par vote
écrit sur le texte des résolutions à adopter, lequel est envoyé par le Conseil de Gérance ou, le cas échéant, le gérant
unique aux associés. Dans ce dernier cas les associés ont l’obligation d'émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société
dans un délai de quinze jours suivant la réception du texte des résolutions proposées.
Art. 16. Année Sociale. L'année sociale de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre de chaque
année.
34846
L
U X E M B O U R G
Art. 17. Approbation des Comptes Annuels. A la fin de chaque année sociale, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés
et dressés, suivant le cas, par le gérant unique ou le Conseil de Gérance, conformément aux Lois, qui, entre autres, dresse
un inventaire comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.
Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l’inventaire et du bilan.
Les comptes annuels sont soumis à l’approbation de l’associé unique ou, selon le cas, de l’assemblée générale des
associés.
Art. 18. Affectation des Bénéfices. Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite
des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net annuel, il est prélevé cinq
pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque et aussi
longtemps que la réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.
Sous conditions de ce qui suit, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés décident de l’affectation du solde
des bénéfices annuels nets. Il peut/Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve
ou de provision, de le reporter à nouveau ou de le distribuer comme dividende à l’associé/aux associés.
Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, le gérant unique ou,
le cas échéant, le Conseil de Gérance peut/peuvent procéder au versement d'un acompte sur dividendes à ou aux associé
(s). Le gérant unique ou, le cas échéant, le Conseil de Gérance déterminera/ont le montant ainsi que la date de paiement
de tels acomptes.
Art. 19. Dissolution, Liquidation. La Société peut être dissoute par une décision de l’associé unique ou de l’assemblée
générale des associés délibérant aux mêmes conditions de quorum et de majorité que celles prévues par les Statuts, sauf
dispositions contraires des Lois.
Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés
par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés qui fixera/ont ses/leurs pouvoirs et leurs émoluments.
Art. 20. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispo-
sitions des Lois et en particulier la Loi de 1915.».
<i>Souscription et libérationi>
L’ensemble des 1.090.000 (un million quatre-vingt-dix mille) parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées
par apport en numéraire par LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., précitée, de sorte que la somme de GBP 10.900 (dix mille
neuf cents livres sterling) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.
<i>Dispositions transitoiresi>
Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2015.
<i>Evaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement EUR 1.400 (mille quatre cents
euros).
La somme de GBP 10.900 (dix mille neuf cents livres sterling) correspond à la somme de EUR 14.564,16 (quatorze
mille cinq cent soixante-quatre Euros et seize Eurocent) conformément au taux de change publié sur XE.COM en date
du 28 janvier 2015.
<i>Assemblée générale constitutivei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé préqualifié représentant la totalité du capital souscrit a
pris les résolutions suivantes:
1. Le nombre de gérants est fixé à 3 (trois).
2. Sont nommés membres du conseil de gérance, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Patrick STEINHAUSER, juriste, né à Baden-Baden, Allemagne, le 21 avril 1975 dont l’adresse professionnelle
est au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg;
- Monsieur Philippe DETOURNAY, directeur de société, né à Hal, Belgique, le 9 avril 1966 dont l’adresse profession-
nelle est au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg; et
- Monsieur Philippe JUSSEAU, comptable, né à Strasbourg, France, le 16 septembre 1979 dont l’adresse professionnelle
est au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg.
3. Le siège social de la Société est établi au Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange,
Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; à la demande de la même partie comparante, en cas de diver-
gence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
34847
L
U X E M B O U R G
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l’année indiquée ci-dessus.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celle-ci a signé le présent acte
avec le notaire.
Signé: C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 2 février 2015. 2LAC/2015/2317. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2015.
Référence de publication: 2015021877/413.
(150025191) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Lysys Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 171.795.
Il est pris acte du changement de siège social de l'Administrateur suivant:
- RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L., 76-78 rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Il est pris acte du changement d'adresse professionnelle de l'Administrateur suivant:
- Mr. Benoît PARMENTIER, 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Il est pris acte du changement d'adresse du commissaire aux comptes:
- Mr. Jean-François DETAILLE, 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Fait à Luxembourg, le 27/01/2015.
Certifié sincère et conforme
LYSYS LUXEMBOURG S.A.
RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L. / Benoît PARMENTIER
<i>Administrateur / Administrateur
i>Mme Gunhilde VAN GORP / -
<i>Représentant Permanent / -i>
Référence de publication: 2015021860/20.
(150025448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
MC Car Loans Finance I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.383.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérancei>
En date du 20 janvier 2015, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15, avenue
de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, et ce avec effet immédiat.
Nous vous prions également de bien vouloir prendre note du changement d'adresse des gérants avec effet immédiat:
- Johan Dejans, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Richard Brekelmans, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
- Hille-Paul Schut, demeurant professionnellement au 6, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 6 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015021915/19.
(150025396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
34848
Corelux S.A.
Corning International Luxembourg S.à r.l.
Corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires Mondercange
Cuny Invest S.A.
Curzon 50 S.à r.l.
CVM SPF S.A.
Cyclon S.A.
Delta AK S.à r.l.
Derceto Management
Desalline S.A.
D.H. Group S.A.
Dodo S.A.
Do Way S.à r.l.
Engineering S.A.
Euro Equity Management S.à r.l.
Euro Equity Management S.à r.l.
Eurozone Development S.A.
Eurozone Development S.à r.l.
Firewall Management Mip S.A.
Firewall Management Mip S.à r.l.
Hydra Luxembourg Investments S.à r.l.
Iberian Hod S.A.
IFCO Systems Luxembourg S.àr.l.
JENSAL Spf S.A.
Johnson Controls Interiors Holding EU S.à r.l.
Kaderma S.A.
Knowles Luxembourg International S.à r.l.
Konoco.M
Laurent Properties S.A.
Lava Participations S.A.
LSREF3 Tiger Grays S.à r.l.
Lysys Luxembourg S.A.
MC Car Loans Finance I S.à r.l.
OCM Luxembourg Leman Street Apart-Hotel S.à r.l.
OCM Luxembourg Olivers Yard Apart-Hotel S.à r.l.
OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings S.à r.l.
OCM Luxembourg Stilo Investment S.à r.l.
Sea View Residence S.A.
Sheet Anchor Properties France S.à r.l.
Sheet Anchor Properties Lux Holding S.à r.l.
Shessen Holding S.A.
Sofidra S.A.
Sogin
TCS II Lu S.à r.l.
Utilicom
Würth Reinsurance Company S.A.