This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 678
12 mars 2015
SOMMAIRE
AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32543
Beauregard Capital Sicav . . . . . . . . . . . . . . .
32501
Capita Fiduciary S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32510
Carmudi SAUDI ARABIA S.C.Sp. . . . . . . .
32506
Carmudi UAE S.C.Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32506
Caroll, succursale Luxembourg . . . . . . . . . .
32506
Ceria S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32542
Classifieds Asia S.C.Sp. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
ClearingHouse for Intellectual Property
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32507
Clickbus Bulgaria Holding S.C.Sp. . . . . . . .
32508
Clickbus Czech Repubic Holding S.C.Sp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32508
Clickbus Germany Holding S.C.Sp. . . . . . .
32508
COFRA Treasury S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
32529
"Communications Investments Europe S.à
r.l." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32509
Comquest Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . .
32510
Concept International S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
32509
Contec Global Investment AG . . . . . . . . . .
32538
Cork Supply Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
32509
CORNALINE S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32511
CPI Digiplex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32512
Da Costa Almeida S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
32517
d'Amico International Shipping S.A. . . . . .
32504
Denise Invest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32518
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren
s.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32512
DreiP AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32515
Dridco Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
32516
D.R.M. Toitures S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32515
GAIA Fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32502
Geonosis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32544
Golden Fleur Private S.A. SPF . . . . . . . . . .
32544
iBondis Capital Holdings . . . . . . . . . . . . . . . .
32518
ING Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32544
Nestan S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32498
Pétrusse Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
32502
Pindo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
PK-phi s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32500
Premium Properties II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
32498
Premium Properties II S.à r.l. . . . . . . . . . . .
32498
Premium Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
32498
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32498
Société Immobilière ING Luxembourg
S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32544
'SOMALUX' Société de Matériel Luxem-
bourgeoise S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32503
Staminvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32501
Starten Partner S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32501
Synergie Investment . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
Tatsuma S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
Tepic Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
Théâtre National du Luxembourg Produc-
tions, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32499
Twelve Allium S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32500
UBS (Lux) Key Selection SICAV . . . . . . . . .
32503
32497
L
U X E M B O U R G
Premium Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 142.747.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021339/10.
(150024428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Premium Properties II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 142.747.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021340/10.
(150024446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Premium Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2320 Luxembourg, 68-70, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 93.980.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021341/10.
(150024415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6961 Senningen, 44, rue du Château.
R.C.S. Luxembourg B 19.597.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021343/10.
(150024614) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Nestan S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 166.339.
EXTRAIT
A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041
Strassen a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la société en date du 23/01/2015, et ce suivant
les dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions ou parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015021269/13.
(150024839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32498
L
U X E M B O U R G
Pindo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5280 Sandweiler, Z.I. Zolach.
R.C.S. Luxembourg B 178.649.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021336/10.
(150024132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Synergie Investment, Société Anonyme.
Siège social: L-1116 Luxembourg, 4, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 104.662.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015021420/10.
(150024058) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Tepic Invest S.A., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 192.914.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015021421/10.
(150024050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Théâtre National du Luxembourg Productions, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1940 Luxembourg, 194, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 70.965.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015021422/10.
(150024569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Tatsuma S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 157.514.
EXTRAIT
A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041
Strassen a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la société en date du 23/01/2015, et ce suivant
les dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions ou parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015021432/13.
(150024975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32499
L
U X E M B O U R G
PK-phi s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3372 Leudelange, 26, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 137.207.
L'an deux mille quinze,
le vingt-huit janvier.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg),
A COMPARU:
Monsieur Claude DUPONT, ingénieur, demeurant à L-6833 Biwer, 7, Neie Wee.
Lequel comparant a exposé au notaire instrumentant ce qui suit:
Qu'il est le seul associé de la société à responsabilité limitée PK-phi S.à r.l., ayant son siège social à L-3372 Leudelange,
26, rue Léon Laval, inscrite au registre de commerce et de sociétés à Luxembourg sous le numéro B 137.207 (NIN 2008
2409 174).
Que ladite société a été constituée suivant acte reçu par le notaire Alex WEBER, de résidence à Bascharage, en date
du 6 mars 2008, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 932 du 15 avril 2008.
Que le capital social de la société s'élève à douze mille cinq cents Euros (€ 12.500.-), représenté par cent (100) parts
sociales de cent vingt-cinq Euros (€ 125.-) chacune, toutes attribuées à Monsieur Claude DUPONT.
Ensuite le comparant a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
<i>Résolution uniquei>
L’associé unique décide de modifier l’article 2 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:
" Art. 2. La société a pour objet les prestations de services administratifs et de conseil.
La société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises
luxembourgeoises ou étrangères, l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l’aliénation par
vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs de toutes espèces, la
possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale et prêter tous concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de toute autre manière.
La société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l’émission d'obligations.
D'une façon générale, elle peut prendre toutes les mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières, commerciales et industrielles, qu'elle juge utiles à l’accomplissement ou au dé-
veloppement de son objet."
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant d'après son nom, prén-
om, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: P. SIMON, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 février 2015. Relation: GAC/2015/949. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): C. PIERRET.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 06 février 2015.
Référence de publication: 2015021337/43.
(150024657) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Twelve Allium S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 172.240.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015021429/10.
(150024526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32500
L
U X E M B O U R G
Staminvest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 111.462.
Les actionnaires sont convoqués, par la présente, à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
des actionnaires de STAMINVEST S.A. qui se tiendra extraordinairement le <i>30 mars 2015i> à 15.00 heures au 231, Val
des Bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire.
2. Approbation des bilan, compte de pertes et profits et attribution du résultat au 31 décembre 2014.
3. Décharge aux administrateurs et commissaire.
4. Décision concernant la continuation de la société en conformité avec l'article 100 de la loi modifiée du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015038948/17.
Starten Partner S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 177.436.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
qui se tiendra extraordinairement le <i>30 mars 2015i> à 14:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux administrateurs et au commissaire
4. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015039496/795/15.
Beauregard Capital Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 180.391.
You are hereby invited to attend the
ANNUAL GENERAL MEETING
of the Fund to be held on <i>8 April 2015i> at 10.00 a.m. (CET) at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy
of Luxembourg, with respect to the agenda set forth below:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the report of the board of directors and the report of the auditor for the financial year ended
31 December 2014;
2. Approval of the financial statements of the Fund for the financial year ended 31 December 2014;
3. Approval of the allocation of results for the financial year ended 31 December 2014;
4. Decision to grant full discharge of personal liability to all current directors of the Fund for their mandate during
the financial year ended 31 December 2014;
5. Re-election of Prof. Dr. Jörg Henzler, Mr. Lawrence Ward and Mr. Grégoire Vaucher as directors of the Fund until
the annual general meeting to be held in 2016;
6. Reappointment of PricewaterhouseCoopers Luxembourg S.à r.l. with registered address at 400, route d'Esch,
L-1014 Luxembourg as auditor of the Fund until the annual general meeting to be held in 2016; and
7. Miscellaneous.
The proxy form, the report of the board of directors, the auditor's report and the audited financial statements of the
Fund are available at the registered office of the Fund.
32501
L
U X E M B O U R G
An attendance list will be established at the Meeting recording the shareholder(s) of the Company. To be recorded
in such a list, a natural or a legal person will have to prove his/her/its quality of shareholder of the Company. In case of
a natural person he/she will have to prove his/her identity. In case of a legal person, its representative will have to prove
that he/she is a duly authorized representative empowered to bind the legal person.
<i>On behalf of the Chairman of the Fundi>
Référence de publication: 2015039498/29.
Pétrusse Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 54.256.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
qui se tiendra anticipativement le <i>30 mars 2015i> à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi modifiée
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
5. Divers
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015039497/795/17.
GAIA Fund, Société d'Investissement à Capital Variable (en liquidation).
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 169.010.
The shareholders of GAIA Fund (the “Company”) are herewith convened to attend the
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
(the “Meeting”), which will be held at the registered office at 8:30 a.m. on <i>20 March 2015i> for the purpose of considering
and voting upon the following matters:
<i>Agenda:i>
1. Acknowledgement of the report of the liquidator;
2. Acknowledgement of the report of the liquidation auditor;
3. Acknowledgement and approval of the Liquidation Balance Sheet and the Profit and Loss Accounts;
4. Discharge (quitus) to the liquidator for the execution of its mandate;
5. Declaration that the payment of the net proceeds of the liquidation in proportion to the number of the shares held
by the shareholders is undertaken against the cancellation of the shares held by them in the Company and that the
Company is thereby dissolved;
6. Declaration that the liquidation proceeds not surrendered will be kept in safe custody at the Caisse de Consignation
in Luxembourg;
7. Declaration that the Company's books and documents shall be deposited with and kept for a term of five years
after the date of publication of the relevant notarial deed in the Luxembourg official gazette at the office of Alceda
Fund Management S.A., 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg; and
8. Miscellaneous.
Voting: The Meeting can validly deliberate only if half of the share capital is present or represented. Insofar as such
quorum is not reached, a second Extraordinary General Meeting will need to be convened. Resolutions on the Agenda
may be passed in both meetings by qualified majority of two-thirds of the votes cast thereon at the Meeting.
<i>Voting Arrangements:
i>Shareholders who cannot attend the Meeting in person are invited to send a duly completed and signed proxy form
by email to corporate@alceda.lu followed by mail or by fax (+352 248 329 444) to the GAIA Fund, 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg to arrive not later than 24 hours before the time fixed for the Meeting or
adjourned Meeting. Proxy forms can also be obtained from the Company. A person appointed a proxy need not be a
holder of shares in the Company; lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if
he decides to do so.
32502
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, February 2015.
<i>The Liquidatori> .
Référence de publication: 2015035451/8040/35.
Somalux S.A. SPF, 'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF, Société Anonyme -
Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 4.523.
Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à
l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
qui se tiendra par-devant notaire le <i>30 mars 2015i> à 9:00 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de l'article 5, alinéa 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante :
" Les actions seront exclusivement émises sous la forme nominative. "
2. Modification de l'article 6 des statuts pour lui donner la teneur suivante :
" Les actions et certificats d'actions nominatives doivent être munis de la signature de deux administrateurs ou de
deux personnes ayant pouvoir d'engager la société."
3. Modification de l'article 7, 1er alinéa des statuts pour lui donner la teneur suivante :
" Toute action est indivisible à l'égard de la société, laquelle ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
En cas d'inscription sous plusieurs noms, le premier inscrit seul exercera le droit de vote et toute autre prérogative
attachée au titre et toute distribution en sa faveur sera libératoire à l'égard des autres copropriétaires inscrits. "
Les actionnaires sont avisés qu'un quorum de 50% des actions émises est requis pour délibérer sur les points de l'ordre
du jour. Si le quorum n'était pas atteint, une 2e Assemblée portant sur ces points devra être convoquée. Les résolutions
pour être valables devront réunir les 2 tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés.
<i>Le Conseil d'Administration.i>
Référence de publication: 2015039499/795/25.
UBS (Lux) Key Selection SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 88.580.
Die Aktionäre der UBS (Lux) Key Selection SICAV sind zur
JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG
der Gesellschaft eingeladen, die am Freitag, den <i>20. März 2015i> um 10:00 Uhr an deren Geschäftssitz mit folgender
Tagesordnung stattfindet:
<i>Tagesordnung:i>
1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers
2. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 30. September 2014
3. Entscheidung über die Ergebnisverwendung
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
5. Satzungsgemässe Wahlen
6. Mandat des Abschlussprüfers
7. Verschiedenes
Die aktuelle Ausgabe des Jahresberichts ist am Geschäftssitz der Gesellschaft in Luxemburg während der normalen
Öffnungszeiten kostenlos erhältlich.
Jeder Aktionär ist zur Teilnahme an der Jahreshauptversammlung berechtigt. Die Aktionäre können einen schriftlich
bevollmächtigten Vertreter an ihrer Stelle senden.
Um an der Jahreshauptversammlung teilzunehmen, müssen die Aktionäre ihre Aktien spätestens um 16:00 Uhr fünf
(5) Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung bei der Depotbank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg oder bei einer anderen beauftragten Zahlstelle hinterlegen. Es besteht kein Anwesen-
heitsquorum für die gültige Beschlussfassung in Bezug auf die Tagesordnungspunkte. Die Beschlussannahme kommt mit
einfacher Mehrheit der bei der Versammlung anwesenden oder vertretenen Aktien zustande. Auf der Jahreshauptver-
sammlung berechtigt jede Aktie zur Abgabe einer Stimme.
Wenn Sie bei dieser Versammlung nicht dabei sein können, aber gerne einen Vertreter entsenden möchten, schicken
Sie bitte eine mit Datum und Unterschrift versehene Vollmacht per Fax und anschliessend per Post spätestens fünf (5)
Geschäftstage vor dem Termin der Jahreshauptversammlung an UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A., 33A, ave-
32503
L
U X E M B O U R G
nue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg zu Händen des Gesellschaftssekretärs, Faxnummer +352 441010 6249. Formulare
zur Ausstellung einer Vollmacht können auf einfache Anfrage von der gleichen Adresse bezogen werden.
<i>Der Verwaltungsrat.i>
Référence de publication: 2015035453/755/34.
d'Amico International Shipping S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 124.790.
CONVENING NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
to the holders of shares with Common Code 029069751 and ISIN Code LU029069751
The
ANNUAL GENERAL MEETING
of the shareholders of the Company (hereinafter, the "Meeting") will be held at the registered address of the Company,
25C boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on <i>15 April 2015i> , at 11.00 a.m., to discuss and
resolve on the following:
<i>Agenda:i>
I.
Consideration of the reports of the Company's Board of Directors and of the Company's auditor ("réviseur d'en-
treprises agréé") on the consolidated and statutory annual accounts of the Company as at 31 December 2014;
II.
Consideration and approval of the Company's consolidated annual accounts as at 31 December 2014 and of the
Company's statutory annual accounts as at 31 December 2014;
III. Approval of the allocation of results of the 2014 financial year;
IV. Discharge of the members of the Board of Directors for the year ended on 31 December 2014;
V. Approval of Directors fees;
VI.
2014 Report of the Board of Directors on Remuneration (drafted in compliance with article 123-ter, clause 6, of
the Italian Legislative Decree 58/98): consideration and evaluation of section I of the Report
Quorum and Majority Requirements
The Meeting shall validly deliberate regardless of the percentage of the Company's corporate capital being represented.
Resolutions shall be adopted by a simple majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the
Meeting.
Declaration of Intention to Participate in the Meeting
Shareholders must notify the Company on the day of the Record Date (as defined hereafter) of their intention to
participate in the Meeting by sending a certificate (the "Certificate") indicating, inter alia, (i) the name and/or corporate
name and the domicile of the shareholder and/or registered address, (ii) a confirmation of participation in the Meeting
and (iii) a confirmation of the number of shares held by the shareholder after closing of the markets on the Record Date
(the "Shareholder's Details"). For shareholders holding their shares through an Intermediary (as defined hereafter), the
Certificate being prepared by the Intermediary with which the shares are held shall be sent to BNP Paribas Securities
Services, Luxembourg branch ("BNP Paribas") in its capacity as the duly mandated agent of the Company with copy to
the Company exclusively through Euroclear and Clearstream. In that respect, Intermediaries are further requested to
compulsory instruct Euroclear and Clearstream to further confirm to BNP Paribas all Shareholder's Details.
Voting Rights and Record Date
The rights of a shareholder to attend and speak at the Meeting and to vote in respect of his shares shall be determined
with respect to the shares held by the shareholder on 01 April 2015 at 24:00 hours Luxembourg time (the "Record
Date"). Only those who are shareholders on that Record Date shall have the right to participate and vote at the Meeting.
Shareholders present or represented are requested to bring a copy of the Certificate to the Meeting in order to
present it to the board of the Meeting.
Representation by Proxy or Voting by Ballot Paper
Each share is indivisible as far as the Company is concerned. The co-proprietors, the usufructuaries and bare-owners
of shares, the creditors and debtors of pledged shares must appoint one sole person to represent them at any general
meeting of shareholders.
Shareholders need not be present at the Meeting in person. In accordance with the Company's Articles of Association,
a shareholder at the Record Date may act at the Meeting by appointing another person who need not be a shareholder
himself, subject to the production of the original of the executed proxy to the Meeting in order to present it to the board
of the Meeting. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions at the Meeting as those to which
the shareholder thus represented would be entitled. Each shareholder shall only be represented by one proxy holder at
the Meeting except that:
32504
L
U X E M B O U R G
(i) if a shareholder has shares of the Company held in more than one securities account, he may appoint one proxy
holder per securities account at the Meeting;
(ii) a shareholder acting professionally for the account of other natural or legal persons may appoint each of these
natural or legal persons or third parties appointed by them.
A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the
number of shareholders so represented. Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast
votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.
Alternatively, in accordance with the Company's Articles of Association, a shareholder may cast his vote by a ballot
paper ("formulaire") expressed in the English language.
Any ballot paper which does not bear the mentions or indications required by the Company's Articles of Association
is to be considered void and shall be disregarded for quorum purposes. In case a proposed resolution is amended by the
Meeting, the votes expressed on such proposed resolution pursuant to the ballot papers received shall be void.
Shareholders must instruct the commercial bank, broker, dealer, custodian, trust company, accountholder, professional
securities depositary, financial institution or other qualified intermediary through which they hold their shares (hereinafter,
the "Intermediary") who handles the management of the Company's shares by using the proxy form or the ballot paper
form.
Intermediaries shall ensure that the signed and dated proxy forms with vote instructions and the ballot papers be
delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post with acknowledgment of receipt, by special courier
service using an internationally recognised courier company, by email or by fax to BNP Paribas with copy to the Company
no later than 5:00 p.m. Luxembourg time on 10 April 2015. Beneficial owners of shares held through an Intermediary are
urged to confirm the deadline for receipt of their proxy forms with vote instructions and ballot papers by such Interme-
diary to ensure their onward delivery to BNP Paribas by the relevant deadline.
Shareholders acknowledge that by sending their proxy forms with their voting instructions or their ballot paper form
they will be deemed to consent to having the relevant Intermediary, including but not limited to Euroclear and Clear-
stream, provide all details concerning their identity to BNP Paribas and to the Company.
Relevant proxy forms and/or ballot papers forms ("formulaires") may be obtained, free of charge, at the registered
office of the Company, on the Company's website www.damicointernationalshipping.com (hereinafter, the "Website")
or at BNP Paribas.
Documentation for the Meeting
In full compliance with the laws and regulations in force and applicable to the Company, the required supporting
documentation, the convening notice, the total number of shares and voting rights, the draft resolutions and the proxy
and ballot papers forms are deposited and available to the public at the Company's registered office and on the Website.
The above mentioned set of documents is also filed with Borsa Italiana S.p.A. and CONSOB through the SDIR-NIS
mechanism.
Shareholders may upon request obtain a copy of the full, unabridged text of the documents to be submitted to the
Meeting and draft resolutions proposed to be adopted by the Meeting by electronic means at the address of the Company
indicated below or by postal services at the registered office of the Company.
Right to Put Items on the Agenda and to Table Draft Resolutions
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders holding individually or collectively at least five
per cent (5%) of the share capital of the Company: (a) have the right to put items on the agenda of the Meeting; and (b)
have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the Meeting. Those rights
shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic
means at the addresses of the Company indicated below. The requests shall be accompanied by a justification or a draft
resolution to be adopted in the Meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can
acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders shall be received by the Company at the
latest on 24 March 2015.
Right to Ask Questions
In accordance with the Company's Articles of Association, shareholders shall have the right to ask questions at the
Meeting related to items on the agenda of the Meeting. The Company shall answer the questions put to it by shareholders.
The right to ask questions and the obligation of the Company to answer are subject to the measures to be taken by the
Company to ensure the identification of shareholders, the good order of general meetings and their preparation as well
as the protection of confidentiality and business interests of the Company.
The contact details of the Company are as follows:
Company
d'Amico International Shipping S.A.
25 C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Fax: + 352 26 26 24 54, Email: ir@damicointernationalshipping.com
Attention: Mr. Marco FIORI, CEO / Mrs. Anna FRANCHIN, Investor Relations Manager
32505
L
U X E M B O U R G
The details of the centralising bank mandated by the Company are as follows:
BNP Paribas Securities Services Branch Luxembourg
Corporate Trust Services
33 rue de Gasperich - Howald - Hesperange,
L-2085 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg
Tel: + 352 2696 2518/2407 Fax: + 352 2696 9757
Email: lux.ostdomiciliees@bnpparibas.com
Attention: Lux ost domiciliées, Sabrina DEVERSENNE / Rudolf VOIGTLANDER
Luxembourg, 12 March 2015
<i>The Board of Directors.i>
Référence de publication: 2015038949/267/123.
Carmudi SAUDI ARABIA S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.757.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Middle East Internet (GP) S.à r.l. précité, a également
déménagé son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Carmudi SAUDI ARABIA S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020885/14.
(150024900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Carmudi UAE S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 186.750.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Middle East Internet (GP) S.à r.l. précité, a également
déménagé son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Carmudi UAE S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020886/14.
(150024899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Caroll, succursale Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2721 Luxembourg, 5, rue Alphonse Weicker.
R.C.S. Luxembourg B 194.295.
OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
<i>Extraiti>
Ouverture d'une succursale luxembourgeoise dénommée «Caroll, succursale Luxembourg» située à L-2721 Luxem-
bourg, 5, rue Alphonse Weicker - Centre Commercial Kirchberg,
Par décision en date du 23 janvier 2015, le Conseil d'Administration de la société de droit français CAROLL INTER-
NATIONAL, Société Anonyme au capital de 9'931'887.05 euros, ayant son siège social à F-75 015 Paris, 38, rue du
Hameau, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 582 001 707, a décidé:
- d'ouvrir une succursale luxembourgeoise dénommée «Caroll, succursale Luxembourg» à L-2721 Luxembourg, 5, rue
Alphonse Weicker - Centre Commercial Kirchberg, ayant pour objet:
* l'exploitation de toutes affaires industrielles et/ou commerciales, l'importation, l'exportation, la distribution, la lo-
cation, l'achat, la vente de toutes marchandises, et en particulier, de tous articles de bonneterie, de vêtements
32506
L
U X E M B O U R G
confectionnés, et d'une manière générale de tous articles textiles, et de tous articles de prêt à porter et accessoires, ainsi
que tous articles similaires ou complémentaires,
* la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution, l'achat et la vente de produits de parfumerie, de cosmétique
et d'hygiène, ainsi que de tous articles similaires ou complémentaires,
* la réalisation pour son compte et pour le compte d'autrui, toutes opérations nécessaires pour assurer le dévelop-
pement commercial de la société sur le territoire luxembourgeois;
- de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de représentant permanent de la société CAROLL INTER-
NATIONAL, pour l'activité de la succursale Caroll, succursale Luxembourg, Monsieur Thierry JAUGEAS, administrateur
de sociétés, né le 3 janvier 1959 à Paris XV
ème
(France), demeurant à F-75 016 Paris, 56 rue Michel Ange.
Il a le pouvoir d'engager la société CAROLL INTERNATIONAL à l'égard des tiers et de la représenter en justice pour
l'activité de sa succursale Caroll, succursale Luxembourg par sa signature individuelle.
Par ailleurs, la société CAROLL INTERNATIONAL est engagée à l'égard des tiers et représentée en justice par son
Conseil d'Administration composé par:
- Monsieur José-Antoine APARISI, Président Directeur Général, né le 11 mai 1960 à Lyon 6
ème
(France), demeurant
à F-69 450 Saint Cyr au Mont d'Or, 15 rue Jean et Catherine Reynier.
- La société anonyme de droit français VIVARTE SERVICES, établie et ayant son siège social à F-75 019 Paris, 28 avenue
de Flandre, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 413 157 090, représentée
par Madame Diane JAYLAC, née le 19 février 1977 à Toulouse (France), demeurant à F-92 200 Neuilly-sur-Seine, 34
Boulevard Victor Hugo.
- La société par actions simplifiée de droit français EUROPEENNE DE NEGOCE ANDRE OU E.N.A, établie et ayant
son siège social à F-75 019 Paris, 27/29 quai de Seine, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris
sous le numéro 378 700 819, représentée par Monsieur Jérôme BANIOL, né le 16 avril 1970 à Ganges (France), demeurant
à F-75 008 Paris, 24 rue de l'Arcade.
- La société par actions simplifiée de droit français VIVARTE, établie et ayant son siège social à F-75 019 Paris, 28
avenue de Flandre, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 308 449 024, re-
présentée par Monsieur Thierry JAUGEAS, né le 3 janvier 1959 à Paris XVème (France), demeurant à F-75 016 Paris, 56
rue Michel Ange.
Howald.
Signature.
Référence de publication: 2015020887/46.
(150024803) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Classifieds Asia S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.311.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Asia Internet (GP) S.à r.l. précité, a également déménagé
son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Classifieds Asia S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020894/14.
(150024898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
ClearingHouse for Intellectual Property S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.
R.C.S. Luxembourg B 170.388.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société adoptées le 19 janvier 2015i>
Il résulte des résolutions que:
1. Roger Greden, Jan Jansen, Hans Seeuws et M. Geert Debyser ont démissionné avec effet au 19 janvier 2015 en tant
qu'administrateurs.
2. M. Jan Jansen a démissionné avec effet au 19 janvier 2015 en tant qu'administrateur-délégué A.
3. M. Hans Seeuws a cessé d'occuper la fonction de l'administrateur-délégué B avec effet au 19 janvier 2015 et à partir
de cette date occupera la fonction du délégué à la gestion journalière jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2016.
32507
L
U X E M B O U R G
4. M. Atul PATEL, né à Hyde (Royaume Uni) le 14 avril 1967, demeurant à Manchester Technology Centre, Oxford
Road, Manchester, Ml 7EF, Royaume Uni et M. Robert COTTON, né à Reading (Royaume-Uni) le 15 février 1965,
demeurant à Manchester Technology Centre, Oxford Road, Manchester, M1 7EF, Royaume Uni ont été nommés admi-
nistrateurs de la Société avec effet au 19 janvier 2015. Leur mandat expirera lors de la tenue de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société statuant sur l'approbation des comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2020.
Howald, le 19 janvier 2015.
Pour extrait conforme
Pierre-Alexandre DEGEHET
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015020895/23.
(150024135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Clickbus Bulgaria Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.410.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Clickbus (GP) S.à r.l. précité, a également déménagé
son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Clickbus Bulgaria Holding S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020896/14.
(150024766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Clickbus Czech Repubic Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.412.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Clickbus (GP) S.à r.l. précité, a également déménagé
son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Clickbus Czech Republic Holding S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020897/14.
(150024765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Clickbus Germany Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 182.416.
En date du 1
er
octobre 2014, le siège social de la Société a été transféré du 7, avenue J.P. Pescatore, L-2324 Luxembourg
au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg avec effet immédiat.
En conséquence, l'associé commandité et gérant de la Société, Clickbus (GP) S.à r.l. précité, a également déménagé
son siège social au 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Clickbus Germany Holding S.C.Sp.
Référence de publication: 2015020898/14.
(150024764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32508
L
U X E M B O U R G
"Communications Investments Europe S.à r.l.", Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 34.258,00.
Siège social: L-1648 Luxembourg, 46, place Guillaume II.
R.C.S. Luxembourg B 153.536.
Par résolutions signées en date du 2 février 2015, les associés de la Société ont pris la décision suivante:
- nomination de M Radek Horak, né le 22 décembre 1974 à Prague (République Tchèque), ayant son adresse profes-
sionnelle au Skokanska 1, 169 00 Prague 6 (République Tchèque) en tant que gérant de classe B avec effet au 2 février
2015 et pour une durée indéterminée.
Dès lors, le conseil de gérance se compose ainsi:
<i>Gérants de classe A:i>
Mme Rosa Villalobos
M. Charles Roemers
M. Jean-François Trapp
<i>Gérants de classe B:i>
M. Jiri Zrust
M. Radek Horak
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015020902/22.
(150024331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Concept International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4761 Pétange, 59, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 147.420.
<i>Procès-verbal de la réunion du conseil de gérance tenue à Petange en date du 1 i>
<i>eri>
<i> novembre 2014.i>
Présent: Madame Isabelle PIERSON
<i>Ordre du jouri>
1. Décision concernant le transfert de siège.
<i>Décisionsi>
A l'unanimité, le conseil
DECIDE
De transférer le siège social de la société à compter du 15 novembre 2014.
Le nouveau siège social est fixé au 59 Route de Luxembourg à L-4761 Pétange.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
<i>Pour la société
i>CONCEPT INTERNATIONAL
18 rue de l'Hôtel de Ville
L-4782 PETANGE
Isabelle PIERSON
Référence de publication: 2015020903/22.
(150024084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Cork Supply Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 149.498.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du 15 décembre 2014i>
1. Mlle Stéphanie MEYER a démissionné de son mandat de gérante de catégorie B.
2. M. David SANA, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1974 à Forbach (France), demeurant professionnellement
à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie B pour une durée indéterminée.
32509
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 5 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Cork Supply Group S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015020904/15.
(150024557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Capita Fiduciary S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 117.939.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l’actionnaire unique de la Société en date du 12 décembre 2014 que:
- La démission de Monsieur Bruno BEERNAERTS, administrateur de catégorie A et administrateur délégué de la Société
a été acceptée avec effet au 31 octobre 2014;
- La démission de Monsieur Ian ROBERTS, administrateur de catégorie A, président du conseil d’administration et
administrateur délégué de la Société, a acceptée avec effet au 31 octobre 2014;
- La démission de Monsieur Alain LAM L.C.K., administrateur de catégorie B de la Société a été acceptée avec effet
au 31 octobre 2014;
- La démission de Monsieur Philippe SALPETIER, délégué à la gestion journalière de la Société été acceptée avec effet
au 31 octobre 2014;
- Monsieur Eric MAGRINI, né le 20 mars 1963 à Luxembourg, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg a été nommé administrateur de catégorie A et administrateur délégué à la gestion journalière de la
Société, avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2017;
- Madame Aurore CALVI, née le 6 avril 1973 à Luxembourg, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310
Luxembourg, a été nommée délégué à la gestion journalière de la Société, avec effet immédiat et ce jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire de l’année 2017; et
- Monsieur Jean Noël LEQUEUE, né le 18 décembre 1946 à Lincent (Belgique), résidant professionnellement au 30,
Chemin du bois des Paresseux B-6700 Arlon a été nommé Président du Conseil d’administration de la Société avec effet
immédiat et ce jusqu’à l’assemblée générale ordinaire de l’année 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 30 décembre 2014.
Référence de publication: 2015020906/29.
(150024605) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Comquest Luxembourg, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 12-14, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 117.560.
L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Par devant le soussigné Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à LUXEMBOURG, Grand-duché de Lu-
xembourg, s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de COMQUEST LUXEM-
BOURG, une société à responsabilité limitée dont le siège social se situe au 12-14 rue de Strasbourg L-2560
LUXEMBOURG, Grand-duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 117.560 (la Société).
La Société a été constituée le 05 juillet 2006, suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence
à Sanem, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1669 du 4 septembre 2006, modifiée pour
la dernière fois suivant acte reçu par Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 25 novembre
2008, publié audit Mémorial C, numéro 27 du 7 janvier 2009.
L'Assemblée a été présidée par Alain MEURISSE, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme Jean-Paul FELIX, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 11,
avenue de la Gare comme secrétaire.
L'Assemblée nomme Jean-Paul FELIX, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1611 Luxembourg, 11,
avenue de la Gare comme scrutateur.
Le bureau de l’Assemblée ayant été formé, le président déclare et requiert le notaire d'acter:
32510
L
U X E M B O U R G
I. Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence signée par chaque actionnaire présent ou son représentant, le bureau de l’Assemblée et le notaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations seront enregistrées avec le présent acte;
II. Qu'il ressort de la liste de présence que la majorité des actions est représentée. L'Assemblée est par conséquent
régulièrement constituée et peut délibérer et décider sur les points de l’ordre du jour ci-dessous:
III. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Dissolution de la société;
2. Nomination du liquidateur;
3. Pouvoirs du liquidateur;
4. Instructions au liquidateur.
IV. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de dissoudre la société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer Monsieur Aymeric MANGENEY ayant son domicile au 2, place du Poulinat F-91370
VERRIERES LE BUISSION (France) en tant que liquidateur (le Liquidateur). Le Liquidateur est autorisé à accomplir, sous
sa seule signature, tout ce qui est nécessaire à la liquidation de la Société et à la réalisation de ses actifs.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi luxem-
bourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi).
Le Liquidateur est autorisé à passer tous les actes et à exécuter toutes les opérations, y compris celles prévues à
l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable des actionnaires. Le Liquidateur peut déléguer, sous sa seule responsa-
bilité, certains de ses pouvoirs, pour des opérations ou des tâches spécifiquement définies, à une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Le Liquidateur est autorisé à verser aux actionnaires des acomptes sur le boni de liquidation, à condition que des
comptes intérimaires soient établis.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'autoriser le Liquidateur à procéder dans les meilleures conditions à la réalisation de l’actif et au
paiement de toutes les dettes de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société en raison du présent acte
notarié s'élèvent approximativement à six cent cinquante euros (EUR 650,-).
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l’étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par nom, prénoms usuels, état
et demeure, ils ont tous signé le présent acte avec le notaire.
Signé: MEURISSE, FELIX, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 117. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015020946/64.
(150024173) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
CORNALINE S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 156.294.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 20 janvier 2015i>
Le Conseil d'administration a nommé Orangefield (Luxembourg) S.A., ayant son siège social 40, avenue Monterey à
L-2163 Luxembourg, agent dépositaire des actions au porteur de la Société.
32511
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 20 janvier 2015.
Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015020948/14.
(150024422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
CPI Digiplex S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.891.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 3 décembre 2014 à 14h00i>
L'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement accepte la démission de Monsieur Chris DE MESTRE,
Gérant A, et décide de nommer en remplacement comme gérant A pour une durée illimitée:
Monsieur Shaun Collins, né le 23 mai 1968 à Hinckley (Royaume-Uni)
25, St. George Street, Londres W1S IFS Royaume-Uni
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015020951/14.
(150024098) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren s.a., Société Anonyme.
Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 72-74, rue du Canal.
R.C.S. Luxembourg B 194.263.
STATUTS
L’an deux mille quinze, le vingt-deux janvier.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
Ont comparu:
Madame AMADO FIGUEIREDO Fatima, née le 19 juin 1969 à Figueira Da Foz (P), demeurant à L-3250 Bettembourg,
41, rue de Kleinsch.
Monsieur CARISSIMI Philippe, né le 5 avril 1967 à Metz (F), demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 12, rue Paul
Claudel.
Madame DUMONT Karine, née le 13 février 1975 à Vesoul (F), demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 13, rue
Général Giraud.
Madame FIRMIN Florence, née le 15 janvier 1968 à Poitiers (F), demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 12, rue Paul
Claudel.
Lesquels sont ici représentés par Monsieur Antonio José DA SILVA ANTUNES, comptable, demeurant profession-
nellement à L-9175 Niederfeulen, 17B, rue de la Fail
En vertu d’une procuration sous seing privé datée du 20 janvier 2015 à Esch/Alzette, laquelle procuration après avoir
été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent acte pour être enre-
gistrée avec lui,
Lesquels comparant, représentés ès-qualité, ont requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société ano-
nyme qu'ils vont constituer, comme suit:
Art. 1
er
. La société anonyme prend la dénomination de «D.P.K. GROUPE KICHEN, FENSTEREN & DIEREN s.a.»
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune d’Esch-sur-Alzette.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’achat, la vente, l’importation et l’exportation de tous matériels mobiliers de cuisines,
fenêtres et portes fenêtre, climatisation et tout ce qui s’y rapporte.
Elle est autorisée à exécuter toute vente et toute prestation de service se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
32512
L
U X E M B O U R G
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu'à l’étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision des actionnaires.
Art. 5. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (31.000.) euros, représenté par mille (1000) actions, d’une
valeur nominale de trente et un (31,-) euros, chacune.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l’actionnaire, à l’exception de celles pour lesquelles la loi
prescrit la forme nominative.
Les actions de la société peuvent être créées, au choix du propriétaire, en titres unitaires ou en certificats représentatifs
de plusieurs actions.
En cas d’augmentation du capital social les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes que ceux dont
jouissent les actions anciennes.
La société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.
Art. 6. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois,
lorsque la société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est
constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un
(1) membre jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, ils sont rééligibles et toujours révo-
cables.
En cas de vacance d’une place d’administrateur nommée par l’assemblée générale, les administrateurs restants ainsi
nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède
à l’élection définitive.
Art. 7. Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet
social; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
Lorsque la société compte un seul administrateur, il exerce les pouvoirs dévolus au conseil d’administration.
Le Conseil d’administration devra choisir en son sein un président, en cas d’absence du président, la présidence de la
réunion sera conférée à un administrateur présent.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peuvent être donné par écrit, télégramme ou télex, étant admis. En cas d’urgence, les admi-
nistrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex ou télécopieur.
Le Conseil d’administration pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son ap-
probation au moyen d’un ou de plusieurs écrits, par courrier ou par courrier électronique ou par télécopie ou par tout
autre moyen de communication similaire, à confirmer le cas échéant par courrier, le tout ensemble constituant le procès-
verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Les décisions du Conseil d’administration sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui
préside la réunion est prépondérante.
La gestion journalière de la société ainsi que la présentation de la société en ce qui concerne cette gestion pourront,
conformément à l’article 60 de la Loi, être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres
agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs attributions seront
réglées par une décision du conseil d’administration. La délégation à un membre du conseil d’administration impose au
conseil l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et
avantages quelconques alloués au délégué.
Exceptionnellement, la ou les premières personnes auxquelles sera déléguée la gestion journalière de la société pour-
ront le cas échéant être nommées par la première assemblée générale extraordinaire suivant la constitution.
La société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.
La société se trouve engagée soit par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute
(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d’administration.
Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société sera engagée par sa seule signature.
Art. 8. La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés pour
une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables.
Art. 9. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.
32513
L
U X E M B O U R G
Art. 10. L’assemblée générale annuelle se réunit le quinzième jour du mois de mai à 14h00 heures au siège social ou
à tout autre endroit à désigner par les convocations.
Si ce jour est un jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.
Art. 11. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne
sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l’ordre de jour.
Le Conseil d’administration peut décider que pour pouvoir assister à l’assemblée générale, le propriétaire d’actions
doit en effectuer le dépôt cinq jours francs avant la date fixée pour la réunion; tout actionnaire aura le droit de voter en
personne ou par mandataire, actionnaire ou non.
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 12. L’assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui
intéressent la société.
Elle décide de l’affectation et de la distribution de bénéfice net.
Le Conseil d’administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions pre-
scrites par la loi.
Art. 13. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur
application partout où il n’y est dérogé par les présents statuts.
<i>Dispositions transitoiresi>
1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.
2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en l’an 2016.
<i>Souscription et libérationi>
Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, les comparants préqualifiés déclarent souscrire les actions de la manière
suivante:
1. Madame Karine Dumont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
2. Monsieur Philippe Carissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400 actions
3. Madame Fatima Amado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
4. Madame Florence Firmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 actions
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions
Les actions ont été entièrement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de trente et un mille
euros (31.000,00) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.
<i>Déclarationi>
Le notaire-rédacteur de l’acte déclare avoir vérifié l’existence des conditions énumérées à l’article 26 de la loi du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales, et en constate expressément l’accomplissement.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s’élève approximativement à la somme de neuf cent euros (900.-
€).
<i>Déclaration du comparanti>
Le(s) associé(s) déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par la suite, être
le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifie(nt) que les fonds/biens/ droits servant à la
libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant
une infraction visée aux articles 506-1 du Code pénal et 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis à l’article
135-5 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Assemblée Générale Extraordinairei>
Et à l’instant les parties comparantes préqualifées, représentant l’intégralité du capital social, se sont constitués en
assemblée générale extraordinaire à laquelle elles se reconnaissent dûment convoquées, et après avoir constaté que celle-
ci était régulièrement constituée, elles ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Le nombre des administrateurs est fixé à trois (3) et celui des commissaires à un (1).
32514
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolutioni>
Sont appelés aux fonctions d’administrateur:
a) Madame DUMONT Karine, née le 13 février 1975 à Vesoul (F), demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 13, rue
Général Giraud.
b) Monsieur CARISSIMI Philippe, né le 5 avril 1967 à Metz (F), demeurant à F-57950 Montigny les Metz, 12, rue Paul
Claudel.
c) Madame AMADO FIGUEIREDO Fatima, née le 19 juin 1969 à Figueira Da Foz (P), demeurant à L-3250 Bettembourg,
41, rue de Kleinsch.
<i>Troisième résolutioni>
Est nommée commissaire aux comptes: Prestasud s.à r.l., ayant son siège à L-4037 Esch-sur-Alzette, 13, rue Bolivar,
inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B21975.
<i>Quatrième résolutioni>
Le mandat des administrateurs et commissaire prendra fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2021.
<i>Cinquième résolutioni>
L’assemblée nomme pour un terme prenant fin à l’issue de l’assemblée générale ordinaire de l’an 2021, Madame
AMADO FIGUEIREDO Fatima, préqualifiée, comme administrateur-délégué.
La société sera engagée par la signature conjointe de l’administrateur-délégué et d’un administrateur.
<i>Sixième résolutioni>
Le siège social de la société est fixé à L-4051 Esch-sur-Alzette, 72-74, rue du Canal.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Antonio José DA SILVA ANTUNES, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 23 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1219. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015020954/167.
(150024199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
D.R.M. Toitures S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4408 Belvaux, 82, rue Waassertrap.
R.C.S. Luxembourg B 122.889.
Il résulte de 'Assemblée Générale Extraordinaire 28 janvier 2015 que
Monsieur MEDAKOVIC Rajko, demeurant 39A chemin du camping L-9022 ETTELBRUCK, détient 80 parts sociales
de la société.
Monsieur MEDAKOVIC Drago, demeurant 10 avenue Lucien Salentiny L-9080 ETTELBRUCK, détient 20 parts sociales
de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015020955/14.
(150024447) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
DreiP AG, Société Anonyme.
Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 139.791.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreißigsten Dezember.
Vor Uns Roger ARRENSDORFF, Notar im Amtssitze zu Luxemburg.
32515
L
U X E M B O U R G
Ist erschienen:
- Jörg PRÜßMEIER, Consultant, wohnhaft in D-60322 Frankfurt am Main, Auf der Körnerwiese,4,
hier vetreten durch Marc KERNEL, Buchhalter, geschäftsansässig zu L-5532 Remich, 6, rue Enz, aufgrund einer Voll-
macht.
welche Vollmacht nach ne varietur Unterzeichnung durch den Komparenten und den amtierenden Notar gegenwär-
tiger Urkunde als Anlage beigelegt bleibt um mit derselben eingeschrieben zu werden
handelnd in seiner Eigenschaft als alleiniger Aktieninhaber der Gesellschaft DreiP AG, mit Sitz zu L-8017 Strassen, 18,
rue de la Chapelle, gegründet gemäss Urkunde aufgenommen vor Notar Paul BETTINGEN aus Niederanven am 14. Mai
2008, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, Nummer 1782 vom 18. Juli 2008, welche
Statuten seither nicht abgeändert wurden, eingetragen im Handelsregister unter der Nummer B 139.791.
Sodann hat der Komparent, vertreten wie hirvor erwähnt, den Notar ersucht um seine Erklärungen und Feststellungen
wie folgt zu beurkunden:
1) Dass die Gesellschaft "DreiP AG" gegründet wurde wie hiervor erwähnt.
2) Dass das Gesellschaftskapital vorgenannter Gesellschaft EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000,-EUR) be-
trägt, eingeteilt in DREITAUSENDEINHUNDERT (3100) Aktien von je ZEHN EURO (10,-EUR).
3) Dass der Komparent alleiniger Eigentümer der genannten Gesellschaft ist, welche das gesamte Gesellschaftskapital
von EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000.-EUR) darstellen und dementsprechend den ausdrücklichen Wunsch
äussert die Gesellschaft aufzulösen und sich bereit erklärt alle Aktiva und Passiva der Gesellschaft zu übernehmen und
für allfällige Schulden aufzukommen und dass somit dieselbe vollständig liquidiert ist.
4) Er ernennt sich selbst zum Liquidator.
5) Sodann erteilt der Komparent dem Verwaltungsratsmitglied der aufgelösten Gesellschaft Entlastung.
6) Die Geschäftsbücher der aufgelösten Gesellschaft werden für die Dauer von fünf (5) Jahren in D-60322 Frankfurt
am Main, Auf der Körnerwiese,4, hinterlegt.
7) Dass der alleinige Aktieninhaber der wirklich Berechtigte des Gesellschaftskapitals ist, welche Gelder aus keiner
Straftat entstammen.
Worüber Urkunde, Errichtet wurde zu Luxemburg, in der Amtsstube.
Nach Vorlesung alles Vorstehenden an den Bevollmächtigten des Komparenten, hat derselbe mit dem Notar gegen-
wärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: KERNEL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 120. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015020957/44.
(150024243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Dridco Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.832.
<i>Extrait des décisions prises par l'assemblée générale de l'actionnaire unique tenue extraordinairement et par le conseil d'adminis-i>
<i>tration en date du 27 janvier 2015i>
1. Monsieur Alejandro Julio SAGUIER a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie A.
2. Monsieur Gerardo SCHLOSSBERG a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie A.
3. Monsieur Guilherme DORING DA CUNHA PEREIRA a démissionné de son mandat d'administrateur de catégorie
A.
4. Madame Valérie PECHON a démissionné de son mandat de présidente du conseil d'administration et son mandat
d'administrateur de catégorie B est confirmé.
5. Monsieur Nicolás TEJERINA, administrateur de sociétés, né à Buenos Aires (Argentine), le 13 février 1974, de-
meurant à Humboldt 1550, 2
nd
floor, suite 201, Buenos Aires, Argentine 1414CTN, a été nommé comme administrateur
de catégorie A pour une durée qui expira à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
6. Monsieur Emilio Alfredo GOMIZELJ, administrateur de sociétés, né à Buenos Aires (Argentine), le 13 août 1970,
demeurant à Humboldt 1550, 2
nd
floor, suite 201, Buenos Aires, Argentine 1414CTN, a été nommé comme adminis-
trateur de catégorie A pour une durée qui expira à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
32516
L
U X E M B O U R G
7. Le nombre des administrateurs a été diminué de 6 (six) à 5 (cinq).
8. Monsieur Nicolás TEJERINA, a été nommé comme président du conseil d'administration pour une durée qui expira
à l'issue de l'assemblée générale statutaire de 2016.
Luxembourg, le 04 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Dridco Luxembourg S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015020958/28.
(150024139) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Da Costa Almeida S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4384 Ehlerange, 34, Zone Industrielle Ilot Ouest.
R.C.S. Luxembourg B 50.277.
L'an deux mille quinze, le quatre février
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.
A comparu:
1. Madame Maria de Fatima TEIXEIRA DOS SANTOS, née le 10 mai 1964 à Rio de Janeiro (Brésil), demeurant à L-4720
Pétange, 3, rue de la Chiers,
agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire spécial de
2. Monsieur Leonel DA COSTA DE ALMEIDA, né le 05 mai 1942 à Mundão (Portugal), demeurant à L-4720 Pétange,
3, rue de la Chiers,
en vertu d'un pouvoir sous seing-privé lui délivré; lequel pouvoir, après avoir été signé ne varietur par son porteur et
le notaire soussigné, restera annexé aux présentes aux fins de formalisation.
Lesquels comparants déclarent être les seuls associés de la société à responsabilité limitée «DA COSTA ALMEIDA
S.à r.l.», établie et ayant son siège social à L-4720 Pétange, 3, Rue de la Chiers,
constituée suivant acte reçu par Maître Emile Schlesser, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 6 février 1995,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 256 du 13 juin 1995
Ensuite les comparants, agissant en leurs dites qualités, représentant l’intégralité du capital social, ont pris à l’unanimité
la résolution suivante:
<i>Résolution uniquei>
Les associés décident de changer le siège social de la société de L-4720 Pétange, 3, rue de la Chiers à L-4384 Ehlerange,
34, Zone Industrielle Ilot Ouest, et de modifier en conséquence le premier alinéa de l’article 5 des statuts pour lui donner
la teneur suivante:
" Art. 5. Le siège est établi dans la commune de Sanem.".
L'autre alinéa de l’article 5 reste inchangé.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société.
Plus rien d'autre ne se trouvant à l’ordre du jour, la comparante a déclaré close la présente assemblée.
DONT ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, en l’étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, elle a signé le présent procès-verbal avec le notaire.
Signé: TEIXEIRA DOS SANTOS, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 05/02/2015. Relation: EAC/2015/2980. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): SANTIONI.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Esch-sur-Alzette, le 06 février 2015.
Référence de publication: 2015020961/40.
(150024532) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32517
L
U X E M B O U R G
Denise Invest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 154.245.
<i>Extrait de la résolution de l'administrateur unique prise en date du 03 février 2015i>
En date du 03 février 2015, l'administrateur unique a pris la résolution suivante:
- Nomination de la société ACCOUNTIS S.à r.l., en sa qualité d'experts-comptables, ayant son siège social au 63-65,
rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro B- 60.219 en tant qu'agent dépositaire.
Le 05 février 2015.
Référence de publication: 2015020971/13.
(150024430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
iBondis Capital Holdings, Société Anonyme.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 194.261.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-seventh day of January.
Before Me Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert (Grand Duchy of Luxembourg), acting
in replacement of her prevented colleague Me Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of
Luxembourg), who last named shall remain depositary of the present deed.
There appeared:
1.- Mr Christian NOTHACKER, CEO, born in Bad Soden am Taunus (Germany) on the 27
th
of May 1989 residing in
Via Cosliva 36, 6926 Montagnola, Switzerland
2.- Mr Alessandra FELISI, COO, born in Sorengo (Switzerland) on the 27
th
of July 1989 residing in Via Ceresio 9, 6963
Pregassona, Swizerland,
3.- Mr Ram CHAWLA, CTO, born in London (UK) on the 25
th
of March 1988 residing in 101 Cavendish Avenue,
Harrow, Middlesex, HA1 3RF UK,
here represented by Mr Max MAYER, employee, residing professionally in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of powers of attorney delivered to him, which after being signed “ne varietur” by the empowered and the officiating
notary shall remain attached to the present deed.
Said proxy after having been initialed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary shall remain attached
to the present deed.
The appearing party, represented as above, has requested the undersigned notary, to state as follows the articles of
incorporation of a private company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “iBondis Capital Holdings” (the Company).
The Company is a private company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended from time to time
(the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred to any other place within the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors (the Board),
and to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholder, acting in accordance
with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events
have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the
Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the regis-
tered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary
measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, remains a Luxembourg incorporated company.
32518
L
U X E M B O U R G
Art. 3. Corporate object.
3.1. The object of the Company is the acquisition of participations, interests and units, in Luxembourg or abroad, in
any form whatsoever and the management of such participations, interests and units. The Company may in particular
acquire by subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities,
bonds, debentures, certificates of deposit and other debt instruments and more generally any securities and financial
instruments issued by any public or private entity whatsoever.
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement
only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including
the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or companies in which it has a direct
or indirect interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any
affiliated company belonging to the same group as the Company (hereafter referred as the “Connected Companies”). It
may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its
Connected Companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over all or
over some of its assets
3.3. The Company may further invest in the acquisition and management of a portfolio of patents and/or other intel-
lectual property rights of any nature or origin whatsoever.
3.4. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to its investments for the purpose
of their efficient management, including techniques and instruments designed to protect the Company against credit,
currency exchange, interest rate risks and other risks.
3.5. The Company may carry out any commercial and/or financial transactions with respect to direct or indirect
investments in movable and immovable property including but not limited to acquiring, owning, hiring, letting, leasing,
renting, dividing, draining, reclaiming, developing, improving, cultivating, building on, selling or otherwise alienating, mort-
gaging, pledging or otherwise encumbering movable or immovable property.
3.6. The above description is to be understood in the broadest senses and the above enumeration is not limiting.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy
or any similar event affecting one or several shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at seventy thousand euro (EUR 70,000.-), represented by one hundred thousand (100,000)
ordinary shares in registered form, without par value.
5.2. The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. Shares are only transferable as described in the Shareholders agreement.
6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for
that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company’s share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of directors.
7.1. The Company is managed by a board of directors composed of one or more director(s) (the Board), who need
not to be shareholders. The directors are appointed and designated as director class A or director class B by a resolution
of the shareholders which sets the term of their office. The directors shall be elected for a term not exceeding six years
and shall be re-elective.
7.2 When a legal person is appointed as a director of the Company (the Legal Entity), the Legal Entity must designate
a permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as member of the Board in
accordance with article 51bis of the Law.
7.3 The directors shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the
director’s remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced,
at any time, by resolution adopted by the General Meeting.
7.4 In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors
appointed by the shareholders’ meeting may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General
Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and
held to appoint new directors
32519
L
U X E M B O U R G
Art. 8. Board of directors.
8.1. Powers of the board of directors
All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or
not, by the single director, or if there are more than one director, by the joint signatures of any two directors.
8.2. Procedure
The Board shall appoint a chairman (the Chairman) amongst its members and may choose a secretary, who need not
be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions
passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all
meetings of the Board and any General Meeting.
The board of directors shall meet as often as the Company’s interests so requires or upon call of the Chairman or
any two directors at the place indicated in the convening notice.
Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least seven (7) days in advance, except in case
of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
No such notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full
knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a
meeting, whether in original, by fax or e-mail received in circumstances allowing to confirm the identity of the sender.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.
A director may grant a power of attorney to another director in order to be represented at any meeting of the Board.
Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of
communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The parti-
cipation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present in person or via any of the means
described above or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors
present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the directors present or their
representative at the meeting.
8.3. Circular resolutions
Circular resolutions signed by all the directors (the Directors Circular Resolutions), are valid and binding as if passed
at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.
8.4. Representation
The Company will be bound in all circumstances (i) by the individual signature of the sole director and (ii) in case more
than one director has been appointed, by the joint signatures of any two directors of the Company, one of which is to
be a director of class A, or (iii), as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory
power has been validly delegated in accordance with article 8.1. of these Articles.
Art. 9. Sole director. If the Company is managed by a sole director, any reference in the Articles to the Board or the
directors is to be read as a reference to such sole director, as appropriate. The mention of classes A and B is, in this
event, obsolete.
Art. 10. Liability of the directors. The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any
commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles
and the Law.
Art. 11. Conflict of interests. No contract or other transaction between the Company and any other company or firm
shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested
in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.
Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with
which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such
other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such
contract or other business.
In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the
Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or
vote upon any such transaction, and such transaction, and such director’s interest therein, shall be reported to the next
following annual General Meeting.
The preceding paragraph does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary
course of business of the Company which are entered into on arm’s length terms.
32520
L
U X E M B O U R G
IV. Shareholder(s)
Art. 12. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
12.1. Powers and voting rights
Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the General Meeting) or by way of
circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).
Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent
to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders
to be taken into account according to Art. 12.2 (vii) are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened
and held and bear the date of the last signature.
Each share entitles to one (1) vote.
12.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any director or
shareholders representing more than one-half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of
the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.
(iii) The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of
the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified
in the convening notice of the meeting, on May 15
th
, of each year at 10.00 a.m. If such day is a day which is not a business
day for banks in Luxembourg generally, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.
(iv) Other General Meetings are held at such place and time specified in the respective convening notice.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the
agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by
shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
(viii) The Articles are amended with the consent of a majority in number of shareholders owning at least three-quarters
of the share capital.
(ix) For the increase of the share capital of the Company, the rules of the Law shall apply.
Art. 13. Sole shareholder. If and as long as there is a sole shareholder of the Company, the Company shall exist as a
single shareholder company, pursuant to the Law. The sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to
the General Meeting.
Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions
is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 14. Financial year and approval of annual accounts.
14.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
14.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating
the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the debts
of the director(s) and shareholders towards the Company.
14.3. Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.
14.4. The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Share-
holders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.
Art. 15. Statutory Auditor.
15.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s) aux
comptes), when so required by law.
15.2. The shareholders appoint the commissaire aux comptes, and determine their number, remuneration and the
term of their office, which may not exceed six (6) years. The commissaire aux comptes may be re-appointed. He may be
removed at any time by the General Meeting with or without cause.
32521
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Allocation of profits.
16.1. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This
allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share
capital.
16.2. The shareholders determine how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance
to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.
16.3. Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
(i) interim accounts are drawn up by the Board;
(ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for
distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distri-
butable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
(iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the shareholders within two (2) months from the
date of the interim accounts;
(iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company;
and
(v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders
must refund the excess to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17.
17.1. The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted by the shareholders
holding three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be sha-
reholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided
by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.
17.2. The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the shareholders
in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
Art. 18.
18.1. Notices and communications are made or waived and the Directors Circular Resolutions as well as the Share-
holders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, fax, e-mail or any other means of electronic
communication.
18.2. Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
18.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Directors Circular Resolutions or the Shareholders Circular
Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which
taken together constitute one and the same document.
Art. 19. Amendments. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary General Meeting,
subject to the quorum and majority requirements referred to in the Law.
Art. 20. Applicable law. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law
as defined in Article 1.
<i>Transitory provisioni>
The first financial year begins on the date of this deed and ends on December 31, 2015.
The first annual General Meeting will be held in 2016.
<i>Subscription and paymenti>
The Appearing acting as said before, declare to subscribe to the one hundred thousand (100,000) shares as follows:
Shareholder
Number
of Shares
1.- Mr Christian NOTHACKER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,300
2.- Mr Alessandra FELISI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,700
3.- Mr Ram CHAWLA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100,000
The amount of seventy thousand euro (EUR 70,000.-) is at the disposal of the Company, evidence of which has been
given to the undersigned notary.
32522
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,400.-.
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, the shareholders of the Company, representing the entire sub-
scribed capital, have passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as directors of the Company for a period ending at the issue of the annual
General Meeting approving the annual accounts for the period ending 31 December 2019:
- Mr Ralph BOURGNON, chartered accountant, residing professionally in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy
- Mr Ronald WEBER, chartered accountant, residing professionally in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, and
Mr Christian NOTHACKER, CEO, born in Bad Soden am Taunus (Germany) on the 27
th
of May 1989 residing in Via
Cosliva 36, 6926 Montagnola, Switzerland
2. The following legal entity is appointed as statutory auditor (commissaire aux comptes) until the annual General
Meeting approving the annual accounts for the period ending 31 December 2019:
Compliance & Control, having its registered office at L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, filed at the Companies
and Trade Register of Luxembourg, section B, under the Number 172.482.
3. The registered office of the Company is set at L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that, on the request of the appearing parties, this
deed is drawn up in English, followed by a German version and, in case of divergences between the English text and the
German text, the English text prevails.
WHEREOF this deed was drawn up in Junglinster, on the day stated above.
This deed has been read to the representatives of the appearing parties, and signed by the latter with the undersigned
notary.
Follows the German translation of the foregoing text:
Im Jahre zweitausend fünfzehn, am siebenundzwanzigsten Januar.
Vor uns Notar Danielle KOLBACH, mit Amtssitz in Redange-sur-Attert, Grossherzogtum Luxemburg, handelnd in
Vertretung ihres verhinderten Kollegen Notar Jean SECKLER, mit Amtssitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg,
welch letztgenannter Depositar der Urkunde bleibt.
Sind erschienen:
1.- Herr Christian NOTHACKER, CEO, geboren in Bad Soden am Taunus (Deutschland) am 27. Mai 1989, wohnhaft
in Via Cosliva 36, 6926 Montagnola, (Schweiz)
2.- Herr Alessandra FELISI, COO, born in Sorengo (Schweiz), am 27. Juli 1989, wohnhaft in Via Ceresio 9, 6963
Pregassona (Schweiz, und
3.- Herr Ram CHAWLA, CTO, geboren in London (Vereinigtes Königreich), am 25. März 1988 wohnhaft in 101
Cavendish Avenue, Harrow, Middlesex, HA1 3RF (Vereinigtes Königreich),
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, Angestellter, berufsansässig in Junglinster, 3, route de Luxembourg, auf Grund
von privatschriftlichen Vollmachten.
Die oben aufgeführten Vollmachten werden, nachdem sie durch den Vollmachtnehmer und den unterzeichneten Notar
"ne varietur" paraphiert wurden, zusammen mit den Gesellschaftssatzungen zur Einregistrierung vorgelegt.
Die Komparenten, handelnd wie erwähnt, ersuchen den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihnen zu gründ-
enden Aktiengesellschaft wie folgt zu beurkunden.
I. Benennung - Sitz - Dauer - Gesellschaftszweck - Kapital
Art. 1. Name. Der Name der Gesellschaft ist “iBondis Capital Holdings” (die Gesellschaft). Die Gesellschaft ist eine
Aktiengesellschaft (société anonyme) nach Luxemburgischem Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in jeweils aktueller Fassung (das Gesetz), sowie dieser Gründungssatzung (die Satzung).
Art. 2. Sitz der Gesellschaft.
2.1 Der Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Er kann, durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates, an jede
andere Adresse innerhalb der Gemeinde Luxemburg verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann durch Beschluss der
Generalversammlung, unter der Beachtung der Bestimmungen über die Änderung der Satzung, an jeden beliebigen Ort
im Großherzogtum Luxembourg verlegt werden.
2.2 Zweigstellen, Tochtergesellschaften oder weitere Büros können im Großherzogtum Luxembourg oder im Ausland
durch einfachen Beschluss des Verwaltungsrates errichtet werden. Sollte der Verwaltungsrat feststellen, dass die normale
32523
L
U X E M B O U R G
Geschäftstätigkeit am Gesellschaftssitz oder der reibungslose Verkehr mit dem Sitz oder von diesem Sitz mit dem Ausland
durch außergewöhnliche Ereignisse politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Art gefährdet werden, so kann der Gesell-
schaftssitz vorübergehend und bis zur völligen Wiederherstellung normaler Verhältnisse ins Ausland verlegt werden.
Diese einstweilige Maßnahme betrifft jedoch in keiner Weise die Nationalität der Gesellschaft, die unabhängig von dieser
einstweiligen Verlegung des Gesellschaftssitzes, luxemburgisch bleibt.
Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist die Übernahme von Beteiligungen, Anteilen und Anteilsscheinen in Luxemburg oder
im Ausland in jeder Form gleich welcher Art sowie die Verwaltung dieser Beteiligungen, Anteile und Anteilsscheine. Die
Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Kauf, Tausch oder in sonstiger Weise Aktien, Anteile und andere
Kapitalbeteiligungen, Anleihen, Schuldtitel, Einlagenzertifikate und andere schuldrechtliche Wertpapiere und im allgemei-
neren Sinne alle Wertpapiere und Finanzinstrumente erwerben, die von einer Publikums- oder privaten Gesellschaft gleich
welcher Art ausgegeben wurden.
3.2. Die Gesellschaft kann Mittel in jeder Form außer über ein öffentliches Zeichnungsangebot aufnehmen. Sie kann
ausschließlich im Wege einer Privatplatzierung Wechsel, Anleihen und Schuldtitel sowie Schuldverschreibungen und/oder
Anteilspapiere emittieren. Die Gesellschaft kann Mittel, einschließlich der Erlöse von Mittelaufnahmen und/oder Emissi-
onen von Wertpapieren, an ihre Tochtergesellschaften oder an Unternehmen ausleihen, an denen sie unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, auch wenn diese Beteiligung nicht erheblich ist, oder an Gesellschaften, die direkter oder indirekter
Gesellschafter der Gesellschaft oder einer zur gleichen Gruppe wie die Gesellschaft gehörenden Konzerngesellschaft sind
(nachfolgend die “verbundenen Unternehmen”). Sie kann des Weiteren Garantien gewähren und Sicherheiten zugunsten
Dritter stellen, um deren Verpflichtungen oder die Verpflichtungen ihrer verbundenen Unternehmen zu besichern. Die
Gesellschaft kann darüber hinaus ihr Vermögen ganz oder teilweise verpfänden, übertragen, belasten oder in sonstiger
Weise Sicherheiten dafür schaffen.
3.3. Die Gesellschaft kann des Weiteren in Erwerb und Management eines Portfolios von Patenten und/oder sonstigen
geistigen Schutzrechten gleich welcher Art oder Herkunft investieren.
3.4. Die Gesellschaft kann im Allgemeinen alle Methoden und Instrumente für ihre Investitionen zum Zwecke des
effizienten Managements derselben einsetzen, darunter auch Methoden und Instrumente, mit denen die Gesellschaft gegen
Kredit-, Währungs-, Zins- und andere Risiken abgesichert werden kann.
3.5. Die Gesellschaft kann wirtschaftliche und/oder finanzielle Geschäfte im Zusammenhang mit direkten oder indi-
rekten Anlagen in bewegliches Vermögen und Immobilien abschließen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Erwerb,
Eigentum, Anmietung, Vermietung, Leasing, Verleih, Teilung, Abschöpfung, Rückforderung, Entwicklung, Umbau, Kulti-
vierung, Erweiterung, Verkauf oder sonstige Veräußerung, hypothekarische Beleihung, Verpfändung oder Belastung in
anderer Weise von beweglichem Eigentum oder Immobilien.
3.6. Die vorgenannte Beschreibung ist im weitesten Sinne zu verstehen und die vorstehende Aufzählung erhebt keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Art. 4. Dauer.
4.1 Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
4.2 Die Gesellschaft wird nicht durch Tod, Aufhebung ziviler Rechte, Unmöglichkeit, Insolvenz, Bankrott oder eines
vergleichbaren Ereignisses in der Person eines Gesellschafters aufgelöst.
II. Gesellschaftskapital - Aktien
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt EUR 70.000,- (siebzig tausend Euro) eingeteilt in einhundert tausend
(100.000) Stammaktien in eingetragener Form, ohne Nennwert.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann einmalig oder mehrfach durch Beschluss der Eigentümer angehoben oder herabge-
setzt werden, wofür die Bedingungen für die Änderung der Satzung gelten.
Art. 6. Aktien.
6.1 Die Aktien sind nicht teilbar und die Gesellschaft akzeptiert nur einen Eigentümer pro Aktie.
6.2 Die Aktien sind zwischen den Eigentümern transferierbar wie dies in der Aktionärsvereinbar vorgesehen ist.
6.3 Ein Gesellschafterregister wird an der offiziellen Anschrift der Gesellschaft geführt und kann von jedem Gesell-
schafter auf Anfrage eingesehen werden.
6.4 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien erwerben, sofern sie ausreichend verfügbare Reserven für diesen Zweck
hat oder wenn der Erwerb auf einer Kapitalreduzierung beruht.
III. Verwaltung - Überwachung
Art. 7. Berufung und Abberufung der Direktoren.
7.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus einem oder mehreren Direktoren besteht,
die keine Aktionäre sein müssen. Die Direktoren werden von der Gesellschafterversammlung als Direktoren der Klasse
32524
L
U X E M B O U R G
A oder der Klasse B ernannt welche ihren Berufungszeitraum bestimmt. Dieser Berufungszeitraum darf sechs Jahre nicht
überschreiten, jedoch sind die Direktoren wiederwählbar.
7.2 Sofern eine Rechtsperson als Direktor bestellt wird, muss diese Rechtsperson einen ständigen Vertreter (repré-
sentant permanent) benennen, der die Rechtsperson als Direktor in Übereinstimmung mit Artl. 51bis des Gesetzes
vertritt.
7.3 Die Direktoren werden von der Generalversammlung gewählt. Die Gesellschafter bestimmen außerdem die Ver-
gütung und Amtsdauer der Direktoren. Ein Direktor kann jederzeit, mit oder ohne Begründung, durch eine Entscheidung
der Generalversammlung abberufen oder ersetzt werden.
7.4 Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitgliedes durch Tod, Rücktritt oder auf andere Weise frei, so können die
so ernannten verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder, das frei gewordene Amt per Mehrheitsentscheid bis zur nächsten
Generalversammlung vorläufig besetzen. Sofern kein Direktor verbleibt, soll die Generalversammlung umgehend durch
den Kommissar einberufen und abgehalten werden, um neue Direktoren zu bestimmen.
Art. 8. Verwaltungsrat.
8.1 Befugnisse des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch das Gesetz und durch die vorliegenden Satz-
ungen der Generalversammlung vorbehalten ist. Er hat die weitest gehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegen-
heiten zu führen und die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten.
Spezielle oder begrenzte Vollmachten dürfen für definierte Angelegenheiten zu einem oder mehreren Vertretern
delegiert werden, die Gesellschafter sein können. Dies erfolgt durch den Direktor, sofern nur ein Direktor benannt ist,
oder durch die gemeinsamen Unterschriften von zwei beliebigen Direktoren.
8.2 Verfahren
Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und kann einen Sekretär bestimmen, der nicht
Direktor sein muss. Dieser ist verantwortlich für die Führung von Sitzungsberichten des Verwaltungsrats und für die
Niederschrift von Beschlüssen der Gesellschafterversammlung oder des einzigen Gesellschafters. Der Vorsitzende leitet
die Sitzungen des Verwaltungsrats und der Gesellschafterversammlung.
Der Verwaltungsrat tagt so häufig wie die Interessen der Gesellschaft es erfordern oder wird vom Vorsitzenden oder
auf Antrag von zwei Verwaltungsratsmitgliedern zum in der Einladung benannten Ort einberufen.
Eine schriftliche Einladung zu jeder Sitzung des Verwaltungsrats wird spätestens sieben (7) Tage im Voraus an alle
Direktoren gesendet, außer wenn ein Notfall vorliegt, dessen Natur und Umstände in der Einladung dargelegt werden.
Eine solche Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Direktoren anwesend oder vertreten sind und wenn sie angeben,
die Tagesordnung der Sitzung vollumfänglich zu kennen. Auf das Erfordernis der Einladung kann außerdem von jedem
Direktor vor oder nach einer Sitzung verzichtet werden, wobei hierfür ein Schreiben im Original, per Fax oder E-Mail
ausreicht, sofern die Umstände es erlauben, den Absender zu identifizieren. Gesonderte Einladungen sind nicht erfor-
derlich für solche Sitzungen, die zu Zeiten und an Orten stattfinden, die vom Verwaltungsrat vorher in einer Liste festgelegt
wurden.
Ein Direktor kann per Vollmacht einen anderen Direktor ermächtigen, um ihn bei einer Sitzung des Verwaltungsrats
zu vertreten.
Jeder Direktor darf an einer Sitzung mittels Telefon, Videokonferenz oder auf jede andere Weise teilnehmen, die es
den Teilnehmern erlaubt, sich gegenseitig zu identifizieren, zu hören und miteinander zu sprechen. Eine Teilnahme auf
diese Weise ist gleichwertig mit einer Teilnahme in Person an einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Sitzung
anzusehen.
Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend, anwesend in einer Form
wie im vorhergehenden Absatz definiert oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der Mehrheit
der Stimmen der so anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder gefasst. Die Beschlüsse werden in einem
Sitzungsprotokoll niedergeschrieben, welches von allen anwesenden Direktoren oder ihren Vertretern unterschrieben
wird.
8.3 Schriftliche Beschlussfassung
Ein schriftlich gefasster Beschluss, der von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben und datiert ist, ist genauso
rechtswirksam wie ein anlässlich einer Verwaltungsratssitzung gefasster Beschluss.
8.4 Vertretung
Die Gesellschaft wird nach Außen verpflichtet (i) durch die alleinige Unterschrift des alleinigen Verwalters; (ii), im Falle
der Existenz eines Verwaltungsrats durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Direktoren, wobei einer dieser Direk-
toren ein Direktor der Klasse A sein muss; oder (iii) durch die Einzelunterschrift eines im Rahmen der ihm erteilten
Vollmachten handelnden Delegierten des Verwaltungsrates, dem solche Vollmachten gültig gemäß Art. 8.1 übertragen
wurden.
Art. 9. Einzeldirektor. Wird die Gesellschaft von einem einzelnen Direktor verwaltet, so ist jede einschlägige Bestim-
mung dieser Satzung so zu lesen, als ob sie sich auf einen einzelnen Direktor beziehen würde. Die Bezeichung der Klassen
A und B ist in diesem Fall nichtig.
32525
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Haftung der Direktoren. Die Direktoren können im Zusammenhang mit der Ausübung ihres Amts und im
Rahmen ihrer Tätigkeit für die Gesellschaft nicht persönlich haftbar gemacht werden, sofern sie nach Gesetz und Satzung
handeln.
Art. 11. Interessenkonflikte. Kein Vertrag und keine sonstige Erklärung zwischen der Gesellschaft und jeder anderen
Gesellschaft oder Firma wird davon beeinflusst oder ungültig, dass ein Direktor oder sonstige Funktionär der Gesellschaft
ein Interesse an jener anderen Gesellschaft oder Firma hat oder ein Direktor, Mitarbeiter, Funktionär oder Angestellter
der anderen Gesellschaft oder Firma ist.
Ein Direktor oder Funktionär der Gesellschaft, der gleichzeitig als Direktor, Funktionär oder Angestellter jedweder
Gesellschaft oder Firma ist, mit der die Gesellschaft in Vertrags- oder sonstige Beziehungen treten möchte, wird durch
diese Beziehung mit einer anderen Gesellschaft oder Firma nicht daran gehindert, über diese Beziehungen der Gesellschaft
mit zu verhandeln und zu entscheiden.
Sofern dieser Direktor der Gesellschaft ein persönliches oder gegenläufiges Interesse an einer Transaktion der Ge-
sellschaft hat, soll dieser Direktor dem Verwaltungsrat sein persönliches oder gegenläufiges Interesse bekannt machen
und soll nicht in dieser Angelegenheit verhandeln oder entscheiden. Über die Transaktion und die Interessen dieses
Direktors soll der nächsten Jahressitzung der Gesellschafterversammlung berichtet werden.
Der vorhergehende Absatz ist nicht anzuwenden auf Beschlüsse des Verwaltungsrats in Bezug auf solche Transaktionen,
die im Bereich des regulären Geschäftsbetriebs liegen und die das Kriterium „on arm’s length“ einhalten.
IV. Gesellschafter
Art. 12. Gesellschafterversammlungen und schriftlicher Beschluss.
12.1 Befugnisse und Wahlrechte
Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in der Gesellschafterversammlung oder per schriftlichem Beschluss
gefasst.
Zur Fassung eines schriftlichen Beschlusses wird der Beschlusstext allen Gesellschaftern, in Übereinstimmung mit der
Satzung, zugesendet. Ein schriftlicher Beschluss, der von allen nach Art. 12.2 (vii) zu berücksichtigenden Gesellschaftern
unterschrieben und datiert ist, ist genauso wirksam und bindend wie ein Beschluss der ordentlich einberufenen und
abgehaltenen Generalversammlung.
Jede Aktie gibt ein Stimmrecht von einer Stimme.
12.2 Einladung, Quorum, Mehrheit und Abstimmungsverfahren
(i) Die Einberufung der Generalversammlung oder schriftliche Beschlussfassung erfolgt aufgrund der Initiative jedes
Direktors oder von Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten.
(ii) Eine schriftliche Einladung zu jeder Sitzung der Generalversammlung wird spätestens acht (8) Tage im Voraus an
alle Gesellschafter gesendet, außer wenn ein Notfall vorliegt, dessen Natur und Umstände in der Einladung dargelegt
werden.
(iii) Die jährliche Generalversammlung tritt, in Übereinstimmung mit dem Luxemburger Gesetz, am Gesellschaftssitz
oder in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes an dem im Einladungsschreiben genannten Ort zusammen und zwar am 15.
Mai eines jeden Jahres um 10.00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein allgemeiner Feiertag für Banken ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden
Arbeitstag statt.
(iv) Andere Generalversammlungen werden an einem solchen Ort und zu solcher Zeit abgehalten, wie im jeweiligen
Einladungsschreiben bestimmt.
(v) Sind alle Gesellschafter anwesend oder vertreten und erachten sich ordentlich einberufen und über die Tagesord-
nung informiert, kann die Generalversammlung ohne vorherige Einladung abgehalten werden.
(vi) Ein Gesellschafter darf sich mittels schriftlicher Vollmacht durch eine andere Person, Gesellschafter oder nicht,
bei einer Generalversammlung vertreten lassen.
(vii) Beschlüsse der Generalversammlung oder im Wege des schriftlichen Beschlusses sind angenommen, wenn die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals repräsentierenden Gesellschafter zugestimmt haben. Wird diese Mehrheit
bei der ersten Generalversammlung oder dem ersten schriftlichen Beschlussverfahren nicht erreicht, so werden die
Gesellschafter per Einschreiben ein zweites Mal einberufen oder es wird ein zweites schriftliches Beschlussverfahren
durchgeführt, wobei für die Beschlussfassung dann die Mehrheit der abgegebenen Stimmen zählt, unabhängig von der
Höhe des vertretenen Gesellschaftskapitals.
(viii) Die Satzung wird mit der doppelten Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Gesellschafts-
kapitals vertreten, geändert.
(ix) Für die Anhebung des Gesellschaftskapitals gelten die Regeln des Gesetzes.
Art. 13. Einzel-Gesellschafter. Wenn und solange die Gesellschaft nur einen Gesellschafter hat, existiert sie als Ein-
Personen-Gesellschaft gemäß dem Gesetz.
Der Gesellschafter übt alle Rechte aus, die vom Gesetz an die Generalversammlung zugewiesen sind.
32526
L
U X E M B O U R G
Jeder Bezug in der Satzung zu den Gesellschafter und zur Gesellschafterversammlung und der Bezug zu schriftlichen
Beschlüssen der Gesellschafter ist jeweils zu lesen als bezogen auf den einzelnen Gesellschafter oder dessen schriftlichen
Beschluss.
Die Beschlüsse des einzelnen Gesellschafters werden in einem Protokoll oder schriftlich gefasst.
V. Jahresabschluss - Gewinnverteilung - Aufsicht
Art. 14. Geschäftsjahr und Zustimmung zum Jahresabschluss.
14.1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember des selben Jahres.
14.2 Der Verwaltungsrat erstellt den Jahresabschluss, eine Gewinn- und Verlustrechnung sowie ein Inventar, welches
den Wert der Güter und Verbindlichkeiten der Gesellschaft wiedergibt, samt Anhängen, die die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft und die Verbindlichkeiten der Direktoren und Gesellschafter gegenüber der Gesellschaft zusammenfasst
14.3 Jeder Gesellschafter darf das Inventar und den Jahresabschluss an der Geschäftsadresse der Gesellschaft inspi-
zieren.
14.4 Der Jahresabschluss und die Gewinn- und Verlustrechnung werden von der Generalversammlung oder mittels
schriftlichem Beschluss der Gesellschafter innerhalb von sechs (6) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres genehmigt.
Art. 15. Satzungsmäßiger Kommissar.
15.1 Die Tätigkeiten der Gesellschaft werden von einem oder mehreren satzungsmäßigen Kommissaren (commissaire
(s) aux comptes) überwacht, soweit das Gesetz dies erfordert.
15.2 Die Gesellschafter bestimmen den commissaire aux comptes und bestimmen ihre Anzahl, Vergütung und Dauer
ihrer Berufung, welche sechs (6) Jahre nicht übersteigen darf. Der commissaire aux comptes kann wiedergewählt werden.
Er kann von der Gesellschafterversammlung jederzeit mit oder ohne Grund abberufen werden.
Er legt diesen, mit einem Bericht über die Geschäfte der Gesellschaft, spätestens einen Monat vor der Jahresgeneral-
versammlung, den Kommissaren zur Einsicht, vor.
Art. 16. Gewinnverwendung.
16.1 Vom Nettogewinn des Geschäftsjahres sind mindestens 5% für die Bildung einer gesetzlichen Rücklage zu ver-
wenden; diese Verpflichtung wird aufgehoben, wenn die gesetzliche Rücklage 10% des Gesellschaftskapitals erreicht hat.
16.2 Die Gesellschafter legen fest, wie der Saldo des Gewinns verwendet wird. Ein solcher Saldo kann verwendet
werden für die Zahlung einer Dividende, einer Zuordnung zu einer Rücklage oder zum Gewinnübertrag.
16.3 Vorschussdividenden dürfen unter den folgenden Bedingungen ausgeschüttet werden:
(i) Der Verwaltungsrat hat eine Zwischenbilanz aufgestellt;
(ii) Diese Zwischenbilanz zeigt, dass ausreichende Gewinne und sonstige Reserven (inklusive eines Vorzugsrechts
(share premium)) zur Ausschüttung vorhanden sind; es wird festgehalten, dass dieser Betrag nicht den Gewinn übersteigen
darf, der seit dem Ende des letzten Geschäftsjahres angefallen ist, für welches der Jahresabschluss genehmigt worden ist,
wobei dieser letztgenannte Gewinn um vorgetragene Gewinne und verteilungsfähige Rücklagen anzuheben, sowie durch
vorgetragene Verluste und die zur gesetzlichen Rücklage zu verwendenden Beträge zu reduzieren ist;
(iii) Die Entscheidung über eine Vorschussdividende wird vom Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Monaten ab dem
Datum der Zwischenbilanz getroffen;
(iv) Die Rechte der Gläubiger der Gesellschaft sind, unter Berücksichtigung der Güter der Gesellschaft, nicht bedroht;
und
(v) Wo gezahlte Vorschussdividenden den Saldo der am Ende des Geschäftsjahres verteilungsfähigen Gewinne über-
steigt, muss der überzahlte Betrag von den Gesellschaftern an die Gesellschaft zurückgezahlt werden.
VI. Auflösung - Liquidation
Art. 17.
17.1 Die Gesellschaft kann jederzeit durch Beschluss der Generalversammlung aufgelöst werden, welcher von den
Gesellschaftern, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals repräsentieren, getroffen wird. Die Gesellschafter be-
stimmen einen oder mehrere Liquidationsverwalter, der nicht Gesellschafter sein muss, und bestimmen ihre Anzahl,
Vollmachten und Vergütung. Soweit von den Gesellschaften nicht anderweitig bestimmt, haben die Liquidationsverwalter
die weitestgehenden Befugnisse, um die Güter zu realisieren und die Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu erfüllen.
17.2 Der verbleibende Saldo nach Realisierung der Güter und Erfüllung der Verbindlichkeiten wird im Verhältnis des
jeweiligen Gesellschaftsanteils an die Gesellschafter verteilt.
VII. Allgemeine Bestimmungen
Art. 18.
18.1 Benachrichtigungen oder sonstige Mitteilungen werden getätigt oder darauf verzichtet sowie über schriftliche
Beschlüsse der Direktoren und der Gesellschafter wird Beweis geführt in Schriftform, per Telegramm, Fax, E-Mail oder
mittels jeder anderen Methode der elektronischen Kommunikation.
32527
L
U X E M B O U R G
18.2 Vollmachten werden mittels jedes der hier genannten Mittel begeben. Vollmachten in Verbindung mit einer Ver-
waltungsratssitzung dürfen von einem Direktor auch in einer Weise ausgestellt werden, deren Bedingungen vom
Verwaltungsrat festgelegt werden können.
18.3 Unterschriften können in handschriftlicher oder elektronischer Form getätigt werden, vorausgesetzt letztere
erfüllen die rechtlichen Voraussetzungen um einer handschriftlichen Unterschrift gleichwertig zu sein. Unterschriften
unter schriftlichen Beschlüssen des Verwaltungsrats oder der Gesellschafter werden, je nach dem konkreten Fall, auf
einem Ordiginal oder mehreren Gegenstücken des gleichen Dokuments getätigt, welche zusammen ein Dokument dar-
stellen.
Art. 19. Satzungsänderungen. Diese Satzungsbestimmungen können von Fall zu Fall durch eine außerordentliche Ge-
sellschafterversammlung abgeändert werden, sofern die Vorschriften des Quorum und die Mehrheitsvorschriften des
Gesetzes eingehalten werden.
Art. 20. Anwendbares Recht. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, gelten die Bestimmungen des
Gesetzes, wie in Art. 1 festgelegt.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tage und endet am 31. Dezember 2015.
Die erste Generalversammlung findet im Jahr 2016 statt.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Gründer vertreten wie oben bezeichnet, erklären alle einhundert tausend (100.000) Aktien in registrierter Form,
wie folgt zu zeichnen:
Aktionär
Anzahl
der
Aktien
1.- Herr Christian NOTHACKER, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49’300
2.- Herr Alessandra FELISI, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35’700
3.- Herr Ram CHAWLA, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15’000
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100’000
Der Betrag von EUR 70.000,- (siebzig tausend Euro) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, was hiermit
ausdrücklich von dem amtierenden Notar festgestellt wurde.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die der Gesellschaft aus Anlass ihrer Gründung anfallenden Kosten, Honorare und Auslagen betragen schätzungsweise
1.400,- EUR.
<i>Ausserordentliche Generalversammlungi>
Sodann haben die Komparenten, handelnd wie erwähnt, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten einstimmig
folgende Beschlüsse gefasst:
1. Als Verwaltungsratsmitglieder bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäftsjahres befindet,
welches am 31. Dezember 2019 endet, werden ernannt:
- Herr Ralph BOURGNON, unabhäniger Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy
-Herr Ronald WEBER, unabhäniger Wirtschaftsprüfer, berufsansässig in L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy, und
- Herr Christian NOTHACKER, CEO, geboren in Bad Soden am Taunus (Deutschland) am 27. Mai 1989, wohnhaft in
Via Cosliva 36, 6926 Montagnola, (Schweiz)
2. Zum Kommissar (commissaire aux comptes) bis zur Generalversammlung, die über die Bilanz des ersten Geschäfts-
jahres befindet, welches am 31. Dezember 2019 endet, wird ernannt:
Compliance & Control, mit Sitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy, eingetragen beim Handels-und Gesellschafts-
register von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 172.482.
3. Die Gesellschaft hat ihren Gesellschaftssitz in L-2212 Luxemburg, 6, Place de Nancy
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache kundig ist, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen der vorstehend
genannten Personen die vorliegende Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Fassung;
auf Wunsch der vorstehend genannten Personen ist bei Widersprüchen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung die englische Fassung maßgeblich.
Daraufhin wurde der vorstehende Urkunde in Junglinster zu dem oben genannten Datum notariell beurkundet.
Nachdem der Text der Erschienenen vorgelesen wurde, deren Vor- und Nachname, Status und Wohnsitz dem Notar
bekannt sind, wurde die vorliegende Urkunde im Original von der Erschienenen gemeinsam mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
32528
L
U X E M B O U R G
Enregistré à Grevenmacher, le 29 janvier 2015. Relation GRE/2014/873. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015020794/592.
(150024166) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
COFRA Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
R.C.S. Luxembourg B 130.920.
In the year two thousand and fifteen, on the eighth of January,
Before Maître Joëlle BADEN, notary, residing in Luxembourg,
Is held
An extraordinary general meeting of the shareholders of “COFRA Treasury S.à r.l.”, a société à responsabilité limitée,
having its registered office in L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, recorded with the Luxembourg Trade and Com-
panies’ Register under number B 130.920, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary dated 10
th
July
2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2200 of 4
th
October 2007 (the
“Company”).
The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the under-
signed notary dated 23
rd
December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
The meeting is opened at 11.30 a.m. with Mr Raf Bogaerts, companies’ director, residing professionally at L-1255
Luxembourg, 48, rue de Bragance, in the chair,
who appointed as secretary Mrs Cheryl Geschwind, private employee, residing professionally at L-1212 Luxembourg,
17, rue des Bains.
The meeting elected as scrutineer Mrs Peggy Partigianone, private employee, residing professionally in L-1255 Lu-
xembourg, 48, rue de Bragance.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the present meeting has the following:
<i>Agendai>
1) Share capital increase by contribution in cash of EUR 1,100,000,000.00 from the sole shareholder of the Company
so as to raise it from its present amount of EUR 12,550.00 to EUR 1,100,012,550.00;
2) Against that contribution, creation of 44,000,000 mandatory redeemable preferred shares with a nominal value of
EUR 25.-each, namely the “MRPS” to be fully paid up and determination of the specific rights attached to the MRPS;
3) Subscription and payment of the newly issued MRPS;
4) Fixation of the Company’s subscribed and paid-up share capital to EUR 1,100,012,550.00 to be represented by 502
ordinary shares with a nominal value of EUR 25,- each and by 44,000,000 MRPS with a nominal value of EUR 25,- each;
5) Subsequent amendment and restatement of the Articles of Association of the Company in order to bring those in
line with the aforementioned resolutions.
6) Miscellaneous.
II. - That the present or represented shareholders, the proxyholders of the represented shareholders and the number
of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the present shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to the present deed to be filed at
the same time with the registration authorities.
The proxies of the represented shareholders will also remain attached to the present deed after having been initialled
ne varietur by the persons appearing.
III. - That the whole corporate capital being present or represented at the present meeting and the shareholders
declaring that they have had due notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting, no convening notices
were necessary.
IV. - That the present meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly
deliberate on all the items on the agenda.
Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:
<i>First resolution:i>
The general meeting decides to increase the share capital of the Company by an amount of one billion one hundred
million euro (EUR 1,100,000,000.-) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred fifty euro
(EUR 12,550.-) represented by five hundred and two (502) shares with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-)
each, up to one billion one hundred million twelve thousand five hundred fifty euro (EUR 1,100,012,550) through the
32529
L
U X E M B O U R G
creation and issue of forty-four million (44,000,000) new mandatory redeemable preferred shares (hereafter the “MRPS”
as described in the articles of incorporation), with a nominal value of twenty-five euro (EUR 25,-) each.
<i>Subscription and paymenti>
All the forty-four million (44,000,000) new MRPS are entirely subscribed by the sole shareholder COFRA HOLDING
AG, a company established under Swiss law and having its registered office at 10, Grafenauweg, CH-6300 Zug (Switzer-
land), here represented by Mr Raf Bogaerts, prenamed, by virtue of a proxy under private seal given in Zug, on 5
th
January
2015,
for a total price of one billion one hundred million euro (EUR 1,100,000,000.-), entirely allocated to the share capital.
All the forty-four million (44,000,000) new MRPS are entirely paid up in cash so that the amount of one billion one
hundred million euro (EUR 1,100,000,000.-), is as of now available to the Company, as it has been proved to the under-
signed notary.
<i>Second resolution:i>
As a consequence of the above resolutions, the general meeting decides to fully restate the articles of incorporation
of the Company in order to bring those in line with the aforementioned resolutions. The articles of incorporation of the
Company will henceforth be read as follows:
“A. Name - Duration - Purpose - Registered office
Art. 1. There exists a company in the form of a société à responsabilité limitée, under the name of “COFRA Treasury
S.à r.l.” (hereinafter the “Company”).
Art. 2. The Company is established for an unlimited duration.
The Company may be dissolved at any time by the decision of the sole shareholder or pursuant to a resolution of the
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 3. The object of the Company is to undertake all financial operations for the benefit of its parent company, its
subsidiaries and the subsidiaries of its parent company and any other company belonging to the group of companies to
which it belongs, the said financial operations including in particular cash pooling, financial assistance through the granting
of loans or otherwise, management of current accounts, management of bank deposits, clearing operations and operations
involving foreign currencies.
The object of the Company is also the taking of participations in any form whatsoever in Luxembourg or foreign
companies and the acquisition by purchase, subscription or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise, of stocks, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, develop-
ment and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation and development of any financial, industrial or commercial undertaking,
both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad, and may render such undertakings any assistance, whether in the
form of loans, guarantees or otherwise.
The Company may borrow in any form and may issue debentures.
In general the Company may adopt any control and supervisory measures and carry out any operation which it may
consider conducive to the attainment or development of its object, provided nevertheless that it remains within the limits
laid down by the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act 1915).
Art. 4. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City.
Within the same municipality, the registered office of the Company may be transferred by resolution of the board of
managers.
If the manager or board of managers determines that extraordinary political, economic, social or military events have
occurred or are imminent which would render impossible the normal activities of the Company at its registered office
or the communication between such registered office and person abroad, the registered office may be temporarily trans-
ferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have no
effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
company.
Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of managers.
B. Share capital - Shares
Art. 5. The share capital of the Company is set at one billion one hundred million twelve thousand five hundred fifty
euro (EUR 1,100,012,550) represented by five hundred and two (502) ordinary corporate units (the “Ordinary Corporate
Units”) and forty-four million (44,000,000) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”), with a nominal value
of twenty-five euro (EUR 25.-) each, each being fully paid-up (together the “Shares”).
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sha-
reholders adopted in the manner required for amendment of these articles of association (the “Articles”). Without
32530
L
U X E M B O U R G
prejudice to what is set out below concerning the redemption of the MRPS, the Company may, to the extent and under
terms permitted by law, redeem its own shares.
Art. 6. The Company may have one or several shareholders. The death or the dissolution of the sole shareholder (or
any other shareholder) shall not lead to the dissolution of the Company.
Art. 7. The Shares of the Company are in registered form.
A shareholders’ register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.
Ownership of Shares will be established by inscription in said register. Certificates of these recordings shall be issued and
signed by two managers upon request of the relevant shareholder.
The Company will recognize only one holder per Share; in case a Share is held by more than one person, the persons
claiming ownership of the Share will have to appoint one sole proxy to represent the share in relation to the Company.
The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been designated
as the sole owner in relation to the Company.
Art. 8. The MRPS may be redeemed by the Company in accordance with article 49-8 of the law of 10 August 1915
regarding commercial companies, as amended, as foreseen for the sociétés anonymes.
The Company is entitled to redeem the MRPS, at any moment, in whole or in part, by sending a notice by registered
mail to any holder of the MRPS at the address which appears in the Company’s shareholders’s register. Such notice will
mention (i) the date of the redemption, (ii) the number of MRPS to be redeemed, (iii) the redemption price and (iv) the
method of payment of the redemption price.
The Company shall redeem the MRPS at the latest on the tenth anniversary of their issuance.
The redemption price of a MRPS shall be equal to the nominal value plus the portion of the share premium account
attributable to such MRPS at the time of the redemption.
C. General meetings of shareholders or resolutions of the sole shareholder
Art. 9. Each shareholder may participate in the collective decisions, irrespective of the number of Shares which he
owns. Each Ordinary Corporate Unit is entitled to one vote. Each MRPS is entitled to one vote, except when the Company
has only one shareholder in which case the MRPS have no voting rights.
Collective decisions are only taken in so far they are adopted by shareholders owning more than half of the share
capital.
If the Company is composed of one shareholder, the latter exercises the powers granted by the law to the general
meetings of shareholders.
If the Company is composed of several shareholders, the decisions of the shareholders are taken in a general meeting
of shareholders or, in case there are not more than twenty-five shareholders, by a vote in writing on the text of the
resolutions to be adopted which will be sent by the board of managers to the shareholders by registered mail. In this
latter case, the shareholders are under the obligation to, within a delay of fifteen days as from the receipt of the text of
the proposed resolution, cast their written vote and mail it to the Company.
Art. 10. The decisions of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders are documented in writing
and recorded in a register. The votes of the shareholders and the power-of-attorneys are attached to the minutes.
D. Management
Art. 11. The Company is managed by one or several managers, who do not need to be shareholders.
The managers are appointed by the sole shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be,
which will determine their number and their term of office, and they will hold office until their successors are appointed.
They are re-eligible, but they may be dismissed freely at any time and without specific cause by a resolution of the sole
shareholder or by the general meeting of shareholders, as the case may be.
The death or resignation of a manager, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 12. In case of several managers, they will form a board of managers. The board of managers shall choose from
among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary,
who need not be a manager, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers
and of the shareholders.
The board of managers shall meet upon call by the chairman, or two managers, at the place indicated in the notice of
meeting.
The chairman shall preside at all meeting of shareholders and of the board of managers, but in his absence, the sha-
reholders or the board of managers may appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority
present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty-four hours at least in
advance of the date scheduled for the meeting, by facsimile or by electronic mail (without electronic signature), except
in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This
32531
L
U X E M B O U R G
notice may be omitted in case of assent of each manager in writing, by facsimile or by any other means of communication,
a copy being sufficient. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the board of managers.
Any managers may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy in writing,
by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. A manager may represent one or more of
his colleagues.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call or video-conference or by
other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a
continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting. The participation in a meeting
by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. A meeting held through such means of com-
munication is deemed to be held at the registered office of the Company.
The board of managers can deliberate or act validly only if the majority (and at least two) of the managers are present
or represented at a meeting of the board of managers.
Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the managers present or represented at the meeting.
The chairman does have a casting vote in case of equality of votes.
The board of managers may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval on one or
several separate instruments in writing, by facsimile or by any other means of communication, a copy being sufficient. The
entirety will form the minutes giving evidence of the passing of the resolutions.
Art. 13. The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by
the vice-chairman if any, or by two managers. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial
proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, or by two managers or by any other person duly appointed
to that effect by the board of managers.
Art. 14. The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition
in the Company's interest. All powers not expressly reserved by law or by these Articles to the general meeting of
shareholders fall within the powers of the board of managers.
The board of managers may delegate special powers or proxies, or entrust determined permanent or temporary
functions, including the daily management of the Company to persons or agents chosen by it.
Art. 15. The Company will be bound towards third parties by the sole signature of the sole manager or by the joint
signature of any two managers, as the case may be, or by the joint signature or single signature of any person to whom
such signatory power has been delegated by the board of managers, but only within the limits of such power.
The Company will be bound towards administrative authorities by the sole signature of any manager.
E. Financial year - Profits
Art. 16. The accounting year of the Company shall begin on March 1
st
of each year and shall terminate on the last
day of February of the next year.
Each year on the last day of February, the accounts are closed and the board of managers prepares an inventory
including an indication of the value of the assets and liabilities of the Company. Each shareholder may inspect the above
inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
The balance sheet and the profit and loss account are submitted to the sole shareholder or, as the case may be, to
the general meeting of shareholders for approval.
The books and accounts of the Company may be audited by an audit firm appointed by the sole shareholder or by a
general meeting of shareholders, as the case may be.
Art. 17. From the annual net profits of the Company, five per cent (5 %) shall be allocated to the legal reserve. This
allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as such reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed
capital of the Company, as stated in article 5 hereof or as increased or reduced from time to time as provided in article
5 hereof.
Each MRPS entitles to a preferential and cumulative annual dividend of 0.5 % of the nominal value of the MRPS.
After payment of these preferred dividend, the sole shareholder or the general meeting of shareholders, as the case
may be, shall determine how the remaining profit is allocated, provided that the MRPS shall have no further rights to any
additional dividends, notwithstanding the power of the board of managers to distribute interim dividends within the limits
permissible under law
Notwithstanding anything to the contrary in these Articles, the preferred dividends to be allocated to the MRPS are
only payable out of the income derived from the assets contributed to or acquired by the Company by using the contri-
butions made to the Company in consideration for the issue of the MRPS.
32532
L
U X E M B O U R G
F. Liquidation
Art. 18. In the event of dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,
who may be physical persons or legal entities, appointed by the meeting of shareholders deciding such dissolution and
which shall determine their powers and their compensation.
In case of a liquidation, each holder of MRPS has a preferential right to (i) the reimbursement of his contribution at its
nominal value and (ii) the payment of any unpaid dividend. After such payments, the holder of MRPS are excluded from
any further liquidation proceeds.
The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the
shareholders proportionally to the Ordinary Corporate Units of the Company held by them.
G. Amendment of the articles of incorporation
Art. 19. These Articles may be amended, from time to time, by an extraordinary general meeting, subject to the quorum
and majority requirements referred to in the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
H. Final clause - Applicable law
Art. 20. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the law of
10 August 1915 governing commercial companies, as amended.
Art. 21. The present articles of incorporation are worded in English followed by a French version. In case of divergence
between the English and the French text, the English version shall prevail.”
There being no further items on the agenda, the meeting is closed.
WHEREOF, the present deed is drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the date named
at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearers, the
present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearers and in case of diver-
gences between the English and the French texts, the English text will prevail.
The document having been read to the appearers, the board of the meeting signed together with the notary this original
deed.
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le huit janvier,
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg,
S'est tenue
L’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée «COFRA Treasury S.à r.l.»,
ayant son siège social à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg, sous le numéro B 130.920, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 10 juillet 2007, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2200 du 4 octobre 2007 (la «Société»).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire soussigné en date du 23 décembre
2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
L'assemblée est ouverte à 11.30 heures sous la présidence de Monsieur Raf Bogaerts, administrateur de sociétés,
résidant professionnellement à L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance,
qui désigne comme secrétaire Madame Cheryl Geschwind, employée privée, résidant professionnellement à L-1212
Luxembourg, 17, rue des Bains.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Peggy Partigianone, employée privée, résidant professionnellement à
L-1255 Luxembourg, 48, rue de Bragance.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jour:i>
1) Augmentation du capital social par apport en espèces de EUR 1.100.000.000,- réalisé par l’associé unique de la
Société afin de le porter de son montant actuel de EUR 12.550,- à EUR 1.100.012.550,-;
2) En contrepartie de cet apport, création et émission de 44.000.000 parts sociales préférentielles obligatoirement
rachetables d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune, dénommées les «MRPS» entièrement libérées et détermination
des droits spécifiques attachés aux MRPS;
3) Souscription et libération des MRPS nouvellement émises;
4) Fixation du capital souscrit et libéré de la Société à EUR 1.100.012.550,- représenté par 502 parts sociales ordinaires
d'une valeur nominale de EUR 25,- chacune et par 44.000.000 MRPS d’une valeur nominale de EUR 25,- chacune;
32533
L
U X E M B O U R G
5) Modification subséquente et refonte des statuts de la Société afin d’y introduire les modifications des résolutions
susmentionnées;
6) Divers.
II.- Que les associés présents ou représentés, les mandataires des associés représentés, ainsi que le nombre de parts
sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
associés présents, les mandataires des associés représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée au
présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des associés représentés, après avoir été paraphées
ne varietur par les comparants.
III.- Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction
des convocations d'usage, les associés présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par
ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.
IV.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée générale décide de d’augmenter le capital social de la Société à concurrence d’un montant d’un milliard
cent millions d’euros (EUR 1.100.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent cinquante
euros (EUR 12.550,-) représenté par cinq cent deux (502) parts sociales d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR
25,-) chacune à un milliard cent millions douze mille cinq cent cinquante euros (EUR 1.100.012.550,-) par la création et
l’émission de quarante-quatre millions (44.000.000) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (ci-après
dénommées les «MRPS», telles que décrites dans les statuts) d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.
<i>Souscription et libérationi>
La totalité des quarante-quatre millions (44.000.000) MRPS nouvelles sont intégralement souscrites par l’associé unique
COFRA HOLDING AG, une société constituée selon le droit suisse et ayant son siège social à 10, Grafenauweg, CH-6300
Zug (Suisse), ici représentée par Monsieur Raf Bogaerts, prénommé, en vertu d’une procuration sous seing privé donnée
à Zug, le 5 janvier 2015,
pour un prix total d’un milliard cent millions d’euros (EUR 1.100.000.000,-) entièrement affectés au capital social de
la Société.
La totalité des quarante-quatre millions (44.000.000) MRPS nouvelles sont entièrement libérées en espèces, de sorte
que la somme d’un milliard cent millions d’euros (EUR 1.100.000.000,-) est dès maintenant à la disposition de la Société,
ce dont il a été justifié au notaire soussigné.
<i>Deuxième résolution:i>
Par conséquent, l’assemblée générale décide la refonte complète des statuts de la Société afin d’y introduire les mo-
difications des résolutions susmentionnées. Les statuts de la Société auront désormais la teneur suivante:
«A. Dénomination - Durée - Objet - Siège social
Art. 1
er
. Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «COFRA Treasury S.à r.l.» (la «So-
ciété»).
Art. 2. La Société est constituée pour une durée illimitée.
La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés,
selon le cas.
Art. 3. La Société a pour objet de faire toutes opérations financières au bénéfice de son entreprise mère, de ses filiales,
des filiales de son entreprise mère et de toute autre société appartenant au groupe de sociétés auquel elle appartient;
lesdites opérations financières comprenant notamment la gestion centralisée de trésorerie (cash-pooling), l’assistance
financière moyennant l’octroi de prêts ou autrement, la gestion de comptes courants, la gestion de dépôts en banque,
les opérations de clearing et les opérations sur devises.
La Société a également pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés lu-
xembourgeoises ou étrangères, ainsi que l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que
l’aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, billets et autres valeurs de toutes espèces,
la possession, l’administration, le développement et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, et leur prêter tous concours, que ce soit par des
prêts, des garanties ou toutes autres manières.
La Société peut emprunter sous toutes formes et procéder à l’émission d'obligations.
32534
L
U X E M B O U R G
D'une façon générale, elle peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle
jugera utiles à l’accomplissement ou au développement de son objet, en restant toutefois dans les limites tracées par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés de 1915).
Art. 4. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-ville.
Le siège social peut être transféré endéans la même commune en vertu d'une décision du conseil de gérance.
Au cas où le conseil de gérance ou le gérant estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, éco-
nomique, social ou militaire, de nature à compromettre l’activité normale au siège social ou la communication aisée avec
ce siège ou de ce siège avec l’étranger, se présentent ou paraissent imminents, le siège social pourra être transféré
provisoirement à l’étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura
toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.
La Société peut ouvrir des succursales ou des autres bureaux soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger en
vertu d’une décision du conseil de gérance.
B. Capital social - Actions
Art. 5. Le capital social de la Société est fixé à la somme d’un milliard cent millions douze mille cinq cent cinquante
euros (EUR 1.100.012.550,-) représenté par cinq cent et deux (502) parts sociales ordinaires (les «Parts Sociales Ordi-
naires») et quarante-quatre millions (44.000.000) parts sociales préférentielles obligatoirement rachetables (les «MRPS»)
d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune, toutes entièrement libérées (ensemble les «Parts Sociales»).
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution de l’assemblée générale des associés
adoptée suivant la manière requise pour modifier les présents statuts (les «Statuts»). Sans préjudice de ce qui est énoncé
ci-dessous concernant le rachat des MRPS, la Société peut, dans la mesure et aux conditions prévues par la loi, racheter
ses propres actions.
Art. 6. La Société peut avoir un ou plusieurs associés. Le décès ou la dissolution de l’associé unique (ou tout autre
associé) n’entraînera pas la dissolution de la Société.
Art. 7. Les Parts Sociales de la Société prennent la forme de parts nominatives.
Un registre des associés sera tenu au siège social, où il sera disponible pour inspection par tout associé. La propriété
des Parts Sociales sera établie par inscription dans ce registre. Les certificats de ces enregistrements sont délivrés et
signés par deux gérants à la demande de l’associé concerné.
La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Part Sociale; si une Part Sociale est détenue par plus d'une personne,
les personnes revendiquant la propriété de la Part Sociale devront désigner un mandataire unique pour représenter la
Part Sociale par rapport à la Société. La Société a le droit de suspendre l’exercice de tous les droits attachés à la Part
Sociale jusqu'à ce qu'une personne a été désignée comme l’unique propriétaire par rapport à la Société.
Art. 8. Les MRPS peuvent être rachetés par la Société conformément à l’article 49-8 de loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales, telle que modifiée, tel que prévu pour les sociétés anonymes.
La Société est autorisée à racheter les MRPS, à tout moment, en totalité ou en partie, par l’envoi d’une notification
par courrier recommandé à tout titulaire de MRPS à l’adresse qui figure dans le registre des associés de la Société. Une
telle notification doit mentionner (i) la date de rachat, (ii) le nombre de MRPS à racheter, (iii) le prix de rachat et (iv) la
méthode de paiement du prix de rachat.
La Société rachètera les MRPS au plus tard au dixième anniversaire depuis leur émission.
Le prix de rachat d’un MRPS est égal à la valeur nominative augmenté de la partie du compte de prime d’émission
attribuable à cet MRPS au moment du rachat.
C. Décisions de l’associé unique ou des associés.
Art. 9. Chaque associé peut participer aux décisions collectives, quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient.
Chaque Part Sociale Ordinaire donne droit à un vote. Chaque MRPS donne droit à un vote, sauf si la Société a seulement
un associé, auquel cas les MRPS n’ont pas de droit de vote.
Les décisions collectives ne sont prises que dans la mesure où elles sont adoptées par les associés détenant plus de la
moitié du capital social.
Si la Société comporte un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués par la loi aux assemblées générales
des associés.
Si la Société est composée de plusieurs associés, les décisions des associés sont prises dans une assemblée générale
des associés ou, dans le cas où il n'y a pas plus de vingt-cinq associés, par un vote écrit sur le texte des résolutions à
adopter qui est envoyé par le conseil de gérance aux associés par courrier recommandé. Dans ce dernier cas, les associés
sont dans l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société dans un délai de quinze jours à compter de la
réception du texte de la résolution proposée.
Art. 10. Les décisions de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés sont enregistrées par écrit et con-
signées dans un registre. Les votes de l’assemblée générale et les procurations sont attachés aux minutes.
32535
L
U X E M B O U R G
Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, qui n'ont pas besoin d'être associés.
Les gérants sont nommés par l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, selon le cas, lesquels fixeront leur
nombre et la durée de leur mandat, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Ils sont
rééligibles et ils peuvent être révoqués librement à tout moment et sans motif par l’associé unique ou l’assemblée générale
des associés, selon le cas.
Le décès d'un gérant ou sa démission, pour quelque motif que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la Société.
Art. 12. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci formeront un conseil de gérance. Le conseil de gérance choisira en son
sein un président et pourra également choisir parmi ses membres un vice-président. Il pourra également choisir un
secrétaire qui n'a pas besoin d'être gérant et qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil
de gérance et des associés.
Le conseil de gérance se réunira sur convocation du président ou de deux gérants, au lieu indiqué dans l’avis de
convocation.
Le président présidera toutes les assemblées des associés et réunions du conseil de gérance; en son absence les associés
ou le conseil de gérance pourra désigner à la majorité des personnes présentes un autre gérant pour assumer la présidence
pro tempore de ces réunions.
Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants au moins vingt-quatre heures avant
la date prévue pour la réunion, par télécopieur ou par courrier électronique (sans signature électronique) sauf s'il y a
urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être
passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque gérant par écrit, télécopie ou par tout autre moyen
de communication, une copie étant suffisante. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil
de gérance se tenant à une heure et un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de
gérance.
Tout gérant pourra se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant un autre gérant comme
son mandataire par écrit, télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant suffisante. Un gérant
peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéoconférence ou
autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les
unes les autres sur une base continue et permettant la participation effective de toutes les personnes à la réunion. La
participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion. Une réunion tenue
par telles moyens de communication est réputée être tenue au siège social de la Société.
Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si la majorité et au moins deux des gérants sont
présents ou représentés à la réunion du conseil de gérance.
Les décisions sont seulement prises avec l’approbation de la majorité des gérants présents ou représentés à cette
réunion. Le président a une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
Le conseil de gérance pourra, à l’unanimité, prendre des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation
sur une ou plusieurs instruments par écrit, par télécopie ou par tout autre moyen de communication, une copie étant
suffisante. Le tout ensemble constituant le procès-verbal faisant preuve de la décision intervenue.
Art. 13. Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président ou, en son
absence, par le vice-président, s’il y en a, ou par deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à
servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux gérants ou par toute autre personne dûment
nommée à cet effet par le conseil de gérance.
Art. 14. Le conseil de gérance a les pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes d’administration et de
disposition dans l’intérêt de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par les
statuts à l’assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gérance.
Le conseil de gérance peut conférer des pouvoirs ou mandats spéciaux ou des fonctions déterminées de façon per-
manente ou temporaire, y compris la gestion journalière de la Société, à des personnes ou agents de son choix.
Art. 15. Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée par la signature du gérant unique ou par la signature conjointe de
deux quelconques gérants, le cas échéant, ou par la signature conjointe ou individuelle de toute personne à qui un tel
pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.
La Société sera engagée envers les autorités administratives par la seule signature de tout gérant.
E. Année fiscale - Profits
Art. 16. L’année fiscale de la Société commence le premier mars de chaque année et se termine le dernier jour du
mois de février de l’année suivante.
Chaque année, au dernier jour du mois de février, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire
comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société. Tout associé peut prendre communication au siège
social de l’inventaire et du bilan.
32536
L
U X E M B O U R G
Les comptes annuels et le compte de profit et perte sont soumis à l’agrément de l’associé unique ou, selon le cas, de
l’assemblée générale des associés.
Les livres et les comptes de la Société peuvent être audités par une société d'audit, nommée par l’associé unique ou
l’assemblée générale des associés selon le cas.
Art. 17. Sur le bénéfice net de la Société, cinq pour cent (5%) sont alloués à la réserve légale. Cette allocation cesse
d’être obligatoire dès que et aussi longtemps que le montant de cette réserve légale s’élève à 10 pour cent (10%) du
capital social de la Société, comme indiqué à l’article 5 ci-dessus ou comme augmenté ou réduit de temps à autre con-
formément à l’article 5 des Statuts.
Chaque MRPS donne droit à un dividende annuel préférentiel et cumulatif de 0,5% de la valeur nominale des MRPS.
Après paiement des dividendes préférentiels, l’associé unique ou l’assemblée générale des associés, le cas échéant,
déterminent comment les profits restants seront alloués, étant entendu que les MRPS n’auront plus de droits à des
dividendes supplémentaires, sous réserve du pouvoir du conseil de gérance de distribuer des dividendes intérimaires dans
les limites permises par la loi.
Nonobstant toute disposition contraire dans les Statuts, les dividendes préférentiels à allouer aux MRPS sont seulement
payables sur les revenus tirés des actifs apportés à, ou acquis par, la Société en utilisant les contributions versées à la
Société en en relation avec l’émission des MRPS.
F. Liquidation
Art. 18. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera exécutée par un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent
être des personnes physiques ou morales, nommés par l’assemblée des associés décidant une telle dissolution et qui fixera
les pouvoirs et la compensation pour le(s) liquidateur(s).
En cas de liquidation, chaque porteur de MRPS dispose d'un droit préférentiel de (i) remboursement de sa contribution
à la valeur nominale et (ii) au paiement de tout dividende impayé. Après ces paiements, les titulaires de MRPS sont exclus
de toute autre surplus de liquidation.
Le surplus résultant de la réalisation de l’actif et du paiement du passif sera distribué aux associés proportionnellement
au nombre de Parts Sociales Ordinaires qu'ils détiennent dans la Société.
G. Modification des statuts
Art. 19. Les Statuts pourront être modifiés de temps en temps par une assemblée générale extraordinaire des associés
sous réserve des conditions de quorum et de majorité prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés com-
merciales, telle que modifiée.
H. Dernière clause - Loi applicable
Art. 20. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les Statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
Art. 21. Les présents statuts ont été rédigés en anglais, suivi d'une version française. En cas de divergence entre les
deux textes, la version anglaise prévaudra.»
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais constate que sur demande des comparants, le présent acte est
rédigé en langue anglaise suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais,
le texte anglais fait foi.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le
présent acte.
Signé: R. BOGAERTS, P. PARTIGIANONE, C. GESCHWIND et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 9 janvier 2015. 1LAC / 2015 / 677. Reçu soixante quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 6 février 2015.
Référence de publication: 2015020942/477.
(150024873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
32537
L
U X E M B O U R G
Contec Global Investment AG, Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 194.287.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundfünfzehn, den siebten Januar.
Vor Uns Notar Roger ARRENSDORFF, im Amtssitz zu Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg).
Ist erschienen:
l) HAYAT General Trading L.L.C P.O.Box 63828 Naser Ahmad Lutah Building 3, Hor Al Anz, Deira Dubai-United
Arab Emirates
hier vertreten durch den alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer Dr Sid Kevin Ghadiani, Ingenieur, wohnhaft
zu D-64347 Griesheim (Deutschland), Feldstraße 8a, befähigt die Gesellschaft rechtskräftig zu verplichten gemäß Artikel
9 der Statuten.
Vorbenannte Person, vertreten wie hiervor erwähnt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer von ihr
zu gründenden Aktiengesellschaft luxemburgischen Rechts wie folgt zu beurkunden:
Art. 1. Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird
eine Aktiengesellschaft unter der Bezeichnung "CONTEC GLOBAL INVESTMENTS AG" gegründet.
Art. 2. Die Gesellschaft wird gegründet für eine unbestimmte Dauer von heute angerechnet. Sie kann frühzeitig auf-
gelöst werden durch Entscheid der Aktionäre, entscheidend so, wie im Falle einer Statutenänderung.
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft ist der Gemeinde Luxemburg.
Sollten außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, ökonomischer oder sozialer Natur die normale Aktivität
der Gesellschaft behindern oder bedrohen, so kann der Sitz der Gesellschaft durch einfache Entscheidung des Verwal-
tungsrates in eine andere Ortschaft des Großherzogtums Luxemburg oder sogar ins Ausland verlegt werden und zwar
so lange bis zur Wiederherstellung normaler Verhältnisse.
Art. 4. Die Gesellschaft hat zum Zweck die Abwicklung (Planung, Projektmanagement, Ausführung) von kommerziellen,
industriellen und finanziellen Geschäften, unter welcher Form auch immer, aller Geschäfte welche sich auf Mobilar-und
Immobilarwerte beziehen.
Desweiteren kann die Gesellschaft Beteiligungen an anderen Gesellschaften erwerben und diesen Gesellschaften, an
denen sie beteiligt ist, jede Art von Unterstützung gewähren, sei es durch Darlehen, Garantien und Vorschüsse.
Die Gesellschaft kann alle Arten von Wertpapieren und Rechten erwerben, dieselben verwalten und verwerten.
Die Gesellschaft kann generell alle Tätigkeiten und Geschäfte betreiben welche mittelbar oder unmittelbar mit ihrem
Gesellschaftszweck zusammenhängen.
Art. 5. Das gezeichnete Aktienkapital beträgt EINUNDDREISSIGTAUSEND EURO (31.000,-€), eingeteilt in DREI-
HUNDERTZEHN (310) Aktien mit einem Nominalwert von je HUNDERT EURO (100,-€), welche eine jede Anrecht
gibt auf eine Stimme in den Generalversammlungen.
Die Aktien, je nach Wahl des Eigentümers, sind Inhaberaktien oder lauten auf Namen.
Die Aktien können, auf Wunsch des Besitzers, aus Einzelaktien oder aus Aktienzertifikaten für zwei oder mehr Aktien
bestehen.
Das gezeichnete Aktienkapital der Gesellschaft kann erhöht oder herabgesetzt werden, durch Beschluss der Gene-
ralversammlung, welcher wie bei Satzungsänderungen zu fassen ist.
Die Gesellschaft kann im Rahmen des Gesetzes und gemäß den darin festgelegten Bedingungen ihre eigenen Aktien
erwerben.
Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat verwaltet, der aus mindestens drei Mitgliedern besteht und
welcher aus seinen Reihen einen Vorsitzenden wählt und bei einer Einpersonenaktiengesellschaft aus einem Mitglied
bestehen kann.Sie werden ernannt für eine Dauer die sechs Jahre nicht überchreiten darf. Der Vorsitzende kann auch
durch die Generalversammlung ernannt werden.
Art. 7. Der Verwaltungsrat hat die weitestgehenden Befugnisse, um die Gesellschaftsangelegenheiten zu führen und
die Gesellschaft im Rahmen des Gesellschaftszweckes zu verwalten. Er ist für alles zuständig, was nicht ausdrücklich durch
das Gesetz oder die vorliegenden Satzung der Generalversammlung vorbehalten ist.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt Vorauszahlungen auf Dividenden zu machen, im Rahmen der Bedingungen und
gemäß den Bestimmungen welche durch das Gesetz festgelegt sind.
Der Verwaltungsrat kann die ganze oder teilweise tägliche Geschäftsführung, sowie die Vertretung der Gesellschaft
betreffend diese Geschäftsführung, an ein oder mehrere Verwaltungsratsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer oder
Agenten übertragen, welche nicht Aktionäre zu sein brauchen.
32538
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft wird verpflichtet sei es durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungsratsmitgliedern oder
durch die alleinige Unterschrift des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieds oder des Verwaltungsratsvorsitzenden
oder des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds.
Art. 8. Die Gesellschaft wird bei Gericht als Klägerin oder als Beklagte durch ein Verwaltungsratmitglied oder duch
die hierzu speziell bestellte Person rechtsgültig vertreten.
Art. 9. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Kommissare überwacht.
Sie werden ernannt für eine Dauer, welche sechs Jahre nicht überschreiten darf.
Art. 10. Das Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am einunddreissigsten Dezember.
Art. 11. Die jährliche Generalversammlung tritt am Gesellschaftssitz oder an dem im Einberufungsschreiben genannten
Ort zusammen und zwar am dritten Montag des Monats April jeden Jahres um 16h00 Uhr.
Falls der vorgenannte Tag ein Feiertag ist, findet die Versammlung am ersten nachfolgenden Werktag statt.
Art. 12. Um der Generalversammmlung beiwohnen zu können, müßen die Besitzer von Inhaberaktien fünf volle Tage
vor dem festgesetzten Datum ihre Aktien hinterlegen. Jeder Aktionär hat das Recht selbst zu wählen oder einen Mandatar
zu bestellen. Letzterer muß nicht unbedingt Aktionär sein.
Art. 13. Die Generalversammlung hat die weitestgehenden Befugnisse um alle Akte, welche die Gesellschaft interes-
sieren zu tätigen oder gutzuheißen. Sie entscheidet über die Zuweisung und über die Aufteilung des Nettogewinns.
Die Generalversammlung kann beschließen, Gewinne und ausschüttungsfähige Rücklagen zur Kapitaltilgung zu benu-
tzen, ohne Durchführung einer Kapitalherabsetzung.
Art. 14. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Gründer auf die Bestimmungen des
Gesetzes vom 10. August 1915, sowie auf dessen spätere Änderungen.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1) Das erste Geschäftsjahr beginnt am heutigen Tag und endet am 31. Dezember 2015.
2) Die erste ordentliche Generalversammlung findet statt im Jahre 2016.
<i>Kapitalzeichnungi>
Die Aktien wurden durch den einzigen Aktieninhaber gezeichnet.
Das gezeichnete Kapital wurde bar in voller Höhe eingezahlt. Demzufolge steht der Gesellschaft der Betrag von ei-
nunddreissigtausend Euro (31.000,-€) zur Verfügung, was dem unterzeichneten Notar nachgewiesen und von diesem
ausdrücklich bestätigt wird.
<i>Bescheinigungi>
Der unterzeichnete Notar bescheinigt, daß die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes vom 10.August 1915 über
die Handelsgesellschaften erfüllt sind.
<i>Schätzung der Gründungskosteni>
Die Gründer schätzen die Kosten, Gebühren und jedwelche Auslagen, welche der Gesellschaft aus Anlaß gegenwärtiger
Gründung erwachsen, auf ungefähr neunhundertfünfzig Euro (EUR 950,-).
<i>Außerordentliche Generalversammlungi>
Sodann hat die Erschienene, vertreten wie hiervor erwähnt, in einer außerordentlichen Generalversammlung folgende
Beschlüsse gefaßt:
<i>Erster Beschlußi>
Die Zahl der Verwaltungsratsmitglieder wird auf einen (1) festgelegt und die der Kommissare auf einen (1)
Zum Verwaltungsratsmitglied wird ernannt:
- Dr Sid Kevin Ghadiani, Ingenieur, wohnhaft zu D-64347 Griesheim (Deutschland), Feldstraße 8a.
<i>Zweiter Beschlußi>
Zum Kommissar wird ernannt:
- LCG International A.G. (B 86.354), mit Sitz in L-1840 Luxemburg, 11A, Boulevard Joseph II.
<i>Dritter Beschlußi>
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder und des Kommissars enden am Tage der Generalversammlung welche
über das Geschäftsjahr 2020 befindet.
32539
L
U X E M B O U R G
<i>Vierter Beschlußi>
Die Anschrift der Gesellschaft lautet L-1840 Luxemburg, 11A, Boulevard Joseph II.
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt die Anschrift der Gesellschaft abzuändern innerhalb der Gemeinde in der sich der
statutarische Gesellschaftssitz befindet.
<i>Fünfter Beschlußi>
Gemäß den Bestimmungen des Artikels 60 des Gesetzes über die Gesellschaften und Artikel 7 der gegenwärtigen
Satzung, ist der Verwaltungsrat ermächtigt unter seinen Mitgliedern ein oder mehrere geschäftsführende Verwaltungs-
ratsmitglieder welche befugt sind die Gesellschaft durch ihre alleinige Unterschrift zu verpflichten für alles was die tägliche
Geschäftsführung anbelangt (administrateur-délégué) zu bezeichnen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Luxemburg, 11A, Boulevard Joseph II.
Der unterzeichnete Notar, welcher der deutschen Sprache mächtig ist, bestätigt hiermit, daß der Text der vorliegenden
Urkunde auf Wunsch der Parteien in deutsch abgefaßt ist, gefolgt von einer englischen Übersetzung; er bestätigt weiterhin,
daß es der Wunsch der Parteien ist, daß im Falle von Abweichungen zwischen dem deutschen und dem englischen Text
der deutsche Text Vorrang hat.
Und nach Vorlesung und Erklärung an den Vertreter der Erschienenen hat derselbe Uns Notar nach Namen, gebräu-
chlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit Uns, Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Follows the English version of the previous text
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January
Before Us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxemburg).
There appeared:
- HAYAT General Trading L.L.C P.O.Box 63828 Naser Ahmad Lutah Building 3, Hor Al Anz, Deira Dubai-United Arab
Emirates
here represented its managing director Dr. Sid Kevin Ghadiani, engineer, residing in D-64347 Griesheim (Germany),
Feldstraße 8a, entitled to legally engage the company in accordance with article 9 of the statutes.
Such appearing party, represented as stated above, has requested the notary to draw up the following Articles of
Incorporation of a société anonyme which he declared to organize among themselves.
Art. 1. Between those present this day and all persons who will become owners of the shares mentioned hereafter,
a société anonyme is hereby formed under the title "CONTEC GLOBAL INVESTMENTS AG".
Art. 2. The Corporation is established for an unlimited period from the date thereof. The Corporation may be dissolved
prior by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorpo-
ration.
Art. 3. The Head Office of the Company is in the city of Luxembourg.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the Head Office of the Company, the Head Office of the Company may be transferred by decision
of the board of directors to any other locality of the Grand Duchy of Luxembourg and even abroad, until such time as
the situation becomes normalised.
Art. 4. The company's purpose is, in whatever form, the realisation (Planing, Project management, execution) of any
industrial, commercial, financial transactions concerning real estate property transactions. The company can take partic-
ipations in companies and provide them with assistance in form of loans of money or deposits as guarantees as well as,
the management and development, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose.
The company may take participating interest by any means in any business, undertakings or companies having the same,
analogous or connected object, or which may favour its development or the extension of its operations.
Art. 5. The subscribed capital is set at THIRTY ONE THOUSAND EUROS (31.000,-€) represented by THREE HUN-
DRED TEN (310) shares with a par value of ONE HUNDRED EUROS (100,-€) each, carrying one voting right in the
general assembly.
All the shares are, at the owner's option, in bearer or nominative form.
The corporation's shares may be created, at the owner's option, in certificates representing single shares or two or
more shares.
The subscribed capital of the corporation may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted
in the manner required for amendment of these article of Incorporation.
The company can proceed to the repurchase of its own shares within the bounds laid down by the law.
Art. 6. The company is administrated by a Board comprising at least three members. It can be administrated by one
director in case of a unipersonal company. Their mandate may not exceed six years.
32540
L
U X E M B O U R G
The chairman is elected by the general meeting.
Art. 7. The Board of Directors possesses the widest powers to manage the business of the Company and to take all
actions of disposal and administration which are in line with the object of the Company, and anything which is not a matter
for the General Meeting in accordance with the present Articles or governed by law, comes within its competence.
The Board of Directors is authorized to proceed to the payment of a provision of dividend within the bounds laid
down by the law.
The Board of Directors may delegate all or part of its powers concerning the daily management of the Company's
business, either to one or more directors, or, as holders of a general or special proxy, to third persons who do not have
to be shareholders of the Company.
All acts binding the company must be signed by two directors or by the sole signature of the managing director or by
the President of the Board of Directors, or by the sole director.
Art. 8. Legal action, as claimant as well as defendant, will be taken in the name of the Company by one member of the
Board of Directors, or by the person delegated to this office.
Art. 9. The Company's operations are supervised by one or more auditors. Their mandate may not exceed six years.
Art. 10. The Company's business year begins on day of its creation and closes on the thirty-first of December of each
year.
Art. 11. The annual General Meeting is held on the third Monday on the month of April at 16h00 at the Company's
Head Office, or at another place to be specified in the convening notices. If such day is a legal holiday, the General Meeting
will be held on the next following business day.
Art. 12. To be admitted to the General Meeting, the owner of bearer shares must deposit them five full days before
the date fixed for the meeting; any shareholder will be entitled to vote in person or through a proxy, who need not be
a shareholder himself.
Art. 13. The General Assembly has the widest powers to take or ratify any action concerning the Company. It decides
how the net profit is allocated and distributed.
The General Assembly may decide that profits and distributable reserves are assigned to the redemption of the stock,
without reduction of the registered capital.
Art. 14. For any points not covered by the present articles, the parties refer to the provisions of the Act of August
10, 1915 and of the modifying Acts.
<i>Transitory dispositionsi>
1) The first accounting year will begin today and will end on December 31, 2015.
2) The first annual general meeting of shareholders will be held in 2016.
<i>Subscriptioni>
The capital has been subscribed by the sole shareholder.
All these shares have been paid up in cash to the extent of one hundred per cent, and therefore the amount of THIRTY-
ONE THOUSAND EUROS (31.000,-€) is as now at the disposal of the Company, proof of which has been duly given to
the notary.
<i>Statementi>
The notary declares that he has checked the existence of the conditions listed in Article 26 of the commercial com-
panies act and states explicitly that these conditions are fulfilled.
<i>Costsi>
The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company, or
charged to it for its formation, amount to about nine hundred fifty euros (EUR 950.-).
<i>Extraordinary General Meetingi>
The appearing person, represented as stated above, takes the following resolution in an extraordinary general meeting
<i>First resolvedi>
The number of Directors is set at one (1) and that of the auditors at one (1).
The following is appointed Director:
- Dr. Sid Kevin Ghadiani, engineer, residing in D-64347 Griesheim (Germany), Feldstraße 8a.
<i>Second resolvedi>
Is elected as auditor:
32541
L
U X E M B O U R G
- LCG International A.G. (B 86.354), with registered office at L-1840 Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II.
<i>Third resolvedi>
Their terms of office will expire after the annual meeting which will approve the financial statements of the year 2020.
<i>Fourth resolvedi>
The address of the company is fixed at L-1840 Luxemburg, 11A, Boulevard Joseph II.
The Board of Directors is authorized to change the address of the compagny inside the municipality of the company's
corporate seat.
<i>Fifth resolvedi>
Persuant to article 60 of the company law and article 7 of these Articles of Incoporation, the Board of Directors is
authorized to elect one or more managing director(s) of the Company with such powers as are necessary to bind the
Company with his (here) sole signature for the day-to-day management.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in German followed by a English translation; on the request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the German texts, the German version will be prevailing.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 11A, Boulevard Joseph II.
The document having been read to the representative of the appearing person, known to the notary, by his surnames,
Christian names, civil status and residences, the said person signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Gezeichnet: GHADIANI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 812. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri>
(signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 6 février 2015.
Référence de publication: 2015020947/231.
(150024609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
Ceria S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560A, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 176.483.
L'an deux mille quinze, le deux février.
Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme Ceria S.A., ayant son siège social au 560A,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 176.483 (la «Société»).
L'assemblée est ouverte sous la présidence de Peggy Simon, employée, demeurant professionnellement à L-6475
Echternach, 9, Rabatt,
qui se nomme elle-même comme scrutateur et qui désigne comme secrétaire Sara Craveiro, employée, demeurant
professionnellement à L-6475 Echternach, 9, Rabatt.
L'assemblée étant valablement constituée, le président déclare et prie le notaire d'acter comme suit:
<i>I. Exposéi>
1) Les actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, signée
par les mandataires des actionnaires représentés, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de pré-
sence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
2) Il appert de cette liste de présence que la totalité des actions représentant le capital social de la Société est repré-
sentée à l'assemblée générale extraordinaire. L'assemblée générale peut dès lors décider valablement sur tous les points
portés à son ordre du jour.
3) Le capital social émis et payé de la Société est fixé à un million deux mille quatre cents Euros (EUR 1.002.400,-)
représenté par deux mille cinq cent six (2.506) actions d'une valeur nominale de quatre cents Euros (EUR 400,-) chacune,
chaque part étant entièrement libérée.
32542
L
U X E M B O U R G
4) La Société n'a jamais été déclarée en faillite ou en procédure de conciliation ou de liquidation de ses avoirs, n'est
pas en cours de fusion ou d'absorption par restructuration, liquidée ou dissoute.
<i>II. Ordre du jouri>
L'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant:
1. Renonciation aux formalités et délais de convocation;
2. Changement de l'exercice social de la Société;
3. Modification afférente de l'article 24 des statuts de la Société; et
4. Divers.
<i>III. Résolutionsi>
L'assemblée générale ayant approuvé les déclarations qui précèdent, prend à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première Résolutioni>
La totalité des actions étant représentée, l'assemblée générale a renoncé aux formalités et délais de convocation,
conformément à l'article 22.7 des statuts de la Société. Les actionnaires ici représentés se considèrent comme dûment
convoqués et déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour, lequel leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième Résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier la date de fin de l'exercice social de la Société, du 28 février au 30 juin, étant
entendu que (i) l'exercice social en cours prendra fin au 28 février 2015 tel qu'initialement prévu, (ii) que l'exercice social
suivant commencera le 1
er
mars 2015 et se terminera le 30 juin 2015, et (iii) que chacun des exercices sociaux suivants
commencera au 1
er
juillet et se terminera au 30 juin de chaque année.
<i>Troisième Résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 24 des statuts de la Société afin de
lui donner la teneur suivante:
« Art. 24. Exercice social. L'année sociale commence le 1
er
juillet et se termine le 30 juin de chaque année».
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est ajournée.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Echternach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états et demeures, ils
ont signé ensemble avec nous notaire, le présent acte.
Signé: P. SIMON, S. CRAVEIRO, Henri BECK.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 03 février 2015. Relation: GAC/2015/973. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Echternach, le 06 février 2015.
Référence de publication: 2015020925/61.
(150024923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 février 2015.
AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 141.774.
RECTIFICATIF
Les comptes annuels rectifiés au 31/12/2013 (rectificatif du dépôt des comptes annuels au 31/12/2013 déposé le
7/7/2014, n° L140113777 et du dépôt des comptes annuels au 31/12/2013 déposé le 20/01/2015, n° L150012797) ont été
déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015017896/14.
(150021394) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
32543
L
U X E M B O U R G
ING Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 6.041.
L’extrait du recueil des signatures autorisées du 1
er
mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037950/10.
(150042413) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
Société Immobilière ING Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 52, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 9.139.
L’extrait du recueil des signatures autorisées au 5 mars 2015 a été déposé au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015038224/10.
(150042414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
Geonosis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 182.579.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour: GEONOSIS S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015019662/16.
(150023910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Golden Fleur Private S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 157.967.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 4 février 2015.
<i>Pour: GOLDEN FLEUR PRIVATE S.A. SPF
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015019669/16.
(150023349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
32544
AMP Capital Investors (CLH No. 1) S.à r.l.
Beauregard Capital Sicav
Capita Fiduciary S.A.
Carmudi SAUDI ARABIA S.C.Sp.
Carmudi UAE S.C.Sp.
Caroll, succursale Luxembourg
Ceria S.A.
Classifieds Asia S.C.Sp.
ClearingHouse for Intellectual Property S.A.
Clickbus Bulgaria Holding S.C.Sp.
Clickbus Czech Repubic Holding S.C.Sp.
Clickbus Germany Holding S.C.Sp.
COFRA Treasury S.à r.l.
"Communications Investments Europe S.à r.l."
Comquest Luxembourg
Concept International S.à r.l.
Contec Global Investment AG
Cork Supply Group S.à r.l.
CORNALINE S.A.
CPI Digiplex S.à r.l.
Da Costa Almeida S.à r.l.
d'Amico International Shipping S.A.
Denise Invest SA
D.P.K. Groupe Kichen, Fensteren & Dieren s.a.
DreiP AG
Dridco Luxembourg S.A.
D.R.M. Toitures S.à r.l.
GAIA Fund
Geonosis S.A.
Golden Fleur Private S.A. SPF
iBondis Capital Holdings
ING Luxembourg
Nestan S.A.
Pétrusse Participations S.A.
Pindo S.A.
PK-phi s.à r.l.
Premium Properties II S.à r.l.
Premium Properties II S.à r.l.
Premium Properties S.à r.l.
Produits Naturels Geimer - Wiltzius s. à r.l.
Société Immobilière ING Luxembourg S.àr.l.
'SOMALUX' Société de Matériel Luxembourgeoise S.A., SPF
Staminvest S.A.
Starten Partner S.A.
Synergie Investment
Tatsuma S.A.
Tepic Invest S.A.
Théâtre National du Luxembourg Productions, s.à r.l.
Twelve Allium S.à r.l.
UBS (Lux) Key Selection SICAV