This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 669
11 mars 2015
SOMMAIRE
4terra S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32076
AFLP Securitisation S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
32084
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l. . . . . . . . .
32080
Artichocs S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32070
Athena Topco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32075
Caduceus Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
32101
Carolin Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32066
CB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32066
Centric IT Solutions Luxembourg S.A. . . .
32067
CHC Helicopter (1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
32066
Colon River S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32066
Corestate Shelf Holdco 3 S.à r.l. . . . . . . . . .
32067
Digital Services XXXVIII S.à r.l. . . . . . . . . .
32102
IACG Holdings LUX S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
32072
Ideal Group Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . .
32071
International Radio Networks Holding S.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32072
Maxiver S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32071
Nido Notting Hill S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
32071
North Star Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . .
32112
Triple Aaart S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32068
UDM Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32069
United Bargain Société de Participations
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32068
Uranium Participation Cyprus Limited-Lu-
xembourg Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32073
Usantar Two S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32072
Valfidus S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32069
Vallis Sustainable Investments I Holding
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32068
VEM Financière Holdings S.A. . . . . . . . . . . .
32073
Ventara S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32069
Venusia Real Estate Investment S.A. . . . . .
32079
Venusia Real Estate Investment S.A. . . . . .
32079
Veolia Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32074
Vertrange Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
32073
VIGO INVEST S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32074
Villiot Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32075
Visionla SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32074
Vistra IP Rights S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32068
Vodafone Procurement Company S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32074
Wallberg Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32067
W.A. Verwijs Beheer S.à r.l. / B.V. . . . . . . .
32091
WPP Luxembourg Turris S.à r.l. . . . . . . . .
32070
Yum! Franchise China IV S.à r.l. . . . . . . . . .
32070
Zenview Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
32070
32065
L
U X E M B O U R G
Colon River S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 153.440.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015019492/10.
(150023794) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
CHC Helicopter (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.559.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015019516/10.
(150024007) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Carolin Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2537 Luxembourg, 19, rue Sigismond.
R.C.S. Luxembourg B 170.513.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Maître Léonie GRETHEN
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015019503/12.
(150023970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
CB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.266.
<i>Extrait du Procès verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social 217 route d’Esch L-1471 Luxembourg, le 28 janvier 2015i>
<i>à 11h00i>
<i>Délibérations:i>
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Le Conseil d'Administration désigne en tant que dépositaire des actions au porteur de la société, la banque BIL Lu-
xembourg S.A. ayant son siège social: 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg numéro
B 6.307.
Il est rappelé que le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes morales et physiques suivantes:
Monsieur Denis MINGARELLI
Monsieur Serge ATLAN
S.F.D. Sàrl
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019504/22.
(150023489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32066
L
U X E M B O U R G
Centric IT Solutions Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6633 Wasserbillig, 37CD, route de Luxembourg.
R.C.S. Luxembourg B 57.916.
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue en date du 21 janvier 2015 que
1. la démission de M Kurt Wach en tant qu'administrateur de catégorie A et Président du Conseil d'Administration
avec effet au 21 mai 2012 a été ratifiée.
2. les démissions de M Rene Nowotny en tant qu'administrateur de catégorie A et de M Steven Wernike en tant
qu'administrateur de catégorie B et avec effet au 12 novembre 2014 ont été acceptées.
3. M. Gerhard P. Sanderink, né le 19 août 1948 à Weerselo, Pays-Bas et résidant au Haarweg 75, NL-7544 RK Enschede
a été nommé en tant qu'administrateur unique avec effet au 12 novembre 2014,
Son mandat viendra à échéance à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2019.
Pour extrait conforme
SG AUDIT S.àr.l.
Référence de publication: 2015019490/17.
(150023238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Wallberg Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 137.988.
Mit Datum vom 28. Juli 2014 tritt Herr Vincent ANDRES in die Geschäftsführung der Gesellschaft ein.
Mit Datum vom 31. Dezember 2014 scheidet Herr Nikolaus RUMMLER aus der Geschäftsführung aus.
Geschäftsadresse von Herrn Andres: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
Die Aufgaben der täglichen Geschäftsführung übernehmen somit:
Herr Marcel ERNZER
Herr Christian KLEIN
Herr Vincent ANDRES
Geschäftsadresse von aller Geschäftsführer: 4, rue Thomas Edison, L-1445 Strassen.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Für Wallberg Invest S.A.
i>DZ PRIVATBANK S.A.
Référence de publication: 2015020081/18.
(150023053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Corestate Shelf Holdco 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.020.
EXTRAIT
Il résulte d'un acte de cession sous seing privé signé en date du 29 décembre 2014 que Corestate Capital AG, avec
siège social à Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Suisse), immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug
sous le numéro CHE-113.002.233 a cédé 20.313 parts sociales de la Société à la société vitB AG, avec siège social à
Baarerstrasse 135, CH-6300 Zug (Suisse), immatriculée auprès du registre de commerce du canton Zug sous le numéro
CH-115.022.991.
Partant, les 25.000 parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont réparties comme suit:
Corestate Capital AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.687
vitB AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.313
Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015019494/19.
(150023542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32067
L
U X E M B O U R G
Vistra IP Rights S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 83.554,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 148.864.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015020065/10.
(150024062) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Triple Aaart S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-8041 Strassen, 80, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 161.322.
EXTRAIT
A&C MANAGEMENT SERVICES, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 80, rue des Romains, L-8041
Strassen a été nommée en tant que dépositaire des actions au porteur de la société en date du 23/01/2015, et ce suivant
les dispositions de la Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions ou parts au porteur et à la tenue du
registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015020042/13.
(150023711) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Vallis Sustainable Investments I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1857 Luxembourg, 5, rue de Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 173.806.
<i>Extrait des résolutions de gérancei>
En date du 11 Novembre 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la Société du 6, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, au 5, rue de Kiem, L-1857 Luxembourg, et ce avec effet au 17 Novembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Février 2014.
Salvatore Rosato
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015020057/15.
(150023296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
United Bargain Société de Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 13.035.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour: UNITED BARGAIN SOCIETE DE PARTICIPATIONS S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015020053/16.
(150023609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32068
L
U X E M B O U R G
Valfidus S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 42-44, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 159.090.
La société a été constituée par acte notarié en date du 20 Janvier 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 1050 du 19 mai 2011.
Les comptes annuels de la Société au 31 Août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
VALFIDUS S.A.
Signature
Référence de publication: 2015020067/14.
(150023476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
UDM Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 170.660.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour: UDM HOLDING S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015020051/16.
(150023918) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Ventara S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 144.110.
EXTRAIT
Suite à un contrat de cession de parts sociales signé sous seing privé en date du 20 janvier 2015, entre:
EUROFINLEADING FIDUCIARIA Spa, avec adresse au 8, Via Porlezza, I-20123 Milan, Italie;
et
ERREDI INVEST Spa, avec adresse au 15, Via G. da Verrazano, Novara, Italie, inscrite au registre delle Imprese de
Novara sous le numéro 10627950016;
Il en résulte ce qui suit:
EUROFINLEADING FIDUCIARIA Spa, dont le siège social est situé au 8, Via Porlezza, I-20123 Milan, Italie, propriétaire
de 23.677 parts sociales de la société Ventara Sàrl, déclare céder à la société ERREDI INVEST Spa, avec adresse au 15,
Via G. da Verrazano, I-28100 Novara, Italie, inscrite au registre delle Imprese de Novara sous le numéro 10627950016,
9.181 parts sociales d'une valeur nominale de 25,00 Eur chacune de la société à responsabilité limitée de droit luxem-
bourgeois Ventara S.àr.l. établie et ayant son siège social à L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich, et inscrite
au Registre de Commerce et des Société de Luxembourg sous le numéro B 144.110,
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Xavier Mangiullo / Julien Nicaud
<i>Gérant / Géranti>
Référence de publication: 2015020072/24.
(150023292) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32069
L
U X E M B O U R G
Yum! Franchise China IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,02.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F.Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.950.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015020100/10.
(150023189) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
WPP Luxembourg Turris S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 13.192.563.721,00.
Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.
R.C.S. Luxembourg B 190.004.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015020096/10.
(150023963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Artichocs S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1319 Luxembourg, 93, rue Cents.
R.C.S. Luxembourg B 170.385.
Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 février 2015.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2015019390/11.
(150023365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Zenview Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 147.093.
Suite aux résolutions de l'associé unique en date du 21 janvier 2015 de la Société, les décisions suivantes ont été prises:
1. Démission du gérant B suivant à compter du 21 janvier 2015:
Madame Stéphanie Jung-Schut, née le 24 novembre 1975 à Metz, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
2. Nomination du gérant B suivant à compter du 21 janvier 2015 pour une durée indéterminée:
Monsieur Sébastien Rimlinger, né le 23 septembre 1975 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au 46A,
avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la société est comme suit:
- William Fung, Gérant A;
- Patrick L.C. van Denzen, Gérant B;
- Sébastien Rimlinger, Gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Patrick L.C. van Denzen
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015020102/22.
(150023462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32070
L
U X E M B O U R G
Nido Notting Hill S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 121.188.
EXTRAIT
Il est porté à la connaissance du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg que Monsieur Dean Merritt a
démissionné de ses fonctions de gérant de la Société avec effet au 31 janvier 2015.
Suite à cette démission, le Conseil de Gérance de la Société se présente désormais comme suit:
- Madame Jennika Lindholm, ayant son adresse professionnelle au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg,
- Monsieur Kemal Akyel, ayant son adresse professionnelle au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg.
Référence de publication: 2015019857/13.
(150023670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Ideal Group Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 17, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 70.773.
- Constituée suivant acte reçu par Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 16 juillet
1999, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 740 du 6 octobre 1999.
- Statuts modifiés en date du 4 novembre 2010 par-devant Maître Emile SCHLESSER, notaire de résidence à Lu-
xembourg, publié au Mémorial Recueil Spécial C n° 89 du 17 janvier 2011.
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui s'est tenue à L-Luxembourg en date
du 12 décembre 2014, que la décision suivante a été prise à l'unanimité des voix:
- Le siège social de la société IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A. est transféré du 223, Val Ste Croix, L-1371 Lu-
xembourg au 17, boulevard Roosevelt, L-2450 Luxembourg, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour la société IDEAL GROUP LUXEMBOURG S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015019712/18.
(150023707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Maxiver S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9690 Watrange, 41, rue Abbé Welter.
R.C.S. Luxembourg B 107.502.
Il résulte d'une cession de parts intervenue en date du 31 décembre 2014 que le capital social de la société se répartit
désormais comme suit:
M. Danny HEREMANS
39, rue Abbé Welter
L-9690 Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71 parts
M. Michaël HEREMANS
78, Biezenstraat
B-9420 Burst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts
M. Jonathan HEREMANS
25, Impegemstraat
B-1770 Liedekerke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40 parts
Mme Cornelia VAN EGDOM
39, rue Abbé Welter
L-9690 Watrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 parts
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 parts
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019846/23.
(150023574) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32071
L
U X E M B O U R G
International Radio Networks Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 75.960.
<i>Extrait des lettres de démission datées du 28 janvier 2015i>
En date du 28 janvier 2015, Madame Sylvie Abtal-Cola, Monsieur Abdelhakim Chagaar et Monsieur Johan Dejans ont
démissionné en tant qu'administrateurs de la société INTERNATIONAL RADIO NETWORKS HOLDING S.A., une
société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 75960, et ce avec effet
au 28 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 5 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019728/17.
(150023668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Usantar Two S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.
R.C.S. Luxembourg B 126.926.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration qui s'est tenue à Luxembourg, le 4 février 2015.i>
<i>Résolution uniquei>
Le conseil d'administration décide de coopter administrateur en remplacement de Monsieur Marco Sterzi, Monsieur
Sabrie Soualmia, né le 15 juillet 1982 à Metz, France et résident professionnellement au 5, Avenue Gaston Diderich,
L-1420 Luxembourg.
L'élection définitive de Monsieur Soualmia sera soumise à la plus proche assemblée générale des actionnaires.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Pour copie conforme
<i>Pour le conseil d'administration
i>Francesca Docchio / Xavier Mangiullo
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015020055/18.
(150023259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
IACG Holdings LUX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 710.000,00.
Siège social: L-1748 Findel, 4, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 164.610.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérancei>
En date du 19 novembre 2014, le conseil de gérance a pris connaissance de la démission de Monsieur Andrew Anderson
en tant que Délégué à la Gestion Journalière avec effet rétroactif au 1
er
février 2015.
En cette même date, le conseil de gérance a décidé de nommer Monsieur Carl-Johan Forsberg, né le 25 octobre 1963
à Lund en Suède, demeurant professionnellement au IAC Goup GmbH, 178 Theodorstrasse, D-40472 Düsseldorf, Alle-
magne, en tant que Délégué à la Gestion Journalière avec effet rétroactif au 1
er
février 2015 et ce jusqu'au 31 décembre
2019.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019710/19.
(150023770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32072
L
U X E M B O U R G
Uranium Participation Cyprus Limited-Luxembourg Branch, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 132.260.
Les comptes annuels de la personne morale de droit étranger au 28 février 2014 ont été déposés au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015020048/11.
(150023450) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Vertrange Holding S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 97.963.
EXTRAIT
Les administrateurs Monsieur Claude GEIBEN et Madame Gabriele SCHNEIDER, ainsi que le commissaire aux comp-
tes, Monsieur Michel SCHAEFFER ont démissionné avec effet immédiat.
L'administrateur, Monsieur Nicolas Schaeffer est décédé.
Luxembourg, le 30 janvier 2015.
POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
i>Signatures
Référence de publication: 2015020073/15.
(150023187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
VEM Financière Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 167.595.
Par résolutions signées en date du 29 janvier 2015, l'actionnaire unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Christophe Davezac, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,
au mandat d'administrateur de catégorie A, avec effet au 26 janvier 2015 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui
se tiendra en 2021;
2. Nomination de Frédéric Salvadore, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat d'administrateur de catégorie A, avec effet au 26 janvier 2015 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui
se tiendra en 2021;
3. Nomination de Laurent Isenegger, avec adresse professionnelle au 22, rue Général-Dufour, 1211 Genève, Suisse,
au mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet au 26 janvier 2015 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui
se tiendra en 2021;
4. Nomination d'Emilio Castelbolognesi, avec adresse au 5, Chemin des prés de la Gradelle, 1223 Cologny, Suisse, au
mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet au 26 janvier 2015 et pour une période venant à échéance lors de
l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31 décembre 2020 et qui
se tiendra en 2021;
5. Acceptation de la démission de Thierry Bounous, avec adresse professionnelle au 22, rue Général-Dufour, 1204
Genève, Suisse de son mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet au 26 janvier 2015;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015020071/28.
(150023204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32073
L
U X E M B O U R G
VIGO INVEST S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5241 Sandweiler, 45A, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 136.463.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015020074/9.
(150023471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Veolia Luxembourg, Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 52, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 18.830.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015020063/10.
(150023833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Vodafone Procurement Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000.000,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 97.920.
En date du 2 février 2015, l'associé unique de Vodafone Procurement Company S.à r.l. a décidé:
- D'accepter la démission de M. Stephen Day, avec adresse au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg en tant
que gérant de la société, et en tant que délégué à la gestion journalière de la société, avec effet au 31 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015020066/13.
(150023461) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Visionla SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 184.913.
<i>Extrait du Procès verbal du Conseil d’Administration tenu au siège social 217 route d’Esch L-1471 Luxembourg, le 28 janvier 2015i>
<i>à 14h00i>
<i>Délibérations:i>
Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité, prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
Le Conseil d'Administration désigne en tant que dépositaire des actions au porteur de la société, la banque BIL Lu-
xembourg S.A. ayant son siège social: 69 route d'Esch L-2953 Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg numéro
B 6.307.
Il est rappelé que le Conseil d'Administration de la société est composé des personnes morales et physiques suivantes:
Monsieur Denis MINGARELLI
Monsieur Serge ATLAN
S.F.D. Sàrl
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015020076/22.
(150023488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
32074
L
U X E M B O U R G
Athena Topco S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. Villiot Holdco S.à r.l.).
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 189.538.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of the month of December.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, having
a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and being registered with the Registre de Commerce
et des Sociétés in Luxembourg under number B 180.314 (the “Sole Shareholder”),
represented by Maître Flora Verrecchia, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy which
shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned
notary,
being the Sole Shareholder of Villiot Holdco S.à r.l., a société à responsabilité limitée (private limited liability company),
incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 2-4, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) and registered with the
Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 189.538 (the "Company"), incorporated on 11
August 2014 pursuant to a deed of Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) on 9 October 2014, number 2837.
The articles of association of the Company have never been amended.
The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the five hundred (500) shares in issue in the Company so that the total share capital
is represented and resolutions can be validly taken by the Sole Shareholder.
2. The item on which a resolution is to be taken is as follows:
Amendment of Article 1 of the articles of incorporation of the Company so that Article 1 of the articles of association
of the Company reads as follows:
“A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Athena Topco S.à r.l.” (the “Company”)
is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The Company will be
governed by these articles of association and the relevant legislation.”
Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder resolved to amend Article 1 of the articles of association of the Company so that Article 1 of
the articles of association of the Company reads as set out in the above agenda.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,
this deed is drafted in English followed by a German translation; at the request of the same appearing person in case of
divergences between the English and German version, the English version will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorhergehenden Englischen Textes:
Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebzehnten Dezember.
Vor Uns, Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
BRE/Europe 7NQ S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) luxemburgischen
Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital zwölftausendfünfhundert Euro
(EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de commerce et des sociétés in Luxemburg unter der Nummer B
180.314, (der «Alleinige Gesellschafter»),
hier vertreten durch Frau Verrecchia Flora, Rechtsanwältin, beruflich wohnhaft in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht
welche gegenwärtiger Urkunde beigefügt wird nachdem sie ne varietur durch den Vollmachtnehmer und den unter-
zeichnenden Notar unterschrieben wurde,
als Alleiniger Gesellschafter der Villiot Holdco S.à r.l., eine société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung) luxemburgischen Rechts mit Sitz in 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, deren Gesellschaftskapital
32075
L
U X E M B O U R G
zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) beträgt und eingetragen ist im Registre de Commerce et des Sociétés in
Luxemburg, unter der Nummer B 189.538 (die «Gesellschaft»), gegründet am 11. August 2014 gemäß Urkunde aufge-
nommen durch den Notar Me Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, veröffentlicht am 9. Oktober 2014 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das «Mémorial»), Nummer 2837.
Die Satzung der Gesellschaft wurde nie abgeändert.
Der Erschienene gibt, in Ausübung seines obenerwähnten Amtes, folgende Erklärungen ab und ersucht den amtieren-
den Notar folgendes zu beurkunden:
1. Der Alleinige Gesellschafter der Gesellschaft hält alle fünfhundert (500) von der Gesellschaft ausgegebenen Gesell-
schaftsanteile, so dass das gesamte Gesellschaftskapital vertreten ist und wirksam über alle Punkte der Tagesordnung
entschieden werden kann.
2. Der Punkt über den ein Beschluss getroffen werden soll ist der folgende:
Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft so dass Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft folgenden
Wortlaut hat:
“Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen "Athena Topco S.à
r.l." (die „Gesellschaft“) wird hiermit von der erschienenen Partei und allen Personen, die gegebenenfalls zukünftig als
Gesellschafter eintreten, gegründet. Die Gesellschaft wird durch vorliegende Satzung und durch die entsprechende lu-
xemburgische Gesetzgebung geregelt.”
Danach wurde der folgende Beschluss vom Alleinigen Gesellschafter getroffen:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Der Alleinige Gesellschafter hat beschlossen Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft abzuändern so dass Artikel 1 der
Satzung der Gesellschaft den Wortlaut hat wie in der Tagesordnung beschrieben.
Der amtierende Notar, der englischen Sprache kundig, stellt hiermit fest, dass auf Ersuchen der vorgenannten Partei,
diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, gefolgt von einer Übersetzung in deutscher Sprache. Im Falle von Ab-
weichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die englische Fassung maßgebend.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Erschienenen hat dieser mit dem amtierenden Notar diese
Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: F. VERRECCHIA und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63672. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR)
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 30. Januar 2015.
Référence de publication: 2015018578/90.
(150021408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
4terra S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5445 Schengen, 1D, Waïstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 110.535.
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am achtundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterschriebenen Notar Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.
Sind die Aktionäre der Aktiengesellschaft "4terra S.A. ", mit Sitz in L-5241 Sandweiler, 56, Rue Principale, eingetragen
im Handels-und Gesellschaftsregister Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 110.535 abgehalten.
Die Gesellschaft wurde durch notarielle Urkunde des Notars Joseph ELVINGER, mit damaligem Amtssitz in Luxem-
burg, handelnd in Vertretrung seines Kollegen Notar Jean-Paul HENCKS, damals mit Amtssitz in Luxemburg, am 17.
August 2005 gegründet, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, unter der Nummer 112 vom
17. Januar 2006. Die Satzung wurde seitdem nicht geändert.
Die außerordentliche Generalversammlung wird eröffnet unter dem Vorsitz von Frau Dagmar REBECK, Ingenieurin,
beruflich ansässig in 56, rue Principale, L-5241 Sandweiler.
Der Vorsitzende bestimmt zur Sekretärin Frau Corinne PETIT, Angestellte, beruflich ansässig in 74, avenue Victor
Hugo, L-1750 Luxemburg,
und die außerordentliche Generalversammlung bestimmt zum Stimmenzähler Frau Dagmar REBECK, vorbenannt.
Nachdem das Büro der außerordentliche Generalversammlung bestimmt und durch den Vorsitzenden festgestellt ist,
ersucht der Vorsitzende den Notar zu beurkunden, dass:
32076
L
U X E M B O U R G
I. Die anwesenden oder vertretenden Aktionäre sowie die jeweilige Anzahl der von ihnen gehaltenen Inhaberaktien
in einer Anwesenheitsliste aufgeführt sind. Diese Liste unterschrieben von den anwesenden Personen und von dem Notar,
wird dieser Urkunde beigefügt und verbleibt bei dem Protokoll.
II. Sich aus der Anwesenheitsliste ergibt, dass alle eintausendzweihundertvierzig (1.240) Aktien, welche das vollständige
Kapital der Gesellschaft darstellen in dieser Versammlung vertreten sind so dass diese über alle Punkte der Tagesordnung
rechtsgültig entscheiden kann, über die die Aktionäre vor der außerordentlichen Generalversammlung unterrichtet wur-
den.
III. Die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung lautet wie folgt:
1. Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5241 Sandweiler, 56, rue Principale nach L-5445 Schengen, 1D, Wäistrooss
mit sofortiger Wirkung;
2. Entsprechende Abänderung von Artikel 2, erster Satz, der Satzung;
3. Änderung von Artikel 5 der Satzung, um diesen dem neuen Gesetz vom 28. Juli 2014 in Bezug der Innhaberaktien
anzupassen und folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in eintausendzweihun-
dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR).
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des
Verwaltungsrats bestellt wird.
Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den
Verwahrer innerhalb 15 (fünfzehn) Werktagen.
Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß
Artikel 11bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffent-
licht werden
Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.
Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahlt oder Einheiten von Inhaberaktien welche
von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inha-
beraktien, auf.
Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.
Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 (acht) Kalendertage eine
Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.
Übertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung
dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments
welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.
Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist,
durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.
Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als aus-
gesetzt.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.“
4. Änderung von Artikel 6 und 9 der Satzung, um diese dem Gesetz vom 25. August 2006 anzupassen und folgenden
Wortlaut zu geben:
„ Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens 3 (drei) Mitgliedern verwaltet. Hat die
Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August 2006,
aus nur einem Mitglied bestehen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Gene-
ralversammlung der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der General-
versammlung festgesetzt.“
„ Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft rechtsverbindlich durch (i) die gemeinsame Unterschrift von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern, von denen ein die des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des Verwaltungs-
rats sein muss, (ii) die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder (iii) die Einzelunterschrift des
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des Verwaltungsrates verpflichtet, ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung
vorgesehenen Vollmachten.“;
32077
L
U X E M B O U R G
5. Verschiedenes.
Nach Zustimmung der Berichte des Vorsitzenden und Feststellung der ordnungsgemäßen Zusammensetzung, fasst die
außerordentliche Generalversammlung einstimmig die folgenden Beschlüsse:
<i>Erster Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die Verlegung des Gesellschaftssitzes von L-5241 Sandweiler,
56, rue Principale nach L-5445 Schengen, 1D, Wäistrooss mit sofortiger Wirkung.
<i>Zweiter Beschlussi>
In Anbetracht des vorher gefassten Beschlusses wird Artikel 2, erster Satz der Satzung von nun an folgenden Wortlaut
haben:
" Art. 2. (erster Satz). Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Schengen.“
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung beschließt Artikel 5 der Satzung zu ändern, um diesen dem neuen Gesetz vom 28. Juli 2014
in Bezug der Innhaberaktien anzupassen und folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 5. Das Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (31.000.- EUR), eingeteilt in eintausendzweihun-
dertvierzig (1.240) Aktien mit einem Nominalwert von je fünfundzwanzig Euro (25.- EUR).
Nach Wunsch der Aktionäre können Einzelaktien oder Zertifikate über zwei oder mehrere Aktien ausgestellt werden.
Die Aktien sind Namens- oder Inhaberaktien, nach Wahl der Aktionäre.
Alle ausgegebenen Inhaberaktien müssen bei einem Verwahrer hinterlegt werden welcher durch einen Beschluss des
Verwaltungsrats bestellt wird.
Der Verwaltungsrat informiert die Gesellschafter über diese Bestellung und über jedwede Änderung betreffend den
Verwahrer innerhalb 15 (fünfzehn) Werktagen.
Beschlüsse über die Ernennung oder die Kenntnisnahme von Änderungen betreffend den Verwahrer müssen, gemäß
Artikel 11bis (1§, 3) des Gesetzes vom 10. August 1915 über handelsrechtliche Gesellschaften, registriert und veröffent-
licht werden
Ein Inhaberaktienregister wird vom Verwahrer gehalten.
Dieses Register weist die Identität eines jeden Gesellschafters, die Anzahlt oder Einheiten von Inhaberaktien welche
von diesen gehalten wird, den Zeitpunkt der Verwahrung, sowie Übertragungen, Einziehung oder Umtausch von Inha-
beraktien, auf.
Der Anteilsbesitz der Inhaberaktien wird gemäß Eintragung im Inhaberaktienregister geltend gemacht.
Nach schriftlicher Aufforderung des Eigentümers von Inhaberaktien, wird diesem innerhalb 8 (acht) Kalendertage eine
Bescheinigung ausgestellt welche die Eintragungen seiner Inhaberaktien zusammenfasst.
Übertragungen von Inhaberaktien inter vivos werden gegenüber Dritten und Gesellschaft wirksam durch die Eintragung
dieser Übertragung im Inhaberaktienregister durch den Verwahrer, auf Basis und durch Erhalt eines jeden Dokuments
welches deren Eigentumsübertragung zwischen Übertragendem und Empfänger nachweist.
Die Anzeige einer Übertragung von Todes wegen beim Verwahrer ist gültig, wenn kein Widerspruch vorhanden ist,
durch die Hinterlegung eines Todesscheins welcher durch den zuständigen Richter oder Notar ausgestellt wurde.
Rechte von ausgegebenen Inhaberaktien welche weder verwahrt noch ordnungsgemäß registriert sind, gelten als aus-
gesetzt.
Die Gesellschaft kann zum Rückkauf ihrer eigenen Aktien schreiten, unter den durch das Gesetz vorgesehenen Be-
dingungen.
Unter den gesetzlichen Bedingungen kann ebenfalls das Gesellschaftskapital erhöht oder vermindert werden.“
<i>Vierter Beschlussi>
Die außerordentliche Generalversammlung beschließt die Änderung von Artikel 6 und 9 der Satzung, um diese dem
neuen Gesetz vom 25. August 2006 anzupassen und folgenden Wortlaut zu geben:
„ Art. 6. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat von mindestens 3 (drei) Mitgliedern verwaltet. Hat die
Gesellschaft nur einen Aktionär kann der Verwaltungsrat, in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 25. August 2006,
aus nur einem Mitglied bestehen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrates müssen nicht Aktionär der Gesellschaft sein. Sie werden ernannt von der Gene-
ralversammlung der Aktionäre; die Dauer ihrer Amtszeit darf sechs Jahre nicht überschreiten.
Die Generalversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit die Mitglieder des Verwaltungsrates abberufen.
Die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates, ihre Bezüge und die Dauer ihrer Amtszeit werden von der General-
versammlung festgesetzt.“
32078
L
U X E M B O U R G
„ Art. 9. Drittpersonen gegenüber wird die Gesellschaft rechtsverbindlich durch (i) die gemeinsame Unterschrift von
zwei Verwaltungsratsmitgliedern, von denen eine die des geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des Verwal-
tungsrats sein muss, (ii) die Einzelunterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitgliedes oder (iii) die Einzelunterschrift des
geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedes des Verwaltungsrates verpflichtet, ungeachtet der in Artikel 10 der Satzung
vorgesehenen Vollmachten.“
Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abschließend von der außerordentlichen Generalversammlung behandelt
wurden, wurde diese für beendet erklärt.
<i>Abschätzung der Kosteni>
Der Betrag der Kosten für die Gesellschaft aufgrund dieser Satzungsänderung aufzukommen hat, beläuft sich auf ein-
tausendzweihundert Euro (1.200.- EUR).
<i>Erklärungi>
Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie am Anfang dieser Urkunde erwähnt.
Und nach Vorlesung an alle Erschienenen und Übersetzung in die Sprache der Vertreter der Erschienenen, alle dem
Notar nach Vor-und Nachnamen, Personenstand und Wohnort bekannt, haben alle die gegenwärtige Urkunde mit dem
Notar unterschrieben.
Signé: D. Rebeck, C. Petit et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/2153. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015018610/152.
(150021801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
VRE, Venusia Real Estate Investment S.A., Société Anonyme,
(anc. Venusia Real Estate Investment S.A.).
Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 96.585.
L'an deux mil quinze, le sept janvier
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme VENUSIA REAL ESTATE INVESTMENT
S.A., avec siège social à L-1470 Luxembourg, 7, Route d’Esch, constituée suivant acte reçu par le notaire Maître André-
Jean-Joseph SCHWACHTGEN, alors de résidence à Luxembourg, en date du 29 octobre 2001, publié au Mémorial C,
Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 365 du 6 mars 2002, et dont les statuts ont été modifiés le 17
octobre 2003 suivant acte reçu par Maître Anja HOLTZ, alors de résidence à Wiltz, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, numéro 1265 du 28 novembre 2003,
inscrite au registre du commerce et des sociétés Luxembourg sous le numéro B 96.585;
L’assemblée est ouverte à 11 heures sous la présidence de Madame Marie DAL PONT, demeurant professionnellement
à Doncols qui fait également office de scrutateur,
qui désigne comme secrétaire Monsieur Max WAGNER, demeurant professionnellement à Wiltz,
Le bureau ainsi constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour
<i>Ordre du jouri>
1. Modification de la dénomination sociale;
2. Divers
II. Que la présente assemblée a été régulièrement convoquée de la manière suivante:
- Le 8 décembre 2014 dans le Mémorial, recueil C, n° 3761, page 180482;
- Le 8 décembre 2014 dans le Journal page 08;
- Le 16 décembre 2014 dans le Mémorial, recueil C, n° 3884, page 186392;
- Le 16 décembre 2014 dans le Journal page 28;
32079
L
U X E M B O U R G
III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d’actions qu’ils
détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été
signées «ne varietur» par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres
du bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes, avec lesquelles elles seront enregistrées.
IV. Que la présente assemblée, réunissant quatre-vingt-dix-neuf virgule neuf pour cent (99.9%) du capital social, est
constituée régulièrement et peut valablement délibérer, telle qu’elle est constituée, sur les points de l'ordre du jour.
Ces faits étant reconnus exacts par l'assemblée, la Présidente expose les raisons qui ont amené le conseil d’adminis-
tration à proposer les points figurant à l'ordre du jour.
L’assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Résolution Uniquei>
L’assemblée des actionnaires décide de changer la dénomination sociale de la société et modifie en conséquence l'article
1
er
des statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il est formé par les comparantes et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées
une société anonyme sous la dénomination de «Venusia Real Estate Investment S.A.», en abrégé «VRE»».
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la présente assemblée a été clôturée à 11.30 heures.
<i>Fraisi>
Le montant des dépens, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la société ou qui sont mis
à sa charge à raison du présent acte s’élèvent approximativement à 800.-EUR
Dont acte, fait et passé à Wiltz, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par noms, prénoms
usuels, états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Dal Pont M., Wagner M., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 8 janvier 2015, Relation: DAC/2015/279, Reçu soixante-quinze euros (75 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 14 janvier 2015.
Référence de publication: 2015018583/57.
(150022061) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.550.000,00.
Siège social: L-2338 Luxembourg, 5, rue Plaetis.
R.C.S. Luxembourg B 120.646.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an extraordinary general meeting of the sole shareholder of “Amazon Eurasia Holdings S.à.r.l.”, a Luxembourg "société
à responsabilité limitée", having its registered office at 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 120.646, incorporated by deed
enacted by Maître Joseph Elvinger, notary public residing in Luxembourg, on 19 September 2006, published in the “Mé-
morial C, Recueil des Sociétés et Associations” no. 2266 of 5 December 2006 (the “Company”). The articles of association
of the Company have been lastly amended by notarial deed enacted on 20 August 2013, published in the “Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations” number 2484, dated 8 October 2013.
THERE APPEARED
The sole shareholder of the Company, Amazon Europe Holdings Technologies S.C.S. having its registered office at 65,
Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (the “Sole Shareholder” or
the “Contributor”), duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, by virtue of a proxy given under private seal
on 14 December 2014.
The above-mentionned proxy, being initialled “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, shall
remain annexed to the present deed to be filed at the same time time with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:
I. - That the 1,323 (one thousand three hundred twenty-three) shares of the Company with a nominal value of EUR
12,500 (twelve thousand five hundred Euros), representing the whole share capital of the Company, are represented so
32080
L
U X E M B O U R G
that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been
duly informed beforehand.
II. - The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the company by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), so
as to raise it from its current amount of EUR 16,537,500 (sixteen million five hundred thirty-seven thousand five hundred
Euro) to EUR 16,550,000 (sixteen million five hundred fifty thousand Euro) by the issuance of 1 (one) new share with a
nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro), subject to payment of a share premium amounting to
EUR 298,934,344 (two hundred ninety-eight million nine hundred thirty-four thousand three hundred forty-four Euro)
out of which an amount of EUR 1,250 (one thousand two hundred fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of
the Company;
3. Subscription, intervention of the subscriber and payment of the new shares of the Company by way of a contribution
in kind;
4. Subsequent amendment of article 8 paragraph 1 of the articles of association of the Company in order to reflect
the new share capital of the Company pursuant to resolutions 2. and 3. above; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to
deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the
meeting has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to
examine carefully each document.
<i>Second resolution:i>
It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred
Euro), so as to raise the share capital from its current amount of EUR 16,537,500 (sixteen million five hundred thirty-
seven thousand five hundred Euro) to EUR 16,550,000 (sixteen million five hundred fifty thousand Euro), by the issuance
of 1 (one) new share with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) (the “New Share”), subject
to the payment of a share premium (the “Share Premium”) amounting to EUR 298,934,344 (two hundred ninety-eight
million nine hundred thirty-four thousand three hundred forty-four Euro), out of which an amount of EUR 1,250 (one
thousand two hundred fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company, the whole to be fully paid up
through a contribution in kind by the Sole Shareholder of a claim of an aggregate amount of EUR 298,946,844 (two
hundred ninety-eight million nine hundred forty six thousand eight hundred forty-four Euro) (the “Contribution”).
<i>Third resolution:i>
It is resolved to accept the subscription and payment by the Contributor of the New Share, the Share Premium and
the legal reserve through the Contribution.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Sole Shareholder, here represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing profes-
sionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal and declares to subscribe to the New Share, having
an aggregate nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro). The issuance of the New Share is also
subject to the payment of the Share Premium, amounting to EUR 298,934,344 (two hundred ninety-eight million nine
hundred thirty-four thousand three hundred forty-four Euro) out of which an amount of EUR 1.250 (one thousand two
hundred fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company. The New Share as well as the Share Premium
have been fully paid up by the Contributor through the Contribution.
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution amounts to EUR 298,946,844 (two hundred ninety-eight million nine hundred forty
six thousand eight hundred forty-four Euro).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated 15 December 2014, whereby the managers of the Company acknowledge their responsibility as managers in the
case of a capital increase and which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of regis-
tration.
The Contribution is allocated as follows:
- EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) to the share capital;
32081
L
U X E M B O U R G
- EUR 298,934,344 (two hundred ninety-eight million nine hundred thirty-four thousand three hundred forty-four
Euro) to the share premium account of the Company out of which an amount of EUR 1.250 (one thousand two hundred
fifty Euro) shall be allocated to the legal reserve of the Company.
<i>Evidence of the Contribution’s existencei>
A proof of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution described above having been fully
carried out, it is resolved to amend the first paragraph of article 8. of the Company’s articles of association (the second
paragraph of article 8. shall remain unchanged) to read as follows:
“ Art. 8. The Company's capital is set at EUR 16,550,000 (sixteen million five hundred fifty thousand Euro), represented
by 1,324 (one thousand three hundred twenty-four) shares with a nominal value of EUR 12,500 (twelve thousand five
hundred Euro) each.”
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about eight thousand Euros (8,000.-Euro).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le dix-septième jour de décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de «Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.», une société à res-
ponsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 5 rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 120.646, con-
stituée suivant acte notarié reçu par devant Maître Joseph Elvinger, notaire public résidant à Luxembourg, le 19 septembre
2006, publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» numéro 2266 en date du 5 décembre 2006, (la
«Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés dernièrement par acte notarié, en date du 20 août 2013, publié au
«Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» numéro 2484 en date du 8 octobre 2013.
A COMPARU:
I.- L’associé unique de la Société, Amazon Europe Holdings Technologies S.C.S. ayant son siège social au 65, Boulevard
Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, (l’»Associé Unique» ou l’»Apporteur»),
dûment représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, en vertu d’une procuration donnée par acte sous seing privé
en date du 14 décembre 2014.
La procuration susmentionnée, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le
notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.
L’Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d’enregistrer comme suit:
I.- Que les 1.323 (mille trois cent vingt-trois) parts sociales de la Société, d’une valeur nominale de 12.500 EUR (douze
mille cinq cent Euros) chacune, représentant l’intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte
que l’assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l’ordre du jour, dont l’Associé Unique a été dûment
informé par avance.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros), afin de le
porter de son montant actuel de 16.537.500 EUR (seize millions cinq cent trente-sept mille cinq cent Euros) à 16.550.000
EUR (seize millions cinq cent cinquante mille Euros) par l’émission d’1 (une) nouvelle part sociale ayant une valeur nominale
de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros), moyennant le paiement d’une prime d’émission d’un montant de 298.934.344
32082
L
U X E M B O U R G
EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent trente-quatre mille trois cent quarante-quatre Euros), dont un
montant de 1.250 (mille deux cent cinquante Euros) sera alloué à la réserve légale de la Société;
3. Souscription, intervention du souscripteur et paiement de la nouvelle part sociale de la Société par voie d’un apport
en nature;
4. Modification subséquente du paragraphe 1 de l’article 8 des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital
social de la Société conformément aux résolutions 2. et 3. qui précèdent; et
5. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été prises:
<i>Première résolution:i>
Il est décidé que l’Associé Unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l’Associé
Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en
conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que
l’ensemble de la documentation produite lors de cette assemblée a été mis à la disposition de l’Associé Unique dans un
laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Seconde résolution:i>
Il est décidé d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros), afin
de le porter de son montant actuel de 16.537.500 EUR (seize millions cinq cent trente-sept mille cinq cent Euros) à
16.550.000 EUR (seize millions cinq cent cinquante mille Euros) par l’émission d’1 (une) nouvelle part sociale ayant une
valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros), (la «Nouvelle Part Sociale»), moyennant le paiement d’une
prime d’émission (la «Prime d’Emission») d’un montant de 298.934.344 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions
neuf cent trente-quatre mille trois cent quarante-quatre Euros), dont un montant de 1.250 (mille deux cent cinquante
Euros) sera alloué à la réserve légale de la Société, la totalité devant être libérée par voie d’apport en nature par l’Associé
Unique consistant en une créance d’un montant total de 298.946.844 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf
cent quarante-six mille huit cent quarante-quatre Euros) (l’»Apport»).
<i>Troisième résolution:i>
Il est décidé d’accepter la souscription et le paiement par l’Apporteur de la Nouvelle Part Sociale, de la Prime d’Emission
et la réserve légale par la voie de l’Apport.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient alors l’Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au
Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé et déclare souscrire à la Nouvelle Part Sociale, ayant
une valeur nominale totale de 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros). L’émission de la Nouvelle Part Sociale est soumise
au paiement de la Prime d’Emission d’un montant de 298.934.344 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent
trente-quatre mille trois cent quarante-quatre Euros), dont un montant de 1.250 (mille deux cent cinquante Euros) sera
alloué à la réserve légale de la Société. La Nouvelle Part Sociale ainsi que la Prime d’Emission ont été entièrement libérées
par l’Associé Unique au travers de l’Apport.
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l’Apport s’élève à 298.946.844 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent quarante-
six mille huit cent quarante-quatre Euros).
Cette évaluation a été approuvée par les gérants de la Société en vertu d’une déclaration de valeur d’apport en date
du 15 décembre 2014, par laquelle les gérants de la Société reconnaissent leur responsabilité en tant que gérants en cas
d’augmentation de capital et qui restera annexée au présent acte.
L’Apport est affecté comme suit:
- 12.500 EUR (douze mille cinq cent Euros) au capital social;
- 298.934.344 EUR (deux cent quatre-vingt-dix-huit millions neuf cent trente-quatre mille trois cent quarante-quatre
Euros) au compte de prime d’émission de la Société, dont un montant de 1.250 (mille deux cent cinquante Euros) sera
alloué à la réserve légale de la Société.
<i>Preuve de l’existence de l’apporti>
Preuve de l’existence de l’Apport a été donnée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l’Apport décrit ci-dessus ayant été entièrement réalisé,
il est décidé de modifier le premier paragraphe de l’article 8. des statuts de la Société (le second paragraphe de l’article
8. restera inchangé) pour qu’il soit rédigé comme suit:
32083
L
U X E M B O U R G
« Art. 6. Le capital de la Société est fixé à 16.550.000 EUR (seize millions cinq cent cinquante mille Euros), représenté
par 1.324 (mille trois cent vingt-quatre) parts sociales ayant une valeur nominale de 12.500 EUR (douze mille cinq cent
Euros) chacune.»
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec son augmentation de capital, ont été estimés approximativement à huit mille Euros (8.000.-
Euros).
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au comparant, il a signé avec nous, notaire, la présente minute.
Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais constate que, sur demande du comparant, le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63333. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015018634/205.
(150022602) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
AFLP Securitisation S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1460 Luxembourg, 48, rue d'Eich.
R.C.S. Luxembourg B 194.181.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-second of January.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared:
SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., a Luxembourg société anonyme, having its registered office at 31, Grand Rue,
L-1661 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 117.449,
here represented by Mr Sylvain KIRSCH, director, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given
on January 22
nd
, 2015.
Which proxy shall be signed “ne varietur” by the attorney of the above named party and the undersigned notary and
shall remain annexed to the present deed for purposes of registration.
The above named party, represented as mentioned above, has declared its intention to constitute by the present deed
a private limited liability company under the name of AFLP Securitisation S.à r.l (the “Company”) and to draw up its
articles of association as follows:
Title I. - Object - Denomination - Registered office - Duration
Art. 1. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) being a securitization company
(société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg law of 22 March 2004 on securitisation, as amended
(hereafter the "Securitization Law") and which shall be governed by the Securitization Law, the law of 10 August 1915
regarding commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by these articles of incorporation (the “Articles”).
Art. 2. The name of the Company is "AFLP Securitisation S.à r.l.".
Art. 3. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred within the
municipality by decision of the sole manager or the board of managers, as the case may be.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at
the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such deci-
sion, however, shall have no effect on the nationality of the Company.
32084
L
U X E M B O U R G
Such declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by
the organ of the Company that is best situated for this purpose under such circumstances.
Art. 4. The Company is established for an unlimited period.
Art. 5. The Company shall have as its business purpose the securitization, within the meaning of the Securitization Law
whereas the Company shall acquire the risks derived from certain underlying assets (the "Permitted Assets"). It may also
transfer and dispose of the Permitted Assets it holds, whether existing or future in one or more transactions or on a
continuous basis. The Company may enter into any agreement and perform any action necessary or useful for the purposes
of securitizing Permitted Assets, provided it is consistent with the Securitization Law.
The Company will finance itself through the issuance of bonds, notes or other debt securities (howsoever described)
and, on an ancillary basis, through loans and whether on a secured or unsecured basis and from any person permitted by
applicable law (including the Company's shareholders).
Art. 6. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers of the Company may, in accordance
with the terms of the Securitization Law, and in particular its article 5, create one or more compartments within the
Company. Each compartment shall correspond to a distinct part of the assets and liabilities in respect of the corresponding
funding. The resolution of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers creating one or more
compartments within the Company, as well as any subsequent amendments thereto, shall be binding as of the date of
such resolutions against any third party.
As between investors, each compartment of the Company shall be treated as a separate entity. Rights of creditors and
investors of the Company that (i) have been designated as relating to a compartment or (ii) have arisen in connection
with the creation, the operation or the liquidation of a compartment are strictly limited to the assets of that compartment
which shall be exclusively available to satisfy such creditors and investors. Creditors and investors of the Company whose
rights are not related to a specific compartment of the Company shall have no rights to the assets of any such compart-
ment.
Unless otherwise provided for in the resolution of the manager, or in case of plurality of managers, the board of
managers of the Company creating such compartment, no resolution of the manager or board of managers of the Com-
pany may amend the resolution creating such compartment or to directly affect the rights of the creditors whose rights
relate to such compartment without the prior approval of the creditors whose rights relate to such compartment. Any
decision of the manager or in case of plurality of managers, the board of managers, taken in breach of this provision shall
be void.
Without prejudice to what is stated in the preceding paragraph, each compartment of the Company may be separately
liquidated without such liquidation resulting in the liquidation of another compartment of the Company or of the Company
itself.
Art. 7. The bankruptcy or the insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders
does not trigger the dissolution of the Company.
Title II. - Capital - Shares
Art. 8. The capital of the Company is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) divided into twelve
thousand five hundred (12,500) shares of one euro (EUR 1) each.
Art. 9. Shares can be freely transferred by the sole shareholder as long as there is only one shareholder.
In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfers of shares
inter vivos to nonshareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing at least three-
quarters (3/4) of the capital. For all other matters pertaining to transfers of shares, reference is made to Articles 189 and
190 of the Law.
Art. 10. A shareholder as well as the heirs and representatives or entitled persons and creditors of a shareholder
cannot, under any circumstances, request the affixing of seals on the assets and documents of the Company, nor become
involved in any way in its administration.
In order to exercise their rights they have to refer to the financial statements and to the decisions of the general
meetings.
Title III. - Management
Art. 11. The Company is managed by one or more managers appointed by the participants for an undetermined term.
If several managers are appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) may be revoked ad nutum.
In case of plurality of managers, the members of the board of managers will appoint a chairman who shall be a member
of the board of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers is invested with the broadest powers to
perform all acts necessary or useful for the accomplishment of the corporate purpose of the Company, except those
expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of participants.
32085
L
U X E M B O U R G
Any litigation involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company
by the manager, or in case of plurality of managers, by the board of managers represented by the manager delegated for
this purpose.
In case of plurality of managers, the Company shall be bound by the joint signature of any two members of the board
of managers.
The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his/its powers for specific
tasks to one or several ad hoc agents.
In case of plurality of managers, the board of managers may only deliberate or act validly if at least fifty percent (50%)
of its members is present either in person or by proxy.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the votes of the managers present either
in person or by proxy. The chairman of the board of managers shall have a casting vote.
All meetings of the board of managers shall be held in Luxembourg.
Resolutions signed by all members of the board of managers will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly
convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and
may be evidenced by letter, telefax or similar communication.
In addition, any member of the board of managers who participates in the proceedings of a meeting of the board of
managers by means of a communication device (including a telephone), which allows all the other members of the board
of managers present at such meeting (whether in person or by proxy or by means of such type of communications device)
to hear and to be heard by the other members at any time, shall be deemed to be present at such meeting and shall be
counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting.
If a resolution is taken by way of conference call, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg
if the call is initiated in Luxembourg.
Title IV. - Supervision
Art. 12. The accounts of the Company are audited by one or more approved statutory auditors (réviseur d'entreprises
agréé).
The approved statutory auditor(s) shall be appointed by the sole manager or the board of managers of the Company,
which shall determine their number, remuneration and the duration of their appointment.
Title V. - General meeting of shareholders
Art. 13. The sole shareholder shall exercise all the powers vested in the general meeting of the shareholders under
section XII of the Law.
All decisions exceeding the powers of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers shall be
taken by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of the shareholders. Any such decisions
shall be in writing and shall be recorded on a special register.
In case there is more than one shareholder, decisions of shareholders shall be taken in a general meeting or by written
consultation at the initiative of the management. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the
shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital. General meetings of shareholders shall be held
in Luxembourg.
Title VI. - Financial year - Profits - Reserves
Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on 1 January of each year and shall terminate on 31 December
of the same year.
Art. 15. Each year on 31 December an inventory of the assets and the liabilities of the Company together with a balance
sheet and a profit and loss account shall be prepared.
The revenues of the Company, deduction made of general expenses and charges, amortization and provisions consti-
tute the net profit.
After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortization, the credit balance represents
the net profits of the Company. Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this
deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of the Company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls
below 10 % of the capital of the Company.
The balance is at the disposal of the sole shareholder or of the general meeting of shareholders, as the case may be.
Title VII. - Liquidation - Dissolution
Art. 16. Without prejudice to the provisions set out in the last paragraph of article 6, and subject to the authorisation
of the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders, which may be required when the articles
of incorporation of the Company are modified, each compartment of the Company may be put into liquidation and its
shares redeemed by a decision of the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers, of the Company.
32086
L
U X E M B O U R G
Art. 17. In case of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or more liquidators who need
not be shareholders, designated by the sole shareholder or, as the case may be, by the meeting of shareholders in
accordance with the majority condition set out under Article 142 of the Law.
The liquidator(s) shall be vested with the broadest powers for the realization of the assets and payment of the liabilities.
Title VIII. - Varia
Art. 18. The parties refer to the existing legal provisions for all matters not provided for in the present articles of
incorporation.
<i>Transitional provisioni>
The first financial year shall begin on the date of the formation of the Company and shall end on 31 December 2015.
<i>Subscriptioni>
The articles of incorporation having thus been established, the appearing party declares to subscribe the whole capital
as follows:
Shares
SYCAMORE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500
The shares have been fully paid up to the amount of one euro (EUR 1) per share by a contribution in cash of twelve
thousand five hundred euro (EUR 12,500). As a result the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500)
is as of now at the disposal of the Company as has been certified to the notary executing this deed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euro
(EUR 1,500).
<i>Extraordinary general meetingi>
After the articles of incorporation have thus been drawn up, the above named shareholder has immediately proceeded
to hold an extraordinary general meeting. Having first verified that it was regularly constituted, it passed the following
resolutions:
1. The registered office of the Company is established at 48, rue d’Eich, L-1460 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as managers (gérants) of the Company and shall be members of the board of
managers of the Company for an undetermined period of time:
a) Mr Pascal BRUZZESE, company director, born on April 7
th
, 1966 in Esch-sur-Alzette (Grand Duchy of Luxem-
bourg), having his professional address at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg;
b) Mr Fabien WANNIER, company director, born on July 18
th
, 1977 in Bern (Switzerland), with professional address
at Downtown Dubai, P.O. Box 123234, Apt nr. 2008, Dubai, United Arab Emirates;
c) Mrs Milène BELEM, company director, born on August 13
th
, 1985 in Samuel / Soure (Portugal), with professional
address at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg; and
d) Mr Sylvain KIRSCH, company director, born on April 8
th
, 1956, in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg),
with professional address at 48, rue d'Eich, L-1460 Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a German translation. On request of the same appearing
person and in case of differences between the English and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this
document.
The deed having been read to the appearing person, whom is known to the notary by its surname, first name, civil
status and residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.
Follows the German version:
Im Jahr zweitausendfünf, am zweiundzwanzigsten Januar.
Vor dem unterzeichneten Notar Martin SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Ist Erschienen:
SYCAMORE LUXEMBOURG S.A., eine luxemburgische société anonyme, mit Sitz in der 31, Grand Rue, L-1661 Lu-
xemburg, eingetragen im Luxembourg Handelsregister unter der Nummer B 117.449,
hier vertreten durch Herrn Sylvain KIRSCH, Geschäftsführer, mit beruflicher Adresse in Luxemburg, durch eine am
22. Januar 2015 erteilte Vollmacht.
32087
L
U X E M B O U R G
Welche Vollmacht, nachdem sie durch den oben genannten Vertreter und den unterzeichnenden Notar „ne varietur“
gezeichnet wurde, mit dieser Urkunde verbunden bleiben soll, um zusammen registriert zu werden.
Die erschienene Partei, vertreten wie oben beschrieben, hat den Notar gebeten, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung société à responsabilité limitée namens AFLP Securitisation S.à r.l. (die" Gesellschaft"), welche die
Partei gründet, wie folgt zu beurkunden:
Titel I. - Zweck, Bezeichnung, Sitz, Dauer
Art. 1. Es gibt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche als Verbriefungs-
gesellschaft im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen, wie abgeändert (das „Verbriefungsgesetz“),
gilt, und welche dem Verbriefungsgesetz, dem Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften, wie abgeändert
(das „Gesetz“), sowie dieser Satzung (die „Satzung“), unterliegt.
Art. 2. Die Gesellschaft führt die Bezeichnung „AFLP Securitisation S.à r.l.".
Art. 3. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Er kann innerhalb der Stadt Luxembourg durch
Entscheidung des Geschäftsführers oder, je nach dem Fall, der Geschäftsführer, verlegt werden.
Sofern außerordentliche Ereignisse, insbesondere politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur einzutreten drohen
oder eingetreten sind, welche die normale Geschäftstätigkeit der Gesellschaft an ihrem Sitz oder die Verbindung zwischen
diesem Sitz und ausländischen Staaten beeinträchtigen, kann die Gesellschaft ihren Sitz nach Maßgabe der in Luxemburg
geltenden Rechtsvorschriften vorübergehend bis zum Ende dieser Ereignisse in einen anderen Staat verlegen. Eine solche
Sitzverlegung hat keinen Einfluss auf die Nationalität der Gesellschaft.
Die Erklärung der Sitzverlegung soll Dritten durch jenes Organ der Gesellschaft bekannt gemacht werden, welches
angesichts der herrschenden Umstände am besten dazu in der Lage ist.
Art. 4. Die Gesellschaft ist auf unbeschränkte Dauer gegründet.
Art. 5. Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Verbriefungsgeschäften im Sinn des Verbriefungsgesetzes, das
auf die Gesellschaft Anwendung findet, wobei die Gesellschaft Risiken erwerben soll, die sich aus bestimmten Vermö-
gensgegenständen ergeben (die „Zulässigen Vermögensgegenstände"). Die Gesellschaft kann die Zulässigen Vermögens-
gegenstände in einer oder mehreren Transaktionen oder auf einer dauernden Basis übertragen und über sie verfügen.
Die Gesellschaft kann jede Art von Vertrag abschließen und alle Aktivitäten ausüben, die für die Durchführung der Ver-
briefung der Zulässigen Vermögensgegenstände erforderlich oder nützlich sind, wenn und soweit diese mit dem
Verbriefungsgesetz vereinbar sind.
Die Gesellschaft soll sich durch die Emission von Anleihen, Schuldverschreibungen oder anderen Schuldtiteln (wie auch
immer bezeichnet) sowie in einem untergeordnetem Rahmen durch besicherte oder unbesicherte Darlehen finanzieren,
die von jedermann gewährt werden können soweit rechtlich erlaubt (einschließlich den Gesellschaftern).
Art. 6. Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann in Übereinstimmung mit den
Vorschriften des Verbriefungsgesetzes, insbesondere Artikel 5, eines oder mehrere Sondervermögen („compartments")
innerhalb der Gesellschaft errichten. Jedes Sondervermögen ist einem bestimmten Teil der Aktiva und Passiva des Ge-
sellschaftsvermögens entsprechend seiner jeweiligen Finanzierung zugeordnet. Der Beschluss der Geschäftsführers oder,
im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands hinsichtlich der Errichtung eines oder mehrerer Sondervermögen
innerhalb der Gesellschaft, einschließlich etwaiger Änderungen diesbezüglich, soll Drittparteien gegenüber ab dem Zeit-
punkt der Beschlussfassung wirksam sein.
Aus Investorensicht wird jedes Sondervermögen als selbständige Einheit behandelt. Ansprüche von Gläubigern und
Investoren die (i) mit einem Sondervermögen zusammenhängen oder (ii) die mit der Errichtung, dem Bestehen oder der
Abwicklung eines solchen Sondervermögens entstanden sind, sind beschränkt auf die Vermögensgegenstände eines sol-
chen Sondervermögens, die ausschließlich den Gläubigern und den Investoren dieses bestimmten Sondervermögens zur
Befriedigung ihrer Ansprüche zur Verfügung stehen. Gläubiger und Investoren der Gesellschaft, deren Ansprüche sich
nicht auf die Vermögensgegenstände eines bestimmten Sondervermögens beziehen, können keine Ansprüche auf die
Vermögensgegenstände dieses oder anderer Sondervermögen der Gesellschaft geltend machen.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann den Inhalt eines Beschlusses über
die Errichtung eines bestimmten Sondervermögens nicht abändern oder die auf ein solches Sondervermögen bezogenen
Ansprüche eines Gläubigers beeinträchtigen, ohne die vorherigen Zustimmung der betroffenen Gläubiger einzuholen, es
sei denn, der Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands über die Errichtung
dieses Sondervermögens bestimmt etwas anderes. Jeder anders lautende Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle
mehrerer Geschäftsführer, des Vorstands diesbezüglich ist nichtig.
Jedes Sondervermögen der Gesellschaft kann unabhängig voneinander abgewickelt werden, ohne dass eine solche
Abwicklung zur Abwicklung eines anderen Sondervermögens oder zur Liquidation der Gesellschaft führt.
Art. 7. Die Gesellschaft wird nicht durch Insolvenz, Zahlungsunfähigkeit oder Verlust der Geschäftsfähigkeit des allei-
nigen Anteilsinhabers oder eines Gesellschafters aufgelöst.
32088
L
U X E M B O U R G
Titel II. - Gesellschaftskapital, Anteile
Art. 8. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist eingeteilt in zwölftau-
sendfünfhundert (12.500) Anteile von je einem Euro (1,- EUR).
Art. 9. Solange nur ein Anteilsinhaber besteht, kann dieser die Anteile frei übertragen.
Für den Fall mehrerer Gesellschafter sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Eine Abtretung von
Anteilen unter Lebenden an Nichtgesellschafter kann nur nach vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern, welche min-
destens drei Viertel (3/4) des Kapitals vertreten, erfolgen. Für alle anderen Angelegenheiten wird auf die Artikel 189 und
190 des luxemburgischen Gesetzes über die Handelsgesellschaften verwiesen.
Art. 10. Ein Gesellschafter, seine Erben, Vertreter, Berechtigten oder Gläubiger können weder einen Antrag auf Sie-
gelanlegung an den Gütern und Werten der Gesellschaft stellen, noch in irgendeiner Form den normalen Geschäftsgang
der Gesellschaft beeinträchtigen.
Zur Ausübung ihrer Rechte müssen sie sich auf die Bilanzen und die Beschlüsse der Gesellschafterversammlung be-
ziehen.
Titel III. - Verwaltung
Art. 11. Die Gesellschaft wird von einem oder mehreren Geschäftsführern, welche von den Gesellschaftern für eine
unbestimmte Dauer gewählt werden, verwaltet. Sofern mehrere Geschäftsführer gewählt sind, bilden sie einen Vorstand.
Die Geschäftsführer können ohne Angabe von Gründen, ad nutum, abgewählt werden.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer bestimmt der Vorstand einen Vorsitzenden, der Mitglied des Vorstandes ist.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand ist mit den größtmöglichen Befugnissen
ausgestattet, um alle Handlungen zur Verwaltung und Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Einklang mit dem Gesell-
schaftszweck durchführen zu können, wobei ihm alle Befugnisse zustehen, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder
diese Satzung der Gesellschafterversammlung zugeschrieben werden.
Sollte die Gesellschaft als Klägerin oder Beklagte in einem Rechtsstreit auftreten, vertritt der Geschäftsführer, oder
im Falle des Vorstands der vom Vorstand dafür autorisierte Geschäftsführer, die Gesellschaft in ihrem eigenen Namen.
Im Falle der Ernennung mehrere Geschäftsführer wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift von zwei
Mitgliedern des Vorstandes rechtswirksam verpflichtet.
Der Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, der Vorstand kann seine Zuständigkeiten für spezielle
Aufgaben an Unterbevollmächtigte oder an einen oder mehrere ad hoc Vertreter delegieren.
Im Falle mehrerer Geschäftsführer kann der Vorstand nur wirksam entscheiden, wenn mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend oder vertreten ist.
Beschlüsse des Vorstandes benötigen eine Mehrheit der Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer.
Der Vorsitzende des Vorstandes hat dabei die ausschlaggebende Stimme.
Alle Treffen des Vorstands finden in Luxemburg statt.
Beschlüsse, welche von allen Mitgliedern des Vorstandes unterzeichnet sind, gelten als genauso wirksam angenommen,
als wenn diese Beschlüsse bei einer korrekt einberufenen und abgehaltenen Vorstandssitzung getroffen worden wären.
Die Unterschriften können auf einem einzelnen Dokument oder auf mehreren identischen Kopien erscheinen und sie
können durch Brief, Telefax oder ähnliche Kommunikation nachgewiesen werden.
Außerdem soll jedes Vorstandsmitglied, welches an einer Vorstandssitzung im Wege einer Kommunikationshilfe (ein-
schließlich Telefon) teilnimmt, welche es den (selbst, durch Vollmacht oder ebenfalls durch eine Kommunikationshilfe)
anwesenden Vorstandsmitgliedern erlaubt, das andere Vorstandsmitglied jederzeit während der Sitzung zu hören und
selbst gehört zu werden als für diese Vorstandssitzung anwesend gelten und soll bei der Aufstellung des Quorums und
mit seiner Stimme bei Abstimmungen während einer solchen Sitzung berücksichtigt werden.
Sollte ein Beschluss im Wege einer Telefonkonferenz gefasst werden, so soll der Beschluss als in Luxemburg gefasst
gelten, sofern die Telefonkonferenz von Luxemburg aus initiiert wurde.
Titel IV. - Aufsicht
Art. 12. Der Jahresabschluss wird durch den unabhängigen Wirtschaftsprüfer (réviseur d’entreprises agréé) geprüft.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch den Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, den
Vorstand, ernannt. Seine Anzahl, Amtsdauer und Belohnung werden durch den Geschäftsführer oder, im Falle mehrerer
Geschäftsführer, den Vorstand, bestimmt.
Titel V. - Gesellschafterversammlung
Art. 13. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilsinhaber hat, übt dieser die Rechte der Gesellschafterversammlung
gemäß Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften aus.
Alle Entscheidungen, die die Kompetenzen der Geschäftsführer überschreiten, werden von dem alleinigen Anteilsin-
haber oder der Gesellschafterversammlung getroffen. Solche Beschlüsse müssen schriftlich gefasst werden und werden
in einem speziellen Register der Gesellschaft eingetragen.
32089
L
U X E M B O U R G
Für den Fall mehrerer Gesellschafter, werden die Beschlüsse in der Gesellschafterversammlung gefasst oder durch
schriftliche Beratung auf Initiative der Geschäftsführung. Beschlüsse gelten nur als angenommen, wenn Gesellschafter,
welche mehr als fünfzig Prozent (50%) des Kapitals vertreten, zugestimmt haben. Die Gesellschafterversammlungen finden
in Luxemburg statt.
Titel VI. - Geschäftsjahr, Gewinn, Reserven
Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar eines jeden Jahres und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Art. 15. Jedes Jahr, am 31. Dezember, werden ein Inventar der Aktiva und Verpflichtungen der Gesellschaft, sowie
eine Bilanz und eine Gewinn und Verlustrechnung erstellt.
Die Einkommen der Gesellschaft, nach Abzug der generellen Ausgaben und der Unkosten, der Abschreibungen und
der Provisionen, stellen den Nettogewinn dar.
Fünf Prozent (5%) des Nettogewinns werden dem gesetzlichen Reservefonds zugeführt; dieser Abzug ist solange ob-
ligatorisch, bis der Reservefonds zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt. Der Abzug muss allerdings wieder
bis zur vollständigen Herstellung des Reservefonds aufgenommen werden, wenn der Fonds, zu welchem Zeitpunkt und
aus welchem Grund auch immer, vermindert wurde.
Der verbleibende Betrag des Nettogewinns steht dem alleinigen Anteilsinhaber oder der Gesellschafterversammlung
zur Verfügung.
Titel VII. - Liquidation, Auflösung
Art. 16. Unbenommen des letzten Absatzes von Artikel 6 und abhängig von der Entscheidung des alleinigen Anteilsin-
habers oder der Gesellschafterversammlung, deren Einberufung im Falle einer Abänderung der Satzung erforderlich ist,
kann jedes Sondervermögen durch Beschluss des Geschäftsführers oder, im Falle mehrerer Geschäftsführer, des Vor-
stands abgewickelt und seine Anteile zurückgegeben werden.
Art. 17. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation von einem oder mehreren Liquidatoren ausgeführt,
welche keine Gesellschafter sein müssen und welche von der Gesellschafterversammlung, mit der in Artikel 142 des
Gesetzes vom 10. August 1915 und seinen Abänderungsgesetzen bestimmten Mehrheit, ernannt werden.
Der (die) Liquidator(en) verfügt/verfügen über die weitestgehenden Befugnisse zur Veräußerung der Aktiva und Be-
gleichung der Verpflichtungen.
Titel VIII. - Verschiedenes
Art. 18. Für alle Punkte, die nicht in dieser Satzung festgelegt sind, verweisen die Parteien auf die bestehenden gesetz-
lichen Bestimmungen.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Zeichnungi>
Nachdem die oben erwähnte Satzung festgelegt wurde, erklärt die erschienene Partei, das gesamte Gesellschaftskapital
wie folgt zu zeichnen:
Anteile
SYCAMORE LUXEMBOURG S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
GESAMT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.500
Alle Anteile wurden zum vollen Betrag von einem Euro (1,- EUR) pro Anteil durch Barzahlung von zwölftausendfünf-
hundert Euro (12.500,-EUR) vollständig bezahlt, so dass nunmehr die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,-
EUR) der Gesellschaft zur Verfügung steht, was auch dem Notar gegenüber nachgewiesen wurde.
<i>Kostenschätzungi>
Die Kosten, Ausgaben, Entschädigungen und sonstigen Aufwendungen, welche die Gesellschaft aufgrund ihrer Grün-
dung tragen muss, belaufen sich auf ungefähr eintausendfünfhundert Euro (1.500,-EUR).
<i>Ausserordentliche Gesellschafterversammlungi>
Die oben benannte Partei, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft als alleiniger Anteilshalter reprä-
sentiert, beschließt sofort im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft eine außerordentliche Gesellschafterversamm-
lung abzuhalten. Nach der Feststellung, dass sich die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengefunden hat,
beschließt der alleinige Anteilsinhaber folgendes:
1. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 48, rue d’Eich, L-1460 Luxembourg;
2. Als Geschäftsführer (gérants) werden für eine unbestimmte Dauer folgende Personen ernannt:
32090
L
U X E M B O U R G
a) Herr Pascal BRUZZESE, Geschäftsführer, geboren in Esch-sur-Alzette (Großherzogtum Luxemburg) am 7. April
1966, mit beruflicher Anschrift in 48, rue d’Eich, L-1460 Luxemburg;
b) Herr Fabien WANNIER, Geschäftsführer, geboren in Bern (Schweiz), am 18. Juli 1977, mit beruflicher Anschrift in
Downtown Dubai, P.O. Box 123234, Apt nr. 2008, Dubai, United Arab Emirates;
c) Frau Milène BELEM, Geschäftsführer, geboren in Samuel / Soure (Portugal), am 13. August 1985 mit beruflicher
Anschrift in 48, rue d’Eich, L-1460 Luxemburg; und
d) Herr Sylvain KIRSCH, Geschäftsführer, geboren in Luxembourg (Großherzogtum Luxemburg), am 8. April 1956,
mit beruflicher Anschrift in 48, rue d’Eich, L-1460 Luxemburg.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache verstehen und sprechen kann, erklärt, dass die vorstehende
Urkunde auf Verlangen der Partei auf Englisch abgefasst worden ist gefolgt von einer deutschen Übersetzung. Die Parteien
legen fest, dass im Falle von Widersprüchen zwischen beiden Versionen, die englische Version Vorrang hat.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxembourg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nachdem diese Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar durch Vorname, Name, Stand und Wohnort
bekannt ist, vorgelesen wurde, hat diese Person zusammen mit dem Notar die Urkunde unterzeichnet.
Signé: S. Kirsch et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/2140. Reçu soixante-quinze euros
Eur 75.-
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015018655/377.
(150022617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
W.A. Verwijs Beheer S.à r.l. / B.V., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.
R.C.S. Luxembourg B 194.138.
STATUTES
IN THE YEAR TWO THOUSAND FIFTEEN
ON THE SIXTH DAY OF JANUARY
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN W.A. VERWIJS BEHEER B.V., a foundation governed by the
laws of The Netherlands, having its address at Havendijk 10, 4401NS Yerseke, The Netherlands and registered at the
Netherlands Chamber of Commerce under the number 22053309,
duly represented by Catherine PEUTEMAN, private employee,
professionally residing at 11 rue de l’Industrie, L-8399 Windhof,
by virtue of a power of attorney given under private on 30 December 2014
Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the sole partner of the limited liability company
(société à responsabilité limitée) under the name W.A. VERWIJS BEHEER B.V., a company incorporated on 27 July 1989
by a deed of Mr Willem Eduard DE VIN and registered at The Netherlands Chamber of Commerce under the number
22030379. The articles have been amended on the last time on 04 January 2000.
The appearing party requested the undersigned notary to state the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder approves, ratifies and confirms as far as is necessary the decision taken in The Netherlands on
6
th
January 2015, to transfer the principal place of business and the place of effective management of the Company from
The Netherlands to the Grand Duchy of Luxembourg, and to adopt the legal form of a société à responsabilité limitée,
A copy of the said decision as well as a declaration of the board of directors of the Company stating that the fair
market value of the Company as per 6
th
January 2015 is at least EUR 20,758.20, after signature “ne varietur” by the
appearing person and the notary, shall remain attached to the present deed, together with the proxy, and shall be filed
at the same time with the registration authorities
32091
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves that the Company adopts the corporate name of "W.A. VERWIJS BEHEER S.à r.l. /
B.V.".
<i>Third resolutioni>
The sole shareholder resolves to accept the Luxembourg nationality arising from the migration of the Company to
the Grand Duchy of Luxembourg and that the Company be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg as
from the date of the present deed, in compliance with the provisions of Luxembourg laws and rules governing the status
of a legal entity, maintained without discontinuance in accordance with such laws
<i>Fourth resolutioni>
The sole shareholder resolves the adoption of the following Articles of Association of a société à responsabilité limitée
for the purpose of its transfer and continuation in the Grand-Duchy of Luxembourg:
ARTICLES OF ASSOCIATION
Name, Registered office and financial year
Art. 1.
1. The name of the company is W.A. Verwijs Beheer S.à r.l. / B.V.
2. The registered office of the company is in Yerseke, The Netherlands.
3. The company shall have its main office and principal place of business in the Municipality of Koerich, Grand Duchy
of Luxembourg.
4. The company may have offices and branches, both in The Netherlands, The Grand Duchy of Luxembourg and abroad.
5. The company has been incorporated for an indefinite period of time.
6. The financial year of the company shall run from the first day of May up to and including the thirtieth day of April.
Objects
Art. 2. The objects for which the company is established are:
a. either alone or jointly with others to acquire and dispose of participations or other interests in legal entities,
companies and enterprises, to co-operate with and to finance and to conduct the management of such legal entities,
companies or enterprises;
b. to acquire, manage, operate, encumber and dispose of any property - including intellectual property rights - and to
invest capital;
c. to raise funds by way of securities, bank loans, bond issues, notes and other debt instruments and to borrow in any
other way, to lend, to provide guarantees and security, including guarantees and security for debts of other persons;
d. to commercialise licences, copyrights, patents, designs, secret processes or formulas, trademarks and similar inter-
ests, to promote the sale and purchase of - and the trade in - these items, including allowing the use of these items and
receiving royalties and other income connected with these activities;
e. for purposes not related to the conduct of its business to make periodic payments for or towards pension or
superannuation funds or other objects;
f. to perform all acts that are advisable, necessary, usual or related to the above mentioned objects.
Capital and issue
Art. 3.
1. The issued and paid up capital of the Company amounts to twenty thousand seven hundred and fifty-eight euro and
twenty eurocents (EUR 20,758.20), divided into three hundred ten thousand nine hundred seventy (310,970) shares A
and thirty-five thousand (35,000) shares B, with a par value of six eurocent (EUR 0.06) each.
In these articles of association the words shares and shareholders shall have the meanings hereby assigned to them:
both the (holders of) shares A and the (holders of) shares B, unless otherwise stated or apparent from the context.
2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible. Joint co-owners have to appoint a sole person as their
representative towards the Company.
3. Shares shall be issued pursuant to and subject to the conditions of a resolution of the general meeting of shareholders
(hereinafter referred to as: the "general meeting"). The resolution to issue shares shall require an instrument to that
effect to be executed before a civil law notary officiating in Luxembourg.
4. The Company may acquire fully paid up shares in its own capital provided that the restrictions as provided by law
in this respect shall be fulfilled.
5. The issue of shares shall be recorded in the register referred to in article 4.
32092
L
U X E M B O U R G
6. At the issue of shares of a particular class each holder of shares of that class shall have a pre-emptive right - save in
the cases where such right is withheld by virtue of mandatory provisions of the law -pro rata to the total amount of the
shares of that class held by him on the date of the resolution to issue shares of that class.
If at the issue of shares of a particular class any shareholder possesses a pre-emptive right and fails to exercise that
pre-emptive right or does not exercise it on time or in full, the pre-emptive right in respect of the shares of that class so
becoming available shall enure to the benefit of the other holders of shares of that class, in proportion to their holdings
of shares of that class as at the date of the resolution to issue shares of that class; if they fail to exercise their pre-emptive
right or do not exercise it on time or in full, the preemptive right in respect of the shares of that class so becoming
available shall enure to the benefit of the holders of shares of the other class, in proportion to their holdings of shares
of that other class as at the date of the resolution to issue shares.
7. The Company shall maintain two share premium reserves: a share premium reserve to which only the holders of
shares A shall be entitled and a share premium reserve to which only the holders of shares B shall be entitled. Any
resolution to make a distribution to the debit of a share premium reserve or to convert (a part of) a share premium
reserve in share capital can only be taken by the meeting of shareholders who are entitled to the share premium reserve
concerned. Paragraph 3 of Article 13 shall apply mutatis mutandis to a resolution make a distribution to the debit of a
share premium reserve. Whenever shares are issued against contribution or payment in excess of the par value of the
shares issued, the excess shall be distributed to a share premium reserve for the class of the shares in respect of which
the excess is paid.
Shares and shareholders' register
Art. 4.
1. The shares are in registered form.
2. The shares shall be consecutively numbered as follows: the numbering of the shares A shall start from number A1
and the numbering of the shares B shall start from number B1.
3. The board of management shall keep a shareholders' register which shall be conform to the statutory requirements.
4. The board of management shall keep the register available at the Company's main office in Luxembourg for inspection
by the shareholders; a copy of or an extract from this register will be made available at cost.
5. The general meeting may resolve to grant and to deprive meeting rights as described in Laws of both countries to
depository receipts. No bearer depository receipts may be issued.
Notices
Art. 5.
1. Notices to shareholders shall be given by registered letter sent to the addresses specified in the shareholders'
register.
2. Notices to the Company shall be given by registered letter to the office of the Company or to the addresses of all
managers.
Transfer of shares
Art. 6.
1. A shareholder can only transfer his shares after he has offered such shares to the other shareholders.
2. The shareholder offering his shares may at any time withdraw his offer, provided this is done within one month
after he has been informed to which prospective purchasers he can sell all the shares to which the offer relates and at
which price. If one of the parties so desire, the price of the shares shall be determined by an expert to be appointed by
the Commercial Court in whose jurisdiction the Company has its registered office.
3. If it appears that not all shares to which the offer relates will be purchased for cash, the offeror may freely transfer
the shares within three months after that determination.
4. The transfer of shares is effected by a notarial deed of transfer to be executed before a civil law notary or by a
private deed.
5. The transfer of shares shall be recorded in the register referred to in article 4.
Board of management
Art. 7.
1. The Company shall be managed by a board of management consisting of one or more managers. A manager need
not to be a shareholder of the Company.
2. The general meeting shall determine the number of managers.
3. The general meeting shall appoint and dismiss managers.
4. The general meeting has the power to suspend a manager.
5. The general meeting shall determine the remuneration and other conditions of employment of the managers.
32093
L
U X E M B O U R G
6. If there are several managers the general meeting can appoint one of them as chairman.
7. In the event one or more managers are absent or prevented to act, the remaining manager shall continue to have
the power to manage the company. In the event all managers or the sole manager are absent or prevented to act, the
Company shall be managed by a person to be designated thereto by the general meeting. Such person shall forthwith
make the necessary arrangements so as to enable the general meeting to make definitive arrangements.
Art. 8.
1. The board of management may adopt additional rules regarding the passing of its resolutions, its organisation and
the division of tasks among its members.
2. The board of management shall observe the instructions of the general meeting with respect to the general lines of
the financial, social and economic policy and of the personnel policy.
3. The board of management requires the approval of the general meeting for transactions as will be clearly defined
by a resolution of the general meeting.
Art. 9. The board of management shall represent the Company.
The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two members of the board of managers.
General Meetings
Art. 10.
1. During each financial year at least one general meeting shall be held if required by law, or at least one resolution
shall be taken in accordance with article 11. Furthermore, general meetings shall be held as often as the board of mana-
gement so desires and as often as such is required by statutory provisions.
2. The notices for general meetings shall be sent by the board of management to the shareholders.
3. The notices shall specify the agenda of the meeting. Resolutions relating to subjects which have not been specified
in the notice or in an additional notice sent with due observance of the proper notice period, can only be passed by
unanimous vote in a meeting in which the entire issued capital is represented.
4. The notice shall be subject to the term, which law imposes on such notice.
5. The general meetings shall be held in the registered office of the Company.
6. Each shareholder shall have the right to be present at the meeting, in person or by proxy (provided such proxy
holds a written power of attorney) and to participate in the discussion.
7. Every share carries the right to cast one vote.
8. All resolutions will be passed by an absolute majority of the votes cast. However, resolutions to alter the Articles
of the Company may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company’s
share capital, subject to the provisions of the Law.
9. The general meetings shall be conducted by the person who has been elected by the general meeting as chairman.
10. The chairman shall determine how the minutes will be recorded.
Passing of resolutions outside a meeting
Art. 11. Resolutions of the general meeting can also be adopted without convening a meeting with due observance of
the law. Votes can only be cast in writing.
Annual accounts and auditor
Art. 12.
1. Each year, within five months from the expiry of the financial year, the board of management shall prepare annual
accounts consisting of a balance sheet, a profit and loss account and explanatory notes thereto. The annual accounts shall
be submitted to the general meeting for adoption.
2. The annual accounts shall be signed by all managers; if one of the signatures is lacking this will be referred to expressly,
stating reasons therefor.
3. The general meeting can and if the law so requires shall appoint an auditor or another expert for the purpose of
auditing the annual accounts prepared by the board of management, to report thereon and to issue a statement with
respect thereto.
Allocation of profits and distributions
Art. 13.
1. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation
and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company’s nominal share capital.
32094
L
U X E M B O U R G
2. The Company can maintain two profit reserves: a profit reserve to which only the holders of shares A shall be
entitled and a profit reserve to which only the holders of shares B shall be entitled. Out of the profits realised in the
immediately preceding financial year a dividend shall, if possible, first be paid on the shares A of seven percent (7 %) of
the reserves attached to the shares A at the time of creation of the shares A and B. Subsequently, the profit remaining
shall be allocated to the shares A and the shares B, in proportion to the issued and paid up shares A and shares B
respectively.
If the profits realised in any financial year are not sufficient to pay the aforesaid percentage, in subsequent years no
other than a reservation of profit as required by the law shall be made, nor shall any dividend be paid on the shares B
until the holders of the shares A have been paid the dividend to which they are still entitled as well as the dividend over
the immediately preceding financial year.
3. The general meeting may appropriate the profits and may decide to make a distribution.
4. The Company may only make distributions if and to the extent that its shareholders' equity exceeds the reserves,
which must be maintained by law or under the articles of association.
5. Distributions can only be made once the board of management has given its approval. The board of management
may only withhold such approval if it knows or should reasonably foresee that, following such distribution, the Company
will be unable to continue paying its due and payable debts.
6. For the purposes of calculating any distribution, shares or depository receipts held by the Company and any shares
or depository receipts of which the Company has a usufruct shall not be taken into account.
7. Unless the general meeting sets a different term for that purpose, distributions shall be made payable within thirty
days after they are declared.
8. A general meeting declaring a distribution may direct that it is to be satisfied wholly or partly by the distribution of
assets.
9. Any deficit may be set off against the statutory reserves only to the extent permitted by law.
Amendment of articles of association
Art. 14.
1. The general meeting has the power to amend the articles of association. The resolution to amend the articles of
association shall require an instrument to that effect to be executed before a civil law notary officiating in Luxembourg.
2. When a proposal for amendment of the articles of association is submitted to the general meeting a copy of such
proposal, including the precise wording of the proposed amendment, has to be sent to the shareholders together with
the notice for the general meeting and should be kept at the office of the Company for inspection by any shareholder
until after the end of the meeting.
3. No amendment of these articles of association shall become effective until such amendment has been embodied in
a notarial deed of amendment to be executed before a civil law notary.
Dissolution and liquidation
Art. 15.
1. The general meeting has the power to dissolve the Company. The resolution to dissolve the Company shall require
an instrument to that effect to be executed before a civil law notary.
2. The board of management shall liquidate the assets and liabilities, unless the general meeting, when deciding to
dissolve, appoints other liquidators.
3. The balance remaining after satisfaction of the creditors shall be distributed among the shareholders pro rata to
their respective shareholdings.
<i>Fifth resolutioni>
The sole shareholder declares that all the three hundred ten thousand nine hundred seventy (310,970) shares A and
thirty-five thousand (35,000) shares B are attributed to STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN W.A.
VERWIJS BEHEER B.V., a foundation governed by the laws of The Netherlands, having its address at Havendijk 10, 4401NS
Yerseke, The Netherlands and registered at the Netherlands Chamber of Commerce under the number 22053309
<i>Sixth resolutioni>
The sole shareholder resolves to fix the business and administrative seat and the principal establishment of the Com-
pany at L-8399 Windhof, 11, rue de l’Industrie, Municipality of Koerich.
<i>Seventh resolutioni>
The sole shareholder resolves to appoint the following person as manager of the Company for an unlimited duration:
- Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l., a société à responsabilité limitée with registered office at 11 rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof and registered at the Trade Register of Commerce and Companies of Luxembourg under the number
32095
L
U X E M B O U R G
B 172533 (with permanent representative Mr. Geert DIRKX, its sole manager, professionally residing at 31 rue de Stras-
bourg, L-2561 Luxembourg).
<i>Transitory provisioni>
1. By way of derogation of article 1.6 of the present articles of association, the Company’s current accounting year
runs from the date of the present deed to April 30, 2015.
2. The first annual general meeting of shareholders under Luxembourg Law shall be held in 2015, if required by law.
<i>Statementi>
The undersigned notary states that the conditions provided by the law of August 10
th
1915 on commercial companies
have been observed.
There being no further business on the agenda, the meeting was closed.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
corporation incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately EUR 1,550.-.
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the ap-
pearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, known to the notary by his surname, Christian name, civil
status and residence, he has signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'AN DEUX MIL QUINZE,
LE SIX JANVIER,
Par devant nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire à Luxembourg.
A comparu:
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN W.A. VERWIJS BEHEER B.V., une fondation de droit néer-
landais établie à Havendijk 10, 4401NS Yerseke, Pays-Bas, et enregistrée auprès de la Chambre du commerce des Pays-
Bas sous le numéro 22053309,
dûment représentée par Madame Catherine Peuteman, employée privée, demeurant professionnellement au 11 rue
de l’Industrie, L-8399 Windhof,
en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 30 décembre 2014
La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a déclaré être l’associé unique de la société à responsabilité
limitée W.A. VERWIJS BEHEER B.V., société constituée le 27 juillet 1989 par un acte de M. Willem Eduard DE VIN et
enregistrée auprès de la Chambre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 22030379. Les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois le 4 janvier 2000.
La comparante a chargé le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique approuve, ratifie et confirme pour autant que de besoin, la décision prise aux Pays-Bas le 6 janvier
2015 de transférer le siège d'activité principal et le lieu de gestion effective de la Société des Pays-Bas vers le Grand-
Duché de Luxembourg et d'adopter la forme juridique d'une société à responsabilité limitée.
Une copie de ladite décision ainsi qu'une déclaration du conseil d'administration de la Société indiquant que la juste
valeur de marché de la Société au 06 janvier 2015 est d'au moins 20.758,20 EUR, après signature «ne varietur» par la
comparante et le notaire, resteront jointes au présent acte ainsi que la procuration, et seront déposées en même temps
auprès des autorités du bureau de l’enregistrement.
<i>Deuxième résolutioni>
L'associé unique décide que la Société adopte la dénomination sociale «W.A. VERWIJS BEHEER S.à r.l. / B.V.».
<i>Troisième résolutioni>
L'associé unique décide d'accepter la nationalité luxembourgeoise découlant de la migration de la Société vers le Grand-
Duché de Luxembourg et accepte que la Société soit régie par la législation du Grand-Duché de Luxembourg à compter
de la date du présent acte, conformément aux lois et dispositions luxembourgeoises régissant le statut des sociétés, sans
interruption et sans perte de la personnalité juridique conformément à ces lois.
32096
L
U X E M B O U R G
<i>Quatrième résolutioni>
L'associé unique décide d'adopter les statuts d'une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois aux fins
de ce transfert et de la poursuite de la société au Grand-duché de Luxembourg, lesquels statuts sont rédigés comme suit:
STATUTS
Dénomination, Siège et exercice social
Art. 1
er
.
1. La Société a pour dénomination W.A. Verwijs Beheer S.à r.l. / B.V.
2. Le siège social de la Société est situé à Yerseke, Pays-Bas.
3. La Société a son siège principal et son lieu d'activité principal dans la Commune de Koerich, Grand-Duché de
Luxembourg.
4. La Société peut posséder des bureaux et des succursales aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et à
l’étranger.
5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
6. L'exercice social de la Société court du 1
er
mai au 30 avril inclus.
Objet
Art. 2. La Société a pour objet:
a. seule ou conjointement avec d'autres, acquérir et aliéner des participations ou autres intérêts dans des entités
juridiques, sociétés ou entreprises, coopérer avec ces entités juridiques, sociétés ou entreprises ou en assurer la gestion;
b. acquérir, gérer, exploiter, grever et aliéner tout bien, en ce compris des droits de propriété intellectuelle, et investir
du capital;
c. lever des fonds par voie de titres, d'emprunts bancaires, d'émissions d'obligations, de billets et autres instruments
de créance et emprunter de toute autre façon, prêter, fournir des garanties et des sûretés, y compris des garanties et
suretés pour les dettes d'autres personnes;
d. commercialiser des licences, droits d'auteur, des brevets, des dessins, des formules ou procédés secrets, des marques
commerciales et intérêts similaires afin de promouvoir la vente et l’achat, ainsi que le commerce, de ces éléments et de
toucher des redevances et autres revenus en lien avec ces activités;
e. à des fins non liées à la réalisation de ses activités, effectuer des paiements périodiques au bénéfice de fonds de
pension ou de retraite ou d'autres objets;
f. poser tous les actes recommandés, nécessaires, usuels ou liés aux objets susmentionnés.
Capital et souscription
Art. 3.
1. Le capital souscrit et libéré de la Société s'élève à vingt mille sept-cent cinquante-huit euros et vingt centimes
(20.758,20 EUR) répartis en trois-cent dix mille neuf-cent soixante-dix (310.970) parts sociales A et trente-cinq mille
(35.000) parts sociales B d'une valeur nominale de six centimes (0,06 EUR) chacune.
Dans les présents statuts, les termes «parts sociales» et «associés» auront le sens qui leur est donné ici, à savoir à la
fois les (titulaires de) parts sociales A et les (titulaires de) parts sociales B, sauf mention contraire ou sauf lorsque le
contexte indique manifestement un sens différent.
2. Les parts sociales de la Société sont indivisibles à l’égard de la Société. Les copropriétaires joints doivent désigner
une personne unique pour les représenter envers la Société.
3. Les parts sociales sont émises conformément aux conditions d'une résolution de l'assemblée générale des associés
(ci-après désignée «assemblée générale»). La résolution d'émettre des parts sociales nécessite un acte à cet effet qui doit
être passé devant un notaire officiant au Luxembourg.
4. La Société peut acquérir des parts sociales entièrement libérées de son propre capital moyennant le respect des
restrictions prévues par la loi.
5. L'émission de parts sociales est enregistrée au registre visé à l’article 4.
6. Lors de l’émission de parts sociales d'une classe donnée, chaque titulaire de parts sociales de cette classe dispose
d'un droit de préemption - sauf dans les cas où ce droit est refusé par des dispositions légales obligatoires - au prorata
du nombre total de parts sociales de cette classe qu'il détient à la date de la résolution d'émettre des parts sociales de
cette classe.
Si, lors de l’émission de parts sociales d'une classe donnée, un associé possède un droit de préemption et n'exerce
pas ce droit ou ne l’exerce pas dans les délais ou intégralement, le droit de préemption relatif aux parts sociales de cette
classe ainsi disponible revient aux autres titulaires de parts sociales de cette classe au prorata du nombre de parts sociales
de cette classe qu'ils possèdent au moment de la résolution d'émettre des parts sociales de cette classe; s'ils n'exercent
pas leur droit de préemption ou ne l’exercent pas dans les délais ou intégralement, le droit de préemption relatif aux
32097
L
U X E M B O U R G
parts sociales de cette classe ainsi disponible revient aux titulaires de parts sociales de l’autre classe au prorata du nombre
de parts sociales de cette autre classe qu'ils détiennent au moment de la résolution d'émettre des parts sociales.
7. La société a deux primes d'émission: une prime d'émission réservée aux titulaires de parts sociales A et une prime
d'émission réservée aux titulaires de parts sociales B. Toute résolution de distribution au débit d'une prime d'émission
ou de conversion (d'une partie) d'une prime d'émission en capital social ne peut être prise que par une réunion des
associés ayant droit à la prime d'émission concernée. Le paragraphe 3 de l’article 13 s'applique mutatis mutandis à une
résolution de distribution au débit d'une réserve d'émission. Lorsque des parts sociales sont émises en contrepartie d'une
contribution ou d'un paiement dépassant la valeur nominale des parts sociales émises, l’excédent est versé à la prime
d'émission de la classe de parts sociales pour lesquelles il a été payé.
Actions et registre des actionnaires
Art. 4.
1. Les parts sociales sont nominatives.
2. Les parts sociales sont numérotées de façon consécutive comme suit: la numérotation des parts sociales A com-
mence au numéro A1 et la numérotation des parts sociales B commence au numéro B1.
3. Le conseil de gérance tient un registre des associés conforme aux prescriptions réglementaires.
4. Le conseil de gérance tient le registre à disposition au siège principal de la Société à Luxembourg, où il peut être
contrôlé par les associés; une copie ou un extrait de ce registre est mis à disposition au prix coûtant.
5. L'assemblée générale peut décider d'accorder ou de supprimer des droits d'assemblée (tels que décrits dans les
législations des deux pays) à des certificats de dépôts. Aucun certificat de dépôt au porteur ne peut être émis.
Avis
Art. 5.
1. Les avis aux associés et convocations sont remis par courrier recommandé envoyé aux adresses indiquées dans le
registre des associés.
2. Les avis à la Société sont remis par courrier recommandé envoyé au siège de la Société ou aux adresses de tous les
gérants.
Cession de parts sociales
Art. 6.
1. Un associé ne peut céder ses parts sociales qu'après les avoir proposées aux autres associés.
2. L'associé qui propose ses parts sociales peut retirer son offre à tout moment pour autant que ce retrait intervienne
dans un délai d'un mois à compter du moment où il a été informé des acheteurs potentiels auxquels il peut vendre toutes
les parts sociales sur lesquelles porte l’offre et à quel prix. Si l’une des parties le souhaite, le prix des parts sociales peut
être déterminé par un expert désigné par le Tribunal du Commerce compétent dans la juridiction dans laquelle la Société
a son siège.
3. S'il apparaît que toutes les parts sociales concernées par l’offre ne seront pas achetées au comptant, l’associé offrant
peut céder librement les parts sociales dans un délai de trois mois suivant ce constat.
4. La cession de parts sociales se fait par acte notarié de cession passé devant un notaire ou par un acte sous seing
privé.
5. La cession de parts sociales est enregistrée au registre visé à l’article 4.
Conseil de gérance
Art. 7.
1. La Société est gérée par un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérants. Il n'est pas nécessaire qu'un
gérant soit associé de la Société.
2. L'assemblée générale détermine le nombre de gérants.
3. L'assemblée générale nomme et révoque les gérants.
4. L'assemblée générale a le pouvoir de suspendre un gérant.
5. L'assemblée générale détermine la rémunération et les autres conditions d'emploi des gérants.
6. S’il y a plusieurs gérants, l’assemblée générale peut désigner l’un d’eux en tant que président.
7. Si un ou plusieurs gérants sont absents ou en état d'incapacité, le gérant restant a le pouvoir de gérer la Société. Si
le gérant unique ou tous les gérants sont absents ou en état d'incapacité, la Société est gérée par une personne désignée
à cette fin par l’assemblée générale. Cette personne prend immédiatement les dispositions nécessaires pour permettre
à l’assemblée générale de prendre des mesures définitives.
Art. 8.
1. Le conseil de gérance peut adopter des règles supplémentaires concernant l’adoption de ses résolutions, son or-
ganisation et la répartition des tâches entre ses membres.
32098
L
U X E M B O U R G
2. Le conseil de gérance respecte les consignes de l’assemblée générale concernant les grandes lignes de la politique
financière, sociale et économique et de la politique de personnel.
3. Le conseil de gérance requiert l’approbation de l’assemblée pour les transactions définies clairement par une réso-
lution de l’assemblée générale.
Art. 9. Le conseil de gérance représente la Société.
La Société est engagée par la signature de son gérant unique ou, si elle compte plusieurs gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance.
Assemblées générales
Art. 10.
1. Au cours de chaque exercice social, au moins une assemblée générale est organisée si la loi l’exige ou au moins une
résolution est adoptée conformément à l’article 11. Des assemblées générales sont en outre organisées aussi souvent
que le conseil de gérance le souhaite et aussi souvent que l’exigent les dispositions réglementaires.
2. Les convocations aux assemblées générales sont envoyées aux associés par le conseil de gérance.
3. Les convocations indiquent l’ordre du jour de l’assemblée. Les résolutions portant sur des sujets non indiqués dans
la convocation ou dans un avis supplémentaire envoyé dans les délais requis ne peuvent être adoptées que par un vote à
l’unanimité lors d'une assemblée où est représentée la totalité du capital souscrit.
4. La convocation est soumise aux conditions fixées par la loi.
5. Les assemblées générales se tiennent au siège de la Société.
6. Chaque associé a le droit d'assister à l’assemblée ou de s'y faire représenter (pour autant que son représentant
dispose d'une procuration écrite) et de participer aux débats.
7. Chaque part sociale donne droit à une voix.
8. Toutes les résolutions sont adoptées à la majorité des votes exprimés. Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts
de la Société ne peuvent être adoptées que par une majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital
social de la Société dans le respect des dispositions légales.
9. Les assemblées générales sont présidées par la personne élue à la présidence par l’assemblée générale.
10. Le président détermine les modalités de consignation du procès-verbal.
Adoption de résolutions en dehors d'une assemblée
Art. 11. Les résolutions de l’assemblée générale peuvent également être adoptées sans convoquer d'assemblée dans
le respect de la loi. Les votes ne peuvent être exprimés que par écrit.
Comptes annuels et auditeur
Art. 12.
1. Chaque année, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice social, le conseil de gérance prépare les comptes annuels
composés d'un bilan, d'un compte de résultats et de leurs notes explicatives. Les comptes annuels sont soumis à l’as-
semblée générale pour approbation.
2. Les comptes annuels sont signés par tous les gérants; en cas d'absence d'une signature, cette absence est signalée
explicitement avec indication des motifs.
3. L'assemblée générale peut désigner, et désigne dans tous les cas si la loi l’exige, un réviseur d'entreprises ou un autre
expert chargé de contrôler les comptes annuels préparés par le conseil de gérance, de rendre compte de son analyse et
de faire une déclaration concernant les comptes.
Affectation des bénéfices et distributions
Art. 13.
1. Le bénéfice brut de la Société indiqué dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, des amortis-
sements et des dépenses, représente le bénéfice net. Un montant égal à cinq pourcent (5 %) du bénéfice net de la Société
est affecté à une réserve légale jusqu'à ce que cette réserve représente dix pourcent (10 %) du capital social de la Société.
2. La Société a deux réserves de bénéfices: une réserve de bénéfices destinée aux seuls titulaires de parts sociales A
et une réserve de bénéfices destinée aux seuls titulaires de parts sociales B.
Sur le bénéfice réalisé lors de l’exercice social immédiatement antérieur, dans la mesure du possible, un dividende est
d’abord versé sur les parts sociales A à hauteur de sept pourcent (7 %) des réserves associées aux parts sociales B au
moment de la création des parts sociales A et B.
Ensuite, le bénéfice restant est affecté aux parts sociales A et aux parts sociales B proportionnellement au nombre de
parts sociales A et B émises et libérées.
Si le bénéfice réalisé lors d'un exercice financier n'est pas suffisant pour distribuer le pourcentage susmentionné, les
exercices suivants, seule la réserve requise par la loi est constituée et aucun dividende n'est versé sur les parts sociales
32099
L
U X E M B O U R G
B jusqu'à ce que les titulaires de parts sociales A aient reçu le dividende auquel ils ont droit ainsi que le dividende relatif
à l’exercice social immédiatement antérieur.
3. L'assemblée générale est compétente pour affecter le bénéfice et décider de procéder à une distribution.
4. La Société ne peut procéder à une distribution que si et dans la mesure où ses fonds propres excèdent les réserves
requises par la loi ou par les statuts.
5. Les distributions ne peuvent avoir lieu qu'après l’accord du conseil de gérance. Le conseil de gérance ne peut refuser
son accord que s'il sait ou doit raisonnablement prévoir qu'à la suite de cette distribution, la Société sera dans l’incapacité
de continuer à s'acquitter de ses dettes en cours et remboursables.
6. Le calcul des distributions éventuelles ne tient pas compte des parts sociales ou certificats de dépôts détenus par
la Société ni des parts sociales ou certificats de dépôts pour lesquels la Société jouit d'un usufruit.
7. Sauf disposition contraire de l’assemblée générale, les distributions sont payables dans un délai de trente jours à
compter de leur déclaration.
8. L'assemblée générale qui déclare une distribution peut décider de réaliser cette distribution en tout ou en partie
par la distribution d'actifs.
9. Tout déficit ne peut être compensé par les réserves légales que dans la mesure autorisée par la loi.
Modification des statuts
Art. 14.
1. L'assemblée générale a le pouvoir de modifier les statuts. La résolution de modification des statuts nécessite un acte
à cet effet qui doit être passé par devant un notaire officiant au Luxembourg.
2. Lorsqu'une proposition de modification des statuts est soumise à l’assemblée générale, une copie de cette propo-
sition incluant le libellé précis de la modification proposée doit être envoyée aux associés en même temps que la
convocation à l’assemblée générale. Cette proposition doit être conservée au siège de la Société où elle peut être con-
trôlée par n'importe quel associé jusqu'à la fin de l’assemblée.
3. Aucune modification des présents statuts ne prend effet tant qu'elle n'a pas été intégrée à un acte de modification
passé devant notaire.
Dissolution et liquidation
Art. 15.
1. L'assemblée générale a le pouvoir de dissoudre la Société. La résolution de dissoudre la Société nécessite un acte
à cet effet qui doit être passé devant un notaire officiant au Luxembourg.
2. Le conseil de gérance liquide l’actif et le passif, sauf si l’assemblée générale désigne d'autres liquidateurs lorsqu'elle
décide la dissolution.
3. Le solde résiduel après remboursement de tous les créanciers est distribué aux associés au prorata du nombre de
parts sociales qu'ils détiennent.
<i>Cinquième résolutioni>
L'associé unique déclare que les trois-cent dix mille neuf-cent soixante-dix (310.970) parts sociales A et les trente-
cinq mille (35.000) parts sociales B sont attribuées à STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN W.A.
VERWIJS BEHEER B.V., une fondation de droit néerlandais établie à Havendijk 10, 4401NS Yerseke, Pays-Bas, et enre-
gistrée auprès de la Chambre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 22053309.
<i>Sixième résolutioni>
L'associé unique décide de fixer le siège commercial et administratif et le siège principal de la Société au 11, rue de
l’Industrie, L-8399 Windhof, commune de Koerich.
<i>Septième résolutioni>
L'associé unique décide de désigner la personne suivante en tant que gérant de la Société pour une durée indéterminée:
- Henley Trust (Luxembourg) S.à r.l., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 11 rue de l’Industrie,
L-8399 Windhof, enregistrée auprès du Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 172533
(ayant pour représentant permanent Monsieur Geert DIRKX, son gérant unique, résidant à titre professionnel au 31 rue
de Strasbourg, L-2561 Luxembourg).
<i>Disposition transitoirei>
1. Par dérogation à l’article 1.6 des présents statuts, l’exercice social actuel de la Société court de la date du présent
acte au 30 avril 2015.
2. La première assemblée générale des associés régie selon le droit luxembourgeois aura lieu en 2015 si la loi le requiert.
32100
L
U X E M B O U R G
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné déclare que les conditions prévues par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
ont été respectées.
L'ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée.
<i>Coûtsi>
Le montant total des coûts, frais, rémunérations et dépenses, sous quelque forme que ce soit, engagés et dus par la
société pour son organisation, s'élève à environ EUR 1.550,-.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais et le français, déclare par la présente qu'à la requête de la com-
parante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française. À la demande de ce même comparant, en
cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.
Ce document ayant été lu au comparant, connu du notaire par son nom, prénom, état civil et lieu de résidence, le dit
comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: C. PEUTEMAN, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: LAC/2015/697. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 février 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015018589/523.
(150021508) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Caduceus Investment S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du Dix Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 150.090.
<i>Extrait de la décision prise par le Conseil d'Administration en date du 8 Août 2014:i>
Il a été décidé de remplacer:
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, en tant que
Réviseur d'Entreprises agréé à la fin de leur mandat concernant la révision des comptes annuels au 31 Décembre 2013;
Par:
- Deloitte Audit S.à r.l., enregistré auprès du Registre de Commerce sous le numéro B67895, ayant son siège social
au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant que nouveau réviseur d'Entreprises agrée.
<i>Extrait de la décision de l'Assemblée Générale Annuelle des Actionnaires de la Société en date du 2 Décembre 2014i>
Il a été décidé d'accepter la décision du Conseil d'Administration en date du 8 Aout 2014 et donc de remplacer:
- PricewaterhouseCoopers S.à r.l. ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, en tant que
Réviseur d'Entreprises agréé avec effet immédiat;
Par:
- Deloitte Audit, enregistré auprès du Registre de Commerce sous le numéro B67895, ayant son siège social au 560,
rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg en tant que réviseur d'Entreprises agrée, avec effet immédiat et ce jusqu'à l'As-
semblée Générale qui se tiendra en l'année 2020.
Il a été décidé de prolonger les mandats de:
- Preeti Kotwani-Khitri, résidant professionnellement au 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg en tant
qu'Administrateur de la Société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020;
- Zamyra Cammans, résidant professionnellement au 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg en tant
qu'Administrateur de la Société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020;
- Petra J. S. Dunselman, résidant professionnellement au 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg en tant
qu'Administrateur de la Société et ce jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'année 2020
Luxembourg, le 23 Janvier 2015.
Référence de publication: 2015017966/30.
(150021729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
32101
L
U X E M B O U R G
Digital Services XXXVIII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 15.000,00.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 194.134.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory
seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;
here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given
in Berlin on 5 January 2015.
Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this
deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a private limited
company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:
A. Name - Purpose - Duration - Registered office
Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name
Digital Services XXXVIII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.
Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.
2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it
holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.
2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by
issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.
2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities
which it considers useful for the accomplishment of these purposes.
Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of
managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution
of the board of managers.
4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances
or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.
32102
L
U X E M B O U R G
B. Share capital - Shares
Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)
shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.
5.3 The Company may redeem its own shares.
Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of
the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.
Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection
by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.
7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall
appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.
7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given
by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of
the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.
7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject
to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.
C. Decisions of the shareholders
Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles
of association.
8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise
conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.
8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of
shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.
Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least
one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.
Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
32103
L
U X E M B O U R G
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.
Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval
of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.
D. Management
Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.
Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-
ration and term of office.
14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision
of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.
14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A
managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.
Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or
otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager by the remaining managers until the next meeting of shareholders which shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.
15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue
delay by the general meeting of shareholders.
Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held
at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.
16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at
least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.
16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive
any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.
Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not
need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.
17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may
appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.
17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either
in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.
17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other
means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.
32104
L
U X E M B O U R G
17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or
represented at a meeting of the board of managers.
17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,
if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).
17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in
writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.
Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by
the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).
18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.
Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.
E. Audit and supervision
Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company
shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.
20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting
of shareholders.
20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé
(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.
20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its
approval.
F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends
Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end
on the thirty-first of December of the same year.
Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of
the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.
22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.
This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.
22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the
contributing shareholder agrees with such allocation.
22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does
not exceed ten per cent (10%) of the share capital.
32105
L
U X E M B O U R G
22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the
remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.
22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.
Art. 23 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared
by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.
23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-
holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the
liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.
24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among
the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.
H. Final clause - Governing law
Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance
with the Law.
<i>Transitional provisionsi>
1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December
2015.
2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.
<i>Subscription and paymenti>
The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the
price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).
The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR
15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.
The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.
<i>Verificationi>
The notary executing this deed declares that the conditions fixed in Article 183 of the law on commercial companies
have been fulfilled.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be
borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening
requirements, has thereupon passed the following resolutions:
1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035
Strassen, Luxembourg;
- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
32106
L
U X E M B O U R G
3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole
shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.
hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5.
Januar 2015, ausgestellt in Berlin.
Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar ne varietur paraphiert
wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.
Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:
A. Name - Zweck - Dauer - Sitz
Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
mit dem Namen Digital Services XXXVIII S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.
Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-
sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.
2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.
2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere
durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.
2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen
sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.
Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,
welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.
Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer
verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.
4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im
Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.
4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale
Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen könnten, so kann der Gesellschaftssitz bis zur endgültigen Beendigung dieser
32107
L
U X E M B O U R G
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
B. Gesellschaftskapital - Anteile
Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend
(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.
5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.
5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.
Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-
schreiten darf.
6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz
oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.
Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden
kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.
7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten
wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.
7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit
einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.
7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil
wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.
7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von
Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.
C. Entscheidungen der Gesellschafter
Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung
übertragen wurden.
8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-
scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.
8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften
des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.
Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich
innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.
32108
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-
sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.
Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-
schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.
D. Geschäftsführung
Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-
schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.
13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.
Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und
Amtszeit festlegt.
14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.
14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien
beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.
Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund
aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.
15.2 Für den Fall, dass der alleinige Geschäftsführer aus seinem Amt ausscheidet, muss die frei gewordene Stelle
unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.
Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen
des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.
16.2 Die Geschäftsführer werden mindestens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem für die Sitzung anberaumten
Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.
16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle
Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.
Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-
schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.
32109
L
U X E M B O U R G
17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-
schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer ein anderes Mitglied des Rates der
Geschäftsführer durch einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro
tempore ernennen.
17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen
Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.
17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein
anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.
17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.
17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer
teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.
17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,
per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.
Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-
schäftsführers.
18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.
18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen
Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.
Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-
ständen durch (i) die Unterschrift des alleinigen Geschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.
E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft
Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der
Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.
20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-
schäfte der Gesellschaft.
32110
L
U X E M B O U R G
20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember
2002 betreffend das Handelsregister und die Buchhaltung und den Jahresabschluss von Unternehmen, in der jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.
20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die
Gesellschafterversammlung abberufen werden.
F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden
Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am
einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.
Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im
Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.
22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage
der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.
22.3 Durch einen Gesellschafter erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters
ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.
22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt
werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.
22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-
setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung wie der verbleibende Bilanzgewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.
22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-
enen Anteile.
Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche
vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.
23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen
des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.
G. Liquidation
Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch
einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.
24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird
an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.
H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht
Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des
Gesetzes von 1915.
<i>Übergangsbestimmungeni>
1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember
2015.
2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
<i>Zeichnung und Zahlungi>
Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von
fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.
32111
L
U X E M B O U R G
Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe
von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.
Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital
zugeführt.
<i>Feststellungi>
Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-
sellschaften erfüllt sind.
<i>Auslageni>
Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare
und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.
<i>Beschlüsse des Alleingesellschaftersi>
Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle
Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:
1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse
20, D-10117 Berlin.
Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,
L-8035 Strassen, Luxemburg;
- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-
berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.
Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen
Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.
Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-
men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/708. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 30. Januar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015018027/584.
(150021422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
North Star Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 185.770.
<i>Extrait des résolutions prise par le conseil de gérance en date du 16 janvier 2015i>
Les gérants ont décidé de transférer le siège social de la Société de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660
Luxembourg au 21, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017491/12.
(150020014) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
32112
4terra S.A.
AFLP Securitisation S.à r.l.
Amazon Eurasia Holdings S.à r.l.
Artichocs S.A.
Athena Topco S.à r.l.
Caduceus Investment S.A.
Carolin Finance S.à r.l.
CB S.A.
Centric IT Solutions Luxembourg S.A.
CHC Helicopter (1) S.à r.l.
Colon River S.A.
Corestate Shelf Holdco 3 S.à r.l.
Digital Services XXXVIII S.à r.l.
IACG Holdings LUX S.à r.l.
Ideal Group Luxembourg S.A.
International Radio Networks Holding S.A.
Maxiver S.àr.l.
Nido Notting Hill S.à r.l.
North Star Investment S.à r.l.
Triple Aaart S.A.
UDM Holding S.A.
United Bargain Société de Participations S.A.
Uranium Participation Cyprus Limited-Luxembourg Branch
Usantar Two S.A.
Valfidus S.A.
Vallis Sustainable Investments I Holding S.à r.l.
VEM Financière Holdings S.A.
Ventara S.àr.l.
Venusia Real Estate Investment S.A.
Venusia Real Estate Investment S.A.
Veolia Luxembourg
Vertrange Holding S.A.
VIGO INVEST S.A.
Villiot Holdco S.à r.l.
Visionla SA
Vistra IP Rights S.àr.l.
Vodafone Procurement Company S.à r.l.
Wallberg Invest S.A.
W.A. Verwijs Beheer S.à r.l. / B.V.
WPP Luxembourg Turris S.à r.l.
Yum! Franchise China IV S.à r.l.
Zenview Holdings S.à r.l.