This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 657
10 mars 2015
SOMMAIRE
2R-Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31493
Antica Bari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31495
Aots S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31524
Apollo Emerging Markets Absolute Return
Holdings (Lux) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31536
Bicocca S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
BSA Consulting S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31536
Câblinvest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31513
Cépages Participations S.A. . . . . . . . . . . . . .
31495
CETP UC4 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
CFFI Holdings S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
Charitable Luxembourg Four S.à r.l. . . . . .
31490
Charitable Luxembourg One Sàrl . . . . . . .
31535
Charitable Luxembourg Three S.à r.l. . . .
31516
Château de Beggen Participations S.A. . . .
31496
CHC Helicopter (1) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31498
CHC Helicopter LLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
Cogesor S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31491
CPI Digiplex S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31535
Damasca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31490
Delarue S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31496
Der Garten S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31496
DJ Manhattan Luxco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
31491
DM Direct Service S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
31495
Dorado Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
Eleanore Luxembourg II S.à r.l. . . . . . . . . .
31514
Emcedeux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31493
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l. . . . . . . . . .
31490
Emile Gestion S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31496
Energreen Investment Europe S.A. . . . . . .
31494
FCA Sport S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31492
Fides Holdings S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31502
Fincorp Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . .
31493
Fineural International S.A. . . . . . . . . . . . . . .
31493
Haynesborough Corporation S.à r.l. . . . . .
31492
Lux Gestion Tresorerie S.A. . . . . . . . . . . . .
31517
Neomed S.P.F. SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31497
Notrine S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31497
Pro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31517
Quay Street Manchester Real Estate S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31505
Rockspring TransEuropean Properties V
Swiss S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31517
Saint Eugène SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31494
Saint-Michel Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
31494
Shanila Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
31500
SO.GE.FER (Luxembourg) S.A. . . . . . . . . .
31494
Tiago Second Frankfurt Properties Limi-
ted S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31497
Zunis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31495
31489
L
U X E M B O U R G
Damasca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 90.199.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 janvier 2015i>
La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.
Pour extrait sincère et conforme
DAMASCA S.A.
Référence de publication: 2015017066/12.
(150020903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
CFFI Holdings S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 28.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 106.155.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions écrites de l'associé unique de la Société prises en date du 6 janvier 2015 que le mandat de la
société Ernst & Young S.A., en tant que Réviseur d'entreprises agréé de la Société, a été renouvelé avec effet au 17 octobre
2014, et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015017015/14.
(150021193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 359.171.699,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 168.467.
La Société note le changement d'adresse de son associé MCP Baffin Lux S.à r.l., dont le siège social est désormais situé
au 2 - 4 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015017112/13.
(150020856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Charitable Luxembourg Four S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 18.431,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.195.
Par résolutions prises en date du 31 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Choui Min Kon Kam King, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015016991/15.
(150020281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
31490
L
U X E M B O U R G
Cogesor S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9570 Wiltz, 11, rue des Tondeurs.
R.C.S. Luxembourg B 98.607.
A dater du 1
er
janvier 2015, le mandat de commissaire aux comptes de la S.à R.L. «AP Audit» confié en date du 13
mars 2013 par l'assemblée générale de la société anonyme «COGESOR» a été dénoncé.
AP Audit S.à R.L.
Pierre Alcover
<i>Réviseurs d'entreprises agréési>
Référence de publication: 2015017032/12.
(150020908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
DJ Manhattan Luxco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 31.066.791,00.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 140.034.
Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la Société au 16A, Avenue de la Liberté,
L-1930 Luxembourg avec effet au 1
er
décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2015.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015017079/13.
(150020039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
CHC Helicopter LLC, Succursale d'une société de droit étranger.
Adresse de la succursale: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 144.470.
FERMETURE D'UNE SUCCURSALE
La succursale CHC Helicopter LLC, ayant son siège social au 13-15, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg est
radiée à la date de ce jour avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 2 février 2015.
Sophie Zintzen
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015017019/14.
(150021088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
CETP UC4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 114.357.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
Par les résolutions du 29 décembre 2014, les associés de la Société ont décidé:
- que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement accomplie et clôturée.
- que les livres et documents sociaux seront conservés pendant cinq (5) ans au siège social de la société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
CETP UC4 S.à r.l.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015017013/15.
(150019964) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
31491
L
U X E M B O U R G
Dorado Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 189.678.
<i>Extrait des résolutions de l'administrateur unique en date du 16 janvier 2015i>
L'administrateur unique Monsieur Paolo BETTIOL décide de transférer le siège social de la Société de son ancienne
adresse sise 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 21, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017086/12.
(150020412) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
FCA Sport S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 167.413.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 16 janvier 2015 à Luxembourg.i>
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration que:
- Le siège social de la Société a été transféré de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 21,
Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017150/13.
(150020013) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Haynesborough Corporation S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 194.761,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 166.535.
<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique, en date du 30 décembre 2014:i>
- l'associé unique accepte la démission de Monsieur Ingor Meuleman de son poste de gérant, avec effet au 30 décembre
2014;
- l'associé unique nomme Madame Catherine Zoller, administrateur de sociétés, née le 08 avril 1967 à Arlon (Belgique),
demeurant professionnellement au 1, rue Goethe, L-1637 Luxembourg, comme nouveau gérant.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018144/14.
(150022170) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Bicocca S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.520,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.440.
Lors de l'assemblée générale annuelle tenue en date du 19 janvier 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de José Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant de catégorie A, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant A, avec effet au 31 décembre 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2015.
Référence de publication: 2015016969/15.
(150020833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
31492
L
U X E M B O U R G
2R-Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3895 Foetz, rue de l'Industrie, Coin des Artisans.
R.C.S. Luxembourg B 178.274.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019364/9.
(150023108) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Emcedeux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 73.814.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2015i>
La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.
Pour extrait sincère et conforme
EMCEDEUX S.A.
Référence de publication: 2015018062/12.
(150022128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Fineural International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 104.959.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 3 février 2015.
<i>Pour: FINEURAL INTERNATIONAL S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015018102/16.
(150022096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Fincorp Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 44.757.
Il résulte d'une réunion du conseil d'administration de la société «FINCORP PARTICIPATIONS S.A.» tenue sous seing
privé en date du 19 janvier 2015, qu'il a été décidé comme suit:
1. De constater que le projet de fusion notarié du 14 novembre 2014, a été publié au Mémorial C en date du 3 décembre
2014, numéro 3676, tel que prévu au point 5 du projet de fusion;
2. De constater également qu'aucun actionnaire n'a convoqué d'assemblée ou rejeté le projet de fusion tel que prévu
au point 8 du projet de fusion;
3. De constater la réalisation de la fusion définitive conformément aux points 5 à 8 du projet de fusion;
4. De constater la dissolution de la société absorbée, à savoir la société MENDOCINO S.A..
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015018101/17.
(150021521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31493
L
U X E M B O U R G
Energreen Investment Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 159.588.
En date du 19 janvier 2015, j'ai démissionné de ma fonction d'administrateur et de Président de la société ENERGREEN
INVESTMENT EUROPE SA, ayant son siège social au 19, Boulevard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg,
RCSL B159588.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2015018064/11.
(150021864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
SO.GE.FER (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 40.840.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 2 février 2015i>
La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.
Pour extrait sincère et conforme
SO.GE.FER. (LUXEMBOURG) S.A.
Référence de publication: 2015019262/12.
(150022528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Saint-Michel Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 20, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 124.347.
Le bilan au 31.12.2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 février 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015019223/14.
(150023085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Saint Eugène SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 78.409.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
SAINT EUGENE S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019248/17.
(150022682) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
31494
L
U X E M B O U R G
DM Direct Service S.A., Société Anonyme.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 42, Gruuss Strooss.
R.C.S. Luxembourg B 91.646.
Il est à noter que l'adresse de VERICOM S.A., commissaire aux comptes est:
L-2341 Luxembourg, 1, rue du Plébiscite
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018806/11.
(150022226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Zunis S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.
R.C.S. Luxembourg B 37.930.
EXTRAIT
Il résulte d'un courrier du 26 janvier 2015 que je démissionne de ma fonction d'administrateur de la société ZUNIS
S.A., établie et ayant son siège social à L-1114 Luxembourg, 10 rue Nicolas Adames, inscrite au Registre de commerce
et des sociétés sous le numéro B 37 930.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 janvier 2015.
Maître Marianne GOEBEL.
Référence de publication: 2015017845/13.
(150020084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Antica Bari, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2470 Dudelange, 28, rue de la Fontaine.
R.C.S. Luxembourg B 176.400.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
PRODESSE S.à r.l.
19, rue de la Gare
L-3237 BETTEMBOURG
Signature
Référence de publication: 2015017900/13.
(150021899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Cépages Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 113.828.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
CEPAGES PARTICIPATIONS S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015017993/17.
(150022263) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31495
L
U X E M B O U R G
Delarue S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 85.000.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 4 février 2015i>
La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège
social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.
Pour extrait sincère et conforme
DELARUE S.A.
Référence de publication: 2015018797/12.
(150023011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Der Garten S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5730 Aspelt, 1, route de Mondorf.
R.C.S. Luxembourg B 141.992.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
LUDWIG & MALDENER S.A.R.L.
<i>EXPERTS COMPTABLES - FIDUCIAIRE
i>31, OP DER HECKMILL - L-6783 GREVENMACHER
Signature
Référence de publication: 2015018799/13.
(150022874) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Château de Beggen Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 4.652.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst den gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen für das Geschäfts-
jahr endend zum 31. Dezember 2013 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Februar 2015
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015018736/13.
(150022611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Emile Gestion S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 181.731.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 4 février 2015.
<i>Pour: EMILE GESTION S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015018840/16.
(150022955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
31496
L
U X E M B O U R G
Neomed S.P.F. SA, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 62.218.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
NEOMED SPF S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019053/17.
(150022545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Notrine S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 68.137.
<i>Extrait des décisions prises par l'administrateur unique au siège social en date du 3 février 2015i>
L'administrateur unique, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A
no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
NOTRINE S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019057/17.
(150022732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Tiago Second Frankfurt Properties Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 176.954.
<i>Résolutions prises par l'associé unique avec effet du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2015i>
Avec effet du 1
er
janvier 2015, l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
1. Approbation de la démission Mr. Kemal Akyel comme gérant de la société avec effet du 1
er
janvier 2015.
2. Nomination de M. Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, dont l'adresse professionnelle est 12, rue
Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérant de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015 pour une durée
indéterminée.
3. Nomination de Mme. Elena Hadjifyntani, née le 2 octobre 1974 à Odessa, Ukraine, dont l'adresse professionnelle
est 12, rue Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérante de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015 pour
une durée indéterminée.
4. Transfert du siège social de la société au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, avec effet immédiat.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015018534/20.
(150022039) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31497
L
U X E M B O U R G
CHC Helicopter (1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.502,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 190.559.
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the sole shareholder of CHC Helicopter (1) S.à r.l., a Luxembourg
private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred and two Euros
(EUR 12,502) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 190559 (the
Company).
The Company has been incorporated on 26 September 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx,
notary residing in Luxembourg City, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 3237 of 4 November 2014. The Company’s articles of association (the Articles) have been amended
on 16 October 2014 pursuant to a deed drawn up by Maître Henri Hellinckx, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 3612 dated 28 November 2014.
THERE APPEARED:
CHC Helicopter S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg,
with registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 139673, being the sole shareholder of the Company
(the Sole Shareholder),
duly represented by Annick Braquet, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue
of a power of attorney given under private seal.
Such power of attorney, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Sole Shareholder, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record that:
I. the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. the agenda of the Meeting is as follows:
1. Change of the financial year of the Company such that the financial year begins on the first (1) day of May and ends
on the thirtieth (30) of April of the following year, it being understood that the current financial year, which started on
the twenty-sixth (26) of September 2014 shall end on the thirtieth (30) of April 2015 and the transitional provision
included in the deed of incorporation of the Company is to be read accordingly.
2. Amendment to articles 13.1 and 13.5 of the articles of association of the Company in order to reflect the change
of financial year; and
3. Miscellaneous.
III. the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company such that the financial year begins on the
first (1) of May and ends on the thirtieth (30) of April of the following year, it being understood that the current financial
year, which started on the twenty-sixth (26) of September 2014 shall end on the thirtieth (30) of April 2015 and the
transitional provision included in the deed of incorporation of the Company is to be read accordingly.
<i>Second resolutioni>
In light of the foregoing, the Sole Shareholder resolves to amend article 13.1 and article 13.5 of the Articles, which
shall henceforth read as follows:
“ 13.1. The financial year begins on the first (1) day of May and ends on the thirtieth (30) day of April of the following
year.”
“ 13.5. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the annual General Meeting shall be
held at the registered office or at any other place within the municipality of the registered office, as specified in the notice,
on the second Monday of September of each year at 10.00 a.m.. If that day is not a business day in Luxembourg, the annual
General Meeting shall be held on the following business day.”
31498
L
U X E M B O U R G
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company in relation
to this deed are estimated at approximately EUR 1,500.-
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the above appearing party, the
present deed is worded in English, followed by a French version, and at the request of the same appearing party, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) de l'associé unique de CHC Helicopter (1) S.à r.l., une société à
responsabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cent deux Euros
(EUR 12.502) et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190559 (la
Société).
La Société a été constituée en date du 26 Septembre 2014 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de
résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 3237 du 4 novembre 2014. Les statuts de la société (les Statuts) ont été modifiés le 16 octobre 2014 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3612 du 28 novembre 2014.
A COMPARU
CHC Helicopter S.A., une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139673 (l'Associé Unique),
ici représentée par Annick Braquet, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant pour le compte de la partie comparante
et par le notaire instrumentaire, restera annexée pour les besoins de l'enregistrement.
L’Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
I. que l'Associé Unique détient toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:
1. Modification de l'exercice social de la Société afin qu’il commence le premier (1) jour du mois de mai et se termine
le trentième (30) jour du mois d’avril de l'année suivante, étant entendu que l'exercice social en cours, qui a commencé
le vingt-six (26) septembre 2014, se terminera le trente (30) avril 2015 et la disposition transitoire incluse dans l'acte de
constitution de la Société doit être lu en conformité avec ce qui précède;
2. Modification des articles 13.1 et 13.5 des statuts de la Société afin de refléter le changement d’exercice social; et
3. Divers.
III. que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de modifier l'exercice social de la Société afin que l'exercice social commence le premier (1)
jour du mois de Mai et se termine le trentième (30) jour du mois d’avril de l'année suivante, étant entendu que l'exercice
social en cours, qui a commencé le vingt-six (26) septembre 2014, se terminera le trente (30) avril 2015 et la disposition
transitoire incluse dans l'acte de constitution de la Société doit être lu en conformité avec ce qui précède.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de refléter la résolution ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier les articles 13.1 et 13.5 des Statuts, qui
aura désormais la teneur suivante:
« 13.1. L'exercice social commence le premier mai et finit le trente avril de l'année suivante.»
« 13.5. Si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), l'assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse
du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième
31499
L
U X E M B O U R G
lundi du mois de septembre de chaque année à 10 heures. Si ce jour n’est pas un jour ouvré à Luxembourg, l'assemblée
Générale annuelle se tient le jour ouvré suivant.»
<i>Fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés à environ EUR 1.500.-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu’à la requête de la partie comparante susnommée, le
présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande de la même partie comparante, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire de la partie comparante, le mandataire de la partie comparante a signé avec
le notaire instrumentant le présent acte original.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63369. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015018762/125.
(150022923) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Shanila Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 172.612.
DISSOLUTION
In the year two thousand fourteen, on the twenty-third day of December.
Before the undersigned Maître Gérard LECUIT, notary residing in Luxembourg.
There appeared:
Mr David Shostak, companies director, born on the 22
nd
day of September, 1971, in USSR, residing at 3-22, Vsevo-
lozhysky Pereulok, RUS -119034 Moscou,
here represented by Mr Frank Trinteler, employee, residing professionally in Schuttrange,
by virtue of a proxy signed on the 17
th
day of December, 2014.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, acting in the said capacity, has requested the undersigned notary to state:
- that the corporation "Shanila Investments S.à r.l.", having its registered office in L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale,
was incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on October 25
th
, 2012, published in the Mémorial,
Recueil des Sociétés et Associations, number 2973 on the 7
th
day of December, 2012;
- that the articles of incorporation haven’t been amended since then;
- that the capital of the company «Shanila Investments S.à.r.l." is fixed at twelve thousand five hundred euro (12,500.-
EUR) represented by twelve thousand five hundred shares (12,500) of one euro (1.-EUR) each, all subscribed and fully
paid-up.
- that the appearing party has become owner of all the shares;
- that the appearing party, in its capacity of sole shareholder of the Company, has resolved to proceed to the antici-
patory and immediate dissolution of the Company;
- that the sole shareholder, in its capacity as liquidator of the Company, and according to the balance sheet of the
Company as at the 17
th
day of December, 2014, declares that all the liabilities of the Company, including the liabilities
arising from the liquidation, are settled or retained;
The appearing party furthermore declares that:
- the Company’s activities have ceased;
31500
L
U X E M B O U R G
- the sole shareholder is thus vested with all the assets of the Company and undertakes to settle all and any liabilities
of the terminated Company, the balance sheet of the Company as at the 17
th
day of December, 2014,being only one
information for all purposes;
- following the above resolutions, the Company’s liquidation is to be considered as accomplished and closed;
- the Company’s managers are hereby granted full discharge with respect to their duties;
- there shall be arranged the cancellation of all issued shares and/or the shareholders register;
- the books and documents of the corporation shall be lodged during a period of five years at L-5367 Schuttrange, 64,
rue Principale;
The undersigned notary, who knows and speaks English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
<i>Costsi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever incumbent to the company and charged to it
by reason of the present deed are estimated approximately at a thousand EUROS (EUR 1,000.-).
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day first above written.
The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by her surname, first name, civil
status and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre.
Pardevant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
M. David Shostak, directeur de sociétés, né le 22 septembre 1971 en URSS, demeurant à 3-22 Vsevolozhysky Pereulok,
Moscou, Russie,
ici représenté par Monsieur Frank Trinteler, employé privé, demeurant professionnellement à Schuttrange,
en vertu d’une procuration accordée en date du 17 décembre 2014,
laquelle, après signature ne varietur, par le notaire instrumentant et le mandataire, restera annexée aux présentes pour
être formalisée avec elles.
Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- que la société Shanila Investments S.à r.l., ayant son siège social à L-5367 Schuttrange, 64, Rue Principale, a été
constituée suivant acte du notaire instrumentant en date du 25 octobre 2012, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 2973 du 7 décembre 2012;
- que les statuts n’ont jamais été modifiés depuis lors;
- que le capital social de la société s'élève actuellement à douze mille cinq cents euros (12.500.-EUR) représenté par
douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d’une valeur nominale de un euro (1.-EUR) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.;
- que la partie comparante est seule propriétaire de toutes les actions;
- que la partie comparante, en sa qualité d’associé unique de la Société, a décidé de procéder à la dissolution anticipée
et immédiate de la Société;
- que l’associé unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 17 décembre 2014,
déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment provisionné;
La partie comparante déclare encore que:
- l’activité de la Société a cessé;
- l’associé unique est investie de l’entièreté de l’actif de la Société et déclare prendre à sa charge l’entièreté du passif
de la Société qu’il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 17 décembre 2014 étant seulement
un des éléments d’information à cette fin;
- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la Société;
il y a lieu de procéder à l’annulation de toutes les parts sociales et/ ou du registre des associés;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-5367 Schuttrange,
64, rue Principale.
Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l’ont
requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
31501
L
U X E M B O U R G
<i>Frais.i>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1,000.-Eur).
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé le présent acte avec le
notaire.
Signé: F. TRINTELER, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63609. Reçu soixante-quinze euros
(EUR 75,-).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017676/98.
(150020362) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Fides Holdings S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades.
R.C.S. Luxembourg B 152.423.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.
APPEARED:
Mrs Geneviève BLAUEN-ARENDT, company director, professionally residing at L-2121 Luxembourg, 231, Val des
Bons Malades,
acting in her capacity as duly appointed attorney of the Board of Directors of the public company limited by shares
(“société anonyme”) Fides Holdings S.A., having its registered office at L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons
Malades, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under section B number 152.423 (the "Com-
pany"), incorporated by deed of the undersigned notary on the 31
st
of March 2010, published in the Mémorial C number
1049 of the 19
th
of May 2010, and whose articles of incorporation have been modified by deeds of the undersigned
notary:
- on the 4
th
of June 2010, published in the Mémorial C number 1667 of the 17
th
of August 2010;
- on the 23
rd
of July 2010, published in the Mémorial C number 2078 of the 5
th
of October 2010,
- on the 22
nd
of October 2010, published in the Mémorial C number 176 of the 28
th
of January 2011, and
- on the 20
th
of December 2013, published in the Mémorial C number 539 of the 28
th
of February 2014.
That the authorized share capital is set at one million Swiss Francs (CHF 1,000,000.-) divided into an aggregate maxi-
mum amount of one million (1,000,000) shares, each with a nominal value of one Swiss Franc (CHF 1.-).
The board of directors is authorized and empowered to:
- realize any increase of the corporate capital within the limits of the authorized capital in one or several successive
tranches, by the issuance of new shares, with or without an issue premium, against payment in cash or in kind, by con-
version of claims or in any other manner;
- determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the
subscription of and paying up of the new shares; and
- remove or limit the preferential subscription rights of the shareholders in case of issue of shares.
This authorization is valid for a period expiring 5 (five) years after 20 December 2013 and it may be renewed by a
general meeting of shareholders for those shares of the authorized corporate capital which up to then will have not been
issued by the board of directors.
Following each increase of the corporate capital realized and duly stated in the form provided for by law, the Article
3 of the Articles of Association will be modified so as to reflect the actual increase; such modification will be recorded
in authentic form by the board of directors or by any person duly authorized and empowered by it for this purpose.
The appearing party referred to the notary that the Board of Directors of the Company, in its meeting dated 7
th
of
January 2015, resolved within the limit of the authorized capital under the terms and conditions of the articles of asso-
ciation of the Company, to increase the share capital of the Company by a contribution in cash amounting to eleven
thousand three hundred and fifty one Swiss Francs (CHF 11,351.-) so as to bring it from its present amount of four
hundred and twenty thousand four hundred and twenty Swiss francs (CHF 420,420.-), represented by four hundred and
twenty thousand four hundred and twenty (420,420) shares, with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) per share, to
31502
L
U X E M B O U R G
the amount of four hundred and thirty one thousand seven hundred and seventy one Swiss francs (CHF 431,771.-)
represented by four hundred and thirty one thousand seven hundred and seventy one (431,771) shares, with a par value
of one Swiss Franc (CHF 1.-) per share.
The 11,351 (eleven thousand three hundred and fifty one) new shares have been issued for a total amount of eleven
thousand three hundred and fifty one Swiss Francs (CHF 11,351.-) allotted to the corporate share capital.
The appearing party then tabled a bank statement, showing that eleven thousand three hundred and fifty one Swiss
Francs (CHF 11,351.-) are blocked on the Company’s bank account for the purpose of the increase of capital. This bank
statement is given to the notary for his comfort.
On the basis of the above listed document, the appearing party hereby requested the notary to state and record:
(i) the increase of the share capital of the Company by a contribution in cash so as to bring it from its present amount
of four hundred and twenty thousand four hundred and twenty Swiss francs (CHF 420,420.-), represented by four hundred
and twenty thousand four hundred and twenty (420,420) shares, with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) per share
to the amount of four hundred and thirty one thousand seven hundred and seventy one Swiss francs (CHF 431,771.-)
represented by four hundred and thirty one thousand seven hundred and seventy one (431,771) shares, with a par value
of one Swiss Franc (CHF 1.-) per share; and
(ii) the consecutive amendment of article 3 paragraph 1 of the articles of association of the Company so as to give it
the following wording:
" Art. 3. (1
st
paragraph). The subscribed share capital of the Company is fixed at four hundred and thirty one thousand
seven hundred and seventy one Swiss francs (CHF 431,771.-) represented by four hundred and thirty one thousand seven
hundred and seventy one (431,771) shares, with a par value of one Swiss Franc (CHF 1.-) per share.".
<i>Costsi>
The amount of expenses, costs, remuneration and charges to be paid by the Company as a result of the present stated
deed is estimated at EUR 1,100.-.
The total amount of the capital increase is valued at EUR 11,170.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French states herewith that on request of the above
appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing
party and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the attorney, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and
residence, the latter signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-et-un janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
A COMPARU:
Madame Geneviève BLAUEN-ARENDT, administrateur de société, demeurant professionnellement à L-2121 Luxem-
bourg, 231, Val des Bons Malades,
agissant en sa qualité de mandataire dûment nommé par le Conseil d’Administration de la société anonyme Fides
Holdings S.A., ayant son siège social sis L-2121 Luxembourg-Kirchberg, 231, Val des Bons Malades, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous section B numéro 152.423 (la «Société») constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 31 mars 2010, publié au Mémorial C numéro 1049 du 19 mai 2010, et
dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le notaire instrumentant:
- en date du 4 juin 2010, publié au Mémorial C numéro 1667 du 17 août 2010;
- en date du 23 juillet 2010, publié au Mémorial C numéro 2078 du 5 octobre 2010,
- en date du 22 octobre 2010, publié au Mémorial C numéro 176 du 28 janvier 2011, et
- en date du 20 décembre 2013, publié au Mémorial C numéro 539 du 28 février 2014.
Que le capital autorisé est fixé à un million de francs suisses (CHF 1.000.000,-) divisé en un montant maximum global
d'un million (1.000.000) d'actions, chacune ayant une valeur nominale d'un franc suisse (CHF 1,-).
Le conseil d'administration est autorisé et habilité, à:
- réaliser toute augmentation du capital social dans les limites du capital autorisé en une ou plusieurs tranches suc-
cessives, par l'émission de nouvelles actions, avec ou sans prime d'émission, contre le paiement en numéraire ou en
nature, par la conversion de créances ou de toute autre manière;
31503
L
U X E M B O U R G
- déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités
de souscription et de libération des nouvelles actions; et
- supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires en cas d'émission d'actions.
Cette autorisation est valable pour une période expirant 5 (cinq) ans après le 20 décembre 2013 et peut être renou-
velée par une assemblée générale des actionnaires pour les actions du capital social autorisé qui jusqu'alors n'auront pas
été émises par le conseil d'administration.
Suite à chaque augmentation du capital social réalisée et dûment déclarée dans la forme requise par la loi, l'Article 3
des statuts sera modifié de façon à refléter l'augmentation réelle; une telle modification sera enregistrée dans une forme
originale notarial par le conseil d'administration ou par toute autre personne dûment autorisée et habilitée par et pour
ces fins."
La partie comparante a déclaré au notaire que le Conseil d’Administration de la Société, lors de la réunion du 7 janvier
2015, a décidé dans les limites du capital autorisé et conformément aux termes et conditions prévus par les statuts de la
Société, d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de onze mille trois cent cinquante et un francs suisses
(CHF 11.351,-) par apport en numéraire pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille quatre cent
vingt francs suisses (CHF 420.420,-), représenté par quatre cent vingt mille quatre cent vingt (420.420) actions d'une
valeur nominale de un franc suisse (CHF 1,-) chacune au montant de quatre cent trente-et-un mille sept cent soixante-
et-onze francs suisses (CHF 431.771,-), représenté par quatre cent trente-et-un mille sept cent soixante-et-onze (431.771)
actions d'une valeur nominale de un franc suisse (CHF 1,-) chacune.
Les onze mille trois cent cinquante et une (11.351) actions nouvelles ont été émises pour un montant total de onze
mille trois cent cinquante et un franc Suisse (CHF 11.351,-), intégralement alloué au compte capital social.
La partie comparante a ensuite présenté un extrait bancaire, attestant que la somme de onze mille trois cent cinquante
et un Francs Suisse (CHF 11.351,-), est bloquée sur le compte bancaire de la Société dans le but de procéder à l'aug-
mentation de capital.
Sur la base dudit certificat, la partie comparante a demandé au notaire de déclarer et d’acter ce qui suit:
(i) l'augmentation de capital de la Société d’un montant de onze mille trois cent cinquante et un francs suisses (CHF
11.351,-) par apport en numéraire pour le porter de son montant actuel de quatre cent vingt mille quatre cent vingt francs
suisses (CHF 420.420,-), représenté par quatre cent vingt mille quatre cent vingt (420.420) actions d'une valeur nominale
de un franc suisse (CHF 1,-) chacune au montant de quatre cent trente-etun mille sept cent soixante-et-onze francs suisses
(CHF 431.771,-), représenté par quatre cent trente-et-un mille sept cent soixante-et-onze (431.771) actions d'une valeur
nominale de un franc suisse (CHF 1,-) chacune, et
(ii) la modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 3 des statuts de la Société afin de lui donner la teneur suivante:
« Art. 3. (1
er
alinéa). Le capital social souscrit de la Société est fixé à quatre cent trente-et-un mille sept cent soixante-
et-onze francs suisses (CHF 431.771,-), représenté par quatre cent trente-et-un mille sept cent soixante-et-onze (431.771)
actions d'une valeur nominale de un franc suisse (CHF 1,-) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent
acte, sont estimés à EUR 1.100,-.
Le montant total de l'apport a été évalué à EUR 11.170,-
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française. A la requête de la même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire, connue du notaire par son nom, prénom usuel, état et
demeure, celle-ci a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Geneviève BLAUEN-ARENDT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 26 janvier 2015. Relation GAC/2015/730. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015018085/144.
(150022093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31504
L
U X E M B O U R G
Quay Street Manchester Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.
R.C.S. Luxembourg B 194.146.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen,
on the twenty-eighth day of the month of January.
Before Us, Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
“CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), which is governed by Luxembourg Law, having its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under company number
R.C.S. B 185.605,
here represented by Mr Alexander Wagner, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal dated 21 January 2015.
Said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to state as follows
the Articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée):
Chapter I. Form, Name, Registered office, Object, Duration.
Art. 1. Form, Corporate Name. Hereby is formed under the name of "Quay Street Manchester Real Estate S.à r.l." a
private limited liability company (société à responsabilité limitée), which will be governed by Luxembourg Law (hereafter
the "Company"), and in particular by the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the
"Law"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "Articles").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg. The board
of managers is authorised to change the address of the Company inside the municipality of the statutory registered office.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its unitholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.
Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent
the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect
on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the board of
managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 3. Corporate Objectives. The company's object is
- buying or holding shares or units in one or more Investment Companies;
- granting financing to Investment Companies provided they are, directly or indirectly via one or more Investment
Companies, controlled by the company; and/or
- buying Real Estate and developing, administering, operating, renting and selling
Real Estate held by it.
For the purpose of this clause, "Real Estate" shall comprise direct title to property (consisting of land and buildings),
property related long-term interests (such as surface ownership, master-lease, fee simple ownership, concession and
lease-hold), purchase options and forward commitments to purchase upon completion in relation to such property and
property-related long term interests and other assets that are necessary to operate such property and propertyrelated
long term interests. For the purpose of this clause, "Investment Company" means any company or other investment
vehicle whose object is (according to its articles of incorporation or other constituent documents) buying Real Estate
and developing, administering, operating, renting and selling Real Estate held by it, (directly or indirectly via one or more
investment vehicles with a similar object clause) buying or holding shares or units in one or more of investment vehicles
with a similar object clause and/ or granting financing to such investment vehicles provided that the financed investment
vehicle is ultimately controlled by the company.
The Company may borrow and proceed to the issue of bonds, preferred equity certificates, loan notes and debentures,
convertible or non-convertible, within the limits of the Law. The Company may grant any assistance, loan, advance, or
guarantee to or in favour of the companies, trustees or enterprises in which it has a direct or indirect participating interest,
or to companies being part of the same group of companies as the Company (the "Connected Companies"). The Company
31505
L
U X E M B O U R G
may grant any guarantee in favour of a third party to secure the obligations of the Connected Companies. The Company
is also authorised to pledge, mortgage or otherwise create security interests in or over its assets to secure its own
obligations or those of the Connected Companies.
The company can perform all operations and transactions which it deems necessary to fulfil its object as well as all
operations connected directly or indirectly to facilitating the accomplishment of its object, including transactions to hedge
interest and/ or currency exchange risks.
Art. 4. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period.
Chapter II. Capital, Units.
Art. 5. Corporate Capital. The unit capital is fixed at twelve thousand five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-)
represented by one hundred and twenty-five (125) units with no reference to nominal value.
Art. 6. Capital Amendment. The capital may be changed at any time by a decision of the single unitholder (where there
is only one unitholder) or by a decision of the unitholders’ meeting, in accordance with article 16 of the Articles.
Art. 7. Distribution Right of Units. Each unit entitles the holder thereof to a fraction of the Company’s assets and
profits of the Company in direct proportion to the number of units in existence.
Art. 8. Units Indivisibility. Towards the Company, the Company’s units are indivisible, since only one owner is admitted
per unit. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of Units. In case of a single unitholder, the Company’s units held by the single unitholder are freely
transferable.
In the case of plurality of unitholders, the units held by each unitholder may be transferred by application of the
requirements of article 189 of the Law.
Each unitholder agrees that it will not pledge or grant a security interest in any of units without the prior consent of
the majority of the unitholders owning at least three-quarter of the Company’s unit capital.
Chapter III. Management.
Art. 10. Management. A board of managers composed of at least three members manages the Company. The managers
need not to be unitholders. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of
unitholders holding a majority of votes.
The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members
one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who needs not to be a director, who shall be responsible for
keeping the minutes of the meetings of the board of managers. The board of managers shall meet upon call by the chairman,
or two managers, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside at all meetings of unitholders or in his absence or inability to act, the vice-chairman or
another manager appointed by the Board of managers shall preside as chairman pro-tempore or in their absence or
inability to act, the unitholders may appoint another manager, an officer of the Company or such other individual as they
may determine as chairman protempore by vote of the majority of shares present or represented at any such meeting.
The board of managers from time to time may appoint the officers of the Company, including general managers, any
assistant general manager, secretaries, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and
management of the Company, who need not be managers or unitholders of the Company. The officers appointed, unless
otherwise stipulated in these articles, shall have the powers and duties given to them by the board of managers. The
board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers
to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to such officers of the Company. Any such ap-
pointment may be revoked at any time by the board of managers.
Notice of any meeting of the Board of managers shall be given in writing, or by cable, telegram, telex, telefax or by
other electronic means of transmission to all manager at least twenty four hours in advance of the day set for the meeting.
The notice shall specify the purposes of and each item of business to be transacted at the meeting, and no business other
than that referred to in such notice may be conducted at any such meeting nor shall any action taken by the board not
referred to in such notice be valid. This notice may be waived by the consent in writing or by cable or telegram or telex
or telefax or by other electronic means of transmission of each manager and shall be deemed to be waived by any manager
who is present in person or represented by proxy at the meeting. Separate notice shall not be required for individual
meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by cable or telegram, telex
or telefax another manager as his proxy. Any manager may attend a meeting of the board of managers using teleconference,
video means or any other audible or visual means of communication. A board member attending a meeting of board of
managers by using such means of communication is deemed to be present in person at this meeting.
31506
L
U X E M B O U R G
A meeting of the board of managers held by teleconference or videoconference or any other audible or visual means
of communication, in which a quorum of managers participate shall be as valid and effectual as if physically held, provided
that a minute of the meeting is made and signed by the chairman of the meeting.
The board of managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented
at a meeting of the board of managers. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting. Managers who are not present in person or represented by proxy may vote in writing or
by cable or telegram or telex or telefax or by other electronic means of communication.
In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have
a casting vote.
Circular Resolutions signed by all directors will be as valid and effectual as if passed at a meeting duly convened and
held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced
by letters or telefaxes. Such resolutions shall enter into force on the date of the Circular Resolution as mentioned therein.
In case no specific date is mentioned, the Circular Resolution shall become effective on the day on which the last signature
of a board member is affixed.
Resolutions taken by any other electronic means of communication e.g. e-mail, cables, telegrams or telexes shall be
formalized by subsequent circular resolution. The date of effectiveness of the then taken Circular resolution shall be the
one of the latest approval received by the Company via electronic means of communication. Such approvals received
from all Board Members shall remain attached to and form an integral part of the Circular Resolution endorsing the
decisions formerly approved by electronic means of communication.
Any Circular Resolutions may only be taken by unanimous consent of all the members of the Board of managers.
The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman of the meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman of the board or chairman pro tempore of that meeting, or by two directors.
Art. 11. Powers of the manager. In dealing with third parties, the managers will have all powers to act in the name of
the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s
objects and provided the terms of this article shall have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of unitholders fall within the
competence of the board of managers. The board of managers, may, in particular, enter into investment advisory agree-
ments and administration agreements such as e.g. real estate agent or property management agreements.
Art. 12. Representation of the Company. The Company will be bound by the joint signature of any two managers,
officers or of any other persons to whom authority has been delegated by the board of managers.
Art. 13. Sub-Delegation and Agent of the manager. Any members of the board of managers may sub-delegate his
powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.
Any members of the board of managers will determine any such agent’s responsibilities and remuneration (if any), the
duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.
Art. 14. Remuneration of the manager. The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later
date in addition to or in the place of the first managers will be determined in the act of nomination.
Art. 15. Liabilities of the manager. In the exercise of their mandate, the members of the board of managers are not to
be personally held liable for the indebtedness of the Company. As agent of the Company they are responsible for the
correct performance of their duties.
Chapter IV. General meeting of unitholders
Art. 16. Powers of the General Meeting of Unitholder(s). The single unitholder assumes all powers conferred to the
general unitholders’ meeting.
In case of a plurality of unitholders, each unitholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of units, which he owns. Each unitholder has voting rights commensurate with his unitholding.
A unitholder may act at any general meeting of unitholders by appointing (or, if the unitholder is a legal entity, its legal
representative(s)) in writing or by telefax, cable, telegram, telex, e-mail as his proxy another person who need not be a
unitholder himself.
Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by unitholders owning more than half of the unit
capital. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority of the unitholders owning at least
three-quarter of the Company’s unit capital, subject to the provisions of the Law.
Chapter V. Financial year - Balance sheet.
Art. 17. Financial Year. The Company’s financial year starts on the 1
st
January and ends on the 31
st
December of
each year.
31507
L
U X E M B O U R G
At the end of each financial year, the Company’s accounts are established and the board of managers prepares an
inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.
Each unitholder shall have the right to inspect the books and records of the Company, the above inventory and balance
sheet at the Company’s registered office.
The operations of the Company, including particularly its books and fiscal affairs and the filing of any tax returns or
other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by an independent auditor («réviseur d’entrepri-
ses»). The independent auditor shall be elected by the annual general meeting of unitholders for a period ending at the
date of the next annual general meeting of unitholders and until his successor is elected.
The independent auditor in office may be removed at any time by the unitholders in accordance with the provisions
of article 256 of the law of 10
th
August 1915 on commercial companies.
Art. 18. Allocation and Distribution of the Profits. The gross profits of the Company stated in the annual accounts,
after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per
cent (5%) of the net profit of the Company is allocated to the legal reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company’s unit capital.
The balance of the net profit may be distributed to the unitholder(s) in proportion to his/their unitholding in the
Company.
Chapter VI. Dissolution - Liquidation.
Art. 19. Causes of Dissolution. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights,
insolvency or bankruptcy of the single unitholder or of one of the unitholders.
Art. 20. Liquidation. At the time of winding up the Company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, unitholders or not, appointed by the unitholders who shall determine their powers and remuneration.
A sole unitholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the
payment of all its assets and liabilities, known or unknown of the Company.
Chapter VII. Applicable law.
Art. 21. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.
<i>Transitional provisionsi>
The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on 31
st
December 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
The capital has been subscribed as follows:
Shares:
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Units
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Units
All these Shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand and five hundred pounds sterling (GBP
12,500.-) corresponding to a share capital of twelve thousand and five hundred pounds sterling (GBP 12,500.-) is now
available to the Company, as evidenced before the undersigned notary.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about thousand euro.
<i>General meetingi>
Immediately after the incorporation of the Company, CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., re-
presenting the entirety of the subscribed capital and exercising the powers devolved to the general meeting of Unitholders,
passed the following resolutions:
1) The number of Managers is three (3).
2) The following are appointed as Managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr. Rudolf Kömen, born on January 01, 1967 in Trier, Germany, having his professional address at 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg;
- Mr. Fernand Schaus, born on April 26, 1967 in Sandweiler, Luxembourg having his professional address at 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxembourg;
- Mr. Frank Schäfer, born on September 06, 1973 in Heidelberg, Germany, having his professional address at Kalan-
derplatz 5, CH-8045 Zurich.
31508
L
U X E M B O U R G
3) The Company shall have its registered office at 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg.
4) PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, with registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-1014 Luxem-
bourg (RCS Luxembourg, section B number 65 477) is appointed as independent auditor of the Company until the end
of the next annual general meeting of unitholders which will deliberate on the annual accounts of the Company.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a German version. On request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, he signed together with Us the notary the present deed.
Follows the German translation of the preceding text
Im Jahre zweitausendfünfzehn,
am achtundzwanzigsten Januar.
Vor Uns dem unterzeichneten Notar Jean-Joseph WAGNER, mit Amtssitz in Sassenheim, Großherzogtum Luxemburg,
ist erschienen:
„CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l.“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à
responsabilité limitée), mit Sitz in 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handelsregister
unter der Nummer R.C.S. B 185.605,
hier vertreten durch Herrn Alexander Wagner, Rechtsanwalt, mit beruflicher Anschrift in Luxemburg,
gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt am 21. Januar 2015.
Die Vollmacht bleibt nach Unterzeichnung ne varietur durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben registriert zu werden.
Die Erschienene, vertreten wie oben angezeigt, ersucht den unterzeichneten Notar, die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden:
Kapitel I. Form, Name, Gesellschaftssitz, Geschäftszweck, Dauer
Art. 1. Form, Name. Hiermit wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht unter der
Firma "Quay Street Manchester Real Estate S.à r.l." (nachstehend die "Gesellschaft") gegründet, die dem Luxemburger
Recht, insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung
(nachstehend das "Gesetz"), sowie dieser Satzung (nachstehend die "Satzung") unterliegt.
Art. 2. Sitz. Sitz der Gesellschaft ist Luxemburg-Stadt. Die Geschäftsführung ist befugt die Adresse der Gesellschaft
innerhalb des Gemeindegebietes des satzungsmäßig festgelegten Gesellschaftssitzes zu verlegen.
Der Sitz kann durch Beschluss einer außerordentlichen Gesellschafterversammlung gemäß dem für Satzungsänderun-
gen geltenden Verfahren an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
Sofern außergewöhnliche Ereignisse militärischer, politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Natur eintreten oder vor-
hersehbar sind, die die Gesellschaft in ihrer Tätigkeit am Gesellschaftssitz behindern, kann der Sitz der Gesellschaft
vorübergehend bis zur Normalisierung der Verhältnisse in ein anderes Land verlegt werden; eine solche vorübergehende
Maßnahme berührt die Nationalität der Gesellschaft nicht, die ungeachtet der einstweiligen Verlegung des Gesellschafts-
sitzes luxemburgisch bleibt. Die Entscheidung den Gesellschaftssitz ins Ausland zu verlegen wird von der Geschäftsführung
getroffen.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen und Geschäftsstellen sowohl in Luxemburg als auch im Ausland haben.
Art. 3. Zweck. Das Ziel der Gesellschaft ist
- das Kaufen oder Halten von Anteilen an einer oder mehreren Investmentgesellschaften;
- die Gewährung von Finanzierungen an Investmentgesellschaften, vorausgesetzt, dass sie direkt oder indirekt durch
eine oder mehrere Investmentgesellschaften von der Gesellschaft kontrolliert werden; und/oder
- das Kaufen von Immobilien und die Entwicklung,
Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von ihr gehaltener Immobilien.
Für diese Klausel gilt, dass "Immobilien" das Eigentum an Grundstücken (bestehend aus Land und Gebäuden), langfristige
Immobilien-bezogene Anlagen (solche wie Oberflächeneigentum (surface ownership), Hauptleasing (masterlease), Voll-
eigentum (fee simple ownership), exklusive Nutzungsrechte (concession) und Nießbrauch (lease-hold), Erwerbsoptionen
und zukünftige Verpflichtungen, die nach Fertigstellung in Bezug auf solche Grundstücke und grundstückbezogene Lang-
zeitinteressen und andere Vermögensgegenstände erworben werden, die notwendig sind, um solche Grundstück und
grundstückbezogene Langzeitinteressen zu betreiben, beinhaltet. Für die Zwecke dieser Klausel meint "Investmentge-
sellschaft" jede Gesellschaft oder anderes Investitionsvehikel, deren Ziel (gemäß ihrer Satzung oder anderen Gründungs-
31509
L
U X E M B O U R G
unterlagen) der Kauf von Immobilien und die Entwicklung, Verwaltung, der Betrieb, die Vermietung und der Verkauf von
ihr gehaltener Immobilien, (direkt oder indirekt durch eine oder mehrere Investitionsvehikel mit einer ähnlichen Ziel-
setzung), der Kauf oder das Halten von Anteilen an einem oder mehreren Investitionsvehikeln mit einer ähnlichen
Zielsetzung und/oder Gewährung von Finanzierungen an solche Investitionsvehikel ist, vorausgesetzt, dass das finanzierte
Investitionsvehikel letztendlich von der Gesellschaft kontrolliert wird.
Die Gesellschaft kann Darlehen aufnehmen und Schuldverschreibungen, Vorzugsaktien, Schuldscheine und Pfandbriefe,
wandelbar oder nicht wandelbar im Rahmen des Gesetzes ausgeben. Die Gesellschaft kann jegliche Unterstützung, Dar-
lehen, Vorschüsse oder Garantien an oder zugunsten von Gesellschaften, Treunehmern oder Unternehmen geben, an
welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält oder die dem gleichen Konzern wie die Gesellschaft angehören
(die "Verbundenen Unternehmen"). Die Gesellschaft kann jegliche Garantie zugunsten einer dritten Partei gewähren, um
die Verpflichtungen von Verbundenen Unternehmen zu besichern. Die Gesellschaft ist zudem dazu berechtigt, sich zu
verbürgen, zu verpfänden oder in anderer Weise Sicherheiten an oder über ihre Vermögenswerte zu bestellen, um die
eigenen Verpflichtungen oder diejenigen eines Verbundenen Unternehmens zu sichern.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten und Transaktionen durchführen, die sie für notwendig erachtet, um ihre Ziele
zu erfüllen, sowie alle Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit der Förderung der Erreichung ihrer Ziele verbunden sind,
einschließlich Transaktionen zur Absicherung von Interessen und/oder Wechselkursrisiken.
Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Dauer gegründet.
Kapitel II. Kapital und Gesellschaftsanteile
Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Pfund Sterling (GBP 12.500,-),
aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Gesellschaftsanteile ohne Bezug zu einem Nennwert.
Art. 6. Kapitaländerungen. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit durch Beschluss des alleinigen Anteilsinhabers (so-
weit es nur einen Anteilsinhaber gibt) oder durch Beschluss der Gesellschafterversammlung gemäß Artikel 16 dieser
Satzung geändert werden.
Art. 7. Ausschüttungsrechte der Anteile. Jeder Anteil gibt seinem jeweiligen Besitzer das Recht auf einen Anteil der
Aktiva und der erzielten Gewinne der Gesellschaft im direkten proportionalen Verhältnis zu den bestehenden Anteilen.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Gesellschaftsanteile unteilbar insofern nur ein
Besitzer pro Anteil zugelassen ist. Die gemeinschaftlichen Miteigentümer sind verpflichtet eine einzige Person als ihren
Vertreter gegenüber der Gesellschaft zu ernennen.
Art. 9. Übertragung der Anteile. Solange die Gesellschaft nur einen Anteilinhaber hat, sind die Gesellschaftsanteile frei
auf Dritte übertragbar.
Hat die Gesellschaft mehrere Anteilinhaber, können die Gesellschaftsanteile unter den im Artikel 189 des Gesetzes
vorgeschriebenen Bedingungen übertragen werden.
Jeder Anteilinhaber ist damit einverstanden seine Gesellschaftsanteile nicht ohne das vorherige Einverständnis der
Mehrheit der Anteilinhaber, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals besitzen, zu verpfänden oder als Garantie
zu verwenden.
Kapitel III. Geschäftsführung
Art. 10. Geschäftsführung. Die Geschäftsführung, die aus mindestens drei Geschäftsführern besteht, verwaltet die
Gesellschaft. Die Geschäftsführer müssen nicht Anteilinhaber sein. Die Geschäftsführer können zu jeder Zeit durch einen
Beschluss der Anteilinhaber, die eine Mehrheit der Stimmen besitzen, mit oder ohne Grund abberufen werden.
Die Beschlüsse der Geschäftsführung werden von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer
gefasst.
Die Geschäftsführer wählen einen Vorsitzenden und einen oder mehrere stellvertretende Vize-Vorsitzenden sowie,
falls erforderlich, einen Sekretär, der nicht Geschäftsführer sein muss, und der die Protokolle der Geschäftsführersit-
zungen aufsetzt. Die Geschäftsführerversammlung wird vom Vorsitzenden bzw. von zwei Geschäftsführern eingeladen
und an dem in der Einladung angegebenen Ort abgehalten.
Der Vorsitzende steht allen Versammlungen der Gesellschafter vor. Für den Fall seiner Abwesenheit oder Handlungs-
unfähigkeit wird er vom Vize-Vorsitzenden oder einem anderen durch die Geschäftsführung bestimmten Geschäftsführer
als Vertreter auf Zeit vertreten. Für den Falle der Abwesenheit oder Handlungsfähigkeit auch dieser Personen können
die Gesellschafter einen anderen Geschäftsführer, einen leitenden Angestellten oder eine sonstige Person zum Vorsit-
zenden auf Zeit durch Beschluss mit Mehrheit der teilnehmenden oder vertretenen Gesellschaftsanteile wählen.
Die Geschäftsführung hat die Befugnis zur Anstellung von leitenden Angestellten, insbesondere Prokuristen, Assisten-
zen von Prokuristen, Sekretären, Assistenzsekretären oder anderen Angestellten, die als erforderlich für die Geschäfts-
tätigkeit der Gesellschaft angesehen werden können, wobei diese Personen keine Geschäftsführer oder Gesellschafter
sein müssen. Die Angestellten haben, solange nichts anderes in dieser Satzung geregelt ist, die ihnen von der Geschäfts-
führung übertragene Handlungsbefugnis. Die Geschäftsführung kann die laufende Geschäftsführung sowie die Abwicklung
31510
L
U X E M B O U R G
von Gesellschaftsbezogenen Angelegenheiten im Einklang mit der Gesellschaftspolitik und dem Gesellschaftszweck an
diese Angestellten delegieren. Eine solche Delegation kann jederzeit von der Geschäftsführung widerrufen werden.
Die Einladung zu einer Versammlung der Geschäftsführung erfolgt schriftlich bzw. per Kabel, Telegramm, Telex, Fax
oder auf elektronischem Wege und soll mindestens vierundzwanzig Stunden vor der Versammlung zugestellt werden.
Die Einladung beinhaltet die Tagesordnung der Versammlung. Ein nicht in der Tagesordnung enthaltener Agenda-Punkt
kann nicht rechtsgültig in der Versammlung beraten werden. Auf die Einberufung zur Versammlung der Geschäftsführer
kann verzichtet werden mittels schriftlicher Einwilligung bzw. mittels einer Zustellung der Mitteilung per Kabel, Tele-
gramm, Telex, Fax oder elektronischer Mittel. Das Erfordernis der Einberufung gilt als verzichtet für alle in der
Versammlung anwesenden oder durch Vollmacht vertretenen Geschäftsführer. Für die Versammlungen, die gemäß einem
durch Beschluss der Geschäftsführer festgesetzten Zeitplan abgehalten werden, ist keine zusätzliche Einladung zur Ver-
sammlung erforderlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich in der Versammlung der Geschäftsführer durch einen anderen Geschäftsführer ver-
treten lassen, in dem er schriftlich bzw. per Kabel, Telefax, Telegramm, Telex, einen anderen Geschäftsführer als seinen
Bevollmächtigten ernennt. Die Teilnahme der Geschäftsführer an der Geschäftsführungssitzung kann per Telefon, Video-
Konferenzschaltung oder anderen ähnlichen Kommunikationsmittel, die es allen an der Geschäftsführungssitzung teil-
nehmenden Personen erlaubt, sich gegenseitig zu hören, erfolgen. Ein Geschäftsführer, der durch die Kommunikations-
mittel an einer Geschäftsführungssitzung teilnimmt, gilt als persönlich Anwesender dieser Sitzung.
Eine Versammlung der Geschäftsführer per Telefon oder Video-Konferenzschaltung oder jeder anderen Art von Au-
dio- oder Videokommunikation, an der ein Quorum von Geschäftsführern teilnimmt, ist genauso bindend als ob alle
Geschäftsführer persönlich anwesend gewesen wären, vorausgesetzt, ein Protokoll wurde erstellt und vom Vorsitzenden
der Geschäftsführungssitzung unterzeichnet.
Die Geschäftsführung kann rechtsgültig Beschlüsse fassen, wenn mindestens die Mehrheit der Mitglieder anwesend
oder vertreten ist. Die Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Geschäftsführer gefasst,
welche bei der Sitzung anwesend oder vertreten sind.
Nicht persönlich anwesende oder nicht vertretene Geschäftsführer können schriftlich bzw. durch Kabel, Telegramm,
Telex, Fax oder durch Einsatz anderer elektronischer Mittel an der Abstimmung teilnehmen.
Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden auschlaggebend.
Umlaufbeschlüsse, die von allen Geschäftsführern unterzeichnet wurden, sind genauso rechtswirksam und bindend, als
ob die Sitzung ordnungsgemäß einberufen und abgehalten worden wäre. Die Unterschrift der Geschäftsführer kann auf
einer einzelnen Ausfertigung bzw. auf mehreren Ausfertigungen eines jeden Beschlusses vermerkt sein, und auch per Brief,
Telefax oder Telex bestätigt werden. Diese Beschlüsse treten in Kraft am Tage des im Umlaufbeschluss vermerkten
Datums. Sollte dort kein spezielles Datum vermerkt sein, wird der Umlaufbeschluss gültig an dem Tag, an dem die letzte
Unterschrift getätigt wird.
Beschlüsse, die durch elektronische Mittel wie z.B. per E-Mail, ein Telegramm oder ein Telex gefasst werden, müssen
anschließend durch einen Zirkularbeschluss formalisiert werden. Das Inkrafttreten des Zirkularbeschlusses erfolgt am
Tage der letzten Zustimmungserklärung, welche die Gesellschaft in elektronischer Form erhielt. Die Zustimmungen von
allen Mitgliedern der Geschäftsführung werden dem Umlaufbeschluss beigefügt und bilden dabei einen integralen Be-
standteil derselben, wobei der Umlaufbeschluss die zuvor in elektronischer Form gefassten Beschlüsse bestätigt.
Umlaufbeschlüsse können nur durch einstimmigen Beschluss aller Geschäftsführer gefasst werden.
Die Protokolle der Sitzungen der Geschäftsführung müssen durch den Vorsitzenden der Sitzung unterzeichnet werden.
Kopien oder Auszüge dieser Protokolle, welche für die Zwecke von juristischen Verfahren oder andersweitig erstellt
werden, sind vom Vorsitzenden der Geschäftsführung oder seinem zeitweisen Vertreter in dieser Sitzung oder von zwei
Geschäftsführern zu unterzeichnen.
Art. 11. Befugnisse der Geschäftsführer. Gegenüber Dritten haben die Geschäftsführer die Befugnis unter allen Um-
ständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Geschäfte und Handlungen, die dem Geschäftszweck der
Gesellschaft entsprechen, auszuführen und zu genehmigen, vorausgesetzt, dass die Bestimmungen dieses Artikels beachtet
wurden.
Sämtliche Befugnisse, die nicht ausdrücklich durch das Gesetz oder die vorliegende Satzung der Gesellschafterver-
sammlung vorbehalten sind, fallen in die Zuständigkeit der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann insbesondere
Vermögensberatungsverträge und Verwaltungsverträge, wie z.B. Grundstücksmakler- oder Grundstücksverwaltungsver-
träge abschließen.
Art. 12. Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift zweier Geschäftsführer
oder anderer Personen, welche hierzu von der Geschäftsführung wirksam bevollmächtigt wurden, rechtsgültig verpflich-
tet.
Art. 13. Befugnisübertragung und Vertretung der Geschäftsführung. Die Geschäftsführung kann ihre Befugnisse für
bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere ad hoc Vertreter abtreten.
Die Geschäftsführung wird die Verantwortung und (gegebenenfalls) Entlohnung, die Dauer der Vertretung und alle
anderen erheblichen Bedingungen dieser Vertretung festlegen.
31511
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Entlohnung der Geschäftsführer. Die Befugnisse und die Entlohnung eines möglicherweise zu einem späteren
Zeitpunkt zusätzlich oder zu Ersatzzwecken ernannten Geschäftsführern werden im jeweiligen Ernennungsschreiben
festgelegt.
Art. 15. Haftung der Geschäftsführer. In Ausübung ihres Mandates sind die Geschäftsführer nicht persönlich haftbar
für die Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie verantwortlich für die gewissenhafte
Ausführung der ihnen obliegenden Pflichten.
Kapitel IV. Gesellschafterversammlung
Art. 16. Befugnisse der Gesellschafterversammlung. Der alleinige Anteilinhaber übernimmt alle der Gesellschafterver-
sammlung zuerkannten Befugnisse.
Falls es mehrere Anteilinhaber geben sollte, kann jeder Anteilinhaber an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen,
unabhängig der ihm gehörenden Anzahl an Anteilen. Jeder Anteilinhaber verfügt über Stimmrechte, entsprechend der ihm
gehörenden Anteile.
Ein Anteilinhaber kann in jeder Gesellschafterversammlung handeln, indem er eine andere Person, die selbst nicht
Anteilinhaber sein muss (oder wenn der Anteilinhaber eine juristische Einheit ist, ihre(n) gesetzliche(n) Vertreter),
schriftlich oder per Telefax, Kabel, Telegramm, Telex, E-Mail als seinen Bevollmächtigten ernennt.
Gemeinsame Beschlüsse sind nur gültig gefasst, wenn sie von Anteilinhabern die mehr als die Hälfte des Gesellschafts-
kapitals besitzen, gefasst wurden. Jedoch können Beschlüsse zur Abänderung der vorliegenden Satzung nur von einer
Mehrheit der Anteilinhaber, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten, nach Maßgabe der ge-
setzlichen Vorschriften gefasst werden.
Kapitel V. Geschäftsjahr - Bilanz
Art. 17. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jedes Jahr am 1. Januar und endet am 31. Dezember
desselben Jahres.
Am Ende jedes Geschäftsjahres werden die Jahresabschlüsse der Gesellschaft erstellt und die Geschäftsführung wird
ein Inventar, einschließlich einer Bilanz und einer Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft vorbereiten.
Jeder Anteilinhaber hat das Recht die Bücher und Niederschriften der Gesellschaft, das oben genannte Inventar und
die Bilanz am eingetragenen Sitz der Gesellschaft einzusehen.
Die Geschäfte der Gesellschaft, einschließlich insbesondere ihrer Bücher und Steuerangelegenheiten oder anderer
Berichte, welche nach Luxemburger Gesetz erforderlich sind, unterliegen der Überwachung durch einen Wirtschafts-
prüfer («réviseur d’entreprises»). Derselbe wird durch die jährliche Generalversammlung bestimmt für eine Periode bis
zur nächsten jährlichen Generalversammlung und bis zur Wahl seines Nachfolgers.
Der Wirtschaftsprüfer kann jederzeit im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 256 des Gesetzes vom 10. August
1915 über Handelsgesellschaften abberufen werden.
Art. 18. Zuweisung und Ausschüttung von Gewinnen. Der Bruttogewinn der Gesellschaft wie in der Jahresbilanz
aufgeführt ergibt nach Abzug der allgemeinen Kosten, Tilgungskosten und Ausgaben jeglicher Art den Reingewinn. Vom
Nettogewinn wird die Summe von fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage zugeführt, solange bis diese Rücklage zehn
Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals erreicht.
Der Überschuss des Nettogewinns kann an die/den Anteilinhaber im Verhältnis zu ihren/seinen Anteilsbeteiligungen
in der Gesellschaft ausgeschüttet werden.
Kapitel VI. Auflösung - Liquidation
Art. 19. Auflösungsgründe. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt nicht im Falle des Todes, der Außerkraftsetzung der
Bürgerrechte, bei Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs des alleinigen Anteilinhabers oder von einem der Anteilinhaber.
Art. 20. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere durch die
Anteilinhaber ernannten Liquidatoren durchgeführt, die nicht unbedingt selbst Anteilinhaber sein müssen; die Anteilin-
haber legen die Aufgaben und Vergütung der Liquidatoren fest.
Ein alleiniger Anteilinhaber kann die Auflösung der Gesellschaft und die Durchführung der Liquidation beschließen,
wobei er persönlich die Zahlung des gesamten Vermögens und der gesamten Schulden übernimmt, welche der Gesell-
schaft bekannt oder unbekannt sind.
Kapitel VII. Geltendes Recht
Art. 21. Ergänzend zu der vorliegenden Satzung gelten für alle weiteren Angelegenheiten die Bestimmungen des Ge-
setzes.
<i>Übergangsbestimmungeni>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tage der Gesellschaftsgründung und endet am 31. Dezember 2015.
31512
L
U X E M B O U R G
<i>Zeichnung - Zahlungi>
Das Kapital wurde wie folgt gezeichnet:
Anteile:
CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Gesamt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Anteile
Diese Anteile wurden voll einbezahlt, sodass der Betrag von zwölftausendfünfhundert Pfund Sterling (GBP 12.500,-)
entsprechend einem Anteilkapital von zwölftausendfünfhundert Pfund Sterling (GBP 12.500,-) nunmehr der Gesellschaft
zur Verfügung steht, wie dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Geschätzte Kosteni>
Die Kosten, Aufwendungen, Gebühren und Auslagen in jedweder Form, die in Verbindung mit der Gesellschaftsgrün-
dung zu tragen sind oder ihr in Rechnung gestellt werden, werden auf etwa tausend Euro geschätzt.
<i>Gesellschafterversammlungi>
Unmittelbar nach Gründung der Gesellschaft, fasst CSRE I European Property (Luxembourg) Holding S.à r.l., die die
Gesamtheit des gezeichneten Kapitals repräsentiert und die Befugnisse der Versammlung der Anteilsinhaber ausübt,
folgende Beschlüsse:
1) Die Zahl der Vorstandsmitglieder wird auf drei (3) festgesetzt.
2) Zu Geschäftsführern werden folgende Personen, für einen unbegrenzten Zeitraum ernannt:
- Herr Rudolf Kömen, geboren am 01. Januar 1967 in Trier, Deutschland, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean Monnet,
L-2180 Luxemburg;
- Herr Fernand Schaus, geboren am 26. April 1967 in Sandweiler, Luxemburg, mit Geschäftsanschrift 5, rue Jean
Monnet, L-2180 Luxemburg;
- Herr Frank Schäfer, geboren am 06. September 1973 in Heidelberg, Deutschland, mit Geschäftsanschrift Kalander-
platz 5, CH-8045 Zürich.
3) Zum Gesellschaftssitz wird 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg bestimmt.
4) Zum Wirtschaftsprüfer wird PricewaterhouseCoopers, Société Coopératve mit Gesellschaftssitz in 2, rue Gerhard
Mercator, L-1014 Luxembourg (RCS Luxemburg, Sektion B Nummer 65 477) bis zum Ende der nächsten jährlichen
Generalversammlung ernannt, die über den Jahresabschluss der Gesellschaft befindet.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch
der oben genannten erschienenen Partei in englischer Sprache verfasst wurde und ihr eine deutsche Version beigefügt
ist. Auf Wunsch derselben erschienenen Partei soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschem Text
die englische Fassung maßgeblich sein.
WORÜBER die vorliegende Urkunde in Luxemburg am eingangs des vorliegenden Dokuments angegebenen Datum
aufgesetzt wurde.
Und nach Verlesung und Erklärung alles Vorstehenden gegenüber dem erschienenen Bevollmächtigten, hat letzterer
mit Uns, dem amtierenden Notar, gemeinsam die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: A. WAGNER, J.J. WAGNER.
Einregistriert zu Esch/Alzette A.C., am 30. Januar 2015. Relation: EAC/2015/2424. Erhalten fünfundsiebzig Euro (75.-
EUR).
<i>Der Einnehmer ff.i> (gezeichnet): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015018433/477.
(150021762) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Câblinvest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 137.413.
Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de
résidence à Esch/Alzette, en date du 13 novembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 15 décembre 2014.
Référence de publication: 2015018726/11.
(150022723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
31513
L
U X E M B O U R G
Eleanore Luxembourg II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 950.000,00.
Siège social: L-8011 Strassen, 179, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 177.684.
In the year two thousand and fourteen, on the first day of December.
Before Maître Francis Kesseler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersi-
gned.
There appeared:
Eleanore Luxembourg I S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 179, route d'Arlon, L-8011
Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number
B 177.581 (the “Sole Shareholder”),
hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address at 5, rue Zénon
Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private
seal.
Such power of attorney having been signed “ne varietur” by the power of attorney holder acting on behalf of the
appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the
registration authorities.
The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of Eleanore Luxembourg II S.à r.l., a private limited liability company
(“société à responsabilité limitée”) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having
its registered office at 179, route d’Arlon, L-8011 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Trade and Companies’ Register under the number B 177.684, incorporated by a deed enacted by the undersigned notary,
on 29 May 2013, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Memorial”) number 1738 on
19 July 2013 (the “Company”).
The articles of association of the Company have been lastly amended by a deed enacted by the undersigned notary on
24 June 2013, published in the Memorial number 2165 on 5 September 2013.
II.- That the 950,000 (nine hundred fifty thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar)
each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all
the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiver of the convening notice;
2. Change of the financial year of the Company to begin on 1
st
January and to end on 31
st
December;
3. Subsequent termination on 31 December 2014 of the current financial year of the Company having started on 1
September 2014;
4. Amendment to articles 17 and 18 of the articles of association of the Company in order to reflect the amendment
under item 2. above; and
5. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder
acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore
agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine
carefully each document.
<i>Second resolution:i>
The Sole Shareholder resolves to change the financial year of the Company to begin on 1
st
January and to end on 31
st
December.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the Sole Shareholder resolves to terminate exceptionally and transitorily
the current financial year of the Company having started on 1 September 2014 on 31 December 2014.
31514
L
U X E M B O U R G
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend the articles
17 and 18 of the articles of association of the Company so as to read respectively as follows:
“ Art. 17. The Company's financial year begins on 1
st
January and closes on 31
st
December.”
“ Art. 18. Each year, as of 31
st
December, the board of managers, or the sole manager (as the case may be) will draw
up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities
and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the manager(s), statutory
auditor(s) (if any) and shareholder(s) toward the Company.
At the same time the board of managers or the sole manager (as the case may be) will prepare a profit and loss account,
which will be submitted to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) together
with the balance sheet.”
There being no further business before the meeting, the same was thereupon closed.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named
at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, she signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version shall prevail.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire public établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
A comparu:
Eleanore Luxembourg I S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant sous le droit du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social sis 179, route d’Arlon, L-8011 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, immatri-
culée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 177.581 (l’“Associé Unique”),
ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, avec adresse professionnelle au 5, rue
Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing
privé.
Ladite procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et
le notaire instrumentaire, demeurera annexée au présent acte pour être soumis ensemble aux formalités de l’enregis-
trement.
La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentaire d’acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l’associé unique de Eleanore Luxembourg II S.à r.l., une société à responsabilité constituée
et existant selon le droit du Grand Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis 179, route d’Arlon, L-8011 Strassen,
Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 177.684, constituée par acte notarié dressé par le notaire instrumentaire le 29 mai 2013, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (le “Mémorial”) numéro 1738 le 19 juillet 2013 (la “Société”).
Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire instrumentaire
le 24 juin 2013, publié au Mémorial numéro 2165 le 5 septembre 2013.
II.- Que les 950.000 (neuf cent cinquante mille) parts sociales d’une valeur nominale de 1 USD (un Dollar américain)
chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l’assemblée peut valable-
ment se prononcer sur tous les points à l’ordre du jour desquels l’Associé Unique reconnaît expressément avoir été
dûment préalablement informé.
III.- L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Changement d’exercice social de la Société afin qu’il débute le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre;
3. Clôture subséquente au 31 décembre 2014 de l’exercice social en cours de la Société ayant débuté le 1
er
septembre
2014;
4. Modification des articles 17 et 18 des statuts de la Société de sorte à refléter la modification sous le point 2. ci-
dessus; et
5. Divers.
Suite à l’approbation de ce qui précède par l’Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:
31515
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolution:i>
L’Associé Unique renonce à son droit de recevoir convocation préalable afférente à la présente assemblée; l’Associé
Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l’ordre du jour, considère l’assemblée valablement convoquée et en
conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l’ordre du jour. Il est en outre décidé que toute
la documentation utile a été mise à la disposition de l’Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un
examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
L’Associé Unique décide de changer l’exercice social de la Société afin qu’il débute le 1
er
janvier et se termine le 31
décembre.
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de la résolution ci-dessus, l’Associé Unique décide de clôturer exceptionnellement et transitoirement
l’exercice social en cours de la Société ayant débuté le 1
er
septembre 2014 au 31 décembre 2014.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier les articles 17 et 18 des
statuts de la Société de sorte qu’ils aient respectivement la teneur suivante:
“ Art. 17. L'exercice social de la Société commence le 1
er
janvier et se termine le 31 décembre.”
“ Art. 18. Chaque année, au 31 décembre, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) établira le bilan qui
contiendra l’inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes accompagné d’une annexe contenant le résumé
de tous ses engagements, ainsi que les dettes du (des) gérant(s), du (des) commissaire(s) (s'il en existe) et du (des) associé
(s) envers la Société.
Dans le même temps, le conseil de gérance ou le gérant unique (selon le cas) préparera un compte de profits et pertes
qui sera soumis à l’assemblée générale des associés ou à l’associé unique (selon le cas) ensemble avec le bilan.”
Aucun autre point n’ayant à être traité devant l’assemblée, celle-ci a été clôturée.
Dont acte fait et passé à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, au jour qu’entête des présentes.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l’original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l’assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d’une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en
cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16922. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015018052/144.
(150021338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Charitable Luxembourg Three S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 15.800,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 128.147.
Par résolutions prises en date du 31 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes :
1. Nomination de Choui Min Kon Kam King, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015016993/15.
(150020280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
31516
L
U X E M B O U R G
Pro S.A., Société Anonyme.
R.C.S. Luxembourg B 107.665.
A dater du 1
er
janvier 2015, le contrat de domiciliation 11, rue des Tondeurs, L-9570 - WILTZ qui liait la S.à R.L. «AP
Audit» et/ou son signataire ci-dessous à la société anonyme «PRO» a été dénoncé.
AP Audit S.à R.L.
Pierre Alcover
<i>Réviseurs d'entreprises agréési>
Référence de publication: 2015017592/11.
(150020238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Lux Gestion Tresorerie S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 109.844.
<i>Extrait des résolutions prises par l'administrateur unique en date du 16 janvier 2015i>
L'administrateur unique Monsieur Paolo BETTIOL décide de transférer le siège social de la Société de son ancienne
adresse sise 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 21, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017419/12.
(150020419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Rockspring TransEuropean Properties V Swiss S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: CHF 15.839.702,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 173.234.
In the year two thousand and four, on the thirtieth day of December.
Before Us, Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
Was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Rockspring TransEuropean Properties V Swiss
S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 173.234 and having a share capital of thirty-one
million six hundred forty-nine thousand and two Swiss franc (CHF 31,649,002) (the Company). The Company has been
incorporated on November 28, 2012 pursuant to a deed of Me Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, pu-
blished in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Memorial C”) under number 110 on January 16,
2013. The articles of association of the Company have been amended for the last time on February 28, 2014 pursuant to
a deed of Maître Francis Kesseler, notary, residing in Esch-sur-Alzette, Luxembourg published in the Mémorial C under
number 2274 on August 26, 2014.
There appeared:
Rockspring Transeuropean Properties V Swiss 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité
limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five
hundred Euro (EUR 12,500.-), with registered office at 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register under number B 181.038. (referred to hereinafter as “RockSwiss”)
hereby represented by Wayne Fitzgerald, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy
given under private seal.
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
and
Partners Group Skylab Access, L.P. Inc., a company incorporated and existing under the laws of Guernsey, with re-
gistered office at Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernsey (referred to hereinafter as “Skylab”),
hereby represented by Wayne Fitzgerald, private employee, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxy
given under private seal.
31517
L
U X E M B O U R G
Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
RockSwiss and Skylab are referred to collectively hereinafter as (the Shareholders), The Shareholders have requested
the undersigned notary to record the following:
- That the thirty-one million six hundred and forty-nine thousand and two Swiss Francs (CHF 31,649,002), divided into
thirty thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class C
shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class D shares, three million
one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E shares, three million one hundred sixty-one
thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class F shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred
and sixty (3,161,860) class G shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860)
class H shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class I shares, and three
million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class J shares, with a par value of one Swiss
Franc (CHF 1) each, representing the entirety of the share capital of the Company, are duly represented at this Meeting
which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items of the agenda, hereinafter reproduced;
- That the Company approved the reduction of the share capital of the Company at the meeting of the board of
managers of the Company dated 23 December 2014, whereby the managers of the Company allow such reduction of
the share capital of the Company. The said minutes of the meeting of the board of managers of the Company shall be
annexed to the present deed for the purpose of registration.
- That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Reduction of the share capital of the Company by an amount of fifteen million eight hundred nine thousand three
hundred Swiss Franc (CHF 15,809,300), in order to bring the share capital of the Company from its present amount of
the thirty-one million six hundred and forty-nine thousand and two Swiss Francs (CHF 31,649,002), represented by thirty
thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred
and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860)
class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class C shares, three
million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class D shares, three million one hundred
sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class F shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class G shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class H
shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class I shares, and three million
one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class J shares, with a par value of one Swiss Franc
(CHF 1) each,
to fifteen million eight hundred thirty-nine thousand seven hundred two Swiss Franc (CHF 15,839,702) represented
by thirty thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class C
shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class D shares, three million
one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E shares,
by the redemption of the shares class J represented by the amount of three million one hundred sixty-one thousand
eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares class I, represented by the amount of three million one
hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares class H represented by the
amount of of three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares
class G represented by the amount of of three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss
Franc (CHF 3,161,860) and shares class F, represented by the amount of of three million one hundred sixty-one thousand
eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860).
2. Amendment of article 5.1 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital adopted under item
1.
3. Amendment of article 5.4 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital adopted under item
1.
4. Amendment of article 15.3 of the Articles in order to reflect the reduction of the share capital adopted under item
1.
5. Miscellaneous.
- That the Meeting has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of fifteen million eight hundred nine
thousand three hundred Swiss Franc (CHF 15,809,300), in order to bring the share capital of the Company from its
present amount of the thirty-one million six hundred and forty-nine thousand and two Swiss Francs (CHF 31,649,002),
31518
L
U X E M B O U R G
represented by thirty thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three million one hundred sixty-one
thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred
and sixty (3,161,860) class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860)
class C shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class D shares, three
million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E shares, three million one hundred
sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class F shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class G shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class H shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class I
shares, and three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class J shares, with a par
value of one Swiss Franc (CHF 1) each,
to fifteen million eight hundred thirty-nine thousand seven hundred two Swiss Franc (CHF 15,839,702) represented
by thirty thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class C
shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class D shares, three million
one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E shares,
by the redemption of the shares class J represented by the amount of three million one hundred sixty-one thousand
eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares class I, represented by the amount of three million one
hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares class H represented by the
amount of of three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860), shares
class G represented by the amount of of three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty Swiss
Franc (CHF 3,161,860) and shares class F, represented by the amount of of three million one hundred sixty-one thousand
eight hundred and sixty Swiss Franc (CHF 3,161,860).
The Meeting resolves to record that the shareholding in the Company is following to the decrease of the share capital
as follows:
Partners Group Skylab Access, L.P. Inc.:
(15,201) ordinary shares;
(1,580,930) class A shares;
(1,580,930) class B shares
(1,580,930) class C shares
(1,580,930) class D shares
(1,580,930) class E shares
Rockspring Transeuropean Properties V Swiss 1 S.à r.l.:
(15,201) ordinary shares;
(1,580,930) class A shares;
(1,580,930) class B shares
(1,580,930) class C shares
(1,580,930) class D shares
(1,580,930) class E shares
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the preceding resolution, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
“ 5.1. “The share capital of the Company is set at fifteen million eight hundred thirty-nine thousand seven hundred
two Swiss Franc (CHF 15,839,702), represented by thirty thousand four hundred and two (30,402) ordinary shares, three
million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class A shares, three million one hundred
sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class B shares, three million one hundred sixty-one thousand eight
hundred and sixty (3,161,860) class C shares, three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty
(3,161,860) class D shares and three million one hundred sixty-one thousand eight hundred and sixty (3,161,860) class E
shares, each share with a par value of one Swiss Franc (CHF 1), all subscribed and fully paid-up”
<i>Third resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 5.4 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
“The share capital may be increased once or more by a resolution of the General Meeting in accordance with the
conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Subject to always complying with applicable law, the share capital of the Company may from time to time be reduced
by the redemption and cancellation of an entire class of shares through the redemption and cancellation of all the shares
31519
L
U X E M B O U R G
in issue in such class, provided that the order of redemption set out below be respected. Any redemption shall be triggered
by the Company. The shareholder(s) have no right to force any redemption of their shares. In the event of a reduction
of share capital through the redemption and the cancellation of a class of shares, such class gives right to the holders
thereof, pro rata to their holding in such class, to the Available Amount (with the limitation however to the Total
Cancellation Amount as determined by the General Meeting) and the holders of shares of the repurchased and cancelled
class shall receive from the Company an amount corresponding to the "Cancellation Value Per Share" for each share of
the relevant class held by them and cancelled, such Cancellation Value Per Share being calculated by dividing the Total
Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class to be repurchased and cancelled.
The above mentioned redemptions shall be made in the following order of priority:
(i) no class A shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class B shares outstanding;
when the class A shares shall be redeemed, the Company shall be dissolved and liquidated at the same time;
(ii) no class B shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class C shares outstanding;
(iii) no class C shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class D shares outs-
tanding.
(iv) no class D shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class E shares outstanding.
(v) no class E shares may be redeemed if the Company has at the time of the redemption any class F shares outstanding.
The above shall not prejudice to any other form of capital reduction or any other form of distribution..”
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the first resolution, the Meeting resolves to amend article 15.3 of the Articles so that it shall
henceforth read as follows:
“ 15.3. The sole Shareholder or, as the case may be, the General Meeting shall determine whether all or part of the
remainder of the net profits shall be distributed. Dividends may be distributed to the sole shareholder or, as the case
may be, the General Meeting pro rata to the amount of shares which each Shareholder holds in respect of each class of
shares of the Company subject to the following:
(a) the class A shares allow the Shareholders holding class A shares the right to receive dividend distributions with
respect to the given financial year in an amount of 0.10% of the nominal value of the class A shares held by them;
(b) the class B shares allow the Shareholders holding class B shares the right to receive dividend distributions with
respect to the given financial year in an amount of 0.15% of the nominal value of the class B shares held by them;
(c) the class C shares allow the Shareholders holding class C shares the right to receive dividend distributions with
respect to the given financial year in an amount of 0.20% of the nominal value of the class C shares held by them;
(d) the class D shares allow the Shareholders holding class D shares the right to receive dividend distributions with
respect to the given financial year in an amount of 0.25% of the nominal value of the class D shares held by them;
(e) the class E shares allow the Shareholders holding class E shares the right to receive dividend distributions with
respect to the given financial year in an amount of 0.30% of the nominal value of the class E shares held by them; and
(f) the class E shares allow the Shareholders holding class E shares the right to receive the remainder of any dividend
distribution.”
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes with power
and authority given to any manager of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the cancelled shares in the share register of the Company, with any other action necessary and related to
the above resolutions.
There being no further business, the meeting is terminated.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present decrease of the share capital, is approximately six
thousand euro (EUR 6.000.-).
The undersigned notary, who knows and understands English, states that on request of the appearing party, the present
deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.
WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, they signed together with the notary the
present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le trentième jour de décembre,
31520
L
U X E M B O U R G
Par devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Rockspring TransEuropean Properties V Swiss
S.à r.l., limitée une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
avec un capital social de CHF 31,649,002 immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 173.234, (la "Société") et constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg par un acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 28 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations daté du 16 janvier 2013 numéro 110 dont les statuts ont été modifiés la dernière fois le 28 février 2014
suite à un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Luxembourg, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations daté du 26 aout 2014 numéro 2274.
Ont comparu
Rockspring TransEuropean Properties V Swiss 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon
les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-), ayant
son siège social au 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 181.038 (ci-après "RockSwiss"),
représentée par Wayne Fitzgerald, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée sous seing privé.
et
Partners Group Skylab Access, L.P. Inc., une société constituée et existant selon les lois de Guernesey, ayant son siège
social au Tudor House, Le Bordage, St. Peter Port, Guernesey, (ci-après le "Skylab"),
représentée par Wayne Fitzgerald, employé privé, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d’une pro-
curation donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant pour le compte des parties com-
parantes et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès de
l’enregistrement.
(les parties comparantes sont ci-dessous collectivement dénommées les Associés) Les Actionnaires ont requis le
notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que les trente et un millions six cent quarante-neuf mille deux Francs suisse (CHF 31,649,002,-), représenté par
trente mille quatre cent deux (30.402) parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante
(3.161.860) parts sociales de classe A, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales
de classe B, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe C, trois millions
cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions cent soixante et un mille
huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe E, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante
(3.161.860) parts sociales de classe F, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales
de classe G, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe H, trois millions
cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe I, et trois millions cent soixante et un
mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe J, ayant une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1, -)
chacune, sont dûment représentées à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour reproduit ci-après;
- Que la société a approuvé la réduction du capital social lors de la réunion du conseil de gérance de la Société en date
du 23 décembre 2014. Lesdites minutes de la réunion du conseil de gérance de la Société seront annexées au présent
acte pour fins d'enregistrement.
- Que l’ordre du jour de l’Assemblée est libellé comme suit:
1. Réduction du capital social de la société par un montant de quinze million huit cent neuf mille trois cent Francs
suisse (CHF 15,809,300), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-un millions six
cent quarante-neuf mille deux Francs suisse (CHF 31,649,002,-), représenté par trente mille quatre cent deux (30.402)
parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe A,
trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe B, trois millions cent soixan-
te-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe C, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent
soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860)
parts sociales de classe E, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe
F, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe G, trois millions cent
soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe H, trois millions cent soixante-et-un mille huit
cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe I, et trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860)
parts sociales de classe J, d'une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1,-) chacune,
à quinze million huit cent trente neuf mille sept cent deux Francs suisse (CHF 15,839,702), représenté par trente mille
quatre cent deux (30.402) parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860)
parts sociales de classe A, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe
B, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe C, trois millions cent
31521
L
U X E M B O U R G
soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions cent soixante-et-un mille huit
cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe E, d'une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1,-) chacune,
par le rachat et l’annulation des parts sociales de class J, ayant la valeur de trois million cent soixante-et-un mille huit
cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class I, ayant la valeur de trois million cent soixante-
et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class H, ayant la valeur de trois million
cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class G, ayant la valeur
de trois million cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class F,
ayant la valeur de trois million cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860).
2. Modification de l’article 5.1 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée au point 1.
3. Modification de l’article 5.4 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée au point 1.
4. Modification de l’article 15.3 des Statuts afin de refléter la réduction du capital social adoptée au point 1.
5. Divers
- Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolution:i>
L’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de quinze million huit cent neuf mille trois
cents Francs suisse (CHF 15,809,300), afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de trente-et-
un millions six cent quarante-neuf mille deux Francs suisse (CHF 31,649,002,-), représenté par trente mille quatre cent
deux (30.402) parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales
de classe A, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe B, trois millions
cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe C, trois millions cent soixante-et-un mille
huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante
(3.161.860) parts sociales de classe E, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales
de classe F, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe G, trois millions
cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe H, trois millions cent soixante-et-un mille
huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe I, et trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante
(3.161.860) parts sociales de classe J, d'une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1,-) chacune,
à quinze million huit cent trente neuf mille sept cent deux Francs suisse (CHF 15,839,702), représenté par trente mille
quatre cent deux (30.402) parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860)
parts sociales de classe A, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe
B, trois millions cent soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe C, trois millions cent
soixante-et-un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions cent soixante-et-un mille huit
cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe E, d'une valeur nominale d'un Franc suisse (CHF 1,-) chacune,
par le rachat et l’annulation des parts sociales de class J, ayant la valeur de trois million cent soixante-et-un mille huit
cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class I, ayant la valeur de trois million cent soixante-
et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class H, ayant la valeur de trois million
cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class G, ayant la valeur
de trois million cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860), des parts sociales de class F,
ayant la valeur de trois million cent soixante-et-un mille huit cent soixante Francs suisse (CHF 3.161.860).
L'Assemblée décide d'enregistrer que suite à la réduction de capital, l’actionnariat de la Société se compose comme
suit:
Partners Group Skylab Access, L.P. Inc.:
(15.201) parts sociales ordinaires
(1,580,930) parts sociales de classe A
(1,580,930) parts sociales de classe B
(1,580,930) parts sociales de classe C
(1,580,930) parts sociales de classe D
(1,580,930) parts sociales de classe E
Rockspring Transeuropean Properties V Swiss 1 S.à r.l.:
(15.201) parts sociales ordinaires
(1,580,930) parts sociales de classe A
(1,580,930) parts sociales de classe B
(1,580,930) parts sociales de classe C
(1,580,930) parts sociales de classe D
(1,580,930) parts sociales de classe E
31522
L
U X E M B O U R G
<i>Deuxième résolution:i>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« 5.1. Le capital social est fixé à quinze million huit cent trente-neuf mille sept cent deux Francs suisse (CHF 15,839,702),
représenté par trente mille quatre cent deux (30.402) parts sociales ordinaires, trois millions cent soixante et un mille
huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe A, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante
(3.161.860) parts sociales de classe B, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales
de classe C, trois millions cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe D, trois millions
cent soixante et un mille huit cent soixante (3.161.860) parts sociales de classe E, d'une valeur nominale d'un Franc suisse
(CHF 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»
<i>Troisième résolution:i>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.4 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« 5.4. Le capital social peut être augmenté ou réduit une ou plusieurs fois, par une résolution de l’Assemblée Générale
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Sous réserve de toujours se conformer à la loi applicable, le capital social de la Société peut à tout moment être réduit
par le rachat et l’annulation d'une classe entière de parts sociales via le rachat et l’annulation de toutes les parts sociales
en circulation dans cette classe, à condition que l’ordre de rachat décrit ci-dessous soit respecté. Tout rachat se fera à
l’initiative de la Société. L(es) associé(s) n'ont pas le droit de forcer un rachat de leurs parts sociales.
Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l’annulation d'une classe de parts sociales, cette classe
donne droit à leurs détenteurs, pro rata de leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (dans la limite du
Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l’Assemblée Générale) et les détenteurs de parts sociales de la classe
rachetée et annulée recevra de la Société un montant correspondant à la «Valeur d'Annulation Par Part Sociale» pour
chaque part sociale de la classe appropriée qu'ils détiennent et annulée, cette Valeur d'Annulation Par Part Sociale étant
calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales en circulation dans la classe à racheter
et annuler.
Les rachats mentionnés ci-dessus se feront dans l’ordre de priorité suivant:
(i) aucune part sociale de classe A ne peut être rachetée si la Société détient encore des parts sociales de classe B au
moment du rachat; lorsque les parts sociales de classe A seront rachetées, la Société sera dissoute et liquidée dans le
même temps;
(ii) aucune part sociale de classe B ne peut être rachetée si la Société détient encore des parts sociales de classe C au
moment du rachat;
(iii) aucune part sociale de classe C ne peut être rachetée si la Société détient encore des parts sociales de classe D
au moment du rachat;
(iv) aucune part sociale de classe D ne peut être rachetée si la Société détient encore des parts sociales de classe E
au moment du rachat;
Ce qui précède n'empêche aucune autre forme de réduction de capital ou toute autre forme de distribution.»
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence de la première résolution, l’Assemblée décide de modifier l’article 15.3 des Statuts qui aura désormais
la teneur suivante:
« 15.3. L'Associé unique ou, selon le cas, l’Assemblée Générale déterminera si tout ou partie des bénéfices nets restants
sera distribué(e). Des dividendes peuvent être distribués à l’associé unique ou, selon le cas, à l’Assemblée Générale au
pro rata du montant des parts sociales que chaque Associé détient dans chaque classe de part sociale de la Société, aux
conditions suivantes:
(a) les parts sociales de classe A donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe A le droit de percevoir
des distributions de dividendes lors de l’année concernée à hauteur de 0,10% de la valeur nominale des parts sociales de
classe A détenues;
(b) les parts sociales de classe B donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe B le droit de percevoir
des distributions de dividendes lors de l’année concernée à hauteur de 0,15% de la valeur nominale des parts sociales de
classe B détenues;
(c) les parts sociales de classe C donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe C le droit de percevoir
des distributions de dividendes lors de l’année concernée à hauteur de 0,20% de la valeur nominale des parts sociales de
classe C détenues;
(d) les parts sociales de classe D donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe D le droit de percevoir
des distributions de dividendes lors de l’année concernée à hauteur de 0,25% de la valeur nominale des parts sociales de
classe D détenues;
31523
L
U X E M B O U R G
(e) les parts sociales de classe E donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe E le droit de percevoir
des distributions de dividendes lors de l’année concernée à hauteur de 0,30% de la valeur nominale des parts sociales de
classe E détenues; et
(f) les parts sociales de classe E donnent aux Associés détenant des parts sociales de classe E le droit de percevoir le
restant de toute distribution de dividendes.»
<i>Cinquième résolution:i>
L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
avec pouvoir et autorité à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder au nom de la Société à
l’enregistrement des parts sociales annulées dans le registre des associés de la Société.
<i>Fraisi>
Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui
incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de la réduction de capital à environ six mille Euros (EUR
6.000.-).
Le notaire soussigné, qui a personnellement connaissance de la langue anglaise, déclare que les mandataires des parties
comparantes l’ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, ceux-ci ont signé le présent
acte avec le notaire.
Signé: W. Fitzgerald et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 08 janvier 2015. 2LAC/2015/618. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015018441/398.
(150021428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Aots S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 194.132.
STATUTES
In the year two thousand fifteen, on the fifteenth of January.
Before the undersigned, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorfles-Bains, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Mr. Abdul Khader Mohamed Ismail, residing at 15 Kings Ride Penn, High Wycombe, HP10 88J Buckinghamshire, United
Kingdom,
here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given in London, on January 13, 2015,
Mr. Nadeem Akhtar residing at 137 Telford Way, High Wycombe, Buckinghamshire HP 13 5SZ, United Kingdom
here represented by Mr Frank Stolz-Page, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxem-
bourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given in London, on January 13, 2015.
Such powers of attorney, after having been signed ne varietur by the representative of the appearing parties and the
undersigned notary, will remain annexed to this deed for the purpose of registration.
The appearing parties, represented as above, have requested the undersigned notary, to state as follows, the articles
of incorporation of a public company limited by shares (société anonyme), which is hereby incorporated:
Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is AOTS S.A. (the Company). The Company is a public company limited by
shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10,
1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).
31524
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of directors (the Board). It may be transferred to any other location
in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting
in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have
occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company
at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may
be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such tem-
porary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its
registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company’s object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any company or enterprise
in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by sub-
scription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents or other
intellectual property rights of any nature or origin.
3.2. The Company may borrow in any form. It may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It
may lend funds, including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and
any other companies. It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security
over some or all of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own
benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any
regulated financial sector activities without having obtained the requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property, which directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty-one thousand euros (EUR 31,000), represented by thirty-one thousand (31,000)
registered shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the General Meeting, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
6.3. A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.
6.4. A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed
and dated by either:
(i) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
(ii) any authorised representative of the Company, following a notification to, or acceptance by, the Company, in
accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.5. Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both
parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.
6.6. The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.
III. Management - Representation
Art. 7. Board of directors.
7.1. Composition of the board of directors
31525
L
U X E M B O U R G
(i) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need
not be shareholders.
(ii) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of
their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment
at the expiry of their term of office. The General Meeting may decide to appoint one or several class A directors and
one or several class B directors.
(iii) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.
(iv) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The
permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions
in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it
represents.
(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint
another permanent representative.
(vi) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on
a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.
7.2. Powers of the board of directors
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this
respect, to one or more directors, officers, managers or other agents, whether shareholders or not, acting either indi-
vidually or jointly. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the
annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial
year.
7.3. Procedure
(i) The Board must appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a
director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.
(ii) The Board shall meet at the request of the chairperson or any two (2) directors, at the place indicated in the notice,
which in principle shall be in Luxembourg.
(iii) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(v) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(vi) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
Resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented, provided that if
the General Meeting has appointed one or several class A directors and one or several class B directors, at least one (1)
class A director and one (1) class B director votes in favour of the resolution. The chairman shall have a casting vote in
the event of a tied vote, except if the Board is composed of one or several class A directors and one or several class B
directors. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson, by all the directors present or
represented at the meeting, or by the secretary (if any).
(vii) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other
means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other.
Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(viii) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held
Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
(ix) A director who has an interest in a transaction carried out other than in the ordinary course of business which
conflicts with the interests of the Company must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the
minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A
special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any
vote on any other resolution.
7.4. Representation
The Company shall be bound towards third parties in all matters by:
(i) the signature of the sole director;
31526
L
U X E M B O U R G
(ii) the joint signature of any two (2) directors, if there is a Board and the shareholders have not appointed different
classes of directors; or
(iii) the joint signature of any class A director and any class B director, if there is a Board and the shareholders have
appointed different classes of directors, namely class A and class B directors.
(iv) the Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom
special signatory powers have been delegated by the Board.
Art. 8. Sole director.
8.1. Where the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the Company may be managed by a single director until the General Meeting following the introduction of an
additional shareholder; and
(ii) any reference in the Articles to the Board, the directors, some directors or any director should be read as a
reference to that sole director, as appropriate.
8.2. Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded
in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.
Art. 9. Liability of the directors. The directors may not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the Company’s name, provided those commitments comply with the Articles and
the Law.
IV. Shareholders
Art. 10. General meetings of shareholders.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company’s
corporate object.
(ii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting proceedings
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the statutory auditor(s). The Shareholders
must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing more than one-tenth (1/10)
of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(v) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vi) Any shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.
(vii) Any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must
contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form
must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return
the voting forms to the Company’s registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be
taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor
an abstention shall be considered void.
(viii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the
proportion of share capital represented.
(ix) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented
and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to
the Company’s object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened by means of
notices published twice in the Mémorial and two Luxembourg newspapers, at an interval of at least fifteen (15) days and
fifteen (15) days before the meeting. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting and the results
of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of
capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds of the votes cast.
(x) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder’s commitment in the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders and bondholders (if any).
31527
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(i) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(ii) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole
shareholder, as appropriate; and
(iii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 12. Financial year and approval of annual accounts.
12.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
12.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory
stating the value of the Company’s assets and liabilities, with an annex summarising the Company’s commitments and the
debts owed by the officers, directors and statutory auditors to the Company.
12.3. One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the statutory auditors with a report on,
and documentary evidence of, the Company’s operations. The statutory auditors shall then prepare a report setting out
their proposals.
12.4. The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the municipality of
the registered office, as specified in the notice, on the second Monday of May of each year at 10.00 a.m.. If that day is not
a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.
Art. 13. Auditors.
13.1. The Company’s operations shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaires).
13.2. When so required by law, the Company’s operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d’entreprises agréés).
13.3. The General Meeting shall appoint the statutory auditors (commissaires)/ approved external auditors (réviseurs
d’entreprises agréés), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of
the statutory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.
Art. 14. Allocation of profits.
14.1. Five per cent (5%) of the Company’s annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
14.2. The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. It may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
14.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) the statutory auditors (commissaires) or the approved external auditors (réviseurs d’entreprises agréés), as ap-
plicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with
the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators,
who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration.
Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company’s assets
and pay its liabilities.
15.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provision
16.1. Notices and communications may be made or waived and circular resolutions may be evidenced in writing, by
fax, e-mail or any other means of electronic communication.
16.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
31528
L
U X E M B O U R G
16.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video
conference may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall
constitute one and the same document.
16.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any nonwaivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company’s first financial year shall begin on the date of this deed and end on the thirty-first (31) of December
2015.
<i>Subscription and paymenti>
The Articles having thus been established, the appearing parties, represented as stated above, declare to subscribe to
the entire capital as follows:
- Mr Abdul Khader Mohamed Ismail prenamed, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,999 shares
- Mr Nadeem Akhtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 share
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,000 shares
The amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31,000) is at the Company’s disposal and evidence of such amount
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately one thousand four hundred euros (EUR 1,400).
<i>Resolutions of the shareholdersi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed share
capital, adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as directors of the Company for a period of six (6) years:
(i) Abdul Khader Mohamed Ismail, born on 22 September 1961, in Nagaipattinam, India, residing at 15 Kings Ride Penn,
High Wycombe, HP10 88J Buckinghamshire United Kingdom.
(ii) Neil McLoughlin, born on 19 December 1955, in Enniskillen, Northern Ireland, residing at Flat 6T4-1903, 392
MARSA DUBAI.
(iii) Nadeem Akhtar, born on 31 August 1972 in Jhelum, Pakistan residing at 137 Telford Way, High Wycombe, Buc-
kinghamshire HP 13 5SZ United Kingdom.
2. Viscomte S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws
of Luxembourg, with registered office at 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, registered with the Register of
Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under the number B 164.981, is appointed as statutory auditor (com-
missaire) of the Company for a period of six (6) years.
3. The registered office of the Company is located at 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences, the English text prevails.
WHEREOF this deed is drawn up at the office of the undersigned notary, on the day stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representative of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le quinze janvier,
par devant Nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg.
ONT COMPARU:
Mr Abdul Khader Mohamed Ismail, résident au 15 Kings Ride Penn, High Wycombe, HP10 88J Buckinghamshire,
Royaume-Uni,
représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Lu-
xembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 13 janvier 2015,
Mr. Nadeem Akhtar, résident au 137 Telford Way, High Wycombe, Buckinghamshire HP 13 5SZ, Royaume-Uni,
31529
L
U X E M B O U R G
représenté par Monsieur Frank Stolz-Page, avec adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Lu-
xembourg,
en vertu d'une procuration sous seing privé donnée à Londres, le 13 janvier 2015.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante, les statuts d'une société anonyme qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "AOTS S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie
par le droit du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales,
telle que modifiée (La Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. II peut être transféré dans la
commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit
du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée générale),
selon les modalités requises pour La modification des Statuts.
2.2. II peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à
compromettre les activités normales de la Société a son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et
l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances.
Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son
siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers
émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle
de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de brevets ou
d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre,
d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment,
les revenus de tous emprunts, a ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'a toutes autres sociétés. La Société peut également
consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou
partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa
faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité
réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et a sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité,
de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant un ou plusieurs Actionnaires.
II. Capital - Actions
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et un mille (31.000) actions
sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune.
5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée
générale, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
31530
L
U X E M B O U R G
Art. 6. Actions.
6.1. Les actions de la Société sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action.
6.2. Les Actions sont et resteront sous forme nominative.
6.3. Un registre des Actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.
6.4. Une cession d'action(s) s'opère par la mention sur le registre des Actions, d’une déclaration de transfert, vala-
blement datée et signée soit:
(i) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires;
(ii) par les représentants de la Société, et suivant une notification à, ou une acceptation par, la Société, conformément
à l'article 1690 du Code Civil.
6.5. La Société peut également accepter comme preuve du transfert d'actions, d'autres documents établissant l'accord
du cédant et du cessionnaire.
6.6. La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la Loi.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil d'administration.
7.1. Composition du conseil d'administration
(i) La Société est gérée par un conseil d'administration (le Conseil) composé d'au moins trois (3) membres, qui ne
doivent pas nécessairement être actionnaires.
(ii) L'Assemblée générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de
leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles. L’Assemblée générale
peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B.
(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée générale.
(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent
qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux
mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s’il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre
compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de La personne morale qu'il représente.
(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer
immédiatement un autre représentant permanent.
(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoi-
rement jusqu'à la nomination définitive qui a lieu lors de la prochaine Assemblée générale.
7.2 Pouvoirs du conseil d'administration
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts a ou aux actionnaires sont de La compétence
du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Des pouvoirs spéciaux et limites peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches
spécifiques.
(iii) Le Conseil peut déléguer La gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette
gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou
conjointement. Si la gestion journalière est déléguée a un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à
l'Assemblée générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) adminis-
trateur(s) pendant l'exercice social en cause.
7.3. Procédure
(i) le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être administrateur,
et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.
(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de con-
vocation, qui en principe, est au Luxembourg.
(iii) II est donne à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre
(24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iv) Aucune convocation n’est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent
avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur peut également renoncer à la
convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas
exigées pour des réunions se tenant à des heures et dans des lieux fixes dans un calendrier préalablement adopté par le
Conseil.
(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion
du Conseil.
(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés,
31531
L
U X E M B O U R G
à condition que si l'Assemblée générale a nommé un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs admi-
nistrateurs de classe B, au moins un administrateur de classe A et un administrateur de classe B vote en de la décision..
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix, sauf dans le cas où le Conseil est composé d’un ou
plusieurs administrateurs A et d’un ou plusieurs administrateurs de classe B. Les décisions du Conseil sont consignées
dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentes à la réunion ou
par le secrétaire (s'il en existe un).
(vii) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout
autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'en-
tendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion
valablement convoquée et tenue.
(viii) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs sont valables et engagent la Société comme si
elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière
signature.
(ix) Tout administrateur qui a un intérêt oppose à celui de la Société dans une transaction qui ne concerne pas des
opérations courantes conclues dans des conditions normales, est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner
cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un
rapport spécial relatif a ou aux transactions concernées est soumis aux actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine
Assemblée générale.
7.4. Représentation
La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par:
(i) par la signature de l'administrateur unique;
(ii) par la signature conjointe de deux administrateurs, si il existe un Conseil d’administration et que les actionnaires
n’ont pas nommé des administrateurs de classes différentes;
(iii) par la signature conjointe de tout administrateur de classe A et tout administrateur de classe B, si il existe un
Conseil d’administration et que les actionnaires ont nommés plusieurs classes d’administrateurs, appelés administrateurs
de classe A et classe B.
(iv) la Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toutes personnes à qui
des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil d’administration.
Art. 8. Administrateur unique.
8.1. Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1):
(i) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivant l'introduction
d'un actionnaire supplémentaire; et
(ii) dans ce cas, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux administrateurs doit être considérée, le cas échéant,
comme une référence à cet administrateur unique.
8.2 Les transactions conclues par la Société peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux et, sauf si elles con-
cernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales, doivent être ainsi mentionnées si elles sont
intervenues avec son administrateur unique ayant un intérêt opposé.
Art. 9. Responsabilité des administrateurs.
9.1.Les administrateurs ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les enga-
gements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts
et à la Loi.
IV. Actionnaire(s)
Art. 10. Assemblée générale des actionnaires.
10.1.Pouvoirs et droits de vote
(i) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors des assemblées générales des actionnaires (l'Assemblée géné-
rale). L'Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes
à l'objet social.
(ii) Chaque action donne droit à un (1) vote.
10.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les actionnaires peuvent être convoqués à l'Assemblée générale par le Conseil d’administration ou de l'auditeur.
Les actionnaires doivent être à l'Assemblée générale suite à la demande d’actionnaires représentant plus de un dixième
(1/10) du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées
dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.
31532
L
U X E M B O U R G
(iv) Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoques
et informes de l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Assemblée générale peut se tenir sans convocation préalable.
(v) Un actionnaire peut donner une procuration écrite a toute autre personne (qui ne doit pas être un actionnaire)
afin de le représenter à toute Assemblée générale.
(vi) Tout actionnaire peut participer à toute Assemblée générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre
moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de
s'entendre et de se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion.
(vii) Tout actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote fournis par la Société. Les formulaires de vote
indiquent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que, pour chaque
résolution, trois cases permettant de voter en faveur, de voter contre ou de s'abstenir. Les formulaires de vote doivent
être renvoyés par les actionnaires au siège social. Pour le calcul du quorum, il n’est tenu compte que des formulaires de
vote reçus par la Société avant La réunion de l'Assemblée générale. Les formulaires de vote dans lesquels ne sont men-
tionnés ni un vote (en faveur ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.
(viii) Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées a la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la
proportion du capital social représenté.
(ix) L'Assemblée générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est
représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de celles qui modifient
l'objet social ou La forme de la Société. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée générale peut être
convoquée par annonces insérées deux fois, quinze (15) jours d'intervalle au moins et quinze (15) jours avant l'assemblée,
dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Ces convocations reproduisent l'ordre du jour de la réunion
et indiquent la date et les résultats de la précédente réunion. La seconde Assemblée générale délibère valablement quelle
que soit la proportion du capital représenté. Dans les deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées
par au moins les deux tiers des voix exprimées.
(x) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un actionnaire dans
La Société exige le consentement unanime des actionnaires et des obligataires (s'il y a lieu).
Art. 11. Actionnaire unique.
11.1 Lorsque le nombre des actionnaires est réduit a un (1):
(i) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée générale.
(ii) toute référence dans les Statuts à l'Assemblée générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence
à cet actionnaire unique.
(iii) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 12. Exercice social et approbation des comptes annuels.
12.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un décembre (31) de chaque année.
12.2 Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur
des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de La Société ainsi que les dettes des
directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.
12.3 Un mois avant l'Assemblée générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de
la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.
12.4 L'Assemblée générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu dans la municipalité du
siège social, comme indiqué dans la convocation, le deuxième lundi du mois de mai de chaque année à 10 heures. Si ce
jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée générale annuelle se tient le jour ouvrable suivant.
Art. 13. Commissaires /Réviseurs d'entreprises.
13.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.
13.2 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, quand cela est requis
par la loi.
13.3 L'Assemblée générale nomme les commissaires/reviseurs d'entreprises et détermine leur nombre, leur rémuné-
ration et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les commissaires/reviseurs d'entreprises peuvent
être réélus.
Art. 14. Dividende - Réserves.
14.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d’être exigée quand la Réserve Légale atteint un montant égal dix pour cent (10
%) du capital social.
31533
L
U X E M B O U R G
14.2. L’Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice
au paiement d’un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales appli-
cables.
14.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(v) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
(vi) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d’émission)
suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant
des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant,
augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter
à la réserve légale ou statutaire;
(vii) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la
date des comptes intérimaires; et
(viii) les commissaires ou les réviseurs d’entreprises agréés, selon le cas, doivent préparer un rapport adressé au
Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.
VI. Dissolution - Liquidation
15.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts. L’Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont
pas besoin d’être des actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf
décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
actifs et payer les dettes de la Société.
15.2. Le boni de liquidation, s’il y en a un, résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes, est distribué
aux actionnaires proportionnellement aux actions détenues par chacun d’entre eux.
VII. Dispositions générales
16.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, sont faites, et les résolutions circu-
laires sont établies par écrit, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
16.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du
Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
16.3 Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques
remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les
signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être appo-
sées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.
16.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légale d’ordre public, à tout accord présent ou futur conclu par les actionnaires.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les trente et un mille (31.000) actions sont souscrites comme suit:
Mr. Abdul Khader Mohamed Ismail,
prénommé, déclare souscrire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.999 actions
Mr. Nadeem Akhtar,
prénommé, déclare souscrire à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 action
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 actions
Le montant de trente et un mille Euros (EUR 31.000) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire
instrumentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à mille quatre cents euros (EUR 1.400).
<i>Résolutions des actionnairesi>
Immédiatement après la constitution de la Société, les actionnaires de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, ont adopté les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de six (6) ans:
(i) Abdul Khader Mohamed Ismail, né le 22 septembre 1961, à Nagaipattinam, Inde, resident au 15 Kings Ride Penn,
High Wycombe, HP10 88J Buckinghamshire, Royaume-Uni.
31534
L
U X E M B O U R G
(ii) Neil McLoughlin, né le 19 décembre 1955, à Enniskillen, Irelande du Nord, resident au Flat 6T4-1903, 392 MARSA,
DUBAI.
(iii) Nadeem Akhtar, né le 31 août 1972 à Jhelum, Pakistan resident au 137 Telford Way, High Wycombe, Buckin-
ghamshire HP 13 5SZ, Royaume-Uni.
2. Viscomte S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Luxembourg, ayant son siège
social au 15, rue Edward Steichen L-2540 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 164.981, est nommé en qualité de commissaire de la Société pour une
durée de six (6) ans.
3. Le siège social de la Société est établi au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte
français, la version anglaise fait foi.
DONT ACTE, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé avec le notaire instru-
mentant, le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 19 janvier 2015. GAC/2015/596. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015017901/595.
(150021528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Charitable Luxembourg One Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 119.345.
Par résolutions prises en date du 31 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Choui Min Kon Kam King, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, au mandat de gérant, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015016992/15.
(150020278) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
CPI Digiplex S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 135.891.
<i>Extrait du conseil de gérance du 30 décembre 2014i>
Le Conseil de Gérance a décidé d'accepter la démission de Monsieur Joseph Winandy comme gérant de catégorie B
de la société avec effet immédiat et nomme comme gérant B de la société pour une durée illimitée:
Jean-Charles Thouand
Né le 25 août 1971 à Metz (France)
Demeurant 183, rue de Luxembourg à L-8077 Bertrange
Pour copie conforme
Signature
Référence de publication: 2015017044/16.
(150020669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
31535
L
U X E M B O U R G
Apollo Emerging Markets Absolute Return Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.000,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 185.848.
Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015017867/15.
(150021625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
BSA Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-5943 Itzig, 1, rue J.P.Lanter.
R.C.S. Luxembourg B 191.685.
L'an deux mille quinze, le vingt-huit janvier.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu:
Madame Catherine SACRÉ, employée, née le 4 octobre 1980 à Liège, Belgique, demeurant à 21, rue de l’Institut Molitor,
B-6717 Attert;
ici représentée par Monsieur Marc VAN HOEK, expert-comptable, en vertu d’une procuration sous seing privée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la comparante et le notaire instru-
mentaire, restera annexée aux présentes pour être formalisée avec elle.
Laquelle comparante a déclaré être l’associé unique de la société à responsabilité limitée "BSA Consulting S.à r.l.", ayant
son siège social à L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentaire,
notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 3675 du 2 décembre 2014. Les statuts n’ont pas été modifiés depuis.
Le capital social est fixé à douze mille quatre cents euros (EUR 12.400.-), représenté par cent vingt-quatre (124) parts
sociales d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune, entièrement libérées et souscrites.
<i>Première et unique résolutioni>
L’assemblée générale décide de transférer, le siège social de la société de 20, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg à
1, rue J.P.Lanter, L-5943 Itzig et de modifier en conséquence l’article 4 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 4. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Hesperange.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger par décision de l’assemblée
générale des associés.»
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire par nom, prénom usuel, état et
demeure, celle-ci a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: M. Van Hoek et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 29 janvier 2015. 2LAC/2015/2151. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveuri> (signé): Paul Molling.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015017961/37.
(150021661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
31536
2R-Invest S.A.
Antica Bari
Aots S.A.
Apollo Emerging Markets Absolute Return Holdings (Lux) S.à r.l.
Bicocca S.à r.l.
BSA Consulting S.à r.l.
Câblinvest S.à r.l.
Cépages Participations S.A.
CETP UC4 S.à r.l.
CFFI Holdings S. à r.l.
Charitable Luxembourg Four S.à r.l.
Charitable Luxembourg One Sàrl
Charitable Luxembourg Three S.à r.l.
Château de Beggen Participations S.A.
CHC Helicopter (1) S.à r.l.
CHC Helicopter LLC
Cogesor S.A.
CPI Digiplex S.à r.l.
Damasca S.A.
Delarue S.A.
Der Garten S. à r.l.
DJ Manhattan Luxco S.à r.l.
DM Direct Service S.A.
Dorado Investment S.A.
Eleanore Luxembourg II S.à r.l.
Emcedeux S.A.
EMG Baffin Holdings Lux S.à r.l.
Emile Gestion S.A.
Energreen Investment Europe S.A.
FCA Sport S.A.
Fides Holdings S.A.
Fincorp Participations S.A.
Fineural International S.A.
Haynesborough Corporation S.à r.l.
Lux Gestion Tresorerie S.A.
Neomed S.P.F. SA
Notrine S.A.
Pro S.A.
Quay Street Manchester Real Estate S.à r.l.
Rockspring TransEuropean Properties V Swiss S.à r.l.
Saint Eugène SA
Saint-Michel Invest S.à r.l.
Shanila Investments S.à r.l.
SO.GE.FER (Luxembourg) S.A.
Tiago Second Frankfurt Properties Limited S.à r.l.
Zunis S.A.