logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 656

10 mars 2015

SOMMAIRE

Abaltex Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31443

Alego S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31448

Apollo TR Emerging Markets Holdings

(Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31443

Arcania S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31450

BGV III Feeder 3 SICAV-FIS  . . . . . . . . . . . .

31442

Bliss  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31452

Cassona Aviation Holding S.A.  . . . . . . . . . .

31451

Cleansecure S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31472

CO2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31487

CONREN Fortune  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31451

Cyralex SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31451

Digital Services XXXIX S.à r.l.  . . . . . . . . . .

31476

Global Négoce Solutions . . . . . . . . . . . . . . . .

31460

Grano S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31454

Halter Ego S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31457

Human Capital Group S.A.  . . . . . . . . . . . . .

31444

Kingberg Immobilière S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

31449

Koonunga Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

31450

Lunasun S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31442

LVO S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31442

Magnum Capital II (SCA) SICAR  . . . . . . . .

31462

Meca-Concept SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31447

Mining Holding Group S.A. . . . . . . . . . . . . . .

31447

Mitteldeutsche Siedlung 2 S.à r.l.  . . . . . . . .

31446

Natitri S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31448

NjordCap Investment (Luxembourg) S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31450

OCM Luxembourg French Leisure SV  . . .

31445

Orion Investment Partners IV Luxem-

bourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31446

Orion IV European 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

31446

PF Prism S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31473

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s. . . . . . .

31443

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s. . . . . . .

31443

Pratzen S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31447

Prominvest S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31444

Property Augsburg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

31455

RisenSky Solar Energy S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

31444

RP Oder S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31449

Scoubidou S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31445

Silver Sea Properties (Hailsham) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31449

Société d'Investissement et de Développe-

ment Economique Familial S.A.  . . . . . . . .

31445

Sumala S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31445

Tiago German Properties GmbH . . . . . . . .

31448

WHITE Investments  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31444

31441

L

U X E M B O U R G

Lunasun S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 78.750.

Claudia HERBER,
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
née le 6 Septembre 1965 à Irmenach (Allemagne),
démissionne par la présente, du mandat d'Administrateur de la société anonyme LUNASUN S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B78.750
Date effective: 30 janvier 2015

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Claudia HERBER.

Référence de publication: 2015018274/15.
(150021833) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

BGV III Feeder 3 SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-2553 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 138.022.

<i>Extrait du procès-verbal des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 5 janvier 2015

Le siège social a été transféré du 65, boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg au 6, rue Eugène

Ruppert, L-2453 Luxembourg, avec effet rétroactif au 1 

er

 janvier 2015.

Veuillez noter que le domicile professionnel de Mr. Marco BREHM se trouve désormais au 6 B, rue Gabriel Lippmann,

L-5365 Munsbach.

Veuillez noter que le domicile professionnel de Mr. Pietro LONGO se trouve désormais au 4 rue Adolphe, L-1116

Luxembourg.

Luxembourg.

Pour extrait et avis sincères et conformes
BGV III Feeder 3 SICAV-FIS
Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.

Référence de publication: 2015017948/19.
(150021316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

LVO S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 187.404.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 2 février 2015

1. M. Frank PLETSCH a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
3. M. Oliver THOMAS, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1983 à Geilenkirchen (Allemagne), demeurant pro-

fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, pour une durée indéter-
minée.

4. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, avec effet au 14 janvier
2015, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour LVO S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015018282/20.
(150021604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

31442

L

U X E M B O U R G

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 43.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 1997 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015019174/11.
(150022352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 43.491.

Les comptes annuels au 31 décembre 1994 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015019177/11.
(150022355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Apollo TR Emerging Markets Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 185.805.

Par résolutions prises en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Joanna Gosselin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Michael Robert Kidd, avec adresse professionnelle au 44, avenue J.F. Kennedy, L-1855

Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet au 31 décembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015017869/15.
(150021623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Abaltex Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 141.563.

<i>Extrait des décisions prises par l'administrateur unique au siège social en date du 3 février 2015

L'administrateur unique, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au

porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial A
no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
ABALTEX GROUP S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015017880/17.
(150022186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

31443

L

U X E M B O U R G

WHITE Investments, Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 129.826.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019343/9.
(150022281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

RisenSky Solar Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 7.820.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 162.076.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 février 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015019203/14.
(150022663) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Human Capital Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 30.107.

<i>Extrait du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 2 février 2015

<i>Première résolution

Afin de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au

porteur, le Conseil d'Administration décide de nommer HRT Fidalux S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 163, rue du Kiem, L-8030 Strassen, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous le numéro B 41178 en qualité de dépositaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Human Capital Group S.A.

Référence de publication: 2015018922/15.
(150022439) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Prominvest S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 183.187.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 4 février 2015.

<i>Pour: PROMINVEST SA SPF
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015019148/16.
(150022946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31444

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg French Leisure SV, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 174.521.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Junglinster, le 3 février 2015.

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015019101/11.
(150022633) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Sumala S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 49.364.

RECTIFICATIF

Dans la mention pour publication déposée le 4 février 2015, portant le numéro de dépôt L150022637, il y a lieu

d'ajouter que, suite la fin du contrat de domiciliation entre la société FIDUCENTER S.A. et SUMALA S.A. en liquidation,
le siège social de ladite société SUMALA S.A. en liquidation est dénoncé à la date du 2 février 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUCENTER S.A.
<i>Le domiciliataire

Référence de publication: 2015019283/13.
(150023036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Société d'Investissement et de Développement Economique Familial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 178.462.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue en date du 2 février 2015

- En date du 2 février 2015, la Société a désigné la société SGG S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro B-65906, ayant son siège social au 412F route d'Esch, L-2086 Luxembourg, comme
dépositaire au sens de l'article 2 de la loi du 28 juillet 2014 relative au dépôt obligatoire et à l'immobilisation des actions
et des parts au porteur.

Fait à Luxembourg, le 2 février 2015.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015019264/14.
(150022704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Scoubidou S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 183.162.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 4 février 2015.

<i>Pour: SCOUBIDOU SA SPF
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015019253/16.
(150022947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31445

L

U X E M B O U R G

Orion Investment Partners IV Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 160.708.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1 

er

 février 2015 et se

trouve désormais au:

- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Orion Investment Partners IV Luxembourg S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015019064/17.
(150022210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Orion IV European 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 660.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 160.707.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1 

er

 février 2015 et se

trouve désormais au:

- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Orion IV European 1 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015019065/17.
(150022209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Mitteldeutsche Siedlung 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.986.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 2 février 2015

1. M. Frank PLETSCH a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
3. M. Oliver THOMAS, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1983 à Geilenkirchen (Allemagne), demeurant pro-

fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, pour une durée indéter-
minée.

4. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, avec effet au 14 janvier
2015, pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 3 février 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Mitteldeutsche Siedlung 2 S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015018296/20.
(150021504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

31446

L

U X E M B O U R G

Mining Holding Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 37, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 153.677.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 26 janvier 2015

Le Conseil d'Administration accepte la démission de BPH FINANCE S.A., ayant son siège social 3, avenue Pasteur,

L-2311 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B-51.675 en tant que déléguée à la gestion journalière des affaires de la société.

<i>Pour la société
MINING HOLDING GROUP S.A.

Référence de publication: 2015018324/12.
(150021529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Pratzen S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 188.243.

<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 29/01/2015

La société Edmond de Rothschild Europe S.A. inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro B 19194, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais; L - 2535 Luxembourg a été nommée
comme dépositaire des actions au porteur.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un administrateur

Référence de publication: 2015018404/13.
(150021357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Meca-Concept SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3752 Rumelange, 2, rue Saint Sébastien.

R.C.S. Luxembourg B 86.093.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22/01/2015 à 15 h

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 22/01/2015, que l'assemblée générale a, à l'una-

nimité:

1. Accepté la démission de Madame Nadine CARELLE demeurant 4 rue du Fossé L-4123 ESCH-SUR-ALZETTE de son

poste de son poste de commissaire aux comptes.

2. Nommé Mr Jean GREFF, demeurant 141 rue Nationale F-57600 FORBACH, au poste de commissaire aux comptes

pour un mandat de six années. La date de l'expiration de son mandat prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra
en 2021.

3- Décidé de proroger les mandats des administrateurs, des administrateurs délégués, pour une durée de six aimées.

La date de l'expiration des mandats prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Il s'agit de reconduire, Mr Joseph TOSCANO, demeurant 37 Av Comte de Bertier F-57100 THIONVILLE, aux fonc-

tions d'administrateur et administrateur délégué jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

Il s'agit de reconduire Mr Laurent PARMENTIER, demeurant 1 Rue du Vieux Moulin F-57 535 MARANGE-SILVANGE

aux fonctions d'administrateur et d'administrateur délégué jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

Il s'agit de reconduire Melle Angèle TOSCANO, demeurant 16 Boucle des Châtaigniers F-57 330 SOETRICH à la

fonction d'administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2021.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/01/2015.

Mr Joseph TOSCANO / Mme C. SIMON / Mme Aurélie VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015018320/29.
(150021850) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

31447

L

U X E M B O U R G

Alego S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 22, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 150.437.

EXTRAIT

Il résulte d'une décision de l'administrateur unique de la Société datée du 27 janvier 2015 que Maître Philippe Morales,

avocat demeurant au 22 avenue de la Liberté - L-1930 Luxembourg a été nommé dépositaire agréé des titres au porteur
de la Société, conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015016893/15.
(150020073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Natitri S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 158.248.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Associés de la société qui s'est tenue en date du 31 décembre

<i>2014 à Luxembourg.

L'Assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société NATITRI S.à r.l., qui cessera d'exister, L'Assemblée

décide que les livres et documents de la société resteront déposés pendant 5 années au 50, route d'Esch, L-1470 Lu-
xembourg.

Extrait certifié conforme
Soparfi Capital S.A.
Signatures
<i>Le Liquidateur

Référence de publication: 2015018338/18.
(150021378) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Tiago German Properties GmbH, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.

R.C.S. Luxembourg B 176.719.

<i>Résolutions prises par l'assemblée générale des associés avec effet du 1 

<i>er

<i> janvier 2015

Avec effet du 1 

er

 janvier 2015, les associés ont adopté les résolutions suivantes à l'unanimité:

1. Approbation de la démission Mr. Kemal Akyel comme gérant de la société avec effet du 1 

er

 janvier 2015.

2. Nomination de M. Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, dont l'adresse professionnelle est 12, rue

Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérant de la société, avec effet du 1 

er

 janvier 2015 pour une durée

indéterminée.

3. Nomination de Mme. Elena Hadjifyntani, née le 2 octobre 1974 à Odessa, Ukraine, dont l'adresse professionnelle

est 12, rue Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérante de la société, avec effet du 1 

er

 janvier 2015 pour

une durée indéterminée.

4. Transfert du siège social de la société au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, avec effet immédiat.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015019289/20.
(150022313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31448

L

U X E M B O U R G

RP Oder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 124.712.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue extraordinairement le 3 décembre 2014 à 11h30

L'Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement accepte la démission de Monsieur Christ DE MESTRE,

Gérant A, et décide de nommer en remplacement comme gérant A pour une durée illimitée:

Monsieur Shaun Collins, né le 23 mai 1968 à Hinckley (Royaume-Uni)
25, St. George Street, Londres W1S 1FS (Royaume-Uni)

Pour copie conforme

Référence de publication: 2015019219/14.
(150022276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Kingberg Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 37.972.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2014 que, le professionnel du

secteur financier, la société INTERCORP S.A., 23, rue Beaumont, -1219 Luxembourg, a été nommée dépositaire des
titres au porteur émis par la société.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2015017360/15.
(150020714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Silver Sea Properties (Hailsham) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 92.470,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 161.173.

Par résolutions signées en date du 30 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Gérald Welvaert, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

au mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

2. Nomination de Michaël Watrin, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

3. Nomination de Robert Strietzel, avec adresse professionnelle au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, au

mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;

4. Acceptation de la démission de Matthew Rosenberg, avec adresse professionnelle au 29, Great Guildford Street,

SE1 0ES Londres, Royaume-Uni de son mandat de gérant de classe A, avec effet immédiat;

5. Acceptation de la démission de Sébastien Comin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

6. Acceptation de la démission de Catherine Baudhuin, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant de classe B, avec effet immédiat;

7. Transférer le siège social de la Société du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 46A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 février 2015.

Référence de publication: 2015019232/25.
(150022217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

31449

L

U X E M B O U R G

Koonunga Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 23, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 69.502.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 décembre 2014 que, le professionnel du

secteur financier, la société INTERCORP S.A., 23, rue Beaumont, -1219 Luxembourg, a été nommée dépositaire des
titres au porteur émis par la société.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME
<i>POUR LE D'ADMINISTRATION
Signature

Référence de publication: 2015017363/15.
(150020716) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Arcania S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 83.128.

<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015

Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts

au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
ARCANIA S.A.
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015017905/17.
(150022200) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

NjordCap Investment (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.200,00.

R.C.S. Luxembourg B 179.795.

Conformément à l'article 3 (1) de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, Intertrust (Luxembourg)

S.à r.l. informe de la résiliation unilatérale de la convention de domiciliation conclue le 13 décembre 2013 pour une durée
indéterminée entre les deux sociétés:

<i>Société domiciliée:

- NjordCap Investment (Luxembourg) S.A.
- Immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B179.795
- Dont le siège social sis au 13-15, avenue de !a Liberté, L-1931 Luxembourg fait l'objet de la présente résiliation

unilatérale

<i>Agent domiciliataire:

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
et ce avec effet au 23 janvier 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015017487/22.
(150020320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

31450

L

U X E M B O U R G

CONREN Fortune, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 79.471.

<i>Beschluss

Der Verwaltungsrat der CONREN Fortune, SICAV fasst gemäß Artikel 18 der Statuten des Fonds im schriftlichen

Verfahren folgenden Beschluß:

Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt von Herrn Max von Frantzius von seiner Funktion als Mitglied des Verwal-

tungsrates mit Wirkung vom 10. September 2014 zur Kenntnis.

Als  neues  Verwaltungsratsmitglied  wird  mit  Wirkung  zum  10.  September  2014  Herr  Stephan  Rudolph,  beruflich

wohnhaft in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, vorbehaltlich der Genehmigung der CSSF, bestellt.

Diese Bestellung ist durch die nächste Generalversammlung der Aktionäre zu bestätigen.

Luxemburg, den 10. September 2014.

Andreas Lesniewicz / Marco Schmitz.

Référence de publication: 2015018013/16.
(150021549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Cassona Aviation Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 129, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 169.374.

<i>Beschluss der Gesellschafterversammlung der Cassona SE (Muttergesellschaft) 16.12.2014

Die Gesellschafterversammlung der Cassona SE beschließt das folgende:

<i>Verwaltungsratsmitglied(er)/Geschäftsführer

Thomas Baumgartner, Anschrift 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg und Guido Quadri, Anschrift: 13,

via Franco Zorzi, 6900 Lugano, Schweiz, sind als aus dem Verwaltungsrat der Cassona Aviation Holding S.A. (B169374)
zu löschen. Alleinvertreter ist Oliver Walangitang, Anschrift: 13, Franco Szorzi, 6900 Lugano, Schweiz.

Sitz der Gesellschaft
Sitz der Gesellschaft Cassona Aviation Holding S.A. (B169374) ist 129, rue Adolphe Fischer, L-1521 Luxembourg.

Markus Gastinger
<i>Geschäftsführender Direktor der Muttergesellschaft

Référence de publication: 2015017970/17.
(150021896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Cyralex SA, Société Anonyme.

Siège social: L-3510 Dudelange, 10, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 172.502.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 26/01/2015 à 15 h

Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26/01/2015, que l'assemblée générale a, à l'una-

nimité:

1.  Accepté  la  démission  de  Mr  ALVES  GONCALVES  Victor  José,  demeurant  10  Rue  de  la  Terre  Noire  L-  4842

RODANGE de sa fonction d'administrateur Unique.

2. Nommé Mr Arnaud THIRIET, demeurant au 40 Rue Général Patton F-57330 HETTANGE-GRANDE pour succéder

au poste d'administrateur Unique, pour un mandat de 6 années. La date de l'expiration de son mandat prendra effet à
l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et

demeure, les comparants ont tous signé la présente minute

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/01/2015.

Mr Arnaud THIRIET / Mme C. SIMON / Mme Aurélie VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateur

Référence de publication: 2015018021/21.
(150021851) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

31451

L

U X E M B O U R G

Bliss, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2667 Luxembourg, 6, rue Verte.

R.C.S. Luxembourg B 194.152.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-trois janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

Monsieur David ROSNER, consultant, né à Luxembourg, le 23 octobre 1973, demeurant à L-2357 Senningerberg, 1,

rue des Pins.

Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'il constitue par la présente.

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de BLISS (ci-après la Société").

Art. 3. La société a pour objet:
- toutes activités d’études de réalisation commerciales en matière de communication et de publicité sous toutes formes,

tel que la publicité directe, la promotion, l’animation, ou sous toute autre forme possible,

- toutes activités de graphismes, gestion de l’informatique et de la communication par tous moyens;
- toutes activités de conseils aux entreprises;
- toutes prestations de conseils en communication écrite, audiovisuelle ou faisant appel aux nouvelles technologies

d’édition, de production et de distribution; et

- la mise à disposition, la location et la vente d’espaces publicitaires
- l’organisation et la gestion d’évenements (Event Management), ainsi que l’Achat/Vente et le négoce de différents

produits, tel que Hardware/wearables/Lifestyle, etc..

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet

2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

La Société a encore pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

La Société pourra employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un porte-feuille

se composant de tous titres et valeurs mobilières de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option
d'achat, de négociation et de toute autre manière, tous titres et droits et les aliéner par vente, échange ou encore
autrement; la Société pourra octroyer aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, tous concours, prêts, avances ou ga-
ranties.

La Société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques,

sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société pourra encore effectuer toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et finan-

cières, susceptibles de favoriser l’accomplissement ou le développement des activités décrites ci-dessus.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg.
Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales,

ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (125,- EUR) chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l’article 199 de la

loi concernant les sociétés commerciales.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

31452

L

U X E M B O U R G

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l’exercer dans les 30

jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de
rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la Société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 9. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.

Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement repré-
senter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 12. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 14. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la Société.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l’inventaire et du bilan.

Art. 16. Les produits de la Société constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements

et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-

ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

Art. 17. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 18. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 19. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites par l’associé unique, Monsieur

David ROSNER, pré-qualifié, et libérées entièrement par le souscripteur prédit moyennant un versement en numéraire,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500,-EUR) se trouve dès-à-présent à la libre disposition de
la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

31453

L

U X E M B O U R G

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge, à raison de sa constitution, à environ 970,- EUR.

<i>Résolutions prises par l'associé unique

Et aussitôt l’associé unique, représentée comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social a pris les ré-

solutions suivantes:

1.- L’adresse du siège social est établie à L-2667 Luxembourg, 6, rue Verte.
2.- Monsieur David ROSNER, consultant, né à Luxembourg, le 23 octobre 1973, demeurant à L-2357 Senningerberg,

1, rue des Pins, est nommé gérant unique de la Société pour une durée indéterminée.

3.- La Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: David ROSNER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 janvier 2015. Relation GAC/2015/799. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2015017950/125.
(150022118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

Grano S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 150.132.

L'an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg-Ville.

S’est réunie

l’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise, dénommée GRANO S.A. ayant son siège

social à L-1260 Luxembourg, 92 rue de Bonnevoie Luxembourg, inscrite au R.C.S. Luxembourg section B n°. 150 132

Ladite société a été constituée par acte reçu par le notaire instrumentant en date du 14 décembre 2009, publié au

Mémorial C n° 138 du 22 janvier 2010, et les statuts n’ont jamais été modifiés depuis

L'assemblée est présidée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxembourg.

Monsieur le Président désigne comme secrétaire Madame Marilyne KRECKE, employée privée, avec même adresse

professionnelle.

L'assemblée désigne comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, prénommé.
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence signée par les actionnaires présents et par les mandataires de ceux représentés, et à
laquelle liste de présence, dressée par les membres du bureau, les membres de l’assemblée déclarent se référer. Ladite
liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant, demeurera annexée au
présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Resteront pareillement annexées au présent acte avec lequel elles seront enregistrées, les procurations émanant des

actionnaires représentés à la présente assemblée, signées "ne varietur" par les parties et le notaire instrumentant.

Ensuite Monsieur le Président déclare et prie le notaire d'acter:
I.- Que toutes les actions représentatives de l’intégralité du capital social sont dûment représentées à la présente

assemblée, qui en conséquence est régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents
points portés à l’ordre du jour, sans convocation préalable.

II.- Que l’ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Décision de mise en liquidation volontaire de la société;
2. Nomination d’un ou plusieurs liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs;
3. Divers.

31454

L

U X E M B O U R G

L'assemblée, après s'être reconnue régulièrement constituée, a approuvé l’exposé de Monsieur le Président et a abordé

l’ordre du jour. Après délibération, l’assemblée a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée décide la dissolution et la mise en liquidation de la société avec effet à partir de ce jour.

<i>Deuxième résolution

A été nommée liquidateur,
PRIVATE TRUSTEES SA, société anonyme luxembourgeoise avec siège à L-1260 Luxembourg, 92 rue de Bonnevoie,

immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro B74.700.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la société. Dans l’exercice de sa

mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur
pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs
à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans
limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l’article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que
de tous les pouvoirs stipulés à l’article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée
générale des associés

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, et plus personne ne demandant la parole, le président lève la séance.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms usuels, états et demeures, les comparants ont signé avec Nous, notaire le présent acte.

Signé: L. Elshani, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 12 janvier 2015. 2LAC/2015/865. Reçu douze euros EUR 12,-.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015017226/59.
(150020338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Property Augsburg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.600,00.

Siège social: L-2551 Luxembourg, 123, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 104.497.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty first day of the month of December.
Before us, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

SN Properties S.à r.l, a société à responsabilité limitée (private limited liability company), incorporated under the laws

of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 123, Avenue du X Septembre, 4 

ème

 étage, L-2551 Luxem-

bourg, having a share capital of twenty nine thousand six hundred seventy five Euros (EUR 29,675) and being registered
with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 104.544 (the “Sole Shareholder”),

represented by Ms. Antonine Sanchez, lawyer, professionally residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 23

December 2014 which shall remain annexed to the present deed after having been signed ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary,

being the Sole Shareholder of Property Augsburg S.à r.l, a société à responsabilité limitée (private limited liability

company), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 123, Avenue du X
Septembre, 4 

ème

 étage, L-2551 Luxembourg, having a share capital of twelve thousand six hundred Euros (EUR 12,600)

and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 104.497 (the "Company"),
incorporated on 2 December 2004 pursuant to a deed of Maître Léon Thomas known as Tom Metzler, notary residing
in Luxembourg-Bonnevoie, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions (the “Mémorial”) dated 23 February 2005, number 163, page 7784, and the articles of association have been amended
for the last time by Maître Joseph Elvinger, notary residing in Luxemboug, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 March
2006 published in the Mémorial dated 19 June 2006, number 1188, page 56997.

The appearing party, acting in the above mentioned capacity, declared and requested the notary to record as follows:
1. The Sole Shareholder holds all the one hundred twenty-six (126) shares in issue in the Company so that the total

share capital is represented and the resolution can be validly taken by the Sole Shareholder.

31455

L

U X E M B O U R G

2. The items on which a resolution is to be taken are as follows:
Change of the financial year so as to end on 31 January of each year and with the first time as of 31 January 2015 and

consequential amendment of Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company so that Articles 10 and 11
of the articles of association of the Company read as follows:

“ Art. 10. The Company’s financial year runs from February 1 

st

 of each year to January 31 

st

 .

Art. 11. Each year, as of January 31 

st

 , there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as

well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and

provisions, represents the net profit of the Company.

Every year five per cent of the net annual profit of the Company shall be transferred to the Company’s legal reserve

until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and for any reason whatsoever
the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five per cent annual contribution shall be resumed until
such one-tenth proportion is restored.

The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,

the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.”

Thereafter the following resolution was passed by the Sole Shareholder of the Company:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder resolved to change the duration of the 2014 financial year and amend Articles 10 and 11 of the

articles of association of the Company so that Articles 10 and 11 of the articles of association of the Company read as
set out in the above agenda.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto,

this deed is drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of
divergences between the English and French version, the English version will prevail.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever, which fall to be paid by the Company as a result of the

present deed are estimated at approximately EUR 1,300.-.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par-devant nous, Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

SN Properties S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg,

dont le siège social est situé au 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg, ayant un capital social de vingt neuf
mille six cent soixante-quinze euros (29.675 EUR) et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 104.544 (l’«Associé Unique»),

représentée par Madame Antonine Sanchez, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration datée du 23 décembre 2014, laquelle sera annexée au présent acte après avoir été signée ne varietur par le
mandataire et le notaire soussigné,

étant l’Associé Unique de Property Augsburg S.à r.l, une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois

du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social est situé au 123, Avenue du X Septembre, L-2551 Luxembourg,
ayant un capital social de douze mille six cent euros (12.600 EUR) et étant immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 104.497 (la «Société»), constituée le 2 décembre 2004 en vertu d’un
acte de Maître Léon Thomas dit Tom Metzler, notaire de résidence à Luxembourg-Bonnevoie, Grand-Duché de Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 23 février 2005, numéro 163, page
7784, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 30 mars 2006 en vertu d’un acte de Maître Joseph
Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial du 22 juin 2006, numéro
1188, page 56997.

La partie comparante, agissant en la qualité mentionnée ci-dessus, a déclaré et requis le notaire d’acter ce qui suit:
1. L’Associé Unique détient l’ensemble des cent vingt-six (126) parts sociales émises dans la Société de sorte que la

totalité du capital social est représentée et la résolution peut être valablement prise par l’Associé Unique.

2. Les points sur lesquels une résolution doit être prise sont les suivants:

31456

L

U X E M B O U R G

Changement de l’année sociale pour y mettre fin le 31 janvier de chaque année et pour la première fois le 31 janvier

2015 avec modification corrélative des articles 10 et 11 des statuts de la Société afin que les articles 10 et 11 des statuts
de la Société aient la teneur suivante:

« Art. 10. L’année sociale commence le 1 

er

 février de chaque année et se termine le 31 janvier.

Art. 11. Chaque année, au 31 janvier, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la Société, ainsi qu'un bilan et

un compte de profits et pertes.

L’excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges, amortissements et provisions,

constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net annuel de la Société seront transférés à la réserve légale de la société

jusqu'à ce que cette réserve atteigne un dixième du capital souscrit. Si à un moment quelconque et pour n’importe quelle
raison,  la  réserve  légale  représentait  moins  d’un  dixième  du  capital  social,  le  prélèvement  annuel  de  cinq  pour  cent
reprendrait jusqu'à ce que cette proportion de un dixième soit retrouvée.

Le surplus du bénéfice net est attribué à l’associé unique ou, selon le cas, réparti entre les associés. Toutefois, l’associé

unique, ou, selon le cas, l’assemblée des associés à la majorité fixée par les lois afférentes, pourra décider que le bénéfice,
déduction faite de la réserve, pourra être reporté à nouveau ou être versé à un fonds de réserve extraordinaire.»

À la suite de quoi, la résolution suivante a été adoptée par l’Associé Unique de la Société:

<i>Résolution unique

L’Associé Unique a décidé de modifier la durée de l’année sociale 2014 et de modifier les articles 10 et 11 des statuts

de la Société afin que les articles 10 et 11 des statuts de la Société aient la teneur énoncée dans l’ordre du jour ci-dessus.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu'à la demande de la partie comparante,

le  présent  acte  est  rédigé  en  anglais  suivi  d’une  traduction  en  langue  française;  à  la  demande  de  la  même  personne
comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature, payables par la Société en raison du présent acte, sont

évalués approximativement à EUR 1.300,-.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du présent procès-verbal, la partie comparante et le notaire ont signé le présent acte.
Signé: A. SANCHEZ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 06 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/262. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015017559/118.
(150020131) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Halter Ego S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5626 Mondorf-les-Bains, 12, avenue Elise Deroche.

R.C.S. Luxembourg B 194.108.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le treize janvier,
Par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains.

Ont comparu:

1. Monsieur Kevin Killburger, informaticien, né à Metz, France, le 3 mars 1985, demeurant à 12, avenue Elise Deroche,

L-5626 Mondorf-les-Bains, et

2. Madame Anne-Gaelle Halter, responsable marketing, née à Thionville, France, le 26 août 1982, demeurant à 12,

avenue Elise Deroche, L-5626 Mondorf-les-Bains.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à respon-

sabilité limitée qu'ils déclarent constituer entre eux:

31457

L

U X E M B O U R G

Titre I 

er

 . Dénomination - Siège social - Objet - Durée - Capital social

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui

pourront le devenir par la suite une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie par les lois y
relatives ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet la location de matériel et vente de prestations de services dans le domaine de l'événe-

mentiel; la production de vidéos; le conseil en informatique, en communication, marketing et stratégie.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins qu'elle ne soit spécialement réglementée.

D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières se
rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

Art. 3. La société prend la dénomination de Halter Ego S.à. r.l..

Art. 4. Le siège social est établi à Mondorf-les-Bains.
Il pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune du siège social par une résolution des/du gérant(s).
La société peut ouvrir des agences ou des succursales dans toutes les autres localités du pays et à l'étranger.

Art. 5. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de EUR 12.500,00 (douze mille cinq cents euros), représenté par 500 (cinq

cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle du nombre des parts existantes dans l'actif

social et dans les bénéfices.

Art. 8. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des non-associés

qu'avec l'agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Titre II. Administration - Assemblée Générale

Art. 9. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, salaries ou gratuits, nommes par l'assemblée

des associés, qui fixe leurs pouvoirs. Ils peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée des associés.

A moins que les associés n'en décident autrement, le où les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom

de la société en toutes circonstances.

En tant que simple mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent en raison de leur fonction aucune

obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; ils ne seront
responsables que de l'exécution de leur mandat.

La société sera engagée en toutes circonstances par la seule signature du gérant unique. En cas de pluralité de gérants,

la société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant ou par la (les) signature(s)
de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareil pouvoir de signature aura été délégué par le ou les gérant
(s).

Art. 10. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts lui appartenant.
Chaque associé à un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représenté; chaque associé peut se

faire représenter valablement aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 11. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux présents statuts doivent être prises à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Titre III. Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 12. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 13. Chaque année, à la clôture de l'exercice, les comptes de la société sont arrêtés et la gérance dresse les comptes

sociaux, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la société communication de l'inventaire et du bilan.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales, amortissements et moins-values jugées

nécessaires ou utiles par les associés, constitue le bénéfice net de la société.

Après dotation à la réserve légale, le solde est à la libre disposition des associés.

31458

L

U X E M B O U R G

Titre IV. Dissolution - Liquidation

Art. 16. La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Art. 17. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scelles sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilans et inventaires de la société.

Art. 18. En cas de dissolution de la société, la liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Art. 19. Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales en vigueur régissant les sociétés à responsabilité limitée.

<i>Souscription et Paiement

Ces parts ont été souscrites comme suit:

1) par Monsieur Kevin Killburger, prénommé,
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
2) par Madame Anne-Gaelle Halter, prénommée,
deux cent cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) se trouve des maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a
été justifie au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille six cents euros
(EUR 1.600).

<i>Disposition transitoire

La première année sociale commencera à la date de constitution et finira le dernier jour de décembre 2015.

<i>Résolutions de l'associé unique

<i>Première résolution

Le nombre de Gérants est fixe à deux (2) et les personnes suivantes sont nommées en tant que Gérants pour une

période illimitée:

1. Monsieur Kevin Killburger, informaticien, né à Metz, France, le 3 mars 1985, demeurant à 12, avenue Elise Deroche,

L-5626 Mondorf-les-Bains, et

2. Madame Anne-Gaelle Halter, responsable marketing, née à Thionville, France, le 26 août 1982, demeurant à 12,

avenue Elise Deroche, L-5626 Mondorf-les-Bains.

<i>Deuxième résolution

Le siège social est établi au 12, avenue Elise Deroche à L-5626 Mondorf-les-Bains.

<i>Avertissement

Avant de clore, le notaire soussigné a attire l'attention du comparant sur le fait que la société doit obtenir une auto-

risation d'établissement de la part des autorités administratives compétentes en rapport avec son objet social avant de
commencer son activité commerciale, avertissement que le comparant reconnaît avoir reçu.

Dont acte, fait et passe à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, il a signa le présent acte ensemble

avec le notaire.

Signé: K. Killburger, A.-G. Halter, M. Loesch.
Enregistre à Grevenmacher A.C., le 19 janvier 2015. GAC/2015/587. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 2 fevrier 2015.

Référence de publication: 2015017245/114.
(150021102) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

31459

L

U X E M B O U R G

Global Négoce Solutions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4384 Ehlerange, 3, Z.A.R.E. Ilot ouest.

R.C.S. Luxembourg B 194.120.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le vingt-trois janvier.
Pardevant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Jean-François FOIS, directeur de société, né le 4 août 1980 à Saint-Avold (France) demeurant à F-57070

Metz, 9 rue de Bourgogne, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que mandataire de:

1. Tech &amp; Trade une société anonyme ayant son siège social à L-4384 Ehlerange, 3, Z.A.R.E. Ilot ouest, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 143.859,

2. Monsieur Julien FOIS, employé privé, né le 25 avril 1983 à Saint-Avold (France) demeurant à 14 rue de la Fenderie

F-57700 Hayange.

3. Madame Halima GESNOT, employée privée, née le 6 décembre 1972 à Casablanca (Maroc), demeurant 11 rue de

la Clairière F-54660 Moutiers.

en vertu de trois (3) procurations données sous seing privé.
Lesquelles procurations, après avoir été paraphées «ne varietur» par la mandataire et le notaire instrumentant, res-

teront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Lesquels comparants, représentés comme ci-avant, déclarent vouloir constituer entre eux une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois, à ces fins, arrêtent les statuts suivants:

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la déno-

mination de "Global Négoce Solutions"

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Sanem.
Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés à

prendre conformément aux dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet tant en tout endroit de la Communauté Européenne que partout ailleurs dans le monde

entier, le négoce de pièces liées à l’industrie et toutes prestations y afférentes.

En outre, la société pourra exercer toute autre activité commerciale à moins que celle-ci ne soit pas spécialement

réglementée. D'une façon générale, elle pourra faire toutes les opérations commerciales, financières, mobilières et im-
mobilières se rattachant directement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue,

similaire ou connexe, et, en vue de favoriser le développement de sa participation ainsi créée, elle peut apporter tout
soutien financier ou même sa caution.

D'une façon générale, la société pourra prendre toutes mesures de contrôle ou de surveillance et effectuer toute

opération qui peut lui paraître utile dans l’accomplissement de son objet et son but.

Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à quinze mille euros (15.000.- EUR) représenté par cent (100) parts sociales de cent

cinquante euros (150,- EUR), chacune.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l’égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul ayant-droit pour chacune

d'elles.

S'il y a plusieurs ayant-droits d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l’exercice des droits afférents, jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de même en
cas de conflit opposant l’usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions entre vifs des parts sociales à des tiers, ainsi que leur transmission pour cause de mort à quelque

héritier ou légataire que ce soit, fût-il réservataire ou légal, sont subordonnées à l’agrément des associés représentant au
moins les trois quarts (3/4) du capital social pour les cessions entre vifs et les trois quarts (3/4) des droits appartenant
aux survivants pour leur transmission à cause de mort.

La cession entre vifs des parts sociales ainsi que leur transmission pour cause de mort à des associés est libre.

Art. 8. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants.

31460

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l’exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l’exécution de son mandat.

Art. 12. Chaque part sociale du capital donne droit à une voix.
Les décisions de l’assemblée générale ne sont valablement prises qu'autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les délibérations qui portent modifications des statuts ne sont valablement prises que par la majorité des associés

représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 15. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5 %) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 16. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 17. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

Art. 18. Tous les litiges, qui naîtront pendant la liquidation de la Société, soit entre les associés eux-mêmes, soit entre

le ou les gérants et la Société, seront réglés, dans la mesure où il s'agit d'affaires de la Société, par arbitrage conformément
à la procédure civile.

<i>Disposition transitoire:

Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et Libération:

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites et libérées comme suit:

- TECH &amp; TRADE, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts

- Monsieur Julien, FOIS, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts

- Monsieur Jean-François FOIS, prénommé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30 parts

- Madame Halima GESNOT, prénommée: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 parts

TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts

Toutes les parts ont été entièrement libérées par un versement en espèces, de sorte que le montant de quinze mille

euros (15.000,- EUR) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire
instrumentant qui le constate.

<i>Résolutions des associés:

Ensuite les associés, représentés comme ci-avant et représentant l’intégralité du capital social, se sont réunis en as-

semblée générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité des voix les décisions suivantes:

1. Le siège social est établi à L-4384 Ehlerange, 3, Z.A.R.E. Ilot ouest.
2. Le nombre de gérants est fixé à un (1) pour une durée indéterminée:
- Monsieur Jean-François FOIS, prénommé.
3. La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

31461

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève à la somme de neuf cents euros (900,- EUR).

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte à la mandataire des comparants, agissant comme dit ci-avant, connue du notaire par

nom, prénom, état civil et domicile, celle-ci a signé ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: J-F. FOIS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 27 janvier 2015. 2LAC/2015/1913. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 2 février 2015.

Référence de publication: 2015017199/117.
(150021279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Magnum Capital II (SCA) SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'In-

vestissement en Capital à Risque.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 194.106.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of January.
Before, Maitre Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, acting in replacement of Maitre Henri Hellinckx, notary

residing in Luxembourg, who will be the depositary of the present deed.

THERE APPEARED:

(i) Magnum Capital Management S.à. r.l., à Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limi-

tée), having its registered office at 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, having a
share capital of EUR 12,500 and in the process of being registered with the Luxembourg Trade and Companies Register;

(ii) Mr Angel Corcostegui Guraya, born on 14 December 1951,in Bilbao, professionally residing in C/ Fortuny 14, 2

nd

 Floor, Madrid 28010, Spain (iii) Mr Enrique de Leyva Perez, born on 16 December 1959, in Sevilla, professionally residing

in C/ Fortuny 14, 2 

nd

 Floor, Madrid 28010, Spain

(iv) Mr Joao Luis Ramalho de Carvalho Talone, born on 27 October 1951, in Lisbon, professionally residing in Avda.

da Liberdade, 249 - 4, Lisbon, 1250-143, Portugal, and

(v) Mr Joao Peres Coelho Borges, born on 12 June 1975, in Lisbon, professionally residing in Avda. da Liberdade, 249

- 4, Lisbon, 1250-143, Portugal.

here represented by Solange Wolter-Schieres, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of proxies

given under private seal.

The said proxies, after having been initialed and signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

shall remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the following articles of association of a part-

nership limited by shares (société en commandité par actions) which they declare to establish as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed among Magnum Capital Management S.à. r.l., the manager of the Company (the General

Partner - actionnaire commandité) and the holders of various classes of ordinary shares (the Limited Shareholders -
actionnaires commanditaires, and collectively with the General Partner, the Shareholders), a société en commandité par
actions with variable capital qualifying as a société d'investissement en capital à risque (SICAR) under the name "MAGNUM
CAPITAL II (SCA) SICAR" (the Company), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the SICAR
Law, the Companies Act, as well as by the Articles of Association and the private placement memorandum of the Company
(the PPM).

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in the municipality of Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the General Partner. The registered
office may further be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Shareholders
adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Association.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a  resolution  of  the  General  Partner.  Where  the  General  Partner  determines  that  extraordinary  political  or  military

31462

L

U X E M B O U R G

developments or events have occurred or are imminent as determined in its sole discretion and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg in-
corporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The object of the Company is the investment of the funds available to it in risk capital within the meaning of Article

1 of the SICAR Law and CSSF Circular 06/241 as more specifically defined and described in the PPM.

3.2 The Company may also invest in any participation, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in

any form whatsoever carrying a risk capital feature and the administration, management, control and development of such
participations.

3.3 The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to its participations in companies and/

or enterprises, including the administration, management, control, development, optimization and realization of such
participations as an investor in such participations, which it may deem useful for the fulfilment and development of its
purpose as stated herein, to the extent permitted under the SICAR Law.

3.4 The Company may grant loans, advances or guarantees to direct and indirect subsidiaries for the accomplishment

of its purpose.

3.5 The Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security (including, a pledge or assignment

by way of security all or part of the Investors' Undrawn Commitments and under any loan or guarantee arrangements)
whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or
future) or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any
of the affiliates, within the limits of any applicable legal provision or generally transfer the right to call for unfunded Investor
Commitments to a third party lender.

3.6 The Company may enter into agreements, underwriting agreements, marketing agreements, management agree-

ments,  advisory  agreements,  administration  agreements  and  other  lease  agreements,  contracts  for  services,  selling
agreements Share and/or currency exchange agreements, and other financial derivative agreements in relation to its object.

3.7 The Company can generally perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly

or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose, it being understood that the Company
will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a
regulated activity of the financial sector.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for ten (10) years from the Final Closing Date, which may be extended by up to two (2)

additional one year periods, at the discretion of the General Partner. Any additional extension shall be approved by the
General Partner, by means of an Investors' Special Consent.

4.2 The Company may, subject to prior approval of the CSSF and approval of the General Partner, be dissolved, at

any time, by a resolution of the Shareholders of the Company adopted in the manner required for the amendment of the
Articles of Association.

4.3  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting any of the Shareholders. In case of death, incapacity or inability of the General
Partner, Article 112 of the Companies Act shall apply.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The capital of the Company is variable and shall be represented by Shares. The minimum subscribed share capital

of the Company, increased by the share premium if any, which must be achieved within twelve (12) months after the date
on which the Company was authorised as a “société d'investissement en capital à risque” or “SICAR” under the SICAR
Law, shall be one million Euro (EUR 1,000,000).

5.3 The share capital is composed of one (1) management share, Class A Shares and Class B Shares, each having a

nominal value of one Euro (EUR 1), with rights and obligations as set forth in the Articles of Association and the PPM.

The initial share capital of the Company upon incorporation amounts to thirty-one thousand and one Euro (EUR

31,001) divided into one (1) management share and thirty-one thousand (31,000) Class B shares.

5.4 The Class A Shares in the Company may only be subscribed for by Well-Informed Investors. In the event a Sha-

reholder  ceases  to  be  a  Well-Informed  Investor  under  the  SICAR  Law,  the  General  Partner  shall  be  entitled  to
compulsorily redeem the Shares of such Shareholder at a price determined by the General Partner.

5.4 The Class A Shares in the Company may only be subscribed for by Investors who are not Initiators and are subject

to the rights set out in the PPM.

31463

L

U X E M B O U R G

5.5 The Class B Shares in the Company may only be subscribed for by Initiators and are entitled to the rights set out

in the PPM.

5.6 Each Shareholder shall have signed an agreement recording its Commitment irrevocably committing to make all

subscriptions and payments for the entire Commitment, unless otherwise decided by the General Partner but ensuring
that all Shareholders are treated equally in this regard.

5.7 The Company, after receiving SICAR authorisation, qualifies as a financial institution within the meaning of the

Luxembourg anti-money laundering legislation. The Company's administrative agent shall be entrusted by the General
Partner to apply all applicable measures in order to prevent money laundering and terrorist financing as well as in order
to comply with insider regulations. Such measure shall include, in particular, the introduction of necessary KYC checks
and anti-money laundering procedures for the Company.

Art. 6. Increase and Reduction of share capital. The share capital of the Company may be increased or reduced by a

resolution of the General Partner of the Company.

Art. 7. Shares. Issuance and Default.
7.1 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives), will be immaterial and delivered to the

Shareholders in the form of a material certificate only at their request.

7.2 A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of

the Companies Act and may be examined by each Shareholder who so requests.

7.3 Shares shall be transferred by a written declaration of transfer registered in the Shareholders' register of the

Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable
powers of attorney. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer satisfactory to
the Company.

7.4 Each Share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence, subject to the terms of the PPM.

7.5 Towards the Company, the Company's Shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint

co-owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.

7.6 There will generally be no redemption at the initiative of the Shareholders, except as provided in clauses 9.8 to

9.13 and clause 16.8 of the PPM. The General Partner may, cause the Company to acquire and redeem its own Shares,
for example with a view to effect distributions or a return of capital in compliance with the terms of the PPM, the Articles
of Association and subject to the limits and procedures set forth by the Company Act and the SICAR Law.

7.7 Notwithstanding clause 7.7, if a shareholder loses its status as a Well-Informed Investor, the General Partner will

automatically and immediately cause the repurchase of the shares of such Shareholder by the Company without approval
from the relevant Shareholder. The purchase price of the repurchased shares will be determined on the basis of the Net
Asset Value of the Company discounted by fifty (50) per cent, or where the loss of status is solely as a result of a change
in SICAR Law discounted by twenty five (25) per cent, and the purchase price will be paid within three (3) months following
the repurchase.

7.8 The Company shall issue Shares to the Shareholders in such number as provided in the drawdown notices issued

by the General Partner in relation to the Shareholders' Commitments pursuant to Article 5.6 not less than 10 Business
Days prior to the due date so that amounts drawn under each notice shall constitute the consideration payable for the
new Shares to be issued by the Company. The Shares will be fully paid up.

7.9 If a Shareholder fails to pay the amount which is the subject of a drawdown notice on or before the date of expiry

of such drawdown notice, such Shareholder shall be a “Defaulting Shareholder” and the General Partner will, at any time
thereafter, give notice to such Defaulting Shareholder (the “Default Notification”). The rights of the General Partner
following a Shareholder becoming a Defaulting Shareholder are set out in the PPM.

Art. 8. Share transfers.
8.1 The General Partner shall not sell, assign, transfer, exchange, pledge, encumber or otherwise dispose of all or any

part of its rights and obligations as a General Partner, other than to an Associate of the General Partner (whereupon in
the case of an assignment or transfer, such Associate shall become the General Partner in place of the transferor), or
voluntarily withdraw as the General Partner of the Company, without the approval of the CSSF and Shareholders by an
Investors' Special Consent.

8.2 No sale, assignment, transfer, exchange, pledge, encumbrance or other disposition (including the granting of any

participation) (“Transfer”) of Shares (other than pursuant to clauses 9.8 to 9.13 of the PPM), whether direct or indirect,
voluntary or involuntary (including, without limitation, to an Associate or by operation of law), shall be valid or effective
except:

(a) to a Well-Informed Investor, and
(b) with the prior written consent of the General Partner which consent can be given or withheld in its sole and

absolute discretion for any reason whatsoever provided that in the case of any Transfer:

31464

L

U X E M B O U R G

(i) to an Associate of an existing Shareholder, provided however that no Transfer shall be valid without the consent

of the General Partner (which consent can be given or withheld in its sole and absolute discretion) if it is undertaken as
a series of Transfers which would result in the ultimate transferee not being an Associate of the original transferor; or

(ii) to a replacement trustee or replacement trustees of an existing Shareholder which holds its interest on trust for

one or more beneficial owners provided that there is no change in beneficial ownership; or

(iii) to any custodian or nominee of an existing Shareholder provided there is no change in beneficial ownership; or
(iv) to any other fund or collective investment scheme managed or advised by the same General Partner or adviser as

an existing Shareholder,

then such consent shall not be unreasonably withheld or delayed; and
(c) where none of the following apply:
(i) such Transfer would result in a violation of applicable law, including United States Federal or State securities laws,

or any term or condition of the PPM;

(ii) as a result of such Transfer, the Company would be required to register as an investment company under the

Investment Company Act;

(iii) such Transfer would cause the Company to be disqualified or terminated as a partnership (including for applicable

tax purposes), but only if such termination could reasonably be expected to result in material adverse tax consequences
to the Shareholders;

(iv) such Transfer would result in the assets of the Company, if any, being treated as “plan assets” under ERISA;
(v) such Transfer would cause the Company to be classified as an association taxable as a corporation for United States

Federal income tax purposes; or

(vi) such Transfer would constitute a transaction effected through an “established securities market” within the meaning

of the United States Treasury Regulations promulgated under section 7704 of the Code or otherwise would cause the
Company to be a “publicly traded partnership” within the meaning of section 7704 of the Code, or would cause there
to be more than 100 Shareholder (as determined under the Treasury Regulations promulgated under section 7704 of
the Code). For purposes of determining the number of Shareholders under this clause 8.2(c)(vi), a person (a “beneficial
owner”) owning an interest in a partnership, grantor trust or S corporation for United States Federal income tax purposes
(a “flow-through entity”) that owns directly, or through other flow-through entities, a Share, is treated as a Shareholder
if (X) substantially all of the value of the beneficial owner's interest in the flow-through entity is attributable to the flow-
through entity's direct or indirect interest in the Company and (Y) a principal purpose in using the tiered arrangement
is to permit the Company to have not more than 100 Shareholders.

8.3 For the purposes of determining whether any proposed Transfer breaches any provision of clause 8.2(c) the General

Partner shall be entitled to require, as a condition of registering any Transfer or giving consent to any Transfer, that any
proposed Substitute Investor either (at the General Partner's discretion) provide to the General Partner an opinion of
counsel (such counsel and opinion to be in a form reasonably satisfactory to the General Partner) or a certificate of an
authorised officer of the proposed Substitute Investor that the proposed Transfer does not breach any of the provisions
of clause 8.2(c). The General Partner shall be entitled to rely on such opinion or certificate for the purposes of determining
whether any proposed Transfer breaches any of the provisions of clause 8.2(c).

8.4 Each Substitute Investor shall be bound by all the provisions of these Articles and the PPM and, as a condition of

registering any Transfer or giving its consent to any Transfer to be made in accordance with the provisions of this clause
8, the General Partner shall require (and the transferring Shareholder shall take all necessary steps to ensure) that the
proposed Substitute Investor acknowledges, in such written form as may be required by the General Partner, its as-
sumption (in whole or, if the substitution is in respect of part only, in the proportionate part) of the obligations of the
transferring Shareholder by agreeing to be bound by all the provisions of these Articles of Association and the PPM and
becoming a Shareholder and undertakes to indemnify the Company and General Partner in respect of any liabilities,
obligations, legal costs, taxes and expenses associated with or arising directly or indirectly as a result of such Transfer.

8.5 The Substitute Investor shall not become a Shareholder and neither the Company nor the General Partner shall

incur any liability to any person for allocations and distributions made in good faith to the transferring Investor until:

(a) the written instrument of transfer has been received by the Company and recorded in its books and the effective

date of the transfer has passed; and

(b) the General Partner has confirmed that the proposed transferee has, in the General Partner's view, supplied the

necessary information to allow the General Partner to comply with any applicable anti-money laundering requirements
relating to the admission of the proposed transferee as a Shareholder in the Company.

8.6 Provided that the Substitute Investor has acknowledged its assumption of the obligations of the transferring Sha-

reholder the General Partner shall, on behalf of all of the Shareholders, be authorised (but shall not be obliged) to release
any Shareholder who is making a Transfer for any future obligation in respect of the Share which is the subject of such
Transfer.

8.7 No transfer of a Share in violation of this clause shall be valid or effective, and the Company shall not recognise

the same, for the purposes of making distributions of Proceeds or repayments of Outstanding Amounts or otherwise
with respect to interests in the Company.

31465

L

U X E M B O U R G

8.8 Except as provided in clauses 9.8 to 9.13 of the PPM and this clause 8, or otherwise agreed with the General

Partner no Shareholder shall have the right to withdraw from the Company.

III. Management - Representation

Art. 9. Management of the Company.
9.1 The Company shall be managed by the General Partner. Subject to the provisions of Article 9.8 below, Magnum

Capital Management S.à. r.l. is and shall remain the General Partner for the duration of the Company.

9.2 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles of Association to the Shareholders fall within

the competence of the General Partner, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company's object.

9.3 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders

or not, by the General Partner.

9.4 The General Partner is authorised to delegate the day-to-day management of the Company and the power to

represent the Company in respect thereto to one or more officers, or other agents who may but are not required to
be Shareholders, acting individually or jointly.

9.5 The Company shall be bound towards third parties by the signature of the General Partner or by the joint or single

signature of any person to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Articles 9.3 and
9.4 of these Articles of Association and within the limits of such power.

9.6 Subject to the provisions of Article 9.8 below, no contract or other transaction between the Company and any

other company or person shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any officers of the
Company has an interest in the transaction, or is a director, associate, officer or employee of such other company or
person.

9.7 The General Partner may be removed as General Partner of the Company provided that such removal has been

approved by Investors holding at least 75% of Total Commitments; for the avoidance of doubt, the Commitments of any
Associates of the General Partner shall not be included as part of the consent or of Total Commitments for these
purposes. After the third anniversary of the Final Closing Date, such resolution may be approved by an Investors' Special
Consent.

9.8 Potential Conflicts of Interest
The General Partner recognises that there may be situations where conflicts of interest arise and intends to avoid or

mitigate such situations during the life of the Company. Where this is not possible, conflicts of interest shall be managed
fairly, openly, honestly and with integrity.

Conflicts of interest will be diligently identified and disclosed to the parties concerned (and in any case to the Investor

Board). The board of managers of the General Partner is responsible to supervise possible conflicts of interest that may
exist. Conflicts of interest shall be subject to the approval of the board and no transaction which is or could be considered
to be a conflict of interest will proceed without such consent. Potential or actual conflicts of interest may furthermore
be identified by the Shareholders. Shareholders may furthermore notify the General Partner of any such potential conflict
matters.

Investor Board meetings shall be held when deemed appropriate for the proper handling of any conflicts brought to

its attention. On any matter involving a potential or actual conflict of interest, the board shall be guided by its good faith
judgment as to the best interests of all parties involved and shall take such actions as are determined by it, as the case
may be, to be necessary or appropriate to ameliorate such conflicts of interest.

In case of a potential conflict situation, the Investor Board will make a sound and reasonable assessment of the situation

taking into account all relevant facts and circumstances. If it is decided that the matter at hand does not represent a
conflict of interest situation, the board will approve to continue with the respective transaction provided that it does not
act in contravention of any decision or advice of the Investor Committee. If it is decided that the matter does present a
(potential) conflict of interest situation, the General Partner shall fully disclose and refer any (potential) conflict of interest
to the Company's general meeting for its binding determination.

Conflicts of interest will in any case be dealt with in accordance with article 7a of the SICAR Law and regulations from

the CSSF.

Art. 10. Liability.
10.1 To the extent permissible under Luxembourg law and subject to the provisions of the PPM, the General Partner

and other officers of the Company, as well as those persons to whom such signatory powers have been validly delegated
in accordance with Articles 9.3 and 9.4 of these Articles of Association, shall be indemnified out of the assets of the
Company against all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in connection with any
actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having been managers,
officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any contract entered
into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties save for where
set out in the PPM.

31466

L

U X E M B O U R G

10.2 The General Partner is jointly and severally liable for all liabilities of the Company to the extent that they cannot

be paid out of the assets of the Company.

IV. General meetings of Shareholders

Art. 11. Powers and Voting rights.
11.1 The general meeting of Shareholders properly constituted represents the entire body of Shareholders of the

Company.

11.2 It cannot order, adopt, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company without the consent of

the General Partner; provided, that the General Partner shall consent to any decision or approval of the Shareholders
or the Investor Committee made pursuant to the terms of the PPM.

11.3 Resolutions of the Shareholders shall be adopted at general meetings.
11.4 Each Shareholder has voting rights commensurate to his shareholding. Each share is entitled to one vote.

Art. 12. Notices, Quorum, Majority and Voting proceedings. Notices of the meetings of the Shareholders.
12.1 The chairman of the General Partner shall preside as chairman of every general meeting of the Company, or if

he is not present or willing to act, the managers of the General Partner shall elect one of their number or the Investment
Advisers to be chairman of the meeting.

12.2 The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by law shall govern the notice

for, and conduct of, the meetings of Shareholders of the Company, unless otherwise provided herein.

12.3 The General Partner shall convene at least an annual meeting a year and, whenever it deems fit, convene other

general meetings with a least a fifteen (15) days' written notice in advance. Any Investors whose Commitments amount
to forty per cent (40%) of the aggregate Commitments may, by way of a written notice, require the General Partner to
call a general meeting and the General Partner shall convene such general meeting within thirty (30) days from the date
of the written notice. The accidental omission to give written notice to, or the non-receipt of a notice of a general meeting
by, any Shareholder shall not invalidate the (proceedings at the) general meeting.

12.4 Meetings of Shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the respective

convening notices of the meetings.

12.5 If all the Shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the Shareholders of the

Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may
be held without prior notice.

Attendance - Representation
12.6 A Shareholder may act at any meeting of the Shareholders of the Company by appointing another person (who

need not be a shareholder) as his proxy in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.

12.7 Each Shareholder may also participate in any meeting of the Shareholders of the Company by telephone or video

conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to
identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation
in person at such meeting.

12.8 Each Shareholder may also vote by way of voting forms provided by the Company. These voting forms contain

the date and place of the meeting, the agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each
proposed resolution, three boxes allowing the Shareholders to vote in favour, against or abstain from voting on the
proposed resolution. The voting forms must be sent by the Shareholders by mail, telegram, telex, facsimile or e-mail to
the registered office of the Company. The Company will only accept the voting forms which are received prior to the
time of the meeting specified in the convening notice. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the
proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

Quorum and Majority
12.9 Except as otherwise required by law, by these Articles of Association and/or by the PPM, resolutions at a meeting

of the Shareholders of the Company duly convened, where Investors representing at least forty per cent (40%) of the
total Commitments are present or represented shall constitute a quorum. If there are fewer than Investors representing
at least forty per cent (40%) of the total Commitments, the general meeting shall be quorate if all Investors attend. If this
quorum is not reached, a second general meeting may be convened in the manner prescribed for by Article 12.10.

12.10 An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of these Articles of Association shall not

validly deliberate unless at least one-half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments
to  these  Articles  of  Association.  If  this  quorum  is  not  reached,  a  second  meeting  may  be  convened,  in  the  manner
prescribed by these Articles of Association, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen
days before the meeting in the Luxembourg official gazette, the Memorial C, and in two Luxembourg newspapers and by
providing written notice to each Shareholder at least 15 days before the meeting. Such convening notice shall reproduce
the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate
regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be
carried by at least two-thirds of the votes cast (excluding the votes of any Class B Shareholder). Notwithstanding the
before, any amendments to these Articles of Association require the prior approval by the CSSF and to the extent that

31467

L

U X E M B O U R G

any proposed amendment would have a material adverse effect on the rights of any Class A Shareholder, the prior approval
of such Class A Shareholder.

12.11 Except as otherwise required by law or by these Articles of Association, and subject to Article 11.2 as well as

subject to resolutions requiring Investors' Special Consent under the PPM, resolutions at a meeting of the Shareholders
of the Company duly convened shall be validly adopted if approved by Shareholders (present or represented) whose
aggregate Commitments represent at least fifty per cent (50%) of the total Commitments.

12.12 The nationality of the Company may be changed, its SICAR status may be abandoned and the commitments of

its Shareholders may be increased only with the unanimous consent of the Shareholders. The change of the nationality
and abandon of the SICAR status can only be made with prior approval of the CSSF.

V. Supervision - Annual accounts - Distributions and allocation of profits

Art. 13. Independent Auditor.
13.1 The operations of the Company and its financial situation including particularly its books shall be audited by an

Independent Auditor, chosen from the list of approved auditors held by the CSSF who shall be appointed by the General
Partner and who shall carry out the duties prescribed by the SICAR Law. The mechanics relating to the appointment of
a replacement Independent Auditor are set out in the PPM.

13.2 The Independent Auditor shall, among other duties, promptly notify the CSSF of any fact or decision of which

the Independent Auditor has become aware while carrying out the audit of the accounting information contained in the
annual report of the Company or any other legal issue concerning the Company, where such fact or decision is liable to
constitute a material breach of the SICAR Law or the regulations adopted for its execution, or affect the continuous
functioning of the Company, or lead to a refusal to certify the accounts or to the expression of reservations thereon.

13.3 The Independent Auditor has extensive duties of informing and notifying the CSSF that may require the Inde-

pendent  Auditor  to  exercise  control  over  one  or  several  particular  aspects  of  the  activities  and  operations  of  the
Company, at the Company's expense.

Art. 14. Accounting Year and Annual general meeting.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first (1 

st

 ) of January of each year and end on the thirty-

first (31 

st

 ) of December of the same year. Notwithstanding the before, the first accounting year shall commence on the

date of the Company's establishment and end on 31 December 2015.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's year, the General Partner must prepare the balance sheet

and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including an indication of the value of the
Company's assets and liabilities, with an annex summarising all the Company's commitments and the debts of the manager
(s), and auditor(s) of the Company.

14.3 The annual general meeting of the Shareholders of the Company shall be held, in accordance with Luxembourg

law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of
the registered office as may be specified in the convening notice of meeting, on the last Thursday of June at 05:00 PM
(Luxembourg time). If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held
on the next following business day.

14.4 The annual general meeting of the Shareholders of the Company may be held abroad if, in the absolute and final

judgement of the General Partner, exceptional circumstances so require.

Art. 15. Distributions and allocation of profits.
15.1 No distributions will be made unless there is sufficient cash available, or (except as part of the liquidation of the

Company) if the capital of the Company would as a consequence of the distribution fall below the legal minimum EUR
1,000,000 (as required by the SICAR Law).

15.2 Distributions and allocation of profits and losses and, to the extent applicable, clawbacks shall be made in accor-

dance with the principle set out in relation to distributions in the PPM.

Art. 16. Redemption of Shares. There will generally be no redemption at the initiative of the Shareholders, except as

explicitly provided otherwise in the Articles. The General Partner may, however, cause the Company to acquire and
redeem its own Shares, for example with a view to effect distributions or a return of capital in compliance with the terms
of the Articles and subject the limits set forth by the Companies Act and the SICAR Law. Such redemption is, however,
currently not anticipated and, in case it is made, shall be made in accordance with the procedures set out in the Companies
Act.

Notwithstanding the above, in case a Shareholder would lose its status of Well-Informed Investor, the General Partner

will automatically and immediately cause the repurchase of the Shares of such Shareholder by the Company without
approval from the Shareholder. The purchase price of the repurchased Shares will be determined on the basis of the Net
Asset Value of the Company discounted by fifty per cent (50%) or where the loss of status is solely as a result of a change
in the SICAR Law discounted by twenty-five per cent (25%) and the purchase price will be paid within three (3) months
following the repurchase.

31468

L

U X E M B O U R G

Art. 17. NAV Calculation.
17.1 The “Net Asset Value” of the Company is equal to the value of the total assets of the Company less the value of

the total liabilities of the Company including accounting profits adjusted for items that do not contribute to fair value
(such as post balance sheet events, or deferred amounts that will not materialise) as well as any other adjustments
necessary to determine the Net Asset Value in accordance with Luxembourg GAAP.

17.2 The assets of the Company shall include (without limitation):
(a) all cash on hand or on deposit, including any interest accrued thereon;
(b) all bills and demand notes payable and accounts receivable (including proceeds of securities sold but not delivered);
(c) all shares, stock, debentures, debenture stocks, subscription rights, warrants, options and other securities, financial

instruments and similar assets owned or contracted for by the Company (provided that the Company may make adjust-
ments with regards to fluctuations in the market value of securities caused by trading ex-dividends, ex-rights, or by similar
practices and being understood that derivatives are only used to hedge interest rate and currency fluctuations);

(d) all stock dividends, cash dividends and cash distributions received by the Company to the extent information

thereon is reasonably available to the Company;

(e) all interest accrued on any interest-bearing assets owned by the Company except to the extent that the same is

included or reflected in the principal amount of such assets;

(f) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and
(g) all other assets of any nature including expenses paid in advance.
17.3 The liabilities of the Company shall include (without limitation):
(a) all loans, bills and accounts payable;
(b) all accrued interest on loans of the Company (including accrued fees for commitment for such loans);
(c) all accrued or payable expenses (including administrative expenses, custodian fees and any other agents' fees);
(d) all known liabilities, present and future, including all matured contractual obligations for payments of money or

property, including the amount of any unpaid dividends declared by the Company;

(e) an appropriate provision for future taxation, if any, based on capital and income on the accounting date, and other

reserves (if any) authorized and approved by the General Partner as well as such amount (if any) as the General Partner
may consider to be an appropriate allowance in respect of any contingent liabilities of the Company; and

(f) all other liabilities of the Company of whatsoever nature assessed in accordance with Lux GAAP. In determining

the amount of such liabilities the Company shall take into account all expenses payable by the Company. The Company
may accrue administrative and other expenses of a regular or recurring nature based on an estimated amount for annual
or other periods.

17.4 All valuations shall be made on the basis of the fair value. Such value shall be determined as follows:
(a) units, shares, stocks or equity shares will be valued in accordance with valuation principles consistent with the

International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines (the “IPEV Guidelines”) as amended from time to
time, supported by, amongst others, the EVCA, provided that if the EVCA at any future date does not recommend the
use of the IPEV Guidelines, valuation shall be determined following such alterative guidelines as the EVCA shall then
approve from time to time and provided further that when evaluating any assets which are held subject to any restriction
on transfer or sales, such assets shall be valued at a reasonable discount;

(b) the value of assets denominated in a currency other than USD shall be determined by taking into account the rate

of exchange prevailing at the time of the determination of the Net Asset Value; and

(c) liquid assets comprising cash, treasury bonds and regularly traded money market instruments will be valued at their

market value with interest accrued.

17.5 The General Partner may apply other fair valuation principles for the assets of the Company to the extent that,

in its reasonable discretion, this is justified by circumstances or market conditions subject to such other fair valuation
principles being applied on a consistent basis.

17.6 The General Partner will ensure, in accordance with the administrative agent, the Net Asset Value is calculated

at least annually and as of such dates as is required by law (including, in particular, the SICAR Law) or determined by the
General Partner (each such date being a “Valuation Day”). If, after a Valuation Day, there has been a material change in
the quotations in the markets on which a substantial portion of the Investments of the Company are dealt or quoted, or
if events or new information is brought to the knowledge of the General Partner which imply that a portion or a substantial
portion of the Company's assets should be revalued, the General Partner may, in order to safeguard the Shares of the
Shareholders and the Company, carry out another valuation prior to the next Valuation Day which shall then replace the
prior valuation.

17.7 The Net Asset Value per Share on any Valuation Day equals the total Net Asset Value of the Company divided

by the total number of Shares on that Valuation Day.

17.8 In the absence of bad faith, gross negligence or manifest error, every decision in calculating the Net Asset Value

taken by the General Partner or by the administrative agent, shall be final and binding on the Company and on present,
past or future Shareholders, subject to the year-end audit by the auditor of the Company (réviseur d'entreprises agréé).

31469

L

U X E M B O U R G

17.9 The General Partner may suspend the calculation of the Net Asset Value for:
(a) any period when, in the reasonable opinion of the General Partner, a fair valuation of the assets of the Company

is not practicable for reasons beyond the control of the Company; or

(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which valuation of assets owned

by the Company would be impractical.

17.10 All Shareholders will be promptly informed of such a suspension by the General Partner.

VI. Dissolution - Liquidation

In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will take place with prior authorisation of the CSSF and

be carried out by one or several liquidators, who do not need to be Shareholders, appointed by a resolution of the general
meeting of Shareholders, which will determine their powers and remuneration (all subject to approval by the CSSF in
accordance with the SICAR Law). Unless otherwise provided for in the resolution of the Shareholders or by Companies
Act or the SICAR Law, the liquidators shall realise the assets and payments of the liabilities of the Company on the best
terms it reasonably believes available having been provided a reasonable amount of time to finalise the process.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid

to the Shareholders in in accordance with the PPM.

At the end of the Company's liquidation and redemption process, any amounts that have not been claimed by the

Shareholders will be paid into the Caisse de consignation, which keep them available for the benefit of the relevant
Shareholders during the duration provided for by law.

VII. General provision

In the event of any conflict or ambiguity between this Articles of Association and the PPM, the terms of the PPM shall

prevail.

VIII. Definitions

A Shares

the A Shares in the capital of the Company

Articles of Association

the articles of association of the Company as amended from time to time

Associate

any corporation or undertaking which in relation to the person concerned is a holding
company or parent undertaking or a subsidiary of any such holding company or
undertaking or any partnership which is a subsidiary undertaking of the person
concerned or of any such holding company, provided however that a Portfolio
Company shall not be deemed to be an Associate of the General Partner by reason
only of an Investment by the Company in such Portfolio Company and, for the
avoidance of doubt, the Investment Advisers and their Associates shall be deemed to
be Associates of the General Partner

B Shares

the B Shares in the capital of the Company

Business Day

a day (not being a Saturday or Sunday or a public holiday) on which banks are generally
open for non-automated business in Luxembourg

CSSF

the Commission de Surveillance du Secteur Financier, the Luxembourg supervisory
authority of the financial sector

Code

the United States Internal Revenue Code of 1986, as amended

Commitment

in relation to a Shareholder, the amount committed by it to the Company (and accepted
by the General Partner), whether or not such amount has been advanced in whole or
in part and whether or not it has been repaid to the Shareholder in whole or in part

Companies Act

the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and supplemented

Defaulting Shareholder

has the meaning given to it in Article 7.8

Default Notification

has the meaning given to it in Article 7.8

Drawdown

in relation to a Shareholder, that tranche of its Commitment which it advances to the
Company

ERISA

the United States Employee Retirement Income Security Act of 1974, as amended

Euro or €

the currency used within the European Monetary System which is used as the reference
accounting unit of the Company

Final Closing Date

the latest to occur of:
(a) the date upon which the last Shareholder is admitted to the Company; or
(b) the last date on which an existing Shareholder increases the amount of its
Commitment;
(c) the date upon which the last Shareholder is admitted to any of the additional limited
partnerships or entities established under agreements containing substantially similar
commercial terms to the PPM; or

31470

L

U X E M B O U R G

(d) the date upon which an existing investor increases its Commitment in any of the
entities mentioned in paragraph (c) above,
provided however that such date shall not be any later than twelve (12) months after
the First Closing Date;

First Closing Date

the date on which Shareholders are first admitted to the Company pursuant to the
PPM

General Partner
(actionnaire commandité)

has the meaning given to it in Article 1

Independent Auditor

the réviseur d'entreprise agréé of the Company appointed in accordance with the
SICAR Law

Initiators

Angel Corcóstegui, Enrique de Leyva, Joao Talone and Joao Coelho Borges

Investment

an investment or investments acquired by the Company (either directly or indirectly)
including but not limited to shares, debentures, convertible loan stock, options,
warrants or other securities and loans (whether secured or unsecured) made to any
corporate or other entity

Investment Advisers

Magnum Industrial Partners Dos, S.L. (Madrid), and Magnum Industrial Partners Dois,
Unipessoal Lda (Lisbon), or their successors

Investment Company Act

the US Investment Company Act of 1940

Investor

any person who becomes a Shareholder by signing a subscription agreement in the
Company and any substitute investor who acquires rights and assumes obligation in
succession to an Investor (for so long as such person or substitute investor remains a
Shareholder

Investor Board

a committee comprising, amongst others, representatives of certain Shareholders in
the Company as described in the PPM

Investors' Ordinary Consent the written consent (which may consist of one or more documents each signed by one

or more of the Investors) of Investors who hold Commitments which in aggregate
exceed fifty per cent (50%) of total Commitments

Investors' Special Consent

the written consent (which may consist of one or more documents each signed by one
or more of the Investors) of Investors who hold Commitments which in aggregate
exceed two-thirds (2/3) of total Commitments

IPEV Guidelines

has the meaning given to it in Article 17

Limited Shareholders
(actionnaires commanditaires)

has the meaning given to it in Article 1

Net Asset Value

has the meaning given to it in Article 17

Outstanding Amount

in relation to a Shareholder, the amount of its Commitment which, at the relevant time,
has been drawn down and has not been repaid (or deemed to be repaid) in accordance
with clauses 3.3, 13.2, 14, 15 or 19 of the PPM

Person

any individual, corporation, partnership, limited liability company, joint-stock company,
association, unincorporated organization or other entity

Portfolio Company

any corporate, partnership or other entity in respect of which the Company holds
Investments

Private Placement
Memorandum or PPM

the private placement memorandum relating to the Company, setting out details about
the Company and its governance

Proceeds

amounts determined by the General Partner to be available for distribution by the
Company or (as the case may be) already distributed by the Company

Share Capital

the share capital of the Company from time to time

Shares

any shares of the Company

Shareholder

means collectively the General Partner and the Limited Shareholders

SICAR Law

the Luxembourg law of 15 June 2004 relating to the investment company in risk capital
(SICAR), as amended

Total Commitments

The aggregate amount of the Commitments of the holders of A Shares and B Shares

Undrawn Commitments

in relation to a Shareholder, the amount of its Commitment which, at the relevant time,
remains available for drawdown pursuant to the PPM

Well-Informed Investor

an investor as defined in Article 2 of the SICAR Law

Valuation Day

has the meaning given to it in Article 17

<i>Transitional provisions

1. The first accounting year begins on the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2015.

31471

L

U X E M B O U R G

2. The first annual general meeting of shareholders will be held in 2016.

<i>Subscription and payment

The subscribers have subscribed for the following shares in the Company:

1) Magnum Capital Management S.à. r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 management share
2) Mr Angel Corcostegui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,060 Class B shares
3) Mr Enrique de Leyva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,920 Class B shares
4) Mr Joao Talone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,060 Class B shares
5) Mr Joao Coelho Borges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,960 Class B shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31,001 shares

The shares have been fully paid up by payment in cash, so that the amount of thirty-one thousand and one euro (EUR

31,001) is from now on at the free disposal of the Company, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Statements

The undersigned notary states that the conditions provided for in articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of August 10,

1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-

<i>General meeting of the shareholders

The above-named persons, representing the entire subscribed capital and considering themselves as having received

due notice, have immediately proceeded to an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the meeting has passed the following resolutions:
1. that there be appointed as auditor (réviseur d'entreprises) of the Company: Deloitte Audit, with registered office

at 560, rue de Neudorf,L-2220, Grand Duchy of Luxembourg, for a period ending at the annual general meeting to be
held in 2016.

2. The registered office of the Company is 9A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary made aware the appearing parties of the necessity to appoint a permanent representative of

the General Partner.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, this deed, including the articles of incorporation, is worded in English.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
This deed having been read to the proxyholder of the appearing parties, the said proxyholder signed together with

Us, the notary, this original deed.

Signé: S. WOLTER et C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1173. Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR).

<i>Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015017447/595.
(150021091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Cleansecure S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 31, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 168.216.

Par la présente, nous vous faisons part de notre décision de démissionner, avec effet immédiat, de notre mandat de

Commissaire aux Comptes de votre société, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 168216.

Luxembourg, le 05 janvier 2015.

PERSKY GmbH

Référence de publication: 2015017027/12.
(150020302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

31472

L

U X E M B O U R G

PF Prism S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 158.347.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November.
Before Maître Blanche MOUTRIER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg), acting in re-

placement of Maître Francis KESSELER, notary residing at Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg) who will keep
the original of this deed.

THERE APPEARED:

Wyeth Ayerst S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 51, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-
Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.053,

duly represented by Me Sonia BELAMINE, Avocat à la Cour, with professional address at 2, rue Peternelchen, Howald,

Grand-Duchy of Luxembourg, given under private seal in Luxembourg on November 25, 2014.

Which proxy shall be signed “ne varietur” by the person representing the above named person and the undersigned

notary and shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The prenamed entity Wyeth Ayerst S.à r.l., is the sole Shareholder in PF Prism S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée), existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 51, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 158.347 (the “Company”) incorporated by deed of the notary Jean-Joseph
Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on January 24, 2011, published in the Memorial C,
Recueil des Sociétés et Associations number 763 dated April 19, 2011, (the “Mémorial C”). The articles of incorporation
have been amended for the last time pursuant to a notarial deed of notary Paul BETTIGEN, dated September 30, 2011,
published in the Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2899 dated November 26, 2011.

The appearing party representing the whole corporate capital requires the notary to enact the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of ONE MILLION U.S.

DOLLARS (USD 1,000,000.-) to bring it from its present amount of SEVEN MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOU-
SAND U.S. DOLLARS (USD 7,250,000.-) to the amount of EIGHT MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND U.S.
DOLLARS (USD 8,250,000.-) by the creation and the issuance of ONE MILLION (1,000,000) new shares having a par
value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each (the “New Shares”), having the same rights and obligations as the existing
shares, together with a total issue premium of SIXTY NINE MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND
TWO HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S DOLLARS (USD 69,624,278.-).

The aggregate contribution of SEVENTY MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED

SEVENTY-EIGHT U.S DOLLARS (USD 70,624,278.-) in relation to the New Shares is allocated as follows:

(i) ONE MILLION U.S DOLLARS (USD 1,000,000.-) to the share capital of the Company, and
(ii) SIXTY NINE MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S

DOLLARS (USD 69,624,278.-) to the share premium account of the Company.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to accept that all the ONE MILLION (1,000,000) New Shares of the Company with a

nominal value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each, be subscribed by Wyeth Ayerst S.à r.l., subject to the payment of
an amount of ONE MILLION U.S. DOLLARS (USD 1,000,000.-) allocated to the share capital and the balance to the
share premium account of the Company by way of a contribution in kind consisting of a receivable of an amount of
SEVENTY MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S. DOL-
LARS (USD 70,624,278.-) (the “Receivable”)

<i>Subscription - Payment

Wyeth Ayerst S.à r.l., through its proxy holder declared to fully subscribe to the above mentioned increase of capital

of an amount ONE MILLION U.S. DOLLARS (USD 1,000,000.-) by subscribing to the ONE MILLION (1,000,000) New
Shares of the Company with a nominal value of ONE U.S DOLLARS (USD 1.-) each and allocating to the share premium
account of the Company an amount of SIXTY NINE MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO
HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S DOLLARS (USD 69,624,278.-) the whole being fully paid up by contributing the Re-
ceivable.

<i>Evaluation

The value of the Receivable is set at SEVENTY MILLION SIX HUNDRED TWENTY FOUR THOUSAND TWO

HUNDRED SEVENTY-EIGHT U.S DOLLARS (USD 70,624,278.-).

31473

L

U X E M B O U R G

<i>Evidence of the contribution’s existence

Proof of the contribution’s existence and valuation has been given by:
- a valuation statement issued by the managers of the Company.
- Wyeth Ayerst S.à r.l.’s accounts as at November 25, 2014.

<i>Effective implementation of the contribution

Wyeth Ayerst S.à r.l., contributor represented as stated here-above, expressly declares that:
(i) the Receivable is certain, valid and due;
(ii) it is the sole legal owner and holder of all rights, title and interest in and to the Receivable;
(iii) the Receivable is free from any charge, option, lien, encumbrance or any other third party rights;
(iv) the Receivable is not the object of a dispute or claim;
(v) the Receivable is freely transferable with all the rights attached thereto;
(vi) to its knowledge, Wyeth Ayerst S.à r.l. is not involved in court proceedings for the purposes of bankruptcy,

liquidation, winding-up or transfer of assets to creditors, and there are no facts or circumstances known to Wyeth Ayerst
S.à r.l. on the date hereof, which could lead to such court proceedings;

(vii) to the extent necessary all actions and formalities have been performed and all the necessary consents and approval

have been obtained to allow the transfer of the Receivable; and

(viii) all formalities subsequent to the transfer of the Receivable required under any applicable law have been or will

be carried out in order for the Receivable to be valid anywhere and towards any third party.

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to amend the first paragraph of article 7 of the bylaws of the Company in order to

reflect such increase of capital, which shall be now read as follows:

Art. 7. first paragraph. “The corporate capital of the company is set at EIGHT MILLION TWO HUNDRED FIFTY

THOUSAND U.S. DOLLARS (USD 8,250,000.-) divided into EIGHT MILLION TWO HUNDRED FIFTY THOUSAND
(8,250,000) shares having a par value of ONE U.S. DOLLARS (USD 1.-) each.”

<i>Valuation - Costs

The costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the Company and charged

to it by reason of the present deed are estimated at 7,000.- Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting is adjourned.
The appearing person, acting in her hereabove capacities, and in the common interest of all the parties, does hereby

grant power to any employees of the law firm of the undersigned notary, acting individually, in order to enact and sign
any deed rectifying the present deed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

person the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person,
in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-Sur-Alzette, on the day named at the beginning of this

document.

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by surname, Christian name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre.
Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), agis-

sant en remplacement de Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxem-
bourg) lequel dernier restera dépositaire de la présente minute.

A COMPARU

Wyeth Ayerst S.à r.l., une société à responsabilité ayant son siège social à 51, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 149.053,

représentée par Me Sonia BELAMINE, Avocat à la Cour, ayant son adresse professionnelle au 2, Rue Peternelchen,

L-2370 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg le 25 novembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par la personne représentant la partie comparante susnom-

mée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

La société prénommée Wyeth Ayerst S.à r.l., est l’associé unique de PF Prism S.à r.l., société à responsabilité limitée

ayant son siège au 51, Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès

31474

L

U X E M B O U R G

registre de commerce et des sociétés de et à Luxembourg sous le numéro B 158.347, constituée suivant acte reçu par
acte du Maître Jean-Joseph WAGNER résidant à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en date du 24 janvier 2011, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 763 le 19 avril 2011.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Paul

BETTINGEN en date du 30 septembre 2011 publié au Mémorial C sous le numéro 2899 du 26 novembre 2011.

Laquelle partie comparante représentant l’intégralité du capital social, a requis le notaire instrumentaire de documenter

ce qui suit:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’augmenter le capital souscrit de la Société d’un montant d’UN MILLION U.S. DOLLARS

(USD 1.000.000,-) pour le porter de son montant actuel de SEPT MILLIONS DEUX CENTS CINQUANTE MILLE U.S.
DOLLARS (USD 7.250.000,-)

à un montant de HUIT MILLIONS DEUX CENTS CINQUANTE MILLE U.S. DOLLARS (USD 8,250,000.-) par l’émis-

sion d’UN MILLION (1.000.000) de nouvelles parts sociales ayant une valeur d’UN U.S. DOLLARS (USD 1,-) chacune
(les «Nouvelles Parts Sociales»), ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, ensemble avec
une prime d’émission de SOIXANTE NEUF MILLIONS SIX CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE
DIX-HUIT U.S. DOLLARS (USD 69.624.278,-)

L’apport total de SOIXANTE-DIX MILLIONS SIX CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-

HUIT U.S. DOLLARS (USD 70.624.278,-) relativement aux Nouvelles Parts Sociales est alloué comme suit:

(i) UN MILLION D’ U.S DOLLARS (USD 1.000.000,-) au capital social de la Société et
(ii)  SOIXANTE  NEUF  MILLIONS  SIX  CENT  VINGT-QUATRE  MILLE  DEUX  CENT  SOIXANTE  DIX-HUIT  U.S.

DOLLARS (USD 69.624.278,-) au compte de prime d’émission de la Société.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide d’accepter que les UN MILLION (1.000.000) de Nouvelles Parts Sociales de la Société d’une

valeur nominale d’UN U.S. DOLLARS (USD 1,-) chacune, soient souscrites, moyennant le paiement d’un montant de UN
MILLION D’ U.S DOLLARS (USD 1.000.000,-) alloué au compte capital social et le solde au compte de prime d’émission
de la Société, au moyen d’un apport en nature consistant en une créance d’un montant SOIXANTE-DIX MILLIONS SIX
CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-HUIT U.S. DOLLARS (USD 70.624.278,-) (la “Créance”).

<i>Souscription - Paiement

Wyeth Ayerst S.à r.l., représentée par son mandataire, a déclaré souscrire à l’augmentation de capital susmentionnée

d’un  montant  de  UN  MILLION  D’  U.S  DOLLARS  (USD  1.000.000,-)  en  souscrivant  à  l’ensemble  des  UN  MILLION
(1.000.000) de Nouvelles Parts Sociales de la Société d’une valeur nominale d’UN U.S. DOLLARS (USD 1,-) chacune et
allouant au compte de prime d’émission de la Société un montant de SOIXANTE NEUF MILLIONS SIX CENT VINGT-
QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX-HUIT U.S. DOLLARS (USD 69.624.278,-) le tout étant entièrement
libéré par apport de la Créance.

<i>Evaluation

La valeur de la Créance a été fixée SOIXANTE-DIX MILLIONS SIX CENT VINGT-QUATRE MILLE DEUX CENT

SOIXANTE DIX-HUIT U.S. DOLLARS (USD 70.624.278,-).

<i>Preuve de l’existence de l’apport

Preuve de l’existence et de l’évaluation de cet apport a été donnée par:
- une déclaration sur la valeur de l’apport émise par les gérants de la Société
- les comptes au 25 novembre 2014 de Wyeth Ayerst S.à r.l.

<i>Mise en oeuvre effective de l’apport

Wyeth Ayerst S.à r.l., apporteur représenté comme indiqué ci-dessus, déclare expressément que:
(i) la Créance est certaine, liquide et exigible;
(ii) il est seul propriétaire de tous les droits, titres et intérêts attachés à la Créance;
(iii) la Créance est libre de tout privilège, charge, option, hypothèque, gage ou de tout autre droit de tiers;
(iv) la Créance ne fait l’objet d’aucune contestation ou action en justice;
(v) la Créance est librement transférable, avec tous les droits y attachés;
et;
à sa connaissance, Wyeth Ayerst S.à r.l. ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire de faillite, liquidation, dissolution

ou de transfert d’actifs à ses créanciers, et il n’existe aucun fait ni aucune circonstance connu de Wyeth Ayerst S.à r.l. à
la date des présentes qui pourrait conduire à de telles actions judiciaires;

31475

L

U X E M B O U R G

(vi) pour autant que de besoin, tous les actes ou formalités ont été accomplis et tous les consentements et approbations

nécessaires ont été obtenus afin d’autoriser le transfert de la Créance;

(vii)  l’ensemble  des  formalités  subséquentes  au  transfert  de  la  Créance  requise  en  vertu  des  lois  applicables  sera

accompli afin que l’apport de la Créance soit valable en tout lieu et à l’égard de tout tiers.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide alors de modifier le premier paragraphe de l’article 7 des statuts de la Société pour refléter

l’augmentation de capital, lequel article sera comme suit:

Art. 7. premier paragraphe. «Le capital social de la société est fixé à HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE

MILLE U.S. DOLLARS (USD 8.250.000.-) divisé en HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE (8.250.000) parts
sociales ayant une valeur nominale d’UN U.S. DOLLARS (USD 1.-) chacune.»

Frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte, sont évalués à 7.000 Euros.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
La personne comparante, es qualité qu’elle agit, agissant dans un intérêt commun, donne pouvoir individuellement à

tous employés de l’Étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et signer tous actes rectificatifs des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête e la personne compa-

rante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Esch-Sur-Alzette, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation données à la personne comparante, connue du notaire par nom, prénom, état

et demeure, cette personne a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Belamine, Moutrier Blanche.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 02 décembre 2014. Relation: EAC/2014/16435. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015017581/190.
(150020172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Digital Services XXXIX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.128.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory

seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin on 5 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XXXIX S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

31476

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)

shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

31477

L

U X E M B O U R G

Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of

31478

L

U X E M B O U R G

the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

31479

L

U X E M B O U R G

E. Audit and Supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

31480

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and payment

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the

price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR

15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5.

Januar 2015, ausgestellt in Berlin.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXIX S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

31481

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend

(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.

31482

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

31483

L

U X E M B O U R G

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2 Für  den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

31484

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22 Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

31485

L

U X E M B O U R G

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von

fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

31486

L

U X E M B O U R G

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/709. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé) I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015018026/584.
(150021481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.

CO2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9633 Baschleiden, Poteau de Harlange.

R.C.S. Luxembourg B 146.814.

L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg).

S’est réunie

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CO2 S.A.», ayant son siège social à

L-9633 Baschleiden, Poteau de Harlange, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 146.814, constituée suivant acte reçu par Maître Pierre Probst, notaire de résidence à Ettelbruck, en date
du 10 juin 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1384 du 17 juillet 2009, et dont les
statuts n’ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la "Société").

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Olga TRYASUGINA, serveuse, demeurant à 2, Colette's Päsch,

L- 9169 Mertzig.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  Monsieur  Carlos  SARAIVA,  comptable,  demeurant  professionnellement  à

L-9227 Diekirch, 20, Esplanade.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Olga TRYASUGINA, serveuse, demeurant à 2, Colette's Päsch, L-

9169 Mertzig.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d’acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions possédées par chacun d’eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, par
les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite
liste de présence ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être
soumises avec lui aux formalités d’enregistrement.

II. Que l’intégralité du capital social, qui est fixé à trente-et-un mille euros (EUR 31.000,-) et divisé en cent (100) actions

d’une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-), étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a
pu être fait abstraction des convocations d’usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment
convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour

1. Elargissement de l’objet social et modification subséquente de l’article 2, premier alinéa, des statuts de la Société:

Art. 2. (premier alinéa). «La Société a pour objet l’exploitation d’un Café, Bar-Lounge, Discothèque avec débit de

boissons alcooliques et non-alcooliques.»

2. Modification de l’article 4 des statuts de la Société concernant l’administration de la Société;
3. Modification du pouvoir de signature dans l’article 5, alinéa 7, des statuts de Société;
4. Révocation de Madame Madame Olga TRYASUGINA, de sa fonction d’administrateur unique de la Société et no-

mination de Monsieur Mario Manuel RIO DOS SANTOS en son remplacement;

5. Divers.

31487

L

U X E M B O U R G

Après due considération de, et délibération sur les points portés à l’ordre du jour par l’Assemblée, les résolutions

suivantes ont été adoptées à l’unanimité des voix ci-dessous:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de changer l’objet social de la Société et de modifier en conséquence l’article 2, premier

alinéa, des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 2. (premier alinéa). «La Société a pour objet l’exploitation d’un Café, Bar-Lounge, Discothèque avec débit de

boissons alcooliques et non-alcooliques.»

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 4 des statuts de la Société concernant l’administration de la Société

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «La Société sera administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, qui n'ont

pas besoin d'être actionnaires.

Toutefois, lorsque la Société est constituée par un actionnaire unique ou que, à une assemblée générale des action-

naires, il est constaté que celle-ci n’a plus qu'un actionnaire unique, la composition du Conseil d’Administration peut être
limitée à un membre, appelé «administrateur unique», jusqu'à l’assemblée générale ordinaire suivant la constatation de
l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateur(s) seront nommés par les actionnaire(s), qui détermineront leur nombre et la durée de leur mandat

qui ne pourra excéder six années, respectivement ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment
par une résolution des actionnaire(s).»

<i>Troisième résolution

L’assemblée générale décide de modifier l’article 5, alinéa 7, des statuts de la Société concernant le pouvoir de signature

pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 5. (septième alinéa). «Vis-à-vis des tiers, la Société sera engagée en toutes circonstances, soit par la signature

individuelle de l’administrateur unique, soit si le Conseil d’Administration est composé de trois membres ou plus par la
signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle de l’administrateur-délégué pour ce qui con-
cerne la gestion journalière. La Société sera également engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature
conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui ce pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil
d’Administration, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.»

<i>Quatrième résolution

L’assemblée générale révoque, avec effet immédiat, de Madame Olga TRYASUGINA, serveuse, née le 12 janvier 1977

à Novocheboksarsk (Russie), demeurant à 2, Colette's Päsch, L-9169 Mertzig, de sa fonction d’administrateur unique.

En remplacement de l’administrateur unique, l’assemblée générale décide de nommer Monsieur Mario Manuel RIO

DOS SANTOS, serveur, né le 7 avril 1973 à Moçambique (Afrique), demeurant à L- 9233 Diekirch, 37, avenue de la Gare.

La durée du mandat du nouvel administrateur unique, prénommé, prendra fin lors de l’assemblée générale des ac-

tionnaires qui se tiendra en l’an 2020.

La Société sera engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de l’administrateur unique.

<i>Frais

Les frais, dépens, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la société en raison du

présent acte sont évalués approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Diekirch, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire instrumentaire par leur

nom, prénom, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: O. TRYASUGINA, C. SARAIVA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 30 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1815. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 04 février 2015.

Référence de publication: 2015018782/89.
(150023093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

31488


Document Outline

Abaltex Group S.A.

Alego S.A.

Apollo TR Emerging Markets Holdings (Lux) S.à r.l.

Arcania S.A.

BGV III Feeder 3 SICAV-FIS

Bliss

Cassona Aviation Holding S.A.

Cleansecure S.A.

CO2 S.A.

CONREN Fortune

Cyralex SA

Digital Services XXXIX S.à r.l.

Global Négoce Solutions

Grano S.A.

Halter Ego S.à r.l.

Human Capital Group S.A.

Kingberg Immobilière S.A.

Koonunga Holding S.A.

Lunasun S.A.

LVO S.à r.l.

Magnum Capital II (SCA) SICAR

Meca-Concept SA

Mining Holding Group S.A.

Mitteldeutsche Siedlung 2 S.à r.l.

Natitri S.àr.l.

NjordCap Investment (Luxembourg) S.A.

OCM Luxembourg French Leisure SV

Orion Investment Partners IV Luxembourg S.à r.l.

Orion IV European 1 S.à r.l.

PF Prism S.à r.l.

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s.

Piemont Hotel S.à r.l. et Cie s.e.c.s.

Pratzen S.A.

Prominvest S.A. SPF

Property Augsburg S.à r.l.

RisenSky Solar Energy S.à r.l.

RP Oder S.à r.l.

Scoubidou S.A. SPF

Silver Sea Properties (Hailsham) S.à r.l.

Société d'Investissement et de Développement Economique Familial S.A.

Sumala S.A.

Tiago German Properties GmbH

WHITE Investments