This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 649
10 mars 2015
SOMMAIRE
Agripartes S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31147
Allegro Short Term Bond Fund . . . . . . . . .
31110
Assenagon Substanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31111
Association des Fonctionnaires du Greffe
de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . .
31109
Association du Personnel de l'Administra-
tion Parlementaire de la Chambre des
Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31109
BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31128
BIGA-Holz S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31127
Biochar S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31127
Bios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31128
By Car Inlux Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31128
C. Hypothek Lux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
31131
Degroof Holding Luxembourg S.A. . . . . . .
31135
Delamain S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31135
Deltalux-Business S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
31135
Deluxegroup S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31135
DFR SARL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31133
DGV Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31132
Dixie Five SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31132
Djerba SA SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31132
Dudimmo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31131
DUVAL INVESTMENTS S.A., société de
gestion de patrimoine familial . . . . . . . . . .
31132
Flossbach von Storch . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31111
Ganador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31110
Global Absolute Return OP . . . . . . . . . . . . .
31111
Helca S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31114
Hobevest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31115
Hormuz Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31116
Hüsges Group International S.à r.l. . . . . . .
31116
Iberian Finance S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31117
I-Wo 5 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31151
J Goncalves S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31119
LILIE Caesar S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31146
Mastercraft Language Solutions S.à r.l. . . .
31151
Norpaper Groupe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
31123
OCM Luxembourg French Leisure SV . . .
31120
OG AcquisitionCo 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
31123
Orion IV European 9 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
31123
QS Italy SICAR S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31111
QS PEP S.C.A., SICAR . . . . . . . . . . . . . . . . .
31136
Queensberry House Building . . . . . . . . . . . .
31108
Saverfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31106
Solomo365 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31106
Soparfi MT 2014/480 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31109
StepStone European Fund SCS, SICAV-
FIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31109
Syz Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31107
Syz & Partners Europe . . . . . . . . . . . . . . . . .
31107
Tech Age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31125
Tiago First Frankfurt Properties Limited
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31108
Titanium I Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31110
Turlux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31126
Unden II S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31127
Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg
mbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31146
Worldwide Consultancy S.à r.l. . . . . . . . . . .
31152
31105
L
U X E M B O U R G
Solomo365 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 505.684,00.
Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 171.351.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par les associés en date du 28 novembre 2014 que la personne suivante a démissionné,
avec effet au 26 novembre 2014, de sa fonction de gérant de catégorie A de la Société:
- Monsieur John Paul Keane, né le 28 mai 1976 à Tipperary, Irlande, ayant son adresse professionnelle au 21, rue
Philippe Il, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte également desdites résolutions que la personne suivante a été nommée, avec effet au 26 novembre 2014, et
pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de catégorie A de la Société:
- Monsieur Arie Van Der Veken, né le 11 janvier 1957 à Zaltbommel, Pays-Bas, ayant son adresse professionnelle au
21, rue Philippe Il, L-2340 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Depuis lors, le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
<i>Gérant de catégorie Ai>
- Monsieur Arie Van Der Veken, prénommé,
- Monsieur Michael Enright, né le 21 novembre 1948 à Limerick, Irlande, ayant son adresse professionnelle à Cregg
Castle House, Fermoy, County Cork, Irlande.
<i>Gérant de catégorie Bi>
- SHRM Corporate Services S,à r,l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social
au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg, et enregistrée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 78100,
- Monsieur Nicolaas Johannes Alexander van Zeeland, né le 16 octobre 1970 à La Haye, Pays-Bas, ayant son adresse
professionnelle au 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange, Grand-Duché de Luxembourg,
- Monsieur Jonathan Mark Nye, né le 20 février 1966 à Reading, Royaume-Uni, ayant son adresse professionnelle à
Mossen Vives, 27 Bajos, 08022 Barcelone, Espagne,
- Monsieur James Sene, né le 11 décembre 1970 à Dakar, Sénégal, ayant son adresse professionnelle à Avenida Tibidado
15, 08022 Barcelone, Espagne.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, le 3 février 2015.
Pour extrait conforme
ATOZ SA
Aerogolf Center - Bloc B
1, Heienhaff
L-1736 Senningerberg
Signature
Référence de publication: 2015018475/40.
(150021947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Saverfin S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1219 Luxembourg, 11, rue Beaumont.
R.C.S. Luxembourg B 72.251.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
SAVERFIN S.A.
Alexis DE BERNARDI / Régis DONATI
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015018487/12.
(150021959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31106
L
U X E M B O U R G
Syz Europe S.A., Société Anonyme,
(anc. Syz & Partners Europe).
Capital social: EUR 500.000,00.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 90.322.
L'an deux mille quatorze, le vingt-quatre décembre.
Par-devant nous Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «SYZ & PARTNERS EUROPE», une société anonyme, con-
stituée et régie selon le droit du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social à L-2134 Luxembourg, 54, rue
Charles Martel, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Frank Baden, alors notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 19 décembre 2002, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le
«Mémorial») le 4 janvier 2003, numéro 9, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le
numéro B 90.322 (la «Société»).
L'actionnaire unique de la Société expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:
Financière Syz & Co S.A., société anonyme de droit suisse, ayant son siège social à Baarestrasse 112, CH-6302 Zoug
(Suisse) et inscrite au Registre du commerce de Zoug sous le numéro CH-660.1.815.996-5, est l’actionnaire unique de
la Société;
dûment représentée par Monsieur Florent Denys, juriste, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration reçue à Genève, le 16 décembre 2014.
Ladite procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
L'actionnaire unique de la Société se considérant comme étant dûment convoqué et informé de l’ordre du jour suivant,
l’assemblée générale extraordinaire peut avoir lieu sans avis de convocation.
(i) L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
<i>Agendai>
1. Changer la dénomination sociale de la Société en «SYZ Europe S.A.»;
2. Approuver la modification de l’article 1
er
des statuts de la Société afin de changer la dénomination de la Société en
«SYZ Europe S.A.».
Par conséquent, Financière Syz & Co S.A., agissant en sa capacité d'actionnaire unique de la Société, prend les décisions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’actionnaire unique décide de changer la dénomination de la Société en «SYZ Europe S.A.».
<i>Deuxième résolutioni>
L’actionnaire unique décide de modifier les statuts de la Société pour changer la dénomination de la Société en «SYZ
Europe S.A.», comme décrit ci-dessous.
L’actionnaire unique décide d’approuver la modification de l’article 1
er
des statuts comme suit:
« Art. 1
er
. Il existe entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après créées,
une société anonyme sous la dénomination de SYZ Europe S.A. (la «Société»).»
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance a été levée.
Dont acte fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire soussigné
par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: F. DENYS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 2 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/37. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
31107
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Référence de publication: 2015018520/53.
(150021708) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Queensberry House Building, Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.
R.C.S. Luxembourg B 168.594.
EXTRAIT
Par un contrat en date du 30 janvier 2015, l'associé unique de la Société, Queensberry House S.à r.l., une société à
responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée sous le numéro B 168.435, a transféré les 20.000 (vingt mille) parts sociales d'une
valeur nominale de 1 GBP (une livre sterling) chacune, qu'elle détenait dans la Société à NBIM Caroline BT Limited, une
société incorporée selon les loi d'Angleterre et du Pays de Galles, ayant son siège social sis au 20 Churchill Place Canary
Wharf Londres E14 5HJ, immatriculée sous le numéro 9351485 (le "Transfert").
Il résulte du Transfert que NBIM Caroline BT Limited est désormais l'associé unique de la Société (l'"Associé Unique").
Il a également été pris connaissance de la démission de M. Stefano Cervone, M. Alessandro Cusumano et M. Massi-
miliano Seliziato de leur mandat de gérants de la Société avec effet au 30 janvier 2015.
Il a été décidé de nommer en tant que nouveaux gérants de la Société:
1. M. Per Arne Eriksen, né à Oslo, Norvège, le 18 août 1973, avec adresse professionnelle au 40 Avenue Monterey,
L-2163 Luxembourg;
2. M. Rupert Robinson, né à Barnston, Royaume-Uni, le 4 Mai 1969, avec adresse professionnelle au 40 Avenue Mon-
terey, L-2163 Luxembourg; et
3. M. Giovanni Manfredi, né à Imperia, Italie, le 9 août 1978, avec adresse professionnelle à Queensberry House, 3 Old
Burlington Street, Londres W1S 3AE;
ce, avec effet au 30 janvier 2015 et pour une durée indéterminée.
Il a également été pris connaissance de la démission de KPMG Luxembourg de leur mandat de réviseur d'entreprise
agréé de la Société avec effet au 30 janvier 2015 et de nommer en remplacement Deloitte Audit, société à responsabilité
limitée, avec adresse au 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, avec effet au 30 janvier 2015 et ce, jusqu'à l'assemblée
générale annuelle de la Société approuvant les comptes annuels au 31 décembre 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Référence de publication: 2015018435/32.
(150022176) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Tiago First Frankfurt Properties Limited S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1913 Luxembourg, 12, rue Léandre Lacroix.
R.C.S. Luxembourg B 176.926.
<i>Résolutions prises par l'associé unique avec effet du 1 i>
<i>eri>
<i> janvier 2015i>
Avec effet du 1
er
janvier 2015, l'associé unique a adopté les résolutions suivantes:
1. Approbation de la démission Mr. Kemal Akyel comme gérant de la société avec effet du 1
er
janvier 2015.
2. Nomination de M. Roel Schrijen, né le 30 juin 1973 à Sittard, Pays-Bas, dont l'adresse professionnelle est 12, rue
Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérant de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015 pour une durée
indéterminée.
3. Nomination de Mme. Elena Hadjifyntani, née le 2 octobre 1974 à Odessa, Ukraine, dont l'adresse professionnelle
est 12, rue Léandre Lacroix, 1913 Luxembourg, en tant que gérante de la société, avec effet du 1
er
janvier 2015 pour
une durée indéterminée.
4. Transfert du siège social de la société au 12, rue Léandre Lacroix, L-1913 Luxembourg, avec effet immédiat.
Signature
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015018530/20.
(150021892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31108
L
U X E M B O U R G
Soparfi MT 2014/480, Société Anonyme.
Siège social: L-5884 Hesperange, 304, route de Thionville.
R.C.S. Luxembourg B 189.487.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de corriger comme suit la première ligne de l'en-tête de l'acte publié dans le Mémorial C no 2868 du 10
octobre 2014, page 137628:
<i>au lieu dei> : "Soparfi MT 2014/480, Société à responsabilité limitée.",
<i>lire:i> "Soparfi MT 2014/480, Société Anonyme".
Référence de publication: 2015038335/11.
A.P.A.P. a.s.b.l., Association du Personnel de l'Administration Parlementaire de la Chambre des Dépu-
tés, Association sans but lucratif,
(anc. A.F.G.C. a.s.b.l., Association des Fonctionnaires du Greffe de la Chambre des Députés).
Siège social: L-1728 Luxembourg, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg F 7.670.
RECTIFICATIF
Il y a lieu de rectifier comme suit la publication de l'extrait paru dans le Mémorial C n o 1469 du 6 juin 2014, page
70512 :
1. La première ligne de l'entête :
<i>au lieu de :i> "P.A.P. a.s.b.l., Association du Personnel de l'Administration Parlementaire de la Chambre des Députés,
Association sans but lucratif,",
<i>lire :i> "A.P.A.P. a.s.b.l., Association du Personnel de l'Administration Parlementaire de la Chambre des Députés, Asso-
ciation sans but lucratif,".
2. Au point 1) deuxième ligne :
<i>au lieu de :i> " Art. 1 er . L'association est dénommée "ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION
PARLEMENTAIRE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES", en abrégé P.A.P. a.s.b.l..",
<i>lire :i> " Art. 1 er . L'association est dénommée "ASSOCIATION DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION PARLE-
MENTAIRE DE LA CHAMBRE DES DEPUTES", en abrégé A.P.A.P. a.s.b.l.".
Référence de publication: 2015038337/21.
StepStone European Fund SCS, SICAV-FIS, Société en Commandite simple sous la forme d'une SICAV
- Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.
R.C.S. Luxembourg B 195.045.
Excerpts of the limited partnership agreement of StepStone European Fund SCS, SICAV-FIS, executed on 19 February
2015, before Me Carlo Wersandt, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), and registered in
Luxembourg A.C. 2, on the February 24, 2015, reference 2LAC/2015/3933.
1. Partners who are jointly and severally liable
StepStone European Fund GP, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg on 28 January 2015, having its registered office at 2, place Dargent, L-1413
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 194395 (the General Partner).
2. Name, purpose and registered office
The partnership is formed under the name of “StepStone European Fund SCS, SICAV-FIS”.
The exclusive object of the Partnership is to invest its funds in assets with the purpose of spreading investment risks
and affording its Partners the results of the management of its assets to the fullest extent permitted under the 2007 Act,
but in any case subject to the terms and limits set out in the Memorandum.
Furthermore, the Partnership is entitled to take any action which may seem necessary or useful in order to achieve
or to further the corporate purpose on the basis and within the limits of the 2007 Act.
The address of the registered office of the partnership is at 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.
3. Designation of the manager and statutory powers
The partnership is managed by the General Partner, who is its sole manager.
31109
L
U X E M B O U R G
The partnership is bound towards third parties in all matters by the corporate signature of the General Partner or by
the individual or joint signatures of any other persons to whom authority has been delegated by the General Partner as
the General Partner may determine in its discretion.
4. Dates on which the partnership shall commence and shall end
The partnership has been formed on 19 February 2015. The Partnership has been formed with an unlimited duration,
provided however that the Partnership will automatically be put into liquidation upon the termination of a Compartment
if no further Compartment is active at that time.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015037381/35.
(150042105) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Titanium I Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 141.272.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 23 février 2015i>
Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société (l'Assemblée)
en date du 23 février 2015 que:
- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé pour la période du 1
er
, août 2013
au 23 mai 2014 (date d'ouverture de la liquidation);
- L'Assemblée a décidé d'approuver les comptes d'ouverture de la liquidation à la date du 23 mai 2014 et de donner
décharge aux administrateurs de la Société pour l'exercice de leur mandat pendant la période allant du 1
er
août 2013 au
23 mai 2014;
- L'Assemblée a entendu le rapport du liquidateur daté du 16 février 2015;
- L'Assemblée a entendu et approuvé le rapport du réviseur d'entreprises agréé à la liquidation émis en date du 18
février 2015;
- L'Assemblée a décidé d'approuver le rapport du liquidateur ainsi que les comptes de clôture de liquidation au 28
novembre 2014;
- L'Assemblée, après avoir donné décharge au liquidateur et au réviseur d'entreprises agréé à la liquidation pour
l'exercice de leur mandat pendant et dans le cadre de la liquidation volontaire de la Société, a décidé de clôturer la
liquidation de la Société;
- Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés, pendant une période de 5 ans suivant la publication
de la clôture de la liquidation volontaire, au siège social de la Société, sis au 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
POUR EXTRAIT CONFORME
TITANIUM I SICAV (en liquidation)
Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015036666/31.
(150041473) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Allegro Short Term Bond Fund, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion au 27 février 2015 du fonds commun de placement Allegro Short Term Bond Fund a été
déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Allegro S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015036735/10.
(150042311) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Ganador, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
31110
L
U X E M B O U R G
Axxion S.A. / Banque de Luxembourg S.A.
Unterschriften
<i>Verwaltungsgesellschaft / Verwahrstellei>
Référence de publication: 2015033498/10.
(150037782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 février 2015.
Global Absolute Return OP, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement - Besonderer Teil - Global Absolute Return OP - wurde beim Handels- und Gesellschafts-
register von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Oppenheim Asset Management Services S.à r.l
Référence de publication: 2015032645/9.
(150036183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2015.
Flossbach von Storch, Fonds Commun de Placement.
Le règlement de gestion de Flossbach von Storch modifié au 17. Février 2015 a été déposé au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, février 2015.
Flossbach von Storch Invest S.A.
Signature
Référence de publication: 2015031107/11.
(150034249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2015.
Assenagon Substanz, Fonds Commun de Placement.
Das Verwaltungsreglement wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Assenagon Asset Management S.A.
Référence de publication: 2015036159/8.
(150041227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
QS Italy SICAR S.A., Société Anonyme sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 106.582.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of the month of February.
Before Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in Sanem (Luxembourg).
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders of “QS Italy SICAR S.A.” (the "Company"), a société d’investis-
sement en capital à risque in the form of a public limited liability company having its registered office in L-2449 Luxembourg,
3, Boulevard Royal, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under the number RCS Luxembourg B
106 582, incorporated by deed of the undersigned notary on 8
th
March 2005, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 674 of 8
th
July 2005, which articles of Incorporation have been amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary on 18
th
December 2014, not yet published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.,
The meeting was presided by Mr Anthony Vrenne, employee, professionally residing in 3 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg.
The chairman appointed as secretary Mr Alexandre Warnier, employee, professionally residing in 3 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Johan Orsinet, maître en droit, professionally residing in 3 Boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg.
The bureau having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
31111
L
U X E M B O U R G
I. The shareholders present and represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list
signed by the proxy holders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well
as the proxies will remain attached to this deed to be filed with the registration authorities.
II. It appears from the said attendance list that out of seven million nine hundred and seventy three thousand four
hundred and thirty-two shares (7,973,432) shares in issue, seven million three hundred eighty-five thousand six hundred
ninety-two (7,385,692) (ie 92,64%) shares were present or represented at the present meeting.
III. The extraordinary general meeting was duly convened by convening notices, containing the agenda,, sent by regis-
tered mail on February 11
th
2015, to all the shareholders inscribed on the shareholders register of the Company, so that
the meeting can validly decide on all items of the agenda as set out below:
<i>Agendai>
- Reduction of the issued share capital of the Company by an amount of six hundred and thirty thousand euro (630,000.-
EUR) so as to bring it from to its former amount of seven million nine hundred and seventy three thousand four hundred
and thirty two euro (7,973,432.-EUR) to seven million three hundred and forty three thousand and four hundred thirty
two euro (7,343,432.- EUR) by the cancellation of six hundred and thirty thousand (630,000) shares of a nominal value
of one euro (1.- EUR) each, against payment to the shareholders of an amount of six hundred and thirty thousand euro
(630,000.- EUR) corresponding to the nominal value of the shares cancelled, noting the cancellation of the shares in the
register of shareholders of the Company thereupon;
- Consequential amendment of Article 5. “Capital - Shares” of the articles of association of the Company to reflect
the situation of the share capital of the Company after the decrease of the share capital.
After the foregoing was approved by the general meeting, the following resolutions were adopted.
<i>First resolutioni>
It was decided to reduce the share capital of the Company by the amount of six hundred and thirty thousand euro
(630,000.- EUR) so as to bring it from to its former amount of seven million nine hundred and seventy-three thousand
four hundred and thirty-two euro (7,973,432.-EUR) to seven million three hundred and forty three thousand and four
hundred thirty two euro (7,343,432.- EUR) by the cancellation of six hundred and thirty thousand (630,000) shares of
one euro (1.- EUR) each, against the payment to the shareholders of the amount of six hundred thousand euro (630,000.-
EUR) corresponding to the nominal value of the shares cancelled.
For: all
Against: none
Abstention: none
<i>Second resolutioni>
As a result of the resolution here above, it was resolved to amend the first paragraph Article 5. “Capital - Shares” of
the articles of association of the Company so that it reads as follows:
Art. 5. Capital - Shares.
(a) “The subscribed share capital is set at seven million three hundred and forty-three thousand four hundred and
thirty-two euro (7,343,432.- EUR) divided into seven million three hundred and forty-three thousand four hundred and
thirty-two shares (7,343,432) with a par value of one euro (1.- EUR) per share.”
For: all
Against: none
Abstention: none
The item of the agenda having been resolved upon, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are
estimated at one thousand five hundred euro.
There being no further business, the meeting was closed.
Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the two
versions, the English version will be prevailing.
The document having been read to the meeting, the members of the meeting, all of whom are known to the notary,
by their surnames, first names, civil status and residences, signed together with Us, the notary, the present original deed,
no shareholder expressing the wish to sign.
31112
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quinze, le vingt-trois février.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem,
a été tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de QS Italy S.A. SICAR, une société d’investissement en
capital risque ayant son siège social au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg et inscrite auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106 582, constituée le 8 mars 2005 suivant acte du notaire
soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 674 du 8 juillet 2005, dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois le 18 décembre 2014, non encore publié au Mémorial.
L’assemblée a été présidée par Monsieur Anthony Vrenne, employé privé, demeurant professionnellement au 3 Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le président a désigné comme secrétaire Alexandre Warnier, employé privé, demeurant professionnellement au 3
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Johan Orsinet, maitre en droit, demeurant professionnellement au 3
Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires présents et représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de
présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Cette liste ainsi que
les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises aux formalités d’enregistrement.
II. Il résulte de ladite liste de présence que sur les sept millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent trente-deux
(7.973.432) actions en circulation, sept millions trois cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-douze (7.385.692)
(càd 92,64%) actions étaient présentes ou représentées à la présente assemblée.
III. L'assemblée générale extraordinaire a été dûment convoquée par convocations envoyées par courrier recomman-
dé, contenant l’agenda, le 11 février 2015, à tous les actionnaires inscrits sur le registre des actionnaires de la Société, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour ci-après:
<i>Ordre du jouri>
I. Réduction du capital social de la Société d'un montant de six cent trente mille euros (630.000,- EUR) afin de le porter
de son montant précédent de sept millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent trente deux euros (7.973.432,-
EUR) à sept millions trois cent quarante-trois mille quatre cent trente deux euros (7.343.432,- EUR) par l’annulation de
six cent trente mille (630.000) actions d'une valeur nominale d’un euro (1,- EUR) chacune, contre paiement aux action-
naires d'un montant de six cent trente mille euros (630.000,- EUR) correspondant à la valeur nominale des actions
rachetées et annulées, cette annulation étant inscrite au registre des actionnaires de la Société;
II. Modification corrélative de l’article 5. "Capital - Actions" des statuts de la Société, pour refléter la situation du capital
par actions de la Société.
Après que ce qui précède ait été approuvé par l’assemblée générale, les résolutions suivantes ont été adoptées.
<i>Première résolutioni>
Il a été décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant de six cent trente mille euros (630.000,-
EUR) afin de le porter de sept millions neuf cent soixante-treize mille quatre cent trente deux euros (7.973.432,- EUR)
à sept millions trois cent quarante-trois mille quatre cent trente deux euros (7.343.432,- EUR) par l’annulation de six
cent trente mille (630.000) actions d'une valeur nominale d’un euro (1,-EUR) chacune, contre paiement aux actionnaires
d'un montant de six cent trente mille euros (630.000,- EUR), correspondant à la valeur nominale des actions annulées.
Pour: toutes les voix
Contre: aucune voix
Abstention: aucune
<i>Deuxième résolutioni>
En conséquence de la résolution précédente, il a été décidé de modifier l’article 5. «Capital - Actions» des statuts de
la Société afin qu'il se lise comme suit:
Art. 5. Capital - actions.
(a) «Le capital social émis est fixé à sept millions trois cent quarante-trois mille quatre cent trente deux euros
(7.343.432,- EUR) divisé en sept millions trois cent quarante-trois mille quatre cent trente-deux (7.343.432) actions d'une
valeur nominale d’un euro (1,-EUR) par action.»
Pour: toutes les voix
Contre: aucune voix
Abstention: aucune
31113
L
U X E M B O U R G
Les points fixés à l’ordre du jour ayant fait l’objet des décisions précitées, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société sont estimés
à mille cinq cents euros.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée a été clôturée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare par les présentes que le présent procès-verbal est rédigé
en anglais suivi d’une version française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre les
deux versions, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite à l’assemblée, les membres de l’assemblée, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états
civils et demeures, ont signé avec Nous, notaire, le présent acte original, aucun actionnaire n’ayant exprimé son souhait
de signer.
Signé: A. VRENNE, A. WARNIER, J. ORSINET, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 février 2015. Relation: EAC/2015/4592. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015036583/146.
(150040040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
Helca S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 154.217.
L'an deux mille quinze, le vingt-septième jour du mois de janvier;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’“Assemblée”) de la société anonyme “HELCA S.A.”, établie et
ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 154217, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par
Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 21 juin 2010, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 1708 du 21 août 2010,
et dont les statuts (les “Statuts”) n'ont plus été modifiés depuis lors.
L'Assemblée est présidée par Madame Sonja BEMTGEN, licenciée en criminologie, demeurant professionnellement à
L-1331 Luxembourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
La Présidente désigne Madame Virginie DERAINS, employée, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg,
31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Sarah LOBO, Master of Commerce, demeurant professionnellement à L-1331 Luxem-
bourg, 31, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, la Présidente a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Décision de dissoudre la Société et de mettre la Société en liquidation volontaire;
2. Nomination d'un liquidateur;
3. Détermination des pouvoirs du liquidateur;
4. Décharge accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes, jusqu'à la date de la présente assemblée
des actionnaires.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l’Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l’Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l’intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l’ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
31114
L
U X E M B O U R G
E) Que la présente Assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l’ordre du jour.
Ensuite l’Assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide avec effet immédiat de dissoudre la Société et de la mettre en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide d'accorder décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour
l’exercice de leurs mandats respectifs jusqu'à la date des présentes.
L’Assemblée décide de reconnaître, approuver, ratifier et reprendre au compte de la Société tous les actes pris par
les administrateurs de la Société pour la période débutant à la date de constitution de la Société et se terminant à ce jour
et de renoncer à son droit d’exercer tout recours à l’encontre des administrateurs résultant de leur gestion de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide de nommer la société anonyme de droit panaméen “QANZAS MANAGEMENT INC.”, ayant son
siège social à Panama-City, N°8 Aquiline de la Guardia Street (République de Panama), inscrite au prescrite au Registro
Público de Panama sous le numéro 801880, en tant que liquidateur (le “Liquidateur”) de la Société.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 144 et suivants
de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la “Loi”).
L'Assemblée décide également d'instruire le Liquidateur, dans la limite de ses capacités et selon les circonstances, afin
qu'il réalise l’ensemble des actifs et solde les dettes de la Société.
L'Assemblée décide que le Liquidateur sera autorisé à signer tous actes et effectuer toutes opérations au nom de la
Société, y compris les actes et opérations stipulés dans l’article 145 de la Loi, sans autorisation préalable de l’assemblée
générale des actionnaires. Le Liquidateur pourra déléguer ses pouvoirs pour des opérations spécifiques ou d'autres tâches
à une ou plusieurs personnes ou entités, tout en conservant seul la responsabilité des opérations et tâches ainsi déléguées.
L'Assemblée décide également de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur, pour le compte de la Société en liqui-
dation, afin qu'il exécute, délivre, et effectue toutes obligations relatives à tout contrat ou document requis pour la
liquidation de la Société et à la liquidation de ses actifs.
L'Assemblée décide en outre de conférer pouvoir et autorité au Liquidateur afin d'effectuer, à sa discrétion, tous
versements d'avances en numéraire ou en nature des boni de liquidation aux actionnaires de la Société, conformément
à l’article 148 de la Loi.
Aucun autre point n'étant porté à l’ordre du jour de l’Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés
ne demandant la parole, la Présidente a ensuite clôturé l’Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à neuf cent cinquante euros.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparantes, connues du notaire par leur nom, prénom, état civil et domicile,
lesdites comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: S. BEMTGEN, V. DERAINS, S. LOBO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 29 janvier 2015. 2LAC/2015/2110. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015018912/82.
(150023111) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Hobevest S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 15.574.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
31115
L
U X E M B O U R G
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 4 février 2015.
<i>Pour: HOBEVEST SA
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015018917/16.
(150022703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Hormuz Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.
R.C.S. Luxembourg B 59.041.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 17 décembre 2014 à 16h00i>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hormuz Holding S.A. a pris les résolutions suivantes:
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société Hormuz Holding S.A., en liquidation, a
définitivement cessé d'exister. Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
ans suivant la liquidation auprès de la société PARFININDUS S.à r.l., 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015018919/15.
(150022500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Hüsges Group International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-3378 Liwigen, route de Bettembourg.
R.C.S. Luxembourg B 157.471.
AUFLÖSUNG
Im Jahre zweitausendfünfzehn, den zweiundzwanzigsten Januar.
Vor Maître Jean SECKLER, Notar mit Amtssitz zu Junglinster, Großherzogtum vom Luxemburg, unterzeichnet.
Ist erschienen:
Hüsges GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in D-47877 Willich, 20, Halskestrasse,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichtes Krefeld unter der Nummer HRB 11349,
„die Komparentin“
hier vertreten durch Herrn Georges THINNES, Steuerberater, beruflich wohnhaft in L-1653 Luxemburg, 2, avenue
Charles de Gaulle,
„der Bevollmächtigte“
auf Grund einer privatschriftlichen Vollmacht welche, nach „ne varietur“ Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten
und den unterzeichneten Notar, gegenwärtiger Urkunde beigefügt bleiben wird, um mit ihr einregistriert zu werden.
Die Komparentin, vertreten wie vorgenannt, erklärt und bittet, den Notar zu beurkunden:
1. Dass die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Hüsges Group International S.à r.l. (die „Gesellschaft“), R.C.S.
Luxemburg B 157471, mit Gesellschaftssitz in L-3378 Liwingen, route de Bettembourg, am 14. Dezember 2010 gegründet
wurde laut Urkunde aufgenommen durch Maître Jean-Joseph WAGNER, Notar mit dem Amtssitz in Sassenheim, veröf-
fentlicht im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ Nr. 288 vom 11. Februar 2011.
2. Dass das Kapital der Gesellschaft EUR 12.500 (zwölftausendfünfhundert Euro) beträgt, eingeteilt in 12.500 (zwölf-
tausendfünfhundert) Anteile mit einem Nennwert von EUR 1 (ein Euro) je Anteil, vollständig eingezahlt.
3. Dass die Komparentin Besitzerin sämtlicher Anteile der Gesellschaft, die das Kapital darstellen, ist.
4. Dass die Komparentin, als alleinige Gesellschafterin, hiermit ausdrücklich erklärt, die Gesellschaft mit Rückwirkung
auf den 31. Dezember 2014 aufzulösen.
5. Dass die Aktivität der Gesellschaft aufgehört hat, dass die alleinige Gesellschafterin sämtliche Aktiva übernimmt und
dass sie als Liquidator der Gesellschaft sämtliche bekannten und unbekannten Passiva der Gesellschaft auszahlen wird, so
dass die Liquidation der Gesellschaft abgeschlossen ist.
6. Dass die Komparentin den Geschäftsführern Entlastung erteilt.
31116
L
U X E M B O U R G
7. Dass sämtliche Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während einer Dauer von fünf Jahren im Gesellschaftssitz
von BDO Tax & Accounting aufbewahrt werden.
WORÜBER URKUNDE, aufgenommen in Luxemburg am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung alles Vorstehende an den Bevollmächtigten der Komparentin, dem Notar nach Namen, gebräu-
chlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat derselbe mit Uns Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Georges THINNES, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 janvier 2015. Relation GAC/2015/753. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015018921/42.
(150023147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Iberian Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 62.007,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 158.574.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of the month of December.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of "Iberian Finance S.à r.l.", a "société à responsabilité
limitée", having its registered office at 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, incorporated by deed of Maître Francis
Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, enacted on December 8, 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 616 dated April 1, 2011, page 29547, and registered with the Luxembourg Trade Register under
section B 158.574.
The meeting is chaired by Mrs Arlette Siebenaler, employee, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mrs Annick Braquet, employee, residing
professionally in Luxembourg.
The chairman requests the notary to act that:
I. The sole shareholder present or represented and the number of shares he owns is shown on an attendance list.
That list and the proxy, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with
the minutes.
II. It appears from the attendance list attached that the sole shareholder owing 44.975 (forty-four thousand nine
hundred seventy-five) shares representing the entire capital of the Company is present or represented at the meeting.
III. The sole shareholder has been duly convened to the meeting.
IV. The meeting can therefore consider and vote on the items concerned on the agenda of the meeting, which is as
follows:
<i>Agendai>
1. To convert the share capital of the Company from EUR to USD with retroactive effect as at January 1, 2014;
2. To fix the number of shares and the par value according to the conversion;
3. To amend article 5 of the Articles of Association.
After the foregoing was approved by the meeting, the sole shareholder decides what follows:
<i>First resolution:i>
The meeting decides to convert the share capital of the Company from euros (EUR) into United States dollars (USD),
with retroactive effect as at January 1, 2014 so that the capital of EUR 44,975 (forty-four thousand nine hundred seventy-
five euros) is converted, at an exchange rate applicable on January 1, 2014, i.e. USD 1 (one dollar) for EUR 0.72532 (zero
point seven two five three two euros), into USD 62,007 (sixty-two thousand seven United States dollars).
<i>Second resolution:i>
The meeting decides to increase the number of shares from 44,975 (forty-four thousand nine hundred seventy-five)
to 62,007 (sixty-two thousand seven) and to fix, after conversion, the par value of the shares at USD 1 (one dollar) each.
<i>Third resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend Article 5 of the Articles of Association
to read as follows:
31117
L
U X E M B O U R G
Art. 5. The subscribed share capital of the Company is set at USD 62,007 (sixty-two thousand seven United States
dollars) represented by 62,007 (sixty-two thousand seven) shares, with a nominal value of USD 1 (one United States
dollar) each.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,500.-There being no further business before the meeting,
the same was thereupon adjourned.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la traduction française:
L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée "Iberian Finance S.à
r.l.", ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et
des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 158.574, constituée suivant acte reçu par Maître Francis Kesseler, notaire
de résidence à Esch/Alzette, le 8 décembre 2010, publié au Mémorial C numéro 616 du 1
er
avril 2011, page 29547.
L'assemblée est présidée par Mme Arlette Siebenaler, demeurant professionnellement à Luxembourg.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutateur Mme Annick Braquet, demeurant
professionnellement à Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I.- L‘associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste de
présence. Cette liste et la procuration, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l’acte.
II. Ainsi qu'il résulte de ladite liste de présence, l’associé unique détenant quarante-quatre mille neuf cent septante-
cinq (44.975) parts sociales, représentant l’intégralité du capital souscrit, est présent ou représenté à la présente assemblée
générale extraordinaire.
III.- L’associé unique a été dûment convoqué à la présente assemblée générale extraordinaire.
IV.- L'assemblée peut donc délibérer et voter sur les points suivants de l’ordre du jour de l’assemblée générale ex-
traordinaire:
<i>Ordre du jour:i>
1. Convertir le capital de la société de l’EUR en USD avec effet rétroactif au 1
er
janvier 2014;
2. Fixer le nombre de parts sociales et la valeur comptable de chaque part sociale suite à la conversion;
3. Modifier l’article 5 des statuts.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, l’associé unique décide ce qui suit:
<i>Première résolution:i>
L’assemblée décide de convertir le capital social de la Société d’euros (EUR) en dollars américains (USD) avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 2014 de sorte que le capital de quarante-quatre mille neuf cent soixante-quinze euros (EUR
44.975) soit converti au taux applicable au 1
er
janvier 2014, c’est-à-dire un dollar (USD 1) pour zéro virgule sept deux
cinq trois deux (EUR 0.72532), en soixante-deux mille sept dollars américains (USD 62.007).
<i>Deuxième résolution:i>
L’assemblée décide d’augmenter le nombre de parts sociales de quarante-quatre mille neuf cent soixante-quinze
(44.975) à soixante-deux mille sept (62.007) pour atteindre après conversion une valeur nominale de un dollar (USD 1)
chacune.
<i>Troisième résolution:i>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier l’article 5
des statuts pour lui donner la teneur suivante:
31118
L
U X E M B O U R G
" Art. 5. Le capital social est fixé à soixante-deux mille sept dollars américains (USD 62.007) représenté par soixante-
deux mille sept (62.007) parts sociales d’une valeur de un dollar américain (USD 1) chacune.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge
en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de EUR 1.500.-
Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande des comparants le présent acte est rédigé
en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
Signé: A. SIEBENALER, A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63363. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, 3 février 2015.
Référence de publication: 2015018928/112.
(150022471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
J Goncalves S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-4782 Pétange, 23, rue de l'Hôtel de Ville.
R.C.S. Luxembourg B 194.175.
STATUTS
L'an deux mille quatorze.
Le douze décembre.
Pardevant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette.
A COMPARU
Monsieur Francisco GONÇALVES DE JESUS, né à St.Etienne le 09 mai 1971
demeurant à L-4782 Pétange, 23, rue de l’Hôtel de Ville
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée
unipersonnelle, qu'il déclare constituer.
Art. 1
er
. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de:
J GONCALVES S. à r.l.
Art. 2. La société a pour objet l’exploitation d'une entreprise de plâtrerie et de façade.
Elle pourra faire toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières, se rattachant
directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet ou qui pourraient en faciliter la réalisation et le dévelop-
pement.
Art. 3. Le siège de la société est établi à Pétange.
Art. 4. Le capital social est fixé à DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (€ 12.500,-), représenté par CENT (100)
PARTS SOCIALES d'une valeur nominale de CENT VINGT-CINQ EUROS (€ 125,-) chacune.
Art. 5. La durée de la société est indéterminée.
Art. 6. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l’unique associé ou les associés qui déter-
mineront leurs pouvoirs et la durée de leurs fonctions. Ils sont rééligibles et révocables ad nutum et à tout moment.
Art. 7. La société n'est pas dissoute par le décès, l’interdiction ou la faillite de l’unique ou d'un associé.
Art. 8. Lorsque la société comporte plus d'un associé, les parts sociales sont librement cessibles entre associés, la
cession entre vifs tant à titre gratuit qu'à titre onéreux à un non-associé ne pourra se faire que de l’assentiment de tous
les associés.
La transmission pour cause de mort requiert l’agrément des propriétaires de parts sociales représentant les trois
quarts des droits appartenant aux survivants qui ont en toute hypothèse un droit de préemption. Cet agrément n'est pas
nécessaire en cas de transmission à un héritier réservataire ou au conjoint survivant.
31119
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Un associé sortant ainsi que les héritiers ou ayants-droit et créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun
prétexte, requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l’exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées générales.
Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Art. 11. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par le ou les gérants en exercice, à moins que
l’associé unique ou l’assemblée générale des associés n'en décide autrement. Le résultat, actif de la liquidation, après
apurement de l’intégralité du passif, sera transmis à l’associé unique ou sera réparti entre les propriétaires des parts
sociales, au prorata du nombre de leurs parts.
Art. 12. Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2014.
<i>Souscriptioni>
Le capital social a été souscrit comme suit:
Monsieur Francisco GONÇALVES DE JESUS prénommé
CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
TOTAL: CENT PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été libérées intégralement libérées comme suit:
- par un apport de matériels, tels qu'énumérés sur une liste annexée, le tout évalué par le comparant à ONZE MILLE
CINQ CENTS EUROS (11.500,-€)
- par des versements en espèces de MILLE EUROS (1.000,-€)
Le comparant déclare que les prédits apports sont à la disposition de la société.
<i>Fraisi>
Le coût des frais, dépenses, charges et rémunérations sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge de la
société en raison de sa constitution s'élève approximativement à NEUF CENT EUROS (€ 900,-).
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Les statuts de la société ainsi arrêtés, le comparant, unique associé de la société se considérant comme réunie en
assemblée générale, a pris les résolutions suivantes:
I.- Est nommé gérant administratif de la société: Monsieur Francisco GONÇALVES DE JESUS, prénommé
II.- Est nommé gérant technique de la société: Monsieur Daniel Jorge FERREIRA DA COSTA, né à São Pedro de
Castelões/Vale de Cambra le 13 octobre 1975
demeurant à L-1941 Luxembourg, 317, route de Longwy
ici présent et acceptant sa nomination
III.- La société est engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux gérants.
IV.- Le siège social de la société se trouve à: L-4782 Pétange, 23, rue de l’Hôtel de Ville.
DONT ACTE, fait et passé à Esch/Alzette, en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, il a signé avec Nous Notaire le présent acte.
Signé: Gonçalves de Jesus, Ferreira da Costa, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 15 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17189. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Santioni A.
POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015018950/77.
(150022475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
OCM Luxembourg French Leisure SV, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 174.521.
In the year two thousand and fifteen, on the nineteenth day of January,
before Us, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
31120
L
U X E M B O U R G
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of OCM Luxembourg French Leisure SV, a Lu-
xembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 26A, Boulevard
Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.00 and registered with the
Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 174.521 (the Company), incorporated following a
deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on December 31, 2012,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the Memorial) number 512 of March 1, 2013. The
articles of association of the Company (the Articles) have not been amended.
There appeared
1. OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 151.276,
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a power of attorney given under private seal; said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration, and
2. OCM Luxembourg VOF S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée)
having its registered office at 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 136.233,
here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by
virtue of a power of attorney given under private seal; said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration,
being all the shareholders of the Company representing its entire share capital (the Shareholders).
The Shareholders, represented as stated above, have requested the undersigned notary to enact the following:
<i>Agendai>
1. Waiver of convening notice requirement;
2. Change of the signature regime of the Company;
3. Subsequent change of article 16 of the Articles to henceforth read as follows:
“ Art. 16. The Company will be bound in all circumstances by the signature of any manager of the Company, or, as
the case may be, by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom general or specific powers have been validly
delegated in accordance with article 14 of these Articles.”
and
4. Miscellaneous.
Now, therefore, the appearing parties, acting through their proxyholders, have requested the undersigned notary to
record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders waive any convening
notice requirement, consider themselves as duly convened, and declare having perfect knowledge of the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to change the signature regime of the Company so that the Company will henceforth be
bound in all circumstances by the signature of any one manager of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to amend article 16 of the Articles to henceforth read as follows:
“ Art. 16. The Company will be bound in all circumstances by the signature of any manager of the Company, or, as
the case may be, by the single or joint signature(s) of any person(s) to whom general or specific powers have been validly
delegated in accordance with article 14 of these Articles.”
There being no further business, the Meeting is closed.
<i>Estimatei>
The expenses, costs, fees, and charges of any kind whatsoever, which will have to be borne by the Company in relation
to this deed, are estimated at approximately EUR 950.-.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that upon request of the appearing
parties, the present deed is worded in English, followed by a French version, and in case of divergences between the
English and the French versions, the English version will prevail.
31121
L
U X E M B O U R G
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholders of the persons appearing, such proxyholders signed together
with the notary the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le dix-neuvième jour du mois de janvier,
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
s'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés d’OCM Luxembourg French Leisure SV, une société
à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,00 et immatriculée auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 174.521 (la Société), constituée selon un acte de Maître Henri Hellinckx,
notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 31 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (le Mémorial) numéro 512 le 1 mars 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) n’ont pas
été modifiés depuis.
ONT COMPARU:
1. OCM Luxembourg OPPS VIII S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège
social au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 151.276,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; ladite procuration, après signature "ne varietur" par le
mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
celui-ci aux formalités de l’enregistrement, et
2. OCM Luxembourg VOF S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social
au 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 136.233,
ici représentée par Monsieur Max MAYER, employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; ladite procuration, après signature "ne varietur" par le
mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec
celui-ci aux formalités de l’enregistrement,
Etant tous les associés de la Société et représentant la totalité du capital social de la Société (les Associés).
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont priés le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification du régime de signature de la Société;
3. Modification subséquente de l’article 16 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
« Art. 16. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de tout gérant de la Société, ou, selon le cas
de figure, par la seule signature ou les signatures conjointes de(s) tout(es) personne(s) à laquelle des pouvoirs généraux
ou spécifiques auront été délégués en accord avec l’article 14 des présents Statuts.»
et
4. Divers.
Sur ce, les parties comparantes, représentées par leur mandataire, ont priés le notaire instrumentant d’acter les ré-
solutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
La totalité du capital social de la Société étant représentée, les Associés renoncent aux formalités de convocation, se
considérant eux-mêmes comme ayant étés dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite connaissance de l’ordre du
jour.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le régime de signature de la Société afin d’établir que la Société sera désormais
engagée en toutes circonstances par la signature de tout gérant de la Société.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident de modifier l’article 16 des Statuts qui aura désormais la teneur suivante:
31122
L
U X E M B O U R G
« Art. 16. La Société est engagée en toutes circonstances par la signature de tout gérant de la Société, ou, selon le cas
de figure, par la seule signature ou les signatures conjointes de(s) tout(es) personne(s) à laquelle des pouvoirs généraux
ou spécifiques auront été délégués en accord avec l’article 14 des présents Statuts.»
Plus aucun point ne figurant à l’ordre du jour, l’Assemblée est close.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant total des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte est estimé à environ 950,- EUR.
<i>Déclarationi>
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la requête des parties comparantes,
le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et en cas de divergences entre la version anglaise et
la version française, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, rédigé et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire
instrumentant, le présent acte original.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 22 janvier 2015. Relation GAC/2015/647. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015019100/132.
(150022194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Orion IV European 9 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 14.750,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 182.391.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1
er
février 2015 et se
trouve désormais au:
- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Orion IV European 9 S.àr.l.
Signature
Référence de publication: 2015019093/17.
(150022249) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Norpaper Groupe S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. OG AcquisitionCo 1 S.à r.l.).
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 185.720.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first of January.
Before us the undersigned Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
Is held
an Extraordinary General Meeting of the sole shareholder of OG AcquisitionCo 1 S.à r.l., a private limited liability
Company (société à responsabilité limitée), having its registered office at L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider,
R.C.S. Luxembourg number B185720, incorporated by Notary Martine Schaeffer on 6 March 2014, published in the
Memorial C number 1435 of 4 June 2014, which articles of association have not been amended since (the Company).
The meeting is presided by Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,
avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Marilyn KRECKÉ, private employee, residing
professionally at the same address.
31123
L
U X E M B O U R G
The chairman requests the notary to record:
That the board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the sole shareholder present or represented as well as the number of shares held by him are indicated on an
attendance list, which after having been signed by the sole shareholder or its proxy-holder, shall remain annexed to this
document as well as the proxy and shall be filed at the same time with the registration authorities.
That it results from the said attendance list that all the issued shares are represented, so that the present meeting can
take place without prior convening notices.
That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads
as follows:
<i>Agendai>
1. Change of name of the Company from OG AcquisitionCo 1 S.à r.l. into Norpaper Groupe S.à r.l.;
2. Amendment of article 1 of the articles of association of the Company in order to reflect the resolution adopted
under item 1;
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The meeting decides to change the name of the Company from OG AcquisitionCo 1 S.à r.l. into Norpaper Groupe
S.à r.l..
<i>Second resolutioni>
As a consequence of the foregoing resolution, the meeting decides to amend article 1 of the articles of association of
the Company which shall be read as follows:
“ Art. 1. Name. There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under
the name Norpaper Groupe S.à r.l. (hereafter the Company):
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed, are estimated at approximately one thousand four hundred Euros (EUR 1,400.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt et un janvier.
Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
Se réunit
l’assemblée générale extraordinaire de l’associé unique de la société à responsabilité limitée OG AcquisitionCo1 S.à
r.l., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider, R.C.S. Luxembourg numéro B185720,
constituée suivant acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, le 6 mars 2014, publié au
Mémorial C numéro 1435 du 4 juin 2014, et dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis(la Société).
La séance est ouverte sous la présidence de Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750
Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
Le président désigne comme secrétaire et l’assemblée choisit comme scrutatrice Marilyn KRECKÉ, employée privée,
demeurant professionnellement à la même adresse.
Le président prie le notaire d'acter:
Que l’associé unique présent ou représenté et le nombre de parts sociales qu'il détient sont renseignés sur une liste
de présence, qui après avoir été signée par l’associé unique ou son mandataire, restera annexée à l’acte ainsi que la
procuration pour être enregistrés en même temps.
Qu'il appert de la liste de présence que toutes les parts sociales émises sont représentées à la présente assemblée, de
sorte que l’assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l’ordre du jour.
Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur l’ordre du jour suivant:
31124
L
U X E M B O U R G
<i>Ordre du jour:i>
1. Modification de la dénomination sociale de la Société de OG AcquisitionCo 1 S.à r.l. en Norpaper Groupe S.à r.l.;
2. Modification de l’article 1 des statuts de la Société afin de refléter la résolution adoptée au point 1 de l’agenda;
Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix, les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de OG AcquisitionCo 1 S.à r.l en Norpaper
Groupe S.à r.l.
<i>Deuxième résolutioni>
Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l’assemblée décide de modifier le premier
alinéa de l’article 1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée sous la dénomination
Norpaper Groupe S.à.r.l. (ci-après la Société).
<i>Évaluation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
s’élève à environ mille quatre cents Euros (EUR 1.400.-).
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu’à la requête des
comparants, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française; à la requête des mêmes comparants et
en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg à la date pré-mentionnée.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 28 janvier 2015. 2LAC/2015/2042. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Yvette Thill.
POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au
Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015019102/98.
(150022782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Tech Age, Société Anonyme.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 53, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 110.562.
<i>Extrait de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20/01/2015 à 15 Hi>
Il ressort du procès- verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 20/01/2015, que l'assemblée générale a, à l'una-
nimité:
1- Décidé de reconduire le mandat des administrateurs, pour une durée de 6 années. La date de l'expiration de leurs
mandats prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Il s'agit de reconduire:
a) Monsieur MARBAIX Christian, demeurant professionnellement au 53 Route d'Arlon L-1140 LUXEMBOURG
b) Monsieur Jean MARBAIX demeurant 1, Route de Sezanne F-10 370 VILLENAUXE LA GRANDE.
c) Monsieur PANZETTA Jérémy , demeurant au 33 Rue de la Prairie F-77 340 PONTAULT-COMBAULT.
2- Décidé de reconduire le mandat de l'administrateur délégué, pour une durée de 6 années. La date de l'expiration
de son mandat prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021. Il s'agit de reconduire:
Monsieur MARBAIX Christian, demeurant professionnellement au 53 Route d'Arlon L-1140 Luxembourg.
3- Décidé de reconduire le mandat du commissaire aux comptes Mr Jean GREFF, demeurant 141 Rue Nationale
F-57600 Forbach, pour une durée de 6 années.
La date de l'expiration de son mandat prendra effet à l'assemblée générale qui se tiendra en 2021.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus par leur nom, prénom usuel, état et
demeure, les comparants ont tous signé la présente minute
31125
L
U X E M B O U R G
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 20/01/2015.
Mr Christian MARBAIX / Mme C. SIMON / Mme Aurélie VERDE
<i>Président / Secrétaire / Scrutateuri>
Référence de publication: 2015019302/28.
(150022595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Turlux, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8315 Olm, 3, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg B 23.824.
DISSOLUTION
L'an deux mil quinze, le sept janvier.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange.
Ont comparu:
1) Monsieur Yusuf Levent DEMIRCIGIL, retraité, né à Kadiköy (Turquie), le 1
er
janvier 1950, demeurant à L-8315
Olm, 3, rue du Commerce,
2) Monsieur Kaya DEMIRCIGIL, consultant informatique, né à Trèves (Allemagne), le 19 janvier 1989, demeurant à
F-75015 Paris (France), 8, rue Corbon, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de mandataire de
3) Monsieur Mete DEMIRCIGIL, étudiant, né à Luxembourg, le 13 novembre 1994, demeurant à L-8315 Olm, 3, rue
du Commerce,
en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Olm, le 29 décembre 2014,
laquelle prédite procuration, après avoir été paraphée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire
instrumentant, restera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles,
Lesquels comparants, ès-qualité qu’ils agissent, ont exposé au notaire instrumentant et l’ont requis d’acter ce qui suit:
Que "TURLUX" -Turquie/Luxembourg société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-8315 Olm,
3, rue du Commerce, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.824 (ci-
après la «Société»), a été constituée suivant acte reçu par Maître Aloyse BIEL, notaire alors de résidence à Differdange,
en date du 25 janvier 1986, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 88 du 10 avril 1986, et
dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu suivant acte reçu par le même notaire alors de
résidence à Capellen, en date du 19 février 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
374 du 26 mai 1999.
Que la Société a un capital social converti en euros de vingt-quatre mille sept cent quatre-vingt-neuf euros et trente-
cinq cents (24.789,35,-EUR) divisé en mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et soixante-
dix-neuf cents (24,79 EUR) chacune.
Que le comparant Monsieur Yusuf Levent DEMIRCIGIL, préqualifié, est le seul et unique associé, représentant l’inté-
gralité du capital social de la Société en vertu des statuts de la Société, tels que publiés, ainsi que de deux cessions de
parts sous seing privé du 29 décembre 2014, aux termes desquelles Messieurs Mete DEMIRCIGIL et Kaya DEMIRCIGIL,
préqualifiés, ont déclaré chacun céder l’intégralité de leurs cent vingt-cinq (125) parts sociales de la Société à leur coassocié
Monsieur Yusuf Levent DEMIRCIGIL, préqualifié, ce acceptant, aux prix convenus entre parties, ce dont quittance et titre
par les cédants.
<i>I. Constat de cessions de partsi>
Ensuite, Monsieur Yusuf Levent DEMIRCIGIL, prénommé, en sa qualité de gérant de la Société, déclare accepter les
prédites cessions du 29 décembre 2014 au nom de la Société, conformément à l’article 1690 nouveau du Code civil.
Il a encore déclaré n'avoir entre ses mains aucune opposition ou empêchement qui puisse arrêter l’effet des susdites
cessions.
Les comparants constatent les cessions de parts prémentionnées comme dûment notifiées.
<i>II. Décisions de l’associé uniquei>
Ensuite, Monsieur Yusuf Levent DEMIRCIGIL préqualifié, désormais seul associé de «TURLUX» - Turquie/Luxembourg
société à responsabilité limitée, agissant en lieu et place de l’assemblée générale des associés, a requis le notaire soussigné
de documenter ses résolutions suivantes:
Le comparant, en tant qu’associé unique prononce la dissolution anticipée de la société «TURLUX» - Turquie/Lu-
xembourg société à responsabilité limitée avec effet au 31 décembre 2014.
Il déclare que l’activité de la Société a cessée, avoir pleine connaissance des statuts de la Société et connaître parfai-
tement la situation financière de la Société.
31126
L
U X E M B O U R G
Il déclare encore en sa qualité de liquidateur de la Société que le passif connu de la Société a été payé ou provisionné,
que l’associé unique est investi de tout l’actif et qu’il s'engage expressément à prendre en charge tout passif pouvant
éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour avant tout paiement à sa personne;
partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
L’associé unique donne décharge pleine et entière au gérant pour son mandat jusqu'à ce jour.
Les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l’ancien siège de la Société.
Sur base de ces faits, le notaire a constaté la dissolution de la Société.
Dont acte, fait et passé à Hesperange, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentant par noms, prénoms,
états et demeures, ils ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Y. L. Demircigil, K. Demircigil, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 15 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1118. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i>
(signé): Carole Frising.
POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.
Hesperange, le 03 février 2015.
Référence de publication: 2015019314/67.
(150022400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Unden II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 120.965.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
UNDEN II S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019321/17.
(150022705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
BIGA-Holz S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6419 Echternach, 4, rue de la Chapelle.
R.C.S. Luxembourg B 159.040.
Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, den 04.02.2015.
Référence de publication: 2015019464/10.
(150023437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Biochar S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 152.006.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration prises en date du 3 février 2015i>
<i>Première résolutioni>
Afin de se conformer aux dispositions de la loi de 28 juillet 2014, le Conseil d'Administration décide de nommer la
société Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son
31127
L
U X E M B O U R G
siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 18433, en qualité de dépositaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BIOCHAR S.A.i>
Référence de publication: 2015019465/15.
(150023539) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 150.768.
Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung nebst den gesetzlich vorgeschriebenen Anhängen für das Ge-
schäftsjahr endend zum 31. Dezember 2013 wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 2. Februar 2015.
<i>Für die Gesellschaft
Ein Bevollmächtigteri>
Référence de publication: 2015019463/13.
(150023521) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Bios S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-2714 Luxembourg, 2, rue du Fort Wallis.
R.C.S. Luxembourg B 3.055.
<i>Extrait des résolutions du Collège des Liquidateurs prises en date du 3 février 2015i>
<i>Première résolutioni>
Afin de se conformer aux dispositions de la loi de 28 juillet 2014, le Collège des Liquidateurs décide de nommer la
société Compagnie Financière de Gestion Luxembourg S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son
siège social au 40, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Com-
merce et des Sociétés de et à Luxembourg, sous le numéro B 18433, en qualité de dépositaire.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour BIOS (en liquidation)i>
Référence de publication: 2015019466/15.
(150023537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
By Car Inlux Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9780 Wincrange, Maison 48.
R.C.S. Luxembourg B 194.243.
STATUTS
L’an deux mil quinze, le vingt-neuf janvier
Par devant Maître Joëlle SCHWACHTGEN, notaire de résidence à Wiltz.
Ont comparu:
1) Monsieur Mohamed YOUJIL, né le 21 novembre 1987 à Libramont-Chevigny (B), demeurant à B-6660 Houffalize,
14, Route de Bastogne
2) Monsieur Ben Abdellah EL KAIDI, né le 12 octobre 1970 à Jerada (Maroc), demeurant à B-4020 Jupille (B), 206, Rue
Charlemagne, ici valablement représenté par Monsieur Mohamed YOUJIL prénommé, en vertu d’une procuration sous
seing privé, donnée à Liège le 17 janvier 2015 signée «NE VARIETUR» annexée au présent acte pour être enregistrée
avec celui-ci.
Lesquels comparants, présents ou tel que représentés, ont requis le notaire instrumentant de dresser un acte d’une
société à responsabilité limitée, qu’ils déclarent constituer entre eux et dont ils ont arrêté les statuts comme suit:
31128
L
U X E M B O U R G
Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital
Art. 1
er
. Il est formé entre les souscripteurs et tous ceux qui deviendront propriétaires des parts sociales ci-après
créées une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «BY CAR INLUX Sàrl».
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Wincrange.
L’adresse du siège social peut être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du ou des gérants.
Il pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale délibérant comme en
matière de modification des statuts.
Art. 3. La durée de la société est illimitée.
Art. 4. La société a pour objet:
- Vente, Location et Leasing de véhicules neufs et d’occasion à moteur et autres véhicules;
- Dépôt-vente de véhicules et pièces pour véhicules à moteur et autres véhicules;
- Import-export de véhicules neuf et d’occasion à moteur et autres véhicules;
- Vente et Import-export de pièces pour véhicules neufs et d’occasion à moteur et autres véhicules;
- Montage et démontage de pneus sur véhicules à moteur et autres véhicules;
- Service de dépannages de véhicules à moteurs et autres véhicules;
- Service de passages au contrôle technique des véhicules à moteur;
- Service de lavage des véhicules à moteur et autres véhicules.
La Société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou
commerciale, tant au Luxembourg qu'à l’étranger et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des garanties ou de
toute autre manière.
La Société a en outre pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d'en favoriser l’exploitation et le développement.
La Société pourra s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans toute
société ou entreprise luxembourgeoise ou étrangère, notamment par la création de filiales ou succursales.
Elle pourra emprunter avec ou sans garantie, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution personnelle et/ou
réelle, au profit d’autres entreprises, sociétés ou tiers, sous réserve des dispositions légales afférentes.
La Société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-
prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00.-EUR) divisé en cent (100) parts sociales de
cent vingt-cinq euros (125,00.-EUR) chacune.
Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes de l’actif social ainsi
que des bénéfices.
Art. 6. Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent être cédées entre vifs à un non associé que de l’accord
du ou des associés représentant l’intégralité des parts sociales.
En cas de refus de cession les associés non-cédants s’obligent eux-mêmes à reprendre les parts offertes en cession.
Les valeurs de l’actif net du bilan serviront de base pour la détermination de la valeur des parts à céder.
Art. 7. Le décès, l’incapacité, la faillite ou la déconfiture d’un associé n’entraînera pas la dissolution de la société.
En cas de transmission pour cause de mort à des non-associés, les parts sociales ne peuvent être transmises pour
cause de mort à des non-associés que moyennant l’agrément unanime des associés survivants.
En cas de refus d’agrément il est procédé comme prévu à l’article 6.
Art. 8. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers, alors même qu’il y aurait parmi eux des mineurs ou incapables, ne
pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer
de quelque manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits ils devront s’en rapporter aux
inventaires de la société et aux décisions des assemblées générales.
Gérance - Assemblée générale
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables ad nutum à tout
moment par l’assemblée générale qui fixe les pouvoirs et les rémunérations.
Le ou les gérants sont nommés par l’assemblée générale. Ils sont nommés pour une durée indéterminée. Leurs pouvoirs
sont définis dans l’acte de nomination.
Art. 10. Le ou les gérants ne contractent en raison de leurs fonctions aucune obligation personnelle relativement aux
engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.
31129
L
U X E M B O U R G
Art. 11. La société sera valablement engagée par la seule signature du ou des gérants techniques ou la signature
conjointe d’un gérant technique et d’un gérant administratif.
Art. 12. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quelque soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède.
Chaque associé peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.
Art. 13. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles sont adoptées par les associés
représentant plus de la moitié du capital social.
Les décisions collectives ayant pour objet une modification des statuts doivent réunir les voix des associés représentant
les trois quarts du capital social.
Année sociale - Bilan
Art. 14. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.
Chaque année, le 31 décembre, les comptes annuels sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire comprenant
l’indication des valeurs actives et passives de la société ainsi qu’un bilan et un compte de pertes et profits.
Art. 15. Les produits de la société, déduction faite des frais généraux et des charges sociales, de tous amortissements
de l’actif et de toutes provisions pour risques commerciaux et industriels, constituent le bénéfice net.
Sur le bénéfice net constaté, il est prélevé cinq pourcent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve légale jusqu’à
ce que celui-ci ait atteint le dixième du capital social.
Le surplus du bénéfice est à la libre disposition des associés.
Les associés pourront décider, à la majorité fixée par les lois afférentes, que le bénéfice, déduction faite de la réserve,
pourra être reporté à nouveau ou versé à un fonds de réserve extraordinaire ou distribué aux associés.
Dissolution - Liquidation
Art. 16. En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
désignés par l’assemblée des associés à la majorité fixée par l’article 142 de la loi du 10 août 1915 et de ses lois modificatives
ou, à défaut, par ordonnance du Président du tribunal d’arrondissement, statuant sur requête de tout intéressé.
Le ou les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Disposition générale
Art. 17. La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et ses modifications ultérieures trouveront leur
application partout où il n’y a pas été dérogé par les présents statuts.
<i>Avertissementi>
Le notaire instrumentaire a rendu attentif les comparants au fait que suite à la présente constitution de société ils
devront se conformer aux dispositions légales relatives à l’exercice de l’objet social.
<i>Mesure transitoirei>
Par dérogation, le premier exercice commence le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les parts sociales ont été souscrites comme suit:
- Monsieur Ben EL KAIDI, prénommé, une part sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
- Monsieur Mohamed YOUJIL, prénommé, quatre-vingt-dix-neuf parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Total des parts: cent parts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Toutes les parts ont été intégralement libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros
(12.500,00.-€) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instrumentant,
qui le constate expressément.
<i>Estimation des fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société
et qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, est évalué sans nul préjudice à la somme de 1000 EUR.
<i>Assemblée générale Extraordinairei>
Et à l’instant les associés, représentant l’intégralité du capital social, prennent à l’unanimité les résolutions suivantes:
1.-Le siège social de la société est établi à L-9780 Wincrange, Maison 48,
2.-Le nombre des gérants est fixé à deux.
3.-L’assemblée générale désigne comme gérants pour une durée indéterminée:
Monsieur Mohamed YOUJIL, prénommé, comme gérant technique
31130
L
U X E M B O U R G
Monsieur Ben Abdellah EL KAIDI, prénommé, comme gérant administratif,
La société sera valablement engagée par la seule signature du ou des gérants techniques ou la signature conjointe d’un
gérant technique et d’un gérant administratif.
Dont acte, fait et passé à Wiltz, en l’étude du notaire instrumentant, date qu’en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentant par nom, prénom
usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: YOUJIL M., Joëlle Schwachtgen.
Enregistré à Diekirch, le 30 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1796,. Reçu soixante-quinze euros (75 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société pour servir à des fins administratives.
Wiltz, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015019479/133.
(150023864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
C. Hypothek Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 163.213.
<i>Extrait des résolutions des associési>
Les associés ont pris la résolution suivante:
- Approuver la démission de Jonathan Fragodt, né le 03 Décembre 1967 à Moorehead, Etats-Unis d'Amérique, ayant
comme adresse professionnelle 54 St James Street, Bennet House, Londres Royaume-Uni, en tant que gérant de la Société
avec effet le 16 Juillet 2014.
- Approuver la démission de Pedro Fernandes das Neves, né le 15 Octobre 1974 à Lisbonne, Portugal, ayant comme
adresse professionnelle 5, rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 15
Décembre 2014.
- Approuver la nomination d'Hervé Marsot, né le 02 Octobre 1974 à Mulhouse, France, ayant comme adresse pro-
fessionnelle 5, C rue Eugène Ruppert, L-2453-Luxembourg, en tant que gérant de la Société avec effet le 17 Décembre
2014.
Depuis cette date, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:
- Julie K.Braun (gérant)
- Herve Marsot (gérant)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 Février 2015.
TCS II Lu S.àr.l.
TCS II Opportunities Lu S.àr.l.
Référence de publication: 2015019480/26.
(150023188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Dudimmo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 4, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 140.744.
Il résulte du procès-verbal de l'Administrateur Unique établit en date du lundi 26 janvier 2015, que:
L'Administrateur Unique a décidé de transférer, avec effet au 1
er
janvier 2015, le siège social de la société du 54,
Boulevard Napoléon 1
er
, L-2210 Luxembourg au 4, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Pour extrait conforme
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015019575/14.
(150023982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
31131
L
U X E M B O U R G
DUVAL INVESTMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 39.014.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour: DUVAL INVESTMENTS S.A. SPF
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015019576/17.
(150023737) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Dixie Five SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 194.191.
<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2015.i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «DIXIE FIVE SA», tenue suite à la constitution
de la société en l'étude de Maître Anja HOLTZ, de résidence à Esch-sur-Alzette en date du 30 janvier 2015, la décision
suivante:
«Le dépositaire des actions au porteur de la société sera la société anonyme «Banque Internationale à Luxembourg»,
dont le siège social se situe à L-2953 Luxembourg, 69, route d'Esch (RCS Luxembourg numéro B 6.307).
Pour extrait conforme.
Fait à Esch-sur-Alzette, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015019571/15.
(150023223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Djerba SA SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 173.278.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 5 février 2015.
<i>Pour: DJERBA SA SPF
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015019572/16.
(150023733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
DGV Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 92.976.
<i>Extrait de la résolution prise par le conseil d'administration, en date du 05 janvier 2015:i>
- nomination de la société Alpha Expert S.A., société d'expertise-comptable avec siège social au 1, rue Goethe, L-1637
Luxembourg, inscrite auprès du RCS de Luxembourg section B 88 567, en qualité de dépositaire des titres au porteur
31132
L
U X E M B O U R G
tel que prévu par la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre
des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019567/13.
(150023697) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
DFR SARL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7410 Angelsberg, 14, rue de Mersch.
R.C.S. Luxembourg B 194.258.
STATUTS
L’an deux mille quinze, le dix-neuf janvier.
Par-devant Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck.
A comparu:
Monsieur FARIA ROCHA Danilo, serveur, né le 8 juin 1991 à Ribeira Brava (P), demeurant à L-5423 Ersange 7, route
de Remich.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentaire d’acter les statuts d’une société à responsabilité limitée qu’il va
constituer, comme suit:
Art. 1
er
. La société à responsabilité limitée prend la dénomination de «DFR SARL».
Elle exercera son commerce sous l`enseigne «ANGSBERSTUFF».
Art. 2. Le siège social de la société est établi dans la commune de Fischbach.
Le siège social pourra être transféré sur simple décision de la gérance en tout autre endroit de la commune. Le siège
social pourra être transféré dans toute autre localité du pays par décision de l’assemblée générale des associés.
Art. 3. La société a pour objet l’exploitation d’un débit de boissons alcooliques et non alcooliques avec petite restau-
ration.
Elle est autorisée à exécuter toute vente et toute prestation de service se rattachant directement ou indirectement à
son objet social.
La société a encore pour objet tous actes, transactions et toutes opérations généralement quelconques de nature
mobilière, immobilière, civile, commerciale et financière, se rattachant directement ou indirectement à l’objet précité ou
à tous objets similaires susceptibles d’en favoriser l’exploitation et le développement.
Elle pourra emprunter, hypothéquer ou gager ses biens, ou se porter caution, au profit d’autres entreprises, sociétés
ou tiers.
La société exercera son activité tant au Grand-Duché de Luxembourg, qu’à l’étranger.
Art. 4. La société est constituée pour une durée illimitée.
Elle pourra être dissoute par décision de l’associé ou des associés.
Art. 5. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents (12.500) euros, représenté par cent (100) parts sociales, d’une
valeur nominale de cent vingt-cinq (125,-) euros, chacune.
Art. 6. Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts sont librement cessibles entre eux. Elles ne peuvent
être cédées entre vifs à des non-associés qu’avec l’agrément donné en assemblée des associés représentant au moins les
trois quarts du capital social.
Les cessions de parts ne sont opposables à la société et aux tiers que si elles ont été faites dans les formes prévues
par l’article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que cette loi a été modifiée.
Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Art. 8. Les héritiers et créanciers d’un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, requérir l’apposition
des scellés sur les biens et documents de la société, ni s’immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration.
Art. 9. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par les associés avec ou sans
limitation de leur mandat. Ils peuvent être à tout moment révoqués par décision de l’associé ou des associés.
Art. 10. L’associé ou les associés fixent les pouvoirs du ou des gérants lors de leur nomination.
Dans tous les cas, les décisions à prendre par les associés ne seront valablement prises qu’à la majorité des trois quarts.
Art. 11. Simples mandataires de la société, le ou les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune
obligation personnelle relativement à celles-ci, ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
31133
L
U X E M B O U R G
Art. 12. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année à l’exception
du premier exercice social qui débutera le jour de la constitution et se terminera le trente et un décembre deux mille
quinze.
Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice
net après déduction des frais d’exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d’amortis-
sement et de réserves sera réparti comme suit:
a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l’assemblée générale des associés.
Les pertes, s’il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que
toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.
Art. 14. En cas de dissolution de la société la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,
nommés par les associés qui en fixeront les émoluments.
Le ou les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l’actif et le paiement du passif.
Art. 15. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts les associés se réfèrent et se soumettent aux
dispositions légales en vigueur.
Le notaire a attiré l’attention des parties sur le fait que l’exercice de l’activité sociale prémentionnée requiert le cas
échéant l’autorisation préalable des autorités compétentes.
<i>Déclarationi>
Les associés déclarent, en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu’elle a été modifiée par la suite, être les
bénéficiaires réels de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droits servent à la libération
du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités constituant une
infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels que définis
à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).
<i>Souscription - Libérationi>
Les parts sociales ont toutes été souscrites par l’associé unique, Monsieur FARIA ROCHA Danilo, prénommé.
Toutes les parts sociales ont été entièrement souscrites et libérées en espèces, de sorte que la somme de douze mille
cinq cents (12.500,-) euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la société ainsi qu’il en a été justifié au notaire
instrumentaire, qui le constate expressément.
<i>Fraisi>
Les frais de toute nature incombant à la société en raison de sa constitution sont estimés à 850.-€ (huit cent cinquante
euros)
<i>Assemblée générale extraordinairei>
Et à l’instant, l’associé représentant l’intégralité du capital social s’est constitué en assemblée générale extraordinaire
à laquelle il se considère comme dûment convoqué.
Les résolutions suivantes sont prises:
- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée, Monsieur FARIA ROCHA Danilo, serveur, né le 8 juin 1991
à Ribeira Brava (P), demeurant à L-5423 Ersange, 7, route de Remich, avec tous pouvoirs pour engager valablement la
société en toutes circonstances par sa seule signature.
- L’adresse du siège de la société est fixée à L-7410 Angelsberg, 14, rue de Mersch.
Dont acte, fait et passé à Ettelbruck, en l’étude du notaire instrumentaire, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par noms, prénoms usuels, états et
demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: Danilo FARIA ROCHA, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, Le 21 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1146. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): Tholl.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande et aux fins de publication au Mémorial.
Ettelbruck, le 5 février 2015.
Référence de publication: 2015019566/97.
(150024119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
31134
L
U X E M B O U R G
Deluxegroup S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Siège social: L-1331 Luxembourg, 11-13, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.
R.C.S. Luxembourg B 77.771.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 février 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015019565/14.
(150023254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Delamain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 129.696.
Lors de l'assemblée générale ordinaire tenue en date du 19 janvier 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Jose Correia, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au mandat
de gérant, avec effet au 31 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, de son mandat de gérante, avec effet au 31 décembre 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Référence de publication: 2015019563/15.
(150023388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Deltalux-Business S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6926 Flaxweiler, 26, rue Berg.
R.C.S. Luxembourg B 111.870.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019564/9.
(150023710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Degroof Holding Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 28.259.
<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 janvier 2015i>
Il résulte des délibérations et décisions de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social le 15
janvier 2015 que:
Le mandat du réviseur d'entreprises venant à échéance au terme de la présente assemblée, l'assemblée générale décide
de renouveler pour une période d'un an, expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes
2015, le mandat de réviseur d'entreprises de la société KPMG Audit établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg,
9, Allée Scheffer.
Pour extrait conforme
Degroof Holding Luxembourg S.A.
Patrick Keusters
<i>Président du Conseil d'administrationi>
Référence de publication: 2015019562/18.
(150023569) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
31135
L
U X E M B O U R G
QS PEP S.C.A., SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement
en Capital à Risque.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 170.993.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-third day of the month of February.
Before Us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem (Luxembourg),
Was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (hereafter referred to as the "Meeting") of QS PEP S.C.A., SICAR
(hereafter referred to as the "Company"), a corporate partnership limited by shares, having its registered office at 3,
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, incorporated by a notarial deed on 14
th
August, 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") N° 2120 dated August 27
th
, 2012.
The Meeting was opened with Mr Johan Orsinet, maître de droit, residing professionally in Luxembourg, as chairman
of the Meeting.
The chairman appointed as secretary Mrs Lola Penin, administrative and accounting officer, residing professionally in
Luxembourg.
The Meeting elected as scrutineer Sylvia Errico, private employee, residing professionally in Luxembourg.
The bureau of the Meeting (hereafter referred to as the "Bureau") having thus been constituted, the chairman declared
and requested the notary to state:
I.- That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agendai>
Restatement of the Articles of Association to comply with the provisions of the law of 12 July 2013 on alternative
investment funds managers.
II. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the re-
presented shareholders and by the Bureau will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
III. The present Meeting was convened by notices containing the agenda sent by registered mail to the registered
shareholders on February 12
th
, 2015.
IV. It appears from the attendance list that, out of the seventy-five million five hundred and twenty-two three hundred
and sixteen (75.522.316) shares in issue, thirty-seven million eight hundred eighty-four thousand three hundred sixty-
eight (37.884.368) (ie 50,16%) shares are present or represented at the Meeting.
V. As a result of the foregoing, the present Meeting is regularly constituted and may validly decide on the items of the
agenda.
After deliberation, the Meeting takes the following resolution:
<i>Sole resolutioni>
The Meeting resolved to restate the Articles of Association in their entirety to comply with the provisions of the law
of 12 July 2013 on alternative investment funds managers and withdrawal of the French translation as permitted by the
Law of 17 December 2010.
Consequently the Articles of Association shall read as follows:
“ Art. 1. Name. There exists among the subscribers and all those who may become owners of the shares (the "Sha-
reholders") of the company hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions (S.C.A.) with
variable capital qualifying as a société d’investissement en capital à risque (SICAR) under the name of PEP S.C.A., SICAR
(the "Company").
The Company shall be governed by the law of 15 June 2004 concerning the société d’investissement en capital à risque
(SICAR), as amended (the "2004 Law").
Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of
Luxembourg. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or
abroad by a decision of the General Partner (as defined under Article 15 below). Within the same borough, the registered
office may be transferred through simple resolution of the General Partner.
If and to the extent permitted by law, the General Partner may decide to transfer the registered office to any other
place in the Grand Duchy of Luxembourg.
In the event that the General Partner determines that extraordinary political, military, economic or social events have
occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or
31136
L
U X E M B O U R G
with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such provisional measures shall have
no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding such temporary transfer, shall remain a Luxembourg
corporation.
Art. 3. Term of the Company. The Company is incorporated for an unlimited duration.
The Company may be dissolved by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for amendments
of these Articles, but only with the consent of the General Partner. The Company will not be dissolved in case the General
Partner resigns, is liquidated, is declared bankrupt or is unable to continue its business.
Art. 4. Purpose. The purpose of the Company is the investment of the funds available to it, directly or indirectly, in
securities and other assets representing risk capital within the broadest meaning permitted under Article 1 of the 2004
Law and any other applicable CSSF circulars (including the CSSF circular 06/241) in order to provide its investors with
the benefit of the result of its assets in consideration of the risk which they incur, however, there is no assurance that
the Company's objectives will be achieved or that there will be any return of capital.
The Company may contract any form of borrowings and issue bonds, debentures and any other debt instruments.
Furthermore, the Company may take any measures and carry out any transactions which it may deem useful for the
fulfilment and development of its purpose to the fullest extent permitted under the 2004 Law and any other applicable
circulars.
Art. 5. Liability. The General Partner is liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.
The holders of Ordinary Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other
than by exercising their rights as Shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their commit-
ment to the Company.
Art. 6. Determination of the investment objectives. In addition to what may be provided for in that respect in these
Articles and/or in applicable Luxembourg laws and regulations, the Company's investment objectives, strategies, policies
and risks, including (i) how the Company's assets may be invested and in which assets the Company may invest and (ii)
any applicable investment limits and restrictions, shall be freely determined from time to time by the General Partner
and/or the Company’s alternative investment fund manager, to the extent that such investment objectives, strategies,
policies and risks comply and remain consistent with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
Where it is mandatory to convey such information to investors, information regarding the Company's investment
objectives, strategies, policies and risks may be disclosed or made available to investors in, via and/or at any of the
Information Means listed in Article 29 of these Articles it being understood that availability or disclosure of any information
regarding the Company's investment objectives, strategies, policies and risks may be restricted to the largest extent
authorised by applicable laws and regulations.
Art. 7. Share Capital.
(a) The share capital of the Company shall be represented by shares (the "Shares") of no nominal value comprising at
least one Share held by the General Partner-associé-gérant-commandité (the "General Partner Share", all other Shares
being referred to as the "Ordinary Shares") and shall at all times be equal to the total net assets of the Company pursuant
to Article 12 hereof. The minimum capital of the Company, which must be achieved within twelve (12) months after the
date on which the Company has been authorized as a société d’investissement en capital à risque (SICAR) under Lu-
xembourg law, is the US Dollar equivalent of one million Euros (EUR 1,000,000). The General Partner acting on behalf
of the Company has full discretion to organise the procedures relating to closings, drawdowns and payments upon
drawdown as further disclosed in the Prospectus.
(b) The General Partner may, at any time, as it deems appropriate, decide to create one or more compartments as
provided for under article 3 of the 2004 Law (each such compartment, a "Compartment"). The Shares to be issued in a
Compartment may, as the General Partner will determine, be of one or more different classes, the features, terms and
conditions of which will be established by the General Partner and provisions set out in these Articles regarding Com-
partments shall apply mutatis mutandis to the Class therein.
The Company constitutes a single legal entity, but the assets of each Compartment will be invested for the exclusive
benefit of the Shareholders of the corresponding Compartment and the assets of a specific Compartment are solely
accountable for the liabilities, commitments and obligations of that Compartment.
The General Partner may create each Compartment for an unlimited or a limited period of time.
The proceeds from the issuance of Shares of any Class within a Compartment will be invested in risk capital pursuant
to Article 4 hereof.
For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Compartment will, if
not expressed in US Dollars, be converted into US Dollars and the capital will be the total of the net assets of all the
Compartments.
The general meeting of holders of Shares of a Compartment or Class, deciding with simple majority, may consolidate
or split the Shares of such Compartment or Class.
31137
L
U X E M B O U R G
(c) The Company was incorporated with a fully subscribed capital of fifty thousand (USD 50,000) US Dollars, consisting
of one (1) General Partner Share with no nominal value and forty nine thousand nine hundred and ninety nine (49,999)
Ordinary Shares with no nominal value.
Art. 8. Eligible Investors. Shares in the Company are exclusively restricted to eligible investors who qualify as "Eligible
Investors" within the meaning of article 2 of the 2004 Law, i.e. any institutional investor, professional investor or any
other investor who confirmed in writing that it/he/she adheres to the status of well-informed investor and who either (i)
invests or commits to invest in US Dollars a minimum equivalent to one hundred and twenty-five thousand Euros (€
125,000) in the Company, or (ii) has obtained an assessment made by a credit institution, within the meaning of Directive
2006/48/EC, an investment firm within the meaning of Directive 2004/39/EC or a management company within the
meaning of Directive 2009/65/EC certifying its/his/her expertise, its/his/her experience and its/his/her knowledge in ade-
quately appraising an investment in risk capital (a "Well-informed Investor") within the meaning of the 2004 Law.
Art. 9. Shares. Shares shall be issued in registered form only.
The inscription of the shareholder’s name in the Register of Shareholders (as defined below) evidences its right of
ownership of such shares. Share certificates in registered form may be issued upon request of the Shareholders and shall
be signed by the General Partner. Such signature may be either manual or printed, or by facsimile. If Share certificates
are issued and a Shareholder desires that more than one share certificate be issued for his Shares, the cost of such
additional certificates may be charged to such Shareholder.
All issued Shares of the Company shall be registered in the register of Shareholders (the "Register of Shareholders"),
which shall be kept by the Registrar and Transfer Agent. The Register of Shareholders shall contain the name of each
Shareholder, its/his/her residence, registered office or elected domicile, the number and Class of Shares it/he/she owns,
the amount paid in on each such Share and banking references. Until notices to the contrary shall have been received by
the Company, it may treat the information contained in the Register of Shareholders as accurate and up to date and may
in particular use the inscribed addresses for the sending of notices and announcements and the inscribed banking refe-
rences for the making of any payments.
If any Shareholder can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, lost, stolen
or destroyed, then, at its/his/her request, a duplicate certificate may be issued under such conditions as the Company
may determine subject to applicable provisions of the law. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall
be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become
void. Severely damaged Share certificates may be exchanged for new ones by order of the Company. The severely damaged
certificates shall be delivered to the Company and shall be annulled immediately. The Company may, at its election, charge
the Shareholder for the costs of a duplicate or for a new certificate and all reasonable expenses incurred by the Company
in connection with the issuance and registration thereof, or in connection with the cancellation of the old certificate.
Fractional Shares may be issued up to two places after the decimal and shall carry rights in proportion to the fraction
of a Share they represent but shall carry no voting rights, except to the extent that their number is such that they represent
a whole Share, in which case they confer a voting right.
Each Share grants the right to one vote at the general meeting of Shareholders and at separate Compartment or Class
meetings of the holders of Shares of each of the Compartments or Classes.
The Company only recognizes one owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of
such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) must appoint a single attorney to represent such
Share(s) in respect of the Company. Failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such
Share(s).
Each Shareholder will have first accepted and signed a subscription agreement (the "Subscription Agreement") wherein
it irrevocably commits to make all payments for the entire amount of its commitment.
Art. 10. Issue of Shares. Shares may be issued only upon acceptance of the subscription and subject to receipt of the
purchase price. The prospective Shareholder will, without undue delay, upon acceptance of the subscription and receipt
of the purchase price, receive title to the shares purchased by him and obtain delivery of definitive share certificates in
registered form or confirmation of his shareholding. Each prospective Shareholder may also be asked for a given Com-
partment to commit to subscribe for Ordinary Shares on one or more dates or periods as determined by the General
Partner and which shall be indicated and more fully described in the Prospectus.
Payments for subscriptions to Ordinary Shares shall be made in whole or in part on the dates described in the Pros-
pectus. The form of payment in relation to such subscriptions shall be determined by the General Partner in accordance
with the provisions of the Prospectus and the Subscription Agreement signed by the Shareholder.
Art. 11. Redemption or Acquisition of Shares. Unless otherwise specified for a given Compartment, unilateral re-
demption requests by Shareholders shall not be accepted by the Company.
Nonetheless, the General Partner may proceed with a transfer or a compulsory redemption or acquisition of the
Shares (excluding the General Partner Share) if a Shareholder ceases to be or is found not to be an Eligible Investor within
the meaning of Article 8 of these Articles.
31138
L
U X E M B O U R G
The Company may also redeem or acquire Shares in the event of default of payment by a Shareholder within the
conditions set forth in the Prospectus of the Company and the law of 10 August 1915 on commercial companies as
amended (the "1915 Law").
The Company may redeem or acquire Shares whenever the General Partner considers redemption to be in the best
interests of the Company.
Shares of the capital stock of the Company redeemed by the Company shall be cancelled or held by the Company in
a treasury account, as may be resolved from time to time by the General Partner.
The Company shall have the right, if the General Partner so determines, to satisfy payment of the redemption price
to any Shareholder who agrees, in specie (in kind) by allocating to the Shareholder assets from the portfolio of the
Company equal to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of assets to be transferred in such case
shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudice to the interests of the other Shareholders of
the Company and the valuation used shall be confirmed by a special report of the approved statutory auditor of the
Company. The specific costs for such redemptions in specie (in kind), in particular the costs of the special audit report,
shall be borne by the Shareholder or by a third party, but will not be borne by the Company unless the General Partner
considers that the redemption in specie (in kind) is in the interest of the Company or made to protect the interests of
the Company.
If at any time an investor or shareholder, who has agreed to commit to subscribe for Ordinary Shares pursuant to
Article 10 hereof, fails to honour its commitment through the full payment of the subscription price within the timeframe
decided by the General Partner (a "Defaulting Investor" and/or (as the case may be), "Defaulting Shareholder") and
referred to in the Prospectus, the General Partner has the right, at its discretion, to apply default provisions, including
the suspension of the voting right or the exclusion of the Defaulting Investor/Shareholder, to such Defaulting Investor/
Shareholder, as the General Partner shall determine in its reasonable discretion and in accordance with Luxembourg law
and as detailed in the Prospectus.
Art. 12. Calculation of the Net Asset Value.
12.1. The Net Asset Value of each Share of the Company shall be determined by the Company, under the prime
responsibility of the alternative investment fund manager or any agent of the Company, at least once a year at such date
to be determined from time to time by the General Partner (each a “Valuation Date”) and disclosed in the Prospectus.
The General Partner may determine or cause to be determined the Net Asset Value more frequently.
12.2. The Net Asset Value per Share of each Class for each Compartment is determined by dividing the value of the
total asset of the Compartment properly allocated to such Class less the liabilities of the Compartment properly allocated
to such Class by the total number of Shares of such Class outstanding on a Valuation Date. The Net Asset Value per
Share will be given to three (3) decimal places.
12.3. The assets of the Company shall be valued on the basis of their fair value. Such fair value will be determined by
using the criteria corresponding to the valuation guidelines and principles set out in the valuation guidelines for Private
Equity and Venture Capital published by the relevant association disclosed for each Compartment in the Prospectus,
including the Association Française des Investisseurs en Capital (AFIC), the British Venture Capital Association (BVCA),
the European Association for Investors in Non-listed Real Estate Vehicles (INREV) and the International Private Equity
and Venture Capital Valuation Guidelines (IPEV) published by the International Private Equity and Venture Capital Va-
luation Board in September 2009 or as amended at any more recent date.
12.4. Shares in unquoted instruments shall be valued on the basis of the General Partner's or the alternative investment
fund manager’s valuation models, including earnings multiples and discounted cash flow models. In order to determine
the most appropriate valuation model, the General Partner will take into account the following criterias:
- the original acquisition cost and the recent developments carried out since the acquisition of the relevant investment;
- the recent transactions operated in similar investments;
- transactions completed by third parties in comparable instruments; and
- reliable indicative offers from potential buyers.
12.5. Shares in Portfolio Funds (as defined in the Prospectus) shall be valued at their last available price or latest official
net asset value, as reported or provided by such Portfolio Funds or their administrator. If events have occurred which
may have resulted in a material change of the net asset value of such shares in Portfolio Funds since the day on which the
latest official net asset value was calculated, the value of such shares or units may be adjusted in order to reflect, in the
reasonable opinion of the alternative investment fund manager, or if applicable the General Partner, such change of value.
12.6. The value of securities which are quoted, traded or dealt in on any stock exchange or on any active regulated
market shall be based on the latest available price published or, if appropriate, on the bid price on the stock exchange
which is normally the principal market of such securities, and each security traded on any other regulated market shall
be valued in a manner as similar as possible to that provided for quoted securities.
12.7. The value of any cash on hand or on deposit, bills and demand notes and accounts, prepaid expenses, cash
dividends declared and interest accrued, and not yet received shall be deemed to be the full amount thereof, unless,
however, the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be determined after
31139
L
U X E M B O U R G
making such discount as the alternative investment fund manager or if applicable the General Partner, may consider
appropriate to reflect the true value thereof.
12.8. Liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest.
12.9. The values expressed in a currency other than the reference currency of a Compartment will be converted at
the applicable exchange rate in Luxembourg on the relevant Valuation Date.
12.10. The Net Asset Value per Share on each Valuation Date will be made available to the Shareholders in the manner
prescribed in the Prospectus.
12.11. In addition to what may be provided for in that respect in these Articles, the valuation of the Company's assets
and the calculation of the net asset value per share shall be governed by the rules contained in the relevant applicable
Luxembourg laws and regulations as well as by all other rules, policies and procedures determined from time to time by
the General Partner and/or the alternative investment fund manager to the extent that such other rules, policies and
procedures comply and remain consistent with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations. Where
it is mandatory to convey such information to investors, information regarding (i) the rules applicable to the valuation of
the Company's assets and the calculation of the net asset value per share and (ii) any valuation and calculation may be
disclosed or made available to investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 29 of these Articles;
it being understood that availability or disclosure of any information regarding asset valuation and calculation of the net
asset value may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations
Art. 13. Suspension of Calculation of the Net Asset Value. The General Partner or any of its agents may temporarily
suspend the calculation of the Net Asset Value of one or more Compartments in any of the following events:
(a) any of the principal markets or stock exchanges on which a substantial portion of the investments of the Company
or of a Compartment are quoted is closed otherwise than for ordinary holidays, or during which dealings therein are
restricted or suspended;
(b) the existence of any state of affairs which constitutes an emergency as a result of which disposal or valuation of
investments in the Company or a Compartment would be impracticable;
(c) a breakdown has occurred with respect to the means of communication normally employed in determining the
price of any of the investments in the Company or a Compartment or the current prices on any market or stock exchange;
or
(d) When the Company is unable to repatriate funds or during which any transfer of funds involved in the realisation
or acquisition of investments in the Company or a Compartment cannot in the opinion of the General Partner be effected
at normal rates of exchange.
(e) No issue or, if applicable, redemption of Shares will take place during any period when the calculation of the Net
Asset Value is suspended. Notice of any suspension will be given to Shareholders who are concerned because of sub-
scription or redemption reasons if, according to the General Partner, the suspension will exceed eight (8) calendar days.
Art. 14. General Partner. The Company shall be managed by QS PEP, société à responsabilité limitée, a company
incorporated under the laws of Luxembourg (the "General Partner") in its capacity as general partner (associé comman-
dité) of the Company.
Art. 15. Powers of the General Partner and Representation of the Company. The General Partner is vested with the
broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company’s corporate objectives, including
all acts of administration and disposition in the Company’s interest. All powers not expressly reserved by law or these
Articles to the general meeting of Shareholders will be exercised by the General Partner or of any of its agents as further
detailed in the present Article.
The General Partner may, from time to time, appoint officers or agents of the Company considered necessary for the
operation and management of the Company, provided however that the holders of Shares other than the General Partner
Share may not act on behalf of the Company without jeopardising their limited liability.
The officers and/or agents appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties
given to them by the General Partner.
The General Partner may appoint special committees, such as an investment committee and an advisory committee,
as described more fully in the Prospectus in order to conclude certain tasks and functions expressly delegated to such
Committee(s).
The General Partner may also appoint an investment adviser. The Company may further enter into an agreement with
an alternative investment fund manager authorised under Directive 2011/61/EU of 8 June 2011 on Alternative Investment
Fund Managers, and the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers implementing Directive 2011/61/
EU, as amended (the “AIFM Law”), pursuant to which the latter shall be appointed as the designated alternative investment
fund manager of the Company and shall provide the Company with all or certain of the services set out under Annex I
of Directive 2011/61/EU. Alternatively, the Company may also elect to qualify as an internally-managed alternative in-
vestment fund under Directive 2011/61/EU
Vis-à-vis third parties, the Company shall be validly bound by the sole signature of the General Partner or by the
signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.
31140
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Actions by the General Partner.
(a) Except as may be expressly limited by the provisions of these Articles and under Directive 2011/61/EU, the General
Partner is specifically authorized to act alone to execute, sign, seal and deliver in the name and on behalf of the Company
any and all agreements, certificates, instruments or other documents requisite to carrying out the intentions and purposes
of these Articles and of the Company;
(b) The General Partner, in its sole discretion, may enter into, terminate or approve any modifications or amendments
of any service or management agreement;
(c) Any documentation, analysis, data or other information gathered or produced by the General Partner in connection
with the management of the Company shall become the property of the General Partner.
(d) The General Partner may authorise or allow the alternative investment fund manager to conduct investment and
management of all or any part of the portfolio of assets established for two or more Compartments on a pooled basis,
or of all or any part of the portfolio of assets of the Company on a co-managed or cloned basis with assets belonging to
other Luxembourg Sicars, all subject to appropriate disclosure and compliance with applicable regulations, and as more
fully described in their respective sales documents.
(e) The General Partner may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting
of such person or persons (whether a member or members of the board of managers of the General Partner or not) as
it thinks fit.
Art. 17. Transfer of Shares.
Transferability.
17.1 a) Any Transfers within the meaning given in the Prospectus shall be made in accordance with the applicable law
and the Articles. Except for any Transfers referred to in clauses 17.6, 17.8 and 17.9 and any Transfers of Carried Shares
within the meaning given in the Prospectus which are governed solely by the provision of 17.20. Shares may be transferred
only with the prior written approval of the General Partner and exclusively to Well-Informed Investors. Where the
General Partner approves a Transfer of Shares in accordance with this clause 17.1, such Transfer shall be effected in
accordance with the relevant provisions of this clause 17.
(b) The Company will restrict or object to the ownership of Shares in the Company by any Person within the meaning
given in the Prospectus not meeting the conditions of Eligible Investor as defined in the Prospectus and the Articles.
For this purpose the Company will:
(i) refuse to issue Shares or register the transfer of Shares where it appears that this issue or transfer would or could
have the effect of allotting ownership of the Share to any Person not meeting the conditions of Eligible Investor;
(ii) proceed with the enforced redemption of all or some of the relevant Shares if it appears that a Shareholder ceases
to be, or is found not to be, an Eligible Investor.
Transfer of the General Partner Share
17.2 The General Partner Share held by the General Partner is not transferable to any Person without the consent
given at a general meeting of Shareholders in accordance with the quorum and majority requirements for the amendment
of the Articles as provided under Article 25 of the Articles.
In the event of a Transfer of the General Partner Share, the assignee or transferee shall be substituted in the place of
the General Partner and admitted to the Company as a general partner of the Company pursuant to applicable law and
with the prior consent of the Luxembourg supervisory authority. Immediately thereafter, such substituted general partner
shall hereby be authorized to and shall continue the business of the Company.
Transfer by Shareholders
17.3 Subject to any limitations in the Articles and the Prospectus, Shares in a Compartment may be transferred by a
written instrument of transfer signed by the transferor and containing the name and address of the transferee. Such
written instrument of transfer as well as a Transfer Agreement shall be sent to the Company for registration, but in the
absence of such written instrument of transfer the General Partner may accept such evidence of a Transfer of Shares as
they consider appropriate. The Transfer of Shares is effective when the name of the transferee is entered on the Register
of Shareholders.
17.4 Notwithstanding any other provision of the Prospectus, in the event that any Shareholder (the “Proposed Trans-
feror”) wishes to transfer (the “Proposed Transfer”) all or any of its Shares (the “Proposed Shares”) to a Person (the
“Proposed Transferee”), the Proposed Transferor shall be required to give a prior notice no later than fifteen (15) Business
Days prior to the Proposed Transfer in writing to the General Partner (the “Transfer Notice”). The Transfer Notice
shall:
(a) state the name and the address of the Proposed Transferee;
(b) indicate the Proposed Transfer sale price (the “Proposed Price”), the number and Class of Shares to be transferred
(together with all rights then attached thereto), the amount of the Transferred Outstanding Commitment (as defined
below) of the Proposed Transferor, and other details of the Proposed Transfer as the General Partner may in its absolute
discretion determine; and
(c) be counter-signed by the Proposed Transferee.
31141
L
U X E M B O U R G
17.5 In the event that a Transfer of Shares is effected at such time as the Proposed Transferor is still bound by an
Outstanding Commitment (the “Transferred Outstanding Commitment”), the Transferred Outstanding Commitment
must be assumed by the Proposed Transferee at the same time as the relevant Transfer of Shares is effected and the
Proposed Transferee shall be obliged to enter into an instrument of transfer in a form approved by the General Partner
requiring the Proposed Transferee to honour and be irrevocably bound by the relevant Transferred Outstanding Com-
mitment. In addition, the Proposed Transferee shall be obliged to enter into an instrument of transfer in a form approved
by the General Partner requiring the Proposed Transferee to honour and be irrevocably bound by any amounts the
relevant Proposed Transferor may be bound to pay to cover a Rate Fluctuation Event, if any.
Unrestricted Transfers
17.6 Provided that the Proposed Transferor sends a Transfer Notice to the General Partner no later than fifteen (15)
Business Days prior to the proposed date of the Transfer, any Transfer of Shares to any of the following persons shall
not be subject to provisions of clauses 17.10 to 17.18:
a) an Affiliate of this Proposed Transferor; or
b) an investment fund managed by this Proposed Transferor or by an Affiliate of this Proposed Transferor; or
c) a trust which shall hold the Proposed Shares on trust for the sole benefit of the Proposed Transferor (the “Affiliated
Trust”).
17.7 The General Partner shall nevertheless have the right to prohibit any Proposed Transfer which may in the opinion
of the General Partner be prejudicial to and/or create a regulatory and/or tax issue for the Compartment to which the
Shares relate, to the Company, the General Partner, or its Affiliates.
17.8 After the Proposed Transfer to an Affiliate or an Affiliated Trust has been effected, if at any time the Proposed
Transferee ceases to be an Affiliate or an Affiliated Trust of the Proposed Transferor, then the Proposed Transferee shall
transfer all of the Proposed Shares back to the Proposed Transferor as soon as reasonably possible.
17.9 If there are two or more successive Transfers of the same Shares proposed to Affiliates or Affiliated Trusts, any
Transfer after the first Transfer will be unrestricted only if the Proposed Transferee is an Affiliate or an Affiliated Trust
of the Proposed Transferor in the first Transfer.
Prior Approval and Pre-Emption Rights
17.10 Except for any Transfer of Shares referred to in the preceding clauses 17.6, 17.8 and 17.9, the Transfer of Investor
Shares, for any reason whatsoever, are subject to the prior written approval of the General Partner and to the provisions
of clauses 17.10 to 17.18.
17.11 Upon receipt of a Transfer Notice, the General Partner shall have the right to purchase all but not some only
of the Proposed Shares or to designate a Person which shall purchase all of the Proposed Shares from the Proposed
Transferor at the Proposed Price.
17.12 The General Partner, for itself or on behalf of its designee, shall have a period of fifteen (15) Business Days from
receipt of the Transfer Notice to inform the relevant Proposed Transferor whether the right conferred pursuant to
clause 17.11 is exercised. If the General Partner elects not to exercise the right conferred by clause 17.11 or fails to
respond within such period, the right conferred pursuant to clause 17.11 shall lapse and the remaining provisions of this
clause 17 shall apply.
17.13 The Compartment, at the discretion of the General Partner shall have the right to purchase all or any of the
Proposed Shares if the General Partner elects not to exercise or fails to exercise the right conferred by clause 17.11.
17.14 If the Compartment elects not to exercise the right conferred by clause 17.13, the right conferred pursuant to
clause 17.13 shall lapse and the remaining provisions of this clause 17 shall apply.
17.15 Subject to the preceding clause 17.14, the General Partner shall inform the other investor Shareholders of the
relevant Compartment (the “Beneficiary Shareholders”) in writing of the intended Proposed Transfer, specifying the
information provided in the Transfer Notice.
17.16 Upon receipt of a notice pursuant to the preceding clause 17.15, the Beneficiary Shareholders shall have the
right, between them, to purchase all but not some only of the Proposed Shares at the Proposed Price and on terms and
conditions no less favourable than those contained in the Transfer Notice, exercisable within fifteen (15) Business Days
following the date on which the General Partner sent the letter informing the Beneficial Investor(s) of the Proposed
Transfer referred to in clause 17.15 above.
17.17 At the end of the period set out in the preceding clause 17.16, if one or more of the Beneficiary Shareholders
announces its intention to purchase all of the Proposed Shares, the General Partner shall inform the Proposed Transferor
as soon as possible, by registered letter with return receipt requested, that one or more Beneficiary Shareholder(s) wishes
to acquire all of the Proposed Shares, and shall indicate the number of Proposed Shares that each Beneficiary Shareholder
proposes to purchase. Where the requests exceed the number of Proposed Shares, the Proposed Shares shall be allocated
amongst the Beneficiary Shareholders in the Compartment according to the ratio equal to the number of Shares held
respectively by each Beneficiary Shareholder in the Compartment divided by the aggregate number of all the Shares held
by the Beneficiary Shareholders who have exercised their pre-emption right (as nearly as may be possible without involving
fractions of Shares).
31142
L
U X E M B O U R G
17.18 If the pre-emption rights conferred pursuant to clauses 17.11, 17.13 and 17.16 are not exercised with respect
to all of the Proposed Shares on the terms set out therein, the General Partner will have thirty (30) Business Days from
the date on which the notice made pursuant to clause 17.16 shall have lapsed to decide whether it does or does not
approve the Proposed Transfer to the Proposed Transferee and to notify such decision to the Proposed Transferor. The
General Partner has full and unfettered discretion in making its decision and is not required to make the reasons for its
decision known. In the event that the General Partner does not approve a Proposed Transfer, notwithstanding any other
provisions of this Prospectus, the General Partner shall not recognize the Transfer nor amend the Register of Sharehol-
ders.
17.19 The General Partner, its Affiliates, the Company and the Compartment shall be reimbursed by the Proposed
Transferor for any costs incurred with respect to a Transfer. The General Partner, its Affiliates, the Company and the
Compartment may also receive compensation from the Proposed Transferor, negotiated by mutual consent, if the Pro-
posed Transferor requires its assistance in seeking a transferee for its Shares.
Transfers of Carried Shares
17.20 The General Partner and/or any other Person which the General Partner designates shall subscribe for the
Carried Shares. The General Partner will have the right to transfer such Carried Shares to whom it thinks fit in its absolute
discretion. Any other Person holding Carried Shares will have the right to transfer its carried Shares subject to the prior
written consent of the General Partner. None of the preceding provisions of clause 17 shall apply to any Transfers of
Carried Shares.
Assignment of interests or Shares in violation of this clause
17.21 No transfer of a Share in violation of this clause shall be valid or effective, and the Company and the Compartment
shall not recognize the same, for the purposes of making distributions of Net Proceeds or reductions of Outstanding
Commitment or otherwise with respect to interests in the Company.
Art. 18. Indemnification.
18.1. The Company will indemnify out of the assets of each Compartment and within the limits set forth in the
Prospectus, either out of any distributions to which any Shareholder is entitled, pro rata to such Shareholder’s interest
in the Compartment, or by requesting the payment of capital calls, each Indemnified Party (as such term is defined in the
Prospectus), for and against any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, actions, judgments, suits, costs,
expenses or disbursements of any kind or nature whatsoever (including legal fees) (other than those resulting from fraud
or gross negligence on the part of any Indemnified Party) which may be imposed on, incurred by or asserted against any
Indemnified Party in performing their obligations or duties as further detailed in the Prospectus.
18.2. The Company may purchase and maintain liability insurance in relation to the General Partner and/or to any
person who is or was its directors, officers, servants or agents and to any person who is or was an Indemnified Party, an
officer or a liquidator of the Compartment as further detailed in the Prospectus.
Art. 19. Conflicts of Interest. The guidelines in relation to the conflict of interest are fully described in the Prospectus.
Art. 20. Depositary. The Company will enter into a depositary agreement with a Luxembourg bank (the "Depositary")
which meets the requirements of the 2004 Law and the AIFM Law.
The Company’s securities, cash and other permitted assets will be held in custody by or in the name of the Depositary,
which will fulfil the obligations and duties provided for by the 2004 Law and the AIFM Law.
The duties of the Depositary cannot be terminated unless and until a successor Luxembourg bank or eligible entity
shall have been appointed to act in the place thereof.
The Depositary of the Company may discharge itself of its liability provided that certain conditions are met, including
the condition that, where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a
local entity and there are no local entities that satisfy the delegation requirements laid down in point (d)(ii) of the second
paragraph of Article 19(11) of the AIFM Law, the Articles expressly allow for such a discharge under the conditions set
out in Article 19(14) of the AIFM Law. The Company hereby expressly allows its General Partner to grant such a discharge
and, more generally, allows for any discharge by the Depositary of its liability that is not prohibited by any applicable laws
and regulations and to be in place in accordance with the conditions set out in the AIFM Law.
Information regarding any discharge by the Depositary of its liability, as well as any material change to this information,
may be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 29 of these
Articles; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge by the Depositary of
its liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
Art. 21. General Meeting of Shareholders. The general meeting of Shareholders represents all Shareholders of the
Company. It has the powers expressly reserved to it by law or these Articles provided that a resolution shall be validly
adopted only if approved by the General Partner. Meetings in any Compartment or Class of Shares may also be held in
circumstances where the rights of the Shareholders in the Compartment or the Class of Shares, respectively, may be
changed as a result of the resolutions.
The annual general meeting of Shareholders of the Company will be held in Luxembourg at the registered office of
the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice, on the first Thursday
31143
L
U X E M B O U R G
of the month of May at 2:00 pm of each year. If such day is not a business day, the meeting shall be held on the following
business day.
Any resolution of a general meeting of Shareholders affecting the interest of the Company vis-à-vis third parties or
amending the present Articles must be approved by the General Partner.
Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Notices of all general meetings of Shareholders, setting forth the agenda and specifying the time and place of such
meeting and the conditions of admission thereto and referring to quorum and majority requirements, will be sent by
registered mail to the Shareholders, at least eight (8) calendar days prior to the meeting, to their addresses in the Register
of Shareholders and may be published if required under Luxembourg laws.
Art. 22. Accounting Year. The Company’s accounting year shall begin on 1
st
January of each year and shall end on 31
st
December of the same year.
Art. 23. Annual Report. The Company shall publish an annual report in accordance with general accounting principles
accepted in Luxembourg or any other accounting principles applicable pursuant to Luxembourg laws.
Art. 24. Distributions. The right to distributions and the right to capital reimbursement of each Class of Shares are
determined by the General Partner in accordance with the provisions of the relevant Compartment's distribution waterfall
further disclosed in the Prospectus. No distribution can take place if, following this distribution, the capital of the Company
would fall below the minimum capital provided for by the 2004 Law.
Art. 25. Amendments to the Articles of Association. Any resolution of a general meeting of Shareholders to the effect
of amending these Articles must be passed by a quorum of fifty percent (50%) of the capital of the Company and a majority
of two-thirds of the votes cast at the meeting and with the consent of the General Partner. Each amendment to these
Articles entailing a variation of rights of a Class of Shares must be approved by a resolution of the general meeting of
Shareholders and of a separate meeting of the Shareholders of the relevant Class of Shares and with the consent of the
General Partner.
Art. 26. Dissolution, Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out in
accordance with the provisions of the 1915 Law and the 2004 Law, by one or more liquidators named by the general
meeting of Shareholders resolving to dissolve the Company, and upon proposal by the General Partner. Such meeting
shall determine their powers and their remuneration. The net proceeds may be distributed in kind to the holders of
Shares.
Compartments may be established for a limited or unlimited period, as specified in the relevant appendix of the
Prospectus.
If the net assets of any Compartment or Class fall below or do not reach an amount determined by the General Partner
to be the minimum level for such Compartment or such Class to be operated in an economically efficient manner or if
a change in the economic or political situation relating to the Compartment or Class concerned justifies it, the General
Partner has the discretionary power to liquidate such Compartment or Class by compulsory redemption of shares of
such Compartment or Class at the Net Asset Value per Share determined as at the Valuation Date at which such a
decision shall become effective. The decision to liquidate will be mailed to the Shareholders concerned prior to the
effective date of the liquidation.
Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a general meeting of
Shareholders of any Compartment or Class may, upon proposal from the General Partner and with its approval, redeem
all the Shares of such Compartment or Class (taking into account actual realisation prices of investments and realisation
expenses). There shall be no quorum requirements for such a general meeting of Shareholders at which resolutions shall
be adopted by simple majority of the votes cast.
Upon the circumstances provided for under the third paragraph of this section, the General Partner may decide to
allocate the assets of any Compartment to those of another existing Compartment within the Company (the "New
Compartment") and to re-designate the Shares of the Compartment concerned as shares of the New Compartment
(following a split or consolidation, if necessary and the payment of the amount corresponding to any fractional entitlement
to shareholders). Such decision will be notified to the Shareholders concerned (and, in addition, the notification will
contain information in relation to the New Compartment) by mail to the address of each concerned Shareholder as
disclosed in the Register of Shareholders.
Notwithstanding the powers conferred to the General Partner by the preceding paragraph, a contribution of the assets
and liabilities attributable to any Compartment to another Compartment of the Company may be decided upon by a
general meeting of the Shareholders, upon proposal from the General Partner and with its approval, of the contributing
Compartment for which there shall be no quorum requirements and which shall decide upon such an amalgamation by
resolution adopted by simple majority of the votes cast.
Assets which could not be distributed to the relevant Shareholders upon the closure of the liquidation of a Compart-
ment or Class will be deposited with the Caisse de Consignation to be held for the benefit of the relevant Shareholders.
Amounts not claimed will be forfeited in accordance with Luxembourg Law.
31144
L
U X E M B O U R G
Any distribution resulting of the foregoing shall be made and processed in accordance with the relevant provisions set
out in the prospectus and the relevant provisions set out in the applicable appendix of the prospectus under section
"Distribution Waterfall".
Art. 27. General Provisions. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the
1915 Law and the 2004 Law.
Withdrawal of the status of société d'investissement en capital à risque (SICAR) of the Company shall require the
unanimous consent of the Shareholders and the prior approval of the CSSF.
Art. 28. Preferential Treatment of Investors. Any prospective or existing shareholder ("Investor") may be accorded a
preferential treatment, or a right to obtain a preferential treatment (a "Preferential Treatment") subject to, and in com-
pliance with the conditions set forth in, applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total
reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription,
redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requi-
rements, lower or no gating, reduced or no sidepocketing, tag-along or drag-along rights; the foregoing being illustrative
and not exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets, liabilities or counter-
parties, (v) in the access to, or increased transparency of, information related to certain aspects of the Company's portfolio
or of the Company's or its alternative investment fund manager's management or activities (whether past, present and/
or future) in general, (vi) in preferential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests,
liquidation proceeds or of any other amount that may be distributed by the Company to Investors), (vii) in certain
preferential terms and rights (including veto) in relation to the appointment or removal of members of the Company's
or its alternative investment fund manager's governing bodies and/or internal committees, (viii) in the participation to the
Company's or its alternative investment fund manager's management or activities in general (including participation to
their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto, to postpone or to otherwise condition certain
decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a "most favoured nation" (or similar) right, or
(xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations
and that may be determined from time to time by, and in the discretion of, the Company and/or its alternative investment
fund manager.
A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment
in, or of any commitment taken vis-à-vis, the Company, (ii) of the type, category, nature, specificity or any feature of the
Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or participation to, the Company's or its alternative investment fund
manager's management or activities (whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other criteria, element
or feature that is not inconsistent with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined
from time to time by, and in the discretion of, the Company and/or its alternative investment fund manager.
A Preferential Treatment may (x) take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the
creation of a specific category or class of shares, or (y) take any other form or arrangement that is not inconsistent with
these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the
discretion of, the Company and/or its alternative investment fund manager.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investors who obtain such preferential treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company
or its alternative investment fund manager, as well as any material change to this information, must be disclosed or made
available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 29 of these Articles; it being understood
that availability or disclosure of any information regarding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent
authorised by applicable laws and regulations.
Art. 29. Investor’s Information. Any information or document that the Company or its alternative investment fund
manager must or wishes to disclose or be made available to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made
available to any of the concerned Investors in, via and/or at any of the following information means (each an "Information
Means"): (i) the Company's sales documents, offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, con-
version or transfer form, (iii) contract note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or
any type of notice or message, (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report,
(vii) the Company's, alternative investment fund manager's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix)
internet/a website (as the case may be subject to password or other limitations) and (x) any other means or medium to
be freely determined from time to time by the Company or its alternative investment fund manager to the extent that
such means or medium comply and remain consistent with these Articles and applicable Luxembourg laws and regulations.
The Company or its alternative investment fund manager may freely determine from to time the specific Information
Means to be used to disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one
current Information Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or
made available shall at least be indicated in either the Company's sales documents or at the Company's or alternative
investment fund manager's registered office.
31145
L
U X E M B O U R G
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with Article 13(1) and (2) of the AIFM Law may be provided by means
of a website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place
of the website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the
Company's or alternative investment fund manager's registered office.
This resolution has been taken by:
all votes FOR, and
no vote AGAINST and
no ABSTENTION.
There being no further business on the agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English only in accordance with Article 26 (2) of the 2010 Law.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date named at the beginning of this document.
The document having been read to the parties appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed, no shareholder expressing the wish to sign.
Signé: J. ORSINET, L. PENIN, S. ERRICO, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 26 février 2015. Relation: EAC/2015/4593. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015036585/602.
(150040076) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
LILIE Caesar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.762.
Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1030 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 17.574.
L’an deux mille quinze, le vingt-six février,
Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),
1) Sociétés fusionnantes:
- «LILIE Caesar S.à r.l.», société à responsabilité limitée, dont le siège est au 412F, route d’Esch, L-1030 Luxembourg,
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192.762. (ci-après appelée
«société absorbée»). La société absorbée a été constituée par un acte reçu par Me Gérard LECUIT, notaire de résidence
à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, no 60 du 9 janvier 2015.
représentée par Carla Alves Silva, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir conféré par une décision du conseil d’administration de la Société Absorbée du 24 février 2015,
- «Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH», société à responsabilité limitée, dont le siège est au 412F, route
d’Esch, L-1030 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
17.574 (ci-après appelée «société absorbante»). Les statuts de la société absorbante ont été modifiés par un acte reçu
par Me Jean Seckler Joseph, notaire de résidence à Junglinster, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
no 986 du 24 septembre 2003.
représentée par Carla Alves Silva, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,
en vertu d’un pouvoir conféré par une décision du conseil d’administration de la Société Absorbante du 24 février
2015,
Les décisions des conseils d’administration respectifs paraphées ne varietur par la mandataire des comparantes et par
le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.
2) La société absorbée est titulaire des parts sociales représentant l’intégralité du capital et détient la totalité des droits
de vote de la société absorbante. La société absorbée ne détient aucune autre participation que les actions de la société
absorbante.
31146
L
U X E M B O U R G
3) Les sociétés fusionnantes n'ont émis ni parts sociales conférant des droits spéciaux, ni titres autres que des parts
sociales, en particulier aucun titres obligataires.
4) La société absorbante absorbera la société absorbée aux termes d'une fusion conformément aux articles 257 et
suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée par la suite.
5) Caesar Luxco S.à r.l., une société constituée sous les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à Luxembourg,
21, Boulevard Grande Duchesse Charlotte, L-1331 et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 167 152, étant l’associé unique de la société absorbée, recevra l’intégralité des parts sociales de la société
absorbante, à savoir cinq cents (500) parts sociales. L'échange s'effectuera par l’inscription dans le registre des associés
de la société absorbante.
6) A partir du 1
er
avril 2015 toutes les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable
comme accomplies pour le compte de la société absorbante.
7) Aucun avantage particulier n'est conféré aux membres des conseils de gérance des sociétés qui fusionnent.
8) La fusion entraînera de plein droit, à partir de sa prise d'effet, la transmission universelle tant entre les sociétés
fusionnantes qu'à l’égard des tiers, de l’ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante,
à sa valeur comptable.
9) Tous les associés ont le droit, durant un mois suivant la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, de
prendre connaissance des documents indiqués à l’article 267 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commer-
ciales, telle que modifiée. Ils auront le droit d'obtenir copie desdits documents, sans frais et sur simple demande.
10) Sous réserve du droit des associés prévu au paragraphe ci-avant, la fusion deviendra effective au terme des as-
semblées générales des sociétés absorbante et absorbée qui se tiendront au plus tard endéans un mois qui suivra la
publication du présent projet de fusion au Mémorial, et entraînera également de plein droit et simultanément les effets
prévus à l’article 274 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.
11) Les mandats des gérants de la société absorbée prendront fin à la date de l’assemblée générale de la société
absorbée et décharge leur sera accordée.
12) Les conseils de gérance des deux sociétés fusionnantes ont constaté que les associés de la société absorbée ont
d'ores et déjà valablement renoncé aux rapports de réviseurs de droit commun, dans les conditions de l’article 266 (5)
de la loi fondamentale sur les sociétés commerciales, et il n'y a dès lors lieu ni à rapports sur la fusion, ni sur le rapport
d'échange des parts sociales.
13) Les livres et documents juridiques de la société absorbée seront conservés pendant une durée de cinq ans au siège
de la société absorbante et les parts sociales de la société absorbée seront annulées après leur échange, comme il est dit
au point 5) ci-dessus.
Le présent Projet de Fusion sera déposé auprès du registre de commerce et des sociétés et publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre les Sociétés Fusionnées,
conformément à l’article 262 et 279 a) de la Loi pour chacune des Sociétés Fusionnées.
Le notaire soussigné atteste la légalité du présent Projet de Fusion conformément à l’article 271 (2) de la Loi.
Tous frais, droits et honoraires dus au titre de la Fusion seront supportés par la Société Absorbante en raison du
présent acte et sont estimés à sept mille cinq cents Euros (7.500.- EUR).
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, ladite mandataire a signé avec
Nous notaire le présent acte.
Signé: C. ALVES SILVA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 27 février 2015. Relation: 1LAC/2015/6171. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 4 mars 2015.
Référence de publication: 2015037188/77.
(150041856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Agripartes S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 67.994.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-ninth of the month of January,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
31147
L
U X E M B O U R G
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of AGRIPARTES S.A., a public company (société
anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 46A, avenue J.F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce
and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 67.994 (the Company). The Company was incorporated on De-
cember 28, 1998 pursuant to a deed of Maître Robert Schuman, notary residing at that time in Differdange, Grand Duchy
of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 210 of March 26, 1999. The
articles of association of the Company have been last amended on December 27, 2010 pursuant to a deed of Maître
Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 665 of April 7, 2011.
The Meeting is opened at 5.30 p.m. and chaired by Mr Frank Stolz-Page, residing professionally in Mondorf-les-Bains
(the Chairman).
The Chairman appoints Mrs Brigitte Wahl, residing professionally in Mondorf-les-Bains, as secretary of the Meeting
(the Secretary).
The Meeting elects Mr Chris Oberhag, residing professionally in Mondorf-les-Bains, as scrutineer of the Meeting (the
Scrutineer; the Chairman, the Secretary and the Scrutineer being collectively referred to as the Bureau of the Meeting).
The shareholders present and/or represented at the Meeting (the Shareholders) and the number of shares they res-
pectively hold are indicated on an attendance list which will remain attached to the present minutes after having been
signed by the Shareholders present, the proxyholders of the Shareholders represented, the members of the Bureau and
the notary.
The proxies from the Shareholders represented at the present Meeting will also remain attached to the present minutes
and signed by all the parties.
The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares the following:
I. That one hundred thirty-seven thousand three hundred fifty (137,350) shares having a par value of two Euro (EUR
2.-) each, representing the entirety of the share capital of the Company of two hundred seventy-four thousand seven
hundred Euro (EUR 274,700.-) are duly represented at this Meeting which is consequently regularly constituted and may
deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices.
2. Approval of the redemption by the Company of thirty-three thousand seven hundred thirteen (33,713) issued shares
of the Company, as determined by the board of directors of the Company iin compliance with article five (5) of the articles
of association of the Company (the Articles) and agreed by the Shareholders, in compliance with articles 49-2 and seq.
of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Company Law).
3. Further to the approval of the redemption by the Company of the thirty-three thousand seven hundred thirteen
(33,713) shares, acknowledgement that the Company holds all of the outstanding thirty-three thousand seven hundred
thirteen (33,713) shares, each share having a par value of two Euro (EUR 2.-), and approval of the decrease of the share
capital of the Company by an amount of sixty-seven thousand four hundred twenty-six Euro (EUR 67,426.-) in order to
bring the share capital of the Company from its present amount of two hundred seventy-four thousand seven hundred
Euro (EUR 274,700.-), represented by one hundred thirty-seven thousand three hundred fifty (137,350) shares, each share
having a par value of two Euro (EUR 2.-), to two hundred seven two seventy-four Euro (EUR 207,274.-) by way of
cancellation of all the thirty-three thousand seven hundred thirteen (33,713) shares held by the Company, in compliance
with articles 49-2 and seq. of the Company Law.
4. Amendment to the first paragraph of article five (5) of the Articles so as to reflect the foregoing items of the agenda.
5. Amendment of the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any director of the Company as well as to any employee of TMF Luxembourg S.A. (each an Authorized
Representative), each acting individually under his/her sole signature, to proceed on behalf of the Company with the
registration of the above changes in the register of shareholders of the Company.
6. Miscellaneous.
III. That the Meeting has taken the following resolutions unanimously:
<i>First Resolution:i>
The entirety of the corporate share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Meeting
waives the convening notices, the Shareholders present considering themselves as duly convened and declaring having
perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance to the Meeting.
<i>Second Resolution:i>
The Meeting resolves to approve the redemption by the Company of thirty-three thousand seven hundred thirteen
(33,713) issued shares of the Company, as determined by the board of directors of the Company in compliance with
article five (5) of the Articles and agreed by the Shareholders in accordance with articles 49-2 and seq. of the Company
Law.
31148
L
U X E M B O U R G
<i>Third Resolution:i>
The Meeting acknowledges that, further to the approval of the above described redemption, the Company holds all
of the outstanding thirty-three thousand seven hundred thirteen (33,713) shares, each share having a par value of two
Euro (EUR 2.-).
As a result of the above, the Meeting resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of sixty-
seven thousand four hundred twenty-six Euro (EUR 67,426.-) in order to bring the share capital of the Company from
its present amount of two hundred seventy-four thousand seven hundred Euro (EUR 274,700.-) represented by one
hundred thirty-seven thousand three hundred fifty (137,350) shares, each share having a par value of two Euro (EUR 2.-),
to two hundred seven two seventy-four Euro (EUR 207,274.-) by way of cancellation of all the thirty-three thousand
seven hundred thirteen (33,713) shares held by the Company in accordance with articles 49-2 and seq. of the Company
Law.
<i>Fourth Resolution:i>
As a consequence of the foregoing resolutions, the Meeting resolves to amend the first (1
st
) paragraph of article five
(5) of the Articles in order to reflect the above changes, so that it shall henceforth read as follows:
“ Art. 5. (first paragraph). The company subscribed capital is set at two hundred seven two seventy-four Euro (EUR
207,274.-) represented by one hundred three thousand six hundred thirty-seven (103,637) shares with a par value of two
euro (EUR 2) per share”.
<i>Fifth Resolution:i>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
and empower and authorize any Authorized Representative, each individually under his/her sole signature, to proceed
on behalf of the Company with the registration of the above changes in the register of shareholders of the Company.
<i>Estimate of Costs:i>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2.500).
There being no further business, the meeting is closed at 5.50 p.m..
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between English and the French versions, the English version will prevail.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the
day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing parties, who are known to the undersigned notary by his/their
surname(s), name(s), civil status and residence, the appearing parties signed the present deed together with the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quinze, le vingt-neuvième jour du mois de janvier,
par-devant nous, Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorfles-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des actionnaires de AGRIPARTES S.A., une société anonyme
constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 67.994 (la Société). La Société a été constituée le 28 décembre 1998
suivant un acte de Maître Robert Schuman, notaire alors de résidence à Differdange, Grand-Duché de Luxembourg, publié
au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 210 du 26 mars 1999. Les statuts de la Société ont été
modifiés pour la dernière fois le 27 décembre 2010 suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 665 du
7 avril 2011.
L’Assemblée est ouverte à 17.30 heures et présidée par Monsieur Frank Stolz-Page, ayant son adresse professionnelle
à Mondorf-les-Bains (le Président).
Le Président nomme Madame Brigitte Wahl, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, comme secrétaire
de l’Assemblée (le Secrétaire).
L’Assemblée élit Monsieur Chris Oberhag, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, comme scrutateur
de l’Assemblée (le Scrutateur; le Président, le Secrétaire et le Scrutateur étant collectivement désignés le Bureau de
l’Assemblée).
Les actionnaires présents et/ou représentés à l’Assemblée (les Actionnaires) ainsi que le nombre d’actions qu’ils dé-
tiennent respectivement sont indiqués sur une liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal après avoir
31149
L
U X E M B O U R G
été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du Bureau et le
notaire.
Les procurations des Actionnaires représentés à la présente Assemblée resteront également annexées au présent
procès-verbal et signées par toutes les parties.
Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare ce qui suit:
I. Que cent trente-sept mille trois cent cinquante (137.350) actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR
2,-) chacune, représentant l’entièreté du capital social de la Société de deux cent soixante-quatorze mille sept cents euros
(EUR 274.700,-) sont dûment représentées à cette Assemblée qui est par conséquent régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur les points de l’ordre du jour, reproduit ci-après;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Approbation du rachat par la Société de trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions émises de la Société, tel
que déterminé par le conseil d’administration de la Société en conformité avec l’article cinq (5) des statuts de la Société
(les Statuts) et accepté par les Actionnaires, en conformité avec les articles 49-2 et suivants de la loi du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi concernant les Sociétés Commerciales).
3. Suite à l’approbation du rachat par la Société de trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions, prise d’acte de
la détention par la Société de l’intégralité des trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions en circulation, chacune
des actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), et approbation de la réduction du capital social de la
Société d’un montant de soixante-sept mille quatre cent vingt-six euros (EUR 67.426,-) afin de porter le capital social de
la Société de son montant actuel de deux cent soixante-quatorze mille sept cents euros (EUR 274.700,-), représenté par
cent trente-sept mille trois cent cinquante (137.350) actions, chaque action ayant une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-), à un montant de deux cent sept mille deux cent soixante-quatorze euros (EUR 207.274,-) par annulation de
toutes les trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions détenues par la Société, en conformité avec les articles 49-2
et suivants de la Loi concernant les Sociétés Commerciales.
4. Modification du premier paragraphe de l’article cinq (5) des Statuts afin de refléter les points de l’ordre du jour ci-
dessus.
5. Modification du registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et
autorité donnée à tout administrateur de la Société ainsi qu’à tout employé de TMF Luxembourg S.A. (chacun un Re-
présentant Autorisé), chacun agissant individuellement sous sa seule signature, pour procéder pour le compte de la Société
aux modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la Société.
6. Divers.
III. Que l’Assemblée a pris les résolutions suivantes à l’unanimité:
<i>Première Résolution:i>
La totalité du capital social de la Société étant représenté à la présente Assemblée, l’Assemblée renonce aux formalités
de convocation, les Actionnaires présents se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir une parfaite
connaissance de l’ordre du jour qui leur a été communiqué avant l’Assemblée.
<i>Deuxième Résolution:i>
L’Assemblée décide d’approuver le rachat par la Société de trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions émises
de la Société, tel que déterminé par le conseil d’administration de la Société en conformité avec l’article cinq (5) des
Statuts et accepté par les Actionnaires, en conformité avec les articles 49-2 et suivants de la Loi concernant les Sociétés
Commerciales.
<i>Troisième Résolution:i>
L’Assemblée prend acte que, suite à l’approbation du rachat tel que décrit ci-dessus, la Société détient l’intégralité des
trente-trois mille sept cent treize (33.713) actions en circulation, chaque action ayant une valeur nominale de deux euros
(EUR 2,-).
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide de réduire le capital social de la Société d’un montant de
soixante-sept mille quatre cent vingt-six euros (EUR 67.426,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant
actuel de deux cent soixante-quatorze mille sept cents euros (EUR 274.700,-), représenté par cent trente-sept mille trois
cent cinquante (137.350) actions, chaque action ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-), à un montant de
deux cent sept mille deux cent soixante-quatorze euros (EUR 207.274,-) par annulation de toutes les trente-trois mille
sept cent treize (33.713) actions détenues par la Société, en conformité avec les articles 49-2 et suivants de la Loi con-
cernant les Sociétés Commerciales.
<i>Quatrième Résolution:i>
En conséquence de ce qui précède, l’Assemblée décide de modifier le premier (1
er
) paragraphe de l’article cinq (5)
des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus de sorte qu’il aura désormais la teneur suivante:
31150
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. (premier paragraphe). Le capital souscrit de la société est fixé à deux cent sept mille deux cent soixante-
quatorze euros (EUR 207.274,-), représenté par cent trois mille six cent trente-sept (103.637) actions d’une valeur
nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.»
<i>Cinquième Résolution:i>
L’Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les modifications ci-dessus
avec donne pouvoir et autorise tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, à procéder au nom et pour le
compte de la Société aux modifications ci-dessus dans le registre des actionnaires de la Société.
<i>Estimation des fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison
du présent acte, sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500).
Plus rien étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 17.50 heures.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mêmes parties comparantes et en cas de divergence
entre les versions anglaise et française, la version anglaise prévaudra.
Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l’étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux parties comparantes, connues du notaire soussigné par leurs noms, prénoms usuels, état civil
et demeure, lesdites parties comparantes ont signé avec le notaire soussigné le présent acte.
Signé: F. Stolz-Page, C. Oberhag, B. Wahl, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 02 février 2015. GAC/2015/935. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 5 mars 2015.
Référence de publication: 2015037589/198.
(150042694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mars 2015.
I-Wo 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 174.240.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 2 février 2015i>
1. M. Frank PLETSCH a démissionné de son mandat de gérant.
2. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
3. M. Oliver THOMAS, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1983 à Geilenkirchen (Allemagne), demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, pour une durée indéter-
minée.
4. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, avec effet au 14 janvier
2015, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour I-Wo 5 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015018168/20.
(150021497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Mastercraft Language Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2560 Luxembourg, 88, rue de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 133.131.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018318/9.
(150021449) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
31151
L
U X E M B O U R G
Worldwide Consultancy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8211 Mamer, 113, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 111.597.
L'an deux mille quinze, le trentième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
1. Monsieur Musiliu Raphael ADELEKE, commerçant, demeurant à L-8024 Strassen, 37 C, rue Henri Dunant.
Lequel comparant, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- Lequel comparant est le seul et unique associé de la société «Worldwide Consultancy S.à r.l.», société à responsa-
bilité limitée, ayant son siège social à L-8039 Strassen, 4, rue des Près, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
du Luxemburg sous le numéro B 111.597, constituée suivant acte reçu de Maître Blanche MOUTRIER, notaire de rési-
dence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg) du 4 novembre 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations du 15 février 2006, numéro 335, et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu de
Maître Aloyse BIEL, alors notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations du 1 août 2008 sous le numéro 1899 (ci-après la «Société»).
II.- Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100)
parts sociales de cent-vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune, toutes entièrement libérées et appartenant à l’associé unique
pré-qualifié.
III. L’associé unique représentant l’intégralité du capital social s’est réuni en assemblée générale extraordinaire à laquelle
il se considère comme dûment convoqué et a pris les résolutions suivantes, qu'il a demandé au notaire d’acter comme
suit:
<i>Ordre du jouri>
1. Transfert du siège social de la Société de L-8039 Strassen, 4, rue des Près à L-8211 Mamer, 113, Route d'Arlon.
2. Modification subséquente de l’article 2 des statuts de la Société.
3. Divers.
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de transférer le siège social de la Société, de son adresse actuelle de L-8039 Strassen, 4, rue
des Près à L-8211 Mamer, 113, Route d'Arlon.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de modifier en conséquence l’article 2 des statuts de la Société pour lui donner désormais la
teneur suivante:
Art. 2. «Le siège de la société est établi dans la commune de Mamer.
Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la même commune par simple décision du gérant ou, en cas de
pluralité de gérants, du Conseil de gérance, et en tout endroit du Grand Duché de Luxembourg aux termes d'une décision
prise par assemblée tenue dans les formes prescrites pour les modifications des statuts.
La société peut ouvrir des succursales, filiales ou d’autres bureaux, dans tout autre lieu du Grand-Duché de Luxem-
bourg, ainsi qu'à l’étranger.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à mille euros (EUR 1.000,-).
Dont acte, fait et passé à Diekirch, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. R. ADELEKE, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 février 2015. Relation: DAC/2015/1831. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 04 février 2015.
Référence de publication: 2015020095/52.
(150023185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
31152
Agripartes S.A.
Allegro Short Term Bond Fund
Assenagon Substanz
Association des Fonctionnaires du Greffe de la Chambre des Députés
Association du Personnel de l'Administration Parlementaire de la Chambre des Députés
BETA REAL ESTATE (Luxembourg) S.à r.l.
BIGA-Holz S.à r.l.
Biochar S.A.
Bios S.A.
By Car Inlux Sàrl
C. Hypothek Lux S.à r.l.
Degroof Holding Luxembourg S.A.
Delamain S.à r.l.
Deltalux-Business S.à r.l.
Deluxegroup S.A.
DFR SARL
DGV Investment S.A.
Dixie Five SA
Djerba SA SPF
Dudimmo S.A.
DUVAL INVESTMENTS S.A., société de gestion de patrimoine familial
Flossbach von Storch
Ganador
Global Absolute Return OP
Helca S.A.
Hobevest S.A.
Hormuz Holding S.A.
Hüsges Group International S.à r.l.
Iberian Finance S.à r.l.
I-Wo 5 S.à r.l.
J Goncalves S. à r.l.
LILIE Caesar S.à r.l.
Mastercraft Language Solutions S.à r.l.
Norpaper Groupe S.à r.l.
OCM Luxembourg French Leisure SV
OG AcquisitionCo 1 S.à r.l.
Orion IV European 9 S.à r.l.
QS Italy SICAR S.A.
QS PEP S.C.A., SICAR
Queensberry House Building
Saverfin S.A.
Solomo365 S.à r.l.
Soparfi MT 2014/480
StepStone European Fund SCS, SICAV-FIS
Syz Europe S.A.
Syz & Partners Europe
Tech Age
Tiago First Frankfurt Properties Limited S.à r.l.
Titanium I Sicav
Turlux
Unden II S.A.
Vermietungsgesellschaft Objekt Kirchberg mbH
Worldwide Consultancy S.à r.l.