This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 641
9 mars 2015
SOMMAIRE
Alinvest Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30722
Amalthee S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30723
ArcIndustrial France Developments I S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30728
Asport I & W, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30723
Autoécole Diederich S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
30723
Azulux S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30722
Beverage Investment Group S.A. . . . . . . . .
30722
Beverage Investment Group S.A. . . . . . . . .
30723
Beverage Investment Group S.A. . . . . . . . .
30722
Bibo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30723
Bigpoint Manager Investments S.C.A. . . . .
30767
Bobby S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30724
Brie Project N° 3 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
30739
BR Jack S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30734
Caldia Fiduciaire S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30749
Cantobre S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30728
CHURCHILL.HUI International S.A. . . . .
30722
CMS Management Services S.A. . . . . . . . . .
30728
Commercial Project Holdings S.à r.l. . . . .
30739
Compagnie Mobilière S.A. . . . . . . . . . . . . . .
30728
Cosminvest SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30724
Design Finance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30726
Doosan Power Systems S.A. . . . . . . . . . . . .
30726
EPIC I GP, S.à rl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30759
Fürstenberger Siedlung 2 S.à r.l. . . . . . . . . .
30749
Horwitz & Partners Advisors . . . . . . . . . . . .
30768
Immomo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30729
Jack (Cologne 20) S. à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
30734
Jessan Participations S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
30729
KP Automotive S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30729
Lacombe Investissement S.A. . . . . . . . . . . .
30768
LFI Brie Comte Robert . . . . . . . . . . . . . . . . .
30739
Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
30744
Murano Invest S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30768
NEDP Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30764
New Village S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30738
Oaktree Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30725
Openregistry S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30725
PAN Asia Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . .
30729
Panev S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30724
Patron ES Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
30725
PG Europe Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
30725
Picard Bondco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30750
Picard PIKco S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30755
Point Lobos S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30724
Safran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30754
Symbiotics SICAV (Lux.) . . . . . . . . . . . . . . .
30730
Tyco Fire & Security Finance S.C.A. . . . . .
30727
Valeur S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30727
Westendam Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
30726
Xevin Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
30727
YBL S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30727
30721
L
U X E M B O U R G
Azulux S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 70.273.
Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015018686/10.
(150022468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Alinvest Ltd, Société Anonyme.
Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.
R.C.S. Luxembourg B 129.216.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 03 février 2015.
Référence de publication: 2015018666/10.
(150022524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Beverage Investment Group S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.779.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015018707/11.
(150022316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Beverage Investment Group S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.779.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015018708/11.
(150022317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
CHURCHILL.HUI International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 4, avenue du Docteur Ernest Feltgen.
R.C.S. Luxembourg B 76.539.
La société LE COMITIUM INTERNATIONAL SA (RCS B83527) démissionne de ses fonctions de commissaire aux
comptes de la société CHURCHILL.HUI INTERNATIONAL SA (RCS B 76.539) au 4a, Avenue du Dr Ernest Feltgen,
L-5635 Mondorf-les-Bains.
Luxembourg, le 4 février 2015.
COMITIUM INTERNATIONAL
Référence de publication: 2015018769/12.
(150023040) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30722
L
U X E M B O U R G
Autoécole Diederich S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-6463 Echternach, 14, rue Maximilien.
R.C.S. Luxembourg B 104.712.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Echternach, le 4 février 2015.
Signature.
Référence de publication: 2015018683/10.
(150022870) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Asport I & W, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9099 Ingeldorf, rue du XXII Mai 2008, Z.I. Walebroch.
R.C.S. Luxembourg B 101.921.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015018681/10.
(150022775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Beverage Investment Group S.A., Société Anonyme Holding.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 117.779.
Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un administrateuri>
Référence de publication: 2015018709/11.
(150022318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Bibo S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.
R.C.S. Luxembourg B 95.591.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
i>Signature
Référence de publication: 2015018711/11.
(150023118) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Amalthee S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.864.
Les comptes annuels arrêtés au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Amalthee S.A.
Société Anonyme
Référence de publication: 2015018672/12.
(150023057) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30723
L
U X E M B O U R G
Point Lobos S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2210 Luxembourg, 38, boulevard Napoléon 1er.
R.C.S. Luxembourg B 136.911.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019142/9.
(150022929) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Panev S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 41.036.
La liste des Fondés de pouvoir A et B a été déposée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019153/12.
(150022898) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Cosminvest SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 67.830.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
COSMINVEST S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015018781/17.
(150022733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Bobby S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.
R.C.S. Luxembourg B 183.835.
Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,
et par décision de l'administrateur unique en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.
Luxembourg, le 4 février 2015.
<i>Pour: BOBBY S.A.
i>Experta Luxembourg
Société anonyme
Référence de publication: 2015018717/16.
(150022957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30724
L
U X E M B O U R G
Oaktree Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 22.951.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg.
Référence de publication: 2015019097/10.
(150022920) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Patron ES Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 20.000,00.
Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 140.636.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015019131/10.
(150022510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
PG Europe Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 50.000,00.
Siège social: L-1631 Luxembourg, 37, rue Glesener.
R.C.S. Luxembourg B 183.329.
En date du 16 janvier 2015, Catherine Delsemme, gérant B de la Société, a changé d'adresse qui est désormais la
suivante:
Catherine Delsemme
37 rue Glesener
L-1631 Luxembourg
Luxembourg, le 19 janvier 2015.
Catherine Delsemme.
Référence de publication: 2015019157/14.
(150022875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Openregistry S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Léon Laval.
R.C.S. Luxembourg B 159.319.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de la société adoptées le 19 janvier 2015i>
Il résulte des résolutions que:
1. Domain Tools Holding S.à r.l. 3Q Management Limited, Sensirius CVBA et M. Geert Debyser ont démissionné avec
effet au 19 janvier 2015 en tant qu'administrateurs.
2. M. Atul PATEL, né à Hyde (Royaume Uni) le 14 avril 1967, demeurant à Manchester Technology Centre, Oxford
Road, Manchester, M1 7EF, Royaume Uni et M. Robert COTTON, né à Reading (Royaume-Uni) le 15 février 1965,
demeurant à Manchester Technology Centre, Oxford Road, Manchester, M1 7EF, Royaume Uni ont été nommés admi-
nistrateurs de la Société avec effet au 19 janvier 2015. Leur mandat expirera lors de la tenue de l'assemblée générale des
actionnaires de la Société statuant sur l'approbation des comptes pour l'année se clôturant au 31 décembre 2020.
Howald, le 19 janvier 2015.
Pour extrait conforme
Pierre-Alexandre DEGEHET
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015019105/20.
(150022193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30725
L
U X E M B O U R G
Design Finance, Société Anonyme.
Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.
R.C.S. Luxembourg B 153.651.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration de la société Design Finance SA en date du 02 févrieri>
<i>2015i>
Le Conseil d'Administration décide de nommer comme dépositaire la société FISCOGES Sàrl, ayant son siège social
au 4, rue de Kleinbettingen, L - 8362 Grass, enregistrée au Registre de Commerce et des sociétés sous le numéro B174051.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Signatures
Référence de publication: 2015018793/14.
(150023135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Doosan Power Systems S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 125.754.
<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 23 janvier 2015i>
1. Monsieur Key Sun HAN a démissionné de son mandat d'administrateur.
2. Monsieur Ji Taik CHUNG, administrateur de sociétés, né à Seoul (République de Corée) le 21 mars 1950, demeurant
professionnellement à 555, Guigok-dong, Changwon-si, 641-792 Gyengsangnam-do, République de Corée a été nommé
administrateur, avec effet au 23 janvier 2015 et jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2015.
Luxembourg, le 4 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Doosan Power Systems S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015018794/16.
(150022820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Westendam Europe S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 51.569.
<i>Extrait des résolutions de l'assemblée générale statutaire tenue le 26 mai 2014i>
Les mandats des administrateurs, A.T.T.C. Management s.à r.l. ayant son siège social 16 rue de Nassau, L-2213 Lu-
xembourg, représentée par Monsieur Nico Patteet, représentant permanent, résidant professionnellement au 16 rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg; A.T.T.C. Directors s.à r.l. ayant son siège social 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg,
représentée par Monsieur Koen Van Huynegem, représentant permanent résidant professionnellement au 16 rue de
Nassau, L-2213 Luxembourg et A.T.T.C. Services s.à r.l. ayant son siège social 16 rue de Nassau, L-2213 Luxembourg
représentée par Monsieur Nico Patteet, représentant permanent résidant professionnellement au 16 rue de Nassau,
L-2213 Luxembourg ainsi que celui du commissaire aux comptes A.T.T.C. Control s.a., étant venus à échéance, les ad-
ministrateurs et le commissaire sortants ont été réélus dans leurs mandats respectifs pour une nouvelle durée de 6 ans
jusqu'à l'assemblée générale statutaire qui se tiendra en 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant / Gérant
i>N. Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015019341/24.
(150022190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30726
L
U X E M B O U R G
YBL S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.
R.C.S. Luxembourg B 134.437.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015019360/9.
(150022431) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Xevin Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 140.065.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015019353/10.
(150022585) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Valeur S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.
R.C.S. Luxembourg B 127.645.
<i>Extrait des décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenu au siège social en date du 3 février 2015i>
Le Conseil d'Administration, conformément à la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts
au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur, publiée au Mémorial
A no 161 du 14 août 2014, décide de nommer, comme agent dépositaire, la société ACCOUNTIS S.à r.l., ayant son siège
social au 63-65, rue de Merl, L-2146 Luxembourg, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B60 219.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
VALEUR S.A.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019331/17.
(150022717) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Tyco Fire & Security Finance S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 190.265.
En date du 11 décembre 2014, le gérant commandité de la Société a décidé de nommer avec effet au 11 décembre
2014 et ce, pour une durée indéterminée:
- Monsieur Francis James McKendry, ayant pour adresse professionnelle le 6600 Congress Avenue, Boca Raton, Floride
33487, Etats Unis d'Amérique, à la fonction de délégué à la gestion journalière de la Société; et
- Monsieur Peter Schieser, ayant pour adresse professionnelle le 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg,
à la fonction de délégué à la gestion journalière de la Société.
Il est à noter qu'ils pourront engager la Société par leur seule signature.
POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
Signature
<i>Un Mandatairei>
Référence de publication: 2015019296/18.
(150022220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30727
L
U X E M B O U R G
CM S.A., Compagnie Mobilière S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.
R.C.S. Luxembourg B 50.319.
Les comptes annuels au 30.09.2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018011/9.
(150022073) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
ArcIndustrial France Developments I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 112.938.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
Un géranti>
Référence de publication: 2015018642/11.
(150022750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Cantobre S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 50.272.
L'adresse professionnelle de Mme Michèle MORIOT, administrateur et de M. Gérard BIRCHEN, administrateur-pré-
sident a été changée du L-1331 Luxembourg, 65 boulevard Grande Duchesse Charlotte au L-2453 Luxembourg, 6 rue
Eugène Ruppert.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Pour avis sincère et conforme
<i>Pour Cantobre S.A.
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015017986/14.
(150021956) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
CMS Management Services S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 81.525.
<i>Extrait des Minutes de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de CMS Management Services S.A. qui s'est tenui>
<i>le 30 janvier 2015i>
A l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Actionnaire Unique de CMS Management Services SA (la "Société"), tenue le
30 Janvier 2015 il a été décidé comme suit:
- De nommer Mr Robert Jan Bertina ayant son adresse professionnelle au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, en qualité d'administrateur de la société avec effet au 1
er
Février 2015, son mandat prenant fin lors de
l'Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra en 2020;
- De nommer de Mr Szymon Bodjanski ayant son adresse professionnelle au 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg,
en qualité d'administrateur de la société avec effet au 1
er
Février 2015, son mandat prenant fin lors de l'Assemblée
Générale Annuelle qui se tiendra en 2020.
Luxembourg, le 2 Février 2015.
Severine Canova
<i>Administrateuri>
Référence de publication: 2015018000/20.
(150021969) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
30728
L
U X E M B O U R G
PAN Asia Investment S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 182.575.
Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018409/9.
(150021668) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Immomo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-7640 Christnach, 5, rue de Larochette.
R.C.S. Luxembourg B 173.451.
Les comptes annuels (version abrégée) au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
<i>Le commissairei>
Référence de publication: 2015018187/12.
(150021367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
KP Automotive S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 102.530.
Par résolutions signées en date du 27 janvier 2015, les associés ont pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Hervé Autet, avec adresse professionnelle au 20, quai Fernand Saguet, 94700 Maisons-Alfort, France,
au mandat de gérant B, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée;
2. Acceptation de la démission de Fernando Duarte, avec adresse au 64, Vale da Arieira-Barosa, 2401-970 Leira,
Portugal de son mandat de gérant B, avec effet immédiat;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017364/15.
(150020047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Jessan Participations S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 165.457.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 31 janvier 2015 que:
- La démission de M. Patrick MOINET, gérant de classe A de la Société a été acceptée avec effet immédiat;
- La personne suivante a été nommée gérant de classe A de la Société, avec effet immédiat et ce pour une durée
indéterminée:
* Mme Caroline GOERGEN, née le 9 juin 1979 à Verviers, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue Pasteur
L-2310 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
Référence de publication: 2015017328/17.
(150021069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
30729
L
U X E M B O U R G
Symbiotics SICAV (Lux.), Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spé-
cialisé.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 169.830.
In the year two thousand fifteen,
on the thirteenth day of the month of February.
Before Us Maître Jean-Joseph WAGNER, notary, residing in SANEM, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of “Symbiotics Sicav (Lux)” (the "Company" or the
"Sicav"), an investment company with variable capital, incorporated under the form of a public limited liability company,
having its registered office in L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer, incorporated pursuant to a notarial deed enacted on
the 27
th
June 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association (the “Mémorial”), on 13 July 2012,
under number 1765 and page 84674. The Articles of Incorporation of the Company have never been amended since.
The Meeting is declared open at 11.00 CET and is presided over by Mr Julien BOUDIN, employee, professionally
residing in Luxembourg,
who appointed as secretary Mrs Lisa SOLD, employee, professionally residing in Luxembourg.
The Meeting unanimously elected as scrutineer Mrs Alexandra SCHMITT, employee, professionally residing in Lu-
xembourg.
The board of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:
I. That the agenda of the Meeting is as follows:
<i>Agendai>
1. To insert a new article 9 of the articles of incorporation (the "Articles") to permit the Board of Directors to issue
parts bénéficiaires in accordance with the sales documents and consequent amendment to articles 10 and 23 (former 9
and 22) of the Articles.
2. To amend article 11 (former article 10) of the Articles to permit the Board of Directors to redeem shares of a Sub-
Fund in order to make a distribution. Such redemption shall be made under the conditions and at the price set forth in
the sales documents of the Sicav.
3. To amend article 16 (former article 15) of the Articles to add that the Sicav may act as an internally managed
alternative investment fund in the meaning of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "AIFM
Law") or appoint another entity as designated AIFM of the Company.
4. To amend article 27 (former article 26) of the Articles in order to allow distributions to be made in accordance
with the provisions set forth in the sales documents of the Sicav under the form of redemption of shares, dividends or
otherwise, as determined by the Board.
5. To replace any reference to the Custodian by reference to the Depositary under article 30 (former article 29) of
the Articles and update the responsibilities and liabilities of the Depositary towards the Sicav.
6. To insert a new article 31 of the Articles defining the preferential treatment of investors.
7. To insert a new article 32 of the Articles related to investors’ information.
8. To delete or update any outdated or redundant information and to clarify the Sicav’s position where appropriate
on the Articles.
II. That a first extraordinary general meeting of the Company (the "First EGM") was held on 29 December 2014 to
deliberate on the items of the agenda. Only one thousand eight hundred twenty-seven point nine seven six (1,827.976)
shares out of the seven million nine hundred ninety-one thousand two hundred and eighty-one point four eight four zero
(7,991,281.4840) shares of no par value outstanding on 29 December 2014 being represented at said meeting, this meeting
was not regularly constituted and could not validly deliberate on the items of the agenda for lack of quorum. It was thus
decided to reconvene on this day.
III. That the present Meeting has been duly convened by notices containing the agenda of the Meeting sent by registered
mail on 12 January 2015 and published in the Mémorial number 76 of 12 January 2015 and number 216 of 28 January
2015, in the daily newspapers “Luxemburger Wort” and “Tageblatt”, on 12 January 2015 and on 28 January 2015. As
indicated in the reconvening notice and relevant publications, although the substance of the agenda and the proposed
changes to the Articles have remained unchanged since the First EGM, the wording of the agenda was amended to correct
an error in the numbering of articles and the reference to the amendments to articles 10 and 23 of the Articles.
IV. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their
shares are shown on an attendance list; this attendance list signed by the shareholders present, the proxies of the re-
presented shareholders and by the Bureau will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the
registration authorities.
30730
L
U X E M B O U R G
V. It appears from the attendance list that, out of the seven million nine hundred and ninety-one thousand six hundred
and fourteen point six hundred and six (7’991’614.606) shares in issue and in circulation, one hundred (100) shares are
duly present or represented at the Meeting.
Pursuant to article 67-1(2) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting is regularly
constituted and may validly deliberate and decide upon the items of the agenda of the Meeting, whatsoever the represented
part of capital.
After deliberation, the Meeting took the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolved to insert a new article 9 of the Articles and consequently to amend articles 10 and 23 (former
9 and 22) of the Articles as follows:
(i) Insertion of a new Article "9 - Certificates" to read as follows:
" Art. 9. Certificates. In addition to share capital, the Company may, from time to time, issue parts bénéficiaires under
the meaning of Article 37 of the 1915 Law (as defined in Article 34 below), which will be referred to as "certificates" in
these Articles. Certificates shall be issued at a price and in accordance with the terms and conditions, including economic
rights, determined in accordance with the sales documents.
The Board may decide to issue Certificates against contribution in kind.
The Certificates to be issued may, as the Board shall determine, be of one or more different classes or series, the
features, terms and conditions of which shall be established by the Board in accordance with the sales documents. Cer-
tificates within a class shall rank pari passu in all respects one vis-à-vis the other.
Certificates of a specified class may also, as the Board shall determine, be of different sub-classes, the features, terms
and conditions of which shall be established by the Board and further described in the sales documents.
Certificates may be redeemable, in kind or in cash, at any time by the Company under the terms and at a price defined
in the sales documents.
Certificates shall be reserved to certain types of investors in accordance with the sales documents and will in any case
be restricted to persons qualifying as Eligible Investors.
The Certificates of a specific Class may or may not benefit from voting rights at meetings of investors of the Company
as disclosed in the sales documents.
The Board may decide to determine a net asset value per certificate in which case the provisions of Articles 12 and
13 thereof shall apply mutatis mutantis.
(ii) Insertion of a last paragraph under "Article 10: Restrictions on the ownership of shares" to read as follows:
" Art. 10. Restrictions on the ownership of shares.
(…)
The provisions of this Article shall apply, mutatis mutandis, to Certificates."
(iii) Insertion of a second paragraph under "Article 23: General meeting of shareholders" to read as follows:
" Art. 23. General meeting of shareholders.
(…)
The Board may decide to issue categories of Certificates whose holders benefit from a voting right at general meetings
of the shareholders of the Company. In case the Company has issued Certificates with a voting right, references to "shares"
or "shareholders" in provisions of these Articles or in applicable law referring to general meetings of shareholders, notably
in terms of quorum and majority requirements, shall be read as references to "shares and Certificates with a voting right"
or "shareholders and holders of Certificates with a voting right". Notwithstanding the foregoing, if the quorum or majority
requirements provided by law in relation to a general meeting of shareholders are of public order, such quorum and
majority requirements shall apply at the level of the shares issued and, in addition, the same majority requirements (at
the exclusion of quorum requirements) shall apply, mutatis mutantis, at the level of the Certificates."
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 11 (former article 10) of the Articles in order to insert a new eighteenth
paragraph so as to read as follows:
" Art. 11. Redemption and Conversion of Shares.
(…)
The Board may further redeem shares of a Sub-Fund in order to make a distribution. Such redemption shall be made
under the conditions and at the price set forth in the sales documents of the Company."
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolved to amend last paragraph of article 16 (former article 15) of the Articles to read as follows:
30731
L
U X E M B O U R G
" Art. 16. Meeting of the Board.
(…)
The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to
carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need
not be members of the Board. The Board may also delegate any of its powers, authorities and discretions to any com-
mittee, consisting of any such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit,
provided that the majority of the members of the committee are directors and that no meeting of the committee shall
be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present
are directors of the Company. The Company may act as an alternative investment fund manager ("AIFM") in the meaning
of the law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "AIFM Law") or appoint another entity as desi-
gnated AIFM of the Company."
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolved to amend the first and second paragraphs of article 27 (former article 26) of the Articles so as
to read as follows:
(1) " Art. 27. Distributions.
(2) Distributions shall be made in accordance with the provisions set forth in the sales documents of the Company
under the form of redemption of shares, dividends or otherwise, as determined by the Board. The general meeting of
shareholders, upon recommendation of the Board, shall determine how the remainder of the annual net profits shall be
disposed of and may declare dividends from time to time. Interim dividends may be distributed upon decision of the
Board.
(3) No distribution of dividends shall be made if, as a result thereof, the capital of the Company became less than the
minimum prescribed by law.
(4) (…)"
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting resolved to amend article 30 (former article 29) of the Articles to read as follows:
(5) " Art. 30. Depositary. The Company shall enter into a depositary agreement with an entity, which shall satisfy the
requirements of the Luxembourg laws (the "Depositary").
The Depositary shall assume towards the Company and its shareholders the responsibilities provided by applicable
laws and regulations, as amended from time to time.
The Company hereby expressly allows the Board to decide whether to grant a discharge of liability to the Depositary
under the condition that this discharge is not prohibited by any applicable laws and regulations and shall be in place in
accordance with the conditions set out in applicable laws and regulations.
Information regarding any discharge of the Depositary’s liability, as well as any material change to this information, may
be disclosed or made available to Investors in, via and/or at any of the Information Means listed in Article 31 of these
Articles; it being understood that availability or disclosure of any information regarding discharge of the Depositary’s
liability may be restricted to the largest extent authorised by applicable laws and regulations.
To the maximum extent authorised by applicable laws and regulations, the Company hereby expressly authorises the
Board to decide to agree upon the transfer of any assets of the Company to, and reuse by, of any third party, including
the Company's Depositary appointed from time to time."
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting resolved to insert a new article 31 of the Articles to read as follows:
" Art. 31. Preferential treatment of Investors. Any prospective or existing shareholder (an "Investor" or collectively
the "Investors") may be accorded a preferential treatment, or a right to obtain a preferential treatment (a "Preferential
Treatment") subject to, and in compliance with the conditions set forth in applicable laws and regulations.
A Preferential Treatment may consist (i) in the diminution or removal of any applicable fees, (ii) in the partial or total
reimbursement or rebate of certain fees, charges and/or expenses, (iii) in preferential terms applicable to any subscription,
redemption, conversion or transfer of shares (such as shorter or no prior notice, lower or no minimum amount requi-
rements, lower or no gating, reduced or no side-pocketing, tag-along or drag-along rights; the foregoing being illustrative
and not exhaustive), (iv) in the possibility of avoiding investment in, or exposure to, certain assets, liabilities or counter-
parties, (v) in the access to, or increased transparency of information related to certain aspects of the Company's portfolio
or of the Company's or its AIFM's management or activities (whether past, present and/or future) in general, (vi) in
preferential terms in relation to any distribution (whether of dividends, carried interests, liquidation proceeds or of any
other amount that may be distributed by the Company to Investors), (vii) in certain preferential terms and rights (including
veto) in relation to the appointment or removal of members of the Company's or its AIFM's governing bodies and/or
internal committees, (viii) in the participation to the Company's or its AIFM's management or activities in general (including
participation to their governing bodies and/or internal committees), (ix) in a right to veto, to postpone or to otherwise
30732
L
U X E M B O U R G
condition certain decisions or resolutions, (x) in increased or additional voting rights, (xi) in a "most favoured nation" (or
similar) right, or (xii) in any other advantage or privilege that is not inconsistent with these Articles and/or with applicable
laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the discretion of the Company and/or its
AIFM.
A Preferential Treatment may be accorded on the basis (i) of the size, nature, timing or any feature of the investment
in, or of any commitment taken vis-à-vis the Company, (ii) of the type, category, nature, specificity or any feature of the
Investor or Investors, (iii) of the involvement in, or participation to the Company's or its AIFM's management or activities
(whether past, present and/or future) in general, or (iv) of any other criteria, element or feature that is not inconsistent
with these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the
discretion of the Company and/or its AIFM.
A Preferential Treatment may (x) take the form (i) of a contractual arrangement, (ii) of a side letter or (iii) of the
creation of a specific category or Class of shares, or (y) take any other form or arrangement that is not inconsistent with
these Articles or with applicable laws and regulations and that may be determined from time to time by, and in the
discretion of, the Company and/or its AIFM.
A Preferential Treatment is not necessarily assorted with the so-called "most favoured nation" clause in favour of all
Investors, meaning that, unless otherwise provided to the contrary or required by applicable laws or regulations, the
existence or introduction of a Preferential Treatment or the fact that one or more Investors have been accorded a
Preferential Treatment does not create a right in favour of any other prospective or existing Investor to claim for its
benefit such a Preferential Treatment, even if, in relation to this Investor, all criteria and features on which is based the
relevant Preferential Treatment are met, and even if the situation and features of this Investor are similar to any of the
Investors to whom this Preferential Treatment has been accorded.
Whenever an Investor obtains a Preferential Treatment, a description of that Preferential Treatment, the type of
Investors who obtain such Preferential Treatment and, where relevant, their legal or economic links with the Company
or its AIFM, as well as any material change to this information, may be disclosed or made available to Investors in, via
and/or at any of the Information Means listed in Article 31 of these Articles; it being understood that availability or
disclosure of any information regarding Preferential Treatment may be restricted to the largest extent authorised by
applicable laws and regulations."
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting resolved to insert a new article 32 of the Articles to read as follows:
" Art. 32. Investor's Information. Any information or document that the Company or its AIFM must or wishes to
disclose or be made available to some or all of the Investors shall be validly disclosed or made available to any of the
concerned Investors in, via and/or at any of the following information means (each an "Information Means"): (i) the
Company's sales documents, offering or marketing documentation, (ii) subscription, redemption, conversion or transfer
form, (iii) contract note, statement or confirmation in any other form, (iv) letter, telecopy, e-mail or any type of notice
or message, (v) publication in the (electronic or printed) press, (vi) the Company's periodic report, (vii) the Company's,
AIFM's or any third party's registered office, (viii) a third-party, (ix) internet/a website (as the case may be subject to
password or other limitations) and (x) any other means or medium to be freely determined from time to time by the
Company or its AIFM to the extent that such means or medium comply and remain consistent with these Articles and
applicable laws and regulations.
The Company or its AIFM may freely determine from time to time the specific Information Means to be used to
disclose or make available a specific information or document, provided, however, that at least one current Information
Means used to disclose or make available any specific information or document to be disclosed or made available shall at
least be indicated in either the Company's sales documents or at the Company's or AIFM's registered office.
Certain Information Means (each hereinafter an "Electronic Information Means") used to disclose or make available
certain information or document requires an access to internet and/or to an electronic messaging system. By the sole
fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor acknowledges the possible use of Electronic
Information Means and confirms having access to internet and to an electronic messaging system allowing this Investor
to access the information or document disclosed or made available via an Electronic Information Means.
By the sole fact of investing or soliciting the investment in the Company, an Investor (i) acknowledges and consents
that the information to be disclosed in accordance with applicable laws and regulations may be provided by means of a
website without being addressed personally thereto and (ii) that the address of the relevant website and the place of the
website where the information may be accessed is indicated in either the Company's sales documents or at the Company's
or AIFM's registered office. "
<i>Eighth resolutioni>
The Meeting resolved to delete or update any outdated or redundant information and to clarify the Sicav’s position
where appropriate on the Articles.
There being no further business before the Meeting and no shareholder present or any other person wishes to speak,
the chairman adjourned thereupon the Meeting at 11.20 CET.
30733
L
U X E M B O U R G
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg, on the day
named at the beginning of this document.
The document having been read to the members of the Board of the Meeting, said persons appearing, signed together
with Us, the notary, the present original deed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the above appearing
parties, this current deed is worded in English only, in accordance with article 26 of the Law of 13 February 2007.
Signé: J. BOUDIN, L. SOLD, A. SCHMITT, J.J.WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 24 février 2015. Relation: EAC/2015/4399. Reçu soixante-quinze Euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015035392/236.
(150039599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 mars 2015.
BR Jack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.137.
Jack (Cologne 20) S. à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 114.140.
PROJET COMMUN DE FUSION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-sixth day of the month of February;
Before Us M
e
Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
THERE APPEARED:
1) Mr. Christian DOSTERT, notary clerk, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling,
acting on behalf of the board of managers of the company “BR Jack S.à r.l.”, designated hereafter,
by virtue of a proxy given by the board of managers on February 25, 2015, such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be
recorded with it;
and
2) Mr. Christian DOSTERT, pre-named,
acting on behalf of the board of managers of the company “Jack (Cologne 20) S.à r.l.”, designated hereafter,
by virtue of a proxy given by the board of managers on February 25, 2015, such proxy, after having been signed “ne
varietur” by the appearing person and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be
recorded with it.
The appearing parties, represented as said before, requested the undersigned notary to record that the managers of
the here-after called Absorbing Company and the board of managers of the here-after called Absorbed Company have
adopted a common terms of merger as follows:
Common draft terms of merger
BETWEEN:
1) the private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“BR Jack S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, registered with
the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, number 114.137, (hereinafter referred to as the “Absorbing
Company”),
originally incorporated under the name of “MGP Jack S.à r.l.”, pursuant to a deed M
e
Paul BETTINGEN, notary residing
in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), on 30 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations, number 868 of May 3, 2006,
and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the
officiating notary, on December 9, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 637
of March 11, 2014, containing notably the adoption by the Absorbing Company of its current denomination as well as a
complete restatement of the articles of association;
AND
2) the private limited liability company incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg
“Jack (Cologne 20) S.à r.l.”, established and having its registered office in L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal,
30734
L
U X E M B O U R G
registered with the Trade and Companies Register of Luxembourg, section B, under number 114.140, (hereinafter re-
ferred to as the “Absorbed Company”),
incorporated pursuant to a deed M
e
Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg),
on 30 January 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 901 of May 9, 2006,
and whose articles of association have been amended several times and for the last time pursuant to a deed of the said
notary Paul BETTINGEN, on March 26, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
1609 of August 20, 2009.
The Absorbing Company and the Absorbed Company are hereinafter collectively referred to as the “Merging Com-
panies”.
WHEREAS:
(A) The corporate capital of the Absorbing Company is set out at EUR 3,199,275.-, represented by 127,971 fully paid
up corporate units and having a par value of EUR 25.- each. The corporate capital of the Absorbed Company is set out
at EUR 1,949,025.-, represented by 77,961 corporate units fully paid up and having a par value of EUR 25.- each.
(B) The Absorbing Company holds the entire corporate capital of the Absorbed Company.
(C) Neither the Absorbing Company nor the Absorbed Company have been dissolved or declared bankrupt or have
applied for suspension of payments.
(D) The respective management bodies of the Merging Companies intend to merge the companies. Such merger will
consist in the absorption of the Absorbed Company by the Absorbing Company (the “Merger”).
(E) As a result of such Merger, all assets and liabilities of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing
Company and the Absorbed Company will be dissolved without liquidation.
(F) Given that the Absorbing Company is the sole member of the Absorbed Company holding 100% of the latter’s
corporate capital, the Merger will be subject to the provisions of articles 278 to 280 of the law dated 10 August 1915 on
Commercial Companies as amended (the “Law”).
(G) The present common draft terms of merger is recorded in a notarial deed in compliance with the requirements
of article 271 of the Law.
Now, therefore, the management bodies of the Merging Companies set out the following Terms of Mer-
ger:
I. Form, corporate denomination and registered office of the Merging Companies and those proposed for the company
resulting from the Merger. The Merging Companies have the form, corporate denominations and registered office as set
out here before.
Following the Merger, the Absorbing Company will maintain its form as a private limited liability company, (société à
responsabilité limitée), and its corporate denomination will remain unchanged.
II. Date as from which the operations of the Absorbed Companies will be treated for accounting purposes as being
carried out on behalf of the Absorbing Companies. The date as from which the transactions of the Absorbed Company
will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company is agreed to be January
1, 2015.
III. Rights conferred by the Absorbing Company to shareholders having special rights and/or to holders of securities
other than corporate units or measures proposed towards them. The sole shareholder of the Absorbed Company does
not hold any special rights and there are no holders of securities other than corporate units. Therefore, no special rights
will be given and no compensation will be paid to anyone.
IV. Special advantages granted to the independent auditors, or the members of the administrative, management, su-
pervisory or controlling organs of the Merging Companies. No special advantages have been or will be granted to the
independent auditors or the members of the administrative, management, supervisory or controlling organs of the Merging
Companies or to any other person involved in the Merger.
Due to the fact that article 278 of the Law will be applicable to the Merger, an independent auditor report will not be
required in this context. Therefore, no special advantages will be granted to any such independent auditor.
V. Publication, shareholder’s rights, effective date. According to the provisions of article 279 and article 262 of the
Law, the present draft common terms of the Merger will be published in the National Official Gazette of the Grand Duchy
of Luxembourg for each of the Merging Companies at least one month before the operation of merger takes effect
between the Merging Companies.
Further, all shareholders of the Absorbing Company will be entitled, at least one month before the operation takes
effect as between the Merging Companies, to inspect the following documents at the registered office of the Absorbing
Company:
- the present draft terms of the Merger;
- the annual accounts and the management reports of the Merging Companies for the last three financial years;
- the accounting statement of the Merging Companies as at December 31, 2014.
30735
L
U X E M B O U R G
Finally, one or more members of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital
will be entitled during the period of one month before the operation takes effect as between the Merging Companies to
require that a general meeting of the Absorbing Company be called in order to decide whether to approve the merger.
The meeting will be convened in such a manner so as to be held within one month of the request for it to be held.
The Merger shall take effect upon publication in accordance with article 9 of the Law of a notary certificate recording
that the conditions of Article 279 of the Law are fulfilled. Such certificate shall be established upon request of the Absorbing
Company after expiration of one month following publication of the present draft terms of merger for both Merging
Companies in the National Gazette of the Grand Duchy of Luxembourg in accordance with article 9 of the Law provided
that no general meeting of the Absorbing Company was called in accordance to article 279 of the Law.
VI. Keeping of the corporate documents and books of the Absorbed Company. The corporate document and books
of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for a period of five years
starting as from the effective date of the Merger.
VII. Costs and fees. Any costs and fees connected to the Merger and the setting-up and implementation of these
common draft terms of Merger as well as accruing transaction tax and any other duties (if any) shall be borne by the
Absorbing Company.
<i>Attestationi>
The undersigned notary attests the legality of the present Common Terms of Merger in conformity with article 271
(2) of the Law.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing parties and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing person, acting as said before, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said appearing person has signed with Us the notary the present deed.
Suit la version française de ce qui précède:
L'an deux mille quinze, le vingt-sixième jour du mois de février;
Par-devant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
A COMPARU:
1) Monsieur Christian DOSTERT, clerc de notaire, demeurant professionnellement à L-1466 Luxembourg, 12, rue
Jean Engling,
agissant au nom et pour compte du conseil de gérance de la société “BR Jack S.à r.l.”, désignée ci-après,
en vertu d’un pouvoir conféré par le conseil de gérance le 25 février 2015 lequel pouvoir, après avoir été signé “ne
varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
2) Monsieur Christian DOSTERT, pré-qualifié,
agissant au nom et pour compte du conseil de gérance de la société “Jack (Cologne 20) S.à r.l.”, désignée ci-après,
en vertu d’un pouvoir conféré par le conseil de gérance le 25 février 2015 lequel pouvoir, après avoir été signé “ne
varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être enregistrée avec lui.
Les parties comparantes, représentées de la manière décrite ci-dessus demandent au notaire d’acter que le conseil de
gérance de la Société Absorbante et le conseil de gérance de la Société Absorbée ont approuvé le projet commun de
fusion comme suit:
Project commun de fusion
ENTRE:
1) la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “BR Jack S.à
r.l.”, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.137, (ci-après dénommée la “Société Absorbante”),
originairement constituée sous le nom de “MGP Jack S.à r.l.”, suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire
de résidence à (Grand-Duché de Luxembourg), le 30 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations, numéro 868 du 3 mai 2006,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire
instrumentant, le 9 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 637 du 11 mars
30736
L
U X E M B O U R G
2014, contenant notamment l’adoption par la Société Absorbante de sa dénomination actuelle ainsi qu'une refonte com-
plète des statuts;
ET
2) la société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “Jack (Cologne
20) S.à r.l.”, établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 28, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 114.140, (ci-après dénommée la “Société Absorbée”),
constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de
Luxembourg), le 30 janvier 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 901 du 9 mai 2006,
et dont les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par ledit notaire Paul
BETTINGEN, le 26 mars 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1609 du 20 août
2009.
La Société Absorbante et la Société Absorbée sont ensemble ci-après désigné comme les “Sociétés”.
CONSIDERANT QUE:
(A) Le capital social de la Société Absorbante est fixé à 3.199.275,- EUR, représenté par 127.971 parts sociales entiè-
rement libérés et ayant une valeur nominale de 25,- EUR chacune. Le capital social de la Société Absorbée est fixé à
1.949.025,-EUR, représenté par 77.961 parts sociales entièrement libérés et ayant une valeur nominale de 25,- EUR
chacune.
(B) La Société Absorbante détient la totalité du capital social de la Société Absorbée.
(C) Ni la Société Absorbante ni la Société Absorbée n’ont été dissoutes ni déclarées en faillite, ni se trouvent en état
de cessation de paiement.
(D) Les organes respectifs de gestion des Sociétés ont l’intention de fusionner les deux sociétés. Cette fusion consistera
dans l’absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la “Fusion”).
(E) Suivant cette fusion, la Société Absorbée transférera l’intégralité de ses actifs et passifs à la Société Absorbante et
la Société Absorbée sera dissoute sans liquidation préalable.
(F) Étant donné que la Société Absorbante est l’associé unique de la Société Absorbée et détient 100% du capital social
de cette dernière, la Fusion sera soumise aux énonciations des articles 278 à 280 de la loi sur les sociétés commerciales
du 10 août 1915 modifiée (la “Loi”).
(G) Le présent projet commun de fusion est enregistré sous forme d’acte notarié suivant les exigences de l’article 271
de la Loi.
Sur ce, les organes de gestion des Sociétés fusionnantes ont fixé les modalités de fusion suivantes:
I. Forme, dénomination et siège social des Sociétés et celles envisagés pour la Société issue de la Fusion. Suite à la
Fusion, la Société Absorbante maintiendra sa forme juridique sous forme de société à responsabilité limitée et sa déno-
mination restera inchangée.
II. Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme
accomplies pour le compte de la Société Absorbante. La date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée
sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante est fixée au 1
er
janvier 2015.
III. Droits assurés par la Société Absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres
que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard. L’associé unique de la Société Absorbé n’a pas de droits
spéciaux et il n’y a aucun porteur de titres autres que des parts sociales. Aucun droit spécial ne sera conféré et aucune
compensation ne sera payée.
IV. Avantages particuliers attribués aux experts, aux membres des organes d’administration, de direction, de surveil-
lance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. Aucun avantage particulier n’a été ou sera attribué aux experts, aux
membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des Sociétés ou à une personne
impliquée dans la Fusion.
Etant donné que l’article 278 de la Loi sera applicable à la Fusion, un expert ou plus particulièrement, un réviseur
d'entreprise ne sera pas requis dans ce contexte. En ce sens, aucun avantage spécial ne sera conféré à un tel réviseur
d’entreprise.
V. Publication, droits d’associé et date effective. Suivant les exigences de l’article 279 et de l’article 262 de la Loi, le
présent projet commun de fusion sera publié au journal officiel du Grand-duché de Luxembourg pour chacune des Sociétés
au moins un mois avant que l’opération de Fusion ne prenne effet entre les Sociétés.
De plus, tous les associés de la Société Absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l’opération de Fusion ne
prenne effet entre parties, de prendre connaissance, au siège social de la Société Absorbante, des documents suivants:
- le projet commun de Fusion;
- les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des Sociétés;
- un état comptable des Sociétés arrêté à la date du 31 décembre 2014.
30737
L
U X E M B O U R G
Finalement, un ou plusieurs associés de la Société Absorbante disposant d’au moins 5% des actions du capital souscrit
ont le droit de requérir pendant le délai d’un mois avant que l’opération prenne effet entre les Société, la convocation
d’une assemblée générale de la Société Absorbante appelée à se prononcer sur l’approbation de la fusion. L’assemblée
sera convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition.
La fusion prendra effet après la publication faite conformément à l’article 9 de la Loi d’un certificat d’un notaire cons-
tatant que les conditions de l’article 279 de la Loi sont remplies. Un tel certificat sera établi à la requête de la Société
Absorbante après l’expiration d’un mois suivant la publication du présent projet commun de fusion au journal officiel du
Grand-duché de Luxembourg conformément à l’article 9 de la Loi pour chacune des Sociétés sous condition qu'aucune
assemblée générale de la Société Absorbée n’a été convoqué conformément à l’article 279 de la Loi.
VI. Conservation des documents sociaux et des livres de la Société Absorbée. Les documents sociaux et les livres de
la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant une période de cinq ans à partir
de la date effective de la Fusion.
VII. Frais et dépenses. Les frais et dépenses liés à la Fusion et à la constitution et l’implémentation du présent projet
commun de fusion ainsi que les impôts accumulée lors de la transaction et toute autre obligation (le cas échéant) seront
pris en charge par la Société Absorbante.
<i>Attestationi>
Le notaire instrumentant atteste la légalité du présent Projet Commun de Fusion, conformément aux dispositions de
l’article 271 (2) de la Loi.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte
est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la demande desdites parties comparantes, il est précisé qu'en
cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire par ses nom, prénom, état
civil et domicile, ledit comparant a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: C. DOSTERT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg, A.C. 2, le 27 février 2015. 2LAC/2015/4391. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 3 mars 2015.
Référence de publication: 2015035566/238.
(150040552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 mars 2015.
New Village S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 151.904.
Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg.
L'adresse de Monsieur Ronald W. DE KONING, gérant de la Société, a changé avec effet au 1
er
février 2015 et se
trouve désormais au:
- Noordensweg 52, 2421 XZ Nieuwkoop, Pays-Bas.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 2 février 2015.
New Village S.à r.l.
Signature
Référence de publication: 2015018336/17.
(150021890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
30738
L
U X E M B O U R G
LFI Brie Comte Robert, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 122.709.
Commercial Project Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 115.476.
Brie Project N° 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 124.463.
PROJET DE FUSION
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-fifth of February.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1) LFI Brie Comte Robert, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 122.709 (the “Absorbing Company”),
here represented by Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,
given in Luxembourg, on February 20, 2015, and
2) Commercial Project Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 115.476 (the “Absorbed Company 1”)
here represented by Mrs Alexander Olliges, previously named by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on February
20, 2015, and
3) Brie Project N° 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 124.463 (the “Absorbed Company 2” and together with
the Absorbed Company 1, the “Absorbed Companies” and together Absorbing Company, the “Merging Companies”),
here represented by Mr Alexander Olliges, previously named, by virtue of a proxy, given in Luxembourg, on February
20, 2015.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing parties have requested the officiating notary to enact the common terms of merger which the Merging
Companies, acting through their board of managers, declare to draw up the following:
Common Terms of Merger
(the “Common Terms of Merger”)
1. The companies involved in the merger.
- LFI Brie Comte Robert, a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 122.709, pursuant to a deed of incorporation of the un-
dersigned notary, on 15 December 2006, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 183 on
15 February 2007. The articles of association of the Absorbing Company have not been amended since.
- Commercial Project Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 115.476, pursuant to a deed of incorporation of
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 30 March 2006,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1173 on 16 June 2006. The articles of association
of the Absorbed Company 1 have not been amended since.
- Brie Project N° 3 S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 124.463, pursuant to a deed of incorporation of Maître
30739
L
U X E M B O U R G
André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 January 2007,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 688 on 24 April 2007. The articles of association of
the Absorbed Company 2 have not been amended since.
2. The contemplate merger. The Absorbing Company as absorbing company, intends to merge with and to absorb its
wholly-owned subsidiaries the Absorbed Company 1 and the Absorbed Company 2 as absorbed companies in accordance
with the procedure of simplified mergers following art. 278 seq. of the law dated August 10, 1915 on commercial com-
panies, as amended (the “Law”). The boards of managers of the Absorbing Company, the Absorbed Company 1 and the
Absorbed Company 2 have approved the merger (the “Merger”) and determined the terms set forth below on February
20, 2015.
The Merger will entail the transfer by the Absorbed Companies of all their assets and liabilities to the Absorbing
Company. The Absorbed Companies shall be dissolved without liquidation after the completion of the respective Merger.
3. The surviving company pursuant to the Merger. Pursuant to the completion of the Merger, the Absorbing Company
will continue to exist under the denomination of “LFI Brie Comte Robert”, a société à responsabilité limitée, existing
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with its registered office at 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg. The articles of association of the Absorbing Company will not be amended pursuant to the Merger.
4. Legal and economic context and/or consequences of the Merger.
4.1 Legal effects
The Absorbing Company will acquire, as a result of its respective Merger, all assets and liabilities of the respective
absorbed company by way of universal transfer of title.
Any claims and debts existing as at the Effective Date (as defined under 9. below) between (i) the Absorbing Company
and the Absorbed Company 1 and (ii) the Absorbing Company and the Absorbed Company 2 are cancelled upon the
completion of the respective Merger. As of the Effective Date, the Absorbing Company shall be subrogated to all rights
and obligations of the Absorbed Companies towards third parties. The rights and claims comprised in the assets of each
absorbed company shall be transferred to the Absorbing Company with all securities, either in rem or personal, attached
thereto.
As a result of the Merger, the Absorbed Companies shall cease to exist and all their issued shares shall be cancelled.
There are no intellectual property rights or real estate properties in the assets of the Merging Companies, nor are
there any other rights in rem.
4.2 Economic
The rationale for the proposed Merger is to simplify and to reduce the holding structure of the group of companies
of which the Merging Companies are part of.
5. Date as of which the operations of the Absorbed Companies shall be treated from an accounting point of view as
being carried out on behalf of the Absorbing Company. As from 1 January 2015, all operations and transactions of the
Absorbed Companies are considered for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company.
The financial data of each absorbed company will be included in the accounts of its respective absorbing company as
from such date; assets and liabilities will be included at their fair market value.
6. Special rights. None of the shareholders or members of any of the Merging Companies has any special rights therein.
There are no securities issued other than the shares of the Merging Companies.
7. Special advantages to any members of the board of managers of the Merging Companies. No special advantages will
be granted to any members of the board of managers of the Merging Companies.
8. Information regarding the Merger. These Common Terms of Merger shall be published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations at least one (1) month prior to the Effective Date (as defined under 9 below).
One or more shareholders of the Absorbing Company holding at least 5% of the shares in the subscribed capital of
the Absorbing Company, are entitled to require the convening of a general meeting of the respective absorbing company
to decide on the approval of the Merger (the “EGM”) prior to the Effective Date. Such meeting would need to be convened
in order to be held within one (1) month of such request.
The following documents shall be held available for inspection by the shareholders of each of the Merging Companies
at the registered office of the latter, at least one (1) month prior to the Effective Date:
a) the Terms of Merger;
b) the annual accounts and the management reports for the financial years ending on 31 December 2012, 2013 and
2014 of each of the Merging Companies.
9. Effective Date of the Merger. The Merger shall become effective between the relevant parties one (1) month after
the publication of these Common Terms of Merger in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Effective
Date”), unless an EGM has been required by one or more shareholders of the Absorbing Company pursuant to 8 above.
The Merger shall become effective upon the publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of a
certificate of a notary confirming that the conditions for the Merger to become effective are fulfilled.
30740
L
U X E M B O U R G
10. Creditor’s rights. Creditors of the Merging Companies, whose claims predate the Effective Date, notwithstanding
any agreement to the contrary, may apply, within two (2) months of the Effective Date, to the judge presiding the chamber
of the Tribunal d’Arrondissement dealing with commercial matters in the district in which the registered office of the
debtor company is located and sitting as in commercial and urgent matters, to obtain adequate safeguards of collateral
for any matured or unmatured debts, where they can be credibly demonstrate that due to the Merger, the satisfaction
of their claims is at stake and that no adequate safeguards have been obtained from the company. The president of such
chamber shall reject the application if the creditor is already in possession of adequate safeguards or if such safeguards
are unnecessary, having regard to the financial situation of the company after the Merger. The debtor company may cause
the application to be turned down by paying the creditor, even if it is a term debt.
If the safeguards are not provided within the time limit prescribed, the debt shall immediately fall due.
11. Mandates of the managers of each of the Absorbed Companies. The mandates of the current managers of each of
the Absorbed Companies will come to an end as of the Effective Date and it is suggested that full discharge shall be granted
to the managers of each of the Absorbed Companies for the exercise of their mandates at the occasion of the first annual
general meeting of the Absorbing Company following the effectiveness of the Merger.
12. Books and records of each of the Absorbed Companies. The books and records of the Absorbed Company will
be kept at the registered office of the Absorbing Company for the period provided by law.
13. Costs. The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger shall be borne by the Absorbing Company.
In accordance with the provisions of article 271 (2) of the Law, the undersigned notary hereby certifies the existence
and legality of the Common Terms of Merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the Merging
Companies pursuant to the Law.
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day mentioned at the beginning of this
document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on the request of the above ap-
pearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same
appearing parties and in case of divergences between the English and the French texts, the English version will prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name,
civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingt-cinquième jour du mois de février.
Par-devant Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, au Grand-Duché de Luxembourg,
ONT COMPARU:
1. LFI Brie Comte Robert, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.709 (la «Société Absorbante»),
ici représentée par Monsieur Alexander Olliges, Rechtsanwalt, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu
d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20 février 2015, et
2. Commercial Project Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.476 (la «Société Absorbée 1»),
ici représentée par Monsieur Alexander Olliges, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20
février 2015, et
3. Brie Project N° 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.463 (la «Société Absorbée 2» et ensemble avec la
Société Absorbée 1, les «Sociétés Absorbées» et ensemble avec la Société Absorbante, les «Sociétés Fusionnantes»),
ici représentée par Monsieur Alexander Olliges, prénommé, en vertu d’une procuration donnée à Luxembourg, le 20
février 2015.
Lesdites procurations paraphées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire resteront anne-
xées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregistrement.
Lesquelles parties comparantes ont requis le notaire instrumentant d’acter le projet commun de fusion que les Sociétés
Fusionnantes, agissant par leurs conseils de gérance, déclarent établir comme suit:
30741
L
U X E M B O U R G
Projet Commun de Fusion
(le «Projet Commun de Fusion»)
1. Les sociétés impliquées dans la fusion.
(i) LFI Brie Comte Robert, une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 122.709, constituée suivant acte de constitution reçu par
le notaire soussigné, en date du 15 décembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
183, le 15 février 2007. Les statuts de la Société Absorbante n’ont pas été modifiés depuis lors.
(ii) Commercial Project Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du
Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 115.476, constituée suivant acte de constitution
reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en
date du 30 mars 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1173, le 16 juin 2006. Les
statuts de la Société Absorbée 1 n’ont pas été modifiés depuis lors.
(iii) Brie Project N° 3 S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existant selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 124.463, constituée suivant acte de constitution reçu par
Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du
23 janvier 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 688, le 24 avril 2007. Les statuts de
la Société Absorbée 2 n’ont pas été modifiés depuis lors.
2. La fusion envisagée. La Société Absorbante, en tant que société absorbante, envisage de fusionner avec et d’absorber
ses filiales entièrement détenues, la Société Absorbée 1 et la Société Absorbée 2, en tant que sociétés absorbées con-
formément à la procédure des fusions simplifiées suivant l’article 278 et s. de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle qu’elle a été modifiée (la «Loi»). Les conseils de gérance de la Société Absorbante, de la Société
Absorbée 1 et de la Société Absorbée 2 ont approuvé la fusion (la «Fusion») et ont déterminé les conditions énoncées
ci-dessous le 20 février 2015.
La Fusion entraîne le transfert par les Sociétés Absorbées de l’ensemble de leur patrimoine actif et passif à la Société
Absorbante. Les Sociétés Absorbées seront dissoutes sans liquidation après la réalisation de la Fusion.
3. La société survivante issue de la Fusion. A la suite de la réalisation de la Fusion, la Société Absorbante continuera
d’exister sous la dénomination «LFI Brie Comte Robert», en tant que société à responsabilité limitée, existant selon les
lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 41, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg. Les statuts
de la Société Absorbante ne seront pas modifiés dans le cadre de la Fusion.
4. Contexte juridique et économique et/ou conséquences de la Fusion.
4.1. Contexte juridique
La Société Absorbante va acquérir, du fait de la Fusion à laquelle elle participe en cette qualité, l’ensemble du patrimoine
actif et passif de la société absorbée respective par voie de transmission universelle de biens.
L’ensemble des obligations et des dettes existant à la Date de Réalisation (telle que définie au point 9 ci-dessous) entre
(i) la Société Absorbante et la Société Absorbée 1 et (ii) la Société Absorbante et la Société Absorbée 2 seront annulées
dès la réalisation de la Fusion respective. A compter de la Date de Réalisation, la Société Absorbante sera subrogée, à
l’égard des tiers, dans l’ensemble des droits et obligations des Sociétés Absorbées. Les droits et créances compris dans
l’actif de chacune des sociétés absorbées seront transférés à la Société Absorbante, avec toutes les sûretés réelles et/ou
personnelles qui les grèvent.
A la suite de la Fusion, les Sociétés Absorbées cesseront d’exister et toutes leurs parts sociales émises seront annulées.
Le patrimoine des Sociétés Fusionnantes ne contient aucun droit de propriété intellectuelle ou de propriétés foncières,
ni aucun droit réel.
4.2. Contexte économique
La finalité de la Fusion envisagée est de simplifier et de réduire la structure de détention du groupe de sociétés auquel
appartiennent les Sociétés Fusionnantes.
5. Date à laquelle les opérations des Sociétés Absorbées devront être considérées, d’un point de vue comptable,
comme ayant été accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante. A compter du 1
er
janvier 2015, toutes
les opérations et transactions des Sociétés Absorbées sont considérées, d’un point de vue comptable, comme ayant été
accomplies au nom et pour le compte de la Société Absorbante.
A compter de cette date, les données financières relatives à chacune des sociétés absorbées seront inclues à leur
valeur de marché dans les comptes annuels de la société absorbante respective.
6. Droits spécifiques. Aucun droit spécifique n’a été constitué au bénéfice des associés ou des membres d’une des
Sociétés Fusionnantes. Il n’y a d’autres titres émis que les parts sociales des Sociétés Fusionnantes.
30742
L
U X E M B O U R G
7. Avantages spécifiques attribués à tout membre des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes. Aucun avantage
particulier ne sera attribué à tout membre des conseils de gérance des Sociétés Fusionnantes.
8. Informations relatives à la Fusion. Le présent Projet Commun de Fusion sera publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations au moins un (1) mois avant la Date de Réalisation (telle que définie au point 9 ci-dessous).
Un ou plusieurs associés de la Société Absorbante, détenant au moins 5% des parts sociales du capital souscrit de la
Société Absorbante, a/ont le droit de requérir la convocation d’une assemblée générale de la société absorbante con-
cernée, appelée à se prononcer sur l’approbation de la Fusion (l’«AGE») antérieurement à la Date de Réalisation. Une
telle assemblée devra, le cas échéant, être convoquée de façon à être tenue dans le délai d’un (1) mois à compter de cette
réquisition.
Les documents suivants sont mis à la disposition pour inspection des associés de chacune des Sociétés Fusionnantes
au siège social de celles-ci au moins un (1) mois avant la Date de Réalisation:
a) le Projet de Fusion;
b) les comptes sociaux annuels et les rapports de gestion des exercices comptables se terminant le 31 décembre 2012,
2013 et 2014 de chacune des Sociétés Fusionnantes.
9. Date de Réalisation de la Fusion. La Fusion sera effective entre les parties concernées à l’expiration d’un délai d’un
(1) mois après la publication du présent Projet Commun de Fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
(la «Date de Réalisation»), à moins qu’une AGE n’ait été convoquée suite à la réquisition d’un ou plusieurs associés de la
Société Absorbante conformément au point 8 ci-dessus.
La Fusion sera effective dès la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations d’un certificat d’un
notaire confirmant que les conditions d’effectivité de la Fusion sont remplies.
10. Droit des créanciers. Les créanciers des Sociétés Fusionnantes, dont les créances sont antérieures à la Date de
Réalisation, nonobstant toute convention contraire, peuvent, dans les deux (2) mois de cette Date de Réalisation, de-
mander au magistrat présidant la chambre du Tribunal d’Arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a
son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des
créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer de manière crédible que la Fusion constitue un risque
pour l’exercice de leurs droits et que ladite société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président de la prédite
chambre rejettera cette demande, si le créancier dispose déjà de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires,
compte tenu de la situation financière de la société après la Fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en
payant le créancier, même si la créance est à terme.
Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
11. Mandats des gérants de chacune des Sociétés Absorbées. Il sera mis un terme aux mandats des gérants actuels des
Sociétés Absorbées à la Date de Réalisation et il est suggéré que décharge intégrale sera accordée aux gérants de chacune
des Sociétés Absorbées pour l’exercice de leur mandat, à l’occasion de la première assemblée générale annuelle de la
Société Absorbante suite à la prise d’effet de la Fusion.
12. Documents et registres sociaux de chacune des Sociétés Absorbées. Les documents et registres sociaux des
Sociétés Absorbées seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la période prévue par la loi.
13. Coûts. Les dépenses, coûts, frais et charges résultant de la Fusion seront assumés par la Société Absorbante.
Conformément aux dispositions de l’article 271 (2) de la Loi, le notaire soussigné atteste par les présentes l’existence
et la légalité du Projet Commun de Fusion et de tous les actes, documents et formalités incombant aux Sociétés Fusion-
nantes conformément à la Loi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise suivi d’une version française; sur demande des mêmes parties comparantes et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
Après lecture faite au mandataire des parties comparantes, connu du notaire soussigné par ses nom, prénom usuel,
état et demeure, ledit mandataire des parties comparantes a signé le présent acte ensemble avec le notaire.
Signé: A. OLLIGES, J.-J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, A.C., le 2 mars 2015. Relation: EAC/2015/4889. Reçu soixante-quinze Euros (75,- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): Monique HALSDORF.
Référence de publication: 2015036464/269.
(150041006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 mars 2015.
30743
L
U X E M B O U R G
Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 154.183.
In the year two thousand and fifteenth, on the twentieth day of February.
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting), of Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 154.183 and having a share capital of EUR
2,651,727 (the Company).
The Company was incorporated on 8 July 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 19 August 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1694.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended several times and for the last time on 4
September 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Association under number 3308 of 8 November 2014.
THERE APPEARED:
Picard PIKco S.A., a public limited liability company (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand
Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 156.504 (the Sole
Shareholder),
hereby represented by Me Gwendoline Licata, lawyer at King & Wood Mallesons, with professional address in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of proxy under private seal given on February 2015.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. that the Sole Shareholder represents all of the issued and subscribed share capital of the Company;
II. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment of article 6 of the Articles to also authorize the general meeting of the shareholders to proceed to the
redemption of mandatory redeemable preferred shares (MRPS);
3. Further amendment of the fifth paragraph of article 6 of the Articles to allow the prior redemption;
4. Amendment of article 27 of the Articles to allow the distribution of interim dividend;
5. Redemption of 9,254 mandatory redeemable preferred shares held by Picard PIKco S.A. (the Redeemed MRPS) and
subsequent reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 9,254 in order to bring the share capital
from its current amount of EUR 2,651,727 to an amount of EUR 2,642,473 by way of the cancellation of the Redeemed
MRPS;
6. Amendment of article 5 of the Articles in order to reflect the above resolutions; and
7. Miscellaneous.
III. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder
waives the convening notice, the Sole Shareholder represented at the Meeting considering itself as duly convened and
declaring having perfect knowledge of the agenda which has been communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to amend article 6 paragraph 2 of the Articles of the Company so that it shall read henceforth
as follows:
“All MRPS issued by the Company are redeemable shares subject to the conditions set forth in article 49-8 of the Law.
Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders of
the Company, subscribed and fully paid-up MRPS shall be redeemable (a) upon request of the Company in accordance
with the provisions of article 49-8 of the Law, and (b) in any case, after ten (10) years as from the date of issuance of the
30744
L
U X E M B O U R G
MRPS (the “Mandatory Redemption Date”). The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of
managers or of the general meeting of the shareholders.”
<i>Third resolutioni>
The Meeting resolves to amend further article 6 paragraph 5 of the Articles of the Company so that it shall read
henceforth as follows:
“Except as provided otherwise (i) in these articles of association or (ii) by a written agreement which may be entered
into between the Company and the shareholders, the redemption price of each MRPS shall be equal to (a) the aggregated
nominal value of all the MRPS plus the portion of the balance of the MRPS Premium Account plus any accrued but unpaid
First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend (b) divided by the number of outstanding MRPS to be redeemed
at the time of the redemption.”
It is noted that the aggregate amount of accrued but unpaid First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend
referred to above shall be identical to the deductions taken on the MRPS dividend for tax purposes in the past years (plus
any dividend accrued for the current year until the date of redemption).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to add an article 27.4 to the Articles, which shall henceforth read as follows:
“ 27.4. Interim dividends, out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital
surplus, may be distributed by the board of managers in compliance with the conditions provided for by law and in
compliance with the rights attached by these articles of incorporation to the different classes of Shares. The MRPS
Premium Account, if any, may be freely distributed to the holders of MRPS by a resolution of the shareholders' meeting
or of the board of managers, subject to any provisions of the Law or these articles of association.”
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to redeem nine thousand two hundred fifty-four (9,254) mandatory redeemable pre-
ferred shares (the Redeemed MRPS) held by Picard PIKco S.A. (the MRPS Redemption) in accordance with the terms of
article 6 of the Articles and article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder, after having acknowledges that, based on the interim accounts of the Company as at 19 February
2015 (the Interim Accounts), the Company has sufficient distributable funds, resolves to approve such MRPS Redemption.
The Interim Accounts after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of nine thousand two hundred
and fifty-four euros (EUR 9,254) in order to bring the share capital from its current amount of two million six hundred
and fifty-one thousand seven hundred twenty-seven euros (EUR 2,651,727), divided into ten thousand (10,000) mandatory
redeemable preferred shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A1
ordinary shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A2 ordinary shares,
four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A3 ordinary shares, four hundred and
thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A4 ordinary shares, four hundred and thirty-one thou-
sand six hundred and seventy-one (431,671) class A5 ordinary shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred
and seventy-one (431,671) class A6 ordinary shares, one (1) class B preferred share, ten thousand five hundred and fifty
(10,550) class C1 preferred shares and forty-one thousand one hundred and fifty (41,150) class C2 preferred shares,
having a nominal value of one euro (EUR 1) each, to an amount of two million six hundred forty-one thousand seven
hundred twenty-seven euro (EUR 2,642,473), divided into seven hundred and forty-six (746) mandatory redeemable
preferred shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A1 ordinary shares,
four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A2 ordinary shares, four hundred and
thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A3 ordinary shares, four hundred and thirty-one thou-
sand six hundred and seventy-one (431,671) class A4 ordinary shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred
and seventy-one (431,671) class A5 ordinary shares, four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one
(431,671) class A6 ordinary shares, one (1) class B preferred share, ten thousand five hundred and fifty (10,550) class C1
preferred shares and forty-one thousand one hundred and fifty (41,150) class C2 preferred shares, having a nominal value
of EUR 1 each, by way of the repurchase, for a total aggregate amount of six hundred one million nine hundred ninety-
five thousand six hundred ninety-four euros and seventy-two cents (EUR 601,995,694.72), and subsequent cancellation
of nine thousand two hundred and fifty-four (9,254) mandatory redeemable preferred shares held by the Company.
<i>Sixth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 5 of the Articles which
shall now read as follows:
“ Art. 5. The Company's share capital is set at EUR 2,642,473 represented by:
- seven hundred and forty-six (746) mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS”);
30745
L
U X E M B O U R G
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A1 ordinary shares (the “A1
Ordinary Shares");
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A2 ordinary shares (the “A2
Ordinary Shares");
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A3 ordinary shares (the “A3
Ordinary Shares");
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A4 ordinary shares (the “A4
Ordinary Shares");
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A5 ordinary shares (the “A5
Ordinary Shares");
- four hundred and thirty-one thousand six hundred and seventy-one (431,671) class A6 ordinary shares (the “A6
Ordinary Shares", together with the A1 Ordinary Shares, the A2 Ordinary Shares, the A3 Ordinary Shares, the A4
Ordinary Shares and the A5 Ordinary Shares, the “A Ordinary Shares”);
- one (1) class B preferred share (the “B Pref Shares”);
- ten thousand five hundred fity (10,550) class C1 preferred shares (the “C1 Shares”);
- forty-one thousand one hundred and fifty (41,150) class C2 preferred shares (the “C2 Shares”).
Each of the above shares has a par value of one euro (EUR 1).
The holders of A Ordinary Shares from time to time will be referred to as “A Partners”.
Any reference made hereinafter to a “share” or to “shares” shall be construed as a reference to any or all of the above
classes of shares, including the MRPS, depending on the context and as applicable, and the same construction shall apply
to a reference to a “partner” or to “partners”.
Each class of shares will have the same rights, save as otherwise provided in these articles of incorporation. Each share
is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of shareholders. Each share is entitled to the
financial rights as per article 27 of these articles of association.
Holders of C2 Shares can only be holders of C1 Shares, unless otherwise agreed by the shareholders representing
three quarters of the share capital.”
<i>Estimate of costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations and expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of this notarial deed, is approximately two thousand five hundred euro
(EUR 2,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French version; at the request of the same
proxyholder of the appearing party, it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French texts,
the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with the notary the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de février,
par devant Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des associés (l’Assemblée) de la société Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., une société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-
Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le
numéro B 154.183 et ayant un capital social de 2.651.727 EUR (la Société).
La Société a été constituée le 8 juillet 2010 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 1694, en date du 19 août 2010.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois à la date du 4 septembre 2014, par acte
du notaire soussigné, publié le 8 novembre 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
3308.
A COMPARU:
Picard PIKco S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 156.504 (l’Associé
Unique),
30746
L
U X E M B O U R G
ici représentée par Maître Gwendoline Licata, juriste chez King & Wood Mallesons, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le février 2015.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,
restera attachée au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.
L’Associé Unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui
suit:
I. Que l’Associé Unique, détient 100% du capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 6 des Statuts afin de permettre également à l’assemblée générale des associés des réaliser
le rachat des parts sociales préférentielles de rachat obligatoire (les MPRS);
3. Modification supplémentaire du paragraphe 5 de l’article 6 des Statuts;
4. Modification de l’article 27 des Statuts afin de permettre la distribution de dividendes intérimaires;
5. Rachat de 9.254 parts sociales préférentielles de rachat obligatoire détenues par Picard PIKco S.A. (les MRPS Ra-
chetées) (le Rachat des MRPS) et diminution successive du capital social de la Société d’un montant de 9.254 EUR afin de
porter le capital social de son montant actuel de 2.651.727 EUR à un montant de 2.642.473 EUR par l’annulation des
MRPS Rachetées;
6. Modification de l’article 5 des Statuts relatif of capital social afin de refléter les résolutions ci-dessus; et
7. Divers.
III. Que l’Associé Unique prend les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social souscrit étant représenté à la présente Assemblée, l’Associé Unique renonce aux for-
malités de convocation, l’Associé Unique représenté se considère lui-même comme dûment convoqué et déclare avoir
parfaitement connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 6 paragraphe 2 des Statuts qui devra en conséquence être lu comme suit:
«Tous les MRPS émis par la Société sont des parts sociales rachetables dans les conditions prévues à l’article 49-8 de
la loi. Sous réserve de ce qui est mentionné dans le présent document ou dans tout autre contrat entré en vigueur entre
les associés et la Société, les MRPS émis et entièrement libérés doivent être rachetés (a) à la demande de la Société
conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la Loi, et (b) dans tous les cas, après dix (10) ans à compter de la date
d'émission des MRPS (la «Date de Rachat Obligatoire»). Le rachat devra se dérouler conformément à la décision du
conseil d'administration ou de l’assemblée générale des associés.».
<i>Troisième résolutioni>
L’Assemblée décide de modifier l’article 6 paragraphe 5 des Statuts qui devra en conséquence être lu comme suit:
«Sous réserve de dispositions contraires dans (i) des présents statuts ou (ii) un contrat entré en vigueur entre la Société
et les associés, le prix de rachat de chaque MRPS doit être égal à (a) la valeur nominale totale de toutes les MRPS, plus
une portion du solde du compte prime MRPS, plus tout cumulé mais non payé Premier Dividende Préférentiel et Second
Dividende Préférentiel (b) divisé par le nombre de MRPS en suspens devant être racheté à la date de rachat.
Il est noté que le montant total des Premier Dividende Préférentiel et Second Dividende Préférentiel cumulé mais non
payé mentionné ci-dessus sera identique à la déduction faite sur les dividendes MRPS aux fins fiscales les années précé-
dentes (plus tout dividende cumulé pour l’année en cours jusqu'à la date de rachat).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Associé Unique d’ajouter un article 27.4 des Statuts qui devra être lu comme suit:
« 27.4. Dividendes intérimaires, hors bénéfices et réserves disponibles pour distribution, y compris les primes d'émis-
sion et le capital excédentaire, peuvent être distribués par le conseil de gérance conformément conditions établies par
la loi et conformément aux droits attachés par ces statuts aux différentes classes de Parts Sociales. Le Compte Premium
des MRPS, le cas échéant, peut être librement distribué aux détenteurs de MRPS par une résolution de l’assemblée des
associés ou du conseil de gérance, sous réserve de la Loi ou de ces Statuts.»
<i>Cinquième résolutioni>
L’Associé Unique décide de racheter neuf mille deux cent cinquante-quatre (9.254) parts sociales préférentielles de
rachat obligatoire (les MRPS Rachetées) détenues par Picard PIKco S.A. (le Rachat des MRPS) conformément aux nou-
veaux termes de l’article 6 des Statuts et de l’article 49-8 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée.
30747
L
U X E M B O U R G
L’Associé Unique note que la condition ci-dessus a dorénavant été satisfaite et le Rachat des MRPS est maintenant
effectif.
L’Associé Unique, après avoir reconnu que, sur la base des comptes intérimaires de la Société datés au 19 février 2015
(les Comptes Intérimaires), la Société a des fonds distribuables suffisant, décide d’approuver un tel Rachat de MRPS.
Les Comptes Intermédiaires après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le
notaire soussigné, restera attachée au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregis-
trement.
L'Assemblée décide de diminuer le capital social de la Société d’un montant de neuf mille deux cent cinquante-quatre
euro (9.254 EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions six cent cinquante-et-un mille
sept cent vingt-six euro (2.651.727 EUR), représenté par dix mille (10.000) parts sociales préférentielles de rachat obli-
gatoire, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A1, quatre
cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A2, quatre cent trente-et-
un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A3, quatre cent trente-et-un mille six cent
soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A4, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze
(431.671) parts sociales ordinaire de classe A5, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts
sociales ordinaire de classe A6, une (1) classe de parts sociales préférentielle B, dix mille cinq cent cinquante (10.550)
classes de parts sociales préférentielles C1 et quarante-et-un mille cent cinquante (41.150) classe de parts sociales C2,
chaque part sociale ci-dessus ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR), à un montant de deux million six cent quarante-
deux mille quatre cent soixante-treize euro (2.642.473 EUR), représenté par sept cent quarante-six (746) parts sociales
préférentielles de rachat obligatoire, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales
ordinaire de classe A1, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de
classe A2, quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A3, quatre
cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A4, quatre cent trente-et-
un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A5, quatre cent trente-et-un mille six cent
soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A6, une (1) classe de parts sociales préférentielle B, dix mille
cinq cent cinquante (10.550) parts sociales préférentielles C1 et quarante-et-un mille cent cinquante (41.150) parts sociales
préférentielles C2, chaque part sociale ci-dessus ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR) par le rachat, pour un prix
total de six cent un millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quatorze euro et soixante-deux cen-
times (601.995.694,72 EUR), et l’annulation successive de neuf mille deux cent cinquante-quatre (9.254) MRPS Rachetées.
<i>Sixième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Associé Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts qui devra être lu
comme suit:
«Le capital social de la Société est fixé à deux million six cent quarante-deux mille quatre cent soixante-treize euro
(2.642.473 EUR) représenté par:
- sept cent quarante-six (746) parts sociales préférentielles de rachat obligatoire (les «MRPS»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A1 (les «Parts
Sociales Ordinaires A1»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A2 (les «Parts
Sociales Ordinaires A2»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A3 (les «Parts
Sociales Ordinaires A3»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A4 (les «Parts
Sociales Ordinaires A4»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A5 (les «Parts
Sociales Ordinaires A5»);
- quatre cent trente-et-un mille six cent soixante-et-onze (431.671) parts sociales ordinaire de classe A6 (les «Parts
Sociales Ordinaires A6», ensemble avec les parts sociales ordinaire de classe A1, parts sociales ordinaire de classe A2,
parts sociales ordinaire de classe A3, parts sociales ordinaire de classe A4, parts sociales ordinaire de classe A5, parts
sociales ordinaire de classe A6, les «Parts Sociales Ordinaires A»);
- une (1) classe de parts sociales préférentielle B (les «Parts Sociales Pref B»);
- dix mille cinq cent cinquante (10.550) parts sociales préférentielles C1 (les «Parts Sociales C1»);
- quarante-et-un mille cent cinquante (41.150) parts sociales préférentielles C2 (les «Parts Sociales C2»).
Chaque part sociale ci-dessus ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR).
Les détenteurs de Parts Sociales Ordinaires A le cas échéant seront dénommés «Associé A».
Toute référence faite ci-après à une «part sociale» ou des «parts sociales» doit être interprété comme une référence
à n'importe quelle ou toutes les classes de parts sociales figurant ci-dessus, y compris les MRPS, selon le contexte et le
cas échéant, il en va de même pour les références à un «associé» ou des «associés».
30748
L
U X E M B O U R G
Chaque classe de parts sociales aura les mêmes droits, sauf dispositions contraires figurant dans les présents statuts.
Chaque part sociale donne droit à une voix dans les assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Chaque part
sociale donne droit à des droits financiers en vertu de l’article 27 de ces présents statuts.
Les détenteurs de Parts Sociales C2 ne peuvent qu'être détenteurs de Parts sociales C1, sauf accord contraire des
Associés représentant trois quart du capital social.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête du même mandataire de la partie comparante,
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l’année et au jour écrits en tête du présent acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire,
l’original du présent acte.
Signé: G. Licata, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 février 2015. GAC/2015/1674. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 4 mars 2015.
Référence de publication: 2015037144/296.
(150041606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Caldia Fiduciaire S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 153.093.
<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration tenue le 16 janvier 2015 à Luxembourg.i>
Il résulte des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'administration que:
- Le siège social de la Société a été transféré de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660 Luxembourg au 21,
Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015017001/13.
(150020434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.
Fürstenberger Siedlung 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 182.995.
<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 2 février 2015i>
1. M. Frank PLETSCH a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
2. M. Mark GORHOLT a démissionné de son mandat de gérant, avec effet au 14 janvier 2015.
3. M. Oliver THOMAS, administrateur de sociétés, né le 25 mai 1983 à Geilenkirchen (Allemagne), demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, pour une durée indéter-
minée.
4. M. Jean-Christophe DAUPHIN, administrateur de sociétés, né à Nancy (France) le 20 novembre 1976, demeurant
professionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant, avec effet au 14 janvier
2015, pour une durée indéterminée.
Luxembourg, le 3 février 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Fürstenberger Siedlung 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015018119/20.
(150021790) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
30749
L
U X E M B O U R G
Picard Bondco, Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 154.899.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of February,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held:
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting), of Picard Bondco, a public limited liability company
(société anonyme), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of
Trade and Companies under number B 154.899 (the Company).
The Company was incorporated on 9 August 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 28 September 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 2011.
The articles of association of the Company (the Articles) were modified for the last time on 4 September 2014 pursuant
to a deed of the undersigned notary, published on 18 November 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations under number 3442.
THERE APPEARED:
Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the
laws of Luxembourg, having its registered office at 27, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, registered with the
Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 154.183 and having a share capital of EUR 2,651,727 (the
Sole Shareholder),
hereby represented by Me Gwendoline Licata, lawyer at King & Wood Mallesons, having his/her professional address
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of proxy under private seal given on February 2015.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as above stated, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment of article 7.1 of the Articles to also authorize the general meeting of the shareholders to proceed to
the redemption of mandatory redeemable preferred shares (MRPS);
3. Deletion of the second paragraph of article 7.6 of the Articles to allow the redemption of MRPS prior to the
repayment in full under the PECs issued by Lion/Polaris Lux 3 S.à r.l.;
4. Redemption of 9,629 MRPS held by Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. (the Redeemed MRPS) (the MRPS Redemption) and
subsequent reduction of the share capital of the Company by an amount of EUR 9,629 in order to bring the share capital
from its current amount of EUR 2,651,726 to an amount of EUR 2,642,097 by way of the cancellation of the Redeemed
MRPS;
5. Amendment of article 6 of the Articles in relation to the share capital in order to reflect the above resolutions; and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder waives the
convening notices, the Sole Shareholder represented considers itself as duly convened and declares having perfect know-
ledge of the agenda of the Meeting duly communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The sole Shareholder resolves to amend article 7.1 to also authorize the general meeting of shareholders to proceed
to the redemption of MRPS so that is shall henceforth read as follows:
“ 7.1. All MRPS issued by the Company are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the
Law. Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders
of the Company, subscribed and fully paid-up MRPS shall be redeemable (a) upon request of the Company in accordance
with the provisions of article 49-8 of the Law, and (b) in any case, after ten (10) years as from the date of issuance of the
30750
L
U X E M B O U R G
MRPS (the “Mandatory Redemption Date”). The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of
directors or of the general meeting of the shareholders.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to delete the second paragraph of article 7.6 of the Articles so that article 7.6 of the
Articles shall read henceforth as follows:
“ 7.6. Except as provided otherwise (i) in these articles of association or (ii) by a written agreement which may be
entered into between the Company and the shareholders, the redemption price of each MRPS shall be equal to (a) the
aggregated nominal value of all the MRPS plus the portion of the balance of the MRPS Premium Account plus any accrued
but unpaid First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend (b) divided by the number of outstanding MRPS to
be redeemed at the time of the redemption. If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their
Mandatory Redemption Date, the Company shall redeem the maximum number of MRPS which the Company is then
permitted to redeem. Such redemption will be made on a pro rata basis from each MRPS holder.
The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by Law. However, the redemption of Or-
dinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.
Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the
Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or
internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the MRPS to be redeemed, at his or her
address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of MRPS so to be
redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the
Company for redemption and the valuation of the redemption price, as provided for in this section. Each holder of MRPS
to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such MRPS to the Company.
The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register
as the owner thereof on the bank account.”
It is noted that the aggregate amount of accrued but unpaid First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend
referred to above shall be identical to the deductions taken on the MRPS dividend for tax purposes in the past years (plus
any dividend accrued for the current year until the date of redemption).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to redeem nine thousand six hundred and twenty-nine (9,629) mandatory redeemable
preferred shares (the Redeemed MRPS) held by Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. (the MRPS Redemption) in accordance with
the new terms of article 6 paragraph 5 of the Articles and article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial
companies, as amended.
The Sole Shareholder, after having acknowledges that, based on the interim accounts of the Company as at 19 February
2015 (the Interim Accounts), the Company has sufficient distributable funds, resolves to approve such MRPS Redemption.
The Interim Accounts, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of nine thousand six hundred
and twenty-nine euro (EUR 9,629) in order to bring it from its current amount of two million six hundred and fifty-one
thousand seven hundred and twenty-six euro (EUR 2,651,726), represented by ten thousand (10,000) mandatory redee-
mable preferred shares and two million six hundred and fifty-one thousand seven hundred and twenty-six (2,641,726)
ordinary shares, each with a par value of one euro (EUR 1), to an amount of EUR 2,642,097, represented by three hundred
seventy-one (371) mandatory redeemable preferred shares and two million six hundred and fifty-one thousand seven
hundred and twenty-six (2,641,726) ordinary shares, each with a par value of one euro (EUR 1), by way of the repurchase,
for a total aggregate price of six hundred twelve million five hundred sixteen thousand two hundred forty-two euros and
sixty-seven cents (EUR 612,516,242.67), and the subsequent cancellation of nine thousand six hundred and twenty-nine
(9,629) mandatory redeemable preferred shares held by the Company as a result of their redemption by the board of
managers of the Company, as further described above.
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles which
shall now read as follows:
“The Company’s subscribed share capital is set at two million six hundred forty-two thousand and ninety-seven euros
(EUR 2,642,097) represented by two million six hundred and forty-one thousand seven hundred and twenty-six
(2,641,726) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value of one euro (EUR 1.-) and three hundred seventy-
one (371) mandatory redeemable preferred shares (the "MRPS”) with a par value of one euro (EUR 1.-) each (together
with the Ordinary Shares, the “Shares”). Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general
meetings. The MRPS are be non-voting shares as provided for in article 44 of the Law.
30751
L
U X E M B O U R G
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sha-
reholders or the shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for amendments of these articles of
incorporation.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the
same proxyholder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de février,
par devant Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue:
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la société Picard Bondco, une société ano-
nyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché
du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le numéro
B 154.899 (la Société).
La Société a été constituée le 9 août 2010 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxem-
bourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2011, en date du 28 septembre 2010.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois à la date du 4 septembre 2014, par un acte
du notaire soussigné, publié le 18 novembre 2014 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro
3442.
A COMPARU:
Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 7, rue
Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro
B 154.183 et ayant un capital social de 2.656.727 EUR (l’Actionnaire Unique),
ici représentée par Maître Gwendoline Licata, juriste chez King & Wood Mallesons, ayant son adresse professionnelle
à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le févier 2015.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,
restera attachée au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.
L’Actionnaire Unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce
qui suit:
I. Que l’Actionnaire Unique, détient 100% du capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 7.1 des Statuts afin de permettre également à l’assemblée générale des actionnaires des
réaliser le rachat des actions préférentielles de rachat obligatoire (les MPRS);
3. Suppression du second paragraphe de l’article 7.6 des Statuts afin de permettre le rachat des MPRS avant le repaie-
ment total des PECS émis par Lion/Polaris Lux 3 S.à r.l.;
4. Rachat de 9.629 actions préférentielles de rachat obligatoire détenues par Lion/Polaris Lux 3 S.à r.l. (les MRPS
Rachetées) (le Rachat des MRPS);
5. Diminution du capital social de la Société d’un montant de 9.629 EUR afin de porter le capital social de son montant
actuel de 2.651.726 EUR à un montant de 2.642.097 EUR par l’annulation des MRPS Rachetées;
6. Modification de l’article 6 des Statuts relatif of capital social afin de refléter les résolutions ci-dessus; et
7. Divers.
III. Que l’Actionnaire Unique prend les résolutions suivantes:
30752
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social souscrit étant représenté à la présente Assemblée, l’Actionnaire Unique renonce aux
formalités de convocation, l’Actionnaire Unique représenté se considère lui-même comme dûment convoqué et déclare
avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 7.1 des Statuts, afin de permettre également à l’assemblée générale
des actionnaires des réaliser le rachat des MRPS, qui devra en conséquence être lu comme suit:
« 7.1. Toutes les MRPS émises par la Société sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l’article
49-8 de la Loi. Sous réserve de ce qui est mentionné dans le présent document ou dans tout autre contrat entré en
vigueur entre les actionnaires et la Société, les MRPS émises et entièrement libérées seront rachetables (a) à la demande
de la Société conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la Loi, et (b) dans tous les cas, après dix (10) ans à
compter de la date d’émission des MRPS (la «Date de Rachat Obligatoire»). Le rachat devra se dérouler conformément
à la décision du conseil d’administration ou de l’assemblée générale des actionnaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de supprimer le second paragraphe de l’article 7.6 des Statuts qui devra en conséquence
être lu comme suit:
« 7.6. Sous réserve de dispositions contraires dans (i) des présents statuts ou (ii) un contrat entré en vigueur entre la
Société et les associés, le prix de rachat de chaque MRPS doit être égal à (a) la valeur nominale totale de toutes les MRPS,
plus une portion du solde du compte prime MRPS, plus tout cumulé mais non payé Premier Dividende Préférentiel et
Second Dividende Préférentiel (b) divisé par le nombre de MRPS en suspens devant être racheté à la date de rachat.
Si la Société n’est pas autorisée par la Loi à racheter toutes les MRPS à leur Date de Rachat Obligatoire, la Société
doit racheter le nombre maximum de MRPS que la Société est autorisée à racheter. Ce rachat sera réalisé sur une base
proportionnelle par chaque propriétaire de MRPS.
La Société peut racheter ses Actions Ordinaires dans les limites établies par la Loi. Cependant, le rachat des Actions
Ordinaires est sujet à un rachat préalable de toutes les MRPS.
Sous réserve de tout contrat entré en vigueur entre les actionnaires et la Société, au moins quinze (15) jours avant la
date de rachat, une notification devra être envoyée par courrier électronique ou par coursier de renommée internationale,
à chaque actionnaire nominatif de MRPS rachetables, à sa dernière adresse connue dans le registre des actionnaires de
la Société, notifiant ce propriétaire du nombre de MRPS rachetables, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les
procédures nécessaires pour soumettre les MRPS à la Société pour le rachat et l’évaluation du prix de rachat, tel que
défini dans cette section. Chaque propriétaire de MRPS rachetable doit abandonner le(s) éventuel(s) certificat(s), émis
en relation avec ces MRPS à la Société. Le prix de rachat de ces MRPS doit être payé à l’ordre des personnes dont le
nom apparaît sur le registre des actionnaires en tant que propriétaire de ce compte bancaire.»
Il est noté que le montant total des Premier Dividende Préférentiel et Second Dividende Préférentiel cumulé mais non
payé mentionné ci-dessus sera identique à la déduction faite sur les dividendes MRPS aux fins fiscales les années précé-
dentes (plus tout dividende cumulé pour l’année en cours jusqu'à la date de rachat).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de racheter neuf mille six cent vingt-neuf (9.629) actions préférentielles de rachat obli-
gatoire (les MRPS Rachetées) détenues par Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l. (le Rachat des MRPS) conformément aux nouveaux
termes de l’article 7.6 des Statuts et de l’article 49-8 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu'amendée.
L’Actionnaire Unique note que la condition ci-dessus a dorénavant été satisfaite et le Rachat des MRPS est maintenant
effectif.
L’Actionnaire Unique, après avoir reconnu que, sur la base des comptes intérimaires de la Société datés au 19 février
2015 (les Comptes Intérimaires), la Société a des fonds distribuables suffisant, décide d’approuver un tel Rachat de MRPS.
Les Comptes Intermédiaires, après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le
notaire soussigné, resteront attachés au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enre-
gistrement.
L’Actionnaire Unique décide de diminuer le capital social de la Société d’un montant de neuf mille six cent vingt-neuf
euros (9.629 EUR) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions six cent cinquante et un mille
sept cent vingt-six euro (2.651.726 EUR), représenté par dix mille (10.000) MRPS et deux millions six cent quarante et
un mille sept cent vingt-six (2.641.726) actions ordinaires, chacune ayant une valeur nominale d’un euro (1 EUR), à un
montant de deux million six cent quarante-deux mille quatre-vingt-sept euros (2.642.097 EUR) représenté par trois cent
soixante et onze (371) MRPS et deux million six cent quarante et un mille sept cent vingt-six (2.641.726) actions ordinaires,
chacune ayant une valeur nominale d’un euro (1 EUR) par le rachat, pour un prix total de six cent douze millions cinq
30753
L
U X E M B O U R G
cent seize mille deux cent quarante-deux euro et soixante-sep centimes (612.516.242,67 EUR), et l’annulation successive
de 9.629 actions préférentielles de rachat obligatoire détenues par la Société.
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 6 des Statuts qui devra
être lu comme suit:
«Le capital social souscrit est fixé à deux million six cent quarante et un mille sept cent vingt-six euro (2.642.097 EUR)
représenté par deux millions six cent quarante et un mille sept cent vingt-six (2.641.726) actions ordinaires («Actions
Ordinaires») d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune et trois cent soixante et onze (371) actions préférentielles
de rachat obligatoire («MRPS») d'une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) chacune (ensemble avec les Actions Ordinaires,
les «Actions»). A chaque Action Ordinaire est accordé un vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordi-
naires. Les MRPS sont des actions sans droit de vote selon l’article 44 de la Loi.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête du même mandataire de la partie comparante,
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l’année et au jour écrits en tête du présent acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire,
l’original du présent acte.
Signé: G. Licata, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher, A.C., le 27 février 2015. GAC/2015/1673. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme,
Mondorf-les-Bains, le 4 mars 2015.
Référence de publication: 2015037306/244.
(150041594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
Safran, Société Anonyme.
Siège social: L-1147 Luxembourg, 42, rue de l'Avenir.
R.C.S. Luxembourg B 46.009.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2014i>
(...)
Commissaire aux comptes - Démission et nomination
L'assemblée prend acte de la démission le 31 décembre 2014 de Monsieur Vincent Van Assche, en tant que Commis-
saire aux comptes de la société.
L'assemblée décide de nommer comme nouveau Commissaire aux comptes, Monsieur Dirk Jacobs, domicilié à 1700
Dilbeek (Belgique), Achter d'Abdij 36, à partir du 1
er
janvier 2015 pour une durée de trois ans, prenant fin à l'issue de
l'assemblée générale ordinaire de 2017, statuant sur les comptes de l'exercice 2016.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.
....
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Le 15 décembre 2014.
<i>Pour le Conseil d'Administration
i>Karin DUBOIS
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2015019247/22.
(150023127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30754
L
U X E M B O U R G
Picard PIKco S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1748 Luxembourg, 7, rue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 156.504.
In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of February,
before Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting), of Picard PIKco S.A., a public limited liability
company (société anonyme), incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office
at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Re-
gister of Trade and Companies under number B 156.504 (the Company).
The Company was incorporated on 5 November 2010 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published on 3 December 2010 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 2655.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on 4 September 2014
pursuant to a deed of the undersigned notary, published on 18 November 2014 in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations under number 3444.
THERE APPEARED:
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l., a private limited liability company (Société à responsabilité limitée) incorporated under
the laws of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Lou Hemmer L-1748 Luxembourg-Findel, registered with
the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 156.509 and having a share capital of EUR 2,656,603.75
(the Sole Shareholder),
hereby represented by Me Gwendoline Licata, lawyer at King & Wood Mallesons, with professional address in Lu-
xembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
by virtue of proxy under private seal given on February 2015.
The proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary,
shall remain attached to this deed in order to be registered therewith.
Such appearing party, represented as above stated, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notice;
2. Amendment of article 7.1 of the Articles to also authorize the general meeting of the shareholders to proceed to
the redemption of mandatory redeemable preferred shares (MRPS);
3. Deletion of the second paragraph of article 7.6 of the Articles to allow the redemption of MRPS prior to the
repayment in full under the MRPS issued by Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l.;
4. Redemption of 7,642.37 MRPS held by Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. (the Redeemed MRPS) and subsequent re-
duction of the share capital of the Company by an amount of EUR 10,000 in order to bring the share capital from its
current amount of EUR 2,651,727 to an amount of EUR 2,641,727 by way of the cancellation of the 10,000 MRPS held
by the Company (2,357.63 MRPS held as treasury shares by the Company from previous redemptions and 7,642.37
Redeemed MRPS);
5. Amendment of article 6 of the Articles in order to reflect the above resolutions; and
6. Miscellaneous.
III. That the Sole Shareholder takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Meeting waives the convening
notices, the Sole Shareholder represented considers itself as duly convened and declares having perfect knowledge of the
agenda of the Meeting duly communicated to it in advance.
<i>Second resolutioni>
The sole Shareholder resolves to amend article 7.1 to also authorize the general meeting of shareholders to proceed
to the redemption of MRPS so that is shall henceforth read as follows: “
7.1. All MRPS issued by the Company are redeemable shares in accordance with the provisions of article 49-8 of the
Law. Except as otherwise provided herein or in any written agreement which may be entered into among the shareholders
of the Company, subscribed and fully paid-up MRPS shall be redeemable (a) upon request of the Company in accordance
with the provisions of article 49-8 of the Law, and (b) in any case, after ten (10) years as from the date of issuance of the
30755
L
U X E M B O U R G
MRPS (the “Mandatory Redemption Date”). The redemption shall take place pursuant to a decision of the board of
directors or of the general meeting of the shareholders.”
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to delete the second paragraph of article 7.6 of the Articles so that article 7.6 of the
Articles shall read henceforth as follows:
“ 7.6. Except as provided otherwise (i) in these articles of incorporation or (ii) by a written agreement which may be
entered into between the Company and the shareholders, the redemption price of each MRPS shall be equal to (a) the
aggregated nominal value of all the MRPS plus the portion of the balance of the MRPS Premium Account plus any accrued
but unpaid First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend (b) divided by the number of outstanding MRPS to
be redeemed at the time of the redemption. If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their
Mandatory Redemption Date, the Company shall redeem the maximum number of MRPS which the Company is then
permitted to redeem. Such redemption will be made on a pro rata basis from each MRPS holder.
If the Company is not permitted by Law to redeem all MRPS on their Mandatory Redemption Date, the Company shall
redeem the maximum number of MRPS which the Company is then permitted to redeem. Such redemption will be made
on a pro rata basis from each MRPS holder.
The Company may redeem its Ordinary Shares within the limits set forth by Law. However, the redemption of Or-
dinary Shares is subject to prior redemption of all the MRPS.
Except as otherwise provided in a written agreement which may be entered into among the shareholders of the
Company, at least fifteen (15) days prior to the redemption date, written notice shall be sent by registered mail or
internationally recognized overnight courier to each registered shareholder of the MRPS to be redeemed, at his or her
address last shown in the shareholders register of the Company, notifying such holder of the number of MRPS so to be
redeemed, specifying the redemption date, the redemption price, the procedures necessary to submit the MRPS to the
Company for redemption and the valuation of the redemption price, as provided for in this section. Each holder of MRPS
to be redeemed shall surrender the certificate or certificates, if any, issued in relation to such MRPS to the Company.
The redemption price of such MRPS shall be payable to the order of the person whose name appears on the share register
as the owner thereof on the bank account."
It is noted that the aggregate amount of accrued but unpaid First Preferred Dividend and Second Preferred Dividend
referred to above shall be identical to the deductions taken on the MRPS dividend for tax purposes in the past years (plus
any dividend accrued for the current year until the date of redemption).
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to redeem seven thousand six hundred forty-two dot thirty-seven (7,642.37) MRPS
(the Redeemed MRPS) held by Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. (the MRPS Redemption) in accordance with the terms of
article 7.6 of the Articles and article 49-8 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.
The Sole Shareholder, after having acknowledges that, based on the interim accounts of the Company as at 19 February
2015 (the Interim Accounts), the Company has sufficient distributable funds, resolves to approve such MRPS Redemption.
The Interim Accounts after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the under-
signed notary, shall remain attached to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The Sole Shareholder further resolves to reduce the share capital of the Company by an amount of ten thousand (EUR
10,000) in order to bring the share capital from its current amount of two million six hundred and fifty-one thousand
seven hundred and twenty-seven euro (EUR 2,651,727), represented by ten thousand (10,000) mandatory redeemable
preferred shares and two million six hundred and fifty-one thousand seven hundred and twenty-seven (2,641,727) ordinary
shares, each with a par value of one euro (EUR 1) to an amount of two million six hundred and forty-one thousand seven
hundred and twenty-seven euro (EUR 2,641,727), represented by two million six hundred and forty-one thousand seven
hundred and twenty-seven (2,641,727) ordinary shares, each with a par value of one euro (EUR 1), by way of the repur-
chase of seven thousand six hundred forty-two dot thirty-seven (7,642.37) MRPS, for a total aggregate amount of four
hundred seventy-nine million five hundred nineteen thousand five hundred ninety-nine euros and twenty-five cents (EUR
479,519,598.25), and the subsequent cancellation of ten thousand (10,000) mandatory redeemable preferred shares held
by the Company (2,357.63 MRPS held as treasury shares by the Company from previous redemptions and 7,642.37
Redeemed MRPS).
<i>Fifth resolutioni>
As a consequence of the above resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the Articles which
shall now read as follows:
“The Company’s subscribed share capital is set at 2,641,727 represented by two million six hundred and forty-one
thousand seven hundred and twenty-seven (2,641,727) ordinary shares (the “Ordinary Shares”) with a par value of one
euro (EUR 1.-) each. Each Ordinary Share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meeting. If the
share capital comprised mandatory redeemable preferred shares (the “MRPS” and, together with the Ordinary Shares,
30756
L
U X E M B O U R G
the “Shares”,) they will be are non-voting shares as provided for in article 44 of the Law. All the shares issued by the
Company are in registered form.
The subscribed capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sha-
reholders or the shareholder, as the case may be, adopted in the manner required for amendments of these articles of
incorporation.”
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the
same proxyholder of the appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English
version will prevail.
Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la version française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de février,
par devant Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
s’est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de la société Picard PIKco S.A., une société
anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-
Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le RCS) sous le
numéro B 156.504 (la Société).
La Société a été constituée le 5 novembre 2010 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 2655, en date du 3 décembre
2010.
Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte du notaire soussigné en
date du 4 septembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, sous le numéro 3444, en date du
18 novembre 2014.
A COMPARU:
Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis
7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le
numéro B 156.509 et ayant un capital social de 2.656.603.75 EUR (l’Actionnaire Unique),
ici représentée par Me Gwendoline Licata, juriste chez King & Wood Mallesons, ayant son adresse professionnelle à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
en vertu d’une procuration sous seing privé donnée le février 2015.
La procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné,
restera attachée au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enregistrement.
L’Actionnaire Unique, représenté selon les modalités susmentionnées, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce
qui suit:
I. Que l’Actionnaire Unique, détient 100% du capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Modification de l’article 7.1 des Statuts afin de permettre également à l’assemblée générale des actionnaires des
réaliser le rachat des actions préférentielles de rachat obligatoire (les MPRS);
3. Suppression du deuxième paragraphe de l’article 7.6 des Statuts afin de permettre le rachat des MRPS avant le
repaiement total des MRPS émises par Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l.;
4. Rachat de 7.642,37 MRPS détenues par Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. (les MRPS Rachetées) (le Rachat des MRPS)
et diminution successive du capital social de la Société d’un montant de 10.000 EUR afin de porter le capital social de son
montant actuel de 2.651.727 EUR à un montant de 2.641.727 EUR par l’annulation des 10,000 MRPS détenues par la
Société (2.357,63 MRPS détenues par la Société en tant qu'actions propres suite à des rachats précédents et 7.642,37
MRPS Rachetées);
5. Modification de l’article 6 des Statuts relatif of capital social afin de refléter les résolutions ci-dessus; et
6. Divers.
III. Que l’Actionnaire Unique prend les résolutions suivantes:
30757
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’intégralité du capital social souscrit étant représenté à la présente Assemblée, l’Actionnaire Unique renonce aux
formalités de convocation, l’Actionnaire Unique représenté se considère lui-même comme dûment convoqué et déclare
avoir parfaitement connaissance de l’ordre du jour de l’Assemblée qui lui a été communiqué au préalable.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 7.1 des Statuts, afin de permettre également à l’assemblée générale
des actionnaires des réaliser le rachat des MRPS, qui devra en conséquence être lu comme suit:
« 7.1. Toutes les MRPS émises par la Société sont des actions rachetables conformément aux dispositions de l’article
49-8 de la Loi. Sous réserve de ce qui est mentionné dans le présent document ou dans tout autre contrat entré en
vigueur entre les actionnaires et la Société, les MRPS émises et entièrement libérées seront rachetables (a) à la demande
de la Société conformément aux dispositions de l’article 49-8 de la Loi, et (b) dans tous les cas, après dix (10) ans à
compter de la date d'émission des MRPS (la «Date de Rachat Obligatoire»). Le rachat devra se dérouler conformément
à la décision du conseil d'administration ou de l’assemblée générale des actionnaires.»
<i>Troisième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de supprimer le second paragraphe de l’article 7.6 des Statuts qui devra en conséquence
être lu comme suit:
« 7.6. Sous réserve de dispositions contraires dans (i) des présents statuts ou (ii) un contrat entré en vigueur entre la
Société et les associés, le prix de rachat de chaque MRPS doit être égal à (a) la valeur nominale totale de toutes les MRPS,
plus une portion du solde du compte prime MRPS, plus tout cumulé mais non payé Premier Dividende Préférentiel et
Second Dividende Préférentiel (b) divisé par le nombre de MRPS en suspens devant être racheté à la date de rachat.
Si la Société n'est pas autorisée par la Loi à racheter toutes les MRPS à leur Date de Rachat Obligatoire, la Société
doit racheter le nombre maximum de MRPS que la Société est autorisée à racheter. Ce rachat sera réalisé sur une base
proportionnelle par chaque propriétaire de MRPS.
La Société peut racheter ses Actions Ordinaires dans les limites établies par la Loi. Cependant, le rachat des Actions
Ordinaires est sujet à un rachat préalable de toutes les MRPS.
Sous réserve de tout contrat entré en vigueur entre les actionnaires et la Société, au moins quinze (15) jours avant la
date de rachat, une notification devra être envoyée par courrier électronique ou par coursier de renommée internationale,
à chaque actionnaire nominatif de MRPS rachetables, à sa dernière adresse connue dans le registre des actionnaires de
la Société, notifiant ce propriétaire du nombre de MRPS rachetables, spécifiant la date de rachat, le prix de rachat, les
procédures nécessaires pour soumettre les MRPS à la Société pour le rachat et l’évaluation du prix de rachat, tel que
défini dans cette section. Chaque propriétaire de MRPS rachetable doit abandonner le(s) éventuel(s) certificat(s), émis
en relation avec ces MRPS à la Société. Le prix de rachat de ces MRPS doit être payé à l’ordre des personnes dont le
nom apparaît sur le registre des actionnaires en tant que propriétaire de ce compte bancaire.»
Il est noté que le montant total des Premier Dividende Préférentiel et Second Dividende Préférentiel cumulé mais non
payé mentionné ci-dessus sera identique à la déduction faite sur les dividendes MRPS aux fins fiscales les années précé-
dentes (plus tout dividende cumulé pour l’année en cours jusqu'à la date de rachat).
<i>Quatrième résolutioni>
L’Actionnaire Unique décide de racheter sept mille six cent quarante-deux virgule trente-sept (7.642,37) MRPS (les
MRPS Rachetées) détenues par Lion/Polaris Lux Topco S.à r.l. (le Rachat des MRPS) conformément aux nouveaux termes
de l’article 6 des Statuts et de l’article 49-8 de la loi du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.
L’Associé Unique, après avoir reconnu que, sur la base des comptes intérimaires de la Société datés au 19 février 2015
(les Comptes Intérimaires), la Société a des fonds distribuables suffisant, décide d’approuver un tel Rachat de MRPS.
Les Comptes Intermédiaires après avoir été signés ne varietur par le mandataire de la partie comparante et par le
notaire soussigné, resteront attachée au présent acte afin d'être soumise avec le présent acte aux formalités de l’enre-
gistrement.
L’Actionnaire Unique décide de diminuer le capital social de la Société d’un montant de dix mille euro (10.000 EUR)
afin de porter le capital social de son montant actuel de deux millions six cent cinquante-et-un mille sept cent vingt-sept
euro (2.651.727 EUR), représenté par deux millions six cent quarante et un mille sept cent vingt-sept (2.641.727) actions
ordinaires et dix mille (10.000) actions préférentielles de rachat obligatoire, chaque action ci-dessus ayant une valeur
nominale d'un euro (1 EUR) à un montant de deux millions six cent quarante-et-un mille sept cent vingt-sept euro
(2.641.727) EUR représenté par deux millions six cent quarante et un mille sept cent vingt-sept (2.641.727) actions
ordinaires, chaque action ci-dessus ayant une valeur nominale d'un euro (1 EUR), par le rachat de sept mille six cent
quarante-deux virgule trente-sept (7.642,37) MRPS, pour un prix total de quatre cent soixante-neuf millions cinq cent
dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-huit euro et vingt-cinq centimes (479.519.598.25 EUR), et l’annulation successive de
dix mille (10.000) MRPS détenues par la Société (2.357,63 MRPS détenues par la Société en tant qu'actions propres suite
à des rachats précédents et 7.642,37 MRPS Rachetées).
30758
L
U X E M B O U R G
<i>Cinquième résolutioni>
En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Actionnaire Unique décide de modifier l’article 5 des Statuts qui devra
être lu comme suit:
«Le capital social souscrit est fixé à 2.641.727 EUR représenté par deux millions six cent quarante et un mille sept cent
vingt-sept (2.641.727) actions ordinaires («Actions Ordinaires») d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune. A
chaque Action Ordinaire est accordé un vote lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Si le capital
social comprenait des actions préférentielles de rachat obligatoire («MRPS» et, Avec les Actions Ordinaires, les «Ac-
tions»), elles seraient des actions sans droit de vote selon l’article 44 de la Loi. Toutes les actions émises le sont sous
forme nominative.
Le capital souscrit de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale des actionnaires
statuant comme en matière de modification des statuts.»
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en
conséquence du présent acte sont estimés approximativement à deux mille cinq cents euros (EUR 2.500,-).
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du mandataire de la partie comparante, le
présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. À la requête du même mandataire de la partie comparante,
et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à l’année et au jour écrits en tête du présent acte.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé ensemble avec nous, le notaire,
l’original du présent acte.
Signé: G. Licata, M. Loesch.
Enregistré à Grevenmacher A.C., le 27 février 2015. GAC/2015/1675. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 4 mars 2015.
Référence de publication: 2015037308/249.
(150041629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2015.
EPIC I GP, S.à rl., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 186.222.
In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of January.
Before us, Maître Edouard Delosch notary residing in Diekirch Grand Duchy of Luxembourg
THERE APPEARED:
Castik Capital, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated and governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred and twelve thousand five hundred euro (EUR
512,500.-), registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B186205,
here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg
on 19 January 2015 and
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed
to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.
Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), representing the entire share capital of EPIC I
GP, S.à r.l., (hereinafter the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incorporated
and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500.-), registered with the Luxembourg Company and Trade Register under number B 186222, incorporated pursuant
to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 March 2014,
published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1620 on 24 June 2014. The articles of association
have not been amended since.
The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general
meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Amendment of article 13 of the articles of association that shall now be read as follows:
30759
L
U X E M B O U R G
“ Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.”
2. Amendment of article 16.5 of the articles of association that shall now be read as follows:
“The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.”
3. Amendment of article 18 of the articles of association that shall now be read as follows:
“ Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.”
4. Acknowledgment of the resignation of Mrs. Catherine Koch, as manager of the Company and granting of discharge;
5. Confirmation of the mandate of Mr. Michael Phillips and Mr. Geoffrey Henry, as managers of the Company;
6. Appointment of Mr. Dan Arendt, as manager of the Company;
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder unanimously takes, and requires the undersigned
notary to enact, the following resolutions:
<i>First Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 13 of the articles of association of the Company which shall henceforth
read as follows:
“ Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers
form a board of managers.
13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not
expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.
13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any
actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.”
<i>Second Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 16.5 of the articles of association that shall now be read as follows:
“The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-
sented at a meeting of the board of managers.”
<i>Third Resolutioni>
The Sole Shareholder decides to amend article 18 of the articles of association that shall now be read as follows:
“ Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the
signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.”
<i>Fourth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mrs. Catherine Koch, as manager of the Company,
with effect as from 15 February 2015 and decides to grant her discharge for the due performance of her duties which
discharge will have to be confirmed at the next annual general meeting approving the next Company’s annual accounts.
<i>Fifth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to confirm the mandate of:
30760
L
U X E M B O U R G
- Mr. Michael Phillips, born on 1 February 1962 in St. Louis, USA, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite
period of time.
- Mr. Geoffrey Henry, born on 5 May 1972, in Chênée, Belgium, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,
L-1528 Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.
<i>Sixth Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Mr. Dan Arendt, born on 15 May 1961, in Luxembourg, professionally residing at 42, op Fankenacker, L-3265 Bet-
tembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period
of time.
As a result of the above resolutions, until 15 February 2015 the board of managers of the Company is composed as
follows:
1. Mrs. Catherine Koch, aforementioned, as manager of the Company
2. Mr. Michael Phillips, aforementioned, as manager of the Company;
3. Mr. Geoffrey Henry, aforementioned, as manager of the Company;
4. Mr. Dan Arendt, aforementioned, as manager of the Company;
From 15 February 2015 the board of managers of the Company is composed as follows:
1. Mr. Michael Phillips, aforementioned, as manager of the Company;
2. Mr. Geoffrey Henry, aforementioned, as manager of the Company;
3. Mr. Dan Arendt, aforementioned, as manager of the Company;
<i>Seventh Resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that each manager, Dr. Christoph Diesel, Ms. Julia Szafranska and any lawyer or em-
ployee of Arendt & Medernach S.A., each acting individually, with full power of substitution, be and hereby is authorised,
empowered and directed, in the name of and on behalf of the Company, to execute and deliver or cause to be executed
and delivered any and all certificates, amendments, reports, applications, notices, letters or other documents and to do
or cause to be done any and all such other acts and things as, in the opinion of any such officer, may be necessary,
appropriate or desirable in order to enable the Company fully and promptly to carry out the purpose and intent of the
foregoing resolutions, and any such action taken or any certificate, report, application, notice, letter or other document
executed and delivered by them or any of them in connection with any such action shall be conclusive evidence of their
or his authority to take, execute and deliver the same, to amend any register of the Company, to proceed with the
completion of any required subsequent formality with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, as well as with
any required publication with the Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg Official Gazette).
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400,-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,
this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,
IST ERSCHIENEN:
Castik Capital, S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilitée limitée) gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528
Luxembourg mit einem Stammkapital von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 512.500,-) und eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186205,
hier vertreten durch Julia Szafranska, mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in
Luxemburg, am 19. Januar 2015.
Diese Vollmachten, unterzeichnet mit ne variatur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und den Notar,
verbleiben als Anhang bei dieser Urkunde um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.
30761
L
U X E M B O U R G
Die erschienene Partei ist alleiniger Gesellschafter (der „Alleingesellschafter“) und vertritt das gesamte Stammkapital
von EPIC I GP, S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilitée limitée) gegründet und
bestehend nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528
Luxembourg mit einem Stammkapital von fünfhundertzwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500,-) und eingetragen im
Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186222, gegründet entsprechend einer Urkunde
des Maître Martine Schaeffer, Notar mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 17. März 2014, veröffentlicht
im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations am 24. Juni 2014 unter der Nummer 1620 (die “Gesellschaft”). Die
Satzung wurde seitdem nicht geändert.
Die erschienen Partei, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, erklärt, unter Verzicht auf sämtliche
Benachrichtigungserfordernisse, die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengetreten, und kann wirk-
sam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:
<i>Tagesordnungi>
1. Änderung von Artikel 13 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:
„ Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäfstührers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.“
2. Änderung von Artikel 16.5 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:
„Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.“
3. Änderung von Artikel 18 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:
„ Art. 18. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Un-
terschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat über-
tragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.“
4. Anerkennung des Rücktritts von Frau Catherine Koch als Geschäftsführerin der Gesellschaft und Erteilung der
Entlastung;
5. Bestätigung der Mandate als Geschäftsführer für Herrn Michael Phillips und Herrn Geoffrey Henry;
6. Bestellung von Herrn Dan Arendt als Geschäftsführer der Gesellschaft;
7. Verschiedenes
Nach umfassender Berücksichtigung aller Tagesordnungspunkte beschließt der Alleingesellschafter einstimmig und
fordert den unterzeichnenden Notar auf, folgende Beschlüsse zu erlassen:
<i>Erster Beschlussi>
Die Generalversammlung der Gesellschafter beschließt Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er
ab nun wie folgt lautet:
„ Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-
schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.
13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-
führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.
13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln
und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.“
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Gesellschafter beschließt Artikel 16.5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er
ab nun wie folgt lautet:
„Der Geschäftsführungsrat kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner
Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.”
30762
L
U X E M B O U R G
<i>Dritter Beschlussi>
Die Generalversammlung der Gesellschafter beschließt Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er
ab nun wie folgt lautet:
„ Art. 18. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Un-
terschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat über-
tragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.“
<i>Vierter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt den Rücktritt von Frau Catherine Koch als Geschäftsführerin der Gesellschaft zum
15. Februar 2015 anzuerkennen und beschließt ihr die Entlastung für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten zu
erteilen, was auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die über den nächsten Jahresabschluss der Gesellschaft
entscheidet, bestätigt werden muss.
<i>Fünfter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt die Mandate folgender Personen zu bestätigen:
- Herr Michael Phillips, geboren am 01. Februar 1962 in St. Louis, USA, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1,
L- 1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte
Zeit.
- Herr Geoffrey Henry, geboren am 05. Mai 1972 in Chênée, Belgien, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1, L-
1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Zeit.
<i>Sechster Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt zu ernennen:
- Herr Dan Arendt, geboren am 15 Mai 1961 in Luxembourg, geschäftsansässig in 42, op Frankenacker, L-3265 Bet-
tembourg, Großherzogtum Luxembourg als Geschäftsführer der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und auf unbe-
stimmte Zeit.
Als Ergebnis der obigen Beschlüsse, setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft zum 15. Februar 2015 folgen-
dermaßen zusammen:
1. Frau Catherine Koch, vorbenannt, als Geschäftsführerin der Gesellschaft;
2. Herr Michael Phillips, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
3. Herr Geoffrey Henry, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
4. Herr Dan Arendt, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft.
Ab dem 15. Februar 2015 setzt sich der Geschäftsführerrat folgendermaßen zusammen:
1. Herr Michael Phillips, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
2. Herr Geoffrey Henry, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
3. Herr Dan Arendt, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft.
<i>Siebter Beschlussi>
Der Alleingesellschafter beschließt, dass jeder Geschäftsführer, Dr. Christoph Diesel, Frau Julia Szafranska und jeder
andere Rechtsanwalt oder Angestellte von Arendt & Medernach S.A., jeweils individuell und mit voller Vertretungsmacht
handelnd, hiermit ermächtigt und angewiesen wird im Namen der Gesellschaft und Interesse der Gesellschaft zu handeln,
jegliche Zertifikate, Änderungen, Berichte, Anträge, Mitteilungen, Briefe und andere Dokumente auszuführen, zu über-
geben oder zu veranlassen ausgeführt zu werden, als auch jegliche Handlungen oder Dinge vorzunehmen, die nach Ansicht
eines solchen Vertreters notwendig, angemessen oder wünschenswert sind um die Gesellschaft voll und schnellstmöglich
zu befähigen, Ziel und Zweck dieser Beschlüsse zu erreichen. Darüber hinaus soll jede von ihnen damit in Verbindung
stehende, vorgenommene Maßnahme, als auch alle von ihnen ausgeführten und gelieferten Zertifikate, Berichte, Anträge,
Notizen, Briefe oder andere Dokumente als beweiskräftiger Nachweis ihrer Bevollmächtigung dienen, diese vornehmen,
auszuführen oder liefern zu können um den Registereintrag der Gesellschaft zu ändern, sich anschließende und dafür
notwendige Formalitäten mit dem Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, als auch jede andere für die Fertig-
stellung notwendige Veröffentlichung im Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg Official Gazette)
fortzuführen.
<i>Kosten und Ausgabeni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass
dieser Beschlüsse entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-).
Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.
30763
L
U X E M B O U R G
Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-
schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und auf Anfrage derselben
erschienenen Parteien im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
vorrangig sein soll.
Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-
amen und Wohnort bekannt ist, vorgelesen worden ist, unterzeichnete die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien
dieses Dokument zusammen mit dem Notar.
Signé: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1344. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri> (signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 30 janvier 2015.
Référence de publication: 2015018844/255.
(150022396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
NEDP Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie.
R.C.S. Luxembourg B 101.019.
In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of January.
Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg,
THERE APPEARED:
Estée Lauder N.V., a company incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 15, Nijverheidss-
traat, B-2260 Oevel, registered to the Trade Register under the number 403.768.933 (the “Sole Shareholder”),
here represented by Maître Astrid WAGNER, lawyer, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given privately
on 19 December 2014.
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed in order to be registered therewith.
Such appearing party is the sole shareholder of NEDP Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its
registered office at L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under section B number B101.019, incorporated pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen,
notary residing at that time in Luxembourg, on the 26 May 2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, number 762 of 24 July 2004 (the “Company”). The articles of association of the Company have been
amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary on the 5 November 2014 published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 3493 of 21 November 2014.
The appearing party being the sole shareholder of the Company and representing the entire share capital took the
following resolutions:
<i>Agendai>
1. Approval of the contribution by the Company of its activities (i) of creation, production and sale of perfumes and
related fragrance, cosmetics and other related products carried out in offices located at 21, rue du Mont Thabor, F-75001
Paris, and in stores located at 21, rue du Mont Thabor, F-75001 Paris, and 37, rue de Grenelle, F-75007 Paris, and (ii) of
sale of perfumes and related fragrance products carried out in a store located at 140, avenue Victor Hugo, F-75016 Paris,
(the activities in (i) and (ii) herein are hereinafter referred to as the “French Business”) and particularly all the assets and
liabilities related to such activities (together with the French Business hereinafter the “Branch of Activities”) as set out
in the contribution plan, to EDP France Holding, a French law governed simplified stock company (société par actions
simplifiée), having its registered office at F-75008 Paris, 37, rue des Mathurins, recorded with the Paris register of trade
and commerce under number 807 760 749, in accordance with the contribution plan dated 26 November 2014 published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 3726 of 5 December 2014 (the “Contribution Plan”);
2. Approval of the final list of the employees whose employment contract is related to the Branch of Activities;
3. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder takes and requires the undersigned notary to
enact, the following resolution:
<i>First Resolutioni>
WHEREAS, the Sole Shareholder had due knowledge of:
- the Contribution Plan according to which the Company shall contribute, without dissolution, the Branch of Activities
to EDP France Holding, a French law governed simplified stock company (société par actions simplifiée), having its re-
30764
L
U X E M B O U R G
gistered office at F-75008 Paris, 37, rue des Mathurins, registered with the Paris register of trade and commerce under
number 807 760 749 (the “Transferee”, together with the Company hereinafter collectively the “Companies”);
- the annual accounts and management reports of the last three financial years of the Company;
- the opening balance sheet of the Transferee; and
- the anticipatory financials of the Branch of Activities as at 9 January 2015 drawn-up by the Company.
WHEREAS,in accordance with article 295 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the”
Law”), the Sole Shareholder received from the Company a copy of the documents listed here above one month prior to
this general meeting.
WHEREAS, the Sole Shareholder confirmed that the conditions precedent to the contribution of the Branch of Acti-
vities have been fulfilled, i.e. (i) a transfer of going concern agreement for the transfer of the Branch of Activities from
Nouvelles Editions de Parfums S.à r.l, a société à responsabilité limitée, duly organized and existing under the laws of
Luxembourg, having a share capital of one million euro (EUR 1,000,000), with its registered office at 16, avenue Pasteur,
L-2310 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 174.985 (the
“Transferor”) to the Company (the “Transfer of the Branch of Activities”) has been signed by the Transferor and the
Company on the date hereof, (ii) the Transfer of the Branch of Activities has been approved by the general meeting of
the Transferor in front of a Luxembourg notary and (iii) the Transfer of the Branch of Activities has been approved by
the general meeting of the Company in front of a Luxembourg notary.
WHEREAS, the Sole Shareholder declared being fully aware of the background and terms and conditions of the Con-
tribution Plan and resolved to waive, in accordance with article 296 of the Law, its right to be presented with, respectively
to receive:
- in accordance with article 293 (1) of the Law, a written report drawn-up by the board of managers of each of the
Companies explaining and justifying the Contribution Plan from a legal and from a financial perspective and the conside-
ration to be paid by the Transferee and indicating particular difficulties in the valuation of the Branch of Activities, if any;
- in accordance with article 293 (3) of the Law, information by the board of managers of the Company of any significant
changes to the assets and liabilities of the Company occurring between the date of the Contribution Plan and the date
hereof;
- in accordance with article 294 (1) of the Law, an examination of the Contribution Plan by and description in a written
report prepared by one or several independent auditors (réviseurs d’entreprises agréés) appointed by each of the Com-
panies.
WHEREAS, the Sole Shareholder confirmed that the contribution of the Branch of Activities shall be effective between
the parties on the date hereof.
WHEREAS, the Sole Shareholder confirmed that from an accounting and tax perspective, the contribution of the
Branch of Activities will with regard to the Companies be considered effective as from the date of this notarial deed.
WHEREAS, the Sole Shareholder confirmed that the contribution of the Branch of Activities to the Company has been
submitted to the provisions of articles 285 to 308, except 303, of the Law and that this contribution will therefore lead
to the transfer ipso jure of all the assets and liabilities related to the Branch of Activities as further set out in the Con-
tribution Plan in accordance with article 308bis-3 of said Law.
THEREFORE, the Sole Shareholder resolves to approve the terms of the Contribution Plan and the transfer of the
Branch of Activities from the Company to the Transferee as outlined above and in the Contribution Plan. The Sole
Shareholder further approves the consideration for the contribution of the Branch of Activities to the Transferor con-
sisting in five million two hundred eighty-one thousand seven hundred forty-six (5,281,746) shares of a nominal value of
one Euro (EUR 1) each to be issued by the Transferor and to be subscribed by the Company.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder approves the final list of the employees whose employment contract is at that the date hereof
related to the Branch of Activities and which employment contracts are thus transferred to the Transferee within the
framework of the contribution of the Branch of Activities. Such list, after having been signed ne varietur by the proxyholder
and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed in order to be registered therewith.
<i>Costs and Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are
estimated at four thousand euro (EUR 4,000.-).
Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-
ment.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,
this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name
and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.
30765
L
U X E M B O U R G
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le neuvième jour du mois de janvier.
Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
Estee Lauder N.V., une société constituée sous les lois de la Belgique, ayant son siège social au 15, Nijverheidsstraat,
B-2260 Oevel, inscrite au Registre de Commerce sous le numéro 403.768.933 (l’«Associé Unique»),
ici représentée par Maître Astrid WAGNER, Avocat, demeurant à Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing
privé en date du 19 décembre 2014,
laquelle procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée
au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
La partie comparante est l’associée unique de NEDP Holding S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son
siège social à L-1247 Luxembourg, 4-6, rue de la Boucherie, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B101.019, constituée suivant acte reçu par Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de
résidence à l’époque à Luxembourg, en date du 26 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 762 du 24 juillet 2004 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte
reçu par le notaire soussigné, le 5 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
3493 du 21 novembre 2014.
La partie comparante étant l’associé unique de la Société et représentant l’intégralité du capital social, a pris les réso-
lutions suivantes:
<i>Ordre du jouri>
1. Approbation de l’apport par la Société de ses activités (i) de conception, fabrication et commercialisation de parfums
et de produits de parfum liés, de cosmétiques et autres produits liés exercées dans des bureaux situés au 21, rue du Mont
Thabor, F-75001 Paris, et dans des magasins situés au 21, rue du Mont Thabor, F-75001 Paris, et au 37, rue de Grenelle,F-
75007 Paris, et (ii) de commercialisation de parfums et de produits de parfum liés exercées dans un magasin situé au 140,
avenue Victor Hugo, F-75016 Paris (les activités sous (i) et (ii) ci-dessus sont ci-après désignées comme l’«Activité Fran-
çaise») et particulièrement tous les actifs et passifs liés à ces activités (ensemble avec l’Activité Française ci-après la
«Branche d’Activités»), telles que décrites dans le projet d’apport, à EDP France Holding, une société par actions simplifiée
de droit français, ayant son siège social à F-75008 Paris, 37, rue des Mathurins, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 760 749, conformément au projet d’apport du 26 novembre 2014 publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3726 du 5 décembre 2014 (le «Projet d’Apport»);
2. Approbation de la liste définitive des salariés dont le contrat de travail est lié à la Branche d’Activité;
3. Divers.
Ayant considéré chaque point à l’ordre du jour, l’Actionnaire Unique prend, et requiert le notaire instrumentant à
acter, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
ATTENDU QUE, l’Associé Unique a pu prendre connaissance:
- du Projet d’Apport selon lequel la Société va apporter, sans dissolution, la Branche d’Activités à EDP France Holding,
une société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège social à F-75008 Paris, 37, rue des Mathurins, imma-
triculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 807 760 749 (le «Bénéficiaire», ensemble avec
la Société ci-après collectivement les «Sociétés»);
- des comptes annuels et des rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux de la Société;
- du bilan d'ouverture du Bénéficiaire; et
- des états comptables anticipatifs de la Branche d’Activités au 9 janvier 2015 établis par la Société.
ATTENDU QUE, conformément à l’article 295 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»), l’Associé Unique a reçu de la Société une copie des documents énumérés ci-dessus un mois avant
cette assemblée générale.
ATTENDU QUE, l’Associé Unique confirme que les conditions préalables à l’apport de la Branche d’Activités ont été
remplies, i.e. (i) un contrat de cession du fonds de commerce pour la cession de la Branche d’Activités de Nouvelles
Editions de Parfums S.à r.l., une société à responsabilité limitée, dûment organisée et existante sous les lois du Luxembourg,
ayant un capital social d’un million d’euros (EUR 1.000.000), avec siège social au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 174.985 (le «Cédant») à la Société (la
«Cession de la Branche d’Activités») a été signé par le Cédant et la Société à la date des présentes, (ii) la Cession de la
Branche d’Activités a été approuvée par l’assemblée générale du Cédant par devant un notaire luxembourgeois et (iii) la
Cession de la Branche d’Activités a été approuvée par l’assemblée générale de la Société par devant un notaire luxem-
bourgeois.
30766
L
U X E M B O U R G
ATTENDU QUE, l’Associé Unique a déclaré avoir pleine connaissance du contexte et des termes et conditions du
Projet d’Apport et a décidé de renoncer, conformément à l’article 296 de la Loi, à son droit de que lui soit présenté,
respectivement de recevoir:
- conformément à l’article 293 (1) de la Loi, un rapport écrit établi par le conseil de gérance de chacune des Sociétés
expliquant et justifiant le Projet d’Apport d’un point de vue juridique et économique et la rémunération à payer par le
Bénéficiaire et indiquant les difficultés d’évaluation particulières de la Branche d’Activités, le cas échéant;
- conformément à l’article 293 (3) de la Loi, l’information par le conseil de gérance de la Société de toute modification
importante du patrimoine actif et passif de la Société intervenant entre la date de l’établissement du Projet d’Apport et
de la présente date.
- conformément à l’article 294 (1) de la Loi, un examen du Projet d’Apport par, et description dans un rapport écrit
préparé par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés nommés par chacune des Sociétés.
ATTENDU QUE, l’Associé Unique a confirmé que l’apport de la Branche d’Activités sera effectif entre parties à la
date des présentes.
ATTENDU QUE, l’Associé Unique a confirmé que d’un point de vue comptable et fiscal, l’apport de la Branche d’Ac-
tivités sera considéré comme effectif à l’égard des Sociétés à la date du présent acte.
ATTENDU QUE, l’Associé Unique a confirmé que l’apport de la Branche d’Activités a été soumise aux dispositions
des articles 285 à 308, hormis l’article 303, de la Loi et que de ce fait l’apport de la Branche d’Activités entraîne de plein
droit le transfert de tous les actifs et passifs qui se rattachent à la Branche d’Activités, tel que défini dans le Projet d’Apport,
conformément à l’article 308bis-3 de ladite Loi.
PAR CONSEQUENT, l’Associé Unique décide d’approuver les termes du Projet d’Apport ainsi que le transfert de la
Branche d’Activités de la Société au Bénéficiaire, tel que décrit ci-dessus et dans le Projet d’Apport. L’Associé Unique
approuve par ailleurs la rémunération pour l’apport de la Branche d’Activités au Bénéficiaire pour un montant de cinq
millions deux cent quatre-vingt-un mille sept cent quarante-six (5.281.746) part sociales avec une valeur nominale d’un
euro (EUR 1) chacune à émettre par le Bénéficiaire et à souscrire par la Société.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique approuve la liste définitive des salariés dont le contrat de travail est lié à la Branche d’Activité et ces
contrats de travail sont donc transférés au Bénéficiaire dans le cadre de l’apport de la Branche d’Activités. Cette liste,
après avoir été signée ne varietur par le mandataire et par le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.
<i>Frais et Dépensesi>
Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombent à la Société en raison de cet acte
est évalué à environ quatre mille euros (EUR 4.000,-).
Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la partie comparante, le présent acte
est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande de la partie comparante et en cas de divergence
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et
résidence, ledit mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. WAGNE R et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 14 janvier 2015 1LAC / 2015 / 988. Reçu soixante-quinze euros € 75,-
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.
Luxembourg, le 29 janvier 2015.
Référence de publication: 2015019052/199.
(150022155) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Bigpoint Manager Investments S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-2341 Luxembourg, 5, rue du Plébiscite.
R.C.S. Luxembourg B 160.029.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015018692/9.
(150022622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
30767
L
U X E M B O U R G
Murano Invest S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen.
R.C.S. Luxembourg B 179.619.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015019018/10.
(150022940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 février 2015.
Lacombe Investissement S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 135.227.
<i>Extrait des résolutions du Conseil d'Administration du 29 janvier 2015i>
La société Edmond de Rothschild Europe S.A. inscrite au Registre de Commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 19194, ayant son siège social au 20, boulevard Emmanuel Servais; L - 2535 Luxembourg a été nommée
comme dépositaire des actions au porteur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Un administrateuri>
Référence de publication: 2015018246/13.
(150021970) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Horwitz & Partners Advisors, Société Civile Particulière.
Siège social: L-3450 Dudelange, 16, rue du Commerce.
R.C.S. Luxembourg E 3.078.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale de la société le 30 Décembre 2014i>
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de transférer le siège social de la Société du 81/A, rue X Octobre, L-7243 Bereldange au 16, rue
du Commerce, L-3450 Dudelange.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale décide de modifier l'article 1 des statuts, qui se lira désormais comme suit:
« Art. 1
er
. HORWITZ & PARTNERS ADVISORS s.c. est une société civile particulière de droit luxembourgeois qui
a pour objet tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger de fournir à toutes personnes physiques ou morales,
luxembourgeoises ou étrangères des conseils et des services de conseil économique. Ces conseils et services portent
notamment sur: gestion et organisation d'entreprises, systèmes de gestion d'entreprise et de gestion financière, réorga-
nisation et restructuration d'entreprise, fusion et acquisition, organisation et gestion du processus de production et du
service (contrôle et assurance de qualité), gestion de l'information et management informatique, marketing et commu-
nication, analyse financière et évaluation d'entreprise, expertise fiscale, gestion comptable, établissement des états
financiers, commissariat aux comptes et aux apports, formation, formation continue et training du personnel, expertise
en fiscalité internationale, gestion des ressources humaines, outplacement, recherche et sélection de personnel, gestion
des problèmes de l'environnement et audit technologique et environnemental, international tax-planing, constitution,
projets européennes. La société pourra de même effectuer toutes opérations se rattachant directement ou indirectement
à son objet ou qui en facilitent la réalisation, prendre des participations dans d'autres sociétés ayant des objets similaires
ou qui s'inscrivent dans une stratégie avantageuse pour la société. Pour extrait sincère et conforme
HORWITZ & PARTNERS ADVISORS scp
Aximmo s.a.
Claudio Bortolotti
Référence de publication: 2015018161/29.
(150021435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 février 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
30768
Alinvest Ltd
Amalthee S.A.
ArcIndustrial France Developments I S.à r.l.
Asport I & W, S.à r.l.
Autoécole Diederich S.à r.l.
Azulux S.A.
Beverage Investment Group S.A.
Beverage Investment Group S.A.
Beverage Investment Group S.A.
Bibo S.A.
Bigpoint Manager Investments S.C.A.
Bobby S.A.
Brie Project N° 3 S.à r.l.
BR Jack S.à r.l.
Caldia Fiduciaire S.A.
Cantobre S.A.
CHURCHILL.HUI International S.A.
CMS Management Services S.A.
Commercial Project Holdings S.à r.l.
Compagnie Mobilière S.A.
Cosminvest SA
Design Finance
Doosan Power Systems S.A.
EPIC I GP, S.à rl.
Fürstenberger Siedlung 2 S.à r.l.
Horwitz & Partners Advisors
Immomo S.A.
Jack (Cologne 20) S. à.r.l.
Jessan Participations S.à r.l.
KP Automotive S.àr.l.
Lacombe Investissement S.A.
LFI Brie Comte Robert
Lion/Polaris Lux 1 S.à r.l.
Murano Invest S.à r.l.
NEDP Holding S.à r.l.
New Village S.à r.l.
Oaktree Holding S.A.
Openregistry S.A.
PAN Asia Investment S.A.
Panev S.A.
Patron ES Holdings S.à r.l.
PG Europe Holding S.à r.l.
Picard Bondco
Picard PIKco S.A.
Point Lobos S.à r.l.
Safran
Symbiotics SICAV (Lux.)
Tyco Fire & Security Finance S.C.A.
Valeur S.A.
Westendam Europe S.A.
Xevin Investments S.à r.l.
YBL S.A.