logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 616

5 mars 2015

SOMMAIRE

Advanzia Bank S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29524

Adventure Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29523

ALUBRA S.à r.l. Luxembourg  . . . . . . . . . . .

29523

Aradio International Group S.A. . . . . . . . . .

29532

Atacama Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29523

BC Bowling S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29527

B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l.  . . . . . . . . .

29522

Beenyn Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

29525

BNAP S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29528

Bosscom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29524

Carrosserie Robert Comes & Compagnie

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29528

Castik Capital, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29547

CCSLUX S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29528

C.D.D. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29528

CDMLUX Expertise Comptable  . . . . . . . . .

29530

Chauffage Nuddelsfabrik S.A.  . . . . . . . . . . .

29554

Cofis Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29525

David Goldstern S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29524

Dynamic Plus Equity Fund (Lux) SIF SI-

CAV S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29568

Euro Secure  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29524

FIL (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29523

Fonsicar Managers S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

29522

Food Delivery Holding 19 S.à.r.l.  . . . . . . . .

29555

Gardur Partners S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29539

Gasfin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29523

Jennifer S.A. S.P.F.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29533

Koromo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29529

Meigerhorn Bulle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29529

Mont Mirail Limited, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

29529

Najade S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29527

Natitri S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29526

Neovara European Mezzanine Partners

2003-B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29566

North American Capital Investors of Lu-

xembourg (NACIL)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29527

Nuremburg Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

29527

Oberheim S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29526

PFB Properties S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29522

Plastiche S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29526

Platanthera S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29539

Public Safety Luxembourg, S.à r.l.  . . . . . . .

29552

RDF Constructions S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29522

Rodeo-Timber de Bellux  . . . . . . . . . . . . . . . .

29522

Solar Carbide S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29568

Sud Petrol S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29525

Thill Romain et Fille S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

29525

29521

L

U X E M B O U R G

Rodeo-Timber de Bellux, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5515 Remich, 3-8, rue des Champs.

R.C.S. Luxembourg B 35.357.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 29 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015016716/10.
(150019781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

RDF Constructions S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4942 Bascharage, 3, rue de la Résistance.

R.C.S. Luxembourg B 166.634.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016708/10.
(150019545) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

PFB Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 169.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015016690/11.
(150019591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8380 Kleinbettingen, 6, rue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 35.741.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PERREAUX Bernard
<i>Gérant

Référence de publication: 2015016925/11.
(150021083) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Fonsicar Managers S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.726.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FONSICAR MANAGERS S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Signatures

Référence de publication: 2015017141/12.
(150019966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

29522

L

U X E M B O U R G

ALUBRA S.à r.l. Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9990 Weiswampach, 1, Kiricheneck.

R.C.S. Luxembourg B 139.311.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Weiswampach, le 2 février 2015.

Référence de publication: 2015016900/10.
(150021060) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Atacama Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20A, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 176.168.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015016920/10.
(150020091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Adventure Europe, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 156.513.

Le bilan et l’annexe au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un gérant

Référence de publication: 2015016880/11.
(150021037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Gasfin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 116.145.

Les comptes annuels du 1 

er

 janvier 2013 au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015017207/11.
(150020441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

FIL (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 29.112.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

FIL (Luxembourg) S.A.
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015017154/12.
(150020188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

29523

L

U X E M B O U R G

David Goldstern S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 20, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 133.884.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016419/9.
(150019366) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Bosscom, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3441 Dudelange, 23, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 156.599.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015016376/11.
(150019460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Euro Secure, Société Anonyme.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 168.067.

EXTRAIT

Monsieur Richard Van't Hof, né le 05 octobre 1965 à Barendrecht, Pays Bas, avec adresse professionnelle au 75, Parc

d'activités, L-8308 Capellen, assure la fonction de représentant permanent de la société à responsabilité limitée SEREN
Sarl pour ses fonctions d'administrateur de la société anonyme Euro Secure S.A jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra
en 2018.

Pour Extrait
La société

Référence de publication: 2015015728/14.
(150018368) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Advanzia Bank S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9, Parc d'Activité Syrdall.

R.C.S. Luxembourg B 109.476.

EXTRAIT

Le conseil d'administration de la Société a élu par voie de cooptation conformément aux statuts coordonnés de la

Société M. Bengt Arve Rem en tant que nouveau membre du conseil, en remplacement de M. Thomas Altenhain. Le
mandataire est inscrit à l'adresse professionnelle suivante: Stranden 1, 0250 Oslo/Norvège.

M. Tom Ruud ainsi que M. Christian Holme, M. Bengt Arve Rem, M. Tor Erland Fyksen et Dr. Thomas Schlieper

représentent les membres du conseil d'administration de la Société et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société approuvant les comptes annuels 2014.

La  Commission  de  Surveillance  du  Secteur  Financier  (CSSF)  a  confirmé  la  nomination  par  courrier  en  date  du

01.12.2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

ADVANZIA Bank S.A.
Signature

Référence de publication: 2015015482/20.
(150019029) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29524

L

U X E M B O U R G

Thill Romain et Fille S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 41, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 152.143.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015016792/10.
(150019502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Sud Petrol S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-4450 Belvaux, 65, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 166.931.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 30 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015016767/10.
(150019808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Beenyn Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 32.958.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue au siège social à Luxembourg, le 14 janvier 2015

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège

social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme
BEENYN INVESTMENTS S.A.

Référence de publication: 2015015576/12.
(150019257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cofis Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1820 Luxembourg, 10, rue Antoine Jans.

R.C.S. Luxembourg B 113.695.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 janvier 2015 que:
- Monsieur Vincent WILLEMS, expert-comptable, né le 30 septembre 1975 à Liège (Belgique) et demeurant profes-

sionnellement au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg, a été nommé administrateur en remplacement de Monsieur
Bertrand MICHAUD, démissionnaire.

Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en 2021.
- Les mandats des administrateurs Madame Orietta RIMI, employée privée, née le 29 septembre 1976 à Erice (Italie)

et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg et Madame Elena LATORRE, employée
privée, née le 6 décembre 1975 à Luxembourg et demeurant professionnellement au 10 rue Antoine Jans L-1820 Lu-
xembourg, ont été renouvelés jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.

- Le mandat du Commissaire SER.COM S.àr.l., B 117 942, ayant son siège social à L-1331 Luxembourg, 19 boulevard

Grande-duchesse Charlotte, a été renouvelé jusqu'à l'assemblée qui se tiendra en 2021.

- Le siège social est transféré du 26/28 Rives de Clausen au 10 rue Antoine Jans L-1820 Luxembourg.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015665/22.
(150018270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29525

L

U X E M B O U R G

Oberheim S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.250.000,00.

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, Val des Bons-Malades.

R.C.S. Luxembourg B 47.928.

<i>Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique de la Société en date du 15 janvier 2015

Il résulte des décisions prises en date du 15 janvier 2015 par Pater Holding SAS, société par actions simplifiée, action-

naire unique, gérant de catégorie A et délégué à la gestion journalière de la Société, que son représentant permanent au
conseil de gérance de la Société n'est plus M. Charles Diehl, mais M. Christophe Lecarme, né le 4 Mai 1964 à Paris 18

ème

 , France, de nationalité française, demeurant professionnellement au 307 rue d'Estiennes d'Orves, 92707 Colombes,

France.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015016051/17.
(150018625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Plastiche S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 76-78, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 64.244.

Il est pris acte du changement de siège social de l'Administrateur suivant:
- RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L., 76-78 rue de Merl, L-2146 Luxembourg
Il est pris acte du changement d'adresse professionnelle de l'Administrateur suivant:
- Mr. Benoît PARMENTIER, 76-78, rue de Merl, L-2146 Luxembourg

Fait à Luxembourg, le 27/01/2015.

Certifié sincère et conforme
PLASTICHE S.A.
RAVAGO MANAGEMENT S.à R.L. / Benoît PARMENTIER
<i>Administrateur / Administrateur
Mme Gunhilde VAN GORP / -
<i>Représentant Permanent / -

Référence de publication: 2015016115/18.
(150018489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Natitri S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 50, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 158.248.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 30 décembre 2014 à 9h00

<i>Résolution:

L'Assemblée décide d'accepter avec effet immédiat la démission de Monsieur Patrick Haller, en sa qualité de gérant

unique de la société.

L'Assemblée décide de nommer comme nouveau gérant unique de la société, pour une durée indéterminée, Monsieur

John Foster, né le 18 mars 1965 à Panama, et résidant professionnellement au 6 

th

 Floor, Humboldt Tower, East 53 

rd

Street, Marbella, Panama (République de Panama).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

p. NATITRI S.à r.l.
Signature
<i>L'Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2015016026/19.
(150018495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29526

L

U X E M B O U R G

BC Bowling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1899 Kockelscheuer, 20, route de Bettembourg.

R.C.S. Luxembourg B 53.208.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016368/9.
(150019479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Nuremburg Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.168.

Par la présente, je démissionne avec effet immédiat de ma fonction d'Administrateur de votre société NUREMBURG

PROPERTIES S.A., enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
118.168.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Max GALOWICH.

Référence de publication: 2015016044/11.
(150018959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Najade S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 139.029.

<i>Auszug aus dem Bericht des Verwaltungsrates vom 15. Dezember 2014 an die Aktionäre und an den Aufsichtskommissar

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ernennung als Depositar FIDUCIAIRE MOSELLAN SARL, eingetragen

im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschriften
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015016022/13.
(150018832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

North American Capital Investors of Luxembourg (NACIL), Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 178.245.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 16 décembre 2014

Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Joseph WINANDY, en sa qualité d'Ad-

ministrateur.

En vertu des articles 51 alinéa 5 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, est nommé provisoi-

rement au poste d'administrateur:

Jean-Charles THOUAND
183, rue de Luxembourg
L-8077 BERTRANGE
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation

de sa nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Copie certifiée conforme
JALYNE S.A. / -
Signatures
<i>Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2015016019/21.
(150018209) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29527

L

U X E M B O U R G

BNAP S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 156.966.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016375/9.
(150019467) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

C.D.D. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3508 Dudelange, 42, Op Lenkeschlei.

R.C.S. Luxembourg B 81.062.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016382/10.
(150019674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

CCSLUX S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 148.256.

<i>Décisions prises lors de la réunion du conseil d'administration du 23 janvier 2015.

Le conseil, après lecture de la lettre de démission de la fonction d'administrateur de Monsieur Antoine Mafrica, décide

d'accepter cette démission avec effet immédiat.

Le conseil coopte comme nouvel administrateur, avec effet immédiat, Madame Marina Padalino, résidant profession-

nellement au 20, rue de la poste à L-2346 Luxembourg, son mandat ayant pour échéance la période expirant à l'assemblée
générale statuant sur les comptes de l'exercice clôturé au 31 décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Citco C&amp;T (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015016393/15.
(150019490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6947 Niederanven, 2, rue Jacques Lamort.

R.C.S. Luxembourg B 6.349.

<i>Extrait de l'Assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2014

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ce qui suit:
L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur Pierre Hirtt comme administrateur.
L'assemblée générale nomme administrateur Monsieur Yves Elsen, né à Luxembourg, le 4 mars 1958, demeurant à

L-8266 Mamer, 8, rue des Thermes.

L'assemblée générale révoque Monsieur Jean-Claude Schmitz de sa fonction de commissaire aux comptes.
L'assemblée nomme commissaire aux comptes Monsieur Frank Hartmann, né à Luxembourg, le 23 juillet 1965, de-

meurant à L-6442 Echternach, 13, Geessbreck.

Les mandats des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux comptes expireront le 31 dé-

cembre 2016.

Luxembourg, le 22 avril 2014.

Pour extrait conforme
CARROSSERIE ROBERT COMES &amp; COMPAGNIE SA

Référence de publication: 2015016392/20.
(150019957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29528

L

U X E M B O U R G

Mont Mirail Limited, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 317.095,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.677.

<i>Extrait des résolutions prises par le gérant unique de la Société en date du 31 décembre 2014

En date du 31 décembre 2014, le gérant unique de la Société a pris la résolution suivante:
- d'accepter la démission de Madame Kim MORGAN de son mandat de gérant de classe A de la Société avec effet au

27 octobre 2014.

Suite à cette démission, Monsieur Eric FORT est désormais le gérant unique de la Société.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Mont Mirail Limited, S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015015968/17.
(150018429) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Meigerhorn Bulle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CHF 82.500,00.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 110.319.

EXTRAIT

Il résulte d'une cession de parts sociales effectuée en date du 20 janvier 2015 que la société MEIGERHORN PRO-

PERTIES S.à r.l., ayant son siège social à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves, inscrite au R.C.S. Luxembourg sous
le n° B 117.988 , a cédé 2.000 parts sociales qu'elle détenait dans la société Meigerhorn Bulle S.à r.l., ayant son siège social
à L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves à Financière Européenne des Retail Parks S.A., en abrégé Financière Eurepa,
ayant son siège social au 60, Grand-Rue, L-1660 Luxembourg inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le n° R.C.S. B 174 364.

Suite à ce transfert, le capital social de la société de la société Meigerhorn Bulle S. à r.l. sera détenu comme suit:

Financière Européenne des Retail Parks S.A. en abrégé Financière Eurepa . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 parts sociales

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015965/18.
(150018710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Koromo S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 153.725.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique de la Société en date du 29 décembre 2014

Il a été décidé:
- D'accepter la démission de Madame Preeti Kotwani-Khitri de son mandat d'Administrateur, résidant 52-54, avenue

du X Septembre, L-2550 Luxembourg avec effet au 1 

er

 Janvier 2015.

- De nommer Madame Catherine Pirrie, résidant 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg avec effet au 1

er

 Janvier 2015 et pour une durée maximale de 6 ans, en tant qu'Administrateur de la Société.

A partir du 1 

er

 Janvier 2015, les administrateurs de la Société sont:

- Madame Petronella Johanna Sophia Dunselman, Administrateur;
- Madame Zamyra Heleen Cammans, Administrateur; et
- Madame Catherine Pirrie, Administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2015015916/19.
(150019243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29529

L

U X E M B O U R G

CDMLUX Expertise Comptable, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 34B, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 194.058.

STATUTS

L'an deux mille quinze, le quinze janvier.
Pardevant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

Madame Corine DAL MAS, expert-comptable, née le 4 septembre 1965 à Algrange (France), demeurant à 18, rue

Guérin de Waldersbach F-57100 Thionville.

Laquelle comparante a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée:

Titre 1 

er

 . - Objet, raison sociale, durée, siège

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi

que par les présents statuts.

Art. 2. La société a pour objet l'exécution de toutes les activités d'expert-comptable et fiscal telles qu'elles sont définies

à l'article 1 

er

 de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable.

La société pourra également, à titre accessoire, exercer les activités d'expertise fiscales, économiques et financières,

de tous mandats d'organisation technique, administrative, les activités en matière de décomptes des salaires et de secré-
tariat social, de domiciliataire de sociétés, ainsi que toutes activités se rattachant directement à la profession d'expert-
comptable, de conseil fiscal, de conseil économique et financier ou à celle de conseil en organisation, le tout sous réserve
du respect des dispositions législatives et déontologiques de la profession d'expert-comptable et à l'exclusion de toute
activité commerciale.

La société pourra notamment prendre des participations dans toutes sociétés exerçant des activités similaires ou

complémentaires, faire toutes les opérations civiles, mobilières, immobilières et financières qui se rattachent à son objet
social ou qui sont susceptibles d'en faciliter la réalisation pour autant que ces opérations restent compatibles avec la
profession d'expert-comptable.

La société peut emprunter et accorder à d’autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours,

prêts, avances ou garanties.

Art. 3. La société prend la dénomination de «CDMLUX Expertise Comptable»

Art. 4. La durée de la société est illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre 2. - Capital social, parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cinq cents

(500) parts sociales, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,-) chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires.

Art. 7. Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord unanime des associés.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction proportionnelle au nombre des parts existantes de l'actif social

ainsi que des bénéfices.

Art. 9. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chacune

d’elles.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et

même personne.

Art. 10. La majorité des droits de vote attachés aux parts sociales doit être détenue par des personnes physiques qui

satisfont  aux  conditions  d’honorabilité  et  de  qualification  professionnelles  pour  l'exercice  de  la  profession  d’expert-
comptable prévues par la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d’établissement.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des

non-associés que moyennant l'agrément unanime.

Les parts sociales ne peuvent être transmises pour cause de mort à des non-associés que moyennant le même agrément

unanime.

29530

L

U X E M B O U R G

Le même agrément unanime de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises pour cause de mort soit

à des descendants, soit au conjoint survivant.

En cas de décès d’un associé, les associés survivants jouissent dans tous les cas d’un droit de préférence pour le rachat

des parts de l'associé décédé; dans ce cas, le prix de rachat des parts sociales se calcule sur la base du bilan moyen des
trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des
deux dernières années.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer endéans les

trente jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d’exercice de ce droit de préemption, la valeur
de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés
commerciales.

Art. 11. Le décès, l'interdiction, la faillite ou déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 12. Les créanciers, ayants droit ou héritiers ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des scellés sur

les biens et documents de la société, ni faire procéder à un inventaire judiciaire des valeurs sociales.

Titre 3. - Administration

Art. 13. La société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés et pris parmi eux ou

en dehors d’eux.

Le gérant unique, ou la majorité des gérants en cas de pluralité, doit(vent) être choisi parmi les personnes physiques

qui satisfont aux conditions d’honorabilité et de qualification professionnelles pour l'exercice de la profession d’expert-
comptable prévues par la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d’établissement.

Le gérant unique, ou l'un des gérants en cas de pluralité, doit avoir un lien réel avec la société en étant associé ou

salarié, et ne doit pas s’être soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire
d’une société qu’il dirige ou qu’il a dirigée.

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d’administration, de gestion et de disposition

intéressant la société, quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu’elles rentrent dans l'objet
de la société.

En cas de pluralité des gérants, l'assemblée générale fixe les attributions et pouvoirs des différents gérants. La durée

des fonctions du gérant n’est pas limitée.

L’assemblée générale pourra décider la révocation du gérant sans qu’il soit besoin d’une décision judiciaire à cet effet.
La révocation pourra être décidée, non seulement pour des causes légitimes, mais encore pour toutes raisons, quelles

qu’elles soient, laissées à l'appréciation souveraine des associés. Le gérant peut pareillement se démettre de ses fonctions.

Les associés décideront de la rémunération du gérant ou des gérants.

Art. 14. Le décès du gérant, associé ou non, sa démission ou sa révocation pour quelque motif que ce soit, n’entraîne

pas la dissolution de la société. Les créanciers, héritiers ou ayants cause du gérant ne peuvent en aucun cas faire apposer
les scellés sur les biens et documents de la société.

Art. 15. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent.
Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu’il possède ou représente.

Art. 16. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu’elles aient été adoptées par des associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés repré-

sentant les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 17. Le gérant ne contracte, en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la société. Simple mandataire, il n’est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 18. L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Art. 19. Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et la gérance dresse un inventaire com-

prenant l'indication des valeurs actives et passives de la société. Tout associé peut prendre au siège social communication
de l'inventaire et du bilan.

Art. 20. Les produits de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, des charges et

des amortissements nécessaires constituent les bénéfices nets.

Sur les bénéfices nets, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d’un fonds de réserve jusqu’au moment

où cette réserve aura atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

Titre 4. - Dissolution, liquidation

Art. 21. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés

par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

29531

L

U X E M B O U R G

Disposition générale

Art. 22. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Les statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les parts sociales ont été souscrites comme suit:

Associés

Nombre

de parts

1. Madame Corine DAL MAS, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

500

Toutes les parts sociales ont été entièrement libéré par des versements en espèces, de sorte que la somme de douze

mille cinq cents Euros (EUR 12.500,-) se trouve dès maintenant à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

<i>Evaluation des Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent approximativement à la somme de mille euros (EUR
1.000,-).

<i>Résolutions de l'associé unique

L’associée unique a immédiatement pris les décisions suivantes:
1. Le siège social de la Société est établi à L-2340 Luxembourg, 34B rue Philippe II.
2. La personne suivante est nommée comme gérant unique de la Société pour une durée indéterminée:
Madame Corine DAL MAS, précitée.
La société est engagée par la seule signature de la gérante unique.
L’attention de la comparante a été expressément attirée par le notaire instrumentaire sur la nécessité d’obtenir des

autorités compétentes les autorisations et/ou agréments requis le cas échéant afin d’exercer les activités telles que dé-
crites à l'article 2 des présents Statuts.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête les présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, la comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Dal Mas, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 21 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/1716. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016396/143.
(150019767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Aradio International Group S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-9647 Doncols, 14, Chemin des Douaniers.

R.C.S. Luxembourg B 83.975.

<i>Procès-verbal de l'assemblée générale extra-ordinaire du 29/01/2015

Il résulte de l'AGE tenue ce 29 Janvier 2015 ce qui suit:
1°) nomination au poste de commissaire aux comptes jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2018, de

La Fiduciaire Comptable Comptafisc Sàrl domiciliée au 18, Route de Bigonville à L-8832 Rombach et immatriculée au
Registre de Commerce sous le numéro B144397

Aradio International Group SA

Référence de publication: 2015015504/13.
(150018669) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29532

L

U X E M B O U R G

Jennifer S.A. S.P.F., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 194.024.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the eighth of January.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Agiannidis DIMITRIOS, entrepreneur, born on 26 April 1941, in Neapoli, Greece, residing at 45, Komninon, 57013

Thessaloniki, Greece, and owner of an passport number AK1768285, here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private
employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy, given under private
seal. (the “Sole Shareholder“),

The said proxy, initialed ne varietur by the mandatory of the appearing party and the notary, will remain annexed to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party, acting in his here above stated capacities, has required the officiating notary to enact the deed

of incorporation of a société anonyme which he declares organized and the articles of incorporation of which shall be as
follows:

Denomination - Registered office - Duration - Object - Capital

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who

may become partners in the future, a Société de gestion de Patrimoine Familial under the form of a limited company
(société anonyme) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended,
the law of 11 May 2007 on the Société de gestion de Patrimoine Familial as well as by the present articles of incorporation.

The company shall assume the name of “Jennifer S.A. SPF”
The Company may have one shareholder or several shareholders. For so long as the Company has a Sole Shareholder,

the Company may be managed by a Sole Director only who does not need to be a shareholder of the Company.

Art. 2. The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries

of the municipality of the registered office by a resolution of the board of directors of the Company or, in the case of a
sole director by a decision of the Sole Director.

Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are

imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its regis-
tered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be
temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary mea-
sures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered
office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited duration.

Art. 4. The object of the company is the acquisition, holding, management and disposal of financial assets within the

meaning of article 2 of the law of 11 May 2007 on the Société de gestion de Patrimoine Familial.

The company shall not carry on any commercial activity.
In general, it may carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its

purpose, remaining always however within the limits established by the law of 11 May 2007 on the Société de Gestion
de Patrimoine Familial.

Art. 5. Share capital. The subscribed share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) consisting of 310

(three hundred and ten) shares with a par value of hundred euro (EUR 100) each.

The shares are in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.

Administration - Supervision

Art. 6. For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director only.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by a Board composed of at least
three (3) directors who need not be shareholders of the Company. In that case, the General Meeting must appoint at
least two new directors in addition to the then existing Sole Director. The director(s) shall be elected for a term not
exceeding six years and shall be re-eligible.

When a legal person is appointed as a director of the Company, the legal entity must designate a permanent repre-

sentative (représentant permanent) who will represent the legal entity in accordance with article 51bis of the Luxembourg
act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

29533

L

U X E M B O U R G

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The shareholders of the Company shall also determine the

number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause
and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors

may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining
directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor and held to appoint new directors.

Art. 7. The Board or the Sole Director, as the case may be, is vested with the broadest powers to perform or cause

to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the Law of August 10, 1915 as amended or by the Articles to the General Meeting

fall within the competence of the Board or the Sole Director, as the case may be.

Art. 8. The Board shall appoint a chairman among its members; in his/her absence, the meeting will be presided by

another member of the Board present at the meeting. Exceptionally, the first chairman shall be appointed by the consti-
tutive general meeting.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing, in writing whether in original, by telefax,

cable,  telegram,  or  telex  another  director  as  his  or  her  proxy.  A  director  may  represent  one  or  several  of  his/her
colleagues.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, visio conference, or similar means of

communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis
and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in
person at such meeting.

The Board can deliberate and act validly only if at least the majority of the Company's directors is present or repre-

sented at a meeting of the Board.

Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the

case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall not have a casting vote.

Resolutions in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as resolutions voted at the

director's meetings.

The resolutions passed by the Sole Director shall be vested with the same authority as the resolutions passed by the

Board and are documented by written minutes signed by the Sole Director.

Art. 9. The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the corporation to one

or more directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the corporation or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

Art. 10. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members

of the Board, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director or (iii) by the sole signature of
the managing director within the limits of the daily management or (iv) by the joint signatures of any persons or sole
signature of the person to whom such signatory power has been granted by the Board or the Sole Director, but only
within the limits of such power.

Supervision

Art. 11. The corporation is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of

shareholders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not
exceed six years.

Accounting year - General meetings

Art. 12. The accounting year of the Company shall begin on the 1 January and shall terminate on the 31 December of

each year.

Art. 13. In the case of a single shareholder, the single shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting

pursuant to the Law of August 10, 1915 as amended.

The notice to attend the General Meetings provided for by law shall govern the notice for. If all the shareholders of

the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and
informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

Each share is entitled to one vote.
Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, visio conference, or similar means of com-

munications equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating
in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis

29534

L

U X E M B O U R G

and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence
in person at such meeting.

Art. 14. Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of

shareholders of the Company.

It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the corporation and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the corporation. Of the net profits, five percent (5,00%) shall be appropriated for the legal
reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10,00%) of the capital of the
corporation, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever,
it has been touched.

The balance is at the disposal of the general meeting. The Board of Directors or the Sole Director, as the case may

be, may pay interim dividends in compliance with the legal requirements.

Art. 16. The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such

other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the
fifth day of May at 11 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on
the next following business day.

Art. 17. Applicable law. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with

the Companies Act 1915 as amended.

<i>Transitional provisions

1) The first financial year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall end on the last day of

December 2015.

2) The first annual General Meeting shall be held in 2016.

<i>Subscription

The articles of association having thus been established, the party appearing declares to subscribe the issued share

capital upon incorporation as follows:

Mr. Agiannidis DIMITRIOS, prenamed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 shares

All the shares of a par value of hundred euros (EUR 100.-) each have been fully paid up by payment in cash and the

amount of thirty-one thousand EURO (EUR 31,000.-) is now available to the corporation, evidence thereof was given to
the undersigned notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of August 10th,

1915 on commercial companies as amended have been observed.

<i>Estimation - Expenses

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of its organisation, is approximately one thousand five hundred Euro
(EUR1,500.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named party, representing the entire subscribed capital of the corporation and considering the meeting

duly convoked, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting.

Having first verified that it was regularly constituted, the single shareholder has passed the following resolutions by its

affirmative vote:

1) The registered office of the corporation is fixed at 11-13 Boulevard de la Foire, L-1258 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg;

2) Have been appointed as the Sole Director of the Company:
Mr. Agiannidis DIMITRIOS, entrepreneur, born on 26 April 1941, in Neapoli, Greece, residing at 45, Komninon, 57013

Thessaloniki, Greece.

3) Has been appointed statutory auditor:
European Trust Services (Luxembourg) S.à r. l., a private limited company having its registered office at 11-13 Boulevard

de la Foire, L-1528 Luxembourg, registered at the Trade and Companies Register under the number B33065;

4) The Sole Director's and the statutory auditor's terms of office will expire after the annual meeting of shareholder

(s) of the year 2020, unless they previously resign or are revoked.

29535

L

U X E M B O U R G

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the date mentioned at the beginning of this

document.

The deed having been read to the appearing person, known to the notary by surname, Christian name, civil status and

residence, the said person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L'an deux mil quinze, le huit janvier.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire, de résidence à Niederanven, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Agiannidis DIMITRIOS, entrepreneur, né le 26 avril 1941 à Neapoli (Grèce), et étant domicilié au 45, Kom-

ninon, 57013 Thessaloniki, Grèce, ayant son passeport sous le numéro AK1768285 ici représentée par Monsieur Liridon
ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu
d'une procuration sous seing privé. («L'Associé Unique»).

La procuration signée ne varietur par la mandataire du comparant et par le notaire soussigné restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société

anonyme qu'elle déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

Dénomination - Siège - Durée - Objet - Capital

Art. 1 

er

 .  Il est formé par le présente par le propriétaire actuel des actions ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir par la suite, une Société de gestion de Patrimoine Familial sous la forme d'une société anonyme qui sera régie
par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, la loi du 11 mai 2007 sur la Société
de gestion de Patrimoine Familial, ainsi que par les présents statuts.

La société prend la dénomination de «Jennifer S.A. SPF».
La Société peut avoir un associé unique ou plusieurs actionnaires. Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la

Société peut être administrée par un administrateur unique seulement qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la
Société.

Art. 2. Le siège social est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans tout autre endroit de la commune du siège

social par décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique, selon le cas.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transférer provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males. Une telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite
et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les cir-
constances données.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d'actifs financiers tels que définis à

l'article 2 de la loi du 11 mai 2007 relative à la Société de gestion de Patrimoine Familial.

La société n'aura pas d'activité commerciale.
La société prendra toutes mesures pour sauvegarder ses droits et fera toute opérations généralement quelconques

qui se rattachent à son objet ou le favorisent, en restant toutefois dans le limite de la loi du 11 mai 2007 relative à la
Société de gestion de Patrimoine Familial.

Art. 5. Le capital souscrit est fixé à trente et un mille euros (31.000.-EUR) représenté par trois cents dix (310) actions

d'une valeur nominale de cent euros (100.- EUR) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.
La Société peut procéder au rachat de ses propres actions sous les conditions prévues par la loi.

Administration - Surveillance

Art. 6. Tant que la Société a un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un administrateur unique

seulement. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société sera administrée par un conseil d'administration comprenant
au moins trois membres, lesquels ne seront pas nécessairement actionnaires de la Société. Dans ce cas, l'assemblée
générale doit nommer au moins 2 (deux) nouveaux administrateurs en plus de l'administrateur unique en place. L'admi-
nistrateur unique ou, le cas échéant, les administrateurs seront élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils
seront rééligibles.

29536

L

U X E M B O U R G

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société, la personne morale doit désigner un repré-

sentant permanent qui représentera la personne morale conformément à l'article 51bis de la loi luxembourgeoise en date
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée.

Le(s) administrateur(s) seront élus par l'assemblée générale. Les actionnaires de la Société détermineront également

le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec
ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'assemblée générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs

restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant
jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'assemblée générale devra
être rapidement être réunie par le commissaire aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

Art. 7. Le conseil d'administration ou, le cas échéant, l'administrateur unique est investi des pouvoirs les plus étendus

pour effectuer tous les actes d'administration ou de disposition dans l'intérêt de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915 telle que modifiée ou les présents

statuts à l'assemblée générale, tombent sous la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique,
selon les cas.

Art. 8. Le conseil d'administration doit désigner parmi ses membres un président; en cas d'absence du président, la

présidence de la réunion sera conférée à un administrateur présent. Le premier président sera exceptionnellement nom-
mé par l'assemblée générale extraordinaire de constitution.

Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original,

soit par téléfax, cable, télégramme ou télex, un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut
représenter un ou plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à la réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, visioconfé-

rence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du
conseil d'administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du conseil d'administration
peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion du conseil d'administration est retransmise en direct
et (iv) les membres du conseil d'administration peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion du conseil
d'administration par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer et/ou agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs

est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une

réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépon-
dérante.

Une résolution prise par écrit, approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une

décision prise à une réunion du conseil d'administration.

Les résolutions prises par l'administrateur unique auront la même autorité que les résolutions prises par le conseil

d'administration et seront constatées par des procès verbaux signés par l'administrateur unique.

Art. 9. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs

qui prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Le conseil ou l'administrateur unique, selon le cas, peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou

branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires
déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.

Art. 10. La Société sera engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux

administrateurs de la Société, ou (ii) selon le cas, la signature de l'Administrateur Unique, ou (iii) par la signature unique
de l'administrateur-délégué dans les limites de la gestion journalière ou (iv) par les signatures conjointes de toutes per-
sonnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil
d'Administration ou l'Administrateur Unique selon le cas, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

Surveillance

Art. 11. La surveillance de la Société est confiée à un ou plusieurs commissaires aux comptes, actionnaires ou non,

nommés pour une durée qui ne peut dépasser six années, rééligibles et toujours révocables.

Année sociale - Assemblée générale

Art. 12. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 13. Pour le cas où il n'y aurait qu'un seul actionnaire (l'associé unique), celui-ci exercera, au cours des assemblées

générales dûment tenues, tous les pouvoirs revenant à l'assemblée générale des actionnaires en vertu de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

29537

L

U X E M B O U R G

Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas

nécessaires, lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et lorsqu'ils déclarent avoir eu préalablement
connaissance de l'ordre du jour.

Chaque action donne droit à une voix.
Tout actionnaire de la Société peut participer à l'assemblée générale par conférence téléphonique, visioconférence ou

tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'assemblée
générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'assemblée générale peut entendre et
parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires
peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion de l'assemblée générale par un tel moyen de communication
équivaudra à une participation en personne à une telle réunion.

Art. 14. L'assemblée des actionnaires de la Société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la

Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
Le conseil d'administration ou l'administrateur unique selon les cas est autorisé à verser des acomptes sur dividendes

en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Art. 16. L'assemblée générale annuelle se tiendra de plein droit le cinquième jour du mois de mai à 11 heures, au siège

social ou à tout autre endroit de la commune du siège social à désigner par les convocations.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures trouveront leur

application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence à la date de constitution de la Société et se terminera le 31 décembre 2015.
2) L'Assemblée Générale annuelle se tiendra pour la première fois en 2016.

<i>Souscription

Les statuts de la société ayant été ainsi arrêtés, le comparant déclare souscrire le capital comme suit:

Mr. Agiannidis DIMITRIOS, prénommé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en espèces, de sorte que la somme de trente e

un mille euros (31,000.-EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi qu'il en a été justifié au notaire
instrumentaire.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la loi sur les sociétés

commerciales telle que modifiée et en constate expressément l'accomplissement.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille cinq cents euros (EUR 1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, s'est

ensuite constitué en assemblée générale extraordinaire. Après avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée,
il a pris les résolutions suivantes:

1) Le siège social est fixé à 11-13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
2) Est appelé aux fonctions d'administrateur unique:
Monsieur Agiannidis DIMITRIOS, entrepreneur, né le 26 avril 1941 à Neapoli (Grèce), et étant domicilié à 45, Kom-

ninon, 57013 Thessaloniki, Grèce;

3) Est appelé aux fonctions de commissaire aux comptes:

29538

L

U X E M B O U R G

European Trust Services (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 11-13

Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B33.065

4) Le mandat de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

annuelle de 2020.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare que sur la demande des comparants, le présent

acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la version
anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 19 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/1284. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015888/341.
(150018952) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Gardur Partners S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 157.361.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016494/9.
(150019543) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Platanthera S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 17, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 194.002.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the thirteenth day of the month of January.
Before Maître Jean SECKLER, notary, residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Mr. Francis VIEZ, consultant, born on 19 

th

 of April 1961 in Lille, France, with a permanent residence at 6, route de

la Barre, Le Ronseray, 27300 St Aubin Le Vertueux, France,

here represented by Mr. Max MAYER, employee, having his professional address at Junglinster, 3 route de Luxembourg,

by virtue of a power of attorney substituted to him. The said power signed “ne varietur” by the appearing partiy and the
officiating notary, shall remain annexed to the present deed.

Such appearing party in the capacity in which it acts, has requested the officiating notary to draw up the following

articles of incorporation (“the Articles”) of a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) which
such party declares to incorporate.

Art. 1. Name. A limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name “Platanthera S.à r.l.” (the

"Company") is hereby formed by the appearing party and all persons who will become shareholders thereafter. The
Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation.

Art. 2. Purpose. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and

any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange
or otherwise of stock, bonds, debentures, notes, certificates of deposits and any other securities or financial instruments
of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.

The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise

and may invest in any way and in any type of assets, the latter including the investment in any category whatsoever of real

29539

L

U X E M B O U R G

estate rights. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Lu-
xembourg or abroad.

The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures

or any kind of debt or equity securities.

The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the

issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
as it deems fit.

The Company may give guarantees and grant securities to any third party for its own obligations and undertakings as

well as for the obligations of any company or other enterprise in which the Company has an interest or which forms part
of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity as it deems fit and generally
for its own benefit or such entities' benefit.

In a general fashion it may grant assistance in any way to companies or other enterprises in which the Company has

an interest or which form part of the group of companies to which the Company belongs or any other company or entity
as it deems fit, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.

The object of the Company also includes the holding of all intellectual and industrial property rights such as trademarks,

patents and domain names.

The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments

for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or

indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 3. Duration. The Company is established for an unlimited period.

Art. 4. Registered Office. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-

bourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an
extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the articles of
association.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the manager or as the

case may be the board of managers.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the manager, or as the case may be the board of managers, should determine that extraordinary

political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances;
such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified
to any interested parties by the manager or as the case may be the board of managers.

Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-)

divided into one hundred (100) shares with a par value of one hundred and twenty-five Euro (EUR 125.-) each.

The capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner

required for amendment of these articles of association and the Company may proceed to the repurchase of its other
shares upon resolution of its shareholders.

Any available share premium shall be distributable.

Art. 6. Transfer of Shares. Shares are freely transferable among shareholders. Except if otherwise provided by law, the

share transfer to nonshareholders is subject to the consent of shareholders representing at least seventy five percent of
the Company's capital.

Art. 7. Management of the Company. The Company is managed by one or several managers who need not be share-

holders.

They are appointed and removed from office by a simple majority decision of the general meeting of shareholders,

which determines their powers and the term of their mandates. If no term is indicated the managers are appointed for
an undetermined period. The managers may be re-elected but also their appointment may be revoked with or without
cause (ad nutum) at any time.

In the case of more than one manager, the managers constitute a board of managers.
Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference call or by other similar means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation in, or the holding of, a meeting by these
means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person.

29540

L

U X E M B O U R G

Managers may be represented at meetings of the board by another manager without limitation as to the number of

proxies which a manager may accept and vote.

Written notice of any meeting of the board of managers must be given to the managers twenty four (24) hours at least

in advance of the date scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives
of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each manager in
writing, by cable, telegram, telex, e-mail or facsimile, or any other similar means of communication. A special convening
notice will not be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted
by the board of managers.

The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two different classes, being class A managers

and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant meeting
and the managers be identified with respect to the class they belong.

Decisions of the board of managers are validly taken by the approval of the majority of the managers of the Company

(including by way of representation). In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

The board of managers may also, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means

when expressing its approval in writing, by e-mail pdf or facsimile or any other similar means of communication. The
entirety will form the circular documents duly executed giving evidence of the resolution. Managers' resolutions and
meeting minutes, including circular resolutions, may be conclusively signed and/or certified or an extract thereof may be
issued under the individual signature of any manager.

The Company will be bound by the sole signature in the case of a sole manager, and in the case of a board of managers

by the joint signature of any two of the managers, provided however that in the event the general meeting of shareholders
has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) the Company will be validly
bound by the sole signature of one class B manager in all circumstances and by the sole signature of one class A manager
for the following acts and operations:

- opening and closing of bank accounts,
- securing legal and accounting advice,
- dealing with general financial and tax returns, and
- general day-to-day administrative tasks.
In any event the Company will be validly bound by the sole signature of any person or persons to whom such signatory

powers shall have been delegated by the sole manager (if there is only one) or as the case may be the board of managers
by any two of the managers provided that, in the event of classes of managers, signatory powers shall have been delegated
by the signature of one class B manager in all circumstances or, with respect to the signatory powers granted to the class
A manager under this article 7, by the sole signature of the class A manager.

Art. 8. Liability Managers. The Manager(s) are not held personally liable for the indebtedness of the Company. As

agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties.

Subject to the exceptions and limitations listed below, every person who is, or has been, a manager or officer of the

Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all
expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding which he becomes
involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such manager or officer and against amounts paid
or incurred by him in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims,
actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability"
and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other
liabilities.

No indemnification shall be provided to any manager or officer:
(i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of willful misfeasance, bad faith, gross negligence

or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office;

(ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in

the interest of the Company; or

(iii) In the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by

the board of managers.

The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any manager

or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such manager or officer
and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall
affect any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by
contract or otherwise under law.

29541

L

U X E M B O U R G

Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding

of the character described in this Article shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt
of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he
is not entitled to indemnification under this Article.

Art. 9. Shareholder voting rights. Each shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes

equal to the number of shares he owns and may validly act at any meeting of shareholders through a special proxy.

Art. 10. Shareholder Meetings. Decisions by shareholders are passed in such form and at such majority(ies) as pre-

scribed by Luxembourg Company law in writing (to the extent permitted by law) or at meetings. Any regularly constituted
meeting of shareholders of the Company or any valid written resolution (as the case may be) shall represent the entire
body of shareholders of the Company.

Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to shareholders to their address appearing

in the register of shareholders held by the Company at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If the entire
share capital of the Company is represented at a meeting the meeting may be held without prior notice.

In the case of written resolutions, the text of such resolutions shall be sent to the shareholders at their addresses

inscribed in the register of shareholders held by the Company. The resolutions shall become effective upon the approval
of the majority as provided for by law for collective decisions (or subject to the satisfaction of the majority requirements,
on the date set out therein). Unanimous written resolution may be passed at any time without prior notice.

Except as otherwise provided for by law, (i) decisions of the general meeting shall be validly adopted if approved by

shareholders representing more than half of the corporate capital. If such majority is not reached at the first meeting or
first written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions
shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the portion of capital represented. (ii) However, decisions
concerning the amendment of the Articles of Incorporation are taken by (x) a majority of the shareholders (y) representing
at least three quarters of the issued share capital and (iii) decisions to change of nationality of the Company are to be
taken by Shareholders representing one hundred percent (100%) of the issued share capital.

In case and for as long as the company has more than 25 shareholders, an annual general meeting shall be held on the

first Monday of the month of May each year at 9:30 a.m. If such day is not a business day, the meeting shall be held on
the immediately following business day.

Art. 11. Accounting Year. The accounting year begins on 1 

st

 January of each year and ends on 31 

st

 December of the

same year.

Art. 12. Financial Statements. Every year as of the accounting year's end, the annual accounts are drawn up by the

manager or, as the case may be, the board of managers.

The financial statements are at the disposal of the shareholders at the registered office of the Company.

Art. 13. Distributions. Out of the net profit five percent (5%) shall be placed into a legal reserve account. This deduction

ceases to be compulsory when such reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the manager,

or as the case may be the board of managers, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood
that the amount to be distributed may not exceed profits realized since the end of the last accounting year increased by
profits carried forward and distributable reserves and premium but decreased by losses carried forward and sums to be
allocated to a reserve to be established by law.

The balance may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.
The share premium account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders.

The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal
reserve account.

Art. 14. Dissolution. In case the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or several liquidators

who may be but do not need to be shareholders and who are appointed by the general meeting of shareholders who will
specify their powers and remunerations.

Art. 15. Sole Shareholder. If, and as long as one shareholder holds all the shares of the Company, the Company shall

exist as a single shareholder company, pursuant to article 179 (2) of the law of 10 

th

 August 1915 on commercial com-

panies; in this case, articles 200-1 and 200-2, among others, of the same law are applicable.

Art. 16. Applicable law. For anything not dealt with in the present articles of association, the shareholders refer to the

relevant legislation.

<i>Transitory Provision

The first accounting year which shall begin on the day of incorporation and end on 31 

st

 December 2015.

29542

L

U X E M B O U R G

<i>Subscription and Payment

The articles of association of the Company having thus been drawn up by the appearing Mr. Francis VIEZ, premamed,

who subscribed to all the issued shares and fully them paid-up in cash.

Evidence of the payment of the subscription price of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) has been given

to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its formation are estimated at approximately one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

<i>Extraordinary decision of the meeting of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the above-named person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is fixed at 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg;
2.- Is appointed as sole manager for an undetermined duration:
- Dr. Olivier Hance, Lawyer born on 02 

nd

 of September 1967 in Nivelles, Belgium, with professional address at 17

boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, G-D de Luxembourg,

3.- The Company will be bound by the sole signature of one of the sole manager for all acts within the bounds laid

down by its purpose or by the Law.

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

parties represented as stated hereabove, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French
version; on request of the same parties and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Junglister, on the day named at the beginning of

this document.

The document having been read to the proxy-holder of the appearing parties, known to the notary by name, first

name, civil status and residence, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le treizième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

M. Francis VIEZ, Consultant né le 19 avril 1961 à Lille, France, ayant son domicile au 6 route de la Barre Le Ronceray,

27300 St Aubin, France,

ici représenté par Monsieur Max MAYER, employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3 route de Luxem-

bourg, en vertu d’une procuration lui substituée, laquelle après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la
comparante et le notaire instrumentant restera annexée aux présentes.

La partie comparante, ès qualités, a demandé au notaire instrumentant d'arrêter les statuts d'une société à responsa-

bilité limitée qui est constituée par la présente comme suit:

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est formé par la comparante et toutes personnes qui deviendront par la suite associés,

une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «Platanthera S.à r.l.» (la «Société»). La Société sera régie par
les présents statuts et les dispositions légales afférentes.

Art. 2. Objet.  L'objet  de  la  Société  est  l’acquisition,  la  détention,  la  gérance  et  la  disposition  de  participations  et

d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autre entités,
entreprises ou investissements, l’acquisition par l’achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que la cession
par la vente, l’échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes, certificats de dépôt et autres
valeurs mobilières ou instruments financiers de toute espèce, et la détention, l’administration, le développement et la
gestion de son portefeuille.

La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise

et peut investir de quelque manière que ce soit dans tous types d'avoirs, en ce compris tous types de droits portant sur
des actifs immobiliers. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son
activité par l’intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l’étranger.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l’émission d'obligations, de

notes et de certificats de créance ou toute sorte de valeur mobilière.

La Société peut prêter des fonds, y compris sans limitation ceux résultant de tous emprunts de la Société ou de

l’émission de tout titres de toute sorte, à ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société ou entité qu'elle juge ap-
propriée.

29543

L

U X E M B O U R G

La Société peut donner des garanties et accorder des sûretés à tout tiers pour ses propres obligations et engagements

ainsi que pour les obligations de toute société ou autre entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie
du groupe de sociétés auquel la Société appartient ou toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée et généralement
pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de cette entité.

D'une manière générale elle peut prêter assistance à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt

ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société ou toute autre société ou entreprise que la Société
juge appropriée, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans
l’accomplissement et le développement de ses objets.

L’objet de la société couvre également la détention de tous droits intellectuels et industriels, tels que marques, brevets

et noms de domaine

La Société peut généralement employer toute technique et tout instrument en relation avec un quelconque de ses

investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à
protéger la Société contre les risques de crédit, de taux de change, taux d'intérêt et tout autre risque.

Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement

ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter la réalisation de son objet.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. Siège Social. Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés délibérant dans les conditions prévues en cas de modification des statuts.

Le siège social peut être transféré à l’intérieur de la municipalité par décision du gérant ou, le cas échéant, du conseil

de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales situés au Luxembourg ou à l’étranger.
Au cas où le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance, estimerait que des événements extraordinaires d'ordre

politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la
communication aisée de ce siège avec l’étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être
déclaré transféré provisoirement à l’étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures
temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait
une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le gérant
ou le cas échéant le conseil de gérance.

Art. 5. Capital Social. Le capital social émis de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) divisé

en cent (100) parts sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR 125,-) chacune.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit par une résolution des associés adoptée de la manière requise

pour la modification des présents Statuts et la Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales en vertu
d'une décision de ses associés.

Toute prime d'émission disponible sera distribuable.

Art. 6. Transfert de parts sociales. Les parts sociales sont librement transférables entre associés. Sauf dispositions

contraires de la loi, les parts sociales ne peuvent être cédées à des non associés que moyennant l’agrément donné par
au moins soixante-quinze pourcent du capital social de la Société.

Art. 7. Gérance de la Société. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.
Ils sont nommés et révoqués par l’assemblée générale des associés, qui détermine leurs pouvoirs et la durée de leurs

fonctions, et qui statue à la majorité simple. Si aucun terme n'est indiqué, les gérants sont nommés pour une période
indéterminée. Les gérants sont rééligibles mais leur nomination est également révocable avec ou sans motifs (ad nutum)
et à tout moment.

Au cas où il y aurait plus d'un gérant, les gérants constituent un conseil de gérance.
Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique ou d'autres moyens de

communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre les unes les autres
et de communiquer les unes avec les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement sous forme de confé-
rence téléphonique. La participation à ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation en personne
à une telle réunion ou à une réunion tenue en personne. Les gérants peuvent être représentés aux réunions du conseil
de gérance par un autre gérant, sans limitation quant au nombre de procurations qu'un gérant peut accepter et voter.

Un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au moins vingt-quatre (24) heures

avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront
mentionnés dans l’avis de convocation. Il pourra être passé outre à cette convocation à la suite de l’assentiment de chaque
gérant par écrit, par câble, télégramme, télex, e-mail ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Une
convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil se tenant à une heure et un endroit déterminés
dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

29544

L

U X E M B O U R G

L'assemblée générale des associés peut décider de nommer des gérants de deux classes différentes, à savoir les gérants

de classe A et les gérants de classe B. Une telle classification de gérants doit être dûment enregistrée dans le procès-
verbal de la réunion concernée et les gérants doivent être identifiés en fonction de la classe à laquelle ils appartiennent.

Les décisions du conseil de gérance sont valablement prises avec l’accord de la majorité des gérants de la Société (y

compris par voie de représentation). Dans le cas toutefois où l’assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), toutes les résolutions du conseil de gérance
ne pourront être valablement prises que si elles sont approuvées par la majorité des gérants comprenant au moins un
gérant de classe A et un gérant de classe B (qui peuvent être représentés).

Le conseil de gérance peut, à l’unanimité, prendre des résolutions sur un ou plusieurs documents similaires par voie

circulaire en exprimant son approbation par écrit, par e-mail pdf ou télécopie ou tout autre moyen de communication
similaire. L'ensemble constituera les documents circulaires dûment exécutés faisant foi de la résolution. Les résolutions
des gérants et les procès-verbaux des réunions, y compris celles prises par voie circulaire, seront signées et/ou certifiées
comme faisant foi et un extrait pourra être émis sous la signature individuelle de chaque gérant.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique en cas d'un seul gérant, et dans le cas d'un conseil de gérance,

par la signature conjointe de deux gérants, étant entendu que si l’assemblée générale des associés a nommé différentes
classes de gérants (à savoir les gérants de classe A et les gérants de classe B), la Société ne sera valablement engagée que
par la signature individuelle d'un gérant de classe B en toutes circonstances et par la signature individuelle d'un gérant de
classe A pour les actes et opérations suivants:

- ouverture et fermeture de comptes bancaires;
- conseil juridique sécurisant ou comptable;
- traitement de déclarations financières générales et fiscales;
- attributions administratives générales quotidiennes.
Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la seule signature de toute(s) personne(s) à qui de tels

pouvoirs de signature auront été délégués par le gérant unique (s'il n'y a qu'un seul gérant) ou le cas échéant par le conseil
de gérance par deux gérants, étant entendu que s'il existe des classes de gérants, des pouvoirs de signature seront délégués
par un gérant de classe B en toutes circonstances ou, concernant les pouvoirs de signature accordés au gérant de classe
A conformément à cet article 7, par la signature individuelle du gérant de classe A.

Art. 8. Responsabilité des gérants. Les Gérant(s) ne sont pas personnellement responsables des dettes de la Société.

En tant que représentants de la Société, ils sont responsables de l’exécution de leurs obligations.

Sous réserve des exceptions et limitations énumérées ci-dessous, toute personne qui est, ou qui a été gérant, dirigeant

ou responsable représentant de la Société, sera, dans la mesure la plus large permise par la loi, indemnisée par la Société
pour toute responsabilité encourue et toutes dépenses raisonnables contractées ou payées par elle en rapport avec toute
demande, action, plainte ou procédure dans laquelle elle est impliquée à raison de son mandat présent ou passé de gérant,
dirigeant ou responsable représentant et pour les sommes payées ou contractées par elle dans le cadre de leur règlement.
Les mots «demande», «action», «plainte» ou «procédure» s'appliqueront à toutes les demandes, actions, plaintes ou
procédures (civiles ou criminelles, y compris le cas échéant toute procédure d'appel) actuelles ou prévisibles et les mots
«responsabilité» et «dépenses» devront comprendre, sans limitation, les honoraires d'avocats, frais, jugements et mon-
tants payés en règlement et autres responsabilités.

Aucune indemnité ne sera versée à tout gérant, dirigeant ou responsable représentant:
(i) En cas de mise en cause de sa responsabilité vis-à-vis de la Société ou de ses associés en raison d'un abus de pouvoir,

de mauvaise foi, de négligence grave ou d'imprudence dans l’accomplissement des devoirs découlant de la conduite de sa
fonction;

(ii) Pour toute affaire dans laquelle il serait finalement condamné pour avoir agi de mauvaise foi et non dans l’intérêt

de la Société; ou

(iii) Dans le cas d'un compromis ou d'une transaction, à moins que le compromis ou la transaction en question n'ait

été approuvé par une juridiction compétente ou par le conseil de gérance.

Le droit à indemnisation prévu par les présentes, n'affectera aucun autre droit dont un gérant, dirigeant ou représentant

peut bénéficier actuellement ou ultérieurement, il subsistera à l’égard de toute personne ayant cessé d'être gérant, diri-
geant ou représentant et bénéficiera aux héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de telle personne. Les
dispositions  du  présent  article  n'affecteront  aucun  droit  à  indemnisation  dont  pourrait  bénéficier  le  personnel  de  la
Société, y compris les gérants, dirigeants ou représentants en vertu d'un contrat ou autrement en vertu de la loi.

Les dépenses en rapport avec la préparation et la représentation d'une défense à l’encontre de toute demande, action,

plainte ou procédure de nature telle que décrite dans le présent article, seront avancées par la Société avant toute décision
sur la question de savoir qui supportera ces dépenses, moyennant l’engagement par ou pour le compte du représentant
ou du dirigeant de rembourser ce montant s'il est finalement déterminé qu'il n'a pas droit à une indemnisation confor-
mément au présent article.

29545

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Droits de vote des associés. Chaque associé peut participer aux décisions collectives. Il a un nombre de voix

égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées des associés par
un porteur de procuration spéciale.

Art. 10. Assemblées des associés. Les décisions des associés sont prises dans les formes et aux majorités prévues par

la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales, par écrit (dans la mesure où c'est permis par la loi) ou lors d'as-
semblées.  Toute  assemblée  des  associés  de  la  Société  valablement  constituée  ou  toute  résolution  circulaire  (le  cas
échéant) représentera l’intégralité des associés de la Société.

Les assemblées seront convoquées par une convocation adressée par lettre recommandée aux associés à leur adresse

contenue dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date d'une telle assemblée. Si
l’intégralité du capital social est représentée à une assemblée l’assemblée peut être tenue sans convocation préalable.

Dans le cas de résolutions circulaires, le texte de ces résolutions sera envoyé aux associés à leurs adresses inscrites

dans le registre des associés tenu par la Société. Les résolutions prennent effet à partir de l’approbation par la majorité
comme prévu par la loi concernant les décisions collectives (ou sujet à la satisfaction des réquisitions de majorité, à la
date y précisée). Une résolution écrite unanime peut être passée à tout moment sans convocation préalable.

A moins que ce soit prévu autrement par la loi, (i) les décisions de l’assemblée générale seront valablement adoptées

si elles sont approuvées par les associés représentant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte
à la première assemblée ou lors de la première résolution écrite, les associés seront convoqués ou consultés une deuxième
fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des voix des votants, sans considérer la
portion du capital représenté. (ii) Cependant, des décisions concernant des modifications des Statuts seront prises par
(x) une majorité des associés (y) représentant au moins trois quarts du capital social émis et (iii) les décisions concernant
le changement de nationalité de la Société seront prises par les associés représentant cent pour cent (100%) du capital
social émis.

A partir du moment où la société compte plus de 25 associés, la tenue d’une assemblée générale annuelle des associés

est obligatoire. La date de l’assemblée générale est fixée au premier lundi du mois de mai de chaque année à 9h30. Si ce
jour n’est pas ouvrable l’assemblée sera tenue le jour ouvrable le plus proche.

Art. 11. Année Sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de

l’année suivante, sauf pour la première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31
décembre 2015.

Art. 12. Comptes annuels. Chaque année, le gérant, ou le cas échéant le conseil de gérance établit les comptes annuels.
Les comptes annuels sont disponibles au siège social pour tout associé de la Société.

Art. 13. Distributions. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'une réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire si cette réserve atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes intérimaires sur base d'un état comptable préparé

par le gérant ou le cas échéant le conseil de gérance, duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour
distribution, étant entendu que les fonds à distribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le
dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves et prime distribuables mais diminué des
pertes reportées et des sommes à allouer à une réserve constituée en vertu de la loi.

Le solde peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.
Le compte de prime d'émission peut être distribué aux associés par décision prise en assemblée générale des associés.

L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant de la prime d'émission à la réserve légale.

Art. 14. Dissolution. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non et qui sont nommés par l’assemblée générale des associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 15. Associé Unique. Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales de la Société entre

ses seules mains, la Société est une société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales; dans ce cas, les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d'application.

Art. 16. Loi Applicable. Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions

légales en vigueur.

<i>Mesure transitoire

La première année sociale qui commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et Libération

Les statuts de la Société ayant été ainsi établis par la partie comparante M. Francis VIEZ, préqualifié et représenté

comme ci-avant, déclare souscrire à toutes les parts sociales émises.

Preuve du paiement du prix de souscription de douze mille cinq cent euros (EUR 12.500) a été donnée au notaire

instrumentant.

29546

L

U X E M B O U R G

<i>Dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations, charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société du fait de sa

formation sont évaluées à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

<i>Décision extraordinaire de l’assemblée de l’associé unique

Et aussitôt, l’associé unique a pris les résolutions suivantes:
1.- Le siège social de la Société est fixé au 17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.
2.- Est nommé gérant unique pour une durée indéterminée:
- Me Olivier HANCE. Avocat, né le 02 septembre 1967 à Nivelles, Belgique, avec l’adresse professionnelle au 17

Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, G.-D de Luxembourg

3.- La Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique pour tous les actes dans la limite de l’objet

social et de la Loi.

Le notaire instrumentant qui comprend et parle l’anglais constate par les présentes qu'à la requête des parties com-

parantes, représentées comme dit ci-avant, les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la
requête des mêmes parties et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, es qualités qu'il agit, connu du

notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 janvier 2015. Relation GAC/2015/483. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015016072/437.
(150018432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Castik Capital, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 186.205.

In the year two thousand and fifteen, on the twenty-first day of January.
Before us, Maître Edouard Delosch notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Michael Robert Phillips, born on 1 February 1962 in St. Louis, USA, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

here represented by Julia Szafranska, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in Luxembourg,

on 19 January 2015, and

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”), representing the entire share capital of Castik

Capital, S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-
porated and governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Boulevard de la
Foire 1, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of five hundred and twelve thousand
five  hundred  euro  (EUR  512,500.-),  registered  with  the  Luxembourg  Company  and  Trade  Register  under  number
B186205, incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, on 17 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1609 on 21 June
2014. The articles of association were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary dated 16
October 2014 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°3501 on 21 November 2014. The
articles of association have not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Amendment of article 13 of the articles of association that shall now be read as follows:

“ Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

29547

L

U X E M B O U R G

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.”

2. Amendment of article 16.5 of the articles of association that shall now be read as follows:
“The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.”

3. Amendment of article 18 of the articles of association that shall now be read as follows:

“ Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.”

4. Acknowledgment of the resignation of Mrs. Catherine Koch, as manager of the Company and granting of discharge;
5. Confirmation of the mandate of Mr. Michael Phillips and Mr. Geoffrey Henry, as managers;
6. Appointment of Mr. Dan Arendt, as manager of the Company;
7. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the Sole Shareholder unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First Resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 13 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.”

<i>Second Resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 16.5 of the articles of association that shall now be read as follows:
“The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or repre-

sented at a meeting of the board of managers.”

<i>Third Resolution

The Sole Shareholder decides to amend article 18 of the articles of association that shall now be read as follows:

“ Art. 18. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.”

<i>Fourth Resolution

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation of Mrs. Catherine Koch, as manager of the Company,

with effect as from 15 February 2015 and decides to grant her discharge for the due performance of her duties which
discharge will have to be confirmed at the next annual general meeting approving the next Company’s annual accounts.

<i>Fifth Resolution

The Sole Shareholder resolves to confirm the mandate of:
- Mr. Michael Phillips, born on 1 February 1962 in St. Louis, USA, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite
period of time.

- Mr. Geoffrey Henry, born on 5 May 1972, in Chênée, Belgium, professionally residing at Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period of time.

29548

L

U X E M B O U R G

<i>Sixth Resolution

The Sole Shareholder resolves to appoint:
- Mr. Dan Arendt, born on 15 May 1961, in Luxembourg, professionally residing at 42, op Fankenacker, L-3265 Bet-

tembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as manager of the Company with immediate effect and for an indefinite period
of time.

As a result of the above resolutions, until 15 February 2015 the board of managers of the Company is composed as

follows:

1. Mrs. Catherine Koch, aforementioned, as manager of the Company
2. Mr. Michael Phillips, aforementioned, as manager of the Company;
3. Mr. Geoffrey Henry, aforementioned, as manager of the Company;
4. Mr. Dan Arendt, aforementioned, as manager of the Company;
From 15 February 2015 the board of managers of the Company is composed as follows:
1. Mr. Michael Phillips, aforementioned, as manager of the Company;
2. Mr. Geoffrey Henry, aforementioned, as manager of the Company;
3. Mr. Dan Arendt, aforementioned, as manager of the Company;

<i>Seventh Resolution

The Sole Shareholder resolves that each manager, Dr. Christoph Diesel, Ms. Julia Szafranska and any lawyer or em-

ployee of Arendt &amp; Medernach S.A., each acting individually, with full power of substitution, be and hereby is authorised,
empowered and directed, in the name of and on behalf of the Company, to execute and deliver or cause to be executed
and delivered any and all certificates, amendments, reports, applications, notices, letters or other documents and to do
or cause to be done any and all such other acts and things as, in the opinion of any such officer, may be necessary,
appropriate or desirable in order to enable the Company fully and promptly to carry out the purpose and intent of the
foregoing resolutions, and any such action taken or any certificate, report, application, notice, letter or other document
executed and delivered by them or any of them in connection with any such action shall be conclusive evidence of their
or his authority to take, execute and deliver the same, to amend any register of the Company, to proceed with the
completion of any required subsequent formality with the Trade and Companies’ Register of Luxembourg, as well as with
any required publication with the Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg Official Gazette).

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand four hundred euro (EUR 1,400,-).

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am einundzwanzigsten Januar.
Vor uns, Maître Edouard Delosch, Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Michael Robert Phillips, geboren am 01. Februar 1962 in St. Louis, USA, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg

hier vertreten durch Julia Szafranksa mit Geschäftsadresse in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht ausgestellt in Lu-

xemburg, am 19. Januar 2015.

Diese Vollmachten, unterzeichnet mit ne variatur durch die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien und den Notar,

verbleiben als Anhang bei dieser Urkunde um zur selben Zeit bei der Registrierungsbehörde eingereicht zu werden.

Die  erschienene  Partei  ist  der  alleinige  Gesellschafter  (der  „Alleingesellschafter“)  der  Castik  Capital  S.à  r.l.,  einer

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilitée limitée) gegründet und bestehend nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxembourg mit einem Stammka-
pital  von  fünfhundertzwölftausendfünfhundert  Euro  (EUR  512.500,-)  und  eingetragen  im  Luxemburger  Handels-  und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 186205, gegründet entsprechend einer Urkunde des Maître Martine Schaeffer,
Notar mit Sitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, am 17. März 2014, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des
Sociétés  et  Associations  am  21.  Juni  2014  unter  der  Nummer  1609  (die  “Gesellschaft”).  Die  Satzung  wurde  zuletzt

29549

L

U X E M B O U R G

entsprechend einer notariellen Urkunde des unterzeichnenden Notars am 21. November 2014 geändert, diese veröf-
fentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 3501 am 21. November 2014. Die
Satzung wurde seitdem nicht mehr geändert.

Die erschienene Partei, welche das gesamte Stammkapital der Gesellschaft vertritt, erklärt, unter Verzicht auf sämtliche

Benachrichtigungserfordernisse, die Gesellschafterversammlung ist ordnungsgemäß zusammengetreten, und kann wirk-
sam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:

<i>Tagesordnung

1. Änderung von Artikel 13 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:

„ Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.“

2. Änderung von Artikel 16.5 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:
„Der  Geschäftsführungsrat kann  nur  dann  wirksam handeln  und abstimmen, wenn zumindest  die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.“

3. Änderung von Artikel 18 der Satzung, welcher nun wie folgt lauten soll:

„ Art. 18. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Un-

terschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die
gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat über-
tragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.“

4. Anerkennung des Rücktritts von Frau Catherine Koch als Geschäftsführerin der Gesellschaft und Erteilung der

Entlastung;

5. Bestätigung der Mandate als Geschäftsführer für Herrn Michael Phillips und Herrn Geoffrey Henry;
6. Bestellung von Herrn Dan Arendt als Geschäftsführer der Gesellschaft;
7. Verschiedenes
Nach  umfassender  Berücksichtigung  aller  Tagesordnungspunkte  beschließt  der  Alleingesellschafter  einstimmig  und

fordert den unterzeichnenden Notar auf, folgende Beschlüsse zu erlassen:

<i>Erster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er ab nun wie folgt lautet:

„ Art. 13. Befugnisse des Einzelgeschäfsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Geschäftsführerrates.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Geschäftsführungsrat.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „Einzelgeschäfts-

führer“ nicht ausdrücklich verwendet wird ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Geschäftsführungsrat“ als Verweis
auf den Einzelgeschäftsführer auszulegen.

13.3 Der Geschäftsführungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.“

<i>Zweiter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 16.5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er ab nun wie folgt

lautet:

„Der  Geschäftsführungsrat kann  nur  dann wirksam  handeln  und abstimmen,  wenn  zumindest die  Mehrheit  seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.”

<i>Dritter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt Artikel 18 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass er ab nun wie folgt lautet:

„ Art. 18. Geschäfte mit Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch (i) die Un-

terschrift des Einzelgeschäftsführers oder, für den Fall, dass die Gesellschaft mehrere Geschäftsführer hat, durch die

29550

L

U X E M B O U R G

gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, oder durch (ii) die gemeinsame Unterschrift oder die
alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Geschäftsführungsrat über-
tragen worden ist, im Rahmen dieser Befugnis wirksam verpflichtet.“

<i>Vierter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt den Rücktritt von Frau Catherine Koch als Geschäftsführerin der Gesellschaft zum

15. Februar 2015 anzuerkennen und beschließt ihr die Entlastung für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Pflichten zu
erteilen, was auf der nächsten ordentlichen Generalversammlung, die über den nächsten Jahresabschluss der Gesellschaft
entscheidet, bestätigt werden muss.

<i>Fünfter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt die Mandate folgender Personen zu bestätigen:
- Herr Michael Phillips, geboren am 01. Februar 1962 in St. Louis, USA, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte
Zeit.

- Herr Geoffrey Henry, geboren am 05. Mai 1972 in Chênée, Belgien, geschäftsansässig in Boulevard de la Foire 1,

L-1528 Luxembourg, Großherzogtum Luxembourg, als Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte
Zeit.

<i>Sechster Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt zu ernennen:
- Herr Dan Arendt, geboren am 15 Mai 1961 in Luxembourg, geschäftsansässig in 42, op Frankenacker, L-3265 Bet-

tembourg,  Großherzogtum  Luxembourg  als  Geschäftsführer  der  Gesellschaft  mit  sofortiger  Wirkung  und  auf  unbe-
stimmte Zeit.

Als Ergebnis der obigen Beschlüsse, setzt sich der Geschäftsführerrat der Gesellschaft zum 15. Februar 2015 folgen-

dermaßen zusammen:

1. Frau Catherine Koch, vorbenannt, als Geschäftsführerin der Gesellschaft;
2. Herr Michael Phillips, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
3. Herr Geoffrey Henry, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
4. Herr Dan Arendt, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft.
Ab dem 15. Februar 2015 setzt sich der Geschäftsführerrat folgendermaßen zusammen:
1. Herr Michael Phillips, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
2. Herr Geoffrey Henry, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft;
3. Herr Dan Arendt, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft.

<i>Siebter Beschluss

Der Alleingesellschafter beschließt, dass jeder Geschäftsführer, Dr. Christoph Diesel, Frau Julia Szafranska und jeder

andere Rechtsanwalt oder Angestellte von Arendt &amp; Medernach S.A., jeweils individuell und mit voller Vertretungsmacht
handelnd, hiermit ermächtigt und angewiesen wird im Namen der Gesellschaft und Interesse der Gesellschaft zu handeln,
jegliche Zertifikate, Änderungen, Berichte, Anträge, Mitteilungen, Briefe und andere Dokumente auszuführen, zu über-
geben oder zu veranlassen ausgeführt zu werden, als auch jegliche Handlungen oder Dinge vorzunehmen, die nach Ansicht
eines solchen Vertreters notwendig, angemessen oder wünschenswert sind um die Gesellschaft voll und schnellstmöglich
zu befähigen, Ziel und Zweck dieser Beschlüsse zu erreichen. Darüber hinaus soll jede von ihnen damit in Verbindung
stehende, vorgenommene Maßnahme, als auch alle von ihnen ausgeführten und gelieferten Zertifikate, Berichte, Anträge,
Notizen, Briefe oder andere Dokumente als beweiskräftiger Nachweis ihrer Bevollmächtigung dienen, diese vornehmen,
auszuführen oder liefern zu können um den Registereintrag der Gesellschaft zu ändern, sich anschließende und dafür
notwendige Formalitäten mit dem Handelsund Gesellschaftsregister von Luxemburg, als auch jede andere für die Fertig-
stellung notwendige Veröffentlichung im Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations (Luxembourg Official Gazette)
fortzuführen.

<i>Kosten und Ausgaben

Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass

dieser Beschlüsse entstehen, beläuft sich auf ungefähr eintausend vierhundert Euro (EUR 1.400,-).

Diese notarielle Urkunde wurde in Luxemburg an dem am Anfang dieses Dokuments genannten Tag aufgenommen.
Der beurkundende Notar, der Englisch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die Urkunde auf Anfrage der er-

schienenen Parteien auf Englisch geschrieben ist, gefolgt von einer deutschen Übersetzung und auf Anfrage derselben
erschienenen Parteien im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text die englische Fassung
vorrangig sein soll.

29551

L

U X E M B O U R G

Nachdem dieses Dokument der Bevollmächtigten der erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vorn-

amen und Wohnort bekannt ist, vorgelesen worden ist, unterzeichnete die Bevollmächtigte der erschienenen Parteien
dieses Dokument zusammen mit dem Notar.

Gezeichnet: J. SZAFRANSKA, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 23 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1345. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 28 Januar 2015.

Référence de publication: 2015016387/254.
(150019503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Public Safety Luxembourg, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 117.722.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of December
Before us, Maître Martine Schaeffer, notary, residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

PSE Newco II Limited, a private limited company registered under 07248807, with registered office at Lancaster House

16, Moorfield Business Park, Yeadon, Leeds, West Yorkshire, LS19 7YA, United Kingdom,

here represented by Mr. Gianpiero Saddi, notary clerc, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 26 November, 2014, which power of attorney, after having been signed “ne variatur” by the proxy holder
representing the new shareholder of the Company and by the notary will remain attached to the present deed to be filed
with it with the registration authorities,

acting as sole shareholder of PUBLIC SAFETY LUXEMBOURG, S.à r.l., a private limited company (société à respon-

sabilité limitée), having its registered office in L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register (RCSL) under the number B 117.722 (the "Company"), incorporated by a deed of the notary
Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem (Grand Duchy of Luxembourg), on July 6, 2006, published in the
Official Gazette Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1725 on September 15, 2006, and amended
for the last time by a deed of the undersigned notary on December 31, 2012, published in the Official Gazette Memorial
C, Recueil des Sociétés et Associations number 588 on March 11, 2013.

The sole shareholder then declares and requests the notary to record the following:
That the agenda of the present meeting is as follows:
1. Reduction of the corporate capital by an amount of EUR 87,182,900 (eighty-seven million one hundred eighty-two

thousand nine hundred Euro) so as to bring it from its present amount of EUR 87,195,400 (eighty-seven million one
hundred ninety-five thousand four hundred Euro) represented by 3,487,816 (three million four hundred eighty-seven
thousand eight hundred sixteen) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each to EUR 12,500 (twelve
thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro)
each by the reimbursement and cancellation of 3,487,316 (three million four hundred eighty-seven thousand three hun-
dred sixteen) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each

2. Subsequent amendment of article 6 of the Articles of Association of the Company as follows:
"The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each."

3. Mandate granted to each manager and the domiciliation agent, to perform all legal action in relation to the agenda

of the meeting, and in particular, to amend and sign the shareholder's register

4. Miscellaneous
After deliberation the sole shareholder took the following decisions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to reduce the corporate capital of the Company by an amount of EUR 87,182,900

(eighty-seven million one hundred eighty-two thousand nine hundred Euro) so as to bring it from its present amount of
EUR 87,195,400 (eighty-seven million one hundred ninety-five thousand four hundred Euro) represented by 3,487,816
(three million four hundred eighty-seven thousand eight hundred sixteen) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five
Euro) each to EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euro) represented by 500 (five hundred) shares with a par value
of EUR 25 (twenty-five Euro) each by the reimbursement and cancellation of 3,487,316 (three million four hundred eighty-
seven thousand three hundred sixteen) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each.

29552

L

U X E M B O U R G

The amount of EUR 87,182,900 (eighty-seven million one hundred eighty-two thousand nine hundred Euro) shall not

be reimbursed immediately but be allocated to the reserves available for distribution.

Pursuant to the present resolution, the 500 (five hundred) shares with a par value of EUR 25 (twenty-five Euro) each,

representing the entire share capital of the Company, will be held by the sole shareholder PSE Newco II Limited.

<i>Second resolution

The shareholders meeting resolves to subsequently amend article 6 of the Articles of Association of the Company as

follows:

"The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) divided into five hundred

(500) shares with a par value of twenty-five Euro (EUR 25) each."

<i>Third resolution

The shareholders' meeting resolves to grant mandate to any manager and any employee of the domiciliation agent to

take any legal action in relation to the agenda, and in particular, to amend and sign the shareholders' register.

<i>Costs, Evaluation

The expenses, costs, fees and outgoings of any kind whatsoever borne by the company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately two thousand three hundred Euros (EUR 2.300.-).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith, that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and
the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
And after reading and giving the interpretation to the proxy holders of the persons appearing, and the members of

the committee, they signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le douze décembre,
Par-devant Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

PSE Newco II Limited, une société privée à responsabilité limitée, enregistrée sous le numéro 07248807, ayant son

siège à Lancaster House 16, Moorfield Business Park, Yeadon, Leeds, West Yorkshire, LS19 7YA, Royaume-Uni,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, clerc du notaire, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu

d’une procuration donnée sous seing privé du 26 novembre 2014, laquelle procuration après avoir été signée «ne varietur»
par le mandataire représentant l’associé unique de la Société et le notaire instrumentant restera annexée au présent acte
afin d’être soumis avec lui aux formalités de l’enregistrement,

en sa qualité d’associé unique de la société PUBLIC SAFETY LUXEMBOURG, S.à r.l., une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social à L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 117.722 (la "Société"), constituée suivant acte notarié du notaire Joseph
Wagner résident à Sanem, en date du 6 juillet 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 1725
du 15 septembre 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié du notaire instrumentant,
en date du 31 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, n° 588 du 11 mars 2013,

Laquelle comparante, représentée comme ainsi qu’il a été dit, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
L'ordre du jour est le suivant:
1. Réduction du capital social à concurrence d'un montant de EUR 87.182.900 (quatre-vingt-sept million cent quatre-

vingt-deux mille neuf cents Euro) en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR 87.195.400 (quatre-
vingt-sept million cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents Euro) représenté par 3.487.816 (trois mille quatre cent
quatre-vingt-sept mille huit cent seize) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune à
un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur
nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune par le remboursement et l’annulation de 3.487.316 (trois mille quatre cent
quatre-vingt-sept mille trois cent seize) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune

2. Modification subséquente de l’article 6 des Statuts de la Société comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune.»

9. Autorisation donnée à chaque gérant ainsi que l’agent domiciliataire pour prendre toute mesure juridique en relation

avec l’ordre du jour et en particulier pour modifier et signer le registre des associés de la Société

10. Divers
L’associé unique a ensuite pris les décisions suivantes:

29553

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’associé unique décide de réduire le capital social à concurrence d'un montant de EUR 87.182.900 (quatre-vingt-sept

million cent quatre-vingt-deux mille neuf cents Euro) en vue de porter le capital social de son montant actuel de EUR
87.195.400 (quatre-vingt-sept million cent quatre-vingt-quinze mille quatre cents Euro) représenté par 3.487.816 (trois
mille quatre cent quatre-vingt-sept mille huit cent seize) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq
Euro) chacune à un montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents) représenté par 500 (cinq cents) parts sociales ayant
une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro) chacune par le remboursement et l’annulation de 3.487.316 (trois mille
quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent seize) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq Euro)
chacune.

Au lieu de rembourser le montant de EUR 87.182.900 (quatre-vingt-sept million cent quatre-vingt-deux mille neuf

cents Euro) immédiatement, ledit montant sera alloué aux réserves distribuables.

En conséquence de la résolution présente, les 500 (cinq cents) parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 25

(vingt-cinq Euro) chacune représentant le capital social entier de la Société sont détenues par l’associé unique PSE Newco
II Limited.

<i>Deuxième résolution

L’associé unique décide de modifier l’article 6 des Statuts de la Société comme suit:
«Le capital de la Société est fixé à la somme de douze mille cinq cents Euro (EUR 12.500), représenté par cinq cents

(500) parts sociales d'une valeur nominale vingt-cinq Euro (EUR 25) chacune.»

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide d'autoriser chaque gérant ainsi que l’agent domiciliataire pour prendre toute mesure juridique

en relation avec l’ordre du jour et en particulier pour modifier et signer le registre des associés de la Société.

<i>Frais, Evaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit, incombant à la Société en raison du présent

acte, furent estimés approximativement à deux mille trois cents Euros (EUR 2.300.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclara qu'à la requête des personnes comparantes ci-dessus, le

présent acte fût rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. A à la requête des mêmes personnes comparantes
et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61605. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016128/137.
(150018428) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Chauffage Nuddelsfabrik S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 181.350,00.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 74, Mühlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 61.252.

<i>Extrait du compte rendu du conseil d'administration du 5 décembre 2013

Le conseil d'administration prend la décision de nommer Monsieur Michel MARCHAND, 30, rue d'Arlon B-6717

Attert, entant qu'administrateur-délégué.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Daniel MACHADO.

Référence de publication: 2015015652/13.
(150019084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29554

L

U X E M B O U R G

Food Delivery Holding 19 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.006.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., a limited liability corporation (société à responsabilité limitée)

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg with its statutory seat in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés)
under B 175738, having its business address at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin on 8 

th

 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Food Delivery Holding 19 S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

29555

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

29556

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

29557

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

29558

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Emerging Markets Online Food

Delivery Holding S.à r.l., aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Ralf Wenzel, born in Berlin, Germany, on 8 August 1979, professionally residing at Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

29559

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am neunten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Emerging Markets Online Food Delivery Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter

dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre
de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 175738, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großher-
zogtum Luxemburg.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 8.

Januar 2015, ausgestellt in Berlin.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Food Delivery Holding 19 S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an

29560

L

U X E M B O U R G

ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer

29561

L

U X E M B O U R G

Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige  Geschäftsführer  aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

29562

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.

17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

29563

L

U X E M B O U R G

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - anwendbares recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

29564

L

U X E M B O U R G

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Emerging Markets Online Food Delivery

Holding S.à r.l., vorbenannt, zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Ralf Wenzel, geboren am 8. August 1979 in Berlin, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse 20, D-10117

Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 12 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/884. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Januar 2015.

Référence de publication: 2015015788/587.
(150018472) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29565

L

U X E M B O U R G

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.796.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B, L.P, a company governed by the laws of Bermudas, having its registered

office at 16, par la Ville Road, bâtiment Century House, HM08 Hamilton, Bermudas and registered with the Bermuda
register of companies under number 34911,

hereby represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, on 10 December 2014.

Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, declares being the sole shareholder (“Sole Shareholder”) of “Neo-

vara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité limitée),
with  registered  office  at  52-54,  avenue  du  X  September,  L-2550  Luxembourg,  with  a  share  capital  of  EUR  12,500.-,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number R.C.S Luxembourg B 99796 (the “Com-
pany”), incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier, notary residing in Esch-surAlzette, dated March 23,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 13, 2004, number 504, page 24152.

The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notary deed of Maître Paul Decker,

notary residing in Luxembourg, dated March 24, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on June 18, 2011, number 1328, page 63707.

All the one hundred (100) shares of the Company with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each,

representing  the  entire  subscribed  capital  of  the  Company  amounting  to  twelve  thousand  five  hundred  Euro  (EUR
12,500.-) are duly represented at the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of the Company (the “Meet-
ing”), which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Sole Shareholder
represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to enter the Company into voluntary liquidation;
2. Appointment of Quorum Investments S.à r.l. as liquidator of the Company and determination of its powers;
3. Discharge to the managers of the Company;
4. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended, the Sole Shareholder decides

to dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator:
Quorum Investments S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered

office at 52-54, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B58442, as Liquidator (the “liquidateur”) of the Company.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10 

th

 , 1915

on commercial companies, as amended.

It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the Sole Shareholder

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its

powers it determines and for the period it will fix.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to grant discharge to the managers of the Company and release them from liability in

respect of the execution of their mandate with regards to the period from January 1 

st

 , 2014 to December 17, 2014.

29566

L

U X E M B O U R G

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B, L.P., une société de droit des Bermudes, avec siège social au 16, la

Ville Road, bâtiment Century House, HM08 Hamilton, Bermudas et immatriculée auprès du Registre des Compagnies
des Bermudes sous le numéro 34911,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration signée sous seing privée, en date du 10 décembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être l’associé unique («l’Associé Unique») de la société à

responsabilité limitée «Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à.r.l.», avec siège social au 52-54, avenue du X
Septembre, L-2550 Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,- enregistrée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99796 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par Maître Blanche
Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et As-
sociations, le 13 mai 2004 sous le numéro 504, page 24152.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 18 juin 2011 sous
le numéro 1328, page 63707.

Toutes les cent (100) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR)

chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,-
EUR) sont dûment représentées à l’assemblée générale extraordinaire de l’Associé Unique de la Société («l’Assemblée»),
qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l’ordre du jour. L’Associé Unique
représenté déclare avoir été dûment convoqué à l’Assemblée et informé de l’ordre du jour.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de Quorum Investments S.à.r.l. an tant que liquidateurs de la société et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge aux gérants de la Société;
4. Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l’Associé

Unique décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de nommer en qualité de liquidateur:
Quorum Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 58442.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Associé Unique dans les

cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

29567

L

U X E M B O U R G

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société, pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1 

er

 janvier 2014 jusqu’au 17 décembre 2014.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62837. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016011/131.
(150018531) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Solar Carbide S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9145 Erpeldange, 1, Porte des Ardennes.

R.C.S. Luxembourg B 170.957.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015016730/10.
(150019878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Dynamic Plus Equity Fund (Lux) SIF SICAV S.A., Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 167.476.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte des décisions prises par les actionnaires de la société en date du 31 décembre 2014 que:
1) la clôture de la liquidation volontaire de la société est prononcée;
2) les comptes de clôture sont approuvés;
3) Les livres et autres documents de la société dissoute resteront conservés durant 5 ans après la clôture de liquidation

au siège social de la société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015015720/19.
(150019205) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29568


Document Outline

Advanzia Bank S.A.

Adventure Europe

ALUBRA S.à r.l. Luxembourg

Aradio International Group S.A.

Atacama Energy S.A.

BC Bowling S.à r.l.

B.C.F. Perreaux Bernard S.à r.l.

Beenyn Investments S.A.

BNAP S.à r.l.

Bosscom

Carrosserie Robert Comes &amp; Compagnie S.A.

Castik Capital, S.à r.l.

CCSLUX S.A.

C.D.D. S.A.

CDMLUX Expertise Comptable

Chauffage Nuddelsfabrik S.A.

Cofis Luxembourg S.A.

David Goldstern S.A.

Dynamic Plus Equity Fund (Lux) SIF SICAV S.A.

Euro Secure

FIL (Luxembourg) S.A.

Fonsicar Managers S.à r.l.

Food Delivery Holding 19 S.à.r.l.

Gardur Partners S.à r.l.

Gasfin S.A.

Jennifer S.A. S.P.F.

Koromo S.A.

Meigerhorn Bulle S.à r.l.

Mont Mirail Limited, S.à r.l.

Najade S.A.

Natitri S.àr.l.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l.

North American Capital Investors of Luxembourg (NACIL)

Nuremburg Properties S.A.

Oberheim S.à r.l.

PFB Properties S.à r.l.

Plastiche S.A.

Platanthera S.à.r.l.

Public Safety Luxembourg, S.à r.l.

RDF Constructions S.A.

Rodeo-Timber de Bellux

Solar Carbide S.à r.l.

Sud Petrol S.A.

Thill Romain et Fille S.à r.l.