logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 613

5 mars 2015

SOMMAIRE

Akryl - Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29424

Arepo BH. S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29381

Belval Square SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29386

Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung

A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29378

Biobu S.à r..l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29412

Bleu Book Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29392

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l. . . . .

29381

Brasserie Everydays  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29381

Cerbero Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29380

Digital Services XXXIII S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

29413

Enop 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29384

Feston Investissements S.A. . . . . . . . . . . . . .

29385

Futura II Holding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29384

Gercomm 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29412

Ice Man SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29379

Ice Man SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29385

Iglux Group S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29423

Institut Epil'Ongles S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

29424

Intermarc s.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29379

IVM Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29378

Jacana S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29385

JAN.CO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29378

Jewel HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29402

KKH Property Investors S.à r.l. . . . . . . . . . .

29409

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

29378

L.O.G.EVAM s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29379

LuxCo 82 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29393

Luxembourg Online S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

29380

M.A.B. Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29386

Martley Holding S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

29380

Merchbanc Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29380

Pasta Mano S.à.r.l. et Cie S.e.c.s  . . . . . . . . .

29379

Patentportfolio 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

29383

Pearson Luxembourg N°. 2.  . . . . . . . . . . . . .

29383

Pegase S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29382

Phary Company S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29381

PK AirFinance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29382

Roof Garden S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29384

Sapphire Shipping S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

29382

Sardinvest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29389

Schindler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29383

Secure Industries S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29387

SH Group Hotels & Residences Global Li-

censing (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29385

29377

L

U X E M B O U R G

IVM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.057.

Le bilan au 30 Juin 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 Janvier 2015.

Référence de publication: 2015016576/10.
(150019540) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 136.528.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016603/10.
(150019743) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.664.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 27. Januar 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 27. Januar 2015 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Daniel Kranz, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
Référence de publication: 2015015556/12.
(150018915) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

JAN.CO S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 150.883.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires de la société,

tenue en date du 29 décembre 2014, que

L'assemblée a pris note de la démission du Commissaire aux comptes KSANTEX S.à.r.l. (numéro RCS Luxembourg:

B152619) avec effet au 31 décembre 2014.

L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux comptes la société SEPRA INVEST S.à.r.l.

(numéro RCS Luxembourg: B169294), avec siège social établi au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à compter
du 1 

er

 janvier 2015.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015016580/20.
(150019859) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29378

L

U X E M B O U R G

Ice Man SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 134.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016548/9.
(150019773) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Pasta Mano S.à.r.l. et Cie S.e.c.s, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 58.314.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015016684/11.
(150019936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

L.O.G.EVAM s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 65, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 161.869.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 30 janvier 2015.

L.O.G.Evam Sàrl
L-4051 Esch/Alzette

Référence de publication: 2015016598/12.
(150019552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Intermarc s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 127.919.

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par jugement rendu en date du 10 décembre 2014, le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

commerciale, a ordonné en vertu de l'article 203 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la
dissolution et la liquidation de

la société à responsabilité limitée INTERMARC s. à r.l., établie et ayant son siège social à L-9530 Wiltz, 45, Grand-rue,

inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 127919.

Le même jugement a désigné comme liquidateur Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

et nommé juge-commissaire Monsieur le Juge Jean-Claude WIRTH.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a déclaré applicables les dispositions légales relatives à la liquidation de

la faillite et a dit que le présent jugement est exécutoire par provision.

Le Tribunal d'Arrondissement de et à Diekirch a également mis les frais à charge de la société, sinon, en cas d'absence

ou d'insuffisance d'actif, à charge du Trésor.

Pour extrait conforme
Me Daniel BAULISCH
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2015016570/22.
(150019299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29379

L

U X E M B O U R G

Martley Holding S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 122.104.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016622/9.
(150019939) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Luxembourg Online S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 52.947.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016618/9.
(150019370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Merchbanc Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 51.646.

Le bilan au 30 septembre 2014 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour MERCHBANC SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015016633/13.
(150019430) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Cerbero Holding S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 30, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.431.

Il résulte du procès-verbal du 14 novembre 2014 que le Conseil d'Administration de la société a pris entre autres la

résolution suivante:

<i>Première Résolution

Il est décidé de nommer en tant que Président du Conseil d'administration de la Société, Monsieur Giovanni Patri, né

le 18 août 1975 à Lobbes (Belgique) et demeurant professionnellement au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le mandat de Président ainsi conféré prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2017.

<i>Deuxième résolution

Le Conseil d'Administration prend acte de, et accepte la démission de Monsieur Mirko LAROCCA de sa fonction

d'Administrateur avec effet au 14 novembre 2014. Le Conseil d'Administration décide de coopter en son sein et avec
effet immédiat Madame Marine SCHRUB, née à Châlons-en-Champagne (France), le 28 octobre 1986 et demeurant
professionnellement au 30 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en remplacement de Monsieur Mirko, Administrateur
démissionnaire.

En conformité avec la loi, l'Assemblée Générale des Actionnaires procèdera, lors de sa prochaine réunion, à la nomi-

nation définitive.

Le mandat des Administrateurs prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en l'an 2017.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016399/23.
(150019375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29380

L

U X E M B O U R G

Arepo BH. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 47, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 145.175.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016341/9.
(150019331) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Brasserie Everydays, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4051 Esch-sur-Alzette, 68-70, rue du Canal.

R.C.S. Luxembourg B 164.991.

Monsieur Avelino AZENHA SIMOES, associé et gérant de la société BRASSERIE EVERYDAYS SARL- a actuellement

son domicile au 73, rue de Luxembourg L-4391 Pontpierre.

Pour avis sincère et conforme

Référence de publication: 2015016358/10.
(150019718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 165.646.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 26. Januar 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 26. Januar 2015 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Daniel Kranz, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
- Herr Achim Mattes, geboren am 29. April 1978 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger abberufen.
- Herr Bernhard Jost, geboren am 07. Oktober 1973 in Grambach (Österreich), geschäftlich ansässig in 5, rue Heienhaff,

L-1736 Senningerberg, wurde mit Wirkung zum 26. Januar 2015 als gemeinschaftlich vertretungsbefugter AGeschäfts-
führer der Gesellschaft auf unbestimmte Zeit bestellt.

Référence de publication: 2015015566/16.
(150018982) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Phary Company S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-1941 Luxembourg, 167, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 166.645.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue au siège social le 29 décembre 2014

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société a définitivement cessé d'exister.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant la période

légale chez Stratego International Sàrl, dont l'adresse actuelle est au 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale confirme que le liquidateur a pris les mesures et réalisé les provisions nécessaires en vue de la

consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou actionnaire.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015016070/18.
(150018781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29381

L

U X E M B O U R G

Sapphire Shipping S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 80.710.

<i>Auszug aus dem Bericht des Verwaltungsrates vom 28. Januar 2015 an die Aktionäre und an den Aufsichtskommissar

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ernennung als Depositar FIDUCIAIRE MOSELLAN SARL., eingetragen

im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015016186/13.
(150018838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Pegase S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 42.741.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 13 janvier 2015

Le Conseil décide de désigner FIDUPAR, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1,

rue Joseph Hackin, comme dépositaire des actions au porteur de la Société, conformément à l'article 42 (1) de la loi
modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour Extrait conforme
FIDUPAR
1, rue Joseph Hackin
L-1746 Luxembourg
Signatures

Référence de publication: 2015016094/16.
(150018672) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

PK AirFinance, Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 27.840.

<i>Extrait de l'Assemblée Générale du 3 Juin 2014

Paragraphe 5
L'Assemblé Générale a approuvé la nomination d'un nouveau membre au Conseil de Gérance Mr Stéphane Daillen-

court, dont la nomination a également été approuvée par la CSSF.

Le Conseil de Gérance est donc constitué comme suit:
David Bartlett, Vice-Président et Conseiller pour GECAS, habitant Zum Wetterbrunnen 36, Bilzingen Wincheringen,

DE-54457 Allemagne, date de naissance 6 mars, 1966

Stephane Daillencourt, Vice- Président Exécutif pour GECAS, habitant 2 Cluny Park, Singapour 259610, date de nais-

sance 16 Juillet, 1956.

Nils Hallerström, Président pour PK AirFinance, 4, vir Reischtert, L-6948 Niederanven, Luxembourg, date de naissance

20 juillet 1953

Greg Hong, Vice-Président Exécutif et Responsable Analyse de Risk pour GECAS, habitant 16 Saint Claire Avenue,

Old Greenwich, Connecticut 06870 USA, date de naissance 26 mars 1964.

Mr Diarmuid M. Hogan, Vice-Président Exécutif et CFO pour GECAS, habitant 5 Hillandale lane, Westport, CT 06880,

USA, date de naissance 28 mai 1968

Serge Michels, Senior Vice-Président Administration pour PK AirFinance, habitant 7, Rue J.B. Kremer, L-7790 Bissen,

Luxembourg, date de naissance 8 juin 1959

Per Waldelöf, Vice-Président Exécutif pour PK AirFinance, habitant 4, rue du Touch, F-31170 Tournefeuilles, France,

date de naissance 9 août 1955.

Référence de publication: 2015016114/25.
(150018610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29382

L

U X E M B O U R G

Schindler, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2413 Luxembourg, 12, rue du Père Raphaël.

R.C.S. Luxembourg B 3.896.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 19 janvier 2015.

Le conseil de gérance de la société SCHINDLER s'est réuni en date du 14 janvier 2015 afin de procéder à la démission

de Monsieur Roger WAGNER, avec effet au 6 janvier 2015. Le conseil de gérance se compose donc de trois membres.

Le conseil de gérance procède également à la nomination de la société ERNST &amp; YOUNG, avec siège à L-5365 Muns-

bach, 7, rue Gabriel Lippmann (RCS B 47.771) comme réviseur d'entreprises statuant sur les comptes de l'exercice de
2015.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016188/14.
(150018635) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Patentportfolio 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 131.250.

EXTRAIT

Laut Umlaufbeschluss der Patentportfolio 2 S.à r.l. am 26.01.2015 wurde folgendes beschlossen:
Herr Hans-Jürgen Eberling, geboren am 15. Mai 1970, wohnhaft in 1180 Wien, Österreich, Scheibenbergstraße 67/9

beendigt seine Tätigkeit als Beirat der Patentportfolio S.à r.l. mit Wirkung zum 26. Januar 2015.

Luxembourg, le 28.01.2015.

Pour avis conforme
Marc Molitor
<i>Directeur

Référence de publication: 2015016065/16.
(150018269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Pearson Luxembourg N°. 2., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 25.100,00.

Siège social: L-1631 Luxembourg, 17, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 100.148.

EXTRAIT

Par décision de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014, il a été décidé (i) de prendre acte de la

démission de Monsieur Jan Francis van der Drift en tant que gérant de la Société, avec effet au 30 avril 2014, (ii) de prendre
acte de la démission de Monsieur James Marshall en tant que gérant de la Société, avec effet au 3 décembre 2014 et (iii)
d'approuver la nomination de Monsieur Ralf Keess, né le 14 octobre 1966 à Memmingen, en Allemagne, demeurant
professionnellement au C/Ribera del Loira, 28, 1 

er

 étage, 28042 - Madrid, Espagne en tant que gérant de la Société, avec

effet au 16 décembre 2014 et pour une durée indéterminée.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société est composé comme suit:
- Monsieur Michael Robert Kidd, avec adresse privée au 28, rue Puert, L-5433 Niederdonven, Grand-Duché de Lu-

xembourg, en tant que gérant;

- Monsieur Keith Proffitt, demeurant professionnellement à 80, Strand, GB - WC2R 0RL Londres, Royaume-Uni, en

tant que gérant; et

- Monsieur Ralf Keess, demeurant professionnellement au C/Ribera del Loira, 28, 1 

er

 étage, 28042 - Madrid, Espagne,

en tant que gérant.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015016068/24.
(150018390) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29383

L

U X E M B O U R G

Enop 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 76.810.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016459/9.
(150019325) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Futura II Holding, Société Anonyme.
Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 135.414.

Les comptes annuels au 30 novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Futura II Holding S.A.

Référence de publication: 2015016475/10.
(150019360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Roof Garden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 71.607.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Lors de l'acte de scission partielle par constitution de la société ROOF GARDEN S.A., ayant son siège social au 45-47,

route d'Arlon, L-1140 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de et à Luxembourg sous le
numéro B 71.607.

tenue par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg en

date du 30 décembre 2014, enregistrée à Luxembourg AC 2, le 9 janvier 2015, 2LAC/2015/714, aux droits de 75.- € et
déposé au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro L150010606,

des erreurs matérielles se sont glissées concernant la fin de mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes

des nouvelles sociétés à constituer.

Il y a donc lieu de rectifier les données suivantes comme suit:
1. Page 14, «DECISIONS COMPLEMENTAIRES», point 4:
«DECISIONS COMPLEMENTAIRES
(...) 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2020.»

2. Page 26, «DECISIONS COMPLEMTAIRES», point 4:
«DECISIONS COMPLEMENTAIRES
(.) 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2020.»

3. Page 35, «DECISIONS COMPLEMENTAIRES», point 4:
«DECISIONS COMPLEMENTAIRES
(.) 4.- Le mandat des administrateurs et du commissaire ainsi nommés prendra fin à l'issue de l'assemblée générale

ordinaire de 2020.»

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 27 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/1957. Reçu douze euros. Eur 12.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016158/35.
(150018801) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29384

L

U X E M B O U R G

Ice Man SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 134.533.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016549/9.
(150019774) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

SH Group Hotels &amp; Residences Global Licensing (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 37.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.376.

Par résolutions signées en date du 11 décembre 2014, les associés ont décidé d'acter et d'accepter la démission de

Steve Hankin de son mandat de gérant avec effet au 25 novembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016747/12.
(150019691) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Jacana S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 10.758.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

<i>Pour: JACANA SA
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015016577/16.
(150019388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Feston Investissements S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 65.031.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants tenue en date du 30 janvier 2015

M. David SANA, administrateur de sociétés, né le 10 avril 1974 à Forbach (France), demeurant professionnellement

à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été coopté comme administrateur de la société en remplacement de
Mlle  Virginie  GUILLAUME,  administrateur  démissionnaire,  dont  il  achèvera  le  mandat  d'administrateur  qui  viendra  à
échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2015.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour FESTON INVESTISSEMENTS S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2015016476/17.
(150019868) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29385

L

U X E M B O U R G

M.A.B. Investments S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2661 Luxembourg, 42, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 143.258.

Conformément à l'article premier de la loi du 28 juillet 2014, relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur,

et par décision du Conseil d' Administration en date du 12 janvier 2015, EXPERTA CORPORATE AND TRUST SERVICES
S.A., Luxembourg, société anonyme, 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, immatriculée au R.C.S. Luxembourg sous
le numéro B-29597, a été nommée agent dépositaire des actions au porteur et détenteur du registre des actions au
porteur de la Société avec effet immédiat et pour une durée illimitée.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

<i>Pour: M.A.B. INVESTMENTS S.A.
Experta Luxembourg
Société anonyme

Référence de publication: 2015015958/16.
(150018314) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Belval Square SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 93.026.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2014

L'assemblée générale, après avoir délibérée, prend à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>1 

<i>ère

<i> Résolution

L'assemblée générale révoque le commissaire aux comptes LUX AUDIT S.A., ayant son siège social L-1510 Luxem-

bourg, 57 rue de la Faïencerie, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 25.797.

<i>2 

<i>ème

<i> Résolution

L'Assemblée générale nomme comme commissaire aux comptes, la société NORDOCOM SÀRL, inscrite au Registre

du Commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B 55862, ayant son siège social à L-1618 Luxembourg, 2
rue des Gaulois, jusqu'à l'assemblée statuant sur l'exercice social 2018.

Ce commissaire aux comptes est désigné à compter de la présente assemblée et jusqu'à l'assemblée générale ordinaire

annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

<i>3 

<i>ème

<i> Résolution

L'assemblée générale prend acte de la démission avec effet immédiat de Monsieur Dan EPPS, conseiller fiscal, né le 25

juillet 1969 à Echternach, de son poste d'administrateur.

<i>4 

<i>ème

<i> Résolution

L'assemblée générale décide de nommer pour une durée indéterminée les administrateurs suivant:
- Monsieur Pasquale Corcelli, entrepreneur de constructions, demeurant à L-2167 Luxembourg, 60, rue des Muguets

(Administrateur délégué);

- Madame Aurelia Corcelli, employée privée, née le 13 mai 1976 à Luxembourg et demeurant à L-2146 Luxembourg,

63, rue du Merl (Administrateur);

- Madame Sandra DOS SANTOS, employée privée, née le 22 avril 1975 à Boulay-Moselle (France) et demeurant à

L-1713 Luxembourg, 66 rue Hamm (Administrateur);

- Monsieur Pierre Hoffmann, employé privé, né le 8 septembre 1982 à Luxembourg et demeurant à L-8052 Bertrange,

au 26 rue des Aubépines (Administrateur).

La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs, soit par la signature individuelle

de l'administrateur délégué.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015579/36.
(150017550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29386

L

U X E M B O U R G

Secure Industries S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte-Croix.

R.C.S. Luxembourg B 180.439.

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of January.
Before Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,
acting as the representative of the board of directors of Secure Industries SA (the Board) pursuant to the resolutions

of the Board dated 12 January 2015 (the Resolutions),

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, itself represented by Maître Serge ZEIEN, avocat à la Cour residing

professionally in Luxembourg-City, by virtue of a power of attorney given under private seal on 1 September 2013 by
Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, acting on behalf of Allen &amp; Overy GP, société coopérative organisée comme
société anonyme, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, itself acting in its capacity as general
partner (associé commandité) of Allen &amp; Overy, société en commandite simple.

An excerpt of the minutes of the Resolutions and the abovementioned power of attorney signed ne varietur by the

appearing person and the notary will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.

The appearing person has requested the undersigned notary to record the following statements:
1. Secure Industries SA (the Company) has been incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 13

September 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2470 of 5 October 2013.
The articles of association of the Company (the Articles) have been modified for the last time by a deed of the undersigned
notary on 8 January 2015, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

2. Pursuant to article 5 of the Articles, the authorised share capital of the Company is set at EUR 700,000,000 (seven

hundred million euro) represented by a maximum of 100,000 (one hundred thousand) A Shares, and a maximum of
600,000 (six hundred thousand) B Shares, each having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro).

3. Pursuant to the Resolutions and in accordance with the Articles, the Board has resolved
(i) to increase the share capital of the Company by EUR 4,261,000 (four million two hundred sixty-one thousand euro)

in order to raise it from its current amount of EUR 348,044,000 (three hundred forty-eight million forty-four thousand
euro) to EUR 352,305,000 (three hundred fifty-two million three hundred five thousand euro); and

(ii) to cancel the preferential subscription right of the existing shareholder(s) of the Company.
4. The share capital increase of the Company has been subscribed and paid up as follows:
Guardian Segur S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated and existing under the laws of

the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 9B, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, and registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under num-
ber B168659, qualifying as a securitisation vehicle (société de titrisation) within the meaning of the Luxembourg act dated
22 March 2004 relating to securitisation, as amended, acting in respect of its compartment called "Compartment 1", has
subscribed to 4,261 (four thousand two hundred sixty-one) A Shares which have been fully paid up by way of a cash
payment in an aggregate amount of EUR 5,077,831.60 (five million seventy-seven thousand eight hundred thirty-one euro
and sixty cent) (the Cash Payment).

The Cash Payment has been allocated as follows:
(i) the amount of EUR 4,261,000 (four million two hundred sixty-one thousand euro) has been allocated to the nominal

share capital of the Company; and

(ii) the amount of EUR 816,831.60 (eight hundred sixteen thousand eight hundred thirty-one euro and sixty cent) has

been allocated to the share premium account of the Company.

The aggregate amount of EUR 5,077,831.60 (five million seventy-seven thousand eight hundred thirty-one euro and

sixty cent) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary, and the
notary expressly bears witness to it.

5. As a consequence of the above share capital increase the first paragraph of article 5 of the Articles shall read from

now on as follows:

"The  share  capital  is  set  at  EUR  352,305,000  (three  hundred  fifty-two  million  three  hundred  five  thousand  euro)

represented by 52,305 (fifty-two thousand three hundred five) class A shares (the A Shares) and 300,000 (three hundred
thousand) class B shares (the B Shares), having a nominal value of EUR 1,000 (one thousand euro) each, which are fully
paid up (the A Shares and the B Shares are collectively referred to as the shares)."

29387

L

U X E M B O U R G

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, allocated by the undersigned notary and which are to be borne by the Company

or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about four thousand five
hundred euros.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person

the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case
of divergences between the English text and the French text, the English text will prevail.

After reading the present deed to the appearing person, the said appearing person signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le seize janvier.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg,
agissant en tant que représentant du conseil d'administration de Secure Industries SA (le Conseil d'Administration)

conformément aux résolutions du Conseil d'Administration en date du 12 janvier 2015 (les Résolutions),

Allen &amp; Overy, société en commandite simple, elle-même représentée par Maître Serge ZEIEN, avocat à la Cour, de

résidence professionnelle à Luxembourg-Ville, en vertu d'une procuration sous seing privé en date du 1 

er

 septembre

2013 conférée par Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, agissant pour le compte de Allen &amp; Overy GP, société
coopérative organisée comme société anonyme, société d'avocats inscrite à la liste V du barreau de Luxembourg, cette
dernière agissant en tant qu'associé commandité de Allen &amp; Overy, société en commandite simple.

Un extrait du procès-verbal des Résolutions et la procuration sous seing privé susmentionnée signés ne varietur par

le comparant et le notaire resteront annexés au présent acte et seront présentés au même moment aux autorités de
l'enregistrement.

Le comparant, agissant en la qualité susmentionnée, prie le notaire d'acter ce qui suit:
1. Secure Industries SA (la Société) a été constituée le 13 septembre 2013 par un acte du notaire soussigné, publié au

Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2470 du 5 octobre 2013. Les statuts de la Société (les Statuts)
ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné du 8 janvier 2015, modifications non publiées au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations à ce jour.

2. En application de l'article 5 des Statuts le capital autorisé de la Société est établi à EUR700.000.000 (sept cent millions

d'euros) représenté par un maximum de 100.000 (cent mille) Actions A, et un maximum de 600.000 (six cent mille)
Actions B, chacune ayant une valeur nominale de EUR1.000 (mille euros).

3. Suite aux Résolutions et en conformité avec les Statuts, le Conseil d'Administration a décidé
(i) d'augmenter le capital social de la Société de EUR 4.261.000 (quatre millions deux cent soixante et un mille euros)

de sorte à ce qu'il soit Page 5 / 6 augmenté de sa valeur actuelle de EUR 348.044.000 (trois cent quarante-huit millions
quarante-quatre mille euros) à EUR 352.305.000 (trois cent cinquante-deux millions trois cent cinq mille euros); et

(ii) de supprimer les droits préférentiels de souscription des actionnaires existants de la Société.
4. L'augmentation du capital social de la Société est souscrite et payée comme suit:
Guardian Segur S.A., une société anonyme constituée et existant d'après les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son adresse au 9B, boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, et enregistrée au Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg sous le numéro B168659, qualifiée de société de titrisation au sens de la loi luxembourgeoise du
22 Mars 2004 sur la titrisation, telle que modifiée, agissant pour le compte de son compartiment appelé "Compartiment
1", a souscrit à 4.261 (quatre mille deux cent soixante et un) Actions A, entièrement libérées par voie de paiement en
espèces du montant de EUR 5.077.831,60 (cinq millions soixante-dix-sept mille huit cent trente et un euros et soixante
centimes) (le Paiement en Espèces).

Le Paiement en Espèces a été alloué comme suit:
(i) le montant de EUR 4.261.000 (quatre millions deux cent soixante et un mille euros) a été alloué au capital social

souscrit de la Société; et

(ii) le montant de EUR 816.831,60 (huit cent seize mille huit cent trente et un euros et soixante centimes) a été alloué

au compte de la prime d'émission de la Société.

Le montant de EUR 5.077.831,60 (cinq millions soixante-dix-sept mille huit cent trente et un euros et soixante cen-

times) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentant qui le constate expressément.

5. En conséquence de l'augmentation du capital social, le premier paragraphe de l'article 5 des Statuts est modifié

comme suit:

29388

L

U X E M B O U R G

"Le capital social souscrit de la Société est fixé à EUR 352.305.000 (trois cent cinquante-deux millions trois cent cinq

mille euros) représenté par 52.305 (cinquante-deux mille trois cent cinq) actions de catégorie A (les Actions A) et 300.000
(trois cent mille) actions de catégorie B (les Actions B), ayant une valeur nominale de EUR1.000 (mille euros) chacune,
entièrement souscrites (les Actions A et les Actions B sont collectivement Page 6 / 6 dénommées les actions)."

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations et charges facturées par le notaire instrumentant et qui incombent à la Société à

raison de sa constitution sont estimés à environ quatre mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête du comparant, le présent acte a été établi

en anglais, suivi d'une version française. A la requête du même comparant, et en cas de divergences entre les versions
anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au comparant, ledit comparant a signé ensemble avec le notaire l'original du présent acte.
Signé: Zeien, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 21 janvier 2015. Relation: DAC/2015/1114. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Tholl.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 28 janvier 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015016726/130.
(150019764) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Sardinvest S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 387.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 167.052.

IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN, ON THE TWENTY-SECOND DAY OF DECEMBER
Before the undersigned Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held

an Extraordinary General Meeting of shareholders of "Sardinvest S.A.", a société anonyme having its registered office

in 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituted by a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in
Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on February 6, 2012, published in the Mémorial, Recueil Spécial C no 896 of April
5, 2012.

The meeting was opened by Mr Alberto MORANDINI, company director, residing professionally in Luxembourg, being

in the chair,

who appointed as secretary Mr Jean FAWE, employee, residing professionally in Luxembourg.
The meeting elected as scrutineer Mr Alberto MORANDINI prenamed.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:
I. The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of the capital to the extent of three hundred fifty-six thousand five hundred Euros (EUR 356.500,-) in order

to raise it from the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,-) to three hundred eighty-seven thousand five
hundred Euros (EUR 387.500) by the issue of three thousand five hundred sixty-five (3.565) new shares with a nominal
value of one hundred Euros (EUR 100,-) each vested with the same rights and obligations as the existing shares.

2. Subscription of three thousand five hundred sixty-five (3.565) new shares with a nominal value of one hundred Euros

(EUR 100,-) each by Oslane United Corp., a Company incorporated under the laws of the British Virgin Islands, having
its registered office at Morgan &amp; Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
and full payment of the three thousand five hundred sixty-five (3.565) new shares by contribution in kind of an unques-
tionable and immediately payable shareholder’s claim of Oslane United Corp. against the company to the extent of nine
million two hundred eighty-nine thousand forty-nine Euros ninety-one Cents (EUR 9.289.049,91), the amount of three
hundred fifty-six thousand five hundred Euros (EUR 356.500) being attributed to the capital account of the company and
the amount of eight million nine hundred thirty-two thousand five hundred forty-nine Euros ninety-one Cents (EUR
8.932.549,91) to be attributed to a share premium account.

3. Subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the articles of association which will henceforth have

the following wording:

29389

L

U X E M B O U R G

Art. 3. ”The corporate capital is fixed at three hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR 387.500,-)

divided into three thousand eight hundred seventy-five (EUR 3.875) shares of one hundred euro each.”

II. The shareholders present or represented, the proxyholders of the represented shareholders and the number of

their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed ne varietur by the shareholders, the proxyholders
of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed.

The proxies of the represented shareholders duly signed ne varietur by the shareholders, the proxyholders of the

represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present
deed.

III. As all the shares in circulation are present or represented at the present general meeting, so that the meeting can

validly decide on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the capital to the extent of three hundred fifty-six thousand five hundred

Euros (EUR 356.500,-) in order to raise it from the amount of thirty-one thousand Euros (EUR 31.000,-) to three hundred
eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 387.500) by the issue of three thousand five hundred sixty-five (3.565)
new shares with a nominal value of one hundred Euros (EUR 100,-) each vested with the same rights and obligations as
the existing shares.

<i>Subscription - Liberation

Thereupon appeared:
Oslane United Corp, a company incorporated under the law of the British Virgin Island, having its registered office at

Morgan &amp; Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, incorporated under
the laws of the BVI Business Companies Act, 2004, on May 20, 2010 under No. 1586261,

here represented by Mr Alberto MORANDINI prenamed, by virtue of a proxy established on 18 December 2014.
The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration,

who declared to subscribe to three thousand five hundred sixty-five (3.565) new shares with a nominal value of one

hundred Euros (EUR 100,-) each and to have them fully paid up by the conversion into capital of an unquestionable and
immediately payable claim held by Oslane United Corp. against the company to the extent of nine million two hundred
eighty-nine thousand forty-nine Euros ninety-one Cents (EUR 9.289.049,91), the amount of three hundred fifty-six thou-
sand five hundred Euros (EUR 356.500) being attributed to the capital account of the company and the amount of eight
million nine hundred thirty-two thousand five hundred forty-nine Euros ninety-one Cents (EUR 8.932.549,91) to be
attributed to a share premium account.

The existence of the said claim is proofed in a report established by ARTEMIS, Audit &amp; Advisory, by Mrs Someya

Qalam, Réviseur d’Entreprises Agréé, on 22 December 2014, concluding as follows:

“4. Conclusion:
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu’à la prime d’émission des actions à émettre
en contrepartie.”

This report, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed for the purpose of registration.

<i>Second Resolution

The general meeting decides the subsequent amendment of the first paragraph of article 3 of the articles of association,

which will henceforth have the following wording:

“ Art. 3. first paragraph. The corporate capital is fixed at three hundred eighty-seven thousand five hundred euro (EUR

387.500,-) divided into three thousand eight hundred seventy-five (EUR 3.875) shares of one hundred euro each.”

There being no further business, the meeting is terminated.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

corporation incurs or for which it is liable by reason of the present increase of capital, is approximately EUR 2,010.-.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

29390

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the persons appearing, they signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'AN DEUX MILLE QUATORZE, LE VINGT-DEUX DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "Sardinvest S.A", une société anonyme

avec siège social à 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, constituée par acte de Maître Jean-Joseph Wagner,
notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg en date du 6 février 2011, publié au Mémorial Recueil Spécial
C numéro 896 du 5 avril 2012.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Alberto MORANDINI, administrateur de société, demeurant

professionnellement à Luxembourg, qui désigne comme secrétaire Monsieur Jean FAWE, employé, demeurant profes-
sionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Alberto MORANDINI prénommé.
Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital à raison de trois cent cinquante-six mille cinq cents Euro (EUR 356.500,-) pour le porter

de  trente-et-un  mille  Euros  (EUR  31.000,-)  à  trois  cent  quatre-vingt-sept  mille  cinq  cents  Euro  (EUR  387.500,-)  par
l’émission de trois mille cinq cent soixante-cinq (3.565) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros (EUR 100,-)
chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

2. Souscription de trois mille cinq cent soixante-cinq (3.565) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent Euros

(EUR 100,-) chacune, par Oslane United Corp, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social
à Morgan &amp; Morgan Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands et libération entière
des trois mille cinq cent soixante-cinq (3.565) actions nouvelles par la conversion en capital d’une créance certaine liquide
et exigible détenue par Oslane United Corp. envers la société d’un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf
mille quarante-neuf Euros et quatre-vingt-et-onze Cents (EUR 9.289.049,91), le montant de trois cent cinquante-six mille
cinq cents Euro (EUR 356.500,-) étant attribué au compte capital de la société et le montant de huit millions neuf cent
trente-deux mille cinq cent quarante-neuf Euros et quatre-vingt-et-onze Cents (EUR 8.932.549,91) étant attribué à un
compte de prime d’émission de la société.

3. Changement conséquent de l’alinéa 1 

er

 de l’article 3 des statuts qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500,-) divisé en trois

mille huit cent soixante-quinze (3.875) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, après avoir été signée "ne
varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau
et le notaire instrumentant, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’en-
registrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées

"ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant.

III.- Que la présente assemblée, réunissant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l’assemblée, celle-ci prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide d’augmenter le capital à raison de trois cent cinquante-six mille cinq cents Euro (EUR

356.500,-) pour le porter de trente-et-un mille Euros (EUR 31.000,-) à trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents Euro
(EUR 387.500,-) par l’émission de trois mille cinq cent soixante-cinq (3.565) actions nouvelles d’une valeur nominale de
cent Euros (EUR 100,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>Souscription - Libération

Est alors intervenue aux présentes:
Oslane United Corp, une société de droit des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Morgan &amp; Morgan

Building, P.O. Box 958, Pasea Estate, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, constituée selon la loi des sociétés
commerciales des Iles Vierges Britanniques en date du 20 mai 2010 sous le numéro 1586261,

ici représentée par Monsieur Alberto MORANDINI prénommé,résidant professionnellement à Luxembourg,
aux termes d’une procuration sous seing privé délivrée le 18 décembre 2014,

29391

L

U X E M B O U R G

La prédite procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant,

annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

lequel déclare souscrire aux trois mille cinq cent soixante-cinq (3.565) actions nouvelles d’une valeur nominale de cent

Euros (EUR 100,-) chacune et les libérer entièrement par la conversion en capital d’une créance certaine, liquide et exigible
détenue par Oslane United Corp à l’encontre de la société, d’un montant de neuf millions deux cent quatre-vingt-neuf
mille quarante-neuf Euros et quatre-vingt-et-onze Cents (EUR 9.289.049,91), le montant de trois cent cinquante-six mille
cinq cents Euro (EUR 356.500,-) étant attribué au compte capital de la société et le montant de huit millions neuf cent
trente-deux mille cinq cent quarante-neuf Euros et quatre-vingt-et-onze Cents (EUR 8.932.549,91) étant attribué à un
compte de prime d’émission de la société.

L'existence de ladite créance a été justifiée au notaire instrumentant dans un rapport établi par ARTEMIS, Audit &amp;

Advisory, by Mrs Someya Qalam, Réviseur d’Entreprises Agréé, on 22 December 2014, qui conclut comme suit:

“Conclusion:
Sur base de nos diligences, aucun fait n’a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale ainsi qu’à la prime d’émission des actions à émettre
en contrepartie.”

Ledit rapport restera, après avoir été signé "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentant, annexé aux

présentes pour être formalisé avec elles.

<i>Deuxième résolution

Par conséquent, l’assemblée générale décide de modifier l’alinéa 1 

er

 de l’article des statuts, qui aura désormais la

teneur suivante:

«  Art. 3. alinéa 1 

er

 .  Le capital social est fixé à trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cents euros (EUR 387.500,-)

divisé en trois mille huit cent soixante-quinze (3.875) actions d’une valeur nominale de cent euros (EUR 100,-) chacune.»

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société

à raison de la présente augmentation de capital est évalué à environ EUR 2.010,-.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate qu’à la demande du comparant, le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d’une traduction en français et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la
version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: A. MORANDINI, J. FAWE, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63570. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015016742/182.
(150019535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Bleu Book Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2518 Luxembourg, 54, rue Schetzel.

R.C.S. Luxembourg B 171.986.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société tenue le 20 janvier 2015 que Monsieur

Ferenc CSADI, demeurant à HU-2083, Solymár, Pacsirta utca 1/D, remplace jusqu'à l'assemblée générale annuelle à tenir
en 2018, l'administrateur démissionnaire Monsieur Antonio COSTA, demeurant à B-1000 Bruxelles, 121, avenue Franklin
Roosevelt.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015585/13.
(150018188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29392

L

U X E M B O U R G

LuxCo 82 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 139.223.

In the year two thousand and fourteen on the twenty-eighth day of November.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) Manco Spólka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia, a limited liability company organized under the laws of Poland,

having its registered office at 38D, Lopuszanska street, PL-02-232 Warsaw, registered with the National Court Register
under number KRS0000461649 (the “Shareholder 1”),

2) Mr. Wojciech Sobieraj, professionally residing at 8, Marii Ludwiki Gonzagi street, PL-01-985 Warsaw (the “Share-

holder 2”),

3) Mr. Niels Lundorff, professionally residing at 15/2301, Lucka street, PL-00-842 Warsaw (the “Shareholder 3”),
4) Mr. Cezary Smorszczewski, professionally residing at 14, Leonarda da vinci street, PL-05-520 Bielawa, Poland (he-

reafter referred to as the “Shareholder 4” and together with Shareholder 1, Shareholder 2, Shareholder 3 referred to as
the “Shareholders”) duly represented by Me Matthieu Groetzinger, lawyer, residing professionally at L-2132 Luxembourg
20, avenue Marie-Thérèse, by virtue of proxies.The said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder
acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the
purpose of registration.

The shareholders of Luxco 82 S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”),, having its

registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' register under number B 139.223, incorporated by a deed received by Maître Gérard
Lecuit, notary residing in Luxembourg on May 28 

th

 , 2008, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-

ciations  under  number  1595  on  June  28,  2008  and  amended  for  the  last  time  by  a  deed  received  by  Maître  Roger
Arrensdorff, notary residing at Luxembourg, on April 17, 2014 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations under number 1704 on July 2, 2014 (the “Company”).

The appearing parties, represented as stated above, declare and request the notary to:
I. state that according to the attendance list, the Shareholders representing the full amount of the corporate capital of

twelve thousand five hundred sixty two Euros and fifty cents (EUR 12,562.50) are present or validly represented at the
meeting. The meeting can thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda without there having
been a prior convening notice.

II. state that any capitalized term used herein and not defined shall have the meaning assigned to it in the articles of

association of the Company (the “Articles”).

III. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according

to the agenda below:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of twelve thousand three hundred Euros (EUR 12,300)

so as to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred sixty-two Euros and fifty cents (EUR 12,562.50)
to the amount of twenty four thousand eight hundred and sixty- two Euros fifty cents (EUR 24,862.50);

2. Subscription and payment of three hundred thirty-five thousand three hundred forty five (335,345) class J shares by

Shareholder 5 (as defined below), two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272) class J shares by
Shareholder 6 (as defined below), three hundred thirty five thousand three hundred forty five (335,345) class J shares by
Shareholder 7 (as defined below), forty eight thousand seven hundred sixty six (48,766) class J shares by Shareholder 8
(as defined below), two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272) class J shares by Shareholder 9
(as defined below) by a contribution in cash;

3. Reclassification of the class J shares into class J1 shares, class J2 shares, class J3 shares, class J4 shares, class J5 shares

and class J6 shares;

4. Decision to amend articles 6.1, 6.4, 6.5 and 19 of the Articles to reflect the above resolutions;
5. Any other business.

<i>First resolution

The Shareholders decide to increase the share capital of the Company by an amount of twelve thousand three hundred

Euros (EUR 12,300) so as to bring it from its present amount of twelve thousand five hundred and sixty two Euros fifty
cents  (EUR  12,562.50)  to  the  amount  of  twenty  four  thousand  eight  hundred  and  sixty  two  Euros  fifty  cents  (EUR
24,862.50).

29393

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The Shareholders decide to issue one million two hundred thirty thousand (1,230,000) class J shares with a par value

of one cent (EUR 0.01) each.

<i>Contributors' Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes:
1) Mr. Artur Maliszewski, professionally residing at 9H, Lanciego street, PL-02-792 Warsaw, Poland, represented by

Mr. Matthieu Groetzinger, prenamed, declares to subscribe for three hundred thirty five thousand three hundred forty
five (335,345) class J shares and to have them fully paid up by contribution in cash (the “Shareholder 5”)

2) Mr. Witold Skrok, professionally residing at 21/104 Dzielna street, PL-01-029 Warsaw, represented by Mr. Matthieu

Groetzinger, prenamed, declares to subscribe for two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272)
class J shares and to have them fully paid up by contribution in cash (the “Shareholder 6”).

3) Granya Limited, the company incorporated under the laws of the Republic Cyprus, having its registered office at 8

Michalaki Karaoli street, Anemomilos Building, 4 

th

 floor, flat/office 401, P.C 1095 Nicosia, registered on Cyprus under

the Registration Number HE 326464, represented by Mr. Matthieu Groetzinger, prenamed, declares to subscribe for
three hundred thirty five thousand three hundred forty five (335,345) class J shares and to have them fully paid up by
contribution in cash, (the “Shareholder 7”).

4) Mr. Adam Czestochowski, professionally residing at 8 Wolfganga A. Mozarta street, PL-05-126 Nieporet, Poland,

represented by Mr. Matthieu Groetzinger, prenamed, declares to subscribe for forty eight thousand seven hundred sixty
six (48,766) class J shares and to have them fully paid up by contribution in cash, (the “Shareholder 8”).

5) Ms. Katarzyna Sulkowska, professionally residing at 70 Waluszewska street, PL-03-005 Warsaw, Poland, represented

by Mr. Matthieu Groetzinger, prenamed, declares to subscribe for two hundred fifty five thousand two hundred seventy
two (255,272) class J shares and to have them fully paid up by contribution in cash, (the “Shareholder 9”).

All the newly subscribed shares have been fully paid up in cash by the prenamed subscribers, so that the total amount

of twelve thousand three hundred Euros (EUR 12,300) is at the disposal of the Company, as justified to the undersigned
notary.

<i>Third resolution

The Shareholders decide to reclassify the class J shares into class J1 shares, class J2 shares, class J3 shares, class J4

shares, class J5 shares and class J6 shares (together the “Classes of J Shares”).

<i>Fourth resolution

The Shareholders further resolve to allocate the Classes of J Shares, so that the shareholding relating to such Classes

of Shares will be divided as follows:

Shareholder 1 owns six hundred eighteen thousand seven hundred fifty (618,750) class J1 shares;
Shareholder 5 owns three hundred thirty five thousand three hundred forty five (335,345) class J2 shares;
Shareholder 6 owns two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272) class J3 shares;
Shareholder 7 owns three hundred thirty five thousand three hundred forty five (335,345) class J4 shares;
Shareholder 8 owns forty eight thousand seven hundred sixty six (48,766) class J5 shares; and
Shareholder 9 owns two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272) class J6 shares.

<i>Fifth resolution

As a consequence of the above resolutions, the Shareholders decide to amend articles 6.1, 6.5 and 19 of the Articles

which shall be read as follows:

“ Art. 6.1. The capital is fixed at twenty four thousand eight hundred and sixty two Euros fifty cents (EUR 24,862.50)

represented by one hundred eighty-seven thousand five hundred (187,500) class B tracking shares (the “Class B Shares”),
one hundred eighty-five thousand five hundred (187,500) class D tracking shares (the “Class D Shares”), two hundred
sixty two thousand five hundred (262,500) class F tracking shares (the “Class F Shares”), six hundred eighteen thousand
seven hundred fifty (618,750) class J1 tracking shares (the “Class J1 Shares”), three hundred thirty five thousand three
hundred forty five (335,345) class J2 tracking shares (the “Class J2 Shares”), two hundred fifty five thousand two hundred
seventy two (255,272) class J3 tracking shares (the “Class J3 Shares”), three hundred thirty five thousand three hundred
forty five (335,345) class J4 tracking shares (the “Class J4 Shares”), forty eight thousand seven hundred sixty six (48,766)
class J5 tracking shares (the “Class J5 Shares”), two hundred fifty five thousand two hundred seventy two (255,272) class
J6 tracking shares (the “Class J6 Shares” and together with Class B Shares, Class D Shares, Class F Shares, Class J1 Shares,
Class J2 Shares, Class J3 Shares, Class J4 Shares and Class J5 Shares referred to as the “Shares” and each class referred
to as a “Class of Shares”), with a par value of one cent (EUR 0.01) each, all fully paid-up.”

“ Art. 6.4. All the rights and obligations attached to each Class of Shares will be referred to as the “Tracked Portfolio”,

so that all the rights and obligations attached to the Class B Shares are referred to as the “Tracked Portfolio B”, all the

29394

L

U X E M B O U R G

rights and obligations attached to the Class D Shares are referred to as the “Tracked Portfolio D”, all the rights and
obligations attached to the Class F Shares are referred to as the “Tracked Portfolio F”, all the rights and obligations
attached to the Class J1 Shares are referred to as the “Tracked Portfolio J1”, all the rights and obligations attached to
the Class J2 Shares are referred to as the “Tracked Portfolio J2”, all the rights and obligations attached to the Class J3
Shares are referred to as the “Tracked Portfolio J3”, all the rights and obligations attached to the Class J4 Shares are
referred to as the “Tracked Portfolio J4”, all the rights and obligations attached to the Class J5 Shares are referred to as
the “Tracked Portfolio J5”, all the rights and obligations attached to the Class J6 Shares are referred to as the “Tracked
Portfolio J6”.

“ Art. 6.5. The Tracked Portfolios consist in the holding of a certain number of tracked incentive shares and tracked

incentive shares to be received as determined in any private Shareholders meeting of the Company (whose exact number
is determined hereunder) which are inalienable until the end of certain lock-up periods and are freely transferable once
these periods are over.

If the Tracked Portfolios attached to each relevant Class of Shares are not sold, they could be transferred to Share-

holders as an in kind redemption of each relevant Class of Shares (combined with a cash redemption or not).”

SHAREHOLDERS

TRACKED

PORTFOLIOS

Shareholder 1
-618,750 Class J1 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73,275

Shareholder 2
-262,500 Class F Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363,974

Shareholder 3
-187,500 Class D Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259,982

Shareholder 4
-187,500 Class B Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259,982

Shareholder 5
-335,345 Class J2 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,537

Shareholder 6
-255,272 Class J3 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103,935

Shareholder 7
-335,345 Class J4 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136,537

Shareholder 8
-48,766 Class J5 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19,855

Shareholder 9
-255,272 Class J6 Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103,935

“ Art. 19. The managers may at all times during the financial year resolve to distribute interim dividends in compliance

with the legal provisions.

The net profits of the Company shall be determined according to the Luxembourg law in force, and shall consist of

any revenue of any kind of the Tracked Portfolio and decreased by losses linked to each Tracked Portfolio and further
decreased by the Company's expenses. The net profits of the Company shall also include the net profits earned on revenue
received by the Company but not distributed by the Company, including the Portion of Profit to its Shareholders and on
any other assets of the Company, including the net profits of the assets held by the Company and not included in the
Tracked Portfolios to be distributed on a pro-rata basis of the Tracked Portfolio held by each Shareholder at the date
the Tracked Portfolio has been allocated to the said Shareholder.

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization

and expenses represent the net profit.

The amount representing the five percent deduction as mentioned under article 18 of the articles of association of the

Company will be supported as follows:

- by the net profits of the Tracked Portfolio B, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class B Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio D, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class D Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio F, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class F Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio J1, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J1 Shares in

the corporate capital of the Company;

29395

L

U X E M B O U R G

- by the net profits of the Tracked Portfolio J2, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J2 Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio J3, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J3 Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio J4, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J4 Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio J5, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J5 Shares in

the corporate capital of the Company;

- by the net profits of the Tracked Portfolio J6, as defined hereafter, in proportion to the quota of Class J6 Shares in

the corporate capital of the Company;

If the net profits of one Tracked Portfolio are not sufficient to support the quota as calculated here before (such

Tracked Portfolio being referred to as the “Defaulting Tracked Portfolio”), the amount to be allocated to the legal reserve
fund in excess of the net profits of the Defaulting Tracked Portfolio is temporarily supported by the other Tracked
Portfolios.

The amount representing the quota to be supported by the Defaulting Tracked Portfolio the following financial year

will be increased by the amount temporarily supported by the other Tracked Portfolio, while the amount representing
the quota to be supported by the other Tracked Portfolio the following financial year will be decreased by the amount
temporarily supported by the other Tracked Portfolio.

The following provisions apply to any distribution of dividends, including interim dividends:
Total net profits and losses as determined and approved by all the Shareholders shall be allocated according to the

following basic rules.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio B or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated by
the Tracked Portfolio B that are not immediately distributed to the holder of Class B Shares will be allocated 100% to
the holder of Class B Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio D or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio D that are not immediately distributed to the holder of Class D Shares will be allocated 100%
to the holder of Class D Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio F or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated by
the Tracked Portfolio F that are not immediately distributed to the holder of Class F Shares will be allocated 100% to
the holder of Class F Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J1 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J1 that are not immediately distributed to the holder of Class J1 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J1 Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J2 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J2 that are not immediately distributed to the holder of Class J2 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J2 Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J3 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J3 that are not immediately distributed to the holder of Class J3 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J3 Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J4 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J4 that are not immediately distributed to the holder of Class J4 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J4 Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J5 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J5 that are not immediately distributed to the holder of Class J5 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J5 Shares.

The net profits and losses realized by the Company and resulting directly or indirectly from the assets being part of

the Tracked Portfolio J6 or resulting from any other net income derived by the Company out of the profits generated
by the Tracked Portfolio J6 that are not immediately distributed to the holder of Class J6 Shares will be allocated 100%
to the holder of Class J6 Shares.

Any other net profits and losses realized by the Company will be allocated to the Shareholders in proportion to their

percentage of Shares of total capital in the Company. Any amount to be distributed may be paid in any currency selected

29396

L

U X E M B O U R G

by the board of managers and may be paid at such places and times as may be determined by the board of managers. The
board of managers may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the
currency of their payment.

All items comprising net profits and losses resulting from each Tracked Portfolio and any other net profits and losses

of the Company shall be respectively and separately shown in the Company's financial statements.

In case of losses of one Tracked Portfolio (hereafter referred to as “Loss Defaulting Tracked Portfolio”), the dividends

to be paid in the framework of the other Tracked Portfolio may not exceed the amount representing the total net profits
of the Company in any financial year. The following financial year, the amount representing the net profits of the other
Tracked Portfolio in excess of the net profits of the Company which could not be distributed the preceding financial year
due to the losses of the Loss Defaulting Tracked Portfolio will be deducted from the results of the Loss Defaulting Tracked
Portfolio and allocated to the results of the other Tracked Portfolio for the purpose of determining the total amounts
that can be distributed with respect to each Tracked Portfolio.

In any case, the dividends distributed to Shareholder 1 shall only derive from net profits obtained by the Tracked

Portfolio J1. Likewise, the dividends distributed to Shareholder 2 shall only derive from net profits obtained by Tracked
Portfolio F. The dividends distributed to Shareholder 3 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio
D. The dividends distributed to Shareholder 4 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio B. The
dividends distributed to Shareholder 5 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio J2. The dividends
distributed to Shareholder 6 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio J3. The dividends distributed
to Shareholder 7 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio J4. The dividends distributed to Sha-
reholder 8 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio J5. The dividends distributed to Shareholder
9 shall only derive from net profits obtained by Tracked Portfolio J6.

Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:
- Interim accounts are established by the board of managers,
- These accounts show a profit including profits carried forward,
- The decision to pay interim dividends is taken by an ordinary general meeting of the Shareholders,
- The payment is made once the Company has obtained the assurance that the rights of the significant creditors of the

Company are not threatened.”

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with it's the present deed have been estimated at about EUR 1030.- (thousand thirty euros).

With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is

closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.

Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary

by his surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary,
the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le vingt-huit novembre,
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

Ont comparu:

1) MANCO SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, une société à responsabilité limitée constitué

et organisé sous les lois polonaises, ayant son siège social à 38D, Lopuszanska street, PL-02- 232 Varsovie, Pologne,
immatriculée auprès du National Court Register sous le numéro KRS0000461649 (l’“Associé 1”),

2) Monsieur Wojciech SOBIERAJ, résidant professionnellement au 8, Marii Ludwiki Gonzagi street, PL-01-985 Varsovie,

Pologne (l’“Associé 2”),

3) Monsieur Niels LUNDORFF, résidant professionnellement au 15/2301, Lucka street, PL-00-842 Varsovie, Pologne

(l’“Associé 3”),

4) Monsieur Cezary SMORSZCZEWSKI, résidant professionnellement au 14, Leonarda da vinci street, PL-05-520

Bielawa, Pologne (ci-après dénommé l’“Associé 4” et ensemble avec l’Associé 1, l’Associé 2, et l’Associé 3 dénommés les
“Associés”),

ici représentés par Me Matthieu GROETZINGER, avocat, demeurant professionnellement à L-2132 Luxembourg, 20,

avenue Marie-Thérèse, en vertu de procurations données sous seing privé.

29397

L

U X E M B O U R G

Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant pour le compte des comparants

et par le notaire instrumentant, resteront annexées aux présentes pour les besoins de l’enregistrement.

Les associés de la société Luxco 82 S.à r.l., une société a responsabilité limitée, ayant son siège social à 46A, Avenue

J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 139.223, constituée par acte reçu le 28 mai 2008 par Maître Gérard Lecuit,
notaire de résidence à Luxembourg, publié le 28 juin 2008 au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations sous le
numéro 1595 le 28 juin 2008, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par un acte reçu par Maître Roger
Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, le 17 avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Asso-
ciations sous le numéro 1704 le 2 juillet 2014 (ci-après désignée la «Société»).

Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont déclaré et demandé au notaire:
I. d'acter que conformément à la liste de présence, tous les Associés, représentant l’ensemble du capital social de

douze mille cinq cent soixante deux euros et cinquante cents (12.562,50 EUR), sont présents ou valablement représentés
à l’assemblée. L'assemblée peut donc valablement délibérer et se prononcer sur l’ordre du jour sans convocation préalable.

II. de déclarer que tous les termes en majuscule utilisés dans le présent acte et non définis ont le sens qui leur est

donné dans les statuts de la Société (les «Statuts»).

III. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l’intérêt de la Société, conformément à l’agenda ci-

dessous:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social souscrit de la Société d'un montant de douze mille trois cents euros (12.300,00 EUR)

afin de le porter de son montant actuel fixé à douze mille cinq cent soixante-deux euros et cinquante cent (12.562,50
EUR) à un montant de vingt-quatre mille huit cent soixante deux euros et cinquante cent (24.862,50 EUR);

2. Souscription et paiement de trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq (335.345) parts sociales de catégorie

J par l’Associé 5 (tel que défini ci-dessous), deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze (255.272) parts
sociales de catégorie J par l’Associé 6 (tel que défini ci-dessous), trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq
(335.345) parts sociales de catégorie J par l’Associé 7 (tel que défini ci-dessous), quarante-huit mille sept cent soixante-
six (48.766) parts sociales de catégorie J par l’Associé 8 (tel que défini ci-dessous), deux cent cinquante-cinq mille deux
cent soixante-douze (255.272) parts sociales de catégorie J par l’Associé 9 (tel que défini ci-dessous) par un apport en
numéraire;

3. Reclassement des parts sociales de catégorie J en parts sociales de catégorie J1, parts sociales de catégorie J2, parts

sociales de catégorie J3, parts sociales de catégorie J4, parts sociales de catégorie J5 et parts sociales de catégorie J6;

4. Décision de modification des articles 6.1, 6.4, 6.5 et 19 des Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus;
5. Divers.

<i>Première résolution

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de douze mille trois cents euros (12.300

EUR) afin de le porter de son montant actuel de douze mille cinq cent soixante- deux euros et cinquante cents (12.562,50
EUR) à un montant de vingt-quatre mille huit cent soixante-deux euros et cinquante cents (24.862,50 EUR).

<i>Deuxième résolution

Les Associés décident d'émettre un million deux cent trente mille (1.230.000) parts sociales de catégorie J d'une valeur

de un cent (0,01 EUR) chacune.

<i>Intervention de l'apporteur - Souscription - Libération

Intervient alors:
1) Mr. Artur Maliszewski, demeurant professionnellement à 9H, Lanciego street, PL-02-792 Varsovie, Pologne, repré-

senté par Maître Matthieu GROETZINGER, déclare souscrire à trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq
(335.345) parts sociales de catégorie J et de les avoir entièrement libérées par apport en numéraire (l’“Associé 5”),

2) Mr. Witold Skrok, demeurant professionnellement à 21/104 Dzielna street, PL-01-029 Varsovie, Pologne, représenté

par  Maître  Matthieu  GROETZINGER,  déclare  souscrire  à  deux  cent  cinquante-cinq  mille  deux  cent  soixante-douze
(255.272) parts sociales de catégorie J et de les avoir entièrement libérées par apport en numéraire (l’“Associé 6”),

3) GRANYA LIMITED, une société régie par les lois de la République Chypriote, ayant son siege social à 8 Michalaki

Karaoli street, Anemomilos Building, 4 

th

 floor, flat/office 401, P.C 1095 Nicosia, enregistrée à Chypre sous le numéro

HE326464, représenté par Maître Matthieu Groetzinger, déclare souscrire à trois cent trente-cinq mille trois cent qua-
rante-cinq (335.345) parts sociales de catégorie J et de les avoir entièrement libérées par apport en nature (l’“Associé
7”),

4) Mr. Adam Czestochowski, demeurant professionnellement à 8 Wolfganga A. Mozarta street, PL-05-126 Nieporet,

Pologne représenté par Maître Matthieu GROETZINGER, déclare souscrire à quarante-huit mille sept cent soixante-six
(48.766) parts sociales de catégorie J et de les avoir entièrement libérées par apport en numéraire (l’“Associé 8”),

29398

L

U X E M B O U R G

5) Mme. Katarzyna Sulkowska, demeurant professionnellement à 70 Waluszewska street, PL-03-005 Warsaw, Pologne

représenté par Maître Matthieu GROETZINGER, déclare souscrire à deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-
douze (255.272) parts sociales de catégorie J et de les avoir entièrement libérées par apport en numéraire (l’“Associé
9”),

Toutes les nouvelles parts sociales souscrites ont été intégralement libérées en espèces par les souscripteurs nommés

ci-dessus, de sorte que le montant total de douze mille trois cents euros (EUR 12.300,-) est à la disposition de la Société,
tel que justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de reclasser les parts sociales de catégorie J en parts sociales de catégorie J1, parts sociales de

catégorie J 2, parts sociales de catégorie J3, parts sociales de catégorie J4, parts sociales de catégorie J5 et parts sociales
de classe J6 (collectivement, les “Parts Sociales de Catégorie J”).

<i>Quatrième résolution

Les Associés décident d'allouer les Parts Sociales de Catégorie J, de sorte que la participation relative à ces catégories

de parts sociales sera divisée comme suit:

L'Associé 1 détient six cent dix-huit mille sept cent cinquante (618.750) parts sociales de catégorie J1;
L'Associé 5 détient trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq (335.345) parts sociales de catégorie J2;
L'Associé 6 détient deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze (255.272) parts sociales de catégorie J3;
L'Associé 7 détient trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq (335.345) parts sociales de catégorie J4;
L'Associé 8 détient quarante-huit mille sept cent soixante-six (48.766) parts sociales de catégorie J5; et
L'Associé 9 détient deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze (255.272) parts sociales de catégorie J6.

<i>Cinquième résolution

En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier les articles 6.1, 6.5 et 19 des Statuts

comme suit:

“ Art. 6.1. Le capital social est fixé à vingt-quatre mille huit cent soixante-deux euros et cinquante cents (24.862,50

EUR) représenté par cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) parts sociales traçantes de catégorie B (ci-après
désignées les “Parts Sociales de Catégorie B”), cent quatre-vingt-sept mille cinq cents (187.500) parts sociales traçantes
de catégorie D (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie D”), deux cent soixante-deux mille cinq cents (262.500)
parts sociales traçantes de catégorie F (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie F”), six cent dix-huit mille sept
cent cinquante (618.750) parts sociales traçantes de catégorie J1 (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie J1”),
trois cent trente-cinq mille trois cent quarante-cinq (335.345) parts sociales traçantes de catégorie J2 (ci-après désignées
les “Parts Sociales de Catégorie J2”), deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze (255.272) parts sociales
traçantes de catégorie J3 (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie J3”), deux cent trente-cinq mille trois cent
quarante-cinq (335.345) parts sociales traçantes de catégorie J4 (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie J4”),
quarante huit mille sept cent soixante-six (48.766) parts sociales traçantes de catégorie J5 (ci-après désignées les “Parts
Sociales de Catégorie J5”), deux cent cinquante-cinq mille deux cent soixante-douze (255.272) parts sociales traçantes
de catégorie J6 (ci-après désignées les “Parts Sociales de Catégorie J6”), et les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts
Sociales de Catégorie D, les Parts Sociales de Catégorie F, les Parts Sociales de Catégorie J1, les Parts Sociales de Catégorie
J2, les Parts Sociales de Catégorie J3, les Parts Sociales de Catégorie J4, et les Parts Sociales de Catégorie J5 seront
ensemble désignées les «Parts Sociales» et chaque catégorie sera ci-après désignée comme une «Catégorie de Parts
Sociales»), avec une valeur nominale d'un cent (EUR 0,01), toutes ayant été intégralement libérées.»

« Art. 6.4. Tous les droits et obligations attachés à chacune des Classes de Parts Sociales sont désignés comme étant

les «Portefeuilles Tracés» de sorte que tous les droits et obligations attachés aux Parts Sociales de Catégorie B sont
désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés B», tous les droits et obligations attachés aux Parts Sociales de Catégorie
D sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés D», tous les droits et obligations attachés aux Parts Sociales de
Catégorie F sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés F», tous les droits et obligations attachés aux Parts
Sociales de Catégorie J1 sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés J1», tous les droits et obligations attachés
aux Parts Sociales de Catégorie J2 sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés J2», tous les droits et obligations
attachés aux Parts Sociales de Catégorie J3 sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés J3», tous les droits et
obligations attachés aux Parts Sociales de Catégorie J4 sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés J4», tous les
droits et obligations attachés aux Parts Sociales de Catégorie J5 sont désignés comme étant les «Portefeuilles Tracés J5»,
tous les droits et obligations attachés aux Parts Sociales de Catégorie J6 sont désignés comme étant les «Portefeuilles
Tracés J6».»

« Art. 6.5. Les Portefeuilles Tracés consistent en la détention d'un certain nombre de parts sociales incitatives tracées

et de parts sociales incitatives tracées à recevoir comme déterminé dans toute assemblée générale sous seing privé des
associés de la Société (dont le nombre exact est déterminé ci-dessous), lesquelles sont inaliénables jusqu'à la fin de
différentes périodes de blocage et seront librement cessibles lorsque ces périodes seront terminées.

29399

L

U X E M B O U R G

Si les Portefeuilles Tracés attachés à chaque Catégorie de Parts Sociales particulière ne sont pas vendus, ils pourront

être transférés aux Associés par rachat en nature de chaque Catégorie de Parts Sociales particulière (combiné ou non à
un rachat en numéraire).»

ASSOCIES

PORTEFEUILLES

TRACES

Associé 1
-618.750 Parts Sociales de Catégorie J1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73.275

Associé 2
-262.500 Parts Sociales de Catégorie F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

363.974

Associé 3
-187.500 Parts Sociales de Catégorie D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259.982

Associé 4
-187.500 Parts Sociales de Catégorie B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

259.982

Associé 5
-335.345 Parts Sociales de Catégorie J2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.537

Associé 6
-255.272 Parts Sociales de Catégorie J3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.935

Associé 7
-335.345 Parts Sociales de Catégorie J4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

136.537

Associé 8
-48.766 Parts Sociales de Catégorie J5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19.855

Associé 9
-255.272 Parts Sociales de Catégorie J6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103.935

“ Art. 19. Les gérants peuvent à tout moment pendant l’exercice social décider de distribuer des dividendes intérimaires

en conformité avec les dispositions légales.

Les bénéfices nets de la Société seront être déterminés en conformité avec les lois luxembourgeoises en vigueur, et

consisteront en tout type de revenu du Portefeuille Tracé diminué des pertes liées à chaque Portefeuille Tracé et diminué
encore des charges de la Société. Les bénéfices nets de la Société incluront en outre les bénéfices nets réalisés par les
revenus reçus par la Société mais non distribués par la Société, incluant la Partie de Bénéfice à ses Associés et sur tout
autre actifs de la Société, incluant les bénéfices nets réalisés par les actifs détenus par la Société et non compris dans les
Portefeuilles Tracés à distribuer au prorata du Portefeuille Tracé détenu par chaque Associé à la date à laquelle le Por-
tefeuille Tracé a été alloué au dit Associé.

Les bénéfices bruts de la Société constatés dans les comptes annuels, après déduction des dépenses générales, des

amortissements et des dépenses représentent le bénéfice net.

Le montant représentant la déduction de cinq pourcent telle que mentionnée sous l’article 18 des statuts de la Société

seront financés comme suit:

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé B, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie B dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé D, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie D dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé F, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie F dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J1, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J1 dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J2, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J2 dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J3, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J3 dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J4, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J4 dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J5, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J5 dans le capital social de la Société;

- par les bénéfices nets du Portefeuille Tracé J6, tel que définis ci-après, proportionnellement au quota de Parts Sociales

de Catégorie J6 dans le capital social de la Société;

Si les bénéfices nets résultant d'un Portefeuille Tracé ne sont pas suffisants pour financer le quota tel que calculé ci-

avant (un tel Portefeuille Tracé étant désigné comme le «Portefeuille Tracé Défaillant»), le montant à allouer à la réserve

29400

L

U X E M B O U R G

légale excédant les bénéfices nets du Portefeuille Tracé Défaillant est temporairement financé par les autres Portefeuilles
Tracés.

Le montant représentant le quota devant être financé par le Portefeuille Tracé Défaillant au cours de l’exercice social

suivant sera augmenté du le montant temporairement financé par un autre Portefeuille Tracé, tandis que le montant
représentant le quota à être financé par l’autre Portefeuille Tracé au cours de l’exercice social suivant sera diminué par
le montant temporairement financé par cet autre Portefeuille Tracé.

Les dispositions suivantes s'appliquent toutes les distributions de dividendes, y compris les dividendes intérimaires.
Le total net des profits et des pertes tel que déterminé et approuvé par les Associés sera alloué conformément aux

règles de base suivantes. Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des
actifs faisant parti du Portefeuille Tracé B ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion
des profits générés par le Portefeuille Tracé B qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales
de Catégorie B seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie B.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé D ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé D qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie D
seront alloués à c 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie D.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé F ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé F qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie F
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie F.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J1 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J1 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J1
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J1.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J2 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J2 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J2
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J2.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J3 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J3 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J3
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J3.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J4 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J4 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J4
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J4.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J5 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J5 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J5
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J5.

Les profits et pertes nets réalisés par la Société et résultant directement ou indirectement des actifs faisant parti du

Portefeuille Tracé J6 ou résultant de n'importe quel autre revenu réalisé par la Société à l’exclusion des profits générés
par le Portefeuille Tracé J6 qui n'ont pas été immédiatement distribués au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J6
seront alloués à 100% au détenteur des Parts Sociales de Catégorie J6.

Tout autre profit et perte net réalisé par la Société seront alloués aux Associés proportionnellement au pourcentage

des Parts Sociales qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Tout montant devant être distribué sera payé dans
la devise déterminée par le conseil de gérance et payé aux lieux et temps déterminés par le conseil de gérance. Le conseil
de gérance pourra faire la détermination finale du taux de change applicable afin de convertir les fonds des dividendes
dans la devise déterminée pour leur paiement.

Tous les éléments comprenant les profits et pertes nets résultant de chaque Portefeuille Tracé et de tous autres profits

et pertes nets de la Société seront respectivement et séparément constatés dans les états financiers de la Société.

Dans le cas de pertes résultant d'un Portefeuille Tracé (ci-après désignées comme une «Perte d'un Portefeuille Tracé

Défaillant»), les dividendes à payer dans le cadre d'un autre Portefeuille Tracé n'excédera pas le montant représentant
le total des bénéfices nets de la Société au cours de chaque exercice social. Au cours de l’exercice social suivant, le
montant représentant les bénéfices nets d'un autre Portefeuille Tracé supérieur aux profits nets de la Société qui n'auraient
pas pu être distribués au cours de l’exercice social précédent à cause des pertes résultantes de la Perte d'un Portefeuille
Tracé Défaillant seront déduits des résultats de la Perte du Portefeuille Tracé Défaillant et alloués aux résultats de l’autre
Portefeuille Tracé afin de déterminer les montants totaux pouvant être distribués à chaque Portefeuille Tracé.

29401

L

U X E M B O U R G

Dans tous les cas, les dividendes distribués à l’Associé 1 proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé

J1. De même, les dividendes distribués à l’Associé 2 proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé F. Les
dividendes distribués à l’Associé 3 proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé D. Les dividendes
distribués à l’Associé 4 proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé B. Les dividendes distribués à
l’Associé 5 proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé J2. Les dividendes distribués à l’Associé 6
proviendront des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé J3. Les dividendes distribués à l’Associé 7 proviendront
des profits nets réalisés par le Portefeuille Tracé J4. Les dividendes distribués à l’Associé 8 proviendront des profits nets
réalisés par le Portefeuille Tracé J5. Les dividendes distribués à l’Associé 9 proviendront des profits nets réalisés par le
Portefeuille Tracé J6.

Les dividendes intérimaires seront distribués, à tout moment, sous les conditions suivantes:
- Les comptes intérimaires sont établis par le conseil de gérance,
- Ces comptes montrent un profit incluant les profits reportés,
- La décision de payer des dividendes intérimaires est prise en assemblée générale ordinaire des Associés,
- Le paiement est fait une fois que la Société a obtenu la garantie que les droits des créanciers importants de la Société

ne sont pas menacés.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de son augmentation de capital, s'élève à environ 1030,-EUR (mille trente euros).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, l’assemblée a levé la

séance. Le notaire instrumentant qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande des parties compa-
rantes  le  présent  acte  est  rédigé  en  langue  anglaise  suivie  d'une  version  française;  sur  demande  des  mêmes  parties
comparantes et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu et traduit en un langage connu des parties comparantes, connues du notaire par leur prénom,

nom, état civil et domicile, lesdites parties comparantes ont signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: GROETZINGER, VOLODINE, UMBDENSTOCK, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 5 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 58081. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Référence de publication: 2015015929/536.
(150018513) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Jewel HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 651.543,07.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 173.021.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1) AIF VII Euro Holdings, L.P., a Cayman Islands exempted limited partnership, having its registered office at c/o Walkers

SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Cayman Islands, duly represented
by its general partner Apollo Advisors VII (EH), L.P., represented by its general partner Apollo Advisors VII (EH-GP), Ltd.

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301133,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301136,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

29402

L

U X E M B O U R G

4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301138,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301140,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301143,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301146,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301150,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301155,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5301159,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5369804,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

12) AP Jewel Holdings (EH-11), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5590448,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

13) AP Jewel Holdings (EH-12), LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at Corporation

Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, with registration number 5590459,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

14) Mr. Justin Stead, residing at Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

15) Mr. Thomas J. O'Neill, residing at 6 Stonehurst Common, NH 03755 Hanover, USA,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

16) Mr. Anthony Broderick, residing at 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

17) Ms. Ruth Benford, residing at 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

18) Mr. Craig Bolton, residing at 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne &amp; Wear, NE21 5SF, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

19) Mr. James Crichton, residing at 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, England,

29403

L

U X E M B O U R G

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

20) Kesef Investments LLC, a limited liability company incorporated in the State of North Carolina, having its registered

office at 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, North Carolina 27612,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

21) Mr. Hugh Brian Duffy, residing at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

22) Mr. François Le Troquer, residing at 14 Cygnet House, 188 Kings Road, London SW3 5XR, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

23) Ms. Lucy Maitland Walker, residing at 3 Weir Road, Kibworth Be, England,
here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal,

24) Duffy Management and Investments Ltd., a private limited company incorporated and existing under the laws of

England and Wales, registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 07852968, having
its registered office at 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, England,

here represented by Ms Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under

private seal.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  parties  are  all  the  shareholders  of  Jewel  Holdco  S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”),  a  société  à

responsabilité limitée, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 173 021, incorporated
pursuant to a notarial deed of the notary Henri Hellinckx, prenamed, on 22 November 2012, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 8, dated 2 January 2013. The articles of association have last been amended
through a deed of the notary Henri Hellinckx, prenamed, on 25 August 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, number 2787, dated 8 October 2014.

The appearing parties, representing the whole corporate capital, requested the undersigned notary to act that the

agenda is as follows:

<i>Agenda

1) Acceptance of Mr. Anders Romberg as new shareholder.
2) Decision to increase the Company's share capital from its current amount of six hundred forty-eight thousand four

hundred forty Pounds Sterling and thirty-one Pence (GBP 648,440.31) up to six hundred fifty-one thousand five hundred
forty-three Pounds Sterling and seven Pence (GBP 651,543.07) through the issue of new B Ordinary Shares, Preference
Shares and C Ordinary Shares.

3) Decision to amend the article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:
"The Company's share capital is set at six hundred fifty-one thousand five hundred forty-three Pounds Sterling and

seven Pence (GBP 651,543.07) represented by one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one (1,239,051) A
Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixty-three million six hundred eighty-
four thousand six (63,684,006) Preference Shares, fifty-five thousand forty-three (55,043) B Ordinary Shares and one
hundred seventy thousand six hundred twenty-two (170,622) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence
(GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or of

the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles”.

4) Miscellaneous.
The appearing parties, represented as stated above, representing the entire share capital, take the following resolutions:

<i>First resolution

The extraordinary general meeting decides to accept Mr. Anders Romberg, born in Hel Trefaldiga - Uppsala, Sweden

on 29 June 1963, residing at 44 Brunswick Gardens Flat 1, SW8 2FW, United Kingdom, as new shareholder.

<i>Second resolution

The extraordinary general meeting decides to increase the Company's share capital from its current amount of six

hundred forty-eight thousand four hundred forty Pounds Sterling and thirty-one Pence (GBP 648,440.31) represented by
one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one (1,239,051) A Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-
five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixty-three million four hundred eleven thousand seven hundred eighty-four (63,411,784)

29404

L

U X E M B O U R G

Preference Shares, forty-nine thousand four hundred eighty-seven (49,487) B Ordinary Shares and one hundred thirty-
eight thousand one hundred twenty-four (138,124) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01)
each, up to six hundred fifty-one thousand five hundred forty-three Pounds Sterling and seven Pence (GBP 651,543.07)
through the issue of five thousand five hundred fifty-six (5,556) B Ordinary Shares, two hundred seventy-two thousand
two hundred twenty-two (272,222) Preference Shares and thirty-two thousand four hundred ninety-eight (32,498) C
Ordinary Shares having a nominal value of one Pence (GBP 0.01) each, to be paid by a contribution in cash.

The newly issued shares are subscribed and fully paid up as follows:
Five  thousand  five  hundred  fifty-six  (5,556)  B  Ordinary  Shares,  two  hundred  seventy-two  thousand  two  hundred

twenty-two (272,222) Preference Shares and thirty-two thousand four hundred ninety-eight (32,498) C Ordinary Shares
are subscribed and fully paid up by Mr. Anders Romberg, prenamed, by a contribution in cash of two hundred sixty-nine
thousand nine hundred sixty-two Pounds Sterling and thirty-three Pence (GBP 269,962.33).

Of the total subscription price of two hundred sixty-nine thousand nine hundred sixty-two Pounds Sterling and thirty-

three Pence (GBP 269,962.33), three thousand one hundred two Pounds Sterling and seventy-six Pence (GBP 3,102.76)
shall be allocated to the share capital of the Company and two hundred sixty-six thousand eight hundred fifty-nine Pounds
Sterling and fifty-seven Pence (GBP 266,859.57) shall be allocated to the share premium account.

The amount of two hundred sixty-nine thousand nine hundred sixty-two Pounds Sterling and thirty-three Pence (GBP

269,962.33) is as now available to the Company as has been proved to the undersigned notary.

As a consequence, Mr. Anders Romberg, prenamed, represented by Ms. Alina Rymalova, Rechtsanwältin, residing in

Luxembourg,  by  virtue  of  a  proxy  given  under  private  seal,  participates  in  the  extraordinary  general  meeting  of  the
Company and will vote on the following resolutions.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Third resolution

As a consequence of the above resolution, the extraordinary general meeting decides to amend article 5 of the articles

of incorporation of the Company to read as follows:

“ Art. 5. Capital.
5.1. The Company's share capital is set at six hundred fifty-one thousand five hundred forty-three Pounds Sterling and

seven Pence (GBP 651,543.07) represented by one million two hundred thirty-nine thousand fifty-one (1,239,051) A
Ordinary Shares, five thousand five hundred eighty-five (5,585) A1 Ordinary Shares, sixty-three million six hundred eighty-
four thousand six (63,684,006) Preference Shares, fifty-five thousand forty-three (55,043) B Ordinary Shares and one
hundred seventy thousand six hundred twenty-two (170,622) C Ordinary Shares having a nominal value of one Pence
(GBP 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2. The share capital may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the sole shareholder or

of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.”

<i>Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to EUR 2,500.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and
in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, known to the notary by name, first name,

civil status and residence, the said proxyholder of the person appearing signed together with the notary the present deed.

Follows the French translation of the preceding deed

L'an deux mille quatorze, le dix-huit décembre.
Par-devant nous, Maître Henri Hellinckx, notaire, de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

ONT COMPARU:

1) AIF VII Euro Holdings, L.P., un exempted limited partnership existant selon les lois des Îles Caïmans, ayant son siège

social à c/o Walkers SPV Limited, Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9002, Îles Caïmans,
représenté par son commandité Apollo Advisors VII (EH), L.P., représenté par son commandité Apollo Advisors VII (EH-
GP), Ltd.,

représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

29405

L

U X E M B O U R G

2) AP Jewel Holdings (EH-1), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301133,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

3) AP Jewel Holdings (EH-2), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301136,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

4) AP Jewel Holdings (EH-3), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301138,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

5) AP Jewel Holdings (EH-4), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301140,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

6) AP Jewel Holdings (EH-5), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301143,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

7) AP Jewel Holdings (EH-6), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301146,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

8) AP Jewel Holdings (EH-7), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301150,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

9) AP Jewel Holdings (EH-8), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant son

siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous le
numéro 5301155,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

10) AP Jewel Holdings (EH-9), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant

son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5301159,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

11) AP Jewel Holdings (EH-10), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant

son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5369804,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

12) AP Jewel Holdings (EH-11), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant

son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5590448,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

13) AP Jewel Holdings (EH-12), LLC, une limited liability company existant selon les lois de l'Etat du Delaware, ayant

son siège social à Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, sous
le numéro 5590459,

29406

L

U X E M B O U R G

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

14) M. Justin Stead, résidant au Halo House, 27 Windsor Road, Gerrards Cross, Bucks, SL9 7ND, England,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

15) M. Thomas J. O'Neill, résidant au 6 Stonehurst Common, Hanover, NH 03755, Etats-Unis,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

16) M. Anthony Broderick, résidant au 5 Bridgnorth Road, Stourton, Stourbridge, DY7 6RP, Angleterre,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

17) Mme Ruth Benford, résidant au 50 Marigold Lane, Mountsorrel, Loughborough, LE12 7FP, Angleterre,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

18) M. Craig Bolton, résidant au 4 Sandmill Mews, Winlaton, Tyne &amp; Wear, NE21 5SF, Angleterre,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

19) M. James Crichton, résidant au 67 Northampton Road, Towcester, Northants, NN12 7AH, Angleterre,
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

20) Kesef Investments LLC, une société à responsabilité limitée existant sous les lois de l'Etat de la Caroline du Nord,

ayant son siège social à 3605 Glenwood Avenue, Ste. 500, Raleigh, Wake County, Caroline du Nord 27612,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

21) M. Hugh Brian Duffy, résidant au 13 Denbigh Gardens, Richmond, London, TW10 6EN, England
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

22) M. François Le Troquer, résidant au 14 Cygnet House, 188 Kings Road, London SW3 5XR, England
représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

23) Mme Lucy Maitland Walker, résidant au 3 Weir Road, Kibworth Be, England,
représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé,

24) Duffy Management and Investments Ltd., une private limited liability company existant selon les lois de l'Angleterre

et du Pays de Galles, immatriculée auprès du Registrar of Companies for England and Wales sous le numéro 07852968,
ayant son siège social 13 Denbigh Gardens, Richmond, London TW10 6EN, Angleterre,

représentée par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée

sous seing privé.

Les procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparants et par le notaire, resteront annexées au

présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparants sont tous les associés de Jewel Holdco S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité

limitée, ayant son siège social 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 173 021, constituée selon acte reçu
par le notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 22 novembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 8 en date du 2 janvier 2013. Les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par le
notaire Henri Hellinckx, prénommé, en date du 25 août 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2787 en date du 8 octobre 2014.

Lesdites comparantes, représentant l'intégralité du capital social, demandent au notaire soussigné de constater que

l'ordre du jour est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation de M. Anders Romberg en qualité de nouvel associé.
2. Décision d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de six cent quarante-huit mille quatre

cent quarante livres sterling et trente-et-un pence (GBP 648.440,31) à un montant de six cent cinquante-et-un mille cinq
cent quarante-trois livres sterling et sept pence (GBP 651.543,07) par l'émission d'Actions Ordinaires A, Actions de
Préférence et Actions Ordinaires C.

3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

29407

L

U X E M B O U R G

«Le capital social de la Société est fixé à six cent cinquante-et-un mille cinq cent quarante-trois livres sterling et sept

pence (GBP 651.543,07) représenté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante-et-un (1.239.051) Actions Or-
dinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Actions Ordinaires A1, soixante-trois millions six cent quatre-
vingt-quatre mille six (63.684.006) Actions de Préférence, cinquante-cinq mille quarante-trois (55.043) Actions Ordinaires
B et cent soixante-dix mille six cent vingt-deux (170.622) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP
0,01) chacune, intégralement souscrites et libérées.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés prise dans

les conditions requises pour une modification des présents Statuts.»

4. Divers.
Les comparants, précités ci-dessus, représentant l'intégralité du capital social, prennent les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'accepter en qualité de nouvel associé M. Anders Romberg,

né à Hel Trefaldiga - Uppsala, Suède, le 29 juin 1963, résidant au 44 Brunswick Gardens Flat 1, SW8 2FW, Angleterre.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant

actuel de six cent quarante-huit mille quatre cent quarante livres sterling et trente-et-un pence (GBP 648.440,31) repré-
senté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante et un (1.239.051) Actions Ordinaires A, cinq mille cinq cent
quatre-vingt-cinq (5.585) Actions Ordinaires A1, soixante-trois millions quatre cent onze mille sept cent quatre-vingt-
quatre (63.411.784) Actions de Préférence, quarante-neuf mille quatre cent quatre-vingt-sept (49.487) Actions Ordinaires
B et cent trente-huit mille cent vingt-quatre (138.124) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP
0,01) chacune, à un montant de six cent cinquante-et-un mille cinq cent quarante-trois livres sterling et sept pence (GBP
651.543,07), par l'émission de cinq mille cinq cent cinquante-six (5.556) Actions Ordinaires B, deux cent soixante-douze
mille deux cent vingt-deux (272.222) Actions de Préférence et trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (32.498)
Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP 0,01) chacune, par une contribution en numéraire.

Les nouvelles parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:
Cinq mille cinq cent cinquante-six (5.556) Actions Ordinaires B, deux cent soixante-douze mille deux cent vingt-deux

(272.222) Actions de Préférence et trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit (32.498) Actions Ordinaires C
sont  intégralement  souscrites  et  libérées  par  M.  Anders  Romberg,  susmentionnée,  pour  un  prix  total  de  deux  cent
soixante-neuf mille neuf cent soixante-deux livres sterling et trente-trois pence (GBP 269.962,33).

De l'apport global d'un montant de deux cent soixante-neuf mille neuf cent soixante-deux livres sterling et trente-

trois pence (GBP 269.962,33), trois mille cent deux livres sterling et soixante-seize pence (GBP 3.102,76) sont alloués au
capital social de la Société et deux cent soixante-six mille huit cent cinquante-neuf livres sterling et cinquante-sept pence
(GBP 266.859,57) sont alloués à la prime d'émission.

La preuve de la totalité de l'apport en numéraire est apportée au notaire par un certificat de blocage.
Par la suite, Monsieur Anders Romberg, susmentionné, ici représenté par Madame Alina Rymalova, Rechtsanwältin,

résidant à Luxembourg, en vertu de la procuration donnée sous seing privé, se joint à l'assemblée générale des associés
de la Société et décide des points suivants à l'ordre du jour.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent

acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier

l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à six cent cinquante-et-un mille cinq cent quarante-trois livres sterling et

sept pence (GBP 651.543,07) représenté par un million deux cent trente-neuf mille cinquante-et-un (1.239.051) Actions
Ordinaires A, cinq mille cinq cent quatre-vingt-cinq (5.585) Actions Ordinaires A1, soixante-trois millions six cent quatre-
vingt-quatre mille six (63.684.006) Actions de Préférence, cinquante-cinq mille quarante-trois (55.043) Actions Ordinaires
B et cent soixante-dix mille six cent vingt-deux (170.622) Actions Ordinaires C, d'une valeur nominale de un pence (GBP
0,01) chacune, intégralement souscrites et libérées.

5.2. Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés prise

dans les conditions requises pour une modification des présents Statuts.»

<i>Frais et Dépenses

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte

est évalué à environ EUR 2.500,-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

29408

L

U X E M B O U R G

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparants connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire des comparants a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. RYMALOVA et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63715. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015889/370.
(150018795) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

KKH Property Investors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 9.529.250,00.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 22, Grand Rue.

R.C.S. Luxembourg B 187.382.

In the year two thousand and fifteen, on the twentieth day of January.
Before Maître Martine SCHAEFFER, civil law notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of «KKH Property Investors SARL», a «société à responsabilité

limitée» (the «Company»), having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, R.C.S. Luxembourg section B number 187.382, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary then residing
in Luxembourg, en acted on the 23 

rd

 day of May 2014, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil Spécial des

Sociétés et Associations, number 2050 of 5 

th

 August 2014, whose articles of association have been amended several

times and latest by deed of the same notary, dated 24 

th

 July 2014, published in the Luxembourg Mémorial C, Recueil

Spécial des Sociétés et Associations, number 2721 of 2 

rd

 October 2014.

There appeared,

- Steel Grafton SARL, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of

Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under registration number B 185.448,
having its registered office at 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital
of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500;-) («Steel»),

here represented by Mr Gianpiero SADDI, private employee, professionally residing at L-1750 Luxembourg, 74, avenue

Victor Hugo, by virtue of a proxy given under private seal.

- KKH Capital Group S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and

existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 22, Avenue de la Liberté, L-1930
Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.988, having a
share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) («KKH»),

here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal.
(the «Shareholders»),
Said proxies, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder of the appearing parties and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing parties, represented as stated above, have requested the undersigned notary to state that the agenda

of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of two million two hundred seventy thousand euros

(EUR 2,270,000.-) so as to bring it from its current amount of seven million two hundred and fifty-nine thousand two
hundred and fifty euros (EUR 7,259,250.-) to nine million five hundred twenty-nine thousand two hundred fifty euros
(EUR 9,529,250.-), by the creation and the issuance of two million two hundred seventy thousand (2,270,000) new shares
with a par value of one euro (EUR 1.-) each;

2. Subscription of two million two hundred seventy thousand (2,270,000) of the newly issued shares by Steel Grafton

SARL and paying up for these shares by a contribution in cash of two million two hundred seventy thousand euros (EUR
2,270,000.-);

29409

L

U X E M B O U R G

3. Waiving by KKH Capital Group S.à r.l. of the preferential subscription rights to which KKH Capital Group S.à r.l.

may be entitled on occasion of the capital increase of the Company;

4. Subsequent amendment of article 6 of the by-laws in order to reflect such action.
After the foregoing was approved by the meeting, the Shareholders decide what follows:

<i>First resolution

It is decided to increase the share capital of the Company by an amount of two million two hundred seventy thousand

euros (EUR 2,270,000.-) so as to bring it from its current amount of seven million two hundred and fifty-nine thousand
two hundred and fifty euros (EUR 7,259,250.-) to nine million five hundred twenty-nine thousand two hundred fifty euros
(EUR 9,529,250.-) and to create and issue in this respect two million two hundred seventy thousand (2,270,000) new
shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each.

<i>Second resolution

It is decided to issue two million two hundred seventy thousand (2,270,000) new shares of the Company to be sub-

scribed by Steel, represented as stated above and fully paid-up by a contribution in cash, so that the amount of two million
two hundred seventy thousand euros (EUR 2,270,000.-) is from now on at the free disposal of the Company, as has been
proved to the notary by a bank certificate, that states it expressly.

<i>Subscription and Payment

Thereupon intervene the afore named company Steel, here represented by Mr Gianpiero SADDI, prenamed, by virtue

of a proxy being here annexed;

declared to subscribe to the two million two hundred seventy thousand (2,270,000) new shares and to have them fully

paid-up by payment in cash, so that from now on the Company has its free and entire disposal the amount of two million
two hundred seventy thousand euros (EUR 2,270,000.-) as was certified to the undersigned notary.

<i>Third resolution

It is noted that the shareholder KKH has specifically renounced to its preferential subscription rights it may be entitled

on the occasion of the present capital increase of the Company.

<i>Fourth resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, it is decided to amend the Article six of the Articles of Association to

read as follows:

« Art. 6. The Company's share capital is set at nine million five hundred twenty-nine thousand two hundred fifty euros

(EUR 9,529,250.-) represented by nine million five hundred twenty-nine thousand two hundred fifty (9,529,250) shares
having a par value of one Euro (EUR 1.-) each.

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.»
As a consequence, the article 6 of the Articles of Association is restated accordingly.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about three thousand four hundred Euro (EUR 3.400.-).

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the appearing parties and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the year and day first written above.
The document having been read to the proxy-holders of the appearing parties, who are known to the notary by

surname, given name, civil status and residence, said proxy-holders signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quinze, le vingt janvier.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société à responsabilité limitée «KKH Property Inves-

tors SARL» (la «Société»), ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B
numéro 187.382, constituée suivant acte du notaire Joseph ELVINGER, alors notaire de résidence à Luxembourg, reçu
en date du 23 mai 2014, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2050 du 5 août 2014

29410

L

U X E M B O U R G

et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le même notaire en date du 24 juillet 2014,
publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2721 du 3 octobre 2014.

Ont comparu:

- Steel Grafton SARL, une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 22, Grand Rue, L-1660 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg section B numéro 185.448 et ayant un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-)
(«Steel»),

ici représentés par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à L-1750 Luxembourg,

74, avenue Victor Hugo, en vertu d'une procuration sous seing privé.

- KKH Capital Group S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 22, Avenue de la Liberté,

L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg section B numéro 186.988 et ayant un capital social de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500,-) («KKH»),

ici représentés par Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé en vertu d'une procuration sous seing privé.
(les «Associés»),
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire des parties comparantes et par le notaire

instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter que l'ordre du jour

de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence de deux millions deux cent septante mille euros (EUR

2.270.000,-) pour le porter de son montant actuel de sept millions deux cent cinquante-neuf mille deux cent cinquante
euros (EUR 7.259.250,-) à neuf millions cinq cent vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (EUR 9.529.250,-), par la
création et l'émission de deux millions deux cent septante mille (2.270.000) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune.

2. Souscription de deux millions deux cent septante mille (EUR 2.270.000,-) parts sociales nouvellement émises par

Steel Grafton SARL et paiement de ces parts sociales par une contribution en espèces de deux millions deux cent septante
mille euros (EUR 2.270.000,-).

3. Renonciation au droit de souscription préférentiel par l'associé KKH Capital Group S.à r.l.
4. Modification subséquente de l'article 6 des statuts.
Après approbation de ce qui précède, il a été décidé ce qui suit:

<i>Première résolution:

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de deux millions deux cent septante mille euros

(EUR  2.270.000,-)  pour  le  porter  de  son  montant  actuel  de  sept  millions  deux  cent  cinquante-neuf  mille  deux  cent
cinquante euros (EUR 7.259.250,-) à neuf millions cinq cent vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (EUR 9.529.250,-),
par la création et l'émission de deux millions deux cent septante mille (2.270.000) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

<i>Deuxième résolution:

Il est décidé d'admettre à la souscription des deux millions deux cent septante mille (2.270.000) nouvelles parts sociales

l'associé Steel, représenté comme indiqué ci-dessus et entièrement libérées par une contribution en espèces de sorte
que la somme de deux millions deux cent septante mille euros (EUR 2.270.000,-) se trouve dès à présent à la libre
disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation bancaire, qui le constate expressément.

<i>Intervention - Souscription - Libération

Intervient ensuite le souscripteur Steel, nommé précédemment, représenté par Monsieur Gianpiero SADDI, prén-

ommé, en vertu d'une procuration ci-attachée;

Lequel déclare souscrire aux deux millions deux cent septante mille euros (EUR 2.270.000,-) parts nouvelles et les

libérer intégralement en numéraire, de sorte que la société a dès maintenant à sa libre et entière disposition la somme
de deux millions deux cent septante mille euros (EUR 2.270.000,-) ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée note que l'actionnaire KKH a expressément renoncé à son droit de souscription préférentiel.

<i>Quatrième résolution:

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, il est décidé de modifier l'article six des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

29411

L

U X E M B O U R G

« Art. 6. Le capital social est fixé à neuf millions cinq cent vingt-neuf mille deux cent cinquante euros (EUR 9.529.250,-)

représenté par neuf millions cinq cent vingt-neuf mille deux cent cinquante (9.529.250) parts sociales d'un euro (EUR 1,-)
chacune.

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordi-

naires»

<i>Coûts

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à approximativement trois mille quatre cents euros (EUR
3.400.-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. Sur la demande des mêmes parties comparantes
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des parties comparantes, connus du notaire instru-

mentaire par nom, prénom usuel, état et demeure, lesdits mandataires ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 26 janvier 2015. 2LAC/2015/1849. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015915/168.
(150018798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Gercomm 1, Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 1, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 115.965.

Les comptes annuels au 30 Novembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Gercomm 1 S.A.

Référence de publication: 2015016497/10.
(150019354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Biobu S.à r..l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 188.128.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associé unique en date du 28 janvier 2015

DÉMISSION D'UN GÉRANT
L'associé unique prend acte de la démission de Monsieur Yvon HELL de ses fonctions de gérant à compter du 1 

er

janvier 2015.

NOMINATION D'UN GÉRANT
L'associé unique décide de nommer au poste de gérant en remplacement du gérant démissionnaire, avec effet rétroactif

au 1 

er

 janvier 2015, pour une durée indéterminée:

- Monsieur Erwin MÜNCH
né le 14 mars 1961 à Mulhouse (France)
demeurant professionnellement à L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015584/18.
(150018419) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

29412

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXXIII S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.033.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory

seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin on 5 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital  Services  XXXIII  S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

29413

L

U X E M B O U R G

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)

shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,

29414

L

U X E M B O U R G

decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by the remaining  managers  until  the  next meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

29415

L

U X E M B O U R G

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

29416

L

U X E M B O U R G

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the

price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR

15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

29417

L

U X E M B O U R G

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5

Januar 2015, ausgestellt in Berlin.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXIII S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser

29418

L

U X E M B O U R G

außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend

(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

29419

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den  Fall, dass der alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

29420

L

U X E M B O U R G

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

29421

L

U X E M B O U R G

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von

fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.

29422

L

U X E M B O U R G

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten, Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/704. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015015686/584.
(150019192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Iglux Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3714 Rumelange, 3, place des Bruyères.

R.C.S. Luxembourg B 158.350.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016550/9.
(150019320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

29423

L

U X E M B O U R G

Akryl - Lux S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3429 Dudelange, 241, rue de Burange.

R.C.S. Luxembourg B 40.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015016331/10.
(150019435) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Institut Epil'Ongles S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich.

R.C.S. Luxembourg B 135.780.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre.
Par devant Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

A comparu:

- Mademoiselle Nathalie Samsel, employée, née à Metz (France) le 18 juin 1973, demeurant à F-54560 Audun-le-Roman,

rue du 9 Septembre, 3bis.

La comparante expose ce qui suit:
1) Elle est propriétaire de la totalité des parts de la société INSTITUT EPIL'ONGLES S.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-1741 Luxembourg, 19, rue de Hollerich, constituée suivant acte du notaire Tom METZLER de Luxembourg-
Bonnevoie en date du 14 janvier 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Numéro 483 du 26
février 2008, inscrite au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 135.780, et dont le capital social est
fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par cent (100) parts sociales de cent vingt-cinq euros (EUR
125,-) chacune, entièrement libérées.

2) L'activité de la Société a cessé.
3) Siégeant en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société, elle prononce la dissolution

anticipée de la Société avec effet immédiat.

4) Elle se désigne comme liquidateur de la Société, et en cette qualité, requiert le notaire d'acter que tout le passif de

la Société est réglé tandis que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné et qu'enfin,
par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et donc non encore payés, elle assume irrévoca-
blement l'obligation de les payer de sorte que tout le passif de la Société est réglé.

5) L'actif restant est attribué à l'associée unique.
6) La liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
7) Décharge pleine et entière est donnée au gérant de la Société.
8) Les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social.
9) Déclaration que, conformément à la loi du 12 novembre 2004, l'associée actuelle est la bénéficiaire économique de

l'opération.

Pour les publications et dépôts à faire, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, en l'étude.
Et après lecture faite et interprétation donnée à la comparante, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: SAMSEL, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 63389. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015878/42.
(150019151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

29424


Document Outline

Akryl - Lux S.A.

Arepo BH. S.à r.l.

Belval Square SA

Berlin, Tauentzienstraße 21-24 Beteiligung A S.à r.l.

Biobu S.à r..l

Bleu Book Group S.A.

Bonn, Viktoria-Karree Holding S.à r.l.

Brasserie Everydays

Cerbero Holding S.A.

Digital Services XXXIII S.à.r.l.

Enop 2 S.à r.l.

Feston Investissements S.A.

Futura II Holding

Gercomm 1

Ice Man SA

Ice Man SA

Iglux Group S.A.

Institut Epil'Ongles S.à r.l.

Intermarc s.à.r.l.

IVM Holdings S.à r.l.

Jacana S.A.

JAN.CO S.A.

Jewel HoldCo S.à r.l.

KKH Property Investors S.à r.l.

Lepus Holdings (Lux) S.à r.l.

L.O.G.EVAM s.à r.l.

LuxCo 82 S.à r.l.

Luxembourg Online S.A.

M.A.B. Investments S.A.

Martley Holding S. à r.l.

Merchbanc Sicav

Pasta Mano S.à.r.l. et Cie S.e.c.s

Patentportfolio 2 S.à r.l.

Pearson Luxembourg N°. 2.

Pegase S.A.

Phary Company S.A.

PK AirFinance

Roof Garden S.A.

Sapphire Shipping S.A.

Sardinvest S.A.

Schindler

Secure Industries S.A.

SH Group Hotels &amp; Residences Global Licensing (Lux) S.à r.l.