logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 604

5 mars 2015

SOMMAIRE

Arulux First S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28954

Black & Decker TransAsia S.à r.l.  . . . . . . . .

28954

Brainforge S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28991

Choreo A.s.b.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28966

Diemmevi S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28949

Digital Services XXXIII (GP) S.à.r.l.  . . . . .

28969

Efesto Energy 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

E-Tech Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28956

FR Acquisition Corporation (Luxem-

bourg), S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28959

Gattyan Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28963

Herbeus SICAV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28947

Larix S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28946

Limone S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28990

M.A. Developments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28955

Neovara European Mezzanine Leveraged

Partners 2003-B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Neovara European Mezzanine Partners

2003-A S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

Neovara European Mezzanine Partners

2003-B S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28951

Neovara European Mezzanine Partners

2003-C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28949

Neovara European Mezzanine Partners

2003-D S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

North Investment Protected Note Issuer

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28948

Nuremburg Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . .

28952

P.H Investment S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28947

Portfolio Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28951

Power Parts Continental . . . . . . . . . . . . . . . .

28950

Premios S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28948

Premium Kaufhaus Immobilien Holding B

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

Provirt Consulting Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28949

Quint:Essence Concept  . . . . . . . . . . . . . . . . .

28946

R.P.S. Consulting  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28951

Salem Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28955

Skype Communications . . . . . . . . . . . . . . . . .

28952

Skype Technologies  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28953

Skype Technologies S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28953

Stentex Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28992

Sybil Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28954

TPL Glauchau S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28947

Whirlpool Overseas Manufacturing S.àr.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28955

Wiljo Letzebuerg S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28946

Windhof Business Center S.A.  . . . . . . . . . .

28948

Woonfonds Holding 2A S.à.r.l.  . . . . . . . . . .

28980

28945

L

U X E M B O U R G

Wiljo Letzebuerg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1611 Luxembourg, 63, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 76.032.

<i>Auszug aus dem Bericht des Verwaltungsrates vom 28. Januar 2015 an die Aktionäre und an den Aufsichtskommissar

Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig die Ernennung als Depositar FIDUCIAIRE MOSELLAN SARL., eingetragen

im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer B120014 mit Sitz in L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Unterschrift
<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015016281/13.
(150018839) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Larix S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 2BIS, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 23.556.

Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

qui se tiendra le <i>20 mars 2015 à 10.00 heures au siège social à Luxembourg pour délibérer de l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août

1915

2. Divers

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015028144/788/14.

Quint:Essence Concept, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-5365 Munsbach, 2, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 150.867.

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Quint: Essence Concept SICAV (die "Gesellschaft") am <i>13. März 2015 um 11.00 Uhr am Hauptsitz

der Gesellschaft stattfinden wird. Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

a. Begrüßung und Feststellung der Regularien;

b. Bericht des Verwaltungsrates;

c. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend

das am 30. September 2014 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 30.
September 2014 beendeten Geschäftsjahrs;

d. Entlastung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013/2014;

e. Festlegung des Mandates für den Réviseur d´Entreprises;

f. Verlängerung der Verwaltungsratsmandate;

g. Verschiedenes.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum

festgelegt ist und dass Beschlüsse der Ordentlichen Generalversammlung mit einer einfachen Stimmenmehrheit der an-
wesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Zu den verschiedenen Punkten der Tagesordnung sind nur die Inhaberaktien stimmberechtigt, welche bei der M.M.

Warburg &amp; CO Luxembourg S.A. bis spätestens zum 10. März 2015 hinterlegt wurden. Der Beleg betreffend den Akti-
enbesitz und die Hinterlegung der Aktien muss erbracht werden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015032898/755/27.

28946

L

U X E M B O U R G

P.H Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 161.560.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017528/9.
(150021024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

TPL Glauchau S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 123.105.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015017758/12.
(150020945) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Herbeus SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 137.944.

Hiermit wird allen Aktionären mitgeteilt, dass die

ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre der HERBEUS SICAV (die "Gesellschaft") am <i>13. März 2015 um 14.00 Uhr am Hauptsitz der Gesellschaft

stattfinden wird.
Bei Angelegenheiten, welche die Gesellschaft als Ganzes betreffen, stimmen die Aktionäre der Gesellschaft gemeinsam
ab. Eine getrennte Abstimmung erfolgt bei Angelegenheiten, die nur einen oder mehrere Teilfonds betreffen.
Die Tagesordnung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung:

1. Vorlage und Zustimmung des Berichtes des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers;
2. Zustimmung der Aufstellung der Nettovermögenswerte der Gesellschaft sowie des Geschäftsberichtes betreffend

das am 30. November 2014 beendete Geschäftsjahr; Beschluss betreffend die Verwendung der Erträge des am 30.
November 2014 beendeten Geschäftsjahres;

3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates im Zusammenhang mit ihren Geschäftstätigkeiten betreffend das

am 30. November 2014 beendete Geschäftsjahr;

4. Bestellung des Verwaltungsrats für einen Zeitraum, der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung

in 2016 endet;

5. Bestellung der Abschlussprüfungsgesellschaft BDO Audit S.A.; B.P. 351, L-2013 Luxembourg für einen Zeitraum,

der zum Zeitpunkt der nächsten jährlichen Generalversammlung in 2016 endet;

6. Verschiedenes.
Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass im Zusammenhang mit der Tagesordnung kein Anwesenheitsquorum

festgelegt  ist,  und  dass  Beschlüsse  der  Ordentlichen  Generalversammlung  mit  einer  einfachen  Stimmenmehrheit  der
anwesenden oder der vertretenen Aktien getroffen werden.

Die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen für die Anteilinhaber können am Gesellschaftssitz der HERBEUS SICAV

in 2, Place François-Joseph Dargent, L-1413 Luxemburg eingesehen werden. Die Aktionäre können außerdem die Zu-
sendung dieser Unterlagen an sich verlangen.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015032900/755/32.

28947

L

U X E M B O U R G

Premios S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6645 Wasserbillig, 8, rue des Pepinières.

R.C.S. Luxembourg B 148.187.

Der Jahresabschluss vom 31.12.2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017557/9.
(150020948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Windhof Business Center S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 87.423.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue en date du 1 

<i>er

<i> décembre 2014 à Windhof

Les administrateurs de la société Windhof Business Center S.A. ont pris la résolution suivante:
1. Les administrateurs nomment au poste de Président du Conseil d'Administration Monsieur Robert Schintgen, de-

meurant à Rue de Bridel, 113 à L-7217 Béreldange, et ce pour une durée de six ans.

Pour extrait conforme
<i>Pour Windhof Business Center S.A.

Référence de publication: 2015016282/13.
(150018957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

North Investment Protected Note Issuer, Société Anonyme (en liquidation).

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.925.

L'Assemblée Générale extraordinaire des obligataires réunie sur première convocation le 26 janvier 2015 à 10h00

n'ayant pu, faute de quorum, délibérer valablement sur les résolutions inscrites à l'ordre du jour, les obligataires sont à
nouveau convoqués par le liquidateur de la Société en assemblée générale extraordinaire.

En conséquence de ce qui précède, conformément aux dispositions de l'article 67.1 de la loi du 10 août 1915, nous

avons l'honneur de vous informer qu'une

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES OBLIGATAIRES

de la Société se tiendra le <i>23 mars 2015 à 14h30, heure locale, au siège social de la Société, 25A, boulevard Royal, 2

ème

 étage, L-2449 Luxembourg Forum Royal, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Prorogation du terme des échéances des emprunts obligataires en cours
2. Modification des taux d'intérêts des emprunts obligataires en cours
3. Traitement des intérêts échus et à échoir
4. Divers

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l'Assemblée générale sont disponibles au siège social

de la Société. Chaque obligataire, sur production de son titre, peut obtenir les jours ouvrables entre le 10/03/2015 et le
23/03/2015, gratuitement, copie des documents dans les conditions légales applicables.

Les porteurs d'obligations sont invités à participer à l'assemblée et à procéder au vote.
Les porteurs d'obligations peuvent mandater par écrit une autre personne pour assister à l'assemblée et voter en leur

nom. Ce mandataire ne doit pas être nécessairement un obligataire de la Société.

Les obligataires sont informés que cette Assemblée reconvoquée ne sera pas soumise à un quelconque quorum et que

les décisions prises en faveur des résolutions devront réunir les deux tiers au moins des votes exprimés à l'Assemblée.
Les votes exprimés ne comprendront pas les droits de vote attachés aux actions pour lesquels les obligataires n'ont pas
pris part au vote, ou se sont abstenus, ou ont remis un bulletin de vote blanc ou nul.

Pour être valables, les procurations doivent arriver au siège de la Société avant le 20/03/2015.

<i>Le liquidateur.

Référence de publication: 2015024699/32.

28948

L

U X E M B O U R G

Provirt Consulting Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 175.929.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017566/9.
(150020886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Diemmevi S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 134.558.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du conseil d'administration tenue le 27 janvier 2015

La société MANACO S.A., inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B19797, ayant son siège

social au 17, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg a été nommée comme dépositaire des actions au porteur.

Pour extrait sincère et conforme
DIEMMEVI S.A.

Référence de publication: 2015015702/12.
(150019236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 100.709.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014, LAC/2014/63003, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
" Neovara European Mezzanine Partners 2003-C S.à r.l., (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 100.709, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 7 mai 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le 9 juillet 2004 sous le numéro 709, page 33986. Dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 20 juin 2011 sous le numéro 1337, page 64143.

- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2014, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société

Quorum Investments S.à.r.l. et au commissaire à la liquidation, la société à EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à
r.l., pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante: 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016640/32.
(150019444) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

28949

L

U X E M B O U R G

Power Parts Continental, Société Anonyme.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 153.413.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017587/9.
(150020348) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Efesto Energy 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 178.713.

Il est porté à la connaissance de tous que l'adresse de l'un des administrateurs, Monsieur Ciro Mongillo, a fait l'objet

d'un changement, celle-ci étant désormais: 67 Grosvenor Street, W1K3JN Londres, Royaume-Uni.

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015015736/12.
(150019120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.800.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014, LAC/2014/63009, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
"Neovara European Mezzanine Partners 2003-A S.à r.l., (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 99.800, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le 13 mai 2004 sous le numéro 505, page 24210. Dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 18 juin 2011 sous le numéro 1326, page 63632.

- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2014, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société

Quorum Investments S.à.r.l. et au commissaire à la liquidation, la société à EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à
r.l., pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante: 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016010/32.
(150019022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28950

L

U X E M B O U R G

R.P.S. Consulting, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 80A, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 146.419.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017600/9.
(150020408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Portfolio Consult S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 32, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 36.035.

<i>Extrait de résolution prise par l'administrateur unique le 23 janvier 2015

La société à responsabilité limitée YES EUROPE établie et ayant son siège social au 32, avenue Monterey L-2163

Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B 150454) est nommée à la fonction de dépositaire en application de l'article 42 de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015016120/12.
(150018459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.796.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014, LAC/2014/63006, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
"Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l., (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 99.796, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le 13 mai 2004 sous le numéro 504, page 24152. Dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 18 juin 2011 sous le numéro 1328, page 63707.

- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2014, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société

Quorum Investments S.à.r.l. et au commissaire à la liquidation, la société à EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à
r.l., pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante: 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016012/32.
(150019021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28951

L

U X E M B O U R G

Skype Communications, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 100.468.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017641/9.
(150020335) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Nuremburg Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 4, rue Henri Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 118.168.

Par la présente, nous démissionnons avec effet immédiat de notre mandat de Commissaire de votre société NUREM-

BURG PROPERTIES S.A., enregistré auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 118.168.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Lux-Audit S.A.

Référence de publication: 2015016047/12.
(150018959) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.801.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014, LAC/2014/63011, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
"Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-B S.à r.l., (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg
sous le numéro B 99.801, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant
acte reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, le 13 mai 2004 sous le numéro 503, page 24146. Dont les statuts ont été modifiés
pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 18 juin 2011 sous le numéro 1329, page 63783 et le
20 juin 2011 sous le numéro 1336, page 64096.

- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2014, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

- L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société

Quorum Investments S.à.r.l. et au commissaire à la liquidation, la société à EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à
r.l., pour l'accomplissement de leur onction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante: 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016008/33.
(150019023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28952

L

U X E M B O U R G

Skype Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Skype Technologies).

Siège social: L-2165 Luxembourg, 23-29, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 111.886.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015017642/9.
(150020353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 février 2015.

Premium Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 173.729.

<i>Auszug aus dem schriftlichen Gesellschafterbeschluss der Gesellschaft vom 26. Januar 2015

Aufgrund eines Gesellschafterbeschlusses der Gesellschaft vom 26. Januar 2015 haben sich folgende Änderungen in

der Geschäftsführung der Gesellschaft ergeben:

- Herr Daniel Kranz, geboren am 10. März 1972 in Trier (Deutschland), wurde mit sofortiger Wirkung abberufen.
Référence de publication: 2015016075/12.
(150018948) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-D S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.795.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Il résulte d'un acte de clôture de liquidation reçu par le notaire Martine SCHAEFFER, de résidence à Luxembourg, en

date du 19 décembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014, LAC/2014/63001, aux droits de
soixante-quinze euros (75.- EUR), que la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination de
" Neovara European Mezzanine Partners 2003-D S.à r.l., (en liquidation)", inscrite auprès du R.C.S. Luxembourg sous le
numéro B 99.795, ayant son siège social au 52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, constituée suivant acte
reçu par Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, le 14 mai 2004 sous le numéro 509, page 24423. Dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 24 mars 2011,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 20 juin 2011 sous le numéro 1336, page 64125.

- La société a été mise en liquidation suivant acte du notaire instrumentaire en date du 17 décembre 2015, non encore

publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée générale adopte le rapport du commissaire à la liquidation.
- L'assemblée générale adopte les comptes de liquidation et donne décharge pleine et entière au liquidateur, la société

Quorum Investments S.à.r.l. et au commissaire à la liquidation, la société à EUROPEAN FIDUCIARY of Luxembourg S.à
r.l., pour l'accomplissement de leur fonction concernant la liquidation de la société.

- L'assemblée générale donne décharge pleine et entière aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la

société pour l'exécution de leur mandat jusqu'à ce jour.

- Par conséquent la liquidation de la société a été clôturée et la société est dissoute.
- Les livres et documents de la société seront conservés pendant une durée de cinq ans à partir de la date de la

publication des présentes dans le Mémorial, Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Recueil des Sociétés et
Associations, à l'adresse suivante: 52-54 avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016641/32.
(150019441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

28953

L

U X E M B O U R G

Arulux First S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 21, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 167.221.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil de gérance en date du 16 janvier 2015

Les gérants ont décidé de transférer le siège social de la Société de son ancienne adresse sise 4, Grand-Rue L-1660

Luxembourg au 21, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016319/12.
(150019677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Black &amp; Decker TransAsia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 147.985.

En date du 21 janvier 2015, l'associé unique a décidé de renouveler le mandat de Ernst &amp; Young, société anonyme,

ayant son siège au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2 à L-5365 Munsbach, Grand Duché du Luxembourg,
comme reviseur d'entreprises agréé de la Société pour un mandat qui prendra fin lors de l'assemblée générale annuelle
approuvant les comptes clos au 31 décembre 2014.

POUR EXTRAIT CONFORME ET SINCERE
Black &amp; Decker TransAsia S.à r.l.
Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015016352/16.
(150019856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Sybil Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 115.000,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 183.968.

Version corrigée qui remplace la 1ère version - Dépôt L150014537

EXTRAIT

Il est porté à la connaissance des tiers que suite à un déménagement, les associés de la Société mentionnés ci-dessous,

demeurent désormais à 1 Waverley Place, Union Street, St. Heller, Jersey, JE1 1SG, Iles Anglo-Normandes:

1. CVC European Equity V Limited, agissant comme general partner au nom et pour compta de CVC European Equity

Partners V (A) LP.;

2. CVC European Equity V Limited, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity

Partners V (B) LP.;

3. CVC European Equity V Limited, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity

Partners V (C) LP..;

4. CVC European Equity V Limited, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity

Partners V (D) LP..;

5. CVC European Equity V Limited, agissant comme general partner au nom et pour compte de CVC European Equity

Partners V (E) LP..

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 22 janvier 2015.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2015016178/26.
(150018771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28954

L

U X E M B O U R G

Salem Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 179.566.

EXTRAIT

En date du 21 janvier 2015, l'associé unique de la société a pris la résolution suivante:
- La démission de Elin Sjöling, en tant que gérant de la société, est acceptée avec effet au 10 janvier 2014.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016164/12.
(150018179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

M.A. Developments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 193.565.

EXTRAIT

II résulte du contrat de transfert de parts sociales signé en date du 30 décembre 2014 que les parts sociales de la

société de EUR 1,- chacune, seront désormais réparties comme suit:

DESIGNATION DE L'ASSOCIE

NOMBRE

AvtoBalt Group Limited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.500

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015957/15.
(150019212) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Whirlpool Overseas Manufacturing S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1526 Luxembourg, 50, Val Fleuri.

R.C.S. Luxembourg B 129.096.

EXTRAIT

Par résolution de l'associé unique de la Société prise en date du 21 janvier 2015, il a été pris connaissance de la démission

de Mme Irene Frances Bellew-Lenarduzzi, née à Liverpool, Royaume-Uni, le 26 Septembre 1952, avec adresse profes-
sionnelle au 27, Viale Guido Borghi, I-21025 Comerio, Italie, de son mandat de gérant de catégorie A de la Société avec
effet au 16 janvier 2015.

Il a également été décidé de nommer avec effet au 16 janvier 2015 et pour une durée indéterminée M. Stefan Lieven

De Jonghe, né le 29 Juin 1971, à Anvers, Belgique, avec adresse professionnelle sise au 27, Viale Guido Borghi, I-21025
Comerio, Italie, en tant que nouveau gérant de catégorie A de la Société.

Il en résulte que le conseil de gérance de la Société se compose comme suit:
- M. Stefan Lieven De Jonghe gérant de catégorie A; et
- M. Marc Zaal, gérant de catégorie A;
- M. Lars Peter Davidsson, gérant de catégorie A;
- M. Tony Whiteman, gérant de catégorie B;
- M. Iain Macleod, gérant de catégorie B; et
- M. Michael Lange, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016280/25.
(150018713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28955

L

U X E M B O U R G

E-Tech Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 115.622.

In the year two thousand fifteen, on the twentieth day of the month of January;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held

the  extraordinary  general  meeting  of  the  shareholders  of  the  company  ETECH  INVEST  S.A.  (the  “Company”),  a

“société anonyme” having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 115622, incorporated on 22 March 2006 pursuant
to a deed received by Me Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven (Grand Duchy of Luxembourg), published
in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1221 of 24 June 2006.

The Articles of the Company have been amended several times and for the last time on 11 June 2009 pursuant to a

deed received by Me Paul DECKER, then notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), published in the
“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” number 1301 of 7 July 2009.

The meeting is opened under the chairmanship of Mr Marc ALBERTUS, employee, residing professionally at 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

residing professionally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Mrs Carine GRUNDHEBER, “licenciée en lettres modernes”, residing professio-

nally at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Gabriele HERBSTHOFER, employee, residing professionally at 2, avenue Charles

de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

The bureau of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state that:
I) The agenda of the meeting is the following:
1. Increase of capital in the amount of EUR 100,000 to raise it from EUR 300,000 up to EUR 400,000 by creation and

issue of 1,000 new shares with a nominal value of EUR 100 each, to be issued at par and benefiting of the same rights and
advantages  as  the  presently  issued  shares,  entirely  subscribed  to  by  the  majority  shareholder  and  fully  paid  up  by  a
contribution in cash.

2. Subsequent amendment of article 5 of the by-laws in order to read as follows:

English version

“ Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 400,000 (four hundred thousand Euro) divided into

4,000 (four thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders

voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.”

French version

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented
shareholders, the members of the bureau of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the members of the

bureau of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole share capital of the Company is present or duly represented at the present

extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that no other security entitled to a voting right has been issued by the Company, so that the

present meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously takes the following resolutions:

28956

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The general meeting decides to increase the Company's share capital by an amount of EUR 100,000 (one hundred

thousand Euro) to raise it from EUR 300,000 (three hundred thousand Euro) up to EUR 400,000 (four hundred thousand
Euro) by the creation and issue of 1,000 (one thousand) new shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro)
each, to be issued at par and benefiting of the same rights and advantages as the presently issued shares.

<i>Subscription - Paying up

The general meeting records and accepts the waiver to their subscription right of the shareholders who did not

subscribe to the capital increase and the subscription by the majority shareholder of the 1,000 (one thousand) newly
issued shares, as well as the full paying up by cash of said shares, so that the Company has now at its disposal the sum of
EUR 100,000 (one hundred thousand Euro) as was certified to the notary executing this deed.

<i>Second resolution

In consequence of the foregoing resolution the general meeting decides to amend article 5 of the by-laws in order to

be worded as follows:

“ Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 400,000 (four hundred thousand Euro) divided into

4,000 (four thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders

voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.”

There being no further business on the agenda, the meeting is thereupon adjourned.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand three
hundred Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks French and English, states herewith that, on request of the above

appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status

and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

Follows the French version of the preceding text.

L'an deux mille quinze, le vingtième jour du mois de janvier.
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme E-TECH INVEST S.A. (la «Société»), ayant

son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 115622, constituée le 22 mars 2006 suivant un acte reçu par
Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1221 du 24 juin 2006.

Les statuts de la Société ont été modifiés à plusieurs reprises et en dernier lieu le 11 juin 2009 suivant un acte reçu

par Maître Paul DECKER, alors notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1301 du 7 juillet 2009.

L'assemblée générale est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc ALBERTUS, employé, demeurant profession-

nellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire Madame Carine GRUNDHEBER, licenciée en lettres modernes, demeurant

professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Gabriele HERBSTHOFER, employée, demeurant professionnellement

au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président déclare et requiert le notaire d'acter que:
I) L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

28957

L

U X E M B O U R G

1. Augmentation du capital social à concurrence de EUR 100.000 pour le porter de EUR 300.000 à EUR 400.000 par

la création et l'émission de 1.000 nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 chacune, à émettre au pair et
bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions en circulation, entièrement souscrites par l'actionnaire majo-
ritaire et intégralement libérées en espèces.

2. Modification subséquente de l'article 5 des statuts qui se lira comme suit:

Version anglaise

“ Art. 5. The subscribed capital of the company is fixed at EUR 400,000 (four hundred thousand Euro) divided into

4,000 (four thousand) shares with a nominal value of EUR 100 (one hundred Euro) each.

The shares are in registered or bearer form, at the option of the shareholders.
The company may, to the extent and under the terms permitted by law, redeem its own shares.
The subscribed capital of the company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders

voting with the same quorum as for the amendment of the Articles of Incorporation.”

Version française

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

II) Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions

détenues par les actionnaires, sont renseignés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et
les mandataires des actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'assemblée et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Les procurations des actionnaires représentés, signées "ne varietur" par les membres du bureau et le notaire instru-

mentaire, resteront aussi annexées au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que l'intégralité du capital social est présente ou dûment représentée à la

présente assemblée générale extraordinaire.

IV) Le président constate qu'aucun autre titre conférant un droit de vote n'a été émis par la Société, de sorte que la

présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du
jour.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'Assemblée cette dernière prend à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de EUR 100.000 (cent mille

euros) pour le porter de EUR 300.000 (trois cent mille euros) à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) par la création
et l'émission de 1.000 (mille) nouvelles actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune, à émettre au
pair et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les actions en circulation.

<i>Souscription - Libération

L'assemblée générale prend acte de et accepte la renonciation à leur droit de souscription de la part des actionnaires

qui n'ont pas souscrit à l'augmentation de capital et la souscription, par l'actionnaire majoritaire, aux 1.000 (mille) actions
nouvellement émises ainsi que de la libération en espèces de l'intégralité desdites actions, de sorte que la somme de EUR
100.000 (cent mille euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve en ayant été donnée au
notaire instrumentant.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner do-

rénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital souscrit de la société est fixé à EUR 400.000 (quatre cent mille euros) représenté par 4.000 (quatre

mille) actions d'une valeur nominale de EUR 100 (cent euros) chacune.

Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.
La société peut, dans la mesure et aux conditions prescrites par la loi, racheter ses propres actions.
Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires

statuant comme en matière de modification des statuts.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

28958

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille trois cents euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné, qui comprend et parle le français et l'anglais, déclare par les présentes, qu'à la requête des

comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: M. ALBERTUS, C. GRUNDHEBER, G. HERBSTHOFER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 22 janvier 2015. 2LAC/2015/1579. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016439/177.
(150019938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

FR Acquisition Corporation (Luxembourg), S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 25.000,00.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 133.361.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of November,
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

FR Acquisition Holding Corporation (Luxembourg), S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée), having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, having a share
capital of GBP 20,000 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
133.623 (the Sole Shareholder),

hereby represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, by

virtue of a proxy established under private seal.

Such proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record the following:
I. The Sole Shareholder holds all the shares in the share capital of the Luxembourg private limited liability company

(société à responsabilité limitée) existing under the name FR Acquisition Corporation (Luxembourg), S.à r.l., having its
registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital
of GBP 20,000, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under the number B 133.361
(the Company), incorporated pursuant to a deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, dated
October 25, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of December 5, 2007, number 2818.
The articles of association of the Company (the Articles) have been amended for the last time on November 8, 2011
pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations of March 16, 2012, number 705;

II. The Company's corporate capital is fixed at twenty thousand British Pounds (GBP 20,000) represented by one

thousand (1,000) shares in registered form with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20) each, all subscribed
and fully paid-up;

III. The Agenda is as follows:
1. Increase of the share capital of the Company by an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000), to bring it

from its present amount of twenty thousand British Pounds (GBP 20,000) represented by one thousand (1,000) shares
in registered form with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20) each, to twenty-five thousand British Pounds
(GBP 25,000), by the issuance of two hundred fifty (250) new shares with a nominal value of twenty British Pounds (GBP
20) each, having the same rights and obligations as the existing shares;

2. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 1. here above by a contribution in kind;

28959

L

U X E M B O U R G

3. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital

increase adopted under item 1. above;

4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and

authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above
changes; and

5. Miscellaneous.
IV. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of five thousand British

Pounds (GBP 5,000), to bring it from its present amount of twenty thousand British Pounds (GBP 20,000) represented
by one thousand (1,000) shares in registered form with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20) each, to twenty-
five thousand British Pounds (GBP 25,000), by the issuance of two hundred fifty (250) new shares with a nominal value
of twenty British Pounds (GBP 20) each, having the same rights and obligations as the existing shares.

<i>Subscription - Payment

Thereupon, FR Acquisition Subco (Luxembourg), S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à

responsabilité limitée) having its registered office at 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, having a share capital of GBP 15,000, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
under the number B 133.365 (FRASL), hereby represented by Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prenamed, by virtue
of a proxy established under private seal, here annexed, declares to subscribe for two hundred fifty (250) new shares
with a nominal value of twenty British Pounds (GBP 20) each, and agrees to fully pay them up, by way of a contribution
in kind consisting of a receivable that FRASL holds against the Company in an aggregate amount of two hundred twenty-
six  million  three  hundred  twenty-two  thousand  one  hundred  eighty-two  British  Pounds  (GBP  226,322,182)  (the
Receivable) to be allocated as follows:

- an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000) to the share capital account of the Company; and
- an amount of two hundred twenty-six million three hundred seventeen thousand one hundred eighty-two British

Pounds (GBP 226,317,182) to the share premium account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Receivable is evidenced by a certificate issued on November 19, 2014,

by FRASL and acknowledged by the Company (the Management Certificate).

The Management Certificate states in essence that:
“- FRASL is the legal and beneficial owner of the Receivable;
- The Receivable is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide

et exigible);

- FRASL is solely entitled to the Receivable and possesses the power to dispose of the Receivable;
- The Receivable is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct

on the Receivable and the Receivable is not subject to any attachment;

- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Receivable be transferred

to him;

- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,

the Receivable is freely transferable;

- All formalities required in any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of the Receivable to the

Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said contribution in kind;

- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of the Receivable to the

Company, as the case may be, have been obtained;

- The Receivable contributed to the Company is valued at two hundred twenty-six million three hundred twenty-two

thousand one hundred eighty-two British Pounds (GBP 226,322,182), and since the date hereof no material changes have
occurred which would have depreciated the value of the contribution made to the Company; and

- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable contributed to the Company have been or will be

accomplished by FRASL and upon the contribution of the Receivable by FRASL to the Company, the Company will become
the full owner of the Receivable which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."

The Management Certificate after signature “ne varietur” by the proxyholder of the Sole Shareholder, FRASL and the

undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.

FRASL and the Sole Shareholder are now referred to as the Shareholders.

<i>Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Shareholders resolve to amend the article 5.1 of the Articles, which

will henceforth read as follows:

28960

L

U X E M B O U R G

“ 5.1. The Company's corporate capital is fixed at twenty-five thousand British Pounds (GBP 25,000) represented by

one thousand two hundred fifty (1,250) shares in registered form with a nominal value of twenty British Pounds (GBP
20) each, all subscribed and fully paid-up.”

<i>Third resolution

The Shareholders resolve to amend the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes

and hereby grants power and authority to any manager of the Company to proceed on behalf of the Company with the
registration of the newly issued shares in the shareholders' register of the Company.

<i>Estimated costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately 7,000.- Euro.

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the
English version and the French version, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of the deed.
The document having been read to the proxyholder, the proxyholder signed together with Us, the notary, the present

original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour de novembre,
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

FR Acquisition Holding Corporation (Luxembourg), S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembour-

geois, dont le siège social est établi au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, disposant d'un capital social de
GBP 20.000 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.623
(l'Associé Unique),

ici représenté par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée, de résidence professionnelle à Esch-sur-Alzette,

en vertu d'une procuration donnée le sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et par

le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être enregistrée ensemble avec celui-ci.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
I. Que l'Associé Unique possède toutes les parts sociales dans le capital social de la société à responsabilité limitée

luxembourgeoise existant sous la dénomination de FR Acquisition Corporation (Luxembourg), S.à r.l., dont le siège social
se situe au 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social
de GBP 20.000, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.361 (la
Société), constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résident à Luxembourg du 25 octobre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 décembre 2007, numéro 2818. Les Statuts de la Société
(les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois le 8 novembre 2011, suivant acte de Maître Francis Kesseler, notaire
de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 16 mars 2012, numéro
705;

II. Le capital sociale de la Société est fixé à vingt mille Livres Sterling (GBP 20.000) représenté par mille (1.000) parts

sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune, toutes souscrites
et entièrement libérées;

III. Que l'ordre du jour est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société par un montant de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000), afin de porter

le capital social de son montant actuel de vingt mille Livres Sterling (GBP 20.000) représenté par mille (1.000) parts
sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune, à vingt-cinq mille
Livres Sterling (GBP 25.000) par l'émission de deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales, ayant une valeur no-
minale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes;

2. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 1. ci-dessus par un apport en

nature;

3. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social

mentionnée au point 1. ci-dessus;

4. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité

donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus;
et

28961

L

U X E M B O U R G

5. Divers.
IV. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille Livres Sterling (GBP

5.000), afin de porter le capital social de son montant actuel de vingt mille Livres Sterling (GBP 20.000) représenté par
mille (1.000) parts sociales, sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune,
à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000) par l'émission de deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales, ayant
une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes.

<i>Souscription - Paiement

Ainsi, FR Acquisition Subco (Luxembourg), S.à r.l., une société à responsabilité limitée dont le siège social est établi au

6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, disposant d'un capital social de GBP
15.000 et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 133.365
(FRASL), ici représenté par Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le
sous seing privé, ci-annexée, déclare souscrire aux deux cent cinquante (250) nouvelles parts sociales, ayant une valeur
nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20) chacune et accepte de les libérer intégralement par un apport en nature se
composant de d'une créance que FRASL détient envers la Société d'un montant total de deux cent vingt-six millions trois
cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-deux Livres Sterling (GBP 226.322.182) (la Créance) qui sera affectée comme suit:

- un montant de cinq mille Livres Sterling (GBP 5.000) au compte de capital social de la Société; et
-  un  montant  deux  cent  vingt-six  millions  trois  cent  dix-sept  mille  cent  quatre-vingt-deux  Livres  Sterling  (GBP

226.317.182) au compte de prime d'émission de la Société.

L'estimation de l'apport en nature de la Créance est démontrée par un certificat émis le 19 novembre 2014, par FRASL

et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance).

Le Certificat de Gérance atteste essentiellement que:
«- FRASL est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance;
- La Créance est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- FRASL est le seul ayant droit de la Créance et possède le droit de disposer de la Créance;
- La Créance n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance

et la Créance n'est soumise à aucun privilège;

- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance est

librement cessible;

- Toutes les formalités requises dans toute juridiction concernée à la suite de l'apport en nature de la Créance à la

Société sera effectuée dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit apport en nature;

- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance à la Société, le

cas échéant, ont été obtenues;

- La Créance apportée à la Société est estimée à deux cent vingt-six millions trois cent vingt-deux mille cent quatre-

vingt-deux Livres Sterling (GBP 226.322.182), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu
qui aurait déprécié la valeur de l'apport fait à la Société; et

- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance apportée à la Société ont été ou seront effectuées

par FRASL et dès l'apport de la Créance par FRASL à la Société, la Société deviendra pleine propriétaire de la Créance
qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois.»

Ledit certificat après signature ne varietur par le mandataire de l'Associé Unique, de FRASL et le notaire instrumentant,

restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

FRASL et l'Associé Unique sont maintenant désignés comme les Associés.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la résolution précédente, les Associés décident de modifier l'article 5.1., des Statuts de sorte qu'il

aura désormais la teneur suivante:

« 5.1. Le capital social de la Société est fixé à vingt-cinq mille Livres Sterling (GBP 25.000), représenté par mille deux

cent cinquante (1.250) parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale de vingt Livres Sterling (GBP 20)
chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.»

<i>Troisième résolution

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus

avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société afin de procéder au nom de la Société à l'enregistrement des
parts sociales nouvellement émises dans le registre des parts sociales de la Société.

28962

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société en

conséquence du présent acte sont estimés approximativement à 7.000,- euros.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le

présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, à la requête de la même partie, et en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch-sur-Alzette.
Et après lecture faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire a signé avec nous, le notaire, l'original

du présent acte.

Signé: Conde, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15810. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

<i>Le Receveur

 (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015016484/220.
(150019949) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Gattyan Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 246.268,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.190.

In the year two thousand fifteen, on the fifteenth day of January.
Before Maître Francis Kesseler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Mr. György Zoltán Gattyán, a Hungarian citizen with passport number BE0140489 valid until 16 April 2024, residing

at 3, Palatinus utca, H-1025, Budapest, Hungary (the “Sole Shareholder”);

The appearing party has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “Gattyan Group S.à r.l.” a company governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 180.190 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary dated 20 August 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2739 on 2
November 2013, amended on 12 September 2013 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2701 on 29 October 2013, further amended on 14 November 2013
pursuant to a deed of the undersigned notary, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number
560 on 3 March 2014, further amended on 13 August 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2911 on 14 October 2014, further amended on 11 No-
vember 2014 pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (hereafter referred to as the “Company”).

The share capital of the Company is currently set at two hundred forty-five thousand two hundred sixty-eight Euros

(EUR 245,268.-) represented by two hundred forty-five thousand two hundred sixty-eight (EUR 245,268.-) shares (parts
sociales), with a par value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid-up.

The appearing party, having recognized to be fully informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all

items of the following agenda:

a. Waiver of the prior convening notice;
b. Decision to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) in order

to raise it from its current amount of two hundred forty-five thousand two hundred sixty-eight Euros (EUR 245,268.-)
to two hundred forty-six thousand two hundred sixty-eight Euros (EUR 246,268.-) by creating and issuing one thousand
(1,000) new shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights and obligations as the
existing shares, together with a total share premium of one hundred two thousand seven hundred fifteen Euros eighty-
eight Cents (EUR 102,715.88) (the “New Shares”);

Subscription to and full payment of the New Shares by György Zoltán Gattyán by contribution in kind consisting of (i)

one business quota representing fifty-five point zero six per cent (55.06%) of the share capital of il Bacio Security Kft., a
Hungarian limited liability company with corporate identification number 01-09-896247, having its registered office at

28963

L

U X E M B O U R G

1101 Budapest, Expo tér 5-7 and of (ii) one business quota representing fifty per cent (50%) of the share capital of
Dunaujvarosi Jegkorong Kft., a Hungarian limited liability company with corporate identification number 07-09-012393,
having its registered office at 2400 Dunaujvaros, Koranyi S. ut 1., together as further described in a report of the board
of managers (conseil de gérance) of the Company;

c. Subsequent modification of Article 8, first paragraph of the articles of incorporation of the Company (“Capital -

Share”);

d. Miscellaneous.
The Sole Shareholder, holding the totality of the share capital of the Company, has immediately proceeded, on the

basis of the above agenda, to the adoption of the following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to waive the prior convening notice, considering himself as duly convened and declaring

having full knowledge of the purpose of the present agenda, which was communicated to him.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand Euros

(EUR 1,000.-) in order to raise it from its current amount of two hundred forty-five thousand two hundred sixty-eight
Euros (EUR 245,268.-) to two hundred forty-six thousand two hundred sixty-eight Euros (EUR 246,268.-) by creating
and issuing one thousand (1,000) New Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, having the same rights
and obligations as the existing shares, together with a total share premium of one hundred two thousand seven hundred
fifteen Euros eighty-eight Cents (EUR 102,715.88), to be fully paid up by the contribution in kind referred to below.

<i>Subscription - Payment - Allocation

The Sole Shareholder DECLARES to subscribe to the New Shares and to have them fully paid up, together with share

premium, by contribution in kind consisting of (i) the business quota representing fifty-five point zero six per cent (55.06%)
of the share capital of il Bacio Security Kft. and of (ii) the business quota representing fifty per cent (50%) of the share
capital of Dunaujvarosi Jegkorong Kft., both as mentioned above (the “Contribution in Kind”).

The net value of the Contribution in Kind is valued at one hundred three thousand seven hundred fifteen Euros eighty-

eight Cents (EUR 103,715.88).

Such valuation has been approved by the management of the Company pursuant to a valuation report dated 15 January

2015 (hereinafter referred to as the “Company's Report”), signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned
notary and which shall remain annexed to this deed.

The contribution of the Contribution in Kind from the Sole Shareholder to the Company is fully permitted, who also

received prior confirmation on the ownership of the contributed business quota of il Bacio Security Kft. and Dunaujvarosi
Jegkorong Kft.

The amount of one hundred three thousand seven hundred fifteen Euros eighty-eight Cents (EUR 103,715.88) is

allocated as follows:

- an amount of one thousand Euros (EUR 1,000.-) to be allocated to the nominal share capital account of the Company;

and,

- an amount of one hundred two thousand seven hundred fifteen Euros eighty-eight Cents (EUR 102,715.88) to be

allocated to the share premium reserve account of the Company.

<i>Third resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of Article

8 of the articles of association of the Company (“Capital - Share”), so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 8. The Company's share capital is fixed at two hundred forty-six thousand two hundred sixty-eight Euros (EUR

246,268) represented by two hundred forty-six thousand two hundred sixty-eight (246,268) shares (parts sociales) with
a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, all fully subscribed and entirely paid up”.

There being no further item on the agenda, the meeting was closed.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states that on request of the parties hereto, the present

deed was drafted in English, followed by a French version; at the request of the same appearing person(s) and in case of
discrepancies between the English and the French version, the English version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
After reading these minutes, the person appearing signed together with the notary the present deed.

Suit la version française de l'acte qui précède:

L'an deux mille quinze, le quinze janvier.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

28964

L

U X E M B O U R G

A COMPARU:

M. György Zoltán Gattyán, un citoyen hongrois avec numéro de passeport BE0140489 valable jusqu'au 16 avril 2024,

demeurant au 3, Palatinus utca, H-1025, Budapest, Hongrie (l'«Associé Unique»).

La partie comparante a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est l'Associé Unique d'une société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Gattyan Group

S.à r.l.», régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 180.190 et constituée suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-
sur-Alzette en date du 20 août 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2739 du 2
novembre 2013, les statuts de la Société ayant été modifiés le 12 septembre 2013 suivant un acte du notaire soussigné,
publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  numéro  2701  du  29  octobre  2013,  puis  modifiés  le  14
novembre 2013 suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
560 du 3 mars 2014, encore modifiés le 13 août 2014 suivant un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations, numéro 2911 du 14 octobre 2014, encore modifiés le 11 novembre 2014 suivant un acte
du notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après désignée comme
la «Société»).

Le capital social de la Société s'élève actuellement à deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-huit Euros

(245.268,- EUR), représenté par deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-huit (245.268) parts sociales d'une
valeur d'un Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

La partie comparante, ayant reconnu être dûment informée des résolutions à prendre, a décidé de voter sur tous les

points de l'agenda reproduit ci-après:

a. Renonciation à la convocation préalable;
b. Décision d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille Euros (1.000,- EUR) afin d'augmenter le

capital de son montant actuel de deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-huit Euros (245.268,- EUR) pour
atteindre la somme de deux cent quarante-six mille deux cent soixante-huit Euros (246.268,- EUR) par l'émission de mille
(1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, ayant les mêmes droits et obli-
gations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission de cent deux mille sept cent quinze Euros quatre-
vingt-huit centimes (102.715,88 EUR) (les “Nouvelles Parts Sociales”);

Souscription et paiement intégral des Nouvelles Parts Sociales par György Zoltán Gattyán par un apport en nature

consistant en (i) un «business quota» représentant cinquante-cinq virgule zéro six pour cent (55,06%) du capital social
d'il  Bacio  Security  Kft.,  une  société  hongroise,  ayant  son  siège  social  en  Hongrie,  à  1101  Budapest,  Expo  tér  5-7  et
immatriculée auprès du registre des sociétés local sous le numéro 01-09-896247 et en (ii) un «business quota» repré-
sentant cinquante pour cent (50%) du capital social de Dunaujvarosi Jegkorong Kft., une société hongroise, ayant son
siège social en Hongrie, à 2400, Dunaujvaros, Koranyi S. ut 1. et immatriculée auprès du registre des sociétés local sous
le numéro 07-09-012393, tels que décrits dans un rapport du conseil de gérance de la Société;

c. Modification subséquente du premier paragraphe de l'Article 8 des statuts de la Société (“Capital - Parts Sociales”);
d. Divers.
L'Associé Unique, détenteur de la totalité du capital social de la Société, a immédiatement procédé, sur base de l'agenda

repris ci-dessus, à l'adoption des résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique DECIDE de renoncer à la convocation préalable, se considérant dûment convoqué et déclarant avoir

entière connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique DECIDE d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de mille Euros (1.000,- EUR) afin

d'augmenter le capital de son montant actuel de deux cent quarante-cinq mille deux cent soixante-huit Euros (245.268,-
EUR)  pour  atteindre  la  somme  de  deux  cent  quarante-six  mille  deux  cent  soixante-huit  Euros  (246.268,-  EUR)  par
l'émission de mille (1.000) nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale d'un Euro (1,- EUR) chacune, ayant les
mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, avec une prime d'émission de cent deux mille sept cent
quinze Euros quatre-vingt-huit centimes (102.715,88 EUR), à libérer intégralement par un apport en nature tel que men-
tionné ci-dessous.

<i>Souscription - Paiement - Allocation

L'Associé Unique DECLARE souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et au fait de les libérer entièrement, avec prime

d'émission, par un apport en nature consistant en l'apport (i) d'un «business quota» représentant cinquante-cinq virgule
zéro six pour cent (55,06%) du capital social d'il Bacio Security Kft. et (ii) d'un «business quota» représentant cinquante
pour cent (50%) du capital social de Dunaujvarosi Jegkorong Kft., tels que susmentionnés (l'«Apport en Nature»).

La valeur de l'Apport en Nature  est  évaluée  à cent  trois  mille sept cent  quinze Euros quatre-vingt-huit  centimes

(103.715,88 EUR).

28965

L

U X E M B O U R G

Cette évaluation de l'Apport en Nature a été approuvée par la gérance de la Société par le biais d'un rapport d'éva-

luation en date du 15 janvier 2015 (ci-après le «Rapport de la Société»), signé “ne varietur” par la partie comparante, et
par le notaire soussignant, lequel sera joint au présent acte.

L'apport de l'Apport en Nature de l'Associé Unique à la Société est pleinement autorisé et rendu possible, en sus de

la confirmation préalable que ce-dernier a obtenu quant à la propriété des «business quota» apportés d'il Bacio Security
Kft. et de Dunaujvarosi Jegkorong Kft.

Le montant de cent trois mille sept cent quinze Euros quatre-vingt-huit centimes (103.715,88 EUR) est alloué comme

décrit ci-dessous:

- un montant de mille Euros (1.000,- EUR) est alloué au compte capital social de la Société; et,
- un montant de cent deux mille sept cent quinze Euros quatre-vingt-huit centimes (102.715,88 EUR) est alloué au

compte réserve prime d'émission de la Société.

<i>Troisième résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'Associé Unique DECIDE de modifier le premier paragraphe de l'Article

8 des statuts de la Société (“Capital - Parts Sociales”), qui aura désormais la teneur suivante:

“ 8. Le capital social de la Société est fixé à deux cent quarante-six mille deux cent soixante-huit Euros (246.268,- EUR)

représenté par deux cent quarante-six mille deux cent soixante-huit (246.268) parts sociales d'une valeur nominale d'un
Euro (1,- EUR) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées”.

Compte tenu qu'il n'y a plus d'autres points à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.
Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande des/de la partie(s) com-

parante(s), le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête des/de la même(s)
partie(s), en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été donnée à la partie comparante, cette-dernière a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Gattyán, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1592. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur ff. (signé): M. Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2015016496/179.
(150019924) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Choreo A.s.b.l., Association sans but lucratif.

Siège social: L-6585 Steinheim, 2, op Maeleck.

R.C.S. Luxembourg F 10.270.

STATUTEN

Im Jahre zweitausend und vierzehn, den 22. Dezember

sind erschienen:

1. Danielle Schmit-Back, geboren am 18.04.1974, wohnhaft in: 2 op Maeleck, L-6585 Steinheim,
2. Fabienne Boes, geboren am 02.07.1986, wohnhaft in: 27, rue de la Montagne, L-6586 Steinheim
3. Sven Tielemans, geboren am 26.11.1991, wohnhaft in: in Badlien 43, D-54668 Echternacherbrück,
Welche hiermit eine Vereinigung ohne Gewinnzweck (A.s.b.l.) gründen möchten, die dem Gesetz vom 21. April 1928

sowie den aufgestellten Statuten unterliegt.

Titel 1. Name, Sitz, Zweck, Dauer

Art. 1. Die Vereinigung führt den Namen "CHOREO A.s.b.l."

Art. 2. Die Vereinigung hat ihren Sitzt in Steinheim. Der Sitz kann jederzeit in eine andere Ortschaft des Großher-

zogtums verlegt werden, dies mittels eines Beschlusses der Generalversammlung der Vereinigung.

Art. 3. Die Vereinigung bezweckt folgendes:
- Das Lehren, Erlernen und Trainieren der Tanzkunst und alles was dazu gehört, wie z.b. Teilnahmen und Ausrichtung

von Wettbewerben, öffentliche Vorstellungen u.s.w.

- das Lehren und einhalten von Teamgeist und Respekt gegenüber den Kollegen usw.
- Förderung von Tanz, Fitness, Beweglichkeit, und Körperkontrolle.

Art. 4. Die Dauer der Vereinigung ist unbegrenzt.

28966

L

U X E M B O U R G

Titel 2. Mitgliedschaft

Art. 5. Die Zahl der Mitglieder ist unbegrenzt, darf jedoch nicht unter 3 sinken. Mitglied kann jeder werden, der die

Grundsätze der Vereinigung anerkennt, sowie ihre Richtlinien zur Mitgliedschaft. Vereinigungen des privaten Rechts kön-
nen ebenso Mitglied werden, wenn diese mit dem oben genannten Zweck vereinbar sind. Über die Aufnahme neuer
Mitglieder entscheidet intern der Verwaltungsrat. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft
als Mitglieder aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Für die Verbindlichkeiten der Vereinigung haftet
ausschließlich das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der Mitglieder besteht nicht. Gesetzliche Haftungsvors-
chriften, insbesondere aus Fahrlässigkeiten, bleiben hiervon unberührt.

Art. 6. Die Mitgliedschaft endet durch folgende Ereignisse:
a. Ausschluss durch die Generalversammlung, wenn die Übereinstimmung mit Artikel 3 nicht mehr gegeben ist;
b. Freiwillige Kündigung;
c. Tod;
d. Nichtbezahlen des Beitrags nach einmonatigem Zahlungsverzug.
e. Ausschluss eines Mitgliedes durch den Verwaltungsrat bei statutenwidrigem Verhalten welches der Vereinigung und

dessen Ansehen schadet (z.b aggressives Verhalten in der Öffentlichkeit) Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder
können keinerlei Ansprüche auf die Rückzahlung ihrer Beiträge oder auf das Vermögen der Vereinigung geltend machen.
Mitglieder, welche der Satzung, den Regeln und den Weisungen der Vereinigung zuwiderhandeln oder sich in ihrer Funk-
tion  nicht  voll  einsetzen,  können  von  der  Generalversammlung  ausgeschlossen  werden.  Die  Generalversammlung
entscheidet mit einer 2/3 Mehrheit der abgegebenen Stimmen über den endgültigen Ausschluss. Die Generalversammlung
ist nicht zur Bekanntgabe der Gründe verpflichtet.

Titel 3. Der Verwaltungsrat

Art. 7. Die Vereinigung wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat wird von der Generalversamm-

lung, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, mit absoluter Stimmenmehrheit, auf unbestimmte Dauer gewählt.

Der Verwaltungsrat besteht aus minimal 3 Vereinsmitgliedern, und zwar aus:
a) dem Präsidenten
b) dem Sekretär
c) dem Kassierer
Die Funktionen des Kassierers und des Sekretärs können auch als Zweitfunktion von dem Präsidenten übernommen

werden.

Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied vorzeitig aus oder ist ein Mitglied des Verwaltungsrates nicht in der Lage sein

Amt bis zur nächsten Generalversammlung weiterzuführen oder sind sonst dringende Gründe vorhanden, ein weiteres
Verwaltungsratsmitglied zu bestellen, kann die Generalversammlung mit absoluter Stimmenmehrheit ein weiteres Ve-
reinsmitglied zum Verwaltungsratsmitglied ernennen.

Das Amt des so ermittelten Verwaltungsratsmitgliedes endet mit dem Ende der nächsten ordentlichen Generalver-

sammlung.

Alle Austretenden sind wiederwählbar, sofern diese es wollen.
Verwaltungsratsmitglieder sind von der Mitgliedsbeitragspflicht befreit. Des Weiteren kann der Verwaltungsrat Mit-

glieder, die sich anderwärtig für den Verein einsetzen, vom Mitgliedsbeitrag befreien.

Dem Verwaltungsrat obliegt die Leitung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben und Geschäfte zuständig, die nicht durch

die Satzung oder einen Beschluss des Gesamtvorstandes einem anderen Organ der Vereinigung oder einem Verwal-
tungsratsmitglied zugewiesen oder durch Gesetz und Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Art. 8. Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten oder auf Antrag von mindestens zwei Mit-

gliedern des Verwaltungsrates.

Die Sitzung wird vom Präsidenten geleitet. Jede ordnungsgemäß einberufene Verwaltungsratsversammlung ist bes-

chlussfähig, ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder.

Die Beschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten, das vom Vorsitzenden der Versammlung und einem von ihm

ernannten Schriftführer zu unterzeichnen ist. Bei der Abstimmung entscheidet die Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

Bei Stimmengleichheit zählt die Stimme des Präsidenten doppelt.
Der Präsident wird im Falle seiner Verhinderung durch einem von Ihm gewählten Verwaltungsmitglied vertreten. Das

vom Präsidenten gewählte Verwaltungsmitglied darf von seinem Vertretungsrecht nur Gebrauch machen, wenn der Prä-
sident tatsächlich oder rechtlich verhindert ist. Im Verhältnis nach außen ist die Vertretungsberechtigung jedoch auch
dann gültig, wenn ein Verhinderungsfall nicht vorgelegen haben sollte.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für alle administrativen und finanziellen Belange der Vereinigung. Er ist die Exekutive

der Generalversammlung in Übereinstimmung mit dem Zweck ihrer Gründung.

Der Verwaltungsrat legt den Mitgliedsbeitrag laut (Kurs-) Teilnahme fest.

28967

L

U X E M B O U R G

Die Führung der Geschäfte der Vereinigung wird vom Präsidenten des Verwaltungsrates übernommen. Der Präsident

ist allein zeichnungs- und vertretungsberechtigt.

Titel 4. Generalversammlung

Art. 9. Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Vereins. Die ordentliche Generalversammlung findet jähr-

lich statt. Die ordentliche Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat mindestens 7 Tage vor dem Termin unter
Bekanntgabe der Tagesordnung mit einfachem Brief einberufen. Die Frist beginnt an dem Datum der Absendung des
Einladeschreibens folgenden Werktag. Die Tagesordnung setzt der Verwaltungsrat fest. Sie ist beschlussfähig wenn min-
destens 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. Ist das nicht der Fall, kann anschließend eine außerordent-
liche  Generalversammlung  einberufen  werden,  welche  in  jedem  Fall  beschlussfähig  ist.  Das  Mindestalter  zur
Wahlberechtigung des Mitgliedes in der Generalversammlung beträgt 18 Jahre. Mitglieder, die das Mindestalter noch nicht
erreicht haben, können durch ihren gesetzlichen Vormund vertreten werden. Jedes Mitglied verfügt über eine Stimme.

Entschuldigte können sich aber durch Vollmacht vertreten lassen. Der Verwaltungsrat kann jederzeit eine außeror-

dentliche Generalversammlung einberufen. Für die Einberufung der außerordentlichen Generalversammlung gelten die
Vorschriften über die Einberufung der ordentlichen Generalversammlung.

Art. 10. Der Mitgliederversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a) Entgegennahme und Genehmigung des Jahresberichts des Verwaltungsrates
b) Befund über das Budget, die Kassenführung, Wahl des Kassenrevisors und Abstimmung (über eine eventuelle Au-

flösung)

c) Entlastung des Verwaltungsrates
d) Die Wahl der Verwaltungsratsmitglieder
e) Die Entscheidung betreffend den Ausschluss von Mitgliedschaften
f) Die Beschlussfassung über Änderungen der Statuten und die freiwillige Auflösung des Vereins
g) Die Beratung und die Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehenden Fragen. Die Art der Bes-

chlussfassung bestimmt der Verwaltungsrat. Beschlüsse über Punkte außerhalb der Tagesordnung können nur gefasst
werden, wenn 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder es so beschließen.

Die Beschlüsse der Generalversammlung werden in einem Register festgehalten und alle Interessierten auf Nachfrage

bei einem der 3 Vorstandsmitglieder.

Anträge der Mitglieder zur Tagesordnung sind spätestens sieben Tage vor dem Versammlungstermin dem Verwal-

tungsrat schriftlich einzureichen. Abänderung der Statuten können nur durch die Generalversammlung erfolgen, wenn
2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind.

Anorderungen müssen bei der Einberufung der Generalversammlung aufgeführt sein, ist dies nicht der Fall kann eine

außerordentliche Generalversammlung sich anschließen, bei der die Hälfte der Mitglieder ausreichen.

Bei Wahlen ist gewählt, wer die meisten stimmberechtigten Stimmen erreicht. Bei Stimmengleichheit hat eine Stichwahl

stattzufinden.

Die Generalversammlung wird vom Präsident, vom Vizepräsident oder einem von der Generalversammlung gewählten

Vorsitzenden geleitet.

Titel 5. Internes Reglement

Art. 11. Die Generalversammlung kann ein internes Reglement stimmen, welches Aspekte der Vereinigung regelt die

nicht in den Statuten inbegriffen sind. Dazu sowie zur Änderung eines bestehenden Reglements müssen 2/3 der stimm-
berechtigten Mitglieder anwesend sein.

Art. 12. Die Schaffung oder die Änderung eines Reglements werden den Mitgliedern der Vereinigung schriftlich von

dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Jedes Mitglied kann dem Verwaltungsrat seine Vorschläge zur Schaffung oder Änderung
des Reglements mitteilen, über die in der Generalversammlung abgestimmt wird.

Titel 6. Kassenführung

Art. 13. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. Januar und endet am 31.Dezember des jeweiligen Jahres.

Art. 14. Die Vereinigung hat über sämtliche Einnahmen und Ausgaben ordnungsgemäß Bücher zu führen und Jahre-

sabschlüsse nach kaufmännischen Grundsätzen zu erstellen und vom Kassenrevisor zu prüfen.

Titel 7. Auflösung

Art. 15. Die Auflösung des Vereins kann erfolgen:
a) in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen
b) wenn die Zahl der Mitglieder unter drei sinkt
c) durch Beschluss der Generalversammlung. Dazu müssen 2/3 der stimmberechtigten Mitglieder anwesend sein.
Ist dies nicht der Fall reicht eine außerordentliche Generalversammlung mit der Hälfte der stimmberechtigten Mit-

glieder, die in jedem Fall beschlussfähig ist. Der Beschluss muss allerdings mit 2/3 Mehrheit erfolgen.

28968

L

U X E M B O U R G

Im Falle der Auflösung des Vereins erfolgt die Abwicklung durch den Präsidenten als alleinvertretungsberechtigten

Liquidator, sofern die Generalversammlung nicht einen oder mehrere andere Liquidatoren bestellt.

Die Rechte und Pflichten des oder der Liquidatoren bestimmen sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetz-

buches über die Liquidation einer Vereinigung.

Im Fall einer Auflösung der Vereinigung wird das Vermögen in eine Vereinigung übergehen, die einen ähnlichen Zweck

verfolgt.

Titel 8. Schlussbestimmung

Art. 16. Schlussbestimmung.
Für alle in diesen Statuten nicht vorgesehenen Punkte, berufen und beziehen sich die Gründungsmitglieder auf die

Bestimmungen des Gesetzes über die Vereinigungen und Stiftungen ohne Gewinnzweck vom 21.April 1928, und dessen
Abänderungen und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Komparenten, haben dieselbe gegenwärtige Satzung un-
terschrieben.

Back-Schmit Danielle geboren am 18.04.1974, wohnhaft in 2, op Maeleck, L-6585 Steinheim.
Boes Fabienne geboren am 02.07.1986, wohnhaft in 27, rue de la Montagne, L-6586 Steinheim.
Tielemans Sven geboren am 26.11.1991, wohnhaft in in Badlien, 43 D-54668 Echternacherbrück.

Steinheim, den 22.12.2014.

Référence de publication: 2015016400/151.
(150019507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Digital Services XXXIII (GP) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 194.053.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

THERE APPEARED:

Digital Services XXXIII S.àr.l., a société à responsabilité limitée incorporated and organised under Luxembourg law,

having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg, in the process of being
registered with the Trade and Companies Register in Luxembourg;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Luxembourg on 7 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital Services XXXIII (GP) S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may also act as a partner with unlimited or limited liability for the debts and obligations of any

Luxembourg or foreign entity.

28969

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,

28970

L

U X E M B O U R G

each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company's

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company's share capital.

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager

28971

L

U X E M B O U R G

in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

28972

L

U X E M B O U R G

20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company's first financial year.

<i>Subscription and payment

The  twelve  thousand  five  hundred  (12,500)  shares  issued  have  been  subscribed  by  Digital  Services  XXXIII  S.àr.l.,

aforementioned, for the price of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five hundred

euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) is entirely allocated to the

share capital.

28973

L

U X E M B O U R G

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Digital Services XXXIII S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) nach dem

Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, und
deren Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister noch aussteht.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 7

Januar 2015, ausgestellt in Luxembourg.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXIII (GP) S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom
10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung
unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

28974

L

U X E M B O U R G

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann auch als Gesellschafterin für die Schulden und Verpflichtungen jeglicher luxemburgischen

und ausländischen Gesellschaft mit unbeschränkter oder beschränkter Haftung handeln.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in der Stadt Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) aufgeteilt in zwölf-

tausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-

28975

L

U X E M B O U R G

stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

28976

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-

28977

L

U X E M B O U R G

fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

28978

L

U X E M B O U R G

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die zwölftausendfünfhundert (12.500) ausgegebenen Anteile wurden durch Digital Services XXXIII S.àr.l. vorbenannt,

zum Preis von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen
wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:
- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

28979

L

U X E M B O U R G

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/713. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé) I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 30. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015016423/590.
(150019613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Woonfonds Holding 2A S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 194.056.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the sixteenth day of January.
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Round  Hill  Dutch  Residential  Investment  SCS,  a  Luxembourg  special  limited  partnership  (société  en  commandite

spéciale), having its registered office at 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register),
under number B 187 247, duly represented by its manager Round Hill Dutch Residential Investment GP S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), having its registered office at
1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg (Luxembourg Trade and Companies Register) under number B 186 819,

here represented by Mr Max MAYER, employee, professionally residing in Junglingster, by virtue of a proxy substituted

to him.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

“Woonfonds Holding 2A S.à r.l.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and any interests,

in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities or enterprises and in any other
form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale,
exchange or otherwise of securities or financial instruments or assets of any kind and the ownership, administration,
management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 An additional purpose of the Company is the acquisition and sale of real estate properties either in the Grand

Duchy of Luxembourg or abroad, including by way of the direct or indirect holding of participations in Luxembourg or
foreign companies, the principal object of which is the acquisition, development, promotion, sale, management and/or
lease of real estate properties.

28980

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is incorporated for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), represented by twelve

thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders representing three quarters of the rights owned by
the surviving shareholders. Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

28981

L

U X E M B O U R G

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter and
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments to the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration, if any, and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by  the  remaining  managers  until  the  next  meeting of  shareholders which shall resolve  on  the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

28982

L

U X E M B O U R G

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to partici-
pation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall [not] have a casting vote.

17.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. Copies or excerpts of such minutes,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2)
managers.

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers,
or (ii) by the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated
by the board of managers within the limits of such delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28983

L

U X E M B O U R G

22.2 Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This

allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per
cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees to such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Dissolution.
24.1 The Company may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the sole shareholder

or, in case of plurality of the shareholders, by a resolution of the general meeting of shareholders by a resolution taken
by a vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy five (75%) percent of the share capital of the
Company.

24.2 The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any

shareholder.

Art. 25. Liquidation.
25.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 24 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

25.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Final clause - Governing law

Art. 26. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

All the twelve thousand five hundred (12,500) shares issued have been subscribed by Round Hill Dutch Residential

Investment SCS, aforementioned, for the total amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500).

The shares so subscribed have been fully paid up by a contribution in cash so that the amount of twelve thousand five

hundred euro (EUR 12,500) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,250.-

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has passed the following resolutions:

28984

L

U X E M B O U R G

1. The address of the registered office of the Company is set at 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand

Duchy of Luxembourg.

2. The following persons are appointed as managers of the Company for an unlimited term:

(i) Kemal Akyel, born in Beringen (Belgium) on June 2 

nd

 , 1977, professionally residing at 1, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

(ii) Jennika Lindholm, born in Berlin (Germany) on March 16 

th

 , 1981, professionally residing at 1, boulevard de la

Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

Whereof the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day specified at the beginning of this document.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same appearing party and in case of
divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L’an deux mille quinze, le seizième jour du mois de janvier.
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Round Hill Dutch Residential Investment SCS, une société en commandite spéciale constituée et existante selon les

lois de Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 187.247, dûment représentée par son gérant Round Hill Dutch Residential Investment GP, une société à responsabilité
limitée, constituée et existante selon les lois de Grand-Duché de Luxembourg, avec un capital social de douze mille cinq
cents euros (EUR 12.500.-) ayant son siège social au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186.819,

ici représenté(e) par Monsieur Max MAYER, résidant professionnellement à Junglinster, en vertu d’une procuration

lui substituée.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire, restera annexée au

présent acte pour être enregistrée en même temps aux autorités d’enregistrement.

La partie comparante a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d’une société à responsabilité

limitée qu'il souhaite constituer avec les statuts suivants:

A. Nom - Objet - Durée - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom - Forme légale.  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Woonfonds Holding

2A S.à r.l.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle
que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. Objet.
2.1 La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et d’intérêts, sous

quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou autres entités commerciales ou entre-
prises, et de toute autre forme d’investissement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même
que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières, instruments financiers ou actifs de tout
type, ainsi que la détention, l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de son portefeuille.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière

des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit
ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut, excepté par voie d’appel publique à l'épargne, lever des fonds en faisant des emprunts sous toute

forme ou en émettant toute sorte d’obligations, de titres ou d’instruments de dettes, d’obligations garanties ou non
garanties, et d’une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

2.4 Un objet supplémentaire de la Société est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au Grand-Duché de

Luxembourg soit ailleurs, y compris par le biais de détention directe ou indirecte de participations dans des sociétés à
Luxembourg ou étrangères, l'objet principal est l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou
la location de biens immobiliers.

2.5 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété

intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

Art. 3. Durée. La Société est constituée pour une durée illimitée.

28985

L

U X E M B O U R G

Art. 4. Siège social.
4.1 Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Dans la même commune, le siège social peut être transféré au moyen d’une décision du conseil de gérance. Il peut

être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d’une décision de l'assemblée
générale des associés, adoptée selon les conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par

décision du conseil de gérance.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil de gérance estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, éco-

nomique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec les
activités normales de la Société à son siège social, le siège social pourra transférer provisoirement à l'étranger jusqu'à la
cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la
nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera une société Luxembourgeoise.

B. Capital social - Parts sociales

Art. 5. Capital social.
5.1 Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille

cinq cents (12.500) parts sociales ayant une valeur nominale d’un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des associés

de la Société, adoptée selon les modalités requises pour la modification des présents statuts.

5.3 La Société peut racheter ses propres parts sociales.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Le capital social de la Société est divisé en parts sociales ayant chacune la même valeur nominale.
6.2 Les parts sociales de la Société sont nominatives.
6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs associés, avec un nombre maximal de quarante (40) associés.
6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire

concernant l'un des associés n’entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 7. Registre des parts sociales - Transfert des parts sociales.
7.1 Un registre des parts sociales est tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque associé

pour inspection. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. Des certificats de cet enregistrement
peuvent être émis sur demande et aux frais de l'associé demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par part sociale. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant

unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs
à cette part sociale, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
7.4 Inter vivos, les parts sociales seront uniquement transférables à de nouveaux associés sous réserve qu'une telle

cession ait été approuvée par les associés représentant une majorité des trois quarts du capital social.

7.5 Toute cession de parts sociales est opposable à la Société et aux tiers sur notification de la cession à, ou après

l'acceptation de la cession par la Société conformément aux dispositions de l'article 1690 du Code civil.

7.6 En cas de décès, les parts sociales de l'associé décédé pourront être uniquement transférées au nouvel associé

sous réserve qu'un tel transfert ait été approuvé par les associés survivants représentant les trois quarts des droits des
survivants. Un tel agrément n’est cependant pas requis dans l'hypothèse où les parts sociales sont transférées soit aux
ascendants, descendants ou au conjoint survivant ou à tout autre héritier légal de l'associé décédé.

C. Décisions des associés

Art. 8. Décisions collectives des associés.
8.1 L'assemblée générale des associés est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par

les présents statuts.

8.2 Chaque associé a la possibilité de participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts sociales qu'il

détient.

8.3 Dans l'hypothèse où et tant que la Société n’a pas plus de vingt-cinq (25) associés, des décisions collectives qui

relèveraient  d’ordinaire  de  la  compétence  de  l'assemblée  générale,  pourront  être  valablement  adoptées  par  voie  de
décisions écrites. Dans une telle hypothèse, chaque associé recevra le texte de ces résolutions ou des décisions à adopter
expressément formulées et votera par écrit.

8.4 En cas d’associé unique, cet associé exercera les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés en vertu des

dispositions de la section XII de la Loi et des présents statuts. Dans cette hypothèse, toute référence faite à «l'assemblée
générale des associés» devra être entendue comme une référence à l'associé unique selon le contexte et le cas échéant
et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés seront exercés par l'associé unique.

28986

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Assemblées générales des associés. Dans l'hypothèse où la Société aurait plus de vingt-cinq (25) associés, une

assemblée générale des associés devra être tenue au minimum dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social au
Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel que précisé dans la convocation [à cette assemblée
générale. D’autres assemblées générales d’associés pourront être tenues aux lieux et heures indiquées dans les convo-
cations [aux assemblées générales] correspondantes. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée
générale des associés et renoncent aux formalités de convocation, l'assemblée pourra être tenue sans convocation ou
publication préalable.

Art. 10. Quorum et vote.
10.1 Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il détient.
10.2 Sous réserve d’un quorum plus élevé prévu par les présents statuts ou la Loi, les décisions collectives des associés

de la Société ne seront valablement adoptées que pour autant qu'elles auront été adoptées par des associés détenant
plus de la moitié du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés
peuvent être convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées avec le même agenda et les décisions
sont valablement prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 11. Changement de nationalité. Les associés ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consente-

ment unanime des associés.

Art. 12. Modification des statuts. Toute modification des statuts requiert l'accord d’une (i) majorité des associés (ii)

représentant au moins les trois quarts du capital social.

D. Gérance

Art. 13. Pouvoirs du gérant unique - Composition et pouvoirs du conseil de gérance.
13.1 La Société peut être gérée par un ou plusieurs gérants. Si la Société a plusieurs gérants, les gérants forment un

conseil de gérance.

13.2 Lorsque la Société est gérée par un gérant unique, le cas échéant et lorsque le terme «gérant unique» n’est pas

expressément mentionné dans ces statuts, une référence au «conseil de gérance» dans ces statuts devra être entendue
comme une référence au «gérant unique».

13.3 Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre

toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés
par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des associés.

Art. 14. Nomination, révocation des gérants et durée du mandat des gérants.
14.1 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui détermine sa (leur) rémunération,

le cas échéant, et la durée de son (leur) mandat.

14.2 Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) et peu(ven)t être librement révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif,

par une décision des associés représentant plus de la moitié du capital social de la Société.

Art. 15. Vacance d’un poste de gérant.
15.1 Dans l'hypothèse où un poste de gérant deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, la faillite, la

démission ou pour tout autre motif, cette vacance peut être pourvue de manière temporaire et pour une période ne
pouvant excéder celle du mandat initial du gérant remplacé par les gérants restants jusqu'à la prochaine assemblée des
associés appelée à statuer sur la nomination permanente, conformément aux dispositions légales applicables.

15.2 Dans l'hypothèse où la vacance survient alors que la Société est gérée par un gérant unique, cette vacance est

comblée sans délai par l'assemblée générale des associés.

Art. 16. Convocation aux réunions du conseil de gérance.
16.1 Le conseil de gérance se réunit sur convocation de tout gérant. Les réunions du conseil de gérance sont tenues

au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation à la réunion.

16.2 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance doit être donné aux gérants au minimum vingt-quatre (24)

heures à l'avance par rapport à l'heure fixée dans la convocation, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature et les motifs
d’une telle urgence seront mentionnées dans la convocation. Une telle convocation peut être omise en cas d’accord écrit
de chaque gérant, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Une copie d’un tel
document signé constituera une preuve suffisante d’un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour un
conseil de gérance dont le lieu et l'heure auront été déterminés par une décision adoptée lors d’un précédent conseil de
gérance, communiquée à tous les membres du conseil de gérance.

16.3 Aucune convocation préalable ne sera requise dans l'hypothèse où tous les gérants seront présents ou représentés

à un conseil de gérance et renonceraient aux formalités de convocation ou dans l'hypothèse de décisions écrites et
approuvées par tous les membres du conseil de gérance.

28987

L

U X E M B O U R G

Art. 17. Conduite des réunions du conseil de gérance.
17.1 Le conseil de gérance peut élire un président du conseil de gérance parmi ses membres. Il peut également désigner

un secrétaire, qui peut ne pas être membre du conseil de gérance et qui sera chargé de tenir les procès-verbaux des
réunions du conseil de gérance.

17.2 Le président du conseil de gérance, le cas échéant, préside toutes les réunions du conseil de gérance. En son

absence, le conseil de gérance peut nommer provisoirement un autre gérant comme président temporaire par un vote
à la majorité des voix présentes ou représentées à la réunion.

17.3 Tout gérant peut se faire représenter à toute réunion du conseil de gérance en désignant tout autre gérant comme

son mandataire par écrit, ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie du
mandat  en  constituant  une  preuve  suffisante.  Un  gérant  peut  représenter  un  ou  plusieurs,  mais  non  l'intégralité  des
membres du conseil de gérance.

17.4 Les réunions du conseil de gérance peuvent également se tenir par téléconférence ou vidéoconférence ou par

tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes y participant de s'entendre mutuellement
sans discontinuité et garantissant une participation effective à cette réunion. La participation à une réunion par ces moyens
équivaut à une participation en personne et la réunion tenue par de tels moyens de communication est réputée s’être
tenue au siège social de la Société.

17.5 Le conseil de gérance ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins la majorité de ses membres est

présente ou représentée à une réunion du conseil de gérance.

17.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés à chaque réunion du conseil

de gérance. Le président du conseil de gérance, le cas échéant, ne dispose pas d’une voix prépondérante.

17.7 Le conseil de gérance peut, à l'unanimité, prendre des décisions par voie circulaire en exprimant son approbation

par écrit, par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication. Chaque gérant peut exprimer
son consentement séparément, l'ensemble des consentements attestant de l'adoption des décisions. La date de ces dé-
cisions sera la date de la dernière signature.

Art. 18. Procès-verbaux des réunions du conseil de gérance; procès-verbaux des décisions du gérant unique.
18.1 Les procès-verbaux de toutes les réunions du conseil de gérance seront signés par le président, le cas échéant,

ou, en son absence, par le président temporaire, et le secrétaire, le cas échéant, ou par deux (2) gérants. Les copies ou
extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou autre seront, le cas échéant, signés par le président
ou par deux (2) gérants.

18.2 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront
signés par le gérant unique.

Art. 19. Rapports avec les tiers. La Société sera valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par

la signature du gérant unique, ou, si la Société a plusieurs gérants, par la signature conjointe de deux (2) gérants, ou (ii)
par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature
aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de cette délégation.

E. Audit et surveillance

Art. 20. Commissaire(s) - réviseur(s) d'entreprises agréé(s).
20.1 Dans l'hypothèse où, et tant que la Société aura plus de vingt-cinq (25) associés, les opérations de la Société

seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des associés désigne les commissaires et dé-
termine la durée de leurs fonctions.

20.2 Un commissaire pourra être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des

associés.

20.3 Le commissaire a un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.
20.4 Si les associés de la Société désignent un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69

de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire sera supprimée.

20.5 Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des associés que pour juste motif

ou avec son accord.

F. Exercice social - Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes

Art. 21. Exercice social. L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine

le trente-et-un décembre de la même année.

Art. 22. Comptes annuels - Distribution des bénéfices.
22.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil de gérance dresse un inventaire de

l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes, conformément à la loi.

28988

L

U X E M B O U R G

22.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette

affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix
pour cent (10%) du capital social de la Société.

22.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un associé peuvent également être affectées à la réserve

légale, si cet associé consent à cette affectation.

22.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle

n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

22.5 Sur proposition du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décide de l'affectation du solde des

bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

22.6 Les distributions aux associés sont effectuées en proportion du nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans

la Société.

Art. 23. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.
23.1 Le conseil de gérance peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes sur la base d’un état comptable

intermédiaire préparé par le conseil de gérance et faisant apparaître que des fonds suffisants sont disponibles pour être
distribués. Le montant destiné à être distribué ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice
social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminués des pertes reportées et des sommes
destinées à être affectées à une réserve dont la Loi ou les présents statuts interdisent la distribution.

23.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux associés

conformément à la Loi et aux présents statuts.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Dissolution.
24.1. La Société peut être dissoute à tout moment, avec ou sans cause, par une résolution de l'associé unique ou, en

cas de pluralité d’associés, par une résolution de l'assemblée générale des associés prise par un vote de la majorité des
associés, représentant au moins soixante-quinze (75%) pour cent du capital social de la Société.

24.2. La Société ne peut être dissoute par le décès, la suspension des droits civils, l'insolvabilité ou la faillite d’un associé.

Art. 25. Liquidation.
25.1 En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 24 des présents statuts, la liquidation sera effectuée

par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des associés ayant décidé de cette dissolution et qui
fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des
pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

25.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les associés en proportion du

nombre de parts sociales qu'ils détiennent dans la Société.

H. Disposition finale - Loi applicable

Art. 25. Loi applicable. Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts, sera déterminé en conformité avec la Loi.

<i>Dispositions transitoires

1. Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 Décembre 2015.
2. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués pendant le premier exercice social de la Société.

<i>Souscription et paiement

Toutes les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales émises ont été intégralement souscrites par Round Hill Dutch

Residential Investment SCS, prénommée, pour un montant total de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-).

Toutes les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en numéraire, de sorte que le

montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été
justifié au notaire soussigné.

<i>Frais

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est évalué à environ 1.250,- EUR.

<i>Résolutions de l'associé unique

L’associé fondateur, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de con-

vocation, a adopté les résolutions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 1, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-duché de

Luxembourg.

2. Les personnes suivantes sont nommées gérant pour une durée indéterminée:

28989

L

U X E M B O U R G

(i) Kemal AKYEL, né à Beringen (Belgique) le 2 juin 1977, résidant professionnellement au 1, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, Grandduché de Luxembourg;

(ii) Jennika Lindholm, né à Berlin (Allemagne) le 16 mars 1981, résidant professionnellement au 1, boulevard de la Foire,

L-1528 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

Dont acte, passé à Junglinster à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate sur demande du comparant que le présent acte est rédigé

en langue anglaise suivi d'une traduction en français; à la demande du même comparant et en cas de divergence entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire du comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit

mandataire du comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 janvier 2015. Relation GAC/2015/625. Reçu soixante-quinze euros 75,00

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015016811/539.
(150019753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 janvier 2015.

Limone S.A., Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 132.647.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le vingt-trois décembre,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

A comparu:

ULISSE OVERSEAS LIMITED, une société constituée et établie suivant les lois des Iles Bahamas, ayant son siège à The

Bahamas Financial Centre, Shirley and Charlotte Streets, P.O. BOX n-3023, Nassau, Bahamas, inscrite auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés des Bahamas sous le numéro 148.931 B, ici représentée par Monsieur Alessandro CU-
SUMANO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration datée du 19 décembre
2014 aux Bahamas, laquelle procuration restera jointe au présent acte.

Laquelle comparante, représentée comme il est dit, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- Que la société LIMONE S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre de commerce à Lu-

xembourg sous la section B et le numéro 132.647, ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, ci-
après nommée la "Société", a été constituée en date du 24 juillet 2007 par acte reçu par Me Jacques DELVAUX, notaire
alors  de  résidence  à  Luxembourg,  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations,  numéro  2653  du  20
novembre 2007

- Que le capital social de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille Euros) représenté par 310 (trois cent

dix) actions d'une valeur nominale de EUR 100.- (cent Euros) chacune;

- Que l'actionnaire unique est propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- Que la société ne possède pas d'immeubles ou de parts d'immeuble.
- Que la société LIMONE S.A. n'est impliquée dans aucun litige ou procès de quelque nature qu'il soit et que les actions

ne sont pas mises en gage ou nantissement

- Que l'activité de la Société ayant cessé, l'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, siégeant comme ac-

tionnaire unique en assemblée générale extraordinaire modificative des statuts de la Société prononce la dissolution
anticipée de la Société avec effet immédiat;

- Que l'actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la Société et qu'en cette qualité il requiert le notaire

instrumentant d'acter:

* Que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné;
* Qu'il déclare irrévocablement reprendre avec effet à partir de ce jour tout le passif de la Société tel que détaillé dans

la situation en annexe du présent acte;

* Que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assume

irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel;

* Qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
* Que l'actif restant est réparti à l'actionnaire unique;

28990

L

U X E M B O U R G

- Que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par DIMEST S.A., 3, Rue des Bains, L-1212 Luxembourg, désigné "commissaire à la liquidation" par l'actionnaire unique
de la Société;

- Que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- Que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs et commissaire de la Société;
- Que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'adresse suivante: 3, rue des Bains,

L-1212 Luxembourg.

Pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres formalités

à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes.

<i>Dépenses

- Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

des présentes sont estimés à approximativement EUR 1.200,-

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et demeure,

ledit comparant a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. CUSUMANO, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 30 décembre 2014. Relation: LAC/2014/64082. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015015940/63.
(150018591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Brainforge S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 133.093.

L’an deux mille quinze, le treizième jour du mois de janvier.
Pardevant Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven.

A comparu:

La société «FARVEST S.à r.l.», ayant son siège social à L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 76.419, ici représentée par son gérant unique Monsieur
Fabien AMORETTI, Directeur Marketing, demeurant professionnellement à L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens.

La comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare être l’unique associé de la société à responsabilité limitée

Brainforge S.à r.l., avec siège social à L-8070 Bertrange, 10a, rue des Mérovingiens, inscrite au Registre de commerce et
des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 133.093, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 17 octobre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2773 du 30 novembre 2007,
modifié en dernier lieu suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange en date du 11
avril 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1648 du 26 juin 2014.

La comparante, agissant en sa qualité d’unique associé de la société à responsabilité limitée Brainforge S.à r.l., a pris la

résolution suivante:

<i>Première et unique résolution

L’associé unique décide de d’étendre l’objet social et de modifier en conséquence l’article 3 des statuts comme suit:

Art. 3. La société a pour objets les conseils en marketing, l’organisation d’événements, de formation et de conférences,

les relationspresse, la réalisation de sites web et d’applications mobiles, le développement de contenus, ainsi que la gestion
d’un organisme de formation professionnelle continue, l’activité de consultants et de conseils dans les domaines du pla-
cement privé, de la gestion, de la sélection et du recrutement permanent de personnel de toutes catégories et notamment
de cadres spécialisés ou de direction, à l’exclusion de la location de services;

La société a également pour objet toutes prestations de conseils dans les domaines de la formation et du conseil de

gestion, de la direction, de la publicité, du marketing, de l’informatique, du secrétariat et de l’administration.

La société pourra effectuer toute opération commerciale, financière, mobilière et immobilière se rattachant à son

objet principal et/ou étant de nature à en faciliter l’extension et le développement."

28991

L

U X E M B O U R G

Le notaire instrumentant a rendu attentif la comparante au fait qu'avant toute activité commerciale de la société

présentement fondée, celle-ci doit être en possession d’une autorisation de commerce en bonne et due forme en relation
avec l’objet social, ce qui est expressément reconnu par la comparante.

<i>Pouvoirs

La comparante donne pouvoir à tous clercs et employés de l’Étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et

signer tous actes rectificatifs éventuels des présentes.

<i>Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes,

s’élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100,-).

Dont procès-verbal, passé à Senningerberg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, le comparant a signé avec Nous, Notaire, le présent acte.

Signé: Fabien Amoretti, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 14 janvier 2015. 1LAC / 2015/ 1082. Reçu 75.-€.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole Frising.

- Pour copie conforme - délivrée à la société aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015569/49.
(150019121) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Stentex Holding, Société à responsabilité limitée.

Capital social: RUB 131.459.843,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 181.970.

<i>Extrait des résolutions des actionnaires de la Société prises en date du 07 Janvier 2015

- d'accepter la démission de Madame Sandrine Bruzzo, en tant que gérant de classe A de la Société avec effet au 29

Novembre 2014;

- de nommer Monsieur Andrej Grossmann, né 19 décembre 1975 à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle

au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange Grand-Duché du Luxembourg, en tant que gérant de classe A de la Société
avec effet au 29 Novembre 2014;

- Depuis le 29 Novembre 2014, le conseil de gérance de la Société est désormais composé des personnes suivantes:

<i>Gérants de Classe A:

Mr. Philippe van den Avenne
Mr. Andrej Grossmann

<i>Gérants de Classe B:

Mr. Sean Michael Salmon
Mr. Jason Robert Weidman
Mr. Geoffrey Straub Martha
Mrs. Elena Plyasunova
Mr. Peter Walsh

<i>Gérants de Classe C:

Mr. Vladimir Pavlovich Kremer
Mr. Egor Lukianov
Mr. Maksim Goldman
Mr. Mikhail Lifshits
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bertrange, le 23 janvier 2015.

Stentex Holding S.à r.l.

Référence de publication: 2015016175/32.
(150018782) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28992


Document Outline

Arulux First S.à r.l.

Black &amp; Decker TransAsia S.à r.l.

Brainforge S. à r.l.

Choreo A.s.b.l.

Diemmevi S.A.

Digital Services XXXIII (GP) S.à.r.l.

Efesto Energy 1 S.A.

E-Tech Invest S.A.

FR Acquisition Corporation (Luxembourg), S. à r.l.

Gattyan Group S.à r.l.

Herbeus SICAV

Larix S.A.

Limone S.A.

M.A. Developments S.à r.l.

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-B S.à r.l.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-A S.à r.l.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-B S.à r.l.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-C S.à r.l.

Neovara European Mezzanine Partners 2003-D S.à r.l.

North Investment Protected Note Issuer

Nuremburg Properties S.A.

P.H Investment S.à r.l.

Portfolio Consult S.A.

Power Parts Continental

Premios S.A.

Premium Kaufhaus Immobilien Holding B S.à r.l.

Provirt Consulting Sàrl

Quint:Essence Concept

R.P.S. Consulting

Salem Investments S.à r.l.

Skype Communications

Skype Technologies

Skype Technologies S.à r.l.

Stentex Holding

Sybil Holdings S.à r.l.

TPL Glauchau S.à r.l.

Whirlpool Overseas Manufacturing S.àr.l.

Wiljo Letzebuerg S.A.

Windhof Business Center S.A.

Woonfonds Holding 2A S.à.r.l.