logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 597

4 mars 2015

SOMMAIRE

A.C.I. Aeronautical S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

28613

A.C.I. Agro S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28613

A.C.I. Armenia S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28643

Cascade Hotel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28610

Cascade Hotel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28610

Cascade Hotel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28611

Cascade Hotel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28611

Cascade Hotel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28614

Charax Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28614

Charax Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28656

CityKids S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28610

CKT s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28612

Com Event More S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28637

Compagnie Mobilière, Financière de Parti-

cipations S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28613

Corporate Sailing S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28619

Creative-Bau S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28643

DB Value S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28623

Demy Pub S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28612

Den Holzmëchel S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

28612

Denmarc S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28613

DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28638

Digital Services XXXIX Top-Holding

S.C.Sp.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28625

Dreamfactory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28646

EIF Soparfi A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28613

Evoleco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28616

Fidelity International Real Estate Fund

Company 14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28610

Global Finance Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

28618

Goodman Melanite Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28614

ICG Luxembourg Joint Venture S.à r.l  . . .

28612

Infrastructure PPP Africa Management

S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28614

Intercapital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28614

Investor Services House S.A.  . . . . . . . . . . . .

28616

Kapets S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28619

Neovara European Mezzanine Leveraged

Partners 2003-A S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

28644

Patron GP IV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28625

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l.  . . .

28610

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l.  . . .

28611

Romaka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28611

ROMAKA, société à responsabilité limitée

& Cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28611

Steinmetzdemeyer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28612

Tallus S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28656

Thalos Investment Platform S.A.  . . . . . . . .

28626

UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.  . . .

28649

Vanille S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28615

28609

L

U X E M B O U R G

CityKids S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 147.980.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015616/9.
(150018405) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Fidelity International Real Estate Fund Company 14, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2A, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 140.070.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015015765/10.
(150018396) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cascade Hotel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 48.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2005 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015633/11.
(150019182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cascade Hotel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 48.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2004 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015634/11.
(150019183) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9970 Leithum, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 101.650.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2011 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Leithum , le 27/01/2015.

Rainer Kaulmann
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2015016153/12.
(150019228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28610

L

U X E M B O U R G

Romaka, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 25.426.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 28 janvier 2014.

Référence de publication: 2015016156/10.
(150018360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie, Société en Commandite simple.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 99, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 27.595.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016157/10.
(150018662) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cascade Hotel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 48.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2003 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015635/11.
(150019184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cascade Hotel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 48.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2002 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015636/11.
(150019185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9970 Leithum, Maison 2.

R.C.S. Luxembourg B 101.650.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations

Leithum , le 27/01/2015.

Rainer Kaulmann
<i>Geschäftsführer

Référence de publication: 2015016154/12.
(150019229) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28611

L

U X E M B O U R G

CKT s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 22, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 162.982.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015658/9.
(150018410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Demy Pub S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8295 Keispelt, 22, rue de Kehlen.

R.C.S. Luxembourg B 155.382.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015015679/10.
(150018759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Den Holzmëchel S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-9831 Consthum, 11, route de Kautenbach.

R.C.S. Luxembourg B 145.795.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015015680/10.
(150018441) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

ICG Luxembourg Joint Venture S.à r.l, Société à responsabilité limitée de titrisation.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 178.689.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

ICG Luxembourg Joint Venture S.à r.l.
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015015868/11.
(150018259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

STDM, Steinmetzdemeyer, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 39, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 150.707.

EXTRAIT

Le siège social est transféré de l'adresse actuelle au 39, rue de Bonnevoie à L-1260 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 29 Janvier 2015.

STEINMETZDEMEYER (en abrégé STDM)
Société à responsabilité limitée
<i>Associés

Référence de publication: 2015015358/14.
(150018093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

28612

L

U X E M B O U R G

CMFP S.A., Compagnie Mobilière, Financière de Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 50.321.

Les comptes annuels au 30.06.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015668/9.
(150019052) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Denmarc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3440 Dudelange, 46, avenue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 55.658.

Les comptes annuels au 31.12.2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015015697/10.
(150019277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

A.C.I. Aeronautical S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.187.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour A.C.I. Aeronautical S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015015451/11.
(150018985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

A.C.I. Agro S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.142.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour A.C.I. Agro S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015015452/11.
(150018995) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

EIF Soparfi A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 105.688.

Les comptes consolidés de CBRE European Industrial Fund CV au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015738/13.
(150018349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28613

L

U X E M B O U R G

Infrastructure PPP Africa Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 170.799.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015861/9.
(150019220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Intercapital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 79.634.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015862/9.
(150018680) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Cascade Hotel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1618 Luxembourg, 2, rue des Gaulois.

R.C.S. Luxembourg B 48.180.

Les comptes annuels au 31 décembre 2001 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015015637/11.
(150019186) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Charax Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 136.979.

Les comptes annuels au 31.12.2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

CHARAX INVEST SA

Référence de publication: 2015015646/11.
(150018571) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Goodman Melanite Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avanches.

R.C.S. Luxembourg B 171.076.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Januar 2015.

Für gleichlautende Abschrift
<i>Für die Gesellschaft
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notar

Référence de publication: 2015015821/14.
(150018567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28614

L

U X E M B O U R G

Vanille S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 58, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 52.579.

L'an deux mil quatorze, le vingt deux décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur William DESMECHT, né le 20 mai 1947 à Léopoldville (République Démocratique du Congo), demeurant à

B-5640 Saint-Gérard (Belgique), 46, rue du Centenaire,

ici représenté par Monsieur Jean Luc CARAMIN, demeurant professionnellement à L-1630 Luxembourg, 58, rue Gle-

sener, agissant en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par
le mandataire comparant et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

lequel comparant est l’associé pour 245 parts de la société à responsabilité limitée
VANILLE S.à.r.l.
une société à responsabilité limitée ayant son siège social à L-1630 Luxembourg, 58 rue Glesener,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 52.579.
Ladite partie comparante, agissant ès-qualité, a requis le notaire instrumentant d’acter les déclarations suivantes:
La société a été constituée suivant acte reçu par Maître Georges d'HUART, alors notaire de résidence à Pétange, en

date du 12 octobre 1995, publié au Mémorial C numéro 646 de l’année 1995, page 31.004.

La Société a un capital souscrit de douze mille trois cent quatre-vingt-quatorze virgule soixante-huit euros (12.394,68.-

€) représenté par cinq cents (500) parts sociales, d'une valeur nominale de vingt-quatre virgule soixante-dix-neuf euros
(24,79.- €) chacune.

La partie comparante expose et prie le notaire instrumentant d’acter:
I. Que les associés de la société ont été convoqués en assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur

l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du Jour

1. Décision de mettre en liquidation la société
2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs
3. Décharge à donner à la gérance
4. Divers
II. Que la présente Assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l’ordre du jour, publiés comme suit:
a) au Mémorial C n°3636, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 1 

er

 décembre 2014;

b) au Mémorial C n° 3826, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 11 décembre 2014
c) au Journal D’Lëtzebuerger Land, édition du 5 décembre 2014 page 18.
III. Que les associés présents à la présente Assemblée générale et le nombre de parts sociales qu’ils détiennent sont

indiqués sur une liste de présence, laquelle, après avoir été signée par les associés présents, restera annexée au présent
procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

IV. II. L'intégralité du capital social souscrit étant représentée à la présente assemblée générale extraordinaire, il a pu

être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires représentés et présents se reconnaissant dûment convoqué
et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l’ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable. La présente
assemblée générale extraordinaire est ainsi régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est con-
stituée, sur les points portés à l’ordre du jour.

<i>Première résolution

L’assemblée générale décide de procéder à la dissolution de la Société et de mettre ainsi volontairement la Société en

liquidation (la «Liquidation»)

<i>Deuxième résolution

L’assemblée générale décide de nommer Monsieur Jean-Luc CARAMIN, demeurant professionnellement à L-1630

Luxembourg, 58, rue Glesener, à la fonction du liquidateur de la Société (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus, prévus par les articles 141 et suivants de la loi sur les sociétés com-

merciales du 10 août 1915 telle que modifiée (la "Loi"). Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 de la Loi sans
devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le Liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

28615

L

U X E M B O U R G

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

L’assemblée générale décide en outre d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion à verser des acomptes sur le

boni de liquidation, aux associés de la Société conformément à l’article 148 de la Loi.

Lorsque la Liquidation sera terminée, le Liquidateur préparera un rapport à l’assemblée générale conformément à

l’article 151 de la Loi.

<i>Frais

Les frais et honoraires incombant à la société à raison des présentes sont évalués à la somme de 1.300.- EUR (mille

trois cents euros).

Dont acte, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Lecture faite à la comparante ainsi qu’aux membres du bureau, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom,

état et demeure, ils ont tous signé avec le notaire le présent acte.

Signés: W. DESMECHT, K.REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 30 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18455. Reçu douze euros 12.-

<i>Le Receveur

 (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015406/72.
(150018141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Evoleco, Société Anonyme.

Siège social: L-9956 Hachiville, 60, Maison.

R.C.S. Luxembourg B 153.308.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015015760/10.
(150019196) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Investor Services House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 113.578.

L'an deux mille quatorze le dix-neuf novembre.
Par-devant Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, instru-

mentant.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme luxembourgeoise dénommée Investor Services House S.A.

en abrégé NISH, ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5 Allée Scheffer, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 113.578, constituée aux termes d'un acte de scission reçu par le notaire
Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, en date du 29 décembre 2005, publié au Mémorial C
Recueil des Sociétés et Associations numéro 223 du 31 janvier 2006, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte de Maître Francis Kesseler, précité, en date du 7 octobre 2014, non encore publié au Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations, ci-après dénommée la «Société».

L'assemblée est présidée par Monsieur Benoît Riaud, résidant professionnellement à L-2520 Luxembourg, 5, Allée

Scheffer.

Le président nomme en qualité de secrétaire Monsieur Julien Fetick, résidant professionnellement à L-2520 Luxem-

bourg, 5, Allée Scheffer.

L'assemblée  choisit  en  qualité  de  scrutateur  Monsieur  Pierre  Coeurderoy,  résidant  professionnellement  à  L-2520

Luxembourg, 5, Allée Scheffer.

Le président prie le notaire d'acter que:
I. Les actionnaires ici représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence.

Cette  liste  ainsi  que  les  procurations,  une  fois  signées  par  les  comparants  et  le  notaire  instrumentant,  resteront  ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

28616

L

U X E M B O U R G

II. Toutes les 1.000 (mille) actions ordinaires, 130 (cent tente) Actions Préférentielles et 2.200 (deux mille deux cent)

Actions Préférentielles Ter représentatives de l'intégralité du capital social d'un montant de 2.235.030.-EUR (deux millions
deux cent trente-cinq mille trente euros), sont dûment représentées à la présente assemblée, qui en conséquence est
régulièrement constituée et peut délibérer et décider valablement sur les différents points portés à l'ordre du jour et
dont les actionnaires de la Société déclarent avoir été valablement et préalablement informés.

III. L'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation aux délais et formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un montant de 250.000.000.- EUR (deux cent cinquante

millions d'euros) par un apport en nature consistant en la créance détenue par CACEIS Bank Luxembourg à l'encontre
de la Société résultant d'un prêt convertible daté du 7 octobre 2014 et l'émission de 250.000 (deux cent cinquante mille)
Actions Préférentielles Ter sans valeur nominale;

3. Souscription et libération de toutes les nouvelles Actions Préférentielles Ter;
4. Modification de l'article 5 des statuts de la Société suite aux résolutions qui précèdent; et
5. Divers.
L'assemblée générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

Les actionnaires de la Société ont décidé de renoncer à leur droit de convocation préalable afférente à la présente

assemblée générale; les actionnaires reconnaissent qu'ils ont été suffisamment informés de l'ordre du jour et qu'ils se
considèrent être valablement convoqués à la présente assemblée et en conséquence, acceptent de délibérer et de voter
sur tous les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires de la Société reconnaissent également que toute la docu-
mentation présentée lors de cette assemblée a été mise à leur disposition dans un laps de temps suffisant afin de leur
permettre un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 250.000.000.- EUR (deux

cent cinquante millions d'euros) par l'émission de 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions Préférentielles Ter sans
valeur nominale, afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de 2.235.030.- EUR (deux millions
deux  cent  trente-cinq  mille  trente  euros)  représenté  par  1.000  (mille)  actions  ordinaires,  130  (cent  trente)  Actions
Préférentielles et 2.200 (deux mille deux cent) Actions Préférentielles Ter au montant de 252.235.030.- EUR (deux cent
cinquante-deux millions deux cent trente-cinq mille trente euros).

<i>Troisième résolution

Est intervenu Monsieur Benoît Riaud, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial de la société CACEIS

Bank Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2520 Luxembourg, 5 allée Scheffer, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91985, en vertu d'une procuration signée sous seing privé
en date du 18 novembre 2014, laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire spécial et le
notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les besoins de l'enregistrement, qui a déclaré, au nom et
pour le compte de l'actionnaire prénommé, souscrire à 250.000 (deux cent cinquante mille) Actions Préférentielles Ter
sans valeur nominale, libérées à hauteur d'un montant de 250.000.000.- EUR (deux cent cinquante millions d'euros) par
un apport en nature résultant d'une créance à l'encontre de la Société d'un montant de 250.000.000.- EUR (deux cent
cinquante millions d'euros) (ci-après la «Créance»).

<i>Description de l'apport

Le comparant déclare qu'en conformité avec les articles 26-1 et 32-1(5) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, un rapport a été établi par KPMG Luxembourg S.à r.l., réviseur d'entreprises agréé, ayant son
siège social à Luxembourg, le 19 novembre 2014, qui décrit et évalue la Créance ainsi apportée.

Le comparant produit ce rapport dont la conclusion est la suivante:
«(...) Based on the work performed, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the

contribution does not correspond at least to the number and value of the preferred shares Ter, to be issued in consi-
deration. (...)»

Ce rapport restera annexé à la présente et sera transmis avec elle à l'administration de l'enregistrement.
Dès lors, l'assemblée décide d'accepter ladite souscription et son paiement et d'attribuer en contrepartie à la société

CACEIS Bank Luxembourg, 250.000 (deux cent cinquante mille) nouvelles Actions Préférentielles Ter sans valeur nomi-
nale entièrement libérées.

28617

L

U X E M B O U R G

<i>Quatrième résolution

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale a décidé de modifier l'article

5 des statuts de la Société comme suit:

Art. 5. Le capital social est fixé à 252.235.030 EUR (deux cent cinquante-deux millions deux cent trente-cinq mille

trente euros), représenté par:

- mille (1.000) actions ordinaires (étant définies comme «Actions Ordinaires»);
- cent trente (130) actions préférentielles (étant définies comme «Actions Préférentielles»);
- 252.200 (deux cent cinquante-deux mille deux cent) actions préférentielles Ter (étant définies comme «Actions

Préférentielles Ter»);

chacune sans valeur nominale.
Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix des Actionnaires. Les actionnaires des Actions Ordinaires (étant

définis comme «Actionnaires Ordinaires»), les actionnaires des Actions Préférentielles (étant définis comme «Action-
naires Préférentiels») et les actionnaires des Actions Préférentielles Ter (étant définis comme «Actionnaires Préférentiels
Ter») sont ensembles définis comme les «Actionnaires».

Tous les droits et obligations attachés à chaque classe d'actions sont définis comme «Branche d'Activité», de manière

que tous les droits et obligations attachés aux Actions Ordinaires sont définis comme «Branche d'Activité A», tous les
droits et obligations attachés aux Actions Préférentielles sont définis comme «Branche d'Activité B» et tous les droits et
obligations attachés aux Actions Préférentielles Ter sont définis comme «Branche d'Activité D».

La Branche d'Activité A, la Branche d'Activité B et la Branche d'Activité D seront définies, séparément, par décision

unanime de l'assemblée générale des Actionnaires.

Le capital souscrit de la société pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des Actionnaires

statuant comme en matière de modification des présents statuts.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou

qui seront chargé en raison de son augmentation de capital, sont estimés à environ 7.000,- Euros.

<i>Déclaration

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, la séance est levée.
Le notaire instrumentant atteste l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la Société, ce qu'il a vérifié.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Le document ayant été lu en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état civil

et domicile, ledit comparant a signé avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé: Riaud, Fetick, Coeurderoy, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15832. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME
Référence de publication: 2015015102/116.
(150017409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Global Finance Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 167.288.

<i>Extrait du conseil d'administration du 27 janvier 2015 tenu au siège de la Société

Par la présente, le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des parts au porteur de la société,

Fisconsult s.a., fiduciaire et cabinet d'expert-comptable ayant son siège social au 56, rue Glesener L-1630 Luxembourg,
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015015048/14.
(150017759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

28618

L

U X E M B O U R G

Corporate Sailing S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl.

R.C.S. Luxembourg B 106.610.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015622/9.
(150018295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Kapets S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 193.054.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first day of December.
Before Us Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the Meeting) of “KAPETS S.A.”, having its registered office at

8, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies register under number
B193.054, incorporated in the form of a société anonyme and under the name of KAPETS S.A. by a deed of Maître Martine
Schaeffer, notary residing in Luxembourg, on the 8 

th

 of December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations.

The Meeting is presided over by Me Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, with professional address in Luxembourg.
The chairman appoints as secretary Miss Audrey Heinry, jurist, with professional address in Luxembourg.
The Meeting elects as scrutineer Me Jonathan Paganelli, Avocat au Barreau de Liège inscrit à la liste IV du Barreau de

Luxembourg, with professional address in Luxembourg.

The chairman declares and requests the notary to record that:
I. The sole shareholder holds all thirty-one thousand (31,000) shares in issue in the Company so that decisions can

validly be taken on all items of the agenda.

II. The agenda of the Meeting is the following:
1. Increase of the Company’s corporate capital in the amount of two million and three hundred thousand euro (EUR

2,300,000.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) divided into thirty-one
thousand (31,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to two million three hundred and thirty-one
thousand euro (EUR 2,331,000.-) divided into two million three hundred and thirty-one thousand (2,331,000) shares,
with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, by the issuance of two million and three hundred thousand (2,300,000)
new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights as the already existing shares,

2. Subscription for and full payment of the new shares by way of a contribution in kind by the sole shareholder of the

Company consisting in total in:

(i) four million two hundred sixty-six thousand one hundred thirty-two (4,266,132) ordinary shares in ALLAGASH

PTE. LTD., a limited private company incorporated and organised under the laws of Singapore, with registered office at
163, Penang Road, #02-03, Winsland House II, Singapore (238463), and registered with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ACRA) under number 201118869E (ALLAGASH),

(ii) two hundred twenty-three thousand one hundred thirty (223,130) ordinary shares in FONTAS PTE. LTD., a limited

private company incorporated and organised under the laws of Singapore, with registered office at 163, Penang Road,
#02-03, Winsland House II, Singapore (238463), and registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority
(ACRA) under number 201128874D (FONTAS),

(iii) three hundred seventy-nine thousand eight hundred three (379,803) ordinary shares in RYBURN INTERNATIO-

NAL PTE. LTD., a limited private company incorporated and organised under the laws of Singapore, with registered office
at 163, Penang Road, #02-03, Winsland House II, Singapore (238463), and registered with the Accounting and Corporate
Regulatory Authority (ACRA) under number 201128037H (RYBURN), and

(iv) fifty-three thousand three hundred fifteen (53,315) ordinary shares in TANTRAMAR PTE. LTD., a limited private

company incorporated and organised under the laws of Singapore, with registered office at 163, Penang Road, #02-03,
Winsland House II, Singapore (238463), and registered with the Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA)
under number 201128877R (TANTRAMAR);

3. Amendment of article 5.1. of the articles of association of the Company so as to reflect the above resolutions; and;
4. Miscellaneous.
After the foregoing has been approved by the Meeting, the same unanimously took the following resolutions:

28619

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The Meeting resolves to increase the Company’s corporate capital in the amount of two million and three hundred

thousand euro (EUR 2,300,000.-) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-)
divided into thirty-one thousand (31,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, to two million three
hundred and thirty-one thousand euro (EUR 2,331,000.-) divided into two million three hundred and thirty-one thousand
(2,331,000) shares, with a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, by the issuance of two million and three hundred
thousand (2,300,000) new shares with a par value of one euro (EUR 1.-) each, having the same rights as the already existing
shares, each at a subscription price of one euro (EUR 1.-) against the contribution in kind of four million two hundred
sixty-six thousand one hundred and thirty-two (4,266,132) ordinary shares in ALLAGASH, two hundred twenty-three
thousand one hundred and thirty (223,130) ordinary shares in FONTAS, three hundred seventy-nine thousand eight
hundred and three (379,803) ordinary shares in RYBURN, and fifty-three thousand three hundred and fifteen (53,315)
ordinary shares in TANTRAMAR, by the subscriber (being the sole shareholder) and to approve the subscription to the
new shares by the subscriber as set out hereafter and the payment of the total subscription price by way of contribution
in kind.

<i>Second resolution

The Meeting resolves to approve the subscription and full payment of the two million and three hundred thousand

(2,300,000) new shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each with such rights and obligations as set out in
the articles of association of the Company in consideration of a contribution in kind amounting to at least two million
and three hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-).

<i>Subscription - Payment

Thereupon, the sole shareholder, named and represented as stated in the attendance list attached hereto, acting in its

capacity as subscriber, declares to subscribe to two million and three hundred thousand (2,300,000) new shares of the
Company, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, and to fully pay them up by way of a contribution in kind
consisting in four million two hundred sixty-six thousand one hundred and thirty-two (4,266,132) ordinary shares in
ALLAGASH, two hundred twenty-three thousand one hundred and thirty (223,130) ordinary shares in FONTAS, three
hundred seventy-nine thousand eight hundred and three (379,803) shares in RYBURN and fifty-three thousand three
hundred and fifteen (53,315) ordinary shares in TANTRAMAR (the Shares).

The Shares so contributed represent a contribution in kind in an aggregate amount of at least two million and three

hundred thousand euro (EUR 2,300,000.-), being the euro equivalent of the contribution of the Shares at the exchange
rate of the Oanda website prevailing on 30 December 2014 (i.e. EUR 0.82067 for USD 1) and rounded down.

The contribution in kind has been valued at an amount of at least two million and three hundred thousand euro (EUR

2,300,000)  pursuant to  the  auditor’s  report  dated 30  December 2014 by ATWELL,  société  à  responsabilité limitée,
independent auditor, which auditor’s report shall be annexed hereto to be registered with this deed. The conclusion of
such report is as follows:

“On the basis of the work carried out by us, nothing has come to our attention that would cause us to believe that

the value of the contributions resulting from the application of the valuation method described above would not be at
least equal to the number and nominal value of the new shares of KAPETS S.A. to be issued in exchange.”

Said report referred to above, after having been signed ne varietur by the proxyholder and the undersigned notary,

will remain attached to the present deed in order to be registered with it.

<i>Third resolution

As a result of the above resolutions, the Meeting resolves to amend article 5.1 of the articles of association of the

Company, which shall henceforth read as follows:

“ 5.1. The subscribed share capital is set at two million three hundred and thirty-one thousand euro (EUR 2,331,000.-)

represented by two million three hundred and thirty-one thousand (2,331,000) shares with a par value of one euro (EUR
1.-) each, all subscribed and fully paid-up.”

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to two thousand eight hundred euro (EUR 2,800.-).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the appearing persons,

the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons and in
case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

28620

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the persons appearing, known to the notary by his surname,

Christian name, civil status and residence, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est tenue

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l’Assemblée) de «KAPETS S.A.», ayant son siège social au 8,

rue Philippe II, L-2340 Luxembourg, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B193.054, constituée sous la forme d’une société anonyme sous la dénomination de KAPETS S.A. par un acte de Maître
Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 8 décembre 2014, n’ayant pas encore été publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L’Assemblée est présidée par Me Claude Feyereisen, Avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg.
Le président nomme comme secrétaire Madame Audrey Heinry, juriste, résidant professionnellement à Luxembourg.
L’Assemblée nomme comme scrutateur Me Jonathan Paganelli, Avocat au Barreau de Liège inscrit à la liste IV du

Barreau de Luxembourg, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le président déclare et requiert le notaire d’acter ce qui suit:
I. L’actionnaire unique détient toutes les trente et un mille (31.000) actions émises par la Société de sorte que les

décisions peuvent être valablement prises sur tous les points de l’ordre du jour.

II. L’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de deux millions trois cents mille euros (2.300.000,- EUR)

de sorte qu’il soit augmenté de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé en trente et un mille
(31.000) actions, d’une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune, à un montant de deux millions trois cent trente et
un mille euros (2.331.000,-EUR) divisé en deux millions trois cent trente et un mille (2.331.000) actions, d’une valeur
nominale d’un euro (1.- EUR) chacune, par l’émission de deux millions trois cents mille (2.300.000) nouvelles actions
d’une valeur nominale d’un euro (1.-EUR) chacune, ayant les mêmes droits que les actions déjà existantes,

2. Souscription et paiement intégral des nouvelles actions par un apport en nature par l’actionnaire unique de la Société

consistant en:

(i) quatre millions deux cent soixante-six mille cent trente-deux (4.266.132) actions ordinaires d’ALLAGASH PTE.

LTD., une société privée constituée et régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au 163, Penang Road, #02-03,
Winsland House II, Singapour (238463), et enregistrée au Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) sous
le numéro 201118869E (ALLAGASH),

(ii) deux cent vingt-trois mille cent trente (223.130) actions ordinaires de FONTAS PTE. LTD., une société privée

constituée et régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au 163, Penang Road, #02-03, Winsland House II,
Singapour  (238463),  et  enregistrée  au  Accounting  and  Corporate  Regulatory  Authority  (ACRA)  sous  le  numéro
201128874D (FONTAS),

(iii) trois cent soixante-dix-neuf mille huit cent trois (379.803) actions ordinaires de RYBURN INTERNATIONAL PTE.

LTD., une société privée constituée et régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au 163, Penang Road, #02-03,
Winsland House II, Singapour (238463), et enregistrée au Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) sous
le numéro 201128037H (RYBURN), et

(iv) cinquante-trois mille trois cent quinze (53.315) actions ordinaires de TANTRAMAR PTE. LTD., une société privée

constituée et régie par les lois de Singapour, ayant son siège social au 163, Penang Road, #02-03, Winsland House II,
Singapour  (238463),  et  enregistrée  au  Accounting  and  Corporate  Regulatory  Authority  (ACRA)  sous  le  numéro
201128877R (TANTRAMAR);

3. Modification de l’article 5.1. des statuts de la Société de manière à refléter les résolutions ci-dessus; et;
4. Divers.
Après que l’ordre du jour a été approuvé par l’Assemblée, celle-ci a pris à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Assemblée décide d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de deux millions trois cents mille euros

(2.300.000,- EUR) de sorte qu’il soit augmenté de son montant actuel de trente et un mille euros (31.000,- EUR) divisé
en trente et un mille (31.000) actions, d’une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune, à un montant de deux millions
trois cent trente et un mille euros (2.331.000,- EUR) divisé en deux millions trois cent trente et un mille (2.331.000)
actions, d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune, par l’émission de deux millions trois cents mille (2.300.000)
nouvelles actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune, ayant les mêmes droits que les actions déjà exi-
stantes, chacune à un prix de souscription d’un euro (EUR 1.-) en contrepartie de l’apport en nature de quatre millions
deux cent soixante-six mille cent trente-deux (4.266.132) actions ordinaires d’ALLAGASH, deux cent vingt-trois mille

28621

L

U X E M B O U R G

cent trente (223.130) actions ordinaires de FONTAS, trois cent soixante-dix-neuf mille huit cent trois (379.803) actions
ordinaires de RYBURN, et cinquante-trois mille trois cent quinze (53.315) actions ordinaires de TANTRAMAR, par le
souscripteur (celui-ci étant l’actionnaire unique) et d’approuver la souscription des nouvelles actions par le souscripteur
tel que défini ci-après et le paiement du prix de la souscription totale par un apport en nature.

<i>Deuxième résolution

L’Assemblée décide d’approuver la souscription et le paiement intégral des deux millions trois cents mille (2.300.000)

nouvelles actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune avec les droits et obligations tels que définis dans
les statuts de la Société en contrepartie d’un apport en nature dont le montant s’élève à deux millions trois cents mille
euros (2.300.000,- EUR).

<i>Souscription - Paiement

Par conséquent, l’actionnaire unique, nommé et représenté tel qu’indiqué dans la liste de présence attachée aux pré-

sentes, agissant en sa capacité de souscripteur, déclare souscrire deux millions trois cents mille (2.300.000) nouvelles
actions de la Société, d’une valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune, et de les payer intégralement par un apport en
nature consistant en quatre millions deux cent soixante-six mille cent trente-deux (4.266.132) actions ordinaires d’AL-
LAGASH, deux cent vingt-trois mille cent trente (223.130) actions ordinaires de FONTAS, trois cent soixante-dix-neuf
mille huit cent trois (379.803) actions ordinaires de RYBURN, et cinquante-trois mille trois cent quinze (53.315) actions
ordinaires de TANTRAMAR (les Actions). Les Actions ainsi apportées représentent un apport en nature d’un montant
global d’au moins deux millions trois cents mille euros (2.300.000 EUR), ce montant étant la valeur correspondant à
l’équivalent en euro de l’apport en nature des Actions au taux d’échange du site internet Oanda en vigueur au 30 décembre
2014 (i.e. 0,82067 EUR pour 1 USD) arrondi par défaut.

L’apport en nature a été évalué à un montant d’au moins deux millions trois cents mille euros (2.300.000,- EUR)

conformément au rapport de l’auditeur, réviseur d’entreprises agréé, daté du 30 décembre 2014 par ATWELL, société
à responsabilité limitée, auditeur indépendant, ce rapport d’auditeur sera annexé aux présentes afin d’être enregistré avec
elles. La conclusion de ce rapport est la suivante:

«Sur base du travail effectué par nous, nous n’avons relevé aucun élément susceptible d’indiquer que la valeur des

apports en nature résultant de l’application de la méthode d'évaluation décrite ci-dessus ne serait pas au moins égal au
nombre et à la valeur nominale des nouvelles actions de KAPETS S.A. à émettre en contrepartie.»

Ce rapport, après avoir été signé ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexé aux pré-

sentes afin d’être enregistré avec elles.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l’Assemblée décide de modifier l’article 5.1 des statuts de la Société, qui

sera désormais lu comme suit:

« 5.1. Le capital social souscrit est fixé à deux millions trois cent trente et un mille euros (2.331.000,- EUR) représenté

par deux millions trois cent trente et un mille (2.331.000) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1.-) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées.»

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est ajournée.

<i>Estimation des frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à deux mille huit cents euros (EUR 2.800,-).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu’à la demande de la partie comparante,

le présent acte est rédigé en langue anglaise, le texte étant suivi d’une version française, et qu’à la demande de la même
partie comparante, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée en tête des présentes.
Après lecture faite du document au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par son nom, prénom,

état civil et résidence, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: FEYEREISEN, HEINRY, PAGANELLI, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 janvier 2015. Relation: 1LAC / 2015 / 137. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Référence de publication: 2015015123/212.
(150018037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

28622

L

U X E M B O U R G

DB Value S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 4, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 127.492.

IM JAHRE ZWEITAUSENDVIERZEHN, DEN SIEBZEHNTEN DEZEMBER,
vor dem unterzeichnenden Notar Cosita DELVAUX, mit Amtssitz in Luxemburg,

sind

die Anteilsinhaber der DB Value S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach Luxemburger Recht (société

à responsabilité limitée), mit Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschafts-
register Luxemburg unter Nummer B 127.492 (die „Gesellschaft“), zu einer außerordentlichen Gesellschafterversamm-
lung zusammengetreten.

Die Gesellschaft wurde gemäß notarieller Urkunde am 30. März 2007 gegründet, welche im Mémorial C, Recueil des

Sociétés et Associations Nummer 991 vom 29. Mai 2007 veröffentlich wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zum
letzten Mal durch eine am 2. Mai 2011 unterzeichnete notarielle Urkunde abgeändert, welche im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations Nummer 1031 vom 18. Mai 2011 veröffentlicht wurde.

Die Gesellschafterversammlung wurde eröffnet um 13.25 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Sebastian Jans, Assessor

juris, mit Berufsanschrift in Luxemburg.

Der Vorsitzende bezeichnet zum Schriftführer Frau Kim Reisch, mit Berufsanschrift in Luxemburg.
Die Gesellschafterversammlung wählt zum Stimmzähler Herrn Sebastian Jans, Assessor juris, mit Berufsanschrift in

Luxemburg.

Der Gesellschafterversammlungsvorstand ist somit gebildet.
Der Vorsitzende gibt gemeinsam mit den Gesellschafterversammlungsmitgliedern folgende Erklärungen ab, und bittet

den amtierenden Notar zu Protokoll zu nehmen:

I. Dass die Gesellschafterversammlung über die folgende

<i>Tagesordnung zu befinden hat:

1. Erste Herabsetzung des Gesellschaftskapitals vom gegenwärtigen Betrag von einer Milliarde sechshundertdreißig

Millionen Euro (EUR 1.630.000.000,-) durch Verlustverrechnung ohne Auszahlung von einer Milliarde einhundertfün-
fundsechzig  Millionen  siebenhundertfünfundfünfzig  Tausend  vierhundertvierundneunzig  Euro  und  elf  Cent  (EUR
1.165.755.494,11) auf vierhundertvierundsechzig Millionen zweihundertvierundvierzig Tausend fünfhundertfünf Euro und
neunundachtzig Cent (EUR 464.244.505,89), durch Annullierung von einer Milliarde einhundertfünfundsechzig Millionen
siebenhundertfünfundfünfzig Tausend vierhundertvierundneunzig (1.165.755.494) Anteilen und Erteilung von Vollmacht
zur Annullierung;

2. Zweite Herabsetzung des Gesellschaftskapitals vom gegenwärtigen Betrag von vierhundertvierundsechzig Millionen

zweihundertvierundvierzig  Tausend  fünfhundertfünf  Euro  und  neunundachtzig  Cent  (EUR  464.244.505,89)  auf  fünfzig
Millionen  Euro  (EUR  50.000.000,-)  durch  Annullierung  von  vierhundertvierzehn  Millionen  zweihundertvierundvierzig
Tausend fünfhundertsechs (414.244.506) Anteilen und Auszahlung von vierhundertvierzehn Millionen zweihundertvie-
rundvierzig Tausend fünfhundertfünf Euro und neunundachtzig Cent (EUR 414.244.505,89) sowie Erteilung von Vollmacht
zur Auszahlung an die Gesellschafterin und Annullierung;

3. Abänderung von Artikel 6, Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft;
4. Reduzierung der gesetzlichen Rücklage vom gegenwärtigen Betrag von siebzig Millionen Euro (EUR 70.000.000,-)

auf  fünf  Millionen  Euro  (EUR  5.000.000,-)  durch  Auszahlung  eines  Betrages  von  fünfundsechzig  Millionen  Euro  (EUR
65.000.000,-) an die Gesellschafterin und Erteilung von Vollmacht zur Auszahlung;

5. Auszahlung des gesamten Agios in Höhe von vierhundertfünfunddreißig Million (EUR 435.000.000,-) an die Gesell-

schafterin und Erteilung von Vollmacht zur Auszahlung; und

6. Verschiedenes.
II. Dass der alleinige vertretene Gesellschafter, der Bevollmächtigte des alleinigen vertretenen Gesellschafters sowie

die Anzahl dessen Gesellschaftsanteile in eine Anwesenheitsliste eingetragen sind. Diese Anwesenheitsliste wird von dem
Bevollmächtigten des vertretenen Gesellschafters sowie von den Mitgliedern des Versammlungsvorstands unterzeichnet
und bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt.

Die Vollmacht des vertretenen alleinigen Gesellschafters bleibt ebenfalls nach ne varietur Unterzeichnung von den

Komparenten gegenwärtiger Urkunde angehängt.

III. Dass das gesamte Gesellschaftskapital zu dieser Gesellschafterversammlung vertreten ist und dass der vertretene

alleinige Gesellschafter sich als ordnungsgemäß einberufen erkennt und erklärt vorweg Kenntnis der Tagesordnung gehabt
zu haben, so dass die förmliche Einberufung unterlassen werden konnte.

IV. Dass die gegenwärtige Gesellschafterversammlung sämtliche Gesellschaftsanteile der Gesellschaft vertritt, ord-

nungsgemäß einberufen ist und in rechtsgültiger Weise über die Tagesordnung beraten kann.

28623

L

U X E M B O U R G

Sodann fasst die Gesellschafterversammlung folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  beschließt,  das  Gesellschaftskapital  vom  gegenwärtigen  Betrag  von  einer  Milliarde

sechshundertdreißig Millionen Euro (EUR 1.630.000.000,-) auf vierhundertvierundsechzig Millionen zweihundertvierund-
vierzig Tausend fünfhundertfünf Euro und neunundachtzig Cent (EUR 464.244.505,89) herabzusetzen, durch Verlustver-
rechnung ohne Auszahlung und Annullierung von einer Milliarde einhundertfünfundsechzig Millionen siebenhundertfün-
fundfünfzig Tausend vierhundertvierundneunzig (1.165.755.494) Anteilen.

Zur Annullierung der in diesem Beschluss genannten Geschäftsanteile wird jedem Geschäftsführer der Gesellschaft,

einzeln handelnd, entsprechend Vollmacht erteilt.

Der Notar macht die Versammlung darauf aufmerksam, dass die Auszahlung an die alleinige Gesellschafterin die Rechte

von eventuellen Gläubigern nicht beeinträchtigen darf.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, nach der vorgehenden Kapitalherabsetzung, das Gesellschaftskapital vom

gegenwärtigen Betrag von vierhundertvierundsechzig Millionen zweihundertvierundvierzig Tausend fünfhundertfünf Euro
und neunundachtzig Cent (EUR 464.244.505,89) auf fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) herabzusetzen, durch An-
nullierung von vierhundertvierzehn Millionen zweihundertvierundvierzig Tausend fünfhundertsechs (414.244.506) Antei-
len  und  einer  entsprechenden  Auszahlung  von  vierhundertvierzehn  Millionen  zweihundertvierundvierzig  Tausend
fünfhundertfünf Euro und neunundachtzig Cent (EUR 414.244.505,89) an die alleinige Gesellschafterin.

Zur Auszahlung und zur Annullierung der Geschäftsanteile wird jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, einzeln han-

delnd, entsprechend Vollmacht erteilt.

<i>Dritter Beschluss

Infolge der voranstehenden Beschlüsse beschließt die Gesellschafterversammlung den 1. Absatz von Artikel 6 der

Satzung der Gesellschaft abzuändern um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

„ Art. 6. Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt fünfzig Millionen Euro (EUR 50.000.000,-) und ist in fünfzig Mil-

lionen (50.000.000) Anteile ohne Nennwert eingeteilt.“

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt weiterhin, die gesetzliche Rücklage vom gegenwärtigen Betrag von siebzig

Millionen Euro (EUR 70.000.000,-) auf fünf Millionen Euro (EUR 5.000.000,-) durch Auszahlung eines Betrages von fün-
fundsechzig Millionen Euro (EUR 65.000.000,-) an die Gesellschafterin zu reduzieren.

Zur Auszahlung der gesetzlichen Rücklage wird jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, einzeln handelnd, entspre-

chend Vollmacht erteilt.

<i>Fünfter Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  beschließt  weiterhin  die  Auszahlung  des  gesamten  Agios  in  Höhe  von

vierhundertfünfunddreißig Million (EUR 435.000.000,-) an die Gesellschafterin.

Zur Auszahlung des Agios wird jedem Geschäftsführer der Gesellschaft, einzeln handelnd, entsprechend Vollmacht

erteilt.

<i>Schätzung der Kosten

Die Komparenten schätzen den Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form

auch immer, welche der Gesellschaft aus Anlass ihrer Kapitalherabsetzung entstehen, auf ungefähr EUR 2.200,-.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung an die Komparenten, haben dieselben mit dem Notar gegenwärtige Urkunde unters-

chrieben.

Gezeichnet: K. REISCH, S. JANS, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62910. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 28. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015015694/108.
(150018282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28624

L

U X E M B O U R G

Patron GP IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 162.291.

<i>Extrait rectificatif à l'acte L150015193 déposé le 23/01/2015

Une erreur s'est glissée dans la publication L150015193 et il convient de noter qu'en date du 23 janvier 2015 le siège

social de la société a été transféré du 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg au 296-298 Route de Longwy, L-1940
Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2015015236/14.
(150017427) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.993.

<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the "Limited Partnership Agreement") of Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp.,

<i>a special limited partnership, executed on 26 

<i>th

<i> January 2015

1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services XXXIX (GP) S.à r.l., a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register
under number in the process of being registered with the R.C.S. Luxembourg (the "General Partner").

2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp. (the "Partnership").
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds)
and the provision through its foreign subsidiaries of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.

The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership

exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.

3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the

General Partner.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and

otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 26

th

 January 2015, for an indefinite term.

28625

L

U X E M B O U R G

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

<i>Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement") der Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp.,

<i>einer Partnerschaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partnership), geschlossen am 26. Januar 2015

1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services XXXIX (GP) S.à r.l., eine Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Groß-
herzogtums Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg,
Eintragung im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) wurde beantragt
(die „Komplementärin").

2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp. (die „Gesellschaft")
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-

schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen  durch  ausländische  Tochtergesellschaften  (im  Bereich  ECommerce  bezüglich  Waren  und  Dienstleistungen
jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistun-
gen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann

jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-

renden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger

Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,

rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 26. Januar 2015 für eine unbegrenzte Dauer

gegründet.

Référence de publication: 2015015687/77.
(150018214) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Thalos Investment Platform S.A., Société Anonyme de Titrisation.

Siège social: L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 193.914.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-ninth day of December.
Before us Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg.

There appeared

Stichting Hoeksteen, a dutch foundation with registered office in Amsterdam, Netherlands, Luna ArenA, Heriker-

bergweg 238, 1101 CM Amsterdam, P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam Zuidoost,

duly represented by Thorsten Lakus, Fund Consultant of LRI Invest S.A., professionally residing in 9A, rue Gabriel

Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg,

by virtue of a proxy, issued in Amsterdam on 23 

rd

 December 2014,

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document

to be filed with the registration authorities.

28626

L

U X E M B O U R G

Such  appearing  party,  in  the  above  stated  capacity,  has  requested  the  undersigned  notary  to  state  the  articles  of

incorporation of a securitisation company in the sense of the law of 22 March 2004 on securitisation, as amended in the
form of a public limited liability company (société anonyme) which is hereby established as follows:

Art. 1. Form, Name. There is hereby established among the subscribers and all those who may become owners of the

shares hereafter issued a securitisation company within the meaning of the law of 22 March 2004 on securitisation, as
amended (the "Securitisation Law") in the form of a public limited liability company (société anonyme), under the name
of Thalos Investment Platform S.A. (the “Company”).

The Company may have one shareholder (the “Sole Shareholder”) or more shareholders.

Art. 2. Duration. The Company is established for an unlimited duration. The Company may be dissolved at any time

by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the present articles of incor-
poration (the “Articles of Incorporation”).

In the event of legal incapacity, liquidation or death of the Sole Shareholder, the Company shall not be dissolved.

Art. 3. Object. The object of the Company is to act as a securitisation company, under and subject to the Securitisation

Law, through the acquisition, financing or assumption, directly or through another undertaking, of risks relating to claims,
other assets (including, without limitation any kind of securities, loans, receivables and other assets, movable or immo-
vable, material or immaterial) or any kind of obligations assumed by third parties or inherent to all or part of the activities
of third parties (the "Underlying Assets").

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, issue any kind of securities of any form whatsoever

including, without limitation, shares, beneficiary certificates, notes and debt instruments as well as options or warrants
giving rights to shares, whose value, return or yield depends directly or indirectly on such risks relating to the Underlying
Assets (each, a "Securitisation").

The Company may issue securities to the public as an unregulated securitisation undertaking within the limits of the

Securitisation Law. The Company may, whilst remaining within the scope of the Securitisation Law, also borrow or raise
funds from any entity in order to fund the purchase of Underlying Assets and/or to comply with any payment or other
obligation it has under any of its securities or under any agreement to be entered into in the context of a Securitisation.

The board of directors of the Company may, whether within the context of a Securitisation programme or not, create

one or several compartments composed of certain specific securities, instruments, claims, other assets, and/or risks
relating thereto (the "Compartments").

The Company may issue series or tranches of securities, including for the avoidance of doubt shares or beneficiary

certificates, whose value, right to dividends or yield is linked to one or more specific Compartment(s) or to specific assets
or risks or whose repayment is subject to the repayment of other instruments or certain claims.

The Company may sell, assign, re-acquire and dispose of any and all of the Underlying Assets through any means

(including by way of sale, assignment, exchange, contribution or through derivative or swap transactions) as described in
the terms and conditions of the relevant securities or the relevant prospectus or information memorandum and in general
manage the Underlying Assets on a continuous and ongoing basis.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, in the context of its Securitisations proceed to (i) the

acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and
interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, including the granting of loans to such entities, (ii)
the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other
manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind and contracts thereon
or related thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio (including, amongst
others, the assets referred to in (i) and (ii) above). The Company may further acquire, hold and dispose of interests in
partnerships, limited partnerships, trusts, funds and other entities.

The Company may, within the limits of the Securitisation Law, grant any kind of security interests under any law to

any trustee, security trustee, security agent, fiduciary-representative or any other person representing the investors or
any other party involved in the Securitisation or with whom the Company entered into agreements in connection with
a Securitisation in order to secure its payment or other obligations under any agreement to be entered into by the
Company in connection with a Securitisation. The Company may enter into any agreement or instruments (including,
without limitation, derivatives) and may issue, sign, approve or ratify any document and may do and allow all things and
acts which are necessary to prepare, carry out and wind up or are incidental to, a Securitisation.

The Company may take any steps and implement any transactions, which it deems useful for the fulfilment and execution

of this purpose, and in the broadest sense pursuant to the Securitisation Law.

Art. 4. Registered office. The registered office of the Company is established in Munsbach. Within the same municipality,

the registered office may be transferred through simple resolution of the board of directors.

In the event that the board of directors determines that extraordinary, political, economic, or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have

28627

L

U X E M B O U R G

no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company.

Art. 5. Capital - Shares and Share certificates. The subscribed capital of the Company is set at thirty-one thousand

Euro (EUR 31,000) divided into three hundred ten (310) shares with a nominal value of one hundred Euro (EUR 100) per
share.

Shares will be issued in registered form only.
The Company shall consider the person in whose name the shares are registered in the register of shareholders, to

be maintained at the Company's registered office, as the legal owner of such shares.

Certificates stating such inscription shall be delivered to the shareholder upon request. Transfer of registered shares

shall be effected by a declaration of transfer inscribed in the register of shareholders, dated and signed by the transferor
and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney to act therefore.

The Company may redeem its own shares within the limits set forth by law.
The Company´s authorized share capital is set at one million Euro (EUR 1,000,000.-).
The board of directors is fully authorized and appointed:
- to render effective such increase of capital as a whole at once, by successive portions or by continuous issues of new

shares, to be paid up in cash, by contribution in kind, by conversion of shareholders' claims, or following approval of the
annual general meeting of shareholders, by incorporation of profits or reserves into capital;

- to determine the place and the date of the issue or of the successive issues, the subscription price, the terms and

conditions of subscription and payment of the additional shares.

- to suppress or limit the preferential subscription right of the shareholders with respect to the above issue of sup-

plementary shares against payment in cash.

Such authorization is valid for a period of five years starting from the date of publication of the present deed and may

be renewed by a general meeting of shareholders with respect to the shares of the authorized capital which at that time
shall not have been issued by the board of directors.

As a consequence of each increase of capital so rendered effective and duly documented in notarial form, the first

paragraph of the present article will be amended such as to correspond to the increase so rendered effective; such
modification will be documented in notarial form by the board of directors or by any persons appointed for such purposes.

Moreover, the Board of Directors is authorised to issue convertible bonds, in registered or bearer form, with any

denomination and payable in any currencies. Any issue of convertible bonds may only be made within the limits of the
authorised capital. The Board of Directors shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of issue
and reimbursement and any other conditions which may be related to such bond issue. A ledger of the registered bond-
holders will be held at the registered office of the company.

Art. 6. Increase or Reduction of capital. The issued share capital of the Company may be increased or reduced by a

resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of the Articles of Incorporation.

Art. 7. Meetings of shareholders - General. Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall

represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify
acts relating to the operations of the Company.

The quorum and time required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings of shareholders of the

Company, unless otherwise provided herein.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person

as his proxy in writing, by fax or telegram.

Except as otherwise required by law, resolutions at a meeting of shareholders duly convened will be passed by a simple

majority of those present and voting.

Any shareholder may participate in any meeting of shareholders by video conference or by way of similar means of

communications allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at
such meeting or the holding of a meeting in person.

The board of directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders for them to take part

in any meeting of shareholders. If all of the shareholders are present or represented at a meeting of shareholders, and if
they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

As the case may be, the Sole Shareholder exercises the powers granted to the meeting of shareholders under the

provisions of section XII of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 8. Annual general meeting of shareholders. The annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance

with Luxembourg law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified
in the notice of meeting on the third Friday of June at 2 p.m. and for the first time in 2016.

28628

L

U X E M B O U R G

If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following

bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the board of
directors, exceptional circumstances so require.

Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of

meeting.

General meetings of shareholders shall usually be convened by the board of directors. General meetings of shareholders

shall be convened pursuant to a notice given by the board of directors setting forth the agenda and sent by registered
letter at least eight days prior to the meeting to each shareholder and to the shareholder's address as recorded in the
register of shares.

Art. 9. Board of directors. The Company shall be managed by a board of directors composed of a minimum of three

members who need not be shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the annual meeting of shareholders for a period of maximum six years. Directors

may be re-elected.

A director may be removed with or without cause and replaced at any time by a resolution adopted by the shareholders.
In case of vacancy in the office of a director, the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis. The

next general meeting shall make the final appointment.

Art. 10. Procedures of meetings of the board of directors. The board of directors may choose from among its members

a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who needs not be a director, who shall be responsible
for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

The board of directors shall meet upon call by the chairman or two directors at the place indicated in the notice of

meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors shall be given to all directors at least twenty-four hours in

advance of such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax, telegram or e-mail of
each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a
schedule previously adopted by resolution of the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy. The proxy

may be given by facsimile. A director may represent more than one of his colleagues.

The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present or represented

at a meeting of the board of directors. Decision shall be taken by a majority of the votes of the directors present or
represented at such meeting.

In the event that any director of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company

(other than that arising by virtue of serving as a director, officer or employee in the other contracting party), such director
shall make known to the board of directors such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions,
and such director's interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call or by other similar means of

communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one
another. A meeting may also be held by conference call only. The participation of a director in a meeting by these means
is equivalent to a participation in person at such meeting.

The minutes of the meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman

pro tempore who presided at such meeting and one other director.

Resolutions of the board of directors may unanimously be passed in writing or by facsimile at the instigation of every

director. Resolutions in writing that are signed by every director are equal to resolutions passed in physical meetings of
the board of directors. Such resolutions may be approved by every director in writing, by facsimile, e-mail or any other
similar means of communication. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

Art. 11. Powers of the board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to perform all

acts of administration and disposition in the Company's interests and within the limits of Securitisation Law. All powers
not expressly reserved by law or by the present Articles of Incorporation to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the board of directors.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the

representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may
constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and
special mandates to any persons who need not be directors.

Art. 12. Signatory authority. The Company will be bound by the joint signature of two directors of the Company or

by the joint or single signature of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the
board of directors.

28629

L

U X E M B O U R G

Art. 13. Statutory auditor. The accounts of the Company shall be audited by an independent and duly authorised

auditor (réviseur d'entreprises agréé) who need not be a shareholder. The statutory auditor shall be appointed or re-
moved by the board of directors.

Art. 14. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first day of January of each year and shall

terminate on the last day of December of the same year, with the exception of the first financial year, which shall begin
on the date of incorporation of the Company and shall terminate on 31 December 2015.

Art. 15. Appropriation of profits. From the annual net profits, five per cent (5 %) shall be allocated to the reserve

required by law, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital.

The general meeting of shareholders, upon recommendation of the board of directors, shall determine how the re-

mainder of the annual net profits shall be disposed of and may, without ever exceeding the amounts proposed by the
board of directors, declare dividends from time to time.

Interim dividends may be distributed, subject to the conditions laid down by of 10 August 1915 on commercial com-

panies, as amended, upon decision of the board of directors and approval by the statutory auditor.

The dividends declared may be paid in any currency selected by the board of directors and may be paid at such places

and times as may be determined by the board of directors.

The board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds

into the currency of their payment.

A dividend declared but not paid on a share during five years cannot thereafter be claimed by the holder of such share,

shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company.

No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of

shares.

Art. 16. Dissolution and Liquidation. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out

by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of shareholders
effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

Each Compartment of the Company may be liquidated separately without such liquidation resulting in the liquidation

of another Compartment.

Art. 17. Amendment of Articles of Incorporation. These Articles of Incorporation may be amended from time to time

by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by Luxembourg law.

Art. 18. Governing law. All matters not governed by these Articles of Incorporation shall be determined in accordance

with the Securitisation Law and the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Art. 19. Segregation of assets. If as of any payment date of the assets relating to a compartment (including a hedging

agreement entered into by the Company in connection with a compartment) the total amount of monies received under
the assets of that compartment exceeds the payments to be made by the Company under the same compartment, the
board of directors may use the excess amount to pay off the claims of those creditors of the Company whose claims
cannot be allocated to a particular compartment.

The assets allocated to a compartment are exclusively available to (1) the investors in that compartment (the “Inves-

tors”),  (2)  the  creditors  whose  claims  have  arisen  in  connection  with  the  creation,  operation  or  liquidation  of  that
compartment and who are provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue documentation (the
“Transaction  Creditors”),  (3)  the  creditors  whose  claims  have  arisen  in  connection  with  the  creation,  operation  or
liquidation of that compartment and who are not provided for in the priority of payments provisions of the relevant issue
documentation (the “Compartment-Specific Claims Creditors” and, together with the Transaction Creditors, the “Cre-
ditors”) and (4), subject to the provisions of the next following paragraph, the creditors whose claims have not arisen in
connection with the creation, operation or liquidation of a compartment and who have not waived their recourse to the
assets of any compartment of the Company (the “Non Compartment-Specific Claims Creditors”).

The rights of the Non Compartment-Specific Claims Creditors shall be allocated by the Company, on a half year basis

in arrears, to all the compartments, on an equal basis and pro rata temporis for compartments created within such half
year, where the relevant issue documentation expressly authorises Non Compartment-Specific Claims Creditors to have
recourse against the assets allocated to such compartments. Such right of a Non Compartment-Specific Claims Creditor
against a compartment are hereinafter referred to as the “Pro Rata Rights”.

The Investors and the Creditors acknowledge and accept that once all the assets allocated to the compartment under

which they have invested or in respect of which their claims have arisen, have been realised, they are not entitled to take
any further steps against the Company to recover any further sums due and the right to receive any such sum shall be
extinguished. Each Non Compartment-Specific Claims Creditor acknowledges and accepts that once all the assets allo-
cated to a compartment in respect of which it has Pro Rata Rights, have been realised, it is not entitled to take any further
steps against the Company to recover such Pro Rata Rights and the right to receive any sum in respect of the Pro Rata
Rights shall be extinguished.

28630

L

U X E M B O U R G

The Compartment-Specific Claims Creditors and the Non Compartment-Specific Claims Creditors expressly accept,

and shall be deemed to have accepted by entering into contractual obligations with the Company, that priority of payment
and waterfall provisions will be included in the relevant issue documentations and they expressly accept, and shall be
deemed to have accepted the consequences of such priority of payments and waterfall provisions.

The rights of the shareholders of the Company are limited to the assets of the Company which are not allocated to

a compartment.

Art. 20. Prohibition to petition for bankruptcy of the Company or to seize the assets of the Company. In accordance

with article 64 of the Securitisation Law, any Investor in, and any Creditor and shareholder of, the Company and any
person which has entered into a contractual relationship with the Company (the “Contracting Party”) agrees, unless
expressly otherwise agreed upon in writing between the Company and the Investor, the Creditor or the Contracting
Party, not to (1) petition for bankruptcy of the Company or request the opening of any other collective or reorganisation
proceedings against the Company or (2) seize any assets of the Company, irrespective of whether the assets in question
belong to (i) the compartment in respect of which the Investor has invested or in respect of which the Creditor or the
Contracting Party have contractual rights against the Company, (ii) any other compartment or (iii) the assets of the
Company which have not been allocated to a compartment (if any).

Art. 21. Subordination. Any claims which the shareholders of the Company may have against the Company (in such

capacity) are subordinated to the claims which any creditors of the Company (including the Creditors) or any investors
in the Company (including the Investors) may have.

The Investors accept and acknowledge that their rights under a compartment may be subordinated to the rights of

other Investors under, and/or Creditors of, the same compartment.

<i>Subscriptions

The shares have been subscribed as follows:

Name of subscriber

Number of

subscribed

Shares

Value

Stichting Hoeksteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

EUR 31,000.-

The shares have been fully paid up by payment in cash, evidence of which was given to the undersigned notary.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a

result of its formation are estimated at approximately EUR 3,000.-.

<i>Statements

The undersigned notary acknowledges that the conditions required by articles 26, 26-3 and 26-5 of the law of 10

August 1915 on commercial companies, as amended have been observed and that the present Articles of Incorporation
comply with the provision of article 27 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

<i>Extraordinary general meeting

The sole shareholder, exercising the powers of the general meeting of shareholders and representing the entire share

capital of the Company, has immediately passed the following resolutions:

<i>First resolution

The following have been elected as directors, their mandate expiring at the issue of the annual general meeting to be

held in 2016:

a) Elmar Christopher Diener, residing professionally in Grafenauweg 4, 6300 Zug, Switzerland, born in Vienna, on

3.10.1976

b) Utz Schüller, residing professionally in 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, born in Munich, on

6.6.1977

c) René Thiel, residing professionally in 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, born in Hamburg,

on 22.05.1971

<i>Second resolution

The registered office of the Company shall be at L-5365 Munsbach, 9A, rue Gabriel Lippmann, Grand-Duchy of Lu-

xembourg.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day first mentioned above.

28631

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the appearing person, known to the notary, by his name, first name, civil status

and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorangegangenen Textes:

Im Jahr zweitausendvierzehn, am neunundzwanzigsten Dezember.
Vor uns Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg.

Ist erschienen:

Stichting Hoeksteen, eine holländische Stiftung mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, Luna ArenA, Herikerbergweg 238,

1101 CM Amsterdam, P.O. Box 23393 1100 DW Amsterdam Zuidoost,

hier vertreten durch Thorsten Lakus, Fund Consultant der LRI Invest S.A., beruflich ansässig in 9A, rue Gabriel Lipp-

mann, 5365 Munsbach, Luxembourg,

gemäß privatschriftlicher Vollmacht, ausgestellt in Amsterdam am 23. Dezember 2014.
Die Vollmacht soll, nach Zeichnung durch die erscheinende Person und den unterzeichneten Notar, dieser Urkunde

zu Registrierungszwecken beigefügt bleiben.

Die erscheinende Partei, in ihrer handelnden Befugnis, hat den unterzeichneten Notar gebeten, die Satzung einer

Verbriefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne des Gesetzes vom 22. März 2004
über Verbriefungen, die hiermit gegründet wird, wie folgt festzuhalten:

Art. 1. Form, Name. Es wird hiermit zwischen den Unterzeichneten und all denen, die Inhaber der im Anschluss

ausgegebenen Aktien werden, eine Verbriefungsgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft (société anonyme) im Sinne
des Gesetzes vom 22. März 2004 über Verbriefungen (das "Verbriefungsgesetz") mit dem Namen "Thalos Investment
Platform S.A." (die „Gesellschaft“) gegründet.

Die Gesellschaft kann einen (der „Alleinige Aktionär“) oder mehrere Aktionäre haben.

Art. 2. Dauer.  Die  Gesellschaft  wird  auf  unbestimmte  Zeit  gegründet.  Die  Gesellschaft  kann  zu  jeder  Zeit  durch

Beschluss  der  Generalversammlung  der  Aktionäre  in der  für die Änderung der  vorliegenden  Satzung  (die "Satzung")
vorgesehenen Form aufgelöst werden.

Im Falle des Verlustes der Rechtsfähigkeit, Liquidation oder des Todes des Alleinigen Aktionärs, wird die Gesellschaft

nicht aufgelöst.

Art. 3. Zweck der Gesellschaft. Der Zweck der Gesellschaft ist das Agieren als Verbriefungsgesellschaft im Sinne des

Verbriefungsgesetzes, durch Ankauf, Finanzierung oder Übernahme, direkt oder über andere Unternehmen, von Risiken
in Zusammenhang mit Forderungen, sonstigen Vermögenswerten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle Arten von
Wertpapieren, Darlehen, Forderungen und sonstigen beweglichen oder unbeweglichen, materiellen oder immateriellen
Vermögenswerten) oder jedweder Art von durch Dritte übernommenen Verpflichtungen oder Risiken die gesamt oder
teilweise den Aktivitäten Dritter eigen sind (die "Basiswerte").

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes alle Arten von Wertpapieren ausgeben, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf Aktien, Genussscheine, Schuldtitel sowie Optionen oder Garantien auf Anteilsrechte, deren
Wert, Ertrag oder Rendite direkt oder indirekt von solchen Risiken in Bezug auf die Basiswerte abhängen (jedes eine
"Verbriefung").

Die Gesellschaft kann als unregulierter Verbriefungsorganismus und in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes öffent-

lich ausgeben. Die Gesellschaft kann, unter Beachtung der Grenzen des Verbriefungsgesetzes, Mittel von jeder Rechts-
persönlichkeit  tilgen  oder  aufbringen,  um  Basiswerte  zu  finanzieren  und/oder  um  Zahlungen  oder  Verpflichtungen
nachzukommen, die sie aus irgendeiner ihrer Verbriefungen oder aus irgendeiner eingegangenen Vereinbarung im Kontext
einer Verbriefung besitzt.

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann, entweder im Kontext eines Verbriefungsplans oder nicht, ein oder mehrere

Teilvermögen gründen, die bestimmte spezifische Wertpapiere, Instrumente, Forderungen oder Vermögenswerte und/
oder Risiken in Bezug darauf umfassen (die "Teilvermögen").

Die Gesellschaft kann Serien oder Tranchen von Wertpapieren ausgeben, um Zweifel auszuräumen, einschließlich

Aktien oder Genussscheine, deren Wert und das Recht auf Dividenden oder Renditen an ein oder mehrere spezifische
Teilvermögen oder an spezifische Vermögenswerte oder Risiken gebunden sind, oder deren Rückzahlung von der Rück-
zahlung anderer Beteiligungen oder bestimmter Forderungen abhängig ist.

Die Gesellschaft kann über jedes Mittel jeden oder alle Basiswerte verkaufen, übertragen, zurückkaufen und dispo-

nieren (einschließlich mittels Verkauf, Übertragung, Austausch, Abgabe oder durch Derivate oder Swap-Transaktionen),
wie in den Bedingungen der betreffenden Wertpapiere oder Emissionsprospekte oder Informationsmemoranden be-
schrieben, und im Allgemeinen die Basiswerte in einer kontinuierlichen und laufenden Weise verwalten.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes im Kontext ihrer Verbriefungen folgendermaßen vor-

gehen: (i) Erwerb, Halten und Veräußern in jeder Form und durch jedes Mittel, direkt oder indirekt, von Anteilen, Rechten
und Beteiligungen an und Obligationen von luxemburgischen und anderen Gesellschaften, inklusive des Gewährens von
Darlehen an solche Gesellschaften, (ii) Erwerb durch Kauf, Zeichnung oder auf irgendeine andere Weise, oder die Über-

28632

L

U X E M B O U R G

tragung durch Verkauf, Tausch oder auf irgendeine andere Weise von Aktien, Anleihen, Pfandbriefen, Schuldscheinen und
anderen Wertpapieren oder Finanzinstrumenten aller Art und Verträge dazu oder mit Bezug darauf und (iii) Eigentü-
merschaft, Administrieren, Entwicklung und Verwaltung eines Portfolios (u.a. einschließlich der oben in Punkt (i) und (ii)
erwähnten Vermögenswerte). Die Gesellschaft kann außerdem Beteiligungen an Personengesellschaften, Kommanditge-
sellschaften, Trusts, Fonds und anderen Einheiten erwerben, halten und darüber verfügen.

Die Gesellschaft kann in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes jede Art von Sicherungsrechten unter jedem Gesetz

gegenüber jedem Treuhänder, Sicherheitentreuhänder, Sicherheitenverwalter, Treuhandsrepräsentanten oder jeder an-
deren Person garantieren, welche die Investoren oder jede andere Partei repräsentieren, die in die Verbriefung involviert
sind, oder mit der die Gesellschaft in Vereinbarungen in Verbindung mit einer Verbriefung eingetreten ist, um die Zahlung
oder andere Verpflichtungen aus jedem beliebigen Vertrag abzusichern, in den die Gesellschaft in Verbindung mit einer
Verbriefung eingetreten ist. Die Gesellschaft kann in jede beliebige Vereinbarung oder in Beteiligungen (einschließlich,
aber nicht beschränkt auf Derivate) eintreten und kann jedes Dokument ausgeben, unterzeichnen, genehmigen oder
ratifizieren und kann alle Akte tätigen und erlauben, die nötig sind, eine Verbriefung vorzubereiten, durchzuführen und
abzuwickeln oder die ihr selbst entsprechen.

Die Gesellschaft kann alle Schritte und jede Transaktion ergreifen, die für die Erfüllung und Durchführung ihres Zwecks

dienlich erscheint und im weitesten Sinne mit dem Verbriefungsgesetz im Einklang stehen.

Art. 4. Gesellschaftssitz. Der Sitz der Gesellschaft ist in Munsbach eingerichtet. Innerhalb derselben Gemeinde kann

der Firmensitz durch einfachen Verwaltungsratsbeschluss verlegt werden.

Für den Fall, dass der Verwaltungsrat feststellt, dass außergewöhnliche, politische, wirtschaftliche oder soziale Ent-

wicklungen eingetreten sind oder bevorstehen, welche mit der normalen Tätigkeit der Gesellschaft an ihrem Firmensitz
interferieren könnten, oder die Kommunikation zwischen einem solchen Büro und Personen im Ausland einfacher ist,
kann der Firmensitz temporär ins Ausland verlegt werden, bis die abnormen Umstände vollständig beigelegt sind; eine
solche temporäre Maßnahme hat keinen Effekt auf die Nationalität der Gesellschaft, die, ungeachtet der temporären
Verlagerung des Firmensitzes, eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

Art. 5. Kapital - Aktien und Aktienzertifikate. Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft ist auf einunddreißigtausend

Euro (EUR 31.000) festgesetzt, unterteilt in dreihundertzehn (310) Aktien mit einem Nominalwert von hundert Euro
(EUR 100) pro Aktie.

Aktien werden nur als Namensaktien begeben.
Die Gesellschaft betrachtet die Person, auf welche die Aktien im am Gesellschaftssitz geführten Aktionärsregister

registriert sind, als rechtlichen Eigentümer dieser Aktien.

Bestätigungen über solche Eintragungen werden an den Aktionär auf Anfrage zugestellt. Die Übertragung von Na-

mensaktien  wird  durch  eine  Erklärung  über  die  erfolgte  Übertragung  im  Aktionärsregister  durchgeführt,  datiert  und
unterzeichnet vom Veräußerer und vom Erwerber oder den Personen mit entsprechender Handlungsvollmacht.

Die Gesellschaft kann ihre eigenen Aktien innerhalb der gesetzlichen Fristen zurücknehmen.
Die Gesellschaft hat ein genehmigtes Kapital von einer Million Euro (EUR 1.000.000).
Der Verwaltungsrat wird ermächtigt und beauftragt
- diese Kapitalerhöhung zu tätigen, besonders die neuen Aktien in einer Gesamtausgabe, in Teilausgaben in Abständen

oder fortlaufend auszugeben mittels Einzahlung durch Bareinlagen, Sacheinlagen, Umwandlung von Forderungen oder
auch, nach Genehmigung durch die jährliche Hauptversammlung, mittels Einbeziehen von Gewinnen oder Reserven.

- den Ort und den Zeitpunkt der Gesamtausgabe oder der eventuellen einzelnen Teilausgaben, den Emissionspreis,

sowie die Zeichnungs- und Einzahlungsbedingungen festzulegen

- das Vorzugsrecht zur Zeichnung der Aktionäre bei der obengenannten Neuausgabe von Aktien mittels Einzahlung

von Bareinlagen aufzuheben oder einzuschränken.

Diese Ermächtigung ist gültig für eine Dauer von fünf Jahren, beginnend mit dem Datum der Veröffentlichung der

gegenwärtigen Urkunde und kann bezüglich der Aktien des genehmigten Kapitals welche bis zu diesem Zeitpunkt noch
nicht ausgegeben wurden, durch eine Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden.

Nach jeder durch den Verwaltungsrat durchgeführten und rechtsmäßig beurkundeten Kapitalerhöhung wird der erste

Abschnitt des vorliegenden Artikels entsprechend abgeändert. Dem Verwaltungsrat oder jeder dazu bevollmächtigten
Person obliegt es, diese Aenderung durch notarielle Urkunde bestätigen zu lassen.

Art. 6. Kapitalerhöhungen oder - reduzierungen. Das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss

der Aktionäre in der für die Änderung dieser Satzung vorgesehenen Form erhöht oder reduziert werden.

Art. 7. Generalversammlungen der Aktionäre - Allgemein. Die rechtmäßig konstituierte Generalversammlung der

Aktionäre der Gesellschaft soll die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft repräsentieren. Sie besitzt die weitestge-
hende  Vollmacht,  Handlungen  in  Bezug  auf  die  Operationen  der  Gesellschaft  anzuordnen,  durchzuführen  oder  zu
ratifizieren.

Wenn in dieser Satzung nicht anders bestimmt, sollen die gesetzlichen Quorums- und Zeitraumanforderungen die

Ladungs- und Durchführungsmodalitäten der Generalversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft bestimmen.

28633

L

U X E M B O U R G

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme. Ein Aktionär kann in der Generalversammlung der Aktionäre durch Ernennung

einer anderen Person an seiner statt handeln, die Ernennung erfolgt schriftlich, per Fax oder Telegramm.

Wenn per Gesetz nicht anders bestimmt, erfolgt die Beschlussfassung in einer Generalversammlung der Aktionäre

durch einfache Mehrheit der anwesenden und abgegebenen Stimmen.

Jeder Aktionär hat das Recht an jeder Generalversammlung der Aktionäre über Videokonferenz oder ähnliche Kom-

munikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben mit den anderen zu kommunizieren. Die
Teilnahme oder die Abhaltung einer Versammlung über diese Mittel ist mit der persönlichen Teilnahme oder der per-
sönlichen Abhaltung einer Versammlung gleichwertig.

Der Verwaltungsrat kann alle weiteren Bedingungen bestimmen, die für die Teilnahme der Aktionäre an der Gene-

ralversammlung der Aktionäre erfüllt sein müssen. Wenn alle Aktionäre in einer Generalversammlung der Aktionäre
anwesend oder vertreten sind, und wenn sie anführen, dass sie über die Tagesordnung der Versammlung informiert
wurden, kann die Versammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Je nach Fallgestaltung, übt der Alleinige Aktionär die Rechte aus, die nach Abschnitt XII des Gesetzes vom 10. August

1915 über Handelsgesellschaften, in der aktuell gültigen Fassung der Generalversammlung der Aktionäre zugewiesen sind.

Art. 8. Jährliche Generalversammlung der Aktionäre. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre soll in Einklang

mit den Luxemburger Gesetzen am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Platz in Luxemburg, wie in der Einbe-
rufung der Versammlung angeführt, am dritten Freitag des Monats Juni um 14:00 Uhr nachmittags abgehalten werden,
erstmals im Jahr 2016.

Ist so ein Tag kein Bankarbeitsstag in Luxemburg, wird die jährliche Generalversammlung der Aktionäre am nächst

folgenden Bankarbeitstag abgehalten. Die jährliche Generalversammlung der Aktionäre kann im Ausland abgehalten wer-
den,  wenn  nach  absolutem  und  endgültigem  Beschluss  des  Verwaltungsrats  die  außergewöhnlichen  Umstände  dies
erfordern.

Andere Generalversammlung der Aktionäre können an einem Ort und zu einer Zeit abgehalten werden, wie in der

entsprechenden Einberufung der Versammlung angeführt.

Generalversammlungen der Aktionäre werden für gewöhnlich durch den Verwaltungsrat einberufen. Die Einberufung

zur Generalversammlung erfolgt schriftlich unter Bekanntmachung der Tagesordnung und per Einschreiben, das mindes-
tens acht (8) Tage vor dem Datum der Generalversammlung der Aktionäre an jeden Aktionär an seine eingetragene
Adresse verschickt wird.

Art. 9. Verwaltungsrat. Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat bestehend aus mindestens drei Mitgliedern

geführt, die keine Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

Die Verwaltungsratsmitglieder werden in der jährlichen Generalversammlung der Aktionäre für eine Dauer von ma-

ximal sechs Jahren gewählt. Die Verwaltungsratsmitglieder können wiedergewählt werden.

Ein Verwaltungsratsmitglied kann zu jeder Zeit mit oder ohne Begründung durch Aktionärsbeschluss abgesetzt oder

ausgetauscht werden.

Wird die Stelle eines Verwaltungsratsmitglieds frei, können die verbleibenden Verwaltungsratsmitglieder das freige-

wordene  Amt  vorläufig  besetzen.  Die  nächste  Generalversammlung  der  Aktionäre  wird  die  endgültige  Bestellung
vornehmen.

Art. 10. Verfahren für Sitzungen des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat bestellt aus dem Kreise seiner Mitglieder

einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Es kann auch ein Sekretär gewählt werden, der kein Ver-
waltungsratsmitglied sein muss und der für die Abfassung des Protokolls der Verwaltungsratssitzung und der Aktionäre
verantwortlich sein soll.

Der Verwaltungsrat soll nach Einberufung durch den Vorsitzenden oder von zwei Verwaltungsratsmitgliedern an einem

in der Einberufung genannten Ort zusammentreten.

Die Einberufung hat unter Mitteilung der Tagesordnung zumindest vierundzwanzig Stunden vor der Sitzung zu erfolgen,

außer in Notfällen, in welchen Fällen die Art des Notfalls in der Einladung vermerkt wird. Auf diese Einladung kann
übereinstimmend schriftlich, durch Telefax, Telegramm oder Email verzichtet werden. Eine Einladung ist nicht notwendig
für Sitzungen, welche zu Zeitpunkten und an Orten abgehalten werden, die zuvor in einem Verwaltungsratsbeschluss
bestimmt worden waren.

Jedes Verwaltungsratsmitglied kann in einer Verwaltungsratssitzung durch Ernennung eines anderen Verwaltungsrats-

mitglieds an seiner statt handeln. Die Bevollmächtigung kann per Fax vollzogen werden. Ein Verwaltungsratsmitglied kann
mehrere seiner Kollegen vertreten.

Der Verwaltungsrat kann nur gültig handeln oder beschießen, wenn zumindest die Mehrheit der Verwaltungsratsmit-

glieder in einer Verwaltungsratssitzung anwesend oder vertreten ist. Der Beschluss erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit
der anwesenden oder vertretenen Verwaltungsratsmitglieder.

Für den Fall, dass ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der

Gesellschaft haben könnte (anders als jenes, das aus der Funktion als Verwaltungsratsmitglied, leitender Mitarbeiter oder
Angestellter der anderen Vertragspartei entsteht), soll dieses sein persönliches Interesse dem Verwaltungsrat bekannt-

28634

L

U X E M B O U R G

geben und solche Transaktionen nicht beachten und nicht über sie abstimmen, und dieses Interesse des Verwaltungs-
ratsmitglieds wird an die nächstfolgende Generalversammlung der Aktionäre berichtet.

Jedes Verwaltungsratsmitglied hat das Recht an jeder Verwaltungsratssitzung per Videokonferenz oder ähnliche Kom-

munikationsmittel teilzunehmen, die es den teilnehmenden Personen erlauben teilzunehmen und mit den anderen zu
kommunizieren. Eine Versammlung kann auch über Konferenzschaltung abgehalten werden. Die Teilnahme an Versamm-
lungen eines Verwaltungsratsmitgliedes über diese Mittel ist der persönlichen Teilnahme an einer Versammlung gleich-
zusetzen.

Das Protokoll der Verwaltungsratssitzung wird vom Vorsitzenden unterschrieben, oder im Falle seiner Abwesenheit,

durch den stellvertretenden Vorsitzenden und ein weiteres Verwaltungsratsmitglied, die in der Versammlung anwesend
waren.

Auf Veranlassung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds können Beschlüsse des Verwaltungsrates auch einstimmig durch

Brief oder Telefax gefasst werden. Schriftliche und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnete Beschlüsse stehen
Beschlüssen auf Verwaltungsratssitzungen gleich. Solche Beschlüsse können von jedem Verwaltungsratsmitglied schriftlich,
durch Telefax oder Email gebilligt werden. Eine solche Billigung wird jedenfalls schriftlich bestätigt und die Bestätigung
wird dem Beschlussprotokoll beizufügen sein.

Art. 11. Befugnisse des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat ist mit den weitestgehenden Befugnissen ausgestattet,

um die Verwaltungs- und Dispositionsakte im Interesse der Gesellschaft in den Grenzen des Verbriefungsgesetzes durch-
zuführen. Alle Vollmachten, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung der Generalversamm-
lung der Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat kann seine Vollmachten delegieren, um die tägliche Verwaltung und die Geschäfte der Gesellschaft

auszuführen und um die Gesellschaft für solche Verwaltungen und Geschäfte zu repräsentieren. Die Delegation kann an
jedes Mitglied oder an Mitglieder des Verwaltungsrats erfolgen, die Gremien bilden können, um unter den vom Verwal-
tungsrat festgelegten Bestimmungen zu beschließen. Er kann auch alle Vollmachten oder spezielle Mandate an beliebige
Personen delegieren, die keine Verwaltungsratsmitglieder sind.

Art. 12. Zeichnungsberechtigung. Die Gesellschaft wird durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern der Gesellschaft oder die gemeinsame oder einzelne Unterschrift einer beliebigen Person oder Personen
verpflichtet, der oder denen die Zeichnungsberechtigung durch den Verwaltungsrat übertragen wurde.

Art. 13. Unabhängiger Wirtschaftsprüfer. Die Buchhaltung der Gesellschaft soll durch einen unabhängigen und ent-

sprechend autorisierten Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprise agréé) geprüft werden, der kein Aktionär sein muss.
Der unabhängige Wirtschaftsprüfer wird durch den Verwaltungsrat berufen oder entlassen.

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar jedes Kalenderjahres und endet

am letzten Tag im Dezember desselben Jahres, mit Ausnahme des ersten Geschäftsjahres, das mit dem Datum der Grün-
dung der Gesellschaft beginnt und mit dem 31. Dezember 2015 endet.

Art. 15. Gewinnverwendung. Vom jährlichen Nettogewinn werden fünf Prozent (5 %) der gesetzlichen Rückstellung

zugeteilt, bis diese Rückstellung zehn Prozent (10%) des Aktienkapitals erreicht.

Die Generalversammlung der Aktionäre wird auf Empfehlung des Verwaltungsrats bestimmen, wie der Rest des jähr-

lichen Nettogewinns verteilt und Dividenden von Zeit zu Zeit festgelegt werden, ohne dabei jemals die vorgeschlagenen
Beträge des Verwaltungsrats zu übersteigen.

Zwischendividenden können ausgeschüttet werden, gemäß den Vorschriften des Gesetzes vom 10. August 1915 über

Handelsgesellschaften, in der aktuell gültigen Fassung und nach Beschluss des Verwaltungsrats und Genehmigung durch
den unabhängigen Wirtschaftsprüfer.

Die erklärten Dividenden können nach Wahl des Verwaltungsrats in jeder Währung ausbezahlt werden, und an Orte

und zu Zeiten, wie sie der Verwaltungsrat bestimmt.

Der Verwaltungsrat trifft die letztgültige Festlegung über die anzuwendenden Wechselkurse, um die Dividenden in die

Zahlungswährung umzurechnen.

Eine erklärte aber nicht ausbezahlte Dividende verfällt nach fünf Jahren und kann vom betreffenden Aktionär nicht

mehr eingefordert werden und fällt der Gesellschaft zu.

Für erklärte aber nicht geforderte Dividenden, die von der Gesellschaft für die Aktionäre gehalten werden, werden

keine Zinsen bezahlt.

Art. 16. Auflösung und Liquidation. Für den Fall, dass die Gesellschaft aufgelöst wird, soll die Liquidation durch einen

oder mehrere Liquidatoren (die natürliche oder juristische Personen sein können) durchgeführt werden. Sie werden
durch die Generalversammlung der Aktionäre ernannt, um die Auflösung durchzuführen, und ihre Vollmachten und ihr
Gehalt wird durch sie festgelegt.

Jedes Teilvermögen der Gesellschaft kann getrennt liquidiert werden, ohne dass diese Liquidation zur Liquidation eines

anderen Teilvermögens führt.

Art. 17. Abänderung der Satzung. Diese Satzung kann von Zeit zu Zeit durch die Generalversammlung der Aktionäre

abgeändert werden, gemäß Quorum und Stimmerfordernissen nach den Luxemburger Gesetzen.

28635

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Geltendes Recht. Alle Belange, die nicht durch diese Satzung geregelt sind, unterliegen dem Verbriefungsgesetz

und dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in ihrer jeweils gültigen Version.

Art. 19. Trennung der Vermögenswerte. Wenn am Zahlungstag der zu einem Teilvermögen zugehörigen Vermögens-

werte (einschließlich der durch die Gesellschaft abgeschlossenen Sicherungsverträge bezüglich eines Teilvermögens) die
komplette Menge an Geldern die im Zusammenhang mit diesem Teilvermögen empfangen wurde, die Zahlungen welche
die Gesellschaft in diesem Teilvermögen zu leisten hat, übersteigen, kann der Verwaltungsrat die überschüssige Summe
dazu nutzen die Forderungen der Gläubiger der Gesellschaft zu bezahlen, welche nicht einem bestimmten Teilvermögen
zugewiesen werden können.

Die einem Teilvermögen zugewiesenen Vermögenswerte stehen ausschließlich (1) den Investoren in dieses Teilver-

mögen zur Verfügung (die „Investoren“), (2) den Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen im Zusammenhang mit
der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung des Teilvermögens entstanden sind und die in den Regelungen zur Zah-
lungsrangfolge  in  der  relevanten  Emissionsdokumentation  berücksichtigt  sind  (die  „Transaktionsgläubiger“),  (3)  den
Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder der Auflösung
des Teilvermögens entstanden sind und die nicht in den Regelungen zur Zahlungsrangfolge in der relevanten Emissions-
dokumentation berücksichtigt sind (die „Gläubiger von teilvermögensspezifischen Forderungen“, und zusammen mit den
Transaktionsgläubigern, die „Gläubiger“) und (4) sofern die Bedingungen des folgenden Paragraphen berücksichtigt wer-
den, den Gläubigern zur Verfügung, dessen Forderungen nicht im Zusammenhang mit der Gründung, dem Betrieb oder
der Auflösung eines Teilvermögens entstanden sind und die nicht auf ihren Rückanspruch auf die Vermögenswerte aller
Teilvermögen der Gesellschaft verzichtet haben (die „Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen“).

Die Rechte der Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen sollen durch die Gesellschaft halbjährlich

rückwirkend allen Teilvermögen, gleichmäßig und pro rata temporis für in diesem Halbjahr entstandene Teilvermögen,
zugewiesen werden, sofern die relevante Emissionsdokumentation ausdrücklich Gläubigern von nicht-teilvermögensspe-
zifischen Forderungen erlaubt auf Vermögenswerte dieser Teilvermögen zuzugreifen. Solche Rechte von Gläubigern von
nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen auf ein Teilvermögen werden nachstehend als „Pro Rata Rechte“bezeichnet.

Die Investoren und Gläubiger bestätigen und akzeptieren dass sobald alle zu dem Teilvermögen, in das sie investiert

haben oder durch das ihre Forderungen entstanden sind, zugehörigen Vermögenswerte verwertet wurden, ihnen keine
weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Wiedererlangung zusätzlicher Summen offen stehen und das Recht solche
Summen zu empfangen, erloschen ist. Die Gläubiger von nicht-teilvermögensspezifischen Forderungen bestätigen und
akzeptieren, dass sobald alle zu einem Teilvermögen, in dem sie Pro Rata Rechte besitzen, zugehörigen Vermögenswerte
verwertet wurden, ihnen keine weiteren Schritte gegen die Gesellschaft zur Durchsetzung dieser Pro Rata Rechte offen
stehen und das Recht jedwede Summe aufgrund solcher Pro Rata Rechte zu empfangen, erloschen ist.

Die Gläubiger von teilvermögensspezifischen und nichtteilvermögensspezifischen Forderungen akzeptieren ausdrück-

lich, und ihre Annahme wird im Falle von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft vorausgesetzt, dass
die Zahlungsrangfolge und die waterfall Regelungen in die relevante Emissionsdokumentation eingefügt werden und dass
sie die Konsequenzen dieser Zahlungsrangfolge und der waterfall Regelungen ausdrücklich akzeptieren und gegebenenfalls
diese Annahme vorausgesetzt wird.

Die Rechte der Gesellschafter sind auf diejenigen Vermögenswerte begrenzt, die nicht einem Teilvermögen zugewiesen

wurden.

Art. 20. Verbot einen Insolvenzantrag für die Gesellschaft zu stellen oder die Vermögenswerte der Gesellschaft zu

pfänden. Gemäß Artikel 64 des Verbriefungsgesetzes erklärt sich jeder Investor, jeder Gläubiger und Gesellschafter der
Gesellschaft und jede Person welche in vertragliche Beziehungen mit der Gesellschaft getreten ist (die „Vertragspartei“)
bereit, außer es wurde ausdrücklich und schriftlich Gegenteiliges zwischen der Gesellschaft, dem Investor, dem Gläubiger
und der Vertragspartei vereinbart, (1) keinen Insolvenzantrag oder in sonstiger Weise die Eröffnung eines Gesamtvollst-
reckungs- oder Sanierungsverfahrens im Hinblick auf die Gesellschaft zu stellen oder zu beantragen oder (2) keinerlei
Vermögenswerte der Gesellschaft zu pfänden, ungeachtet dessen, dass die betroffenen Vermögenswerte (i) dem Teil-
vermögen angehören, in das der Investor investiert hat oder durch das dem Gläubiger oder der Vertragspartei vertragliche
Rechte gegen die Gesellschaft zustehen, (ii) jeglichem anderen Teilvermögen angehören oder (iii) zu den Vermögens-
werten der Gesellschaft gehören welche keinem Teilvermögen zugewiesen wurden (sofern vorhanden).

Art. 21. Rangrücktritt. Jegliche Forderung die ein Gesellschafter (in dieser Eigenschaft) gegen die Gesellschaft geltend

machen kann, tritt gegenüber den Forderungen jeglicher Gläubiger der Gesellschaft (einschließlich der oben definierten
Gläubiger) und jeglicher Investoren in die Gesellschaft (einschließlich der oben definierten Investoren) im Rang zurück.

Die Investoren akzeptieren und bestätigen, dass ihre Rechte an einem Teilvermögen hinter die Rechte anderer Inves-

toren, und / oder Gläubiger, in dem selben Teilvermögen im Rang zurücktreten können.

<i>Zeichnungen

Die Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

28636

L

U X E M B O U R G

Name des Zeichners

Anzahl der

gezeichneten

Aktien

Gesamtwert

Stichting Hoeksteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

310

EUR 31,000.-

Sämtliche Aktien wurden voll und bar eingezahlt, wie dies dem unterzeichneten Notar nachgewiesen wurde.

<i>Aufwendungen

Die Aufwendungen, Kosten, Honorare oder Gebühren aller Art, die anlässlich der Begründung der Gesellschaft ent-

stehen, werden etwa auf EUR 3.000.- geschätzt.

<i>Angaben

Der unterzeichnete Notar bestätigt, dass die erforderlichen Bedingungen aus den Artikeln 26, 26-3 und 26-5 des

Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften beachtet wurden und dass die vorliegende Satzung der Vor-
schrift des Artikels 27 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften entspricht.

<i>Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre

Der alleinige Aktionär, der die Vollmachten der Generalversammlung der Aktionäre ausübt und das gesamte Aktien-

kapital der Gesellschaft repräsentiert, hat sofort die folgenden Beschlüsse gefasst:

<i>Erster Beschluss

Die folgenden Personen werden für die Dauer bis zur Generalversammlung der Aktionäre im Jahre 2016 als Verwal-

tungsratsmitglieder bestellt:

a) Elmar Christopher Diener, beruflich ansässig in Grafenauweg 4, 6300 Zug, Switzerland, geboren in Wien, am 3.

Oktober 1976

b) Utz Schüller, beruflich ansässig in 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, geboren in München,

am 6. Juni 1977

c) René Thiel, beruflich ansässig in 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Luxembourg, geboren in Hamburg, am

22. Mai 1971

<i>Zweiter Beschluss

Der Firmensitz wird auf L-5365 Munsbach. 9A, rue Gabriel Lippmann festgelegt.
Der unterzeichnete Notar, der Englisch in Wort und Schrift beherrscht, erklärt hiermit, dass auf Antrag durch die

erscheinende Person die vorliegende Urkunde in englischer Sprache verfasst wurde und nachfolgend ins Deutsche über-
setzt wird; auf Antrag derselben erscheinenden Person und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und
deutschen Fassung des Textes soll die englische Version den Vorrang haben.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an den Komparenten, namens und handelnd wie hiervor er-

wähnt,  dem  instrumentierenden  Notar  nach  Namen,  gebräuchlichem  Vornamen,  Stand  und  Wohnort  bekannt,  hat
derselbe mit Uns dem Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: T. LAKUS und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/315. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 23. Januar 2015.

Référence de publication: 2015014671/617.
(150016518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Com Event More S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6970 Oberanven, 45A, rue Andethana.

R.C.S. Luxembourg B 156.091.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015015666/10.
(150018589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28637

L

U X E M B O U R G

DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 166.250.

In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of December.
Before us Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

1) AEA Investors Fund V LP, a limited partnership fund registered under the laws of the Cayman Islands, whose

registered office is at PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the Registrar
of Companies under number MC-48167,

being the holder of five hundred and ninety-two thousand, nine hundred and seventy-two (592,972) class A ordinary

shares,

here represented by Ms. Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy

given on 12 December 2014,

2) AEA Investors Fund V-A LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware, whose

registered office is at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, registered
with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5127331,

being the holder of nine thousand, eight hundred and ninety-one (9,891) class A ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014,
3) AEA Investors Fund V-B LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware, whose

registered office is at The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, registered
with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5186585,

being the holder of three thousand, two hundred and ninety-five (3,295) class A ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014
4) AEA Investors QP Participant Fund V LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of

Delaware, whose registered office is at the Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801,
USA, registered with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5015544,

being the holder of twenty thousand, three hundred and seventy-nine (20,379),
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014 class A

ordinary shares,

5) AEA Investors Participant Fund V LP, a limited partnership fund incorporated under the laws of the State of Delaware,

whose registered office is at the Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA, regis-
tered with the Office of the Secretary of State of the State of Delaware under number 5015541,

being the holder of eight thousand and fifteen (8,015) class A ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
6) AEA Europe Fund II LP, an exempted limited partnership fund incorporated under the laws of the Cayman Islands,

whose registered office is at PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Cayman Islands, registered with the
Registrar of Companies under MC-52184,

being the holder of one hundred and twenty-three thousand, four hundred and twenty-four (123,424) class A ordinary

shares,

here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
7) DH Services Employee Benefit Trust, represented by its trustee, RBC cees Trustee Limited whose registered office

is situated at 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 3PB, registered with the Jersey Financial Services
Commission under number 68138,

being the holder of thirty-five thousand, six hundred and forty (35,640) class B ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 16 December 2014.
8) DH C-Holdings, a limited liability company incorporated under the laws of the Cayman Islands, whose registered

address is at PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, registered with the Registrar of Companies under
MC-273742,

being the holder of one million, four hundred and seven thousand, five hundred (1,407,500) class C preference shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
9)  2348614  Ontario  Limited,  a  limited  liability  company  incorporated  under  the  laws  of  Ontario,  Canada,  whose

registered office is Yonge Street, Toronto, Ontario, M2M 4H5, registered with the Ministry of Governmental Services
of Ontario under number 002348614,

being the holder of seven hundred and fifty-seven thousand, nine hundred and seventy-six (757,976) class A ordinary

shares,

28638

L

U X E M B O U R G

here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
10) Mr. Cletus von Pichler, residing at Tizianstr. 129, 80638 Munich, Germany,
being the holder of two thousand, eight hundred (2,800) class B ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
11) G. Richard Wagoner Jr. Trust dated 7/13/89, as amended and restated 12/16/11, represented by its trustee, Mr.

G. Richard Wagoner Jr., born on 9 February 1953, with address at 1155 Quarton Road, Birmingham, MI 48009, USA,

being the holder of five thousand, six hundred (5,600) class B ordinary shares,
here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 12 December 2014.
12) RBC cees Nominees Limited, a limited liability company incorporated under the laws of Jersey, whose registered

office is situated at 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel Islands JE1 3PB, registered with the Jersey Financial
Services Commission under number 83756,

being the holder of twenty-five thousand, four hundred and twenty-six (25,426) class A ordinary shares and two

hundred thirty-seven thousand three hundred and eighty-five (237,385) class B ordinary shares,

here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 16 December 2014.
13) DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., as described below, being the temporary holder of one hundred and

thirty-one (131) class A ordinary shares,

here represented by Ms. Antje Reibold, previously named, by virtue of a proxy given on 16 December 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary, will

remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties are all the shareholders of/and DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., a société à respon-

sabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of thirty-two thousand,
three hundred and four United States Dollars and thirty-four cents (USD 32,304.34), with registered office at 2-8, avenue
Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies' Register under number B 166.250, incorporated pursuant to a deed of Maître Gérard Lecuit, notary residing in
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 27 December 2011, and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations n° 572 page 27410 on 5 March 2012 (the "Company"). The articles of association of the Company have
for the last time been amended following a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy
of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxem-
bourg, of 6 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3550 page 170392 on
25 November 2014.

The appearing parties representing the entire share capital declare having waived any notice requirement, the general

meeting of the shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1) Reduction of the share capital of the Company by an amount of one United States Dollar and thirty one cents (USD

$1.31) in order to reduce it from its present amount of thirty two thousand, three hundred and four United States Dollars
and thirty four cents (USD$32,304.34) to thirty two thousand three hundred and three United States Dollars and three
cents (USD$32,303.03) by cancellation of one hundred and thirty one (131) class A ordinary shares of the Company
having a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each;

2) Subsequent amendment of article 5.1 of the Company's articles of association so that it shall henceforth read as

follows:

“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty two thousand, three hundred and three United States Dollars and three cents

(USD$32,303.03), represented by three million two hundred and thirty thousand, three hundred and three (3,230,303)
shares in registered form, with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, which is
divided into:

(i) one million, five hundred and forty one thousand, three hundred and seventy eight (1,541,378) class A ordinary

shares (the “Class A Ordinary Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01)
each, all subscribed and fully paid up;

(ii) two hundred and eighty-one thousand, four hundred and twenty-five (281,425) class B ordinary shares (the “Class

B Ordinary Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, all subscribed
and fully paid up;

(iii) one million four hundred and seven thousand and five hundred (1,407,500) class C preference shares (the “Class

C Preference Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, and which
entitle to the Profit Entitlement as defined in article 14 below, all subscribed and fully paid up.”;

3) Miscellaneous.
Then, the voting shareholders requested the notary to enact the following resolutions:

28639

L

U X E M B O U R G

<i>First resolution

The general meeting of the shareholders resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of one

United States Dollar and thirty one cents (USD$1.31) in order to reduce it from its present amount of thirty-two thou-
sand, three hundred and four United States Dollars and thirty-four cents (USD$32,304.34) to thirty two thousand three
hundred and three United States Dollars and three cents (USD$32,303.03) by cancellation of one hundred and thirty one
(131) class A ordinary shares of the Company having a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD
$0.01) each, that are temporarily held by the Company following the redemption by the Company on 16 December 2014
of one hundred and thirty one (131) class A ordinary shares held in the Company by RBC cees Nominees Limited.

The general meeting of the shareholders took the above resolution with the following specified number of votes:
- Class A ordinary shares in favor: 1,520,242, against: 0, abstaining: 21,136
- Class B ordinary shares in favor: 67,543, against: 0, abstaining: 213,882, and
- Class C preference shares in favor: 1,407,500, against: 0, abstaining: 0.

<i>Second resolution

As a consequence of the above resolution, the general meeting of the shareholders resolves to amend article 5.1 of

the Company's articles of association so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at thirty two thousand, three hundred and three United States Dollars and three cents

(USD$32,303.03), represented by three million two hundred and thirty thousand, three hundred and three (3,230,303)
shares in registered form, with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, which is
divided into:

(i) one million, five hundred and forty one thousand, three hundred and seventy eight (1,541,378) class A ordinary

shares (the “Class A Ordinary Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01)
each, all subscribed and fully paid up;

(ii) two hundred and eighty-one thousand, four hundred and twenty-five (281,425) class B ordinary shares (the “Class

B Ordinary Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, all subscribed
and fully paid up;

(iii) one million four hundred and seven thousand and five hundred (1,407,500) class C preference shares (the “Class

C Preference Shares”), with a nominal value of zero point zero one United States Dollars (USD$0.01) each, and which
entitle to the Profit Entitlement as defined in article 14 below, all subscribed and fully paid up.”;

The general meeting of the shareholders took the above resolution with the following specified number of votes:
- Class A ordinary shares in favor: 1,520,242, against: 0, abstaining: 21,136
- Class B ordinary shares in favor: 67,543, against: 0, abstaining: 213,882, and
- Class C preference shares in favor: 1,407,500, against: 0, abstaining: 0.

<i>Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at one thousand five hundred euro.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le seizième jour de décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

ONT COMPARU:

1) AEA Investors Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée au Registre des
Sociétés sous le numéro MC-48167,

détentrice de cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-douze (592.972) parts sociales ordinaires de ca-

tégorie A,

ici représentée par Madame Antje Reibold, Rechtsanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une

procuration donnée le 12 décembre 2014,

28640

L

U X E M B O U R G

2) AEA Investors Fund V-A LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l'Etat du Delaware,

ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, enregistrée
auprès du Bureau du Ministre d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5127331,

détentrice de neuf mille huit cent quatre-vingt-onze (9.891) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
3) AEA Investors Fund V-B LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l'Etat du Delaware,

ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA, enregistrée
auprès du Bureau du Ministre d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5186585,

détentrice de trois mille deux cent quatre-vingt-quinze (3.295) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
4) AEA Investors QP Participant Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l'Etat

du Delaware, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801
USA, enregistrée auprès du Bureau du Ministre d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5015544,

détentrice de vingt mille trois cent soixante-dix-neuf (20.379) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
5) AEA Investors participant Fund V LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l'Etat du

Delaware, ayant son siège social à The Corporation Trust Company, 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801 USA,
enregistrée auprès du Bureau du Ministre d'Etat de l'Etat du Delaware sous le numéro 5015541,

détentrice de huit mille quinze (8.015) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
6) AEA Europe Fund II LP, une association à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des Iles Cayman, ayant

son siège social au PO Box 309, Ugland House, KY1-1104, Grand Cayman, Îles Cayman, enregistrée au Registre des
Sociétés sous le numéro MC-52184,

détentrice de cent vingt-trois mille quatre cent vingt-quatre (123.424) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
7) DH Services Employee Benefit Trust, représenté par son fiduciaire, RBC cees Trustee Limited, ayant son siège social

au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel islands JE1 3PB, enregistré à la Commission des Services Financiers de
Jersey sous le numéro 68138,

détenteur de trente-cinq mille six cent quarante (35.640) parts sociales ordinaires de catégorie B,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 16 décembre 2014,
8) DH C-Holdings, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois des iles Cayman, ayant son siège social

à PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Îles Cayman, enregistrée au Registre des Sociétés sous le
numéro MC-273742,

détentrice d'un million quatre cent sept mille cinq cents (1.407.500) parts sociales de préférence de catégorie C,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
9) 2348614 Ontario Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de l'Etat de l'Ontario, ayant

son siège social au 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario, M2M 4H5, enregistrée auprès du Ministère des Services Gou-
vernementaux de l'Ontario, sous le numéro 002348614,

détentrice de sept cent cinquante-sept mille neuf cent soixante-seize (757.976) parts sociales ordinaires de catégorie

A,

ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
10) Monsieur Cletus von Pichler, résidant au Tizianstr. 129, 80638 Munich, Allemagne,
détenteur de deux mille huit cents (2.800) parts sociales ordinaires de catégorie B,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
11) G. Richard Wagoner Jr. Trust en date du 13/07/1989, tel qu'amendé et réaffirmé le 16/12/2011, représenté par

son fiduciaire, Monsieur G. Richard Wagoner Jr., né le 9 février 1953, résidant au 1155 Quarton Road, Birmingham, MI
48009, USA,

détenteur de cinq mille six cents (5.600) parts sociales ordinaires de catégorie B,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 12 décembre 2014,
12) RBC cees Nominees Limited, une société à responsabilité limitée enregistrée selon les lois de Jersey, ayant son

siège social au 19-21 Broad Street, St Helier, Jersey, Channel islands JE1 3PB, enregistré à la Commission des Services
Financiers de Jersey sous le numéro 83756,

détentrice de vingt-cinq mille quatre cent vingt-six (25.426) parts sociales ordinaires de catégorie A et deux cent trente-

sept mille trois cent quatre-vingt-cinq (237.385) parts sociales ordinaires de catégorie B,

ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 16 décembre 2014,
13) DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., telle que décrite ci-après,

28641

L

U X E M B O U R G

détentrice temporaire de cent trente et une (131) parts sociales ordinaires de catégorie A,
ici représentée par Madame Antje Reibold, prénommée, en vertu d'une procuration donnée le 16 décembre 2014.
Lesdites procurations, paraphées ne varietur par le mandataire des comparantes et par le notaire soussigné resteront

annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Les comparantes sont tous les associés de/et DH Services Luxembourg Holding S.à r.l., une société à responsabilité

limitée soumise aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social de trente-deux mille trois cent quatre
Dollars US et trente-quatre cents (USD$32.304,34), ayant son siège social au 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 166.250, constituée conformément à un acte dressé par Maître Gérard Lecuit, notaire résidant à
Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27 décembre 2011 et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations n° 572 page 27410 le 5 mars 2012 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière
fois par un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant
en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, du 6
octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 3550 page 170392 le 25 novembre 2014.

Les comparantes représentant l'intégralité du capital social déclarent avoir renoncé à toute formalité de convocation,

l'assemblée générale des associés est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points figurant
à l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1) Réduction du capital social de la Société d'un montant d'un Dollar US et trente et un cents (USD$1,31) afin de le

faire  passer  de  son  montant  actuel  de  trente-deux  mille  trois  cent  quatre  Dollars  US  et  trente-quatre  cents  (USD
$32.304,34) à celui de trente-deux mille trois cent trois Dollars US et trois cents (USD$32.303,03) par l'annulation de
cent trente et une (131) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société ayant une valeur nominale de zéro virgule
zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune;

2) Modification consécutive de l'article 5.1 des statuts de la Société de sorte qu'il soit désormais établi comme suit:

« Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social est fixé à trente-deux mille trois cent trois Dollars US et trois cents (USD$32.303,03), représenté

par trois millions deux cent trente mille trois cent trois (3.230.303) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur
nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune, divisé en:

(i) un million cinq cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-huit (1.541.378) parts sociales ordinaires de caté-

gorie A (les “Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD
$0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

(ii) deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent vingt-cinq (281.425) parts sociales ordinaires de catégorie B (les “Parts

Sociales Ordinaires de Catégorie B”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées;

(iii) un million quatre cent sept mille cinq cents (1.407.500) parts sociales de préférence de catégorie C (les “Parts

Sociales de Préférence de Catégorie C”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune
et donnant un accès à la Participation aux Bénéfices tel que définie à l'article 14 ci-dessous, toutes souscrites et entièrement
libérées.»;

3) Divers.
Ensuite, les associés votants ont demandé au notaire d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale des associés décide de réduire le capital social de la Société d'un montant d'un Dollar US et

trente et un cents (USD$1,31) afin de le faire passer de son montant actuel de trente-deux mille trois cent quatre Dollars
US et trente-quatre cents (USD$32.304,34) à celui de trente-deux mille trois cent trois Dollars US et trois cents (USD
$32.303,03) par l'annulation de cent trente et une (131) parts sociales ordinaires de catégorie A de la Société ayant une
valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune, temporairement détenues par la Société suite
au rachat par la Société, le 16 décembre 2014, de cent trente et une (131) parts sociales de catégorie A détenues dans
la Société par RBC cees Nominees Limited.

L'assemblée générale des associés a pris la résolution qui précède avec le nombre de votes précisé ci-après:
- parts sociales ordinaires de catégorie A en faveur: 1.520.242; abstenues: 21.136; contre: 0;
- parts sociales ordinaires de catégorie B en faveur: 67.543; abstenues: 213.882; contre: 0; et
- parts sociales de préférence de catégorie C en faveur: 1.407.500, abstenues: 0, contre: 0.

<i>Seconde résolution

En conséquence de la résolution précédente, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des

statuts de la Société de sorte qu'il soit désormais établi comme suit:

28642

L

U X E M B O U R G

« Art. 5. Capital Social.
5.1. Le capital social est fixé à trente-deux mille trois cent trois Dollars US et trois cents (USD$32.303,03), représenté

par trois millions deux cent trente mille trois cent trois (3.230.303) parts sociales sous forme nominative, d'une valeur
nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune, divisé en:

(i) un million cinq cent quarante et un mille trois cent soixante-dix-huit (1.541.378) parts sociales ordinaires de caté-

gorie A (les “Parts Sociales Ordinaires de Catégorie A”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD
$0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées;

(ii) deux cent quatre-vingt-un mille quatre cent vingt-cinq (281.425) parts sociales ordinaires de catégorie B (les “Parts

Sociales Ordinaires de Catégorie B”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune,
toutes souscrites et entièrement libérées;

(iii) un million quatre cent sept mille cinq cents (1.407.500) parts sociales de préférence de catégorie C (les “Parts

Sociales de Préférence de Catégorie C”), d'une valeur nominale de zéro virgule zéro un Dollars US (USD$0,01) chacune
et donnant un accès à la Participation aux Bénéfices tel que définie à l'article 14 ci-dessous, toutes souscrites et entièrement
libérées.»;

L'assemblée générale des associés a pris la résolution qui précède avec le nombre de votes précisé ci-après:
- parts sociales ordinaires de catégorie A en faveur: 1.520.242; abstenues: 21.136; contre: 0;
- parts sociales ordinaires de catégorie B en faveur: 67.543; abstenues: 213.882; contre: 0; et
- parts sociales de préférence de catégorie C en faveur: 1.407.500, abstenues: 0, contre: 0.

<i>Dépenses

Le montant des dépenses, frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, résultant du présent acte

et incombant à la Société sont estimés à mille cinq cents euros.

Dont acte, fait et passé par le notaire soussigné à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparantes, le présent acte est

rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; sur demande des mêmes comparantes et en cas de divergences
entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte ayant été lu au mandataire des comparantes, dont le nom, le prénom l'état civil et le lieu de résidence sont

connus du notaire soussigné, ledit mandataire des comparantes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18042. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015014955/311.
(150017656) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Creative-Bau S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 14, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 98.122.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015015623/9.
(150018899) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

A.C.I. Armenia S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 174.152.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour A.C.I. Armenia S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015015456/11.
(150019019) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28643

L

U X E M B O U R G

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2550 Luxembourg, 52-54, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 99.799.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A, L.P, a company governed by the laws of Bermudas, having

its registered office at 16, par la Ville Road, batiment Century House, HM08 Hamilton, Bermudas and registered with the
Bermuda register of companies under number 34878,

hereby represented by Mister Gianpiero SADDI, private employee, with professional address at 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal, on 10 

th

 December 2014.

Which proxy, after signature “ne varietur” by the proxy-holder and the undersigned notary will remain attached to

the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated above, declares being the sole shareholder (“Sole Shareholder”) of “Neo-

vara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A S.à r.l.”, a private limited liability company (société à responsabilité
limitée), with registered office at 52-54, avenue du X September, L-2550 Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.-,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number R.C.S Luxembourg B 99799 (the “Com-
pany”), incorporated pursuant to a deed of Maître Blanche Moutrier notary residing in Esch-sur-Alzette, dated March 23,
2004, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on May 13, 2004, number 503, page 24130.

The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notary deed of Maître Paul Decker,

notary residing in Luxembourg, dated March 24, 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
on June 18, 2011, number 1329, page 63781.

All the one hundred (100) shares of the Company with a par value of one hundred twenty-five Euro (EUR 125.-) each,

representing  the  entire  subscribed  capital  of  the  Company  amounting  to  twelve  thousand  five  hundred  Euro  (EUR
12,500.-) are duly represented at the extraordinary general meeting of the Sole Shareholder of the Company (the “Meet-
ing”), which is thus regularly constituted and can validly deliberate on all the items of the agenda. The Sole Shareholder
represented declares that it has had due notice of, and has been duly informed of the agenda prior to the Meeting.

The agenda of the Meeting is the following:
1. Decision to enter the Company into voluntary liquidation;
2. Appointment of Quorum Investments S.à r.l. as liquidator of the Company and determination of its powers;
3. Discharge to the managers of the Company;
4. Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

<i>First resolution

In compliance with the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended, the Sole Shareholder decides

to dissolve the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the above taken resolution, the Sole Shareholder decides to appoint as liquidator:
Quorum Investments S.à r.l., a Luxembourg limited liability company (société à responsabilité limitée) with registered

office at 52-54, avenue du X Septembre L-2550 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies
Register under the number B58442, as Liquidator (the “liquidateur”) of the Company.

The liquidator has the broadest powers as provided for by Articles 144 to 148 bis of the law of August 10 

th

 , 1915

on commercial companies, as amended.

It may accomplish all the acts provided for by Article 145 without requesting the authorisation of the Sole Shareholder

in the cases in which it is requested.

The liquidator is relieved from inventory and may refer to the accounts of the Company.
It may, under its responsibility, for special or specific operations, delegate to one or more proxies such part of its

powers it determines and for the period it will fix.

<i>Third resolution

The Sole Shareholder decides to grant discharge to the managers of the Company and release them from liability in

respect of the execution of their mandate with regards to the period from January 1 

st

 , 2014 to December 17, 2014.

28644

L

U X E M B O U R G

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated at approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states that upon request of the above appearing persons,

this deed is worded in English followed by a French translation and that in case of any divergence between the English
and the French text, the English text shall be prevailing.

Whereof this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.
The document having been read and translated to the appearing persons, the members of the office of the meeting

signed together with us the notary the present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A, L.P., une société de droit des Bermudes, avec siège social

au 16, la Ville Road, bâtiment Century House, HM08 Hamilton, Bermudas et immatriculée auprès du Registre des Com-
pagnies des Bermudes sous le numéro 34878,

ici représentée par Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement au 74, avenue Victor

Hugo, L-1750 Luxembourg, en vertu d’une procuration signée sous seing privée, en date du 10 décembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentant,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l’enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare être l’associé unique («l’Associé Unique») de la société à

responsabilité limitée «Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A S.à.r.l.», avec siège social au 52-54,
avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, avec un capital social de EUR 12.500,- enregistrée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 99799 (la «Société»), constituée suivant acte reçu par
Maître Blanche Moutrier, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, le 23 mars 2004, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations, le 13 mai 2004 sous le numéro 503, page 24130.

Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Decker, notaire de résidence à

Luxembourg, en date du 24 mars 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le 18 juin 2011 sous
le numéro 1329, page 63781.

Toutes les cent (100) parts sociales de la Société ayant une valeur nominale de cent vingt-cinq Euros (125,- EUR)

chacune, représentant la totalité du capital souscrit de la Société d’un montant de douze mille cinq cents Euros (12.500,-
EUR) sont dûment représentées à l’assemblée générale extraordinaire de l’Associé Unique de la Société («l’Assemblée»),
qui est par conséquent valablement constituée et peut délibérer sur les points portés à l’ordre du jour. L’Associé Unique
représenté déclare avoir été dûment convoqué à l’Assemblée et informé de l’ordre du jour.

Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
1. Décision de mettre la Société en liquidation;
2. Nomination de Quorum Investments S.à.r.l. an tant que liquidateurs de la société et détermination de ses pouvoirs;
3. Décharge aux gérants de la Société;
4. Divers.
Suite à cet ordre du jour, les résolutions suivantes ont été prises à l’unanimité:

<i>Première résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée, l’Associé

Unique décide de dissoudre la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution qui précède, l’Associé Unique décide de nommer en qualité de liquidateur:
Quorum Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au

52-54, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 58442.

Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 concernant

les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée.

Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’Associé Unique dans les

cas où elle est requise.

Le liquidateur est dispensé de l’inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.

28645

L

U X E M B O U R G

Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires

telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

<i>Troisième résolution

L’Associé Unique décide de donner décharge pleine et entière aux gérants de la Société, pour l’exécution de leur

mandat pour la période du 1 

er

 janvier 2014 jusqu'au 17 décembre 2014.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais et rémunérations et charges qui pourraient incomber à la Société à la suite du présent acte sont

estimés à environ mille trois cents euros (1.300,- EUR).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare que sur demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande de la comparante et en cas de divergences entre le texte
anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures,

tous ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62828. Reçu douze euros (12.- €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Référence de publication: 2015016005/131.
(150018534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Dreamfactory, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1660 Luxembourg, 30, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 194.022.

STATUTS

L'an deux mille quinze.
Le quinze janvier.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Philippe JOURNO, né le 7 juin 1961 à Tunis (Tunisie), demeurant à F-75006 Paris, 1, rue des Grands

Augustins;

2.- La société à responsabilité limitée de droit français CDP CAPITAL, établie et ayant son siège social à F-75001 Paris,

22, Place Vendôme, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 798 660 981;

3.- Monsieur Nicolas NEBOT, né le 17 novembre 1973 à Paris (France), demeurant à F-75017 Paris, 5, rue Daubigny;
4.- Monsieur Dominique MATTEI, né le 24 novembre 1981 à Marseille (France), demeurant à F-75017 Paris, 81, Avenue

de Ternes.

tous les quatre sont ici représentés par Monsieur Max MAYER, employé privé, demeurant professionnellement à

L-6130 Junglinster, 3, route de Luxembourg, en vertu de quatre (4) procurations sous seing privé lui délivrées.

Lesdites procurations, signées ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent

acte pour être formalisées avec lui.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant de documenter comme suit les statuts d'une société à res-

ponsabilité limitée qu'ils constituent par la présente:

Titre I 

er

 . - Objet - Raison sociale - Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront

le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents
statuts.

Art. 2. La société a pour objet toutes prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises

luxembourgeoises ou étrangères, la gestion ainsi que la mise en valeur de ces participations.

28646

L

U X E M B O U R G

La société a encore pour objet de toucher des indemnités et des rémunérations en tant qu’administrateur de sociétés

du groupe ainsi que l’administration et la gérance de telles sociétés du groupe, à qui elle pourra notamment fournir toute
prestation d’assistance stratégique, administrative ou commerciale.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières, industrielles, ou commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également réaliser toutes
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, l’exploitation et la gestion d'immeubles, à l’exclusion des activités
spécialement réglementées d’agent immobilier, de promoteur immobilier, et d’administrateur de biens - syndic de co-
propriété.

La société pourra aussi acquérir et mettre en valeur tous brevets, marques de fabrique et autres droits intellectuels

et immatériels ainsi que tous autres droits s’y rattachant ou pouvant les compléter.

D'une manière générale, elle pourra prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et exécuter toutes opé-

rations qu'elle jugera utiles pour l’accomplissement et le développement de son objet.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La société prend la dénomination de DREAMFACTORY.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
La société peut ouvrir des succursales au Luxembourg ou dans d'autres pays.
Le siège pourra être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés.

Titre II. - Capital social - Parts sociales

Art. 6. Le capital social est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR), représenté par cent (100) parts sociales de trois

cents euros (300,- EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu’un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, la société est une

société unipersonnelle au sens de l’article 179 (2) de la loi modifiée sur les sociétés commerciales; dans cette éventualité,
les articles 200-1 et 200-2, entre autres, de la même loi sont d’application, c’est-à-dire chaque décision de l’associé unique
ainsi que chaque contrat entre celui-ci et la société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées
générales des associés ne sont pas applicables.

La société peut acquérir ses propres parts à condition qu’elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l’accord unanime

de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption.
Ils doivent l’exercer endéans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé.
En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions

des alinéas 6 et 7 de l’article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

Art. 9. Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer

des scellés sur les biens et documents de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration;
pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la société.

Titre III. - Administration et gérance

Art. 10. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment

par l’assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

Art. 11. Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre des parts qui lui appartiennent;

chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède. Chaque associé peut se faire vala-
blement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir les voix des associés représentant

les trois quarts (3/4) du capital social.

Art. 13. Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l’assemblée

générale sont exercés par l’associé unique.

Les décisions prises par l’associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par

écrit.

De même, les contrats conclus entre l’associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-

verbal ou établies par écrit.

28647

L

U X E M B O U R G

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 14. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de
l’exécution de leur mandat.

Art. 15. Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des

associés.

Art. 16. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre.

Titre IV. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. Lors de la dissolution de la société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par les associés, qui en fixeront les pouvoirs et émoluments.

Titre V. - Dispositions générales

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales.

<i>Disposition transitoire

Par dérogation, le premier exercice commence aujourd'hui et finira le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et libération

Toutes les parts sociales ont été souscrites par:

1.- Monsieur Philippe JOURNO, prédésigné, trente parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

2.- La société CDP CAPITAL, prédésignée, vingt parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

3.- Monsieur Nicolas NEBOT, prédésigné, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

4.- Monsieur Dominique MATTEI, prédésigné, vingt-cinq parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Total: cent parts sociales, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Toutes les parts sociales ont été libérées intégralement en numéraire de sorte que la somme de trente mille euros

(30.000,- EUR), se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instru-
mentaire qui le constate expressément.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s’élève à environ 1.350,- EUR..

<i>Assemblée générale extraordinaire

Les comparants préqualifiés, représentant la totalité du capital souscrit, se considérant comme dûment convoqués, se

sont ensuite constitués en assemblée générale extraordinaire.

Après avoir constaté que la présente assemblée est régulièrement constituée, ils ont pris à l’unanimité les résolutions

suivantes:

1.- Le siège social est établi à L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.
2.- Sont nommés gérants de la société:
a) Monsieur Raphaël MARTIN, né le 30 avril 1961 à Compiègne (France), demeurant à F-60410 Saintines, 537, rue

Edouard Collas;

b) Monsieur Christophe ANTINORI, né le 8 septembre 1971 à Woippy (France), demeurant professionnellement à

L-1660 Luxembourg, 30, Grand-Rue.

3.- La société est valablement engagée par la signature conjointe des deux gérants.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité, connu du notaire par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 20 janvier 2015. Relation GAC/2015/618. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015015707/130.
(150018931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

28648

L

U X E M B O U R G

UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 43, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 193.947.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fifteenth of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary public residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Ares European Real Estate Fund IV, L.P., a limited partnership existing under the laws of Delaware, with registered

office at 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, United States, registered with the Trade Register of
Delaware under number 5362677.

here represented by Mr. Liridon ELSHANI, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

proxy given under private seal on 11 

th

 of December 2014 and a power of substitution given to him on 12 

th

 of December

2014.

The beforesaid proxy, being initialled “ne varietur” by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain

annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such party has requested the notary to draw up the following by-laws of a “société à responsabilité limitée” (limited

liability partnership company), which it declares to incorporate.

Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. There is hereby formed a “société à responsabilité limitée”, limited liability company, governed by the present

articles of incorporation and by current Luxembourg laws, especially the laws of August 10 

th

 , 1915 on commercial

companies, of September 18 

th

 , 1933 and of December 28 

th

 , 1992 on "sociétés à responsabilité limitée", as amended,

and the present articles of incorporation.

At any moment, a sole shareholder may join with one or more joint shareholders and, in the same way, the following

shareholders may adopt the appropriate measures to restore the unipersonal character of the Company. As long as the
Company remains with one sole shareholder, he exercises the powers devolved to the General Meeting of shareholders.

Art. 2. The Company's name is "UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.".

Art. 3. The Company's purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial,

industrial, financial or other, Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities and rights through participation,
contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire patents and
licences, and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage,
develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in
particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial,
commercial and other transactions, and to grant to any holding company, subsidiary, or fellow subsidiary, or any other
company associated in any way with the Company, or the said holding company, subsidiary or fellow subsidiary, in which
the Company has a direct or indirect financial interest, any assistance, loans, advances or guarantees; to borrow and raise
money in any manner and to secure the repayment of any money borrowed; finally to perform any operation which is
directly or indirectly related to its purpose.

The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all

areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

Art. 4. The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the board of managers.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
In the event that the management should determine that extraordinary political, economic or social developments

have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have
no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will
remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the
management of the Company.

Art. 5. The Company is constituted for an unlimited duration.

28649

L

U X E M B O U R G

Art. 6. The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency

of any shareholder.

Art. 7. The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in circumstances,

to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration
of the Company. They must for the exercise of their rights refer to financial statements and to the decisions of the
meetings.

Capital - Shares

Art. 8. The Company's capital is set at GBP 12,500 (twelve thousand five hundred pounds sterling), represented by

12,500 (twelve thousand five hundred) shares of GBP 1 (one pound sterling) each.

Art. 9. Each share confers an identical voting right at the time of decisions taking.

Art. 10. The shares are freely transferable among the shareholders.
Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless members representing at least three-quarter of

the corporate capital shall have agreed thereto in a general meeting.

Otherwise it is referred to the provisions of articles 189 and 190 of the co-ordinate law on trading companies.
The shares are indivisible with regard to the Company, which admit only one owner for each of them.

Management

Art. 11. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they will

constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The managers may be removed at any time,
with or without cause, by a resolution of shareholders holding a majority of votes.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances

and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of
this article shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within

the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its single manager, and, in case of plurality of managers, by the

single signature of any of the members of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may sub-delegate his powers for specific tasks

to one several ad hoc agents.

The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will determine this agent's responsibilities and

remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In case of plurality of managers, boards of managers will be validly held provided that the majority of managers be

present.

In this case, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or

represented.

The board meetings should be held in Luxembourg. In extraordinary circumstances and if necessary the use of video-

conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating member of the Board of
Managers is able to hear and to be heard by all other participating members whether or not using this technology, and
each participating member of the Board of Managers shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by
video or by phone.

The powers and remunerations of any managers possibly appointed at a later date in addition to or in the place of the

first managers will be determined in the act of nomination.

Art. 12. Any manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly

taken by him in the name of the Company; as a mandatory he is only responsible for the execution of his mandate.

The company shall indemnify any manager and his heirs, executors and administrators, against expenses, damages,

compensation and costs reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may
be made a party by reason of his being or having been a manager of the Company, or, at the request of the Company, of
any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which he is not entitled to be indemnified,
except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for
gross negligence or misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with
such matters covered by the settlement, and only to the extend the Company is advised by its legal counsel that the
person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude
other rights to which he may be entitled.

Art. 13. Managers decisions are taken by meeting of the board of managers.
Any manager may act at any meeting of managers by appointing in writing or by telefax, cable, telegram or telex another

manager as his proxy.

28650

L

U X E M B O U R G

Resolutions in writing approved and signed by all managers shall have the same effect as resolutions passed at the

managers' meeting.

In such cases, resolutions or decisions shall be expressly taken, either formulated by writing by circular way, transmitted

by ordinary mail, electronic mail or telecopier, or by phone, teleconferencing or other telecommunications media.

Shareholders decisions

Art. 14. Shareholders decisions are taken by shareholder's meetings.
However, the holding of meeting is not compulsory as long as the shareholders number is less than twenty-five.
In such case, the management can decide that each shareholder shall receive the whole text of each resolution or

decisions to be taken, expressly drawn up by writing, transmitted by ordinary mail, electronic mail or telecopier.

Art. 15. Resolutions are validly adopted when taken by shareholders representing more than half of the capital.
If this quorum is not attained at a first meeting, the shareholders are immediately convened by registered letters to a

second meeting.

At this second meeting, decisions will be taken at the majority of voting shareholders whatever majority of capital be

represented.

However, decisions concerning an amendment of the articles of association must be taken by a majority vote of

shareholders representing the three quarters of the capital.

Every meeting shall be held in Luxembourg or such other place as the managers may from time to time determine.
A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the dispositions of Section

XII of the law of August 10 

th

 , 1915 on sociétés à responsabilité limitée.

As a consequence thereof, all decisions which exceed the powers of the managers are taken by the sole shareholder.

Financial year - Balance sheet

Art. 16. The Company's financial year begins on January 1 

st

 and closes on December 31 

st

 .

Art. 17. Each year, as of the 31 

st

 of December, the management will draw up the balance sheet which will contain a

record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing
a summary of all its commitments and the debts of the manager(s) toward the company.

At the same time, the management will prepare a profit and loss account which will be submitted to the general meeting

of shareholders together with the balance sheet.

Art. 18. Each shareholder may inspect at the head office the inventory, the balance sheet and the profit and loss account.

Art. 19. The credit balance of the profit and loss ac-count, after deduction of the expenses, costs, amortisation, charges

and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.
This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to one tenth of the issued capital but

must be resumed till the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has been
broken into.

The balance is at the disposal of the shareholders.
The shareholders may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the managers

showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not
exceed realised profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves,
but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles
of incorporation.

The excess is distributed among the shareholders. However, the shareholders may decide, at the majority vote de-

termined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried
forward or transferred to an extraordinary reserve.

Winding-up - Liquidation

Art. 20. The liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the

general meeting of shareholders which will specify their powers and fix their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholders at

the pro-rata of their participation in the share capital of the company.

A sole shareholder can decide to dissolve the Company and to proceed to its liquidation, assuming personally the

payment of all the assets and liabilities, known or unknown of the Company.

28651

L

U X E M B O U R G

Applicable law

Art. 21. The laws here above mentioned in article 1 

st

 shall apply in so far as these Articles of Incorporation do not

provide for the contrary.

<i>Transitory measures

Exceptionally the first financial year shall begin today and end on December 31, 2015.

<i>Subscription - Payment

All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares representing the capital have been entirely subscribed by Ares

European Real Estate Fund IV, L.P., prenamed, and fully paid up in cash, therefore the amount of GBP 12,500 (twelve
thousand five hundred pounds sterling) is as now at the disposal of the Company UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.,
proof of which has been duly given to the notary.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand four hundred euro (EUR
1,400.-).

The  amount  of  GBP  12,500  (twelve  thousand  five  hundred  pounds  sterling)  corresponds  to  the  amount  of  EUR

15,720.50 (fifteen thousand seven hundred twenty Euro and fifty cent) according to the exchange rate published on
XE.COM on December 15 

th

 , 2014.

<i>General meeting

Immediately after the incorporation of the Company, the abovenamed person, representing the entirety of the sub-

scribed capital and exercising the powers devolved to the meeting, passed the following resolutions:

1) Are appointed as managers for an undetermined duration

- Mrs Anne Delord with professional address at 43 Avenue J-F Kennedy 3 

rd

 Floor, L-1855 Luxembourg

- Mrs Priscille Fourneaux with professional address at 43 Avenue JF Kennedy 3 

rd

 Floor, L-1855 Luxembourg

- Mr Luke Hamill with professional address at 10, New Burlington Street, 6 

th

 floor, W1S 3BE London, United Kingdom

In accordance with article eleven of the by-laws, the company shall be bound by the sole signature of its single manager,

and, in case of plurality of managers, by the sole signature of any of the members of the board of managers.

2) The Company shall have its registered office at L-1855 Luxembourg, 43 Avenue J-F Kennedy 3 

rd

 Floor.

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the above appearing

person, the present incorporation deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

In faith of which we, the undersigned notary have set hand and seal in Luxembourg-City, on the day named at the

beginning of this document.

The document having been read to the proxy holder, said person signed with us, the Notary, the present original deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le quinze décembre.
Par devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, soussigné.

Comparaît:

Ares European Real Estate Fund IV, L.P., une société en commandite régie par le droit de Delaware, et ayant son siège

social au 2711, Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, Etats-Unis d'Amérique, immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés du Delaware sous le numéro 5362677,

ici représentée par Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement à Luxembourg, en

vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée le 11 décembre 2014 et en vertu d'un pouvoir de substitution lui
accordé le 12 décembre 2014.

Ladite procuration, paraphée «ne varietur» par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au président

acte pour être formalisée avec lui.

Lequel a requis le notaire instrumentant de dresser acte des statuts d'une société à responsabilité limitée qu'il a arrêté

comme suit.

28652

L

U X E M B O U R G

Dénomination - Siège - Objet - Durée.

Art. 1 

er

 .  Il est constitué par cet acte une société à responsabilité limitée, régie par les présents statuts et par les lois

luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18
septembre 1933 sur les sociétés à responsabilité limitée et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée,
telles que modifiées, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, un associé unique peut s'associer à un ou plusieurs partenaires et, de la même manière, les associés

ultérieurs peuvent prendre toutes mesures appropriées pour restaurer le caractère unipersonnel de la société. Aussi
longtemps que la Société demeure avec un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs attribués à l'Assemblée Générale
des associés.

Art. 2. La dénomination de la société sera "UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.".

Art. 3. L'objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce soit, dans

toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et
d'acquérir par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation ou de
toute autre manière tous titres et droits, tous brevets et licences, et autres propriétés, droits et intérêts de propriété
que la Société jugera approprié, et plus généralement les détenir, gérer, développer, les vendre ou en disposer, en tout
ou partie, aux conditions que la Société jugera appropriées, et en particulier en contrepartie d'actions ou de titres de
toute société les acquérant; de prendre part, d'assister ou de participer à des transactions financières, commerciales ou
autres, et d'octroyer à toute société holding, filiale ou filiale apparentée, ou toute autre société liée d'une manière ou
d'une autre à la Société ou aux dites holdings, filiales ou filiales apparentées dans lesquelles la Société a un intérêt financier
direct ou indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties; d'emprunter et de lever des fonds de quelque manière que
ce soit et de garantir le remboursement de toute somme empruntée; enfin de mener à bien toutes opérations généra-
lement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte

avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l'accomplissement de son objet.

Art. 4. Le siège social est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision modificatrice des statuts. Le

siège social pourra être transféré dans la commune par décision de la gérance.

La Société pourra ouvrir des bureaux ou succursales, au Luxembourg et à l'étranger.
Au cas où la gérance estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature

à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert
du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par la gérance.

Art. 5. La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Art. 7. Les créanciers, représentants, ayants-droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce

soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les
actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux
décisions des assemblées.

Capital - Parts sociales

Art. 8. Le capital social est fixé à GBP 12,500 (douze mille cinq cents livres sterling), représenté par 12,500 (douze

mille cinq cents) parts sociales de GBP 1 (une livre sterling) chacune.

Art. 9. Chaque part sociale confère un droit de vote identique lors de la prise de décisions.

Art. 10. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Aucune cession de parts sociales entre vifs à un tiers non-associé ne peut être effectuée qu'avec l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.
Les parts sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elle.

Gérance

Art. 11. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent un conseil

de gérance. Le(s) gérant(s) ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants peuvent être révoqués à tout moment, avec
ou sans justification, par une résolution des associés titulaires de la majorité des votes.

28653

L

U X E M B O U R G

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) a(ont) tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer

et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et pourvu que les termes du présent article aient
été respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les Statuts seront de

la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, détermine les responsabilités et la rémunération

(s'il y en a) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

En cas de pluralité de gérants, les réunions du conseil de gérance se tiendront valablement si la majorité des gérants

sont présents.

Dans ce cas, les résolutions du conseil de gérance sont adoptées à la majorité des gérants présents ou représentés.
Les conseils de gérance se tiendront à Luxembourg. En cas de circonstances extraordinaires l'utilisation de la vidéo

conférence et de conférence téléphonique est autorisée si chaque participant est en mesure d'entendre et d'être entendu
par tous les membres du Conseil de Gérance participants, utilisant ou non ce type de technologie. Ledit participant sera
réputé présent à la réunion et sera habilité à prendre part au vote via téléphone ou la vidéo.

Les pouvoirs et rémunérations des gérants éventuellement nommés postérieurement en sus ou en remplacement des

premiers gérants seront déterminés dans l'acte de nomination.

Art. 12. Un gérant ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

La Société indemnisera tout gérant et leurs héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs de biens pour tous

frais, dommages, coûts et indemnités raisonnables qu'ils auront encourus par suite de leur comparution en tant que
défendeurs dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires qui leur auront été intentés de par leurs
fonctions actuelles ou anciennes de gérants, ou à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société
est actionnaire ou créancier et que de ce fait ils n'ont pas droit à indemnisation, exception faite pour les cas où ils auraient
été déclarés coupables pour négligence grave ou pour avoir manqué à leurs devoirs envers la Société; en cas d'arrangement
transactionnel, l'indemnisation ne portera que sur les matières couvertes par l'arrangement transactionnel et dans le cas
où la Société serait informée par son conseiller juridique que la personne à indemniser n'aura pas manqué à ses devoirs
envers la Société. Le droit à indemnisation qui précède n'exclut pas pour les personnes susnommées d'autres droits
auxquels elles pourraient prétendre.

Art. 13. Les décisions des gérants sont prises en réunions du conseil de gérance.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit ou par téléfax, cable,

télégramme ou télex un autre gérant pour le représenter.

Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision

prise à une réunion du conseil de gérance.

Dans ces cas, les résolutions ou décisions à prendre seront expressément prises, soit formulées par écrit par voie

circulaire, par courrier ordinaire, électronique ou télécopie, soit par téléphone, téléconférence ou autre moyen de té-
lécommunication.

Décisions des associés

Art. 14. Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Toutefois, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, tant que le nombre des associés est inférieur à vingt-

cinq.

Dans ce cas, chaque associé recevra le texte complet de chaque résolution ou décision à prendre, expressément

formulées et émettra son vote par écrit, transmis par courrier ordinaire, électronique ou télécopie.

Art. 15. Les résolutions ne sont valablement adoptées que pour autant qu'elles soient prises par les associés repré-

sentant plus de la moitié du capital social.

Si ce quorum n'est pas atteint lors de la première assemblée, une seconde assemblée sera immédiatement convoquée

par lettre recommandée.

Lors de cette deuxième assemblée, les résolutions seront adoptées à la majorité des associés votant quelle que soit

la portion du capital représenté.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Toute assemblée se tiendra à Luxembourg ou à tout autre endroit que la gérance déterminera.

28654

L

U X E M B O U R G

Un associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés par les dispositions de la section

XII de la loi du 10 août 1915 relatives aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l'associé unique.

Exercice social - Comptes annuels

Art. 16. L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 17. Chaque année, avec effet au 31 décembre, la gérance établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de

la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi
que les dettes des gérants et associés envers la société.

Au même moment la gérance préparera un compte de profits et pertes qui sera soumis à l'assemblée ensemble avec

le bilan.

Art. 18. Tout associé peut prendre communication au siège social de la Société de l'inventaire, du bilan et du compte

de profits et pertes.

Art. 19. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et

provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.
Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint un dixième du capital social, mais

devront être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de
réserve se trouve entamé.

Le solde est à la disposition des associés.
Les associés peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes sur base d'un état comptable préparé par les

gérants duquel il ressort que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que les fonds à dis-
tribuer ne peuvent pas excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice fiscal augmenté des bénéfices
reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à porter en réserve en vertu
d'une obligation légale ou statutaire.

Le solde du bénéfice net est distribué entre les associés. Néanmoins, les associés peuvent, à la majorité prévue par la

loi, décider qu'après déduction de la réserve légale et des dividendes intérimaire le cas échéant, le bénéfice sera reporté
à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Dissolution - Liquidation

Art. 20. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs,

personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés au pro rata de leur participation dans le

capital de la Société.

Un associé unique peut décider de dissoudre la Société et de procéder à sa liquidation en prenant personnellement à

sa charge tous les actifs et passifs, connus et inconnus, de la Société.

Loi applicable

Art. 21. Les lois mentionnées à l'article 1 

er

 , ainsi que leurs modifications ultérieures, trouveront leur application

partout où il n'est pas dérogé par les présents statuts.

<i>Disposition transitoire

Exceptionnellement le premier exercice commencera le jour de la constitution pour finir le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Les 12,500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social ont toutes été souscrites

par Ares European Real Estate Fund IV, L.P., prénommé, et ont été intégralement libérées par des versements en numé-
raire, de sorte que la somme de GBP 12,500 (douze mille cinq cents livres sterling) se trouve dès maintenant à la disposition
de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille quatre cents euros (EUR 1.400,-).

La somme de GBP 12.500 (douze mille cinq cents Livres Sterling) correspond à la somme de EUR 15.720,50 (quinze

mille sept cents vingt Euros et cinquante Euro cent), conformément au cours d'échange publié au XE.COM le 15 décembre
2014.

28655

L

U X E M B O U R G

<i>Assemblée générale

Immédiatement après la constitution de la Société, le comparant précité, représentant la totalité du capital social,

exerçant les pouvoirs de l'assemblée, a pris les résolutions suivantes:

1) Sont nommés gérants pour une durée indéterminée
- Madame Anne Delord avec adresse professionnelle au 43, avenue J-F Kennedy, 3 

ème

 étage, L-1855 Luxembourg

- Madame Priscille Fourneaux avec adresse professionnelle au 43, avenue J-F Kennedy, 3 

ème

 étage, L-1855 Luxembourg

- Monsieur Luke Hamill, avec adresse professionnelle au 10, New Burlington Street, 6 

ème

 étage, W1S 3BE Londres,

Royaume-Uni

Conformément à l'article onze des statuts, la Société se trouvera engagée par la seule signature du gérant unique, et,

en cas de pluralité de gérants, par la signature individuelle de chacun des membres du conseil de gérance.

2) Le siège social de la Société est établi à L-1855 Luxembourg, 43 avenue J-F Kennedy, 3 

ème

 étage.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais constate par le présent qu'à la requête de la personne comparante

les présents statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, il a signé avec nous notaire la présente minute.
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62784. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014706/391.
(150016845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Charax Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 18, rue Robert Stumper.

R.C.S. Luxembourg B 136.979.

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

CHARAX INVEST SA

Référence de publication: 2015015647/11.
(150018599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 janvier 2015.

Tallus S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1630 Luxembourg, 56, rue Glesener.

R.C.S. Luxembourg B 181.808.

<i>Extrait du conseil d'administration du 27 janvier 2015 tenu au siège de la Société

Par la présente, le conseil d'administration décide de nommer comme dépositaire des parts au porteur de la société,

Fisconsult s.a., fiduciaire et cabinet d'expert-comptable ayant son siège social au 56, rue Glesener L-1630 Luxembourg,
avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015015375/14.
(150017753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

28656


Document Outline

A.C.I. Aeronautical S.à r.l.

A.C.I. Agro S.à r.l.

A.C.I. Armenia S.à r.l.

Cascade Hotel S.à.r.l.

Cascade Hotel S.à.r.l.

Cascade Hotel S.à.r.l.

Cascade Hotel S.à.r.l.

Cascade Hotel S.à.r.l.

Charax Invest S.A.

Charax Invest S.A.

CityKids S.à r.l.

CKT s.à r.l.

Com Event More S.à r.l.

Compagnie Mobilière, Financière de Participations S.A.

Corporate Sailing S.à.r.l.

Creative-Bau S.A.

DB Value S.à r.l.

Demy Pub S.à r.l.

Den Holzmëchel S.à r.l.

Denmarc S.à r.l.

DH Services Luxembourg Holding S.à r.l.

Digital Services XXXIX Top-Holding S.C.Sp.

Dreamfactory

EIF Soparfi A S.à r.l.

Evoleco

Fidelity International Real Estate Fund Company 14

Global Finance Invest S.A.

Goodman Melanite Logistics (Lux) S.à r.l.

ICG Luxembourg Joint Venture S.à r.l

Infrastructure PPP Africa Management S.A.

Intercapital S.à r.l.

Investor Services House S.A.

Kapets S.A.

Neovara European Mezzanine Leveraged Partners 2003-A S.à r.l.

Patron GP IV S.à r.l.

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l.

RK Steng - A Verbotzarbechten s.à.r.l.

Romaka

ROMAKA, société à responsabilité limitée &amp; Cie

Steinmetzdemeyer

Tallus S.A.

Thalos Investment Platform S.A.

UK Regional Portfolio Holdings S.à r.l.

Vanille S.à.r.l.