This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 571
2 mars 2015
SOMMAIRE
Alonely S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27394
Barraud Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
27365
Ciresia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27366
Clamans Counselling S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
27366
Constructions & Management Paul S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27362
COSOS (Complete Solutions & Services)
S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27362
Craftwave S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27363
CRC CF (LUX) S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27362
Creatherm SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27362
CTL Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27363
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l. . . . . .
27363
CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l. . . . . . .
27364
Daobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27363
Degomex Holding Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
27364
Den Daimerléck, S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
27363
Diacine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27369
Diani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27396
Domco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27364
Dry Mix Solutions Holdings S.à r.l. . . . . . . .
27362
Elimmo S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27366
Entreprise de Peinture Jean-Pierre Wer-
sant & Fils s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27364
Field Investment S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27364
H3 Brand S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27365
Hendrickx Dries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27365
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl . . . . . . . . . .
27393
HPF Holding S.A. - SPF . . . . . . . . . . . . . . . . .
27365
Hydraganymed S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27393
Ilidor S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27367
ILP Acquisitions S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
27381
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27408
Kahala LuxCo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27365
LCN IPPT 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27365
Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27381
Mabledon Holdings UK S.à r.l. . . . . . . . . . . .
27388
Mangaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27372
MAXimmo, s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27408
Midarex S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27366
Mores Pierre S.à r.l. entreprise de cons-
tructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27408
PH International Holdings I S.à r.l. . . . . . . .
27376
Rodange Investments S.A. . . . . . . . . . . . . . .
27368
RPTRE I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27394
Soclair Equipements S.A. . . . . . . . . . . . . . . .
27367
SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l. . . . . . . . . .
27397
Square 41 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27394
Structured Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27367
Visitation S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27375
27361
L
U X E M B O U R G
Constructions & Management Paul S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7303 Steinsel, 44, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 109.296.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014167/10.
(150016998) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
COSOS (Complete Solutions & Services) S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Siège social: L-3651 Kayl, 48, rue Joseph Müller.
R.C.S. Luxembourg B 142.963.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014168/10.
(150017280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
CRC CF (LUX) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 193.317.
L'adresse professionnelle de Madame Nicole RIKER, gérante de la Société, est désormais située au 1, Skyline Road,
Smiths, GB - BER - FL 08 (Bermudes).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015014170/11.
(150016674) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Creatherm SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9412 Viande, 12, rue de la Frontière.
R.C.S. Luxembourg B 175.591.
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Unterschrift.
Référence de publication: 2015014171/11.
(150016666) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Dry Mix Solutions Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 185.612.
Les statuts coordonnés au 08/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/01/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015014187/12.
(150017099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27362
L
U X E M B O U R G
Craftwave S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5627 Mondorf-les-Bains, 13, avenue Lou Hemmer.
R.C.S. Luxembourg B 175.471.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014169/10.
(150017236) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Den Daimerléck, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8383 Koerich, 21B, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 50.115.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014180/10.
(150016895) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
CTL Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 178.324.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 27 janvier 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015014175/11.
(150016745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 180.307.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 octobre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2015014177/11.
(150016541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Daobo, Société Anonyme.
Siège social: L-1258 Luxembourg, 16, rue Jean-Pierre Brasseur.
R.C.S. Luxembourg B 183.988.
Les statuts coordonnés au 15/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27/01/2015.
Me Cosita Delvaux
<i>Notairei>
Référence de publication: 2015014189/12.
(150016617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27363
L
U X E M B O U R G
Field Investment S.A., Société à responsabilité limitée soparfi.
Siège social: L-4963 Clémency, 9bis, rue Basse.
R.C.S. Luxembourg B 168.082.
Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Clémency, le 27 janvier 2015.
Référence de publication: 2015014254/10.
(150016984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Entreprise de Peinture Jean-Pierre Wersant & Fils s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8805 Rambrouch, 25, rue Principale.
R.C.S. Luxembourg B 96.963.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014218/10.
(150016900) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.
R.C.S. Luxembourg B 180.321.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 22 octobre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 24 novembre 2014.
Référence de publication: 2015014178/11.
(150016542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Degomex Holding Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 149.577.
L'adresse professionnelle de Monsieur Ricardo RODRIGUEZ, gérant de classe A de la Société, est désormais située
au 785, Admiralty Parade, Naples, Florida, 34102 (États-Unis d'Amérique).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015014179/11.
(150017074) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Domco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1445 Strassen, 3, rue Thomas Edison.
R.C.S. Luxembourg B 33.769.
Les Comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Strassen, le 27/01/2015.
<i>Pour DOMCO S.à r.l.
i>J. REUTER
Référence de publication: 2015014200/12.
(150016873) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27364
L
U X E M B O U R G
LCN IPPT 1, Société à responsabilité limitée,
(anc. Barraud Investments S.à r.l.).
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 176.256.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015014424/9.
(150016747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
H3 Brand S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 70.000,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 156.477.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Référence de publication: 2015015069/10.
(150017492) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
HPF Holding S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-2121 Luxembourg, 231, Val des Bons-Malades.
R.C.S. Luxembourg B 172.835.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 janvier 2015.
SG AUDIT SARL
Référence de publication: 2015015067/11.
(150018067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Kahala LuxCo, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 186.962.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Junglinster, le 28 janvier 2015.
Pour copie conforme
Référence de publication: 2015015121/11.
(150017984) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Hendrickx Dries S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.400,00.
Siège social: L-7220 Walferdange, 133, route de Diekirch.
R.C.S. Luxembourg B 181.437.
Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2013 de la société ont été déposés au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Walferdange.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015015063/12.
(150018017) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
27365
L
U X E M B O U R G
Elimmo S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1118 Luxembourg, 14, rue Aldringen.
R.C.S. Luxembourg B 72.870.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015014231/9.
(150017316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Clamans Counselling S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 5, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 177.096.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014162/10.
(150016999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Ciresia, Société Anonyme.
Siège social: L-1836 Luxembourg, 23, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 150.688.
La version abrégée des comptes annuels au 31 décembre 2013 a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Dandois & Meynial
Référence de publication: 2015014161/11.
(150016622) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Midarex S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 83.043.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 26 janvier 2015 que Monsieur Reno Maurizio TONELLI a démissionné
de son mandat d'administrateur et Président du Conseil d'Administration de la société MIDAREX S.A., inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83 043, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 26 janvier 2015 que Monsieur Thierry FLEMING a démissionné de son
mandat d'administrateur de la société MIDAREX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro
B 83 043, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 26 janvier 2015 que Monsieur Pierre LENTZ a démissionné de son mandat
d'administrateur et de la société MIDAREX S.A., inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 83
043, avec effet immédiat.
Il résulte d'une lettre de démission datée du 26 janvier 2015 que la société anonyme AUDIEX S.A. a démissionné de
son mandat de commissaire aux comptes de la société MIDAREX S.A. inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
sous le numéro B 83 043, avec effet immédiat.
Luxembourg, le 26 janvier 2015.
CF Corporate Services
Société Anonyme
2, avenue Charles de Gaulle
L - 1653 Luxembourg
Référence de publication: 2015014469/24.
(150016919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27366
L
U X E M B O U R G
Ilidor S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.
R.C.S. Luxembourg B 127.591.
Les comptes annuels de la société au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015015083/12.
(150018035) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Structured Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 150.669.
Die Bilanz zum 30. September 2014 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September 2014 abgelaufene
Geschäftsjahr wurden beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Munsbach, den 28. Januar 2015.
<i>Für Structured Solutions
i>Die Zentralverwaltungsstelle:
Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
Référence de publication: 2015015325/14.
(150017720) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Soclair Equipements S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1852 Luxembourg, 7, rue Kalchesbrück.
R.C.S. Luxembourg B 17.638.
EXTRAIT
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 19 juin 2013
que:
- Les mandats des administrateurs suivants étant arrivés à échéance, l'Assemblée décide de réélire aux fonctions
d'administrateur:
* Monsieur Max Kayser pour un mandat d'une durée de cinq ans
* Monsieur Edouard Kayser pour un mandat d'une durée de cinq ans
Il résulte des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires tenue en date du 2 juin 2014
que:
- Le mandat de l'administrateur suivant étant arrivé à échéance, l'Assemblée décide de réélire aux fonctions d'admi-
nistrateur:
* Monsieur Jean Welbes pour un mandat d'une durée de cinq ans
- Le mandat de Réviseur d'entreprises agréé de la société FIDUCIAIRE JOSEPH TREIS S. A R.L., ayant son siège social
au 57, Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, a été révoqué;
- La société LUXEMBOURGEOISE D'AUDIT ET DE REVISION S.A R.L., ayant son siège social au 29, boulevard du
Prince Henri, L-1724 Luxembourg, a été nommée aux fonctions de Commissaire aux comptes de la société pour un
mandat d'une durée d'un an
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 janvier 2015.
<i>Pour la Société
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015014648/28.
(150017080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27367
L
U X E M B O U R G
Rodange Investments S.A., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 31.000,00.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 91.570.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
L'AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE VINGT-DEUX DECEMBRE.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Se réunit
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RODANGE INVESTMENTS S.A.»,
société en liquidation (la Société), ayant son siège social à 18, rue Michel Rodange, L-2430 Luxembourg, inscrite au Registre
de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 91570, constituée sous la dénomination de «EDEN
INVESTMENTS S.A.» suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire alors de résidence à Mersch, en date du
22 janvier 2003, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 277 du 14 mars 2003. Les statuts
ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg,
en date du 30 novembre 2011, publié au Mémorial C numéro 268 du 1
er
février 2012.
L'assemblée est présidée par Mademoiselle Jennifer BOUVARD, employée, demeurant professionnellement à Luxem-
bourg.
Le président désigne comme secrétaire Monsieur Benoit TASSIGNY, demeurant professionnellement à Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutateur Mademoiselle Sabrina CHARNY, employée, demeurant professionnellement à
Luxembourg.
Le président prie le notaire d'acter que:
I. La société a été mise en liquidation suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 2 décembre 2014, en
cours de publication au Mémorial Recueil des Sociétés et Associations.
II.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de
présence, qui sera signée, ci-annexée ainsi que les procurations, le tout enregistré avec l'acte.
III.- Qu'il ressort de la liste de présence que les trente-et-une (31) actions, représentant l'intégralité du capital social
sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.
IV.- Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jour:i>
1) Présentation du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge à donner au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Prononciation de la clôture de la liquidation.
4) Indication de l'endroit où les livres et documents de la société devront être déposés et conservés pendant cinq ans
à partir du jour de la liquidation.
5) Divers.
V.- Qu'en conséquence la présente assemblée, réunissant plus de la moitié du capital social, est régulièrement consti-
tuée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.
Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'admi-
nistration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.
L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, la résolution suivante:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée entend le rapport de EP International, une société avec siège social au 20, rue Michel Rodange, à L-2430
Luxembourg, sur l'examen des documents de la liquidation et sur la gestion du liquidateur.
Ce rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et à la décharge du liquidateur.
<i>Deuxième résolutioni>
Adoptant les conclusions de ce rapport, l'assemblée approuve les comptes de liquidation et donne décharge pleine et
entière, sans réserve ni restriction, au liquidateur de la société, à savoir Monsieur Roger GREDEN, né le 10 octobre 1953
à Arlon, demeurant à 4A rue de l'Ouest L-2273 Luxembourg, de sa gestion de liquidateur de la société.
L'assemblée donne également décharge au commissaire à la liquidation à savoir EP International précitée, pour l'exé-
cution de son mandat.
27368
L
U X E M B O U R G
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée prononce la clôture de liquidation et constate que la société «RODANGE INVESTMENTS S.A.» a défi-
nitivement cessé d'exister.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pour une durée de cinq ans à
partir d'aujourd'hui à L-2430 Luxembourg, 18, rue Michel Rodange.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, profession, état et de-
meure, ces derniers ont signé avec le notaire le présent acte.
Signé: J. BOUVARD, B. TASSIGNY, S. CHARNY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62962. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015015299/72.
(150017673) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 janvier 2015.
Diacine, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.175.040,00.
Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.
R.C.S. Luxembourg B 152.321.
In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of the month of December.
Before us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
There appeared
Sophie Bronkart, avocat à la Cour, residing in Luxembourg, as proxyholder on behalf of Diacine Holding, a société à
responsabilité limitée, with registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxem-
bourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 152.075 (the “Sole
Shareholder”), pursuant to a proxy dated 17 December 2014, being the sole shareholder of Diacine, a société à respon-
sabilité limitée, having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 152.321 (the "Company"),
incorporated by deed of Maître Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg dated 11 March
2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) number 983, page 47177, on
11 May 2010.
I. The articles of association of the Company have been amended for the last time on 28 June 2010 by deed of Maître
Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg published in the Mémorial number 1812, page
86944, on 4 September 2010.
II. The appearing party declared and requested the notary to record that the Sole Shareholder holds all the seventeen
million one hundred seventy-five thousand and forty (17,175,040) in class A shares to class J shares, with a par value of
ten euro cents (EUR 0.10) each, so that the decisions can validly be taken on the following items:
<i>Agendai>
1. Decision to put the Company into liquidation and to dissolve it;
2. Appointment of Simovia S.àr.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of Lu-
xembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés under number B 132.684, having its registered
office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as liquidator of the Company,
determination of the powers of the liquidator and granting the largest powers and especially those determined by articles
144 and 145 and following of the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies (as amended) including without
limitation:
- power to bring and defend any action on behalf of the Company, receive any payments, grant releases with or without
receipt, realise all securities of the Company, endorse any negotiable instrument and transact or compromise on any
disputes; dispose of immovable property of the Company by public auction if they consider the sale thereof necessary to
pay the debts of the Company or if there are seven or more members;
27369
L
U X E M B O U R G
- power to continue, until the sale thereof, with the industrial and commercial activity of the Company, borrow moneys
to pay the debts of the Company, issue negotiable instruments, mortgage and pledge the assets of the Company, dispose
of the immovable property thereof, even by private contract, and contribute the assets of the Company to other com-
panies;
- power to proceed to the payment of any interim liquidation proceed that it would consider appropriate;
- for specific operations of contracts, power to delegate to one or more proxies part of its powers;
3. Discharge the liquidator to make an inventory and can simply refer to the documents of the Company;
4. Authorise and approve, for the avoidance of doubt, the distribution of one or more interim distributions of liquidation
surplus in cash or in kind to the Sole Shareholder by decision of the liquidator.
The following resolutions were passed by the Sole Shareholder:
<i>Sole resolutioni>
The Sole Shareholder noted that the Sole PECs Holder of the Company resolved as of the date hereof to approve the
proposal to liquidate the Company.
After considering the above, the Sole Shareholder resolved to put the Company into liquidation and to dissolve it (the
Company subsisting for the sole purpose of the liquidation).
In relation thereto, the Sole Shareholder resolved to appoint as liquidator Simovia S.àr.l., a société à responsabilité
limitée, incorporated and existing under the laws of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés under number B 132.684, having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg, and to grant it the largest powers and particularly those set forth in articles 144 and following of
the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies (as amended).
The Sole Shareholder resolved to grant the largest powers and particularly those set forth in articles 144 and following
of the Law of 10
th
August 1915 on commercial companies to the liquidator and without limitation the Sole Shareholder
resolved to authorise the liquidator in advance to execute the acts and enter into the operations set forth in article 145
of the same law without any special authorisation, if such authorisation is required by law and including further without
limitation the powers set forth in the agenda.
The liquidator may, under its responsibility, for specific operations of contracts, delegate to one or more proxies part
of its powers to determine.
The Sole Shareholder resolved to discharge the liquidator to make an inventory and can simply refer to the documents
of the Company.
The Sole Shareholder resolved to authorise and approve, for the avoidance of doubt the distribution of one or more
interim distributions of liquidation surplus in cash or in kind by decision of the liquidator.
All the items of the agenda have been resolved upon, the meeting was closed.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a
result of the above resolutions are estimated at approximately EUR 1,300.-.
Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.
The undersigned notary, who speaks and understands English, states that the present deed is worded in English followed
by a French translation; at the request of the appearing person, the English text shall prevail in case of any discrepancy
between the English and the French texts.
This document having been read to the appearing person, who is known to the notary by its respective name, first
name, civil status and residence, the said person signed this original deed with us, the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède
L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre.
Par-devant Nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A comparu
Sophie Bronkart, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en tant que mandataire au nom de Diacine Holding, une
société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 152.075 (l’«Associé Unique»), en vertu d’une procuration datée du 17 décembre 2014, étant l’associé unique de Diacine,
une société à responsabilité limitée, dont le siège social se situe au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-
Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro
B 152.321 (la «Société»), constituée le 11 mars 2010 par acte de Maître Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 983,
page 47177, du 11 mai 2010.
27370
L
U X E M B O U R G
I. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 juin 2010 par acte de Maître Hellinckx, notaire
de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 1812, page 86944, du 4 septembre
2010.
II. La partie comparante a déclaré et requis le notaire d’acter que l’Associé Unique détient l’ensemble des dix-sept
millions cent soixante-quinze mille quarante (17.175.040) parts sociales de classe A à classe J, d’une valeur nominale de
dix centimes d’euro (0,10 EUR) chacune, de sorte que les décisions peuvent valablement être prises sur les points suivants:
<i>Ordre du jouri>
1. Décision de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre;
2. Nomination de Simovia S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 132.684, dont le siège social se situe au 4, rue Albert
Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que liquidateur de la Société, détermination des
pouvoirs du liquidateur et octroi des pouvoirs les plus larges et notamment ceux déterminés par les articles 144 et 145
et suivants de la loi (telle que modifiée) du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, y compris et ce de manière non
limitative:
- pouvoir d’intenter et de soutenir toutes actions pour la Société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou
sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la Société, endosser tous effets de commerce, transiger ou com-
promettre sur toutes contestations; aliéner les immeubles de la Société par adjudication publique, s’ils jugent la vente
nécessaire pour payer les dettes de la Société ou si le nombre des associés est de sept ou plus;
- pouvoir de continuer, jusqu'à réalisation, l’industrie et le commerce de la Société, emprunter pour payer les dettes
de la Société, créer les effets de commerce, hypothéquer les biens de la Société, les donner en gage, aliéner ses immeubles,
même de gré à gré, et faire apport de l’avoir de la Société dans d’autres sociétés;
- pouvoir de procéder au paiement de tout produit de liquidation intermédiaire qu'il jugerait approprié;
- pour des opérations spécifiques de contrats, pouvoir de déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de ses
pouvoirs;
3. Décharge du liquidateur de dresser un inventaire et possibilité de simplement se référer aux documents de la Société;
4. Autorisation et approbation, afin d’éviter tout doute, de la distribution d’une ou de plusieurs distributions inter-
médiaires de boni de liquidation en espèces ou en nature à l’Associé Unique par décision du liquidateur.
L’Associé Unique a adopté les résolutions suivantes:
<i>Résolution uniquei>
L’Associé Unique relève que le Détenteur Unique de titres participatifs (PECs) de la Société a décidé d’approuver la
proposition de mettre la Société en liquidation.
Après avoir considéré ce qui précède, l’Associé Unique a décidé de mettre la Société en liquidation et de la dissoudre
(la Société subsistant uniquement aux fins de la liquidation).
Dans ce cadre, l’Associé Unique a décidé de nommer comme liquidateur Simovia S.à r.l., une société à responsabilité
limitée de droit luxembourgeois, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B
132.684, dont le siège social se situe au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et
de lui octroyer les pouvoirs les plus larges et notamment ceux indiqués aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée).
L’Associé Unique a décidé d’octroyer les pouvoirs les plus larges et notamment ceux indiqués aux articles 144 et
suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales au liquidateur et de manière non limitative,
l’Associé Unique a décidé d’autoriser à l’avance le liquidateur à accomplir les actes et conclure les opérations indiqués à
l’article 145 de ladite loi sans autorisation spéciale, si la loi requiert cette autorisation, y compris et ce de manière non
limitative les pouvoirs énoncés dans l’ordre du jour.
Le liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spécifiques de contrats, déléguer à un ou plusieurs
mandataires une partie de ses pouvoirs à déterminer.
L’Associé Unique a décidé de décharger le liquidateur de dresser un inventaire et peut simplement se référer aux
documents de la Société.
L’Associé Unique a décidé d’autoriser et d’approuver, afin d’éviter tout doute, la distribution d’une ou de plusieurs
distributions intermédiaires de boni de liquidation en numéraire ou en nature par décision du liquidateur.
Tous les points portés à l’ordre du jour ayant fait l’objet d’une résolution, l’assemblée a été clôturée.
<i>Dépensesi>
Les dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison
des résolutions ci-dessus, sont estimés à approximativement EUR 1.300,-.
Dont acte, fait à Luxembourg, date qu'en tête du présent document.
27371
L
U X E M B O U R G
Le notaire soussigné, qui parle et comprend l’anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une
traduction en langue française; à la demande de la personne comparante, en cas de divergences entre les versions anglaise
et française, la version anglaise fera foi.
Après lecture faite du présent document à la personne comparante, connue du notaire par son nom, prénom, état
civil et résidence, ladite personne a signé le présent acte original avec Nous, notaire.
Signé: S. BRONKART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62049. Reçu douze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015011928/157.
(150013810) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Mangaki, Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 133.887.
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of the month of December;
Before Us Me Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;
Is held
an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of the public limited company governed by the
laws of Luxembourg “MANGAKI”, established and having its registered office in L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau,
registered with the Trade and Companies Registry of Luxembourg, section B, under number 133887, (the “Company”),
incorporated pursuant to a deed of Me Joseph GLODEN, notary then residing in Grevenmacher (Grand Duchy of Lu-
xembourg), on November 29, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2979 of
December 21, 2007,
and whose articles of association (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed of the officiating notary, on
October 23, 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2335 of December 1, 2009.
The Meeting is presided by Mr. Eric LECLERC, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.
The Chairman appoints Mr. Christophe JASICA, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternel-
chen, as secretary.
The Meeting elects Mrs. Laetitia KELKERMANS, employee, residing professionally in L-2370 Howald, 4, rue Peternel-
chen, as scrutineer.
The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state the
following:
A) That the agenda of the Meeting is the following:
<i>Agenda:i>
1. Exchange of the existing one hundred thousand (100,000) shares without indication of the nominal value against
seven million (7,000,000) shares without indication of the nominal value;
2. Decrease of the corporate capital to the extent of one million and eighty thousand Euros (1,080,000.- EUR) in order
to reduce it from its present amount of seven million Euros (7,000,000.- EUR) to five million nine hundred and twenty
thousand Euros (5,920,000.- EUR), by cancellation of one million and eighty thousand (1,080,000) shares without indication
of the par value and reimbursement of the amount of one million and eighty thousand Euros (1,080,000.- EUR) to the
present shareholders, the cancellation of the shares and the reimbursement being done in proportion to the shareholding;
3. Subsequent amendment of the 1
st
paragraph of article 5 of the bylaws;
4. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the Company with the
exchange of the shares, made under item (1), as well as with the registration of the cancelled shares;
5. Miscellaneous.
B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of their shares held by them, are shown on
an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders, the
members of the board of the Meeting and the officiating notary.
C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting
and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration
authorities.
27372
L
U X E M B O U R G
D) That the whole corporate capital being present or represented at the present Meeting and that all the shareholders,
present or represented, declare having had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Meeting and waiving
to the usual formalities of the convocation, no other convening notice was necessary.
E) That the present Meeting, representing the whole corporate capital, is regularly constituted and may validly deli-
berate on all the items on the agenda.
Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Meeting resolves the exchange the existing one hundred thousand (100,000) shares without indication of the
nominal value against seven million (7,000,000) shares without indication of the nominal value.
Pursuant to such resolutions the share capital of seven million Euros (7,000,000.-EUR) is henceforth represented by
seven million (7,000,000) shares without indication of the nominal value and each shareholder will receive seventy (70)
“new” shares against on “old” share.
<i>Second resolutioni>
The Meeting resolves to decrease the corporate capital to the extent of one million and eighty thousand Euros
(1,080,000.- EUR) in order to reduce it from its present amount of seven million Euros (7,000,000.- EUR) to five million
nine hundred and twenty thousand Euros (5,920,000.- EUR), by cancellation of one million and eighty thousand (1,080,000)
shares without indication of the nominal value and reimbursement of the amount of one million and eighty thousand
Euros (1,080,000.- EUR) to the present shareholders, the cancellation of the shares and the reimbursement being done
in proportion to the shareholding;
All powers are conferred to the board of directors in order to implement the necessary bookkeeping amendments,
to the cancellation of reimbursed shares and the shareholder's reimbursement.
<i>Reimbursement delay:i>
The undersigned notary has drawn the attention of the Meeting to the provisions of article 69 of the law on commercial
companies establishing a legal protection in favour of` eventual creditors of the Company, the effective reimbursement
to the shareholders cannot be made freely and without recourse from them before thirty (30) days after publication of
the present deed in the Luxembourg Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Third resolutioni>
As a result of the resolutions taken here-before, the Meeting resolves to amend the first paragraph of article 5 of the
Articles in order to give it the following wording:
“ Art. 5. (first paragraph). The corporate capital is fixed at five million nine hundred and twenty thousand Euros
(5,920,000.- EUR), represented by five million nine hundred and twenty thousand (5,920,000) fully paid up shares without
indication of the nominal value.”
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and to authorise and empower any director of the Company, acting individually, to proceed on behalf of the
Company with the exchange of the shares, made under first resolution above, as well as with the registration of the
cancelled shares.
No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the
Meeting.
<i>Costsi>
The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the
Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand four
hundred Euros.
<i>Statementi>
The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above
appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.
After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status
and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre;
27373
L
U X E M B O U R G
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
soussigné;
S'est réunie
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'“Assemblée”) de la société anonyme régie par les lois du Lu-
xembourg “MANGAKI”, établie et ayant son siège social à L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 133887, (la “Société”), constituée suivant acte
reçu par Maître Joseph GLODEN, notaire alors de résidence à Grevenmacher (Grand-Duché de Luxembourg), le 29
novembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2979 du 21 décembre 2007,
et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, le 23 octobre 2009,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2335 du 1
er
décembre 2009.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Eric LECLERC, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Howald,
4, rue Peternelchen.
Le Président désigne Monsieur Christophe JASICA, employé, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4, rue
Peternelchen, comme secrétaire.
L'Assemblée choisit Madame Laetitia KELKERMANS, employée, demeurant professionnellement à L-2370 Howald, 4,
rue Peternelchen, comme scrutatrice.
Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:
<i>Ordre du jour:i>
1. Echange des cent mille (100.000) actions existantes sans indication de valeur nominale contre sept millions
(7.000.000) d'actions sans indication de valeur nominale;
2. Réduction du capital social à hauteur d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR) pour le ramener de
son montant actuel de sept millions d'euros (7.000.000,- EUR) à cinq millions neuf cent vingt mille euros (5.920.000,-
EUR) par annulation d'un million quatre-vingt mille (1.080.000) actions sans indication de valeur nominale et rembour-
sement du montant d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR) aux actionnaires actuels, l'annulation et le
remboursement étant réalisés en proportion de leur participation dans le capital social;
3. Modification subséquente du 1
er
alinéa de l'article 5 des statuts;
4. Modification du registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus avec pouvoir
et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à
l'échange des actions, résultant du point (1), ainsi qu'à l'enregistrement des actions annulées;
5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont
portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.
C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.
D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,
déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.
E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer
valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.
Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide d'échanger les cent mille (100.000) actions existantes sans indication de valeur nominale contre
sept millions (7.000.000) d'actions sans indication de valeur nominale.
A la suite de cette résolution le capital social de sept millions d'euros (7.000.000,-EUR) est dorénavant représenté par
sept millions (7.000.000) d'actions sans indications de valeur nominale et chaque actionnaire recevra soixante-dix (70)
actions “nouvelles” en échange d'une (1) action “ancienne”.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de réduire le capital social à hauteur d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR) pour
le ramener de son montant actuel de sept millions d'euros (7.000.000,- EUR) à cinq millions neuf cent vingt mille euros
(5.920.000,- EUR) par annulation d'un million quatre-vingt mille (1.080.000) actions sans indication de valeur nominale et
remboursement du montant d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000,- EUR) aux actionnaires actuels, l'annulation
et le remboursement étant réalisés en proportion de leur participation dans le capital social.
27374
L
U X E M B O U R G
Tous pouvoirs sont conférés au conseil d'administration pour procéder aux écritures comptables qui s'imposent, à
l'annulation des actions remboursées et au remboursement des actionnaires.
<i>Délai de remboursement:i>
Le notaire a attiré l'attention de l'Assemblée sur les dispositions de l'article 69 de la loi sur les sociétés commerciales
instaurant une protection en faveur des créanciers éventuels de la Société, le remboursement effectif aux actionnaires
ne pouvant avoir lieu librement et sans recours de leur part que trente (30) jours après la publication du présent acte au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Troisième résolutioni>
En conséquence des résolutions adoptées ci-avant, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des
statuts afin de lui donner la teneur suivante:
“ Art. 5. (premier alinéa). Le capital social est fixé à cinq millions neuf cent vingt mille euros (5.920.000,-EUR), repré-
senté par cinq millions neuf cent vingt mille (5.920.000,-) actions entièrement libérées sans indication de valeur nominale.”
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin d'y faire figurer les modifications ci-dessus
et d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder pour le
compte de la Société à l'échange des actions, conformément à la première résolution ci-dessus, ainsi qu'à l'enregistrement
des actions annulées.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a
ensuite clôturé l'Assemblée.
<i>Fraisi>
Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la
Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cents euros.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des com-
parants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas
de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits
comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.
Signé: E.LECLERC, C. JASICA, L. KELKERMANS, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 6 janvier 2015. 2LAC/2015/351. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.
Luxembourg, le 19 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012234/185.
(150013541) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Visitation S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8190 Kopstal, 61, rue Schmitz.
R.C.S. Luxembourg B 114.558.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 25 janvier 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015014716/14.
(150017047) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
27375
L
U X E M B O U R G
PH International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 2.269.559.656,53.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.788.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November at 3:38 p.m. Central European Time.
Before Maître Henri Hellinckx, notary public established in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
1) PH Global Holdings, Inc., a Delaware corporation, having its registered office at 1209 Orange Street, Corporation
Trust Center, Wilmington, DE 19801, United States of America;
2) Yum! Restaurants International Management LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office
at 1209 Orange Street, Wilmington, DE, 19801, United States of America (together with PH Global Holdings, Inc., the
“Shareholders”); and
3) PH International Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), organised
under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.215 (the “Con-
tributor”);
hereby represented by Mr. Régis Galiotto, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxembourg, by virtue
of proxies given under private seal.
Such proxies having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.
The appearing parties, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record as follows:
I.- PH Global Holdings, Inc. and Yum! Restaurants International Management LLC are the shareholders of PH Inter-
national Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) organized under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
incorporated by a deed enacted by Maître Edouard Delosch, notary in Diekirch, on 8 October 2013, published in the
“Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” dated 22 November 2013 number 2954, registered with the Luxem-
bourg Trade and Companies Register under number B 180.788 (the “Company”).
II.- The 196,362,615,691 (one hundred ninety-six billion three hundred sixty-two million six hundred fifteen thousand
six hundred ninety-one) shares, with a nominal value of 0.01 EUR (one Euro Cent) each, representing the whole share
capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which
the Shareholders expressly state having been duly informed beforehand.
III.- The agenda of the meeting is the following:
<i>Agendai>
1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 305,933,499.62 (three hundred five million nine
hundred thirty-three thousand four hundred ninety-nine Euros and sixty-two Cents) so as to raise it from its current
amount of EUR 1,963,626,156.91 (one billion nine hundred sixty-three million six hundred twenty-six thousand one
hundred fifty-six Euros and ninety-one Cents) to EUR 2,269,559,656.53 (two billion two hundred sixty-nine million five
hundred fifty-nine thousand six hundred fifty-six Euros and fifty-three Cents) by the issuance of 30,593,349,962 (thirty
billion five hundred ninety-three million three hundred forty-nine thousand nine hundred sixty-two) new shares of the
Company with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each the whole to be fully paid up through a contribution
in kind;
3. Subscription and payment by PH International Holdings II S.à r.l. of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the Shareholders, the following resolutions have been taken:
<i>First resolution:i>
The Shareholders resolve to waive their right to the prior notice of the current meeting; the Shareholders acknowledge
being sufficiently informed on the agenda and consider the meeting to be validly convened and therefore agree to deli-
berate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put
at the disposal of the Shareholders within a sufficient period of time in order to allow them to examine carefully each
document.
27376
L
U X E M B O U R G
<i>Second resolution:i>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 305,933,499.62 (three
hundred five million nine hundred thirty-three thousand four hundred ninety-nine Euros and sixty-two Cents), so as to
raise it from its current amount of EUR 1,963,626,156.91 (one billion nine hundred sixty-three million six hundred twenty-
six thousand one hundred fifty-six Euros and ninety-one Cents) to EUR 2,269,559,656.53 (two billion two hundred sixty-
nine million five hundred fifty-nine thousand six hundred fifty-six Euros and fifty-three Cents) by the issuance of
30,593,349,962 (thirty billion five hundred ninety-three million three hundred forty-nine thousand nine hundred sixty-
two) new shares with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each (the “New Shares”) the whole to be fully paid
by a contribution in kind made by the Contributor.
<i>Third resolution:i>
The Shareholders further resolves to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares
through the contribution in kind as detailed below.
<i>Intervention - Subscription - Paymenti>
Thereupon intervenes the Contributor, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy
given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.
The New Shares have been fully paid-up by the Contributor through a contribution in kind as described below.
<i>Description of the contributioni>
The contribution made by the Contributor, in exchange for the issuance of the New Shares, is composed of
38,000,000,000 (thirty eight billion) shares held by the Contributor in PH Intermediate Holdings S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office
at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Trade and Companies Register under number B 190.942 (the “Contribution”).
<i>Valuationi>
The net value of the Contribution amounts to EUR 305,933,499.62 (three hundred five million nine hundred thirty-
three thousand four hundred ninety-nine Euros and sixty-two Cents) being the EUR equivalent of USD 380,000,000 (three
hundred eighty million United States Dollars) using the exchange rate USD/EUR of 1.2421 published by Bloomberg as at
November 25, 2014.
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value
dated November 25, 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.
<i>Evidence of the Contribution's existencei>
A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.
<i>Managers' interventioni>
Thereupon intervene:
a) Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, manager;
b) Darin Orr, residing professionally at 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, United States of
America, manager; and
c) Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg, manager.
all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy contained in the above statement of
contribution value.
Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the
Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Fourth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as
follows:
- PH Global Holdings, Inc.: 17,174,949,700 (seventeen billion one hundred seventy-four million nine hundred forty-
nine thousand seven hundred) shares;
- Yum! Restaurants International Management LLC: 179,187,665,991 (one hundred seventy-nine billion one hundred
eighty-seven million six hundred sixty-five thousand nine hundred ninety-one) shares;
- PH International Holdings II S.à r.l.: 30,593,349,962 (thirty billion five hundred ninety-three million three hundred
forty-nine thousand nine hundred sixty-two) shares
27377
L
U X E M B O U R G
The notary acts that the 226,955,965,653 (two hundred twenty-six billion nine hundred fifty-five million nine hundred
sixty-five thousand six hundred fifty-three) shares, representing the entire share capital of the Company, are represented
so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.
<i>Fifth resolution:i>
As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it
is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:
“ Art. 8. The Company's share capital is set at EUR 2,269,559,656.53 (two billion two hundred sixty-nine million five
hundred fifty-nine thousand six hundred fifty-six Euros and fifty-three Cents), represented by 226,955,965,653 (two
hundred twenty-six billion nine hundred fifty-five million nine hundred sixty-five thousand six hundred fifty-three) shares
with a nominal value of EUR 0.01 (one Euro Cent) each.“
No other amendments shall be made to this article.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with this deed, have been estimated at about eight thousand five hundred Euros (8,500.-Euros).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original
deed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.
Traduction française du texte qui précède
L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de novembre, à 15h38, heure d'Europe Centrale.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire public établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Ont comparu:
1) PH Global Holdings, Inc., une société de l'Etat du Delaware, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Corpo-
ration Trust Center, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique;
2) Yum! Restaurants International Management LLC, une société de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant
son siège social au 1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique (ensemble avec PH Global Hol-
dings, Inc., les «Associés»); et
3) PH International Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée, organisée selon les lois du Grand-Duché
de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.215 (l'«Apporteur»);
ici dûment représentées par M. Régis Galiotto, avec adresse professionnelle sise au 101, rue Cents, L-1319 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de procurations données sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte pour être enregistrées avec celui-ci auprès des
autorités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. PH Global Holdings, Inc. et Yum! Restaurants International Management LLC sont les associés de PH International
Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard
Delosch, notaire établi à Diekirch, le 8 octobre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté
du 22 novembre 2013 numéro 2954, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B 180.788 (la «Société»).
II. Les 196.362.615.691 (cent quatre-vingt-seize milliards trois cent soixante-deux millions six cent quinze mille six cent
quatre-vingt-onze) parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro) chacune, représentant la totalité
du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les
points de l'ordre du jour, dont les Associés reconnaissent avoir été dûment et préalablement informés.
III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 305.933.499,62 EUR (trois cent cinq millions neuf cent
trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-deux Cents) afin de le porter de son montant actuel
27378
L
U X E M B O U R G
de 1.963.626.156,91 EUR (un milliard neuf cent soixante-trois millions six cent vingt-six mille cent cinquante-six Euros et
quatre-vingt-onze Cents) à 2.269.559.656,53 EUR (deux milliards deux cent soixante-neuf millions cinq cent cinquante
neuf mille six cent cinquante-six Euros et cinquante-trois Cents) par l'émission de 30.593.349.962 (trente milliards cinq
cent quatre-vingt-treize millions trois cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-deux) nouvelles parts sociales d'une
valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport en
nature;
3. Souscription et libération par PH International Holdings II S.à r.l. des nouvelles parts sociales par voie d'apport en
nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par les Associés, les résolutions suivantes ont été adoptées:
<i>Première résolution:i>
Les Associés décident de renoncer à leur droit de convocation préalable à la présente assemblée; les Associés recon-
naissent avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour et considèrent avoir été valablement convoqués et en
conséquence acceptent de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que
l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition des Associés dans un laps de temps suffisant afin
de leur permettre un examen attentif de chaque document.
<i>Deuxième résolution:i>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 305.933.499,62 EUR (trois cent cinq
millions neuf cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-deux Cents) afin de le porter de
son montant actuel de 1.963.626.156,91 EUR (un milliard neuf cent soixante-trois millions six cent vingt-six mille cent
cinquante-six Euros et quatre-vingt-onze Cents) à 2.269.559.656,53 EUR (deux milliards deux cent soixante-neuf millions
cinq cent cinquante neuf mille six cent cinquante-six Euros et cinquante-trois Cents) par l'émission de 30.593.349.962
(trente milliards cinq cent quatre-vingt-treize millions trois cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-deux) nouvelles
parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 EUR (un cent d'euro) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant
être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Apporteur.
<i>Troisième résolution:i>
Les Associés décident ensuite d'accepter la souscription et la libération par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales
par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Intervention - Souscription - Paiementi>
Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration donnée
sous seing privé qui déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales.
Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.
<i>Description de l'apporti>
L'apport réalisé par l'Apporteur, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales, est composé de 38.000.000.000
(trente-huit milliards) parts sociales détenues par l'Apporteur dans PH Intermediate Holdings S.à r.l., une société à res-
ponsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John
F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous
le numéro B 190.942 (l'«Apport»).
<i>Evaluationi>
La valeur nette de l'Apport s'élève à 305.933.499,62 EUR (trois cent cinq millions neuf cent trente-trois mille quatre
cent quatre-vingt-dix-neuf Euros et soixante-deux Cents) étant l'équivalent en Euro de 380.000.000 USD (trois cent
quatre-vingt millions de Dollars américains) selon le taux de change USD/EUR de 1.2421 publié par Bloomberg le 25
novembre 2014.
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de
l'apport en date du 25 novembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d'enregistrement.
<i>Preuve de l'existence de l'Apporti>
Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.
<i>Intervention des gérantsi>
Interviennent ensuite:
27379
L
U X E M B O U R G
a) Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, gérant;
b) Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats-Unis
d'Amérique, gérant; et
c) Michael McAuliffe, résidant professionnellement au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché
of Luxembourg, gérant;
Tous représentés par M. Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration sur la
valeur de l'apport visée ci-dessus.
Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que
gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.
<i>Quatrième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé com-
me suit:
- PH Global Holdings, Inc.: 17.174.949.700 (dix-sept milliards cent soixante-quatorze millions neuf cent quarante-neuf
mille sept cents) parts sociales.
- Yum! Restaurants International Management LLC: 179.187.665.991 (cent soixante-dix-neuf milliards cent quatre-
vingt-sept millions six cent soixante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-onze) parts sociales
- PH International Holdings II S.à r.l.: 30.593.349.962 (trente milliards cinq cent quatre-vingt-treize millions trois cent
quarante-neuf mille neuf cent soixante-deux) parts sociales
Le notaire constate que les 226.955.965.653 (deux cent vingt-six milliards neuf cent cinquante-cinq millions neuf cent
soixante-cinq mille six cent cinquante-trois) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont
représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-dessous.
<i>Cinquième résolution:i>
En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de
modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:
« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 2.269.559.656,53 EUR (deux milliards deux cent soixante-neuf millions
cinq cent cinquante neuf mille six cent cinquante-six Euros et cinquante-trois Cents), représenté par 226.955.965.653
(deux cent vingt-six milliards neuf cent cinquante-cinq millions neuf cent soixante-cinq mille six cent cinquante-trois) parts
sociales ayant une valeur nominale de 0,01 EUR (un euro cent) chacune.»
Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.
<i>Estimation des coûtsi>
Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être
payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ huit mille cinq cents Euros (8.500.- Euro).
Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent
document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent
acte.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,
le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57506. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012320/264.
(150013891) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
27380
L
U X E M B O U R G
Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8832 Rombach-Martelange, 17, rue des Tilleuls.
R.C.S. Luxembourg B 178.272.
Statuts coordonnés, suite à une cession de parts sociales ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire reçue par
Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette en date du 29 octobre 2014 déposés au registre de com-
merce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 1
er
décembre 2014.
Référence de publication: 2015014414/12.
(150016935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
ILP Acquisitions S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.
Capital social: EUR 34.783.475,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 109.755.
In the year two thousand and fourteen on the thirty-first day of December.
Before Us, Maître Léonie Grethen notary residing in Luxembourg.
THERE APPEARS:
CEP II Investment Holdings L.P., a limited partnership existing and incorporated under the laws of the state of Ontario,
Canada, having its registered office at 40 King Street West, Scotia Plaza, Suite 5800, Toronto, Ontario M5H3Z7, Canada,
registered with the Ontario Ministry of Consumer and Business Services under registration number 130931116,
here represented by Mrs. Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg, by virtue of one (1) proxy given on December 30, 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company having the status of a securitization
company (société à responsabilité limitée de titrisation) established and existing in Luxembourg under the name of “ILP
Acquisitions S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxem-
bourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 109755, established pursuant to
a deed of Maître Joseph Elvinger, then notary residing in Luxembourg, of July 15, 2005, published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations of December 2, 2005, number 1316, and whose bylaws have been last amended
pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg of December
11, 2013 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of January 24, 2014, number 216.
II. The Company's share capital is set at eighteen million seven hundred five thousand four hundred Euro (EUR
18,705,400) represented by five hundred (500) Compartment A shares, four thousand nineteen (4,019) Compartment
G Series 1 shares, thirty thousand three hundred seventy-eight (30,378) Compartment G Series 2 shares, eighty (80)
Compartment H Series 1 shares, ten thousand eight hundred forty-two (10,842) Compartment H Series 2 shares, seven
thousand nine hundred twenty-two (7,922) Compartment I Series 1 shares, forty-eight thousand nine hundred ninety-
five (48,995) Compartment I Series 2 shares, five thousand two hundred thirty-four (5,234) Compartment K Series 1
shares, fifty-four thousand five hundred and eight (54,508) Compartment K Series 2 shares, three thousand four hundred
sixty-nine (3,469) Compartment L Series 1 shares, thirty-five thousand two hundred fifteen (35,215) Compartment L
Series 2 shares, three thousand six hundred eighteen (3,618) Compartment N Series 1 shares, twenty-eight thousand six
hundred thirty-four (28,634) Compartment N Series 2 shares, three thousand three hundred thirty-six (3,336) Com-
partment O Series 1 shares, forty-four thousand two hundred seventeen (44,217) Compartment O Series 2 shares, three
thousand four hundred twenty-seven (3,427) Compartment P Series 1 shares, thirty-five thousand three hundred eighty-
two (35,382) Compartment P Series 2 shares, six thousand one hundred twenty-seven (6,127) Compartment Q Series
1 shares, three hundred twenty-four thousand eight hundred seventy-nine (324,879) Compartment Q Series 2 shares,
three hundred fifty-four (354) Compartment R Series 1 shares, eleven thousand nine hundred forty-eight (11,948) Com-
partment R Series 2 shares, two thousand four hundred ten (2,410) Compartment S Series 1 shares, twenty-five thousand
nine hundred nineteen (25,919) Compartment S Series 2 shares, four thousand three hundred two (4,302) Compartment
T Series 1 shares, and fifty two thousand five hundred one (52,501) Compartment T Series 2 shares with a par value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
The appearing party, duly represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to document the
following resolutions:
27381
L
U X E M B O U R G
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of fifty-four million four
hundred eighty-one thousand four hundred fifty Euro (EUR 54,481,450.-) in order to raise it from its present amount of
eighteen million seven hundred five thousand four hundred Euro (EUR 18,705,400.-) to seventy-three million one hundred
eighty-six thousand eight hundred fifty Euro (EUR 73,186,850.-) by the creation and issuance of two million one hundred
seventy-nine thousand two hundred fifty-eight (2,179,258) new shares, with a nominal value of twenty-five Euro (EUR
25.-) each, vested with the same rights and obligations as the existing shares of respectively the same compartment and
series, as detailed in the following table (the New Shares):
Compartment / Series of Shares
Share capital
before capital
increase
Number
of new
shares to
be issued
Amount of
capital increase
Number
of shares
after capital
increase
Share capital
after capital
increase
Compartment A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 12.500,-
0
€ 0,-
500
€ 12.500,-
Compartment G Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 100.475,-
858
€ 21.450,-
4.877
€ 121.925,-
Compartment G Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 759.450,-
111.795
€ 2.794.875,-
142.173
€ 3.554.325,-
Compartment H Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 2.000,-
6
€ 150,00
86
€ 2.150,-
Compartment H Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 271.050,-
25.978
€ 649.450,-
36.820
€ 920.500,-
Compartment I Series 1 . . . . . . . . . . . . .
€ 198.050,-
3.560
€ 89.000,-
11.482
€ 287.050,-
Compartment I Series 2 . . . . . . . . . . . . .
€ 1.224.875,-
103.536
€ 2.588.400,-
152.531
€ 3.813.275,-
Compartment K Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 130.850,-
4.488
€ 112.200,-
9.722
€ 243.050,-
Compartment K Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 1.362.700,-
126.861
€ 3.171.525,-
181.369
€ 4.534.225,-
Compartment L Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 86.725,-
355
€ 8.875,-
3.824
€ 95.600,-
Compartment L Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 880.375,-
75.099
€ 1.877.475,-
110.314
€ 2.757.850,-
Compartment N Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 90.450,-
1.524
€ 38.100,-
5.142
€ 128.550,-
Compartment N Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 715.850,-
56.409
€ 1.410.225,-
85.043
€ 2.126.075,-
Compartment O Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 83.400,-
1.473
€ 36.825,-
4.809
€ 120.225,-
Compartment O Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 1.105.425,-
113.632
€ 2.840.800,-
157.849
€ 3.946.225,-
Compartment P Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 85.675,-
363
€ 9.075,-
3.790
€ 94.750,-
Compartment P Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 884.550,-
76.552
€ 1.913.800,-
111.934
€ 2.798.350,-
Compartment Q Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 153.175,-
817
€ 20.425,-
6.944
€ 173.600,-
Compartment Q Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 8.121.975,-
361.290
€ 9.032.250,-
686.169 € 17.154.225,-
Compartment R Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 8.850,-
6.231
€ 155.775,-
6.585
€ 164.625,-
Compartment R Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 298.700,-
224.897
€ 5.622.425,-
236.845
€ 5.921.125,-
Compartment R Series 3 . . . . . . . . . . . .
€ 0,-
714.953 € 17.873.825,-
714.953 € 17.873.825,-
Compartment S Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 60.250,-
1.913
€ 47.825,-
4.323
€ 108.075,-
Compartment S Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 647.975,-
65.994
€ 1.649.850,-
91.913
€ 2.297.825,-
Compartment T Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 107.550,-
1.308
€ 32.700,-
5.610
€ 140.250,-
Compartment T Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 1.312.525,-
99.366
€ 2.484.150,-
151.867 € 3.796.675,00
N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 18,705,400.- 2,179,258 € 54,481,450.-
2,927,474 € 73,186,850.-
<i>Subscription - Paymenti>
The sole shareholder resolves to subscribe the New Shares, and to fully pay them up at their nominal value of twenty-
five Euro (EUR 25.-) each, having an aggregate value of fifty-four million four hundred eighty-one thousand four hundred
fifty Euro (EUR 54,481,450.-), by contribution in kind in the amount of fifty-four million four hundred eighty-one thousand
four hundred fifty Euro (EUR 54,481,450.-) consisting in the conversion of a receivable in the same amount held by it
towards the Company, which receivable is incontestable, payable and due (the Receivable).
<i>Evidence of the contribution's existence and valuei>
Proof of the existence and value of the contribution in kind has been given by:
- a balance sheet dated as of November 30, 2014 of the Company, certified “true and correct” by its management;
- a contribution declaration of the sole shareholder, attesting that it is the unrestricted owner of the Receivable.
<i>Effective implementation of the contribution in kindi>
The sole shareholder, through its proxy holder, declares that:
- it is the sole unrestricted owner of the Receivable to be contributed and possesses the power to dispose of it, it
being legally and conventionally freely transferable;
27382
L
U X E M B O U R G
- the Receivable has consequently not been transferred and no legal or natural person other than the sole shareholder
is entitled to any rights as to the Receivable;
- all further formalities are in course in the jurisdiction of the location of the Receivable in order to duly carry out and
formalize the contribution and to render it effective anywhere and toward any third party.
<i>Report of the Company's managersi>
The report of the managers of the Company, dated December 30, 2014, annexed to the present deed, attests that
the managers of the Company, acknowledging having been informed beforehand of the extent of their responsibility,
legally bound as managers of the Company owing the above described contribution in kind, expressly agree with its
description, with its valuation and confirm the validity of the subscription and payment.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to decrease the share capital of the Company by an amount of thirty-eight million four
hundred three thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 38,403,375.-) so as to bring it from its current amount
of seventy-three million one hundred eighty-six thousand eight hundred fifty Euro (EUR 73,186,850.-) to an amount of
thirty-four million seven hundred eighty-three thousand four hundred seventy-five Euro (EUR 34,783,475.-) by cancella-
tion of one million five hundred thirty-six thousand one hundred thirty five (1,536,135) shares of the Company, with a
nominal value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each and an aggregate value of thirty-eight million four hundred three
thousand three hundred seventy-five Euro (EUR 38,403,375.-), it holds, as detailed in the following table (the Cancelled
Shares), and to repay the Cancelled Shares to the latter:
Compartment and serie of Shares
Share capital
before capital
decrease
Number
of shares
to be
cancelled
Amount of
capital decrease
Number
of shares
after capital
decrease
Share capital
after capital
decrease
Compartment A . . . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 12.500,-
0
€ 0,-
500
€ 12.500,-
Compartment G Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 121.925,-
4.877
€ 121.925,-
0
€ 0,-
Compartment G Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 3.554.325,-
142.173
€ 3.554.325,-
0
€ 0,-
Compartment H Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 2.150,-
86
€ 2.150,-
0
€ 0,-
Compartment H Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 920.500,-
36.820
€ 920.500,-
0
€ 0,-
Compartment I Series 1 . . . . . . . . . . . .
€ 287.050,-
11.482
€ 287.050,-
0
€ 0,-
Compartment I Series 2 . . . . . . . . . . . .
€ 3.813.275,-
152.531
€ 3.813.275,-
0
€ 0,-
Compartment K Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 243.050,-
0
€ 0,-
9.722
€ 243.050,-
Compartment K Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 4.534.225,-
0
€ 0,-
181.369
€ 4.534.225,-
Compartment L Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 95.600,-
3.308
€ 82.700,-
516
€ 12.900,-
Compartment L Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 2.757.850,-
95.437
€ 2.385.925,-
14.877
€ 371.925,-
Compartment N Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 128.550,-
0
€ 0,-
5.142
€ 128.550,-
Compartment N Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 2.126.075,-
0
€ 0,-
85.043
€ 2.126.075,-
Compartment O Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 120.225,-
0
€ 0,-
4.809
€ 120.225,-
Compartment O Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 3.946.225,-
0
€ 0,-
157.849
€ 3.946.225,-
Compartment P Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 94.750,-
0
€ 0,-
3.790
€ 94.750,-
Compartment P Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 2.798.350,-
0
€ 0,-
111.934
€ 2.798.350,-
Compartment Q Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 173.600,-
6.944
€ 173.600,-
0
€ 0,-
Compartment Q Series 2 . . . . . . . . . . . € 17.154.225,-
686.169
€ 17.154.225,-
0
€ 0,-
Compartment R Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 164.625,-
6.585
€ 164.625,-
0
€ 0,-
Compartment R Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 5.921.125,-
236.845
€ 5.921.125,-
0
€ 0,-
Compartment R Series 3 . . . . . . . . . . . € 17.873.825,-
0
€ 0,-
714.953 € 17.873.825,-
Compartment S Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 108.075,-
4.080
€ 102.000,-
243
€ 6.075,-
Compartment S Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 2.297.825,-
86.755
€ 2.168.875,-
5.158
€ 128.950,-
Compartment T Series 1 . . . . . . . . . . .
€ 140.250,-
2.210
€ 55.250,-
3.400
€ 85.000,-
Compartment T Series 2 . . . . . . . . . . .
€ 3.796.675,-
59.833
€ 1.495.825,-
92.034
€ 2.300.850,-
N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 73,186,850.- 1,536,135
€ 38,403,375.-
1,391,339 € 34,783,475.-
The payment may only take place after any claims held by any creditors against the Company have been fully reimbursed
or retained, in accordance with article 69 of the Luxembourg law on commercial companies.
<i>Third resolutioni>
Pursuant to the above increase and decrease in capital, the sole shareholder resolves to entirely restate article 6
paragraph 1 of the Company's articles of association, to give it henceforth the following content:
27383
L
U X E M B O U R G
“The Company's share capital is set at thirty-four million seven hundred eighty-three thousand four hundred seventy-
five Euro (EUR 34,783,475.-) represented by five hundred (500) Compartment A shares, nine thousand seven hundred
twenty-two (9,722) Compartment K Series 1 shares, one hundred eighty-one thousand three hundred sixty-nine
(181,369) Compartment K Series 2 shares, five hundred sixteen (516) Compartment L Series 1 shares, fourteen thousand
eight hundred seventy-seven (14,877) Compartment L Series 2 shares, five thousand one hundred forty-two (5,142)
Compartment N Series 1 shares, eighty-five thousand forty-three (85,043) Compartment N Series 2 shares, four thousand
eight hundred nine (4.809) Compartment O Series 1 shares, one hundred fifty-seven thousand eight hundred forty-nine
(157,849) Compartment O Series 2 shares, three thousand seven hundred ninety (3,790) Compartment P Series 1 shares,
one hundred eleven thousand nine hundred thirty-four (111,934) Compartment P Series 2 shares, seven hundred fourteen
thousand nine hundred fifty-three (714,953) Compartment R Series 3 shares, two hundred forty-three (243) Compart-
ment S Series 1 shares, five thousand one hundred fifty-eight (5,158) Compartment S Series 2 shares, three thousand
four hundred (3,400) Compartment T Series 1 shares, and ninety-two thousand thirty-four (92,034) Compartment T
Series 2 shares, all with a par value of twenty-five Euro (EUR 25.-) each. The Compartment A shares, the Compartment
K Series 1 and Series 2 shares, the Compartment L Series 1 and Series 2 shares, the Compartment N Series 1 and Series
2 shares, the Compartment O Series 1 and Series 2 shares, the Compartment P Series 1 and Series 2 shares, the Com-
partment R Series 3 shares, the Compartment S Series 1 and Series 2 shares, and the Compartment T Series 1 and Series
2 shares together with the shares of other compartments which may be issued from time to time shall be referred to as
the «Shares».”
<i>Costsi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne to the Company as a result
of the present resolutions are estimated at approximately nine thousand Euro (EUR 9,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her name,
civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par-devant Nous, Maître Léonie Grethen, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
La soussignée CEP II Investment Holdings L.P., un limited partnership constitué et régi en vertu du droit de l'état
d'Ontario, Canada, ayant son siège social au 40, King Street West, Scotia Plaza, Suite 5800, Toronto, Ontario M5H3Z7,
Canada, enregistrée auprès du Ministère des Petites Entreprises et des Services aux Consommateurs de l'Etat d'Ontario
(Canada) sous le numéro 130931116,
ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché
de Luxembourg, en vertu d'une (1) procuration donnée sous seing privé le 30 décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de personne comparante et le notaire
instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.
La comparante, représentée par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
I. La comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie dans le Grand-Duché de Luxembourg
sous la dénomination «ILP Acquisitions S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
109755, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 15 juillet
2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le numéro 1316 en date du 2 décembre 2005, et dont
les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte de Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch,
Grand-Duché de Luxembourg, en date du 11 décembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
le numéro 216 en date du 24 janvier 2014.
II. Le capital social de la Société est fixé à dix-huit millions sept cent cinq mille quatre cents Euro (EUR 18.705.400)
représenté par cinq cents (500) Parts sociales de Compartiment A, quatre mille dix-neuf (4.019) Parts sociales de Com-
partiment G Série 1, trente mille trois cent soixante-dix-huit (30.378) Parts sociales de Compartiment G Série 2, quatre-
vingt (80) Parts sociales de Compartiment H Série 1, dix mille huit cent quarante-deux (10.842) Parts sociales de
Compartiment H Série 2, sept mille neuf cent vingt-deux (7.922) Parts sociales de Compartiment I Série 1, quarante-huit
mille neuf cent quatre-vingt-quinze (48.995) Parts sociales de Compartiment I Série 2, cinq mille deux cent trente-quatre
(5.234) Parts sociales de Compartiment K Série 1, cinquante-quatre mille cinq cent huit (54.508) Parts sociales de Com-
partiment K Série 2, trois mille quatre cent soixante-neuf (3.469) Parts sociales de Compartiment L Série 1, trente-cinq
27384
L
U X E M B O U R G
mille deux cent quinze (35.215) Parts sociales de Compartiment L Série 2, trois mille six cent dix-huit (3.618) Parts sociales
de Compartiment N Série 1, vingt-huit mille six cent trente-quatre (28.634) Parts sociales de Compartiment N Série 2,
trois mille trois cent trente-six (3.336) Parts sociales de Compartiment O Série 1, quarante-quatre mille deux cent dix-
sept (44.217) Parts sociales de Compartiment O Série 2, trois mille quatre cent vingt-sept (3.427) Parts sociales de
Compartiment P Série 1, trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-deux (35.382) Parts sociales de Compartiment P Série
2, six mille cent vingt-sept (6.127) Parts sociales de Compartiment Q Série 1, trois cent vingt-quatre mille huit cent
soixante-dix-neuf (324.879) Parts sociales de Compartiment Q Série 2, trois cent cinquante-quatre (354) Parts sociales
de Compartiment R Série 1, onze mille neuf cent quarante-huit (11.948) Parts sociales de Compartiment R Série 2, deux
mille quatre cent dix (2.410) Parts sociales de Compartiment S Série 1, vingt-cinq mille neuf cent dix-neuf (25.919) Parts
sociales de Compartiment S Série 2, quatre mille trois cent deux (4.302) Parts Sociales de Compartiment T Série 1, et
cinquante-deux mille cinq cent une (52.501) Parts sociales de Compartiment T Série 2, d'une valeur de vingt-cinq Euro
(EUR 25,-) chacune.
La comparante, représentée tel qu'indiqué ci-dessus, a demandé au notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de cinquante-quatre millions quatre
cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante Euro (EUR 54,481,450.-) pour le faire passer de son montant actuel de
dix-huit millions sept cent cinq mille quatre cents Euro (EUR 18,705,400.-) à soixante-treize millions cent quatre-vingt-
six mille huit cent cinquante Euro (EUR 73,186,850.-) par la création et l'émission de deux millions cent soixante-dix-neuf
mille deux cent cinquante-huit (2,179,258) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25.-)
chacune, vêtues des mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes de même compartiment et série, comme
détaillé dans le tableau suivant (les Nouvelles Parts Sociales):
Compartiment et Série
de parts sociales
Capital
social avant
augmentation
de capital
Nombre
de parts
sociales
émises
Montant de
l'augmentation
de capital
Nombre de
parts sociales
après
augmentation
de capital
Capital
social après
augmentation
de capital
Compartiment A . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 12.500,-
0
€ 0,-
500
€ 12.500,-
Compartiment G Séries 1 . . . . . . . . .
€ 100.475,-
858
€ 21.450,-
4.877
€ 121.925,-
Compartiment G Séries 2 . . . . . . . . .
€ 759.450,-
111.795
€ 2.794.875,-
142.173
€ 3.554.325,-
Compartiment H Séries 1 . . . . . . . . .
€ 2.000,-
6
€ 150,00
86
€ 2.150,-
Compartiment H Séries 2 . . . . . . . . .
€ 271.050,-
25.978
€ 649.450,-
36.820
€ 920.500,-
Compartiment I Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 198.050,-
3.560
€ 89.000,-
11.482
€ 287.050,-
Compartiment I Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 1.224.875,-
103.536
€ 2.588.400,-
152.531
€ 3.813.275,-
Compartiment K Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 130.850,-
4.488
€ 112.200,-
9.722
€ 243.050,-
Compartiment K Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 1.362.700,-
126.861
€ 3.171.525,-
181.369
€ 4.534.225,-
Compartiment L Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 86.725,-
355
€ 8.875,-
3.824
€ 95.600,-
Compartiment L Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 880.375,-
75.099
€ 1.877.475,-
110.314
€ 2.757.850,-
Compartiment N Séries 1 . . . . . . . . .
€ 90.450,-
1.524
€ 38.100,-
5.142
€ 128.550,-
Compartiment N Séries 2 . . . . . . . . .
€ 715.850,-
56.409
€ 1.410.225,-
85.043
€ 2.126.075,-
Compartiment O Séries 1 . . . . . . . . .
€ 83.400,-
1.473
€ 36.825,-
4.809
€ 120.225,-
Compartiment O Séries 2 . . . . . . . . .
€ 1.105.425,-
113.632
€ 2.840.800,-
157.849
€ 3.946.225,-
Compartiment P Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 85.675,-
363
€ 9.075,-
3.790
€ 94.750,-
Compartiment P Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 884.550,-
76.552
€ 1.913.800,-
111.934
€ 2.798.350,-
Compartiment Q Séries 1 . . . . . . . . .
€ 153.175,-
817
€ 20.425,-
6.944
€ 173.600,-
Compartiment Q Séries 2 . . . . . . . . .
€ 8.121.975,-
361.290
€ 9.032.250,-
686.169 € 17.154.225,-
Compartiment R Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 8.850,-
6.231
€ 155.775,-
6.585
€ 164.625,-
Compartiment R Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 298.700,-
224.897
€ 5.622.425,-
236.845
€ 5.921.125,-
Compartiment R Séries 3 . . . . . . . . . .
€ 0,-
714.953 € 17.873.825,-
714.953 € 17.873.825,-
Compartiment S Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 60.250,-
1.913
€ 47.825,-
4.323
€ 108.075,-
Compartiment S Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 647.975,-
65.994
€ 1.649.850,-
91.913
€ 2.297.825,-
Compartiment T Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 107.550,-
1.308
€ 32.700,-
5.610
€ 140.250,-
Compartiment T Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 1.312.525,-
99.366
€ 2.484.150,-
151.867 € 3.796.675,00
N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 18,705,400.- 2,179,258 € 54,481,450.-
2,927,474 € 73,186,850.-
<i>Souscription - Libérationi>
L'associé unique décide de souscrire aux Nouvelles Parts Sociales et de les libérer intégralement à leur valeur nominale
de vingt-cinq Euro (EUR 25.-) chacune, pour un montant total de cinquante-quatre millions quatre cent quatre-vingt-un
27385
L
U X E M B O U R G
mille quatre cent cinquante Euro (EUR 54,481,450.-), par apport en nature d'un montant de cinquante-quatre millions
quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent cinquante Euro (EUR 54,481,450.-) consistant en la conversion d'une créance
d'un même montant détenue par lui-même à l'égard de la Société, laquelle créance est incontestable, liquide et exigible
(la Créance).
<i>Preuve de l'existence et valeur de l'apporti>
Preuve de l'existence et de la valeur de cet apport en nature a été donnée au notaire soussigné par:
- un bilan de la Société daté du 30 novembre 2014, certifié conformé par son conseil de gérance;
- une déclaration d'apport de l'associé unique attestant qu'il est seul propriétaire de la Créance.
<i>Réalisation effective de l'apporti>
L'associé unique, par son mandataire, déclare que:
- il est seul propriétaire sans restriction de la Créance et possède les pouvoirs d'en disposer, celle-ci étant légalement
et conventionnellement librement transmissible;
- la Créance n'a pas fait l'objet d'une quelconque cession et aucune personne morale ou physique autre que l'associé
unique ne détient de droit sur la Créance;
- toutes autres formalités sont en cours de réalisation dans la juridiction de situation de la Créance aux fins d'effectuer
son apport et le rendre effectif partout et vis-à-vis de tous tiers.
<i>Rapport des gérants de la Sociétéi>
Le rapport des gérants de la Société en date du 30 décembre 2014, annexé aux présentes, atteste que les gérants de
la Société, reconnaissant avoir pris connaissance de l'étendue de leur responsabilité, légalement engagés en leur qualité
de gérants de la Société à raison de l'apport en nature décrit plus haut, marquent expressément leur accord sur la
description de l'apport en nature, sur son évaluation et confirment la validité des souscriptions et libérations.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unique décide de diminuer le capital social de la Société à concurrence de trente-huit millions quatre-cent
trois mille trois cent soixante-quinze Euro (EUR 38,403,375.-) pour le faire passer de son montant actuel de soixante-
treize millions cent quatre-vingt-six mille huit cent cinquante Euro (EUR 73,186,850.-) à trente-quatre millions sept cent
quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-quinze Euro (EUR 34,783,475.-) par annulation d'un million cinq cent trente-
six mille cent trente-cinq (1,536,135) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale de vingt-cinq Euro (EUR 25.-)
chacune et une valeur totale de trente-huit millions quatre-cent trois mille trois cent soixante-quinze Euro (EUR
38,403,375.-), qu'il détient, comme détaillé dans le tableau suivant (les Parts Sociales Annulées), et de rembourser les
Parts Sociales annulées à ce dernier:
Compartiment / Série de parts sociales
Capital
social avant
diminution du
capital social
Nombre
de parts
sociales
annulées
Montant de
la diminution
de capital
Nombre de
parts sociales
après
diminution
de capital
Capital
social après
diminution de
capital social
Compartiment A . . . . . . . . . . . . . . . .
€ 12.500,-
0
€ 0,-
500
€ 12.500,-
Compartiment G Séries 1 . . . . . . . . .
€ 121.925,-
4.877
€ 121.925,-
0
€ 0,-
Compartiment G Séries 2 . . . . . . . . .
€ 3.554.325,-
142.173
€ 3.554.325,-
0
€ 0,-
Compartiment H Séries 1 . . . . . . . . .
€ 2.150,-
86
€ 2.150,-
0
€ 0,-
Compartiment H Séries 2 . . . . . . . . .
€ 920.500,-
36.820
€ 920.500,-
0
€ 0,-
Compartiment I Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 287.050,-
11.482
€ 287.050,-
0
€ 0,-
Compartiment I Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 3.813.275,-
152.531
€ 3.813.275,-
0
€ 0,-
Compartiment K Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 243.050,-
0
€ 0,-
9.722
€ 243.050,-
Compartiment K Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 4.534.225,-
0
€ 0,-
181.369
€ 4.534.225,-
Compartiment L Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 95.600,-
3.308
€ 82.700,-
516
€ 12.900,-
Compartiment L Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 2.757.850,-
95.437
€ 2.385.925,-
14.877
€ 371.925,-
Compartiment N Séries 1 . . . . . . . . .
€ 128.550,-
0
€ 0,-
5.142
€ 128.550,-
Compartiment N Séries 2 . . . . . . . . .
€ 2.126.075,-
0
€ 0,-
85.043
€ 2.126.075,-
Compartiment O Séries 1 . . . . . . . . .
€ 120.225,-
0
€ 0,-
4.809
€ 120.225,-
Compartiment O Séries 2 . . . . . . . . .
€ 3.946.225,-
0
€ 0,-
157.849
€ 3.946.225,-
Compartiment P Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 94.750,-
0
€ 0,-
3.790
€ 94.750,-
Compartiment P Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 2.798.350,-
0
€ 0,-
111.934
€ 2.798.350,-
Compartiment Q Séries 1 . . . . . . . . .
€ 173.600,-
6.944
€ 173.600,-
0
€ 0,-
Compartiment Q Séries 2 . . . . . . . . . € 17.154.225,-
686.169 € 17.154.225,-
0
€ 0,-
27386
L
U X E M B O U R G
Compartiment R Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 164.625,-
6.585
€ 164.625,-
0
€ 0,-
Compartiment R Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 5.921.125,-
236.845
€ 5.921.125,-
0
€ 0,-
Compartiment R Séries 3 . . . . . . . . . . € 17.873.825,-
0
€ 0,-
714.953 € 17.873.825,-
Compartiment S Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 108.075,-
4.080
€ 102.000,-
243
€ 6.075,-
Compartiment S Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 2.297.825,-
86.755
€ 2.168.875,-
5.158
€ 128.950,-
Compartiment T Séries 1 . . . . . . . . . .
€ 140.250,-
2.210
€ 55.250,-
3.400
€ 85.000,-
Compartiment T Séries 2 . . . . . . . . . .
€ 3.796.675,-
59.833
€ 1.495.825,-
92.034
€ 2.300.850,-
N/A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 73,186,850.- 1,536,135 € 38,403,375.-
1,391,339 € 34,783,475.-
Le paiement ne pourra s'effectuer qu'après remboursement de la totalité des créanciers de la Société ou qu'après que
ces créances aient été provisionnées, en conformité avec l'article 69 de la loi luxembourgeoise concernant les sociétés
commerciales.
<i>Troisième résolutioni>
Suite à l'augmentation et à la diminution de capital, l'associé unique décide de refondre intégralement l'article 6 para-
graphe premier des statuts de la Société, afin de lui donner le contenu suivant:
«Le capital social de la Société est fixé à trente-quatre millions sept cent quatre-vingt-trois mille quatre cent soixante-
quinze Euro (EUR 34,783,475.-) représenté par cinq cents (500) Parts sociales de Compartiment A, neuf mille sept cent
vingt-deux (9,722) Parts sociales de Compartiment K Série 1, cent quatre-vingt-un mille trois cent soixante-neuf (181,369)
Parts sociales de Compartiment K Série 2, cinq cent seize (516) Parts sociales de Compartiment L Série 1, quatorze mille
huit cent soixante-dix-sept (14,877) Parts sociales de Compartiment L Série 2, cinq mille cent quarante-deux (5,142) Parts
sociales de Compartiment N Série 1, quatre-vingt-cinq mille quarante-trois (85,043) Parts sociales de Compartiment N
Série 2, quatre mille huit cent neuf (4,809) Parts sociales de Compartiment O Série 1, cent cinquante-sept mille huit cent
quarante-neuf (157,849) Parts sociales de Compartiment O Série 2, trois mille sept cent quatre-vingt-dix (3.790) Parts
sociales de Compartiment P Série 1, cent onze mille neuf cent trente-quatre (111,934) Parts sociales de Compartiment
P Série 2, sept cent quatorze mille neuf cent cinquante-trois (714,953) Parts sociales de Compartiment R Série 3, deux
cent quarante-trois (243) Parts sociales de Compartiment S Série 1, cinq mille cent cinquante-huit (5,158) Parts sociales
de Compartiment S Série 2, trois mille quatre cents (3,400) Parts Sociales de Compartiment T Série 1, et quatre-vingt-
douze mille trente-quatre (92,034) Parts sociales de Compartiment T Série 2, d'une valeur de vingt-cinq Euro (EUR 25.-)
chacune. Les Parts sociales de Compartiment A, les Parts sociales de Compartiment K Série 1 et Série 2, les Parts sociales
de Compartiment L Série 1 et Série 2, les Parts sociales de Compartiment N Série 1 et Série 2, les Parts sociales de
Compartiment O Série 1 et Série 2, les Parts sociales de Compartiment P Série 1 et Série 2, les Parts sociales de Com-
partiment R Série 3, les Parts sociales de Compartiment S Série 1 et Série 2 et les Parts sociales de Compartiment T
Série 1 et Série 2 avec les parts sociales des autres compartiments qui seront émises de temps en temps, sont dénommées
les «Parts».»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de neuf mille Euro (EUR 9.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 5 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/175. Reçu soixante-quinze euros (75,00
€).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012115/371.
(150014323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
27387
L
U X E M B O U R G
Mabledon Holdings UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 433.514,00.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 172.352.
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December,
before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
was held
an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Mabledon Holdings UK S.à r.l., a private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxem-
bourg, Grand-Duchy of Luxembourg, having a share capital of two hundred sixty thousand nine hundred five British
Pounds (GBP 260,905), and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B
172.352 (the Company). The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on October 22, 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations (the Memorial) N° 2858 dated November 24, 2012. The articles of association of the Company (the
Articles) have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, on July 11, 2014, published in the Memorial, N° 2598 dated September 25, 2014.
THERE APPEARED:
- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité
limitée), having its registered office at 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, registered with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies under number B 168.972 and having a share capital amounting to twenty five
thousand British Pounds (GBP 25,000) (AREIV),
hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal; and
- Norfolk Joint Venture Limited, a company registered in England and Wales under number 08116327 and whose
registered office is at Norfolk House, 31 St James' Square, London SWY 4JJ, United Kingdom (Norfolk and together with
AREIV, the Shareholders),
hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, by virtue of a proxy given under a private seal.
Said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.
The Shareholders, represented as stated here above, have requested the undersigned notary to record the following:
I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company.
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of the convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-two thousand six hundred nine
British Pounds (GBP 172,609) in order to bring the share capital from its present amount of two hundred sixty thousand
nine hundred five British Pounds (GBP 260,905) to four hundred thirty three thousand five hundred fourteen British
Pounds (GBP 433,514) by way of the issuance of (i) eight thousand six hundred thirty (8,630) Class A Shares and (ii) one
hundred sixty-three thousand nine hundred seventy nine (163,979) Class B Shares, all in registered form;
3. Subscription to and payment of the share capital increase specified in item 2. here above by a contribution in kind;
4. Subsequent amendment of 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the share capital
increase adopted under item 2. above;
5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and
authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company, to the above
changes; and
6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders resolve to waive the convening notices, considering themselves duly convened and having perfect
knowledge of the agenda which was communicated to them in advance.
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of one hundred seventy-two
thousand six hundred nine British Pounds (GBP 172,609) in order to bring the share capital from its present amount of
two hundred sixty thousand nine hundred five British Pounds (GBP 260,905) to four hundred thirty three thousand five
27388
L
U X E M B O U R G
hundred fourteen British Pounds (GBP 433,514) by way of the issuance of (i) eight thousand six hundred thirty (8,630)
Class A Shares and (ii) one hundred sixty-three thousand nine hundred seventy nine (163,979) Class B Shares, all in
registered form.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions for and full payments of the share capital
increase as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
Thereupon,
(1) Norfolk, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe for eight thousand six hundred thirty
(8,630) new Class A Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, and fully pays
them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that Norfolk holds against the Company in an aggregate
amount of three hundred fifty seven thousand five hundred British Pounds (GBP 357,500) (Receivable 1) to be allocated
as follows:
- an amount of eight thousand six hundred thirty British Pounds (GBP 8,630) to the share capital account of the
Company; and
- an amount of three hundred forty eight thousand eight hundred seventy British Pounds (GBP 348,870) to the Class
A Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of the Receivable 1 is evidenced by a certificate issued on 9 December 2014,
by Norfolk and acknowledged by the Company (the Management Certificate 1).
The Management Certificate 1 states in essence that:
“- Norfolk is the legal and beneficial owner of Receivable 1;
- Receivable 1 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- Norfolk is solely entitled to Receivable 1 and possesses the power to dispose of Receivable 1;
- Receivable 1 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on Receivable 1 and Receivable 1 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 1 be transferred to
him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 1 is freely transferable;
- All formalities required in United Kingdom or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of
Receivable 1 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 1 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of Norfolk will be obtained in a manner permitted by
the laws of the jurisdiction in which Norfolk is registered;
- Receivable 1 contributed to the Company is valued at three hundred fifty seven thousand five hundred British Pounds
(GBP 357,500), and since the date hereof no material changes have occurred which would have depreciated the value of
the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of the Receivable 1 contributed to the Company have been or will be
accomplished by Norfolk and upon the contribution of the Receivable 1 by Norfolk to the Company, the Company will
become the full owner of the Receivable 1 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300
of the Luxembourg Civil Code."
(2) AREIV, prenamed and represented as stated above, declares to subscribe to one hundred sixty-three thousand
nine hundred seventy nine (163,979) new Class B Shares, in registered form, having a nominal value of one British Pound
(GBP 1) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting of a receivable that AREIV holds against
the Company in an aggregate amount of three million four hundred thirty five thousand British Pounds (GBP 3,435,000)
(Receivable 2) to be allocated as follows:
- an amount of one hundred sixty three thousand nine hundred seventy nine British Pounds (GBP 163,979) to the
share capital account of the Company; and
- an amount of three million two hundred seventy one thousand twenty one British Pounds (GBP 3,271,021) to the
Class B Share Premium Account of the Company.
The valuation of the contribution in kind of Receivable 2 is evidenced by a certificate issued on 9 December 2014, by
AREIV and acknowledged by the Company (the Management Certificate 2 and together with the Management Certificate
1, the Management Certificates).
The Management Certificate 2 states in essence that:
27389
L
U X E M B O U R G
“- AREIV is the legal and beneficial owner of Receivable 2;
- Receivable 2 is certain and will be due and payable on its respective due date without deduction (certaine, liquide et
exigible);
- AREIV is solely entitled to Receivable 2 and possesses the power to dispose of Receivable 2;
- Receivable 2 is not encumbered with any pledge or usufruct, there exists no right to acquire any pledge or usufruct
on Receivable 2 and Receivable 2 is not subject to any attachment;
- There exist no rights by virtue of which any person may be entitled to demand that Receivable 2 be transferred to
him;
- According to the applicable law and respective articles of association or other organizational documents, as amended,
Receivable 2 is freely transferable;
- All formalities required in Luxembourg or any relevant jurisdiction subsequent to the contribution in kind of Recei-
vable 2 to the Company will be effected upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the said
contribution in kind;
- All corporate, regulatory and other approvals for the execution, delivery and performance of Receivable 2 to the
Company, as the case may be, have been obtained or, in the case of AREIV will be obtained in a manner permitted by
the laws of the jurisdiction in which AREIV is registered;
- Receivable 2 contributed to the Company is valued at three million four hundred thirty five thousand British Pounds
(GBP 3,435,000), and since the date hereof no material changes have occurred which would have depreciated the value
of the contribution made to the Company; and
- All formalities to transfer the legal ownership of Receivable 2 contributed to the Company have been or will be
accomplished by AREIV and upon the contribution of Receivable 2 by AREIV to the Company, the Company will become
the full owner of Receivable 2 which will be extinguished by way of confusion in accordance with article 1300 of the
Luxembourg Civil Code."
The Management Certificates, after signature ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the under-
signed notary, will remain annexed to the present deed to be filed with the registration authorities.
<i>Fourth resolutioni>
As a consequence of the preceding resolutions, the Shareholders resolve to amend article 5.1 of the Articles, so that
it shall henceforth read as follows:
" 5.1. The share capital is set at four hundred thirty three thousand five hundred fourteen British Pounds (GBP 433,514),
represented by twenty one thousand six hundred seventy five (21,675) class A shares, and four hundred eleven thousand
eight hundred thirty nine (411,839) class B shares, having a nominal value of one British Pound (GBP 1) each, all in
registered form."
<i>Fifth resolutioni>
The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes
with power and authority given to any manager of the Company to proceed, in the name and on behalf of the Company,
to the above changes.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of the present deed are estimated at approximately two thousand six hundred Euros (EUR 2,600.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states that on request of the above appearing parties,
the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing parties, in case
of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties
signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le onzième jour de décembre,
Pardevant Nous, Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire (l'Assemblée) des associés de Mabledon Holdings UK S.à r.l., une société à
responsabilité limitée, dont le siège social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, disposant d'un capital social de deux cent soixante mille neuf cent cinq livres sterlings (GBP 260.905), et
27390
L
U X E M B O U R G
immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.352 (la Société). La Société
a été constituée suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Lu-
xembourg, le 22 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le Mémorial) N° 2858 le 24
novembre 2012. Les statuts de la Société (les Statuts) ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître
Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 11 juillet 2014, publié au Mémorial,
N°2598 le 25 septembre 2014.
ONT COMPARU:
- AIMCo RE Holdings (Luxembourg) IV S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, dont le siège
social est établi au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 168.972 et disposant d'un capital social de vingt-cinq mille livres sterling (GBP 25.000)
(AREIV),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé; et
- Norfolk Joint Venture Limited, une société immatriculée en Angleterre et aux Pays de Galles sous le numéro
08116327, et dont le siège social est établi à Norfolk House, 31 St James' Square, London SWY 4JJ, Royaume-Uni (Norfolk
et avec AREIV, les Associés),
ici représentée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Luxembourg, Grand-Duché de
Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
Lesdites procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire agissant au nom des parties comparantes
et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour le besoin de l'enregistrement.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-dessus, ont requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. Que les Associés détiennent l'intégralité des parts sociales dans le capital social de la Société.
II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cent soixante-douze mille six cent neuf livres sterling
(GBP 172.609) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante mille neuf cent cinq livres
sterling (GBP 260.905) à quatre cent trente-trois mille cinq cent quatorze livres sterling (GBP 433.514) par voie d'émission
de (i) huit mille six cent trente (8.630) Parts Sociales de Classe A et (ii) cent soixante-trois mille neuf cent soixante-dix-
neuf (163.979) Parts Sociales de Classe B, toutes sous forme nominative;
3. Souscription à et libération de l'augmentation de capital social mentionnée au point 2. ci-dessus par un apport en
nature;
4. Modification subséquente de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation de capital social
mentionnée au point 2. ci-dessus;
5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité
donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux changements ci-dessus;
et
6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
Les Associés décident de renoncer aux formalités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et ayant
parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance.
<i>Deuxième résolutioni>
Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cent soixante-douze mille six cent
neuf livres sterling (GBP 172.609) afin de porter le capital social de son montant actuel de deux cent soixante mille neuf
cent cinq livres sterling (GBP 260.905) à quatre cent trente-trois mille cinq cent quatorze livres sterling (GBP 433.514)
par voie d'émission de (i) huit mille six cent trente (8.630) Parts Sociales de Classe A et (ii) cent soixante-trois mille neuf
cent soixante-dix-neuf (163.979) Parts Sociales de Classe B, toutes sous forme nominative.
<i>Troisième résolutioni>
Les Associés décident d'accepter et d'enregistrer les souscriptions suivantes et les libérations intégrales de l'augmen-
tation de capital social comme suit:
<i>Souscription - Libérationi>
Sur ces faits,
(1) Norfolk, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux huit mille six cent trente (8.630)
nouvelles Parts Sociales de Classe A, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1)
chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que Norfolk détient envers la
27391
L
U X E M B O U R G
Société d'un montant total de trois cent cinquante-sept mille cinq cents livres sterling (GBP 357.500) (la Créance 1) devant
être affectée comme suit:
- un montant de huit mille six cent trente livres sterling (GBP 8.630) au compte de capital social de la Société; et
- un montant de trois cent quarante-huit mille huit cent soixante-dix livres sterling (GBP 348.870) au Compte de Prime
d'Emission de Classe A de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 1 est démontrée par un certificat émis le 9 décembre 2014, par
Norfolk et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 1).
Le Certificat de Gérance 1 atteste essentiellement que:
"- Norfolk est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 1;
- La Créance 1 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- Norfolk est le seul ayant droit de la Créance 1 et possède le droit de disposer de la Créance 1;
- La Créance 1 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
1 et la Créance 1 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 1 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 1 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Royaume-Uni ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en
nature de la Créance 1 à la Société sera effectuée dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit
apport en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 1 à la Société,
le cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de Norfolk seront obtenues de la manière requise par les lois de la
juridiction où Norfolk est immatriculée;
- La Créance 1 apportée à la Société est estimée à trois cent cinquante-sept mille cinq cents livres sterling (GBP
357.500), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui aurait déprécié la valeur de l'apport
fait à la Société; et
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 1 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par Norfolk et dès l'apport de la Créance 1 par Norfolk à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance
1 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
(2) AREIV, précitée et représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire aux cent soixante-trois mille neuf cent
soixante-dix-neuf (163.979) nouvelles Parts Sociales de Classe B, sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une
livre sterling (GBP 1) chacune, et les libère intégralement par un apport en nature consistant en une créance que AREIV
détient envers la Société d'un montant total de trois millions quatre cent trente-cinq mille livres sterlings (GBP 3.435.000)
(la Créance 2) devant être affectée comme suit:
- un montant de cent soixante-trois mille neuf cent soixante-dix-neuf livres sterling (GBP 163.979) au compte de capital
social de la Société; et
- un montant de trois millions deux cent soixante-et-onze mille vingt-et-une livres sterling (GBP 3.271.021) au Compte
de Prime d'Emission de Classe B de la Société.
L'estimation de l'apport en nature de la Créance 2 est démontrée par un certificat émis le 9 décembre 2014, par AREIV
et reconnu par la Société (le Certificat de Gérance 2 et avec le Certificat de Gérance 1, les Certificats de Gérance).
Le Certificat de Gérance 2 atteste essentiellement que:
"- AREIV est le propriétaire légal et l'ultime bénéficiaire de la Créance 2;
- La Créance 2 est certaine, liquide et exigible en date due sans déduction;
- AREIV est le seul ayant droit de la Créance 2 et possède le droit de disposer de la Créance 2;
- La Créance 2 n'est grevée d'aucun gage ou usufruit, il n'existe aucun droit d'acquérir un gage ou usufruit sur la Créance
2 et la Créance 2 n'est soumise à aucun privilège;
- Il n'existe aucun droit en vertu duquel une personne serait autorisée à demander à ce que la Créance 2 lui soit cédée;
- Selon la loi applicable et les statuts ou autres documents constitutifs respectifs, tels que modifiés, la Créance 2 est
librement cessible;
- Toutes les formalités requises au Luxembourg ou dans toute autre juridiction concernée à la suite de l'apport en
nature de la Créance 2 à la Société sera effectuée dès réception d'une copie certifiée de l'acte notarié documentant ledit
apport en nature;
- Toutes les approbations sociales, réglementaires ou autres dans le cadre de la cession de la Créance 2 à la Société,
le cas échéant, ont été obtenus ou, dans le cas de AREIV seront obtenues de la manière requise par les lois de la juridiction
où AREIV est immatriculée;
- La Créance 2 apportée à la Société est estimée à trois millions quatre cent trente-cinq mille livres sterlings (GBP
3.435.000), et depuis la date des présentes aucun changement matériel n'est survenu qui aurait déprécié la valeur de
l'apport fait à la Société; et
27392
L
U X E M B O U R G
- Toutes les formalités pour céder la propriété légale de la Créance 2 apportée à la Société ont été ou seront effectuées
par AREIV et dès l'apport de la Créance 2 par AREIV à la Société, la Société deviendra plein propriétaire de la Créance
2 qui sera éteinte par voie de confusion conformément à l'article 1300 du code civil luxembourgeois."
Les Certificats de Gérance, après signature ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire ins-
trumentant, resteront attachés au présent acte pour être soumis avec lui auprès des autorités d'enregistrement.
<i>Quatrième résolutioni>
En conséquence des résolutions précédentes, les Associés décident de modifier l'article 5.1 des Statuts, de sorte qu'il
ait désormais la teneur suivante:
" 5.1. Le capital social est fixé à quatre cent trente-trois mille cinq cent quatorze livres sterling (GBP 433.514), repré-
senté par vingt-et-un mille six cent soixante-quinze (21.675) parts sociales de classe A et quatre cent onze mille huit cent
trente-neuf (411.839) parts sociales de classe B, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP 1) chacune, toutes
sous forme nominative."
<i>Cinquième résolutioni>
Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société pour procéder, au nom et pour le compte de la Société, aux
changements ci-dessus.
<i>Estimation des fraisi>
Les dépenses, frais, honoraires et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incomberont à la Société en raison du
présent acte sont estimés à environ deux mille six cents Euros (EUR 2.600.-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le
présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaut.
Dont Acte, en foi de quoi le présent acte notarié est passé à Luxembourg, à la date indiquée qu'en tête des présentes.
Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, il a signé avec nous, le notaire, le présent acte original.
Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61574. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012217/310.
(150013947) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9044 Ettelbruck, 1, rue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 91.505.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013485/9.
(150015135) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.
Hydraganymed S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8221 Mamer, 21, rue Cunégonde.
R.C.S. Luxembourg B 100.804.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015013486/10.
(150015457) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.
27393
L
U X E M B O U R G
Alonely S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 32, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 117.147.
Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-
dence à Esch/Alzette, en date du 29 octobre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch/Alzette, le 1
er
décembre 2014.
Référence de publication: 2015014043/11.
(150016938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Square 41 S.à r.l., Société à responsabilité limitée,
(anc. RPTRE I S.à r.l.).
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 140.024.
In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth of December,
Before the undersigned, Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED
IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed
by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies ("RCS")
under number B 186778, here represented by Henri DA CRUZ, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy
given on 30
th
December 2014; and
Da Viken Holdings Limited, a limited liability company incorporated and existing under the laws of England & Wales
with registered offices at Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V9EE, registered in the Companies House Cardiff
under number 8935553, here represented by Henri DA CRUZ, prenamed, by virtue of a proxy given on 30
th
December
2014.
Such appearing parties are the shareholders (the "Shareholders") of RPTRE I S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg with registered office at 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered in the RCS under number
B 140.024 and having a share capital of EUR 12,500, incorporated by a notarial deed drawn up by the undersigned notary
on 2 July 2008. The articles of incorporation of the Company (the "Articles") have been published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") no. 1872, p. 89817 on 30 July 2008. The Articles have been amended
for the last time by a notarial deed drawn up by the undersigned notary on 14 December 2010, published in the Mémorial
no. 389, p. 18641 on 26 February 2011.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary, will remain annexed
to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.
The appearing parties representing the whole corporate capital of the Company require the notary to act the following
resolutions:
<i>First resolutioni>
The Shareholders decide to change the corporate name of the Company from "RPTRE I S.à r.l." to "Square 41 S.à r.l."
and to amend article 1 of the Articles which shall henceforth read as follows:
" Art. 1. This document constitutes the articles of incorporation (the "Articles") of Square 41 S.à r.l. (the "Company"),
a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of
Luxembourg including the law of 10 August 1915 on commercial companies as amended from time to time (the "1915
Law")."
<i>Second resolutioni>
The Shareholders resolve to transfer the registered office of the Company from its current address at 46A, Avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, to 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand
Duchy of Luxembourg, with effect as of the date of the present resolutions.
<i>Third resolutioni>
The Shareholders resolve consequently to the second resolution to amend article 4, first sentence of the Articles,
which will henceforth read as follows:
27394
L
U X E M B O U R G
" Art. 4. The Company has its registered office in the municipality of Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg."
<i>Costs and expensesi>
The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it
by reason of the present deed are assessed to EUR 950.-.
The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in
English, followed by a German version; on request of the appearing parties and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties known to the notary by his name, first
name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with the notary the present
deed.
Es folgt die deutsche Übersetzung:
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am dreißigsten Dezember,
Vor Uns, dem unterzeichnenden Notar Jean SECKLER, Notar, mit Amtssitz in Junglinster, Großherzogtum Luxemburg,
SIND ERSCHIENEN
IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)
gegründet nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Gesellschaftssitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister ("RCS") unter
der Nummer B 186778, hier vertreten durch Herrn Henri DA CRUZ, Privatbeamter, geschäftsansässig in Junglinster,
aufgrund einer Vollmacht, die am 30. Dezember 2014 erteilt wurde; und
Da Viken Holdings Limited, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet nach dem Recht von England &
Wales mit eingetragener Adresse in Finsgate, 5-7 Cranwood Street, London EC1V9EE, eingetragen im Companies House
Cardiff unter der Nummer 8935553, hier vertreten durch Henri DA CRUZ, vorbenannt, aufgrund einer Vollmacht, die
am 30. Dezember 2014 erteilt wurde.
Die Erschienenen sind die Gesellschafter (die "Gesellschafter") von "RPTRE I S.à r.l." (im Folgenden, die "Gesellschaft"),
einer Luxemburger Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Gesellschaftssitz in 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im RCS unter der Nummer B 140.024, gegründet durch eine
notarielle Urkunde, welche von dem unterzeichnenden Notar am 2. Juli 2008 erstellt wurde. Die Satzung der Gesellschaft
(die "Satzung") wurde noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das "Mémorial") Nr. 1872, S. 89817
am 30. Juli 2008 veröffentlicht. Die Satzung wurde zuletzt durch eine Urkunde des unterzeichnenden Notars am 14.
Dezember 2010 abgeändert, welche am 26. Februar 2011 im Mémorial Nr. 389, S. 18641 veröffentlicht wurde.
Die genannten Vollmachten, bleiben nach "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Erschienenen
und den amtierenden Notar der gegenwärtigen Urkunde als Anlage beigefügt, um mit derselben hinterlegt zu werden.
Die Erschienenen, welche das gesamte Gesellschaftskapital vertreten, ersuchen den Notar den folgenden Beschluss zu
beurkunden:
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den Namen der Gesellschaft von "RPTRE I S.à r.l." in "Square 41 S.à r.l." abzuändern
und den ersten Artikel der Satzung zu ändern, welcher nunmehr folgenden Wortlaut erhält:
" Art. 1. Die Gesellschaft besteht in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à respon-
sabilité limitée) unter dem Namen "Square 41 S.à r.l." (im Folgenden die "Gesellschaft"). Die Gesellschaft unterliegt
insbesondere dem Luxemburger Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
(im Folgenden das "Gesetz von 1915") und den Vorschriften dieser Satzung (im Folgenden die "Satzung")."
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen den Gesellschaftssitz von der derzeitigen Adresse 46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg nach 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg,
mit Wirkung des Datums der vorliegenden Beschlüsse zu verlegen.
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschließen infolge des zweiten Beschlusses, Artikel 4 der Satzung abzuändern und diesen wie folgt
festzulegen:
" Art. 4. Der eingetragene Sitz der Gesellschaft befindet sich in Munsbach, Großherzogtum Luxemburg."
<i>Kosten und Ausgabeni>
Jegliche Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Abgaben in jeglicher Art, die die Gesellschaft aufgrund dieser notariellen
Urkunde zu tragen hat, werden auf EUR 950,- geschätzt.
27395
L
U X E M B O U R G
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache spricht und versteht, stellt hiermit fest, dass die vorliegende
Urkunde in englischer Sprache abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Version; auf Wunsch der erschienenen
Person soll bei Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, die englische Version maßgebend sein.
Worüber die notarielle Urkunde in Junglinster aufgenommen wurde, An dem Tag und zu der Zeit, der bzw. die zu
Beginn dieses Dokuments genannt ist.
Nachdem das Dokument der erschienenen Person vorgelesen wurde, die dem Notar mit ihrem Nachnamen, Vorn-
amen, Personenstand und Wohnsitz bekannt sind, hat diese erschienene Person gemeinsam mit dem Notar die
vorliegende Urkunde unterzeichnet.
Gezeichnet: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/185. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015012355/110.
(150014270) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Diani, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 16.250,00.
Siège social: L-1911 Luxembourg, 9, rue du Laboratoire.
R.C.S. Luxembourg B 191.465.
L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE QUINZE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
INTERNATIONAL TECHNOLOGY SOLUTIONS S. à r. l., société à responsabilité limitée, ayant son siège social au
9, rue du Laboratoire, L 1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section
B sous le numéro 172447,
ici représentée par son gérant unique, Monsieur Adrian DIACONU, directeur de sociétés, demeurant professionnel-
lement au 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg.
Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a prié le notaire instrumentant d'acter que:
- elle est l'unique associée de la société à responsabilité limitée DIANI, ayant son siège social au 9, rue du Laboratoire,
L-1911 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro
191465, ci-après la «Société»;
- la Société a été constituée en date du 17 octobre 2014 suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en voie de
publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 3642 du 1
er
décembre 2014;
- le capital social de la Société s'élève actuellement à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) représenté par 100
(cent) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.
Tout ceci ayant été déclaré, la comparante, représentée comme dit ci-avant, détenant cent pour cent (100%) du capital
de la Société, a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'associée unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de EUR 3.750 (trois mille sept cent cinquante
euros) afin de le porter de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) à EUR 16.250 (seize mille deux cent cinquante
euros) par la création et l'émission de 30 (trente) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-
cinq euros) chacune, émises au pair et bénéficiant des mêmes droits et avantages que les parts sociales actuellement en
circulation.
<i>Souscription - Libérationi>
L'associée unique, représentée comme dit ci-avant, accepte la souscription et la libération des 30 (trente) nouvelles
parts sociales, d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune, par Madame Darja NIKITINA, designer
informaticien, née le 2 avril 1981 à Klaipeda, République de Lituanie et demeurant professionnellement au 9, rue du
Laboratoire, L-1911 Luxembourg, ici présente.
Les 30 (trente) nouvelles parts ont été intégralement libérées moyennant versement en espèces de sorte que la somme
de EUR 3.750 (trois mille sept cent cinquante euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, preuve
en ayant été donnée au notaire instrumentant.
<i>Seconde résolutioni>
Suite à la résolution qui précède, l'associée unique décide de modifier l'article 5 des statuts pour lui donner dorénavant
la teneur suivante:
27396
L
U X E M B O U R G
« Art. 5. Le capital social est fixé à EUR 16.250 (seize mille deux cent cinquante euros) représenté par 130 (cent trente)
parts sociales d'une valeur nominale de EUR 125 (cent vingt-cinq euros) chacune.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société en raison du
présent acte sont évalués à environ EUR 1.200,-.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite au représentant de la comparante, il a signé avec Nous, notaire la présente minute.
Signé: A. DIACONU, D. NIKITINA, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 18 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61047. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015011937/57.
(150014084) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l., Société Anonyme Unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 193.818.
STATUTES
In the year two thousand and fifteen, on the fourteenth day of the month of January.
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the
laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500),
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 186.115, with registered office at L-1882
Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
here represented by Mrs. Julie INDENKLEEF, private employee, residing professionally at L-9242 Diekirch, 4 rue Alexis
Heck, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given in Luxembourg on January 9
th
, 2015.
The proxy signed “ne varietur” by the proxyholder and the undersigned notary, will remain annexed to the present
deed for the purpose of registration.
The appearing party, represented as stated here-above, requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name
“SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by
the law dated August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Company Law”) and by the present articles
of association (the “Articles”).
Art. 2. Registered office.
2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Luxembourg.
2.2 The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the Company’s board of managers. The registered office may further be transferred to any other place within the
Grand Duchy of Luxembourg by a resolution adopted by the shareholders in the manner required to amend the Articles.
2.3. Branches, subsidiaries or other offices may be established either within the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the board of managers. Where the board of managers determines that extraordinary political or military
developments or events have occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the board of managers
and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office,
or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily
transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall
27397
L
U X E M B O U R G
have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office,
shall remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Object. The Company’s purpose is to take participations and interests, in any form whatsoever, in any com-
mercial, industrial, financial and other, Luxembourg or foreign enterprises. The Company’s purpose is, in particular, to
generate significant returns for its shareholders by
(i) locating, analyzing, investing in, acquiring, holding, originating, maintaining, operating, leasing, managing, developing,
improving, mortgaging, encumbering, and selling for profit equity and debt interests in real estate and in securities and
other interests related to real estate, including, without limitation, developable land, rental apartment buildings, office
properties, retail properties, industrial properties, research and development properties, hotels, resorts and destination
complexes, timeshares, motels and other lodging facilities, mixed use properties, telco properties and zoned residential
land and debt instruments secured by real estate or by interests in such real estate,
(ii) participating as a partner, owner or investor in or lender to other general or limited partnerships, limited liability
companies, corporations or other vehicles or Persons, the business of which is related to real estate including, without
limitation, the ownership, sale, leasing, financing, development and/or management thereof or the provision of services
thereto, and
(iii) engaging in all other activities related or incidental thereto.
The Company can perform all commercial, technical and financial operations, connected directly or indirectly in all
areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purpose.
Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in the
manner required to amend the Articles.
4.3 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The Company's corporate capital is set at twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) represented by five
hundred (500) shares in registered form with a nominal value of twenty-five euros (EUR 25.-), all subscribed and fully
paid-up.
5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
shareholders, adopted in the manner required to amend the Articles.
5.3 Any share premium paid in respect of any shares upon their issuance shall be allocated to a share premium account
(the “share premium account” of the Company. Such share premium account may be incorporated into the share capital
of the Company, against the issuance of new shares, subject to the provisions of the Articles. Moreover, the amount of
the said share premium account may be used to provide for the payment of shares, which the Company may redeem
from its respective shareholders, to offset any net losses, to make distributions to the shareholders, or to allocate funds
to the legal reserve.
Art. 6. Shares.
6.1. Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion
to the number of shares in existence.
6.2. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint
owners must appoint a sole person as their representative towards the Company.
6.3. Shares are freely transferable among shareholders. The transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is
subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share
capital of the Company. A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following notification
to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code. For all other matters, reference is
made to articles 189 and 190 of the Company Law.
6.4. A shareholders’ register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions
of the Company Law and may be examined by any shareholder who so requests.
6.5. The Company may redeem its own shares, in the framework of a decrease of its share capital by cancellation of
the redeemed shares, under the following terms and conditions:
(i) the redemption price shall be set by reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the
total amount of any distributable sums in accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the
Articles. Where the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption
may only be decided to the extent that sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price;
27398
L
U X E M B O U R G
(ii) the redemption shall be carried out by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders, representing
at least seventy-five percent (75%) of the share capital; and
(iii) the redeemed shares shall be cancelled following the decrease of the capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Manager(s).
7.1. The Company is managed by one or more managers appointed by the shareholders who set the term of their
office. Managers of the Company need not be shareholders.
7.2 If several managers have been appointed, they shall collectively constitute a board of managers.
7.3 If a sole manager has been appointed, she/he/it shall assume all powers conferred by the Company Law and the
Articles to the board of managers. The sole manager shall have the option of memorializing her/his/its decisions in minutes.
7.4. The managers are eligible for reappointment but may be dismissed at any time ad nutum (i.e. without any reason)
by a resolution of the shareholders. A Manager may resign at any time, but a resigning Manager shall continue to hold
office until his successor has been appointed.
Art. 8. Powers.
8.1. All powers not expressly reserved by the Luxembourg law or the present Articles to the shareholders fall within
the competence of the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations
consistent with the Company’s object.
8.2. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether shareholders
or not, by the board of managers or in accordance with article 10.
Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers may appoint from among its members a chairman, who will preside at all meetings of the
board of managers and of the shareholders. It may also appoint a secretary, who need not be a manager and who will be
responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.
9.2 The board of managers shall meet as often as the Company’s interests so require or upon call of the chairman or
any other manager at the place indicated in the convening notice.
9.3 Written notice of any meeting of the board of managers, regardless of whether such notice is the original or a
copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in
advance of the date set for such meeting, except in the case of an emergency meeting, in which case the nature of such
circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.4 No such convening notice is required if all members of the board of managers are present or represented at the
meeting and if they state to have been duly informed and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The
notice requirement may be waived by the written consent, regardless of whether the original consent or a copy thereof
is delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers. Separate written notice
shall not be required for meetings that are held at times and places designated in a schedule previously adopted by a
resolution of the board of managers.
9.5 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, regardless of whether the
original appointment or a copy thereof delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail, another manager as his proxy. A
manager may also appoint another manager as his proxy by phone, such appointment to be confirmed subsequently in
writing.
9.6 The board of managers may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.
Resolutions of the board of managers are validly taken by a majority of the votes cast. The resolutions of the board of
managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.7 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication that allows all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to in-person participation at
such meeting.
9.8 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting
duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by an original or by a copy delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.
Art. 10. Representation of the Company.
10.1 The Company shall be bound towards third parties by the sole signature of its single manager, and, in case of
plurality of managers, by the single signature of any member of the board or managers or by the joint or single signature
of any person to whom such signatory power shall have been delegated by the board of managers.
10.2 The Company shall furthermore be bound towards third parties by the single or joint signature of any persons
to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2 and within the limits of such
power.
27399
L
U X E M B O U R G
Art. 11. Conflicts of interest.
11.1 In the event that any manager or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the
Company, such manager or officer shall make known to the board of managers such personal interest and shall not
consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such manager’s or officer’s interest therein, shall
be reported to the next succeeding meeting of the shareholders.
11.2 Notwithstanding the above, no contract or other transaction between the Company and any other company or
firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the managers or officers of the Company is
interested in, or is a manager, director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any manager or
officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company
shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm,
be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.
Art. 12. Liability of the managers.
12.1 In connection with their mandate, the managers assume no personal liability for any commitment validly made by
them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles and the applicable
provisions of the Luxembourg law.
12.2 To the extent permissible under Luxembourg law and except as provided for in article 59 paragraph 2 of the
Company Law, a manager shall not be responsible for the acts, omissions or defaults of the other managers, or for any
loss or damage caused by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune
whatsoever which may occur in the performance of their duties, except if the same is caused by his gross negligence or
willful default.
12.3 To the full extent permissible under Luxembourg law, the managers and other officers of the Company, as well
as those persons to whom signatory powers have been validly delegated in accordance with article 8.2, shall be indemnified
out of the assets of the Company for all costs, charges, losses, damages and expenses incurred or sustained by them in
connection with any actions, claims, suits or proceedings to which they may be made a party by reason of being or having
been managers, officers or delegates of the Company, by reason of any transaction carried out by the Company, any
contract entered into or any action performed, concurred in, or omitted, in connection with the execution of their duties,
save for liabilities and expenses caused by from their gross negligence or willful default and in each case without prejudice
to any other rights to which such persons may be entitled.
IV. General Meetings of shareholders
Art. 13. Powers and voting rights.
13.1 The general meeting of shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the
Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all operations of the Company within
the limits of the Company Law.
13.2 Each share is entitled to one vote. Each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.
13.3 Without prejudice to articles 13.4 and 13.5, resolutions of the shareholders shall be adopted at general meetings.
13.4 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by
circular resolution. The shareholders shall be consulted in writing in accordance with article 14.2 and shall cast their vote
by signing the circular resolution. Shareholders shall be obliged to cast their vote and mail it to the Company within fifteen
(15) days as from the sending of the text of the proposed resolution. The signatures of the shareholders may appear on
a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by an original or by a copy
delivered by telegram, telex, facsimile or e-mail.
13.5 The sole shareholder assumes all powers conferred by the Company Law to the general meeting of shareholders.
The decisions of the sole shareholder shall be memorialized in minutes.
Art. 14. Notices, quorum, majority and voting proceedings.
14.1 The shareholders may be convened or consulted by any manager. The board of managers must convene or consult
the shareholders at the request of shareholders representing more than one-half (1/2) of the share capital of the Company.
14.2 The shareholders shall be convened or consulted in writing, whether in original or delivered by telegram, telex,
facsimile or e-mail.
14.3 Written notice of any meeting of the shareholders shall be given to all shareholders at least eight (8) days in
advance of the date set for such meeting, except in case of an emergency, in which case the nature of such circumstances
shall be set forth in the convening notice of the meeting.
14.4 Meetings of the shareholders of the Company shall be held at such place and time as may be specified in the
convening notices for the meetings.
14.5 If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the
Company, and consider themselves as having been duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting
may be held without prior notice.
27400
L
U X E M B O U R G
14.6 A shareholder may act at any meeting of the shareholders of the Company by appointing another person (who
need not be a shareholder) as his proxy, such proxy to be granted in writing, whether in original or delivered by telegram,
telex, facsimile or e-mail.
14.7 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than one-
half (1/2) of the share capital of the Company. If this figure is not reached at the first meeting or upon the first written
consultation, the shareholders shall be convened or consulted a second time by registered letter, and decisions shall be
adopted by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
14.8 However, resolutions to modify or amend the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be
adopted by the majority of the shareholders owning at least three (3/4) quarters of the share capital of the Company.
However, under no circumstances may a majority of the shareholders oblige any shareholders to increase their partici-
pation in the Company.
14.9 The shareholders may only change the nationality of the Company by unanimous vote.
V. Annual accounts - Allocation of profits
Art. 15. Accounting Year and annual general meeting.
15.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first of
December of the same year.
15.2 Each year, with reference to the end of the Company’s accounting year, the Company’s board of managers shall
prepare the balance sheet and the profit and loss accounts of the Company as well as an inventory including the value of
the Company’s assets and liabilities, with an annex summarizing all of the Company’s commitments and the debts of the
manager(s), auditor(s) and shareholders of the Company.
15.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.
15.4 If there are more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be held
at the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office as may be
specified in the convening notice.
15.5 If there are not more than twenty-five (25) shareholders, the annual general meeting of the shareholders shall be
held at such place and time as may be specified in the convening notice for the meeting, such meeting to take place within
the time period set forth by the Company Law.
Art. 16. Allocation of Profits.
16.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve as required by
the Company Law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve is equal to ten per cent (10%)
of the share capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in article 5.
16.2 The general meeting of shareholders has discretionary power to allocate any surplus. It may in particular allocate
such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.
16.3 Interim dividends may be distributed, at any time, pursuant to the following conditions:
(i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the board of managers;
(ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient profits and other reserves (including share
premium) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits
accrued since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves and de-
creased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
(iii) the decision to pay interim dividends is taken by the shareholders of the Company;
(iv) assurance has been given that the rights of the creditors of the Company are not threatened; and
(v) if after the close of the financial year, the amount available for distribution is less than the amount distributed as
an interim dividend, the relevant shareholders shall be required to refund the shortfall to the Company.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 In the event of the dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,
who need not be shareholders, appointed by a resolution of the general meeting of shareholders which will determine
their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholders or by the Company
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the sale of the assets and the payment of the liabilities
of the Company.
17.2 Any surplus remaining from the sale of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid
to the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder of the Company.
27401
L
U X E M B O U R G
VII. General provision
Art. 18. General provision. Reference is made to the provisions of the Company Law and to any agreement which
may be entered into among the shareholders from time to time (if any) for all matters for which no specific provision is
made in these Articles.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on December 31, 2015.
<i>Subscription - Paymenti>
All the five hundred (500) shares representing the capital have been entirely subscribed as follow:
- SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., prenamed,
five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: five hundred shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
and fully paid up in cash, therefore the amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12.500.-) is as now at the
disposal of the Company proof of which has been duly given to the notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of its incorporation are estimated at approximately one thousand two hundred fifty hundred euro (EUR 1,250.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately upon the incorporation of the Company, the sole shareholder of the Company, representing all of the
subscribed share capital, passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The sole shareholder resolves to set at three (3) the number of members of the board of managers and to appoint
the following persons as the managers of the Company for an unlimited period of time:
(i) Mr. Thierry DRINKA, born in Laon (France) on October 11, 1968, with professional address at L-2166 Luxembourg,
3, rue Mozart;
(ii) Mr. Julien PETITFRÈRE, born in Thionville (France) on March 17, 1981, with professional address at L-2166 Lu-
xembourg, 3, rue Mozart;
(ii) Mr. Jerome SILVEY, born in Pennsylvania (USA) on June 27, 1957, with professional address at 591, West Putnam
Avenue, Greenwich, CT 06830, United States of America.
<i>Second resolutioni>
The sole shareholder resolves to establish the registered office of the Company at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation, and in case of any
divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.
WHEREOF the present deed is drawn up in Diekirch, at the office of the undersigned notary, on the date first indicated
in this document.
The present deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, was signed by the proxyholder and
the notary.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quinze, le quatorzième jour du mois de janvier,
par-devant Nous, Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU
1. SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,
avec un capital social de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-), immatriculée auprès du Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro B 186.115, avec siège social au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll,
ici représentée par Madame Julie INDENKLEEF, employée privée, demeurant professionnellement à L-9242 Diekirch,
4, rue Alexis Heck, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé délivrée à Luxembourg
le 9 janvier 2015.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instru-
mentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.
27402
L
U X E M B O U R G
La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante
les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination «SOF-10 Starlight 26
EUR S.à r.l.» (la «Société»), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les
sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi») et par les présents statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg.
2.2 Le siège social de la Société peut être transféré dans les limites de la commune par décision du conseil de gérance.
Le siège social peut également être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution
des associés adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
2.3 Il peut être créé des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu’à l’étranger par
décision du conseil de gérance de la Société si le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d’ordre
politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces évènements seraient de nature à compromettre
l’activité normale de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l’étranger, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l’étranger, jusqu’à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces
mesures provisoires n’auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège
social, restera une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social. L’objet de la Société est de prendre des participations et des intérêts sous quelque forme que ce
soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, qu’elles soient luxembour-
geoises ou étrangères.
Plus particulièrement, la Société a pour objet de générer d’importants bénéfices au profit de ses associés par
(i) La localisation, l’analyse, l’investissement, l’acquisition, la détention, l’initialisation, le soutien, le maintien, le contrôle,
la location, la gestion, le développement, l’amélioration, l’hypothèque, les sûretés et garanties, la vente bénéficiaire et la
conclusion d’emprunts porteurs d’intérêts relatifs à des propriétés immobilières ou titres et autres intérêts liés à l’im-
mobilier, y inclus, sans y être limités, les terres à améliorer et développer, les immeubles de rapport et d’appartements
à louer, les immeubles de bureaux, les maisons unifamiliales, les ensembles industriels, les immeubles de recherche et
développement, les parcs de loisirs, ensembles et complexes hôteliers, les propriétés à temps partiels, motels et autres
lieux d’hébergement, habitations mixtes, propriétés telco et terrains en zone résidentielle, et les emprunts hypothécaires
ou garantis par des sûretés grevant ces droits immobiliers,
(ii) Prendre des participations en tant qu’associé, propriétaire ou investisseur ou bailleur de fonds, comme commandité
ou commanditaire de société en commandite, associé de sociétés à responsabilité limitée, actionnaire de sociétés ano-
nymes, ou autres formes juridiques de personnes morales, dont l’objet commercial est en relation avec le domaine de
l’immobilier, en ce compris, sans y être limité, la propriété, la vente, la location, le financement, le développement et/ou
la gestion de ceux-ci ou la prestation de services y relative, et
(iii) L’engagement et l’implication dans toute autre activité qui pourrait être liée à celles évoquées ci-avant, de manière
directe, indirecte ou accessoire.
La Société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, en relation directe ou indirecte
avec les activités prédécrites aux fins de faciliter l’accomplissement de son objet.
Art. 4. Durée.
4.1 La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2 La Société peut être dissoute, à tout moment, par une résolution des associés de la Société adoptée selon les
modalités requises pour la modification des Statuts.
4.3 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l’interdiction, de l’incapacité, de l’insolvabilité, de la faillite
ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital social - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500.-) représenté par cinq cents
(500) parts sociales sous forme nominative, d’une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-), toutes souscrites et
entièrement libérées.
5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par résolution des associés
adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
5.3 Toute prime d'émission payée lors de l’émission de parts sociales doit être affectée à un compte de prime d'émission
(le “Compte de Prime d'émission des Parts Sociales”) de la Société. Le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales
peut être incorporé dans le capital social de la Société, en échange respectivement de l’émission de nouvelles Parts
Sociales, conformément aux dispositions des Statuts. En outre, le Compte de Prime d'émission des Parts Sociales peut
27403
L
U X E M B O U R G
être utilisé pour effectuer le remboursement de Parts Sociales, que la Société peut racheter aux associés respectifs, pour
compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions, respectivement, aux associés détenant des Parts
Sociales ou pour être affecté à la réserve légale.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Chaque part sociale donne droit à son détenteur à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion
directe avec le nombre des parts sociales existantes.
6.2. Envers la Société, les parts sociales de la Société sont indivisibles, de sorte qu’un seul propriétaire par part sociale
est admis. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.
6.3. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. La cession de parts sociales (inter vivos) à des non
associés est soumise à l’accord préalable de l’assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts (3/4)
du capital social de la Société. Une cession de parts sociales n’est opposable à la Société ou aux tiers qu’après qu’elle a
été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec l’article 1690 du code civil. Pour toutes les autres
questions, il est fait référence aux articles 189 et 190 de la Loi.
6.4. Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi et peut
être consulté par chaque associé qui le désire.
6.5. La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital
souscrit par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes:
(i) le prix de rachat est fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou, s'il est
supérieur, dans la limite du montant total de toutes les sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés
aux parts sociales rachetées tels que prévus par les Statuts. Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale
des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être décidé que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes
sont disponibles pour couvrir l’excédent de prix;
(ii) le rachat est décidé par une résolution prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze
pour cent (75%) du capital social de la Société; et
(iii) les parts sociales rachetées sont annulées immédiatement après la réduction du capital social.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par les associés, qui fixeront la durée de leur mandat. Le
ou les gérants ne sont pas nécessairement associés.
7.2 Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance.
7.3 Si un gérant unique a été nommé, il assume tous les pouvoirs conférés par la Loi et les Statuts au conseil de gérance.
Le gérant unique aura l’option de consigner ses décisions dans des procès-verbaux.
7.4 Les gérants sont rééligibles pour nomination mais révocables à n’importe quel moment ad nutum (sans justifier
d’une raison) par une résolution des associés. Un gérant peut démissionner de son mandat à n’importe quel moment
mais un gérant démissionnaire devra continuer d’exercer son mandat jusqu’à ce qu’un successeur lui soit désigné.
Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts aux associés seront de la compé-
tence du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et activités conformes à l’objet
social de la Société.
8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés
ou non, par le conseil de gérance de la Société ou conformément à l’article 10.
Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance peut nommer parmi ses membres un président, qui présidera toutes les réunions du conseil
de gérance et des associés. Il peut aussi nommer un secrétaire, qui n’a pas besoin d’être un gérant et qui sera responsable
de garder les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.
9.2 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige ou sur convocation d’un gérant au
lieu indiqué dans l’avis de convocation.
9.3 Il sera donné à tous les gérants une convocation, qu’elle soit en original ou en copie envoyée par télégramme,
télex, facsimile ou courriel, de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue
pour la réunion, sauf en cas de réunion urgente, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans la convocation
de la réunion du conseil de gérance.
9.4 Cette convocation écrite n’est pas nécessaire si tous les membres du conseil de gérance de la Société sont présents
ou représentés à la réunion et déclarent avoir été dûment informés et avoir une parfaite connaissance de l’ordre du jour
de la réunion. Il peut aussi être renoncé à l’exigence de convocation écrite avec l’accord écrit de chaque membre du
conseil de gérance que le consentement soit en original, soit en copie envoyée par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique par chaque membre du conseil de gérance. Des convocations écrites séparées ne seront pas exigées pour
27404
L
U X E M B O U R G
des réunions se tenant à une heure et à un endroit prévus dans un calendrier préalablement adopté par résolution du
conseil de gérance de la Société.
9.5 Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance en nommant par écrit, que ce soit en original
ou sur copie par télégramme, télex, facsimile ou courriel, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut éga-
lement nommer un autre gérant comme son mandataire par téléphone, mais cette nomination devra ensuite être
confirmée par écrit.
9.6 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou
représentés. Les décisions du conseil de gérance ne sont prises valablement qu’à la majorité des voix exprimées. Les
résolutions du conseil de gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.
9.7 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout
autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s’identifier, s’entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en
personne à la réunion.
9.8 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants seront valables et engageront la Société comme si elles
avaient été adoptées à une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. Les signatures des gérants peuvent
être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, attestées soit en original soit
en copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courriel.
Art. 10. Représentation.
10.1 La société sera engagée par rapport aux tiers par la seule signature de son gérant unique, et, en cas de pluralité
de gérants, par la seule signature d’un membre du conseil de gérance ou par la signature conjointe ou individuelle de
toute personne à qui un tel pouvoir de signature a été délégué par le conseil de gérance.
10.2 La Société sera en outre engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle ou les signatures conjointes de
toutes personnes à qui un tel pouvoir de signature a été valablement délégué conformément à l’article 8.2 et dans les
limites de ce pouvoir.
Art. 11. Conflit d’intérêts.
11.1. Au cas où un gérant, directeur ou fondé de pouvoir aurait un intérêt personnel dans quelque affaire de la Société,
ce gérant, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le conseil de gérance de son intérêt personnel et il ne délibérera
et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l’intérêt personnel
de pareil gérant, directeur ou fondé de pouvoir à la prochaine assemblée des associés.
11.2 Nonobstant ce qui précède, aucun contrat et aucune transaction que la Société pourra conclure avec d’autres
sociétés ou firmes ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu’un ou plusieurs gérants, directeurs ou fondés de
pouvoir de la Société auraient un intérêt quelconque dans telle autre société ou firme, ou par le fait qu’il en serait gérant,
administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé. Le gérant, directeur ou fondé de pouvoir de la Société,
qui est gérant, administrateur, directeur, fondé de pouvoir ou employé d’une société ou firme avec laquelle la Société
passe des contrats, ou avec laquelle elle est autrement en relations d’affaires, ne sera pas par là même privé du droit de
délibérer, de voter et d’agir en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Art. 12. Responsabilité des gérants.
12.1 Dans le cadre de leur mandat, les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.
12.2 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, et sauf dans les cas prévus à l’article 59, alinéa 2 de la Loi,
un gérant ne sera pas responsable des actes, négligences ou manquements des autres gérants, ou pour toute perte ou
tout dommage causés par une erreur de jugement ou inadvertance de leur part, ou pour toute autre perte, dommage ou
préjudice quelle qu’il soit qui surviendrait lors de l’exécution de son mandat, sauf si cela résulte de, ou est causé par, une
faute lourde ou manquement dolosif lui incombant.
12.3 Dans la mesure permise par le droit luxembourgeois, les gérants et autres fondés de pouvoir de la Société, ainsi
que toutes les personnes à qui des pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l’article 8.2 seront
indemnisés par prélèvement sur les actifs de la Société contre tous les coûts, frais, pertes, dommages et dépenses encourus
ou supportés par eux en relation avec toutes actions, plaintes, procès ou procédures auxquels ils peuvent être partie en
raison de leur statut actuel ou passé de gérants, fondés de pouvoir ou délégués de la Société, en raison de toute transaction
effectuée par la Société, tout contrat conclu ou action accomplie, ou omise ou dans laquelle ils ont participé, en relation
avec l’exécution de leurs obligations, à l’exception des dommages et dépenses dues à leur faute lourde ou manquement
dolosif, dans chaque cas, sans préjudice de tous les autres droits dont ces personnes peuvent jouir.
27405
L
U X E M B O U R G
IV. Assemblées générales des associés
Art. 13. Pouvoirs et droits de vote.
13.1 L’assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l’ensemble des actionnaires de la Société.
Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à toutes les activités de la
Société dans les limites de la Loi.
13.2 Chaque part sociale donne droit à un vote. Chaque associé a des droits de vote proportionnellement au nombre
de parts détenues par celui-ci.
13.3 Sans préjudice des articles 13.4 et 13.5, les résolutions des associés sont adoptées en assemblées générales.
13.4 Si le nombre d’associés n’excède pas vingt-cinq (25) associés, les décisions des associés pourront être prises par
résolution circulaire. Les associés seront consultés par écrit conformément à l’article 14.2 et exprimeront leur vote en
signant la résolution circulaire. Les associés ont l’obligation d’émettre leur vote écrit et de l’envoyer à la Société dans un
délai de quinze (15) jours suivant l’envoi du texte de la résolution proposée. Les signatures des associés peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d’une résolution identique, attestées soit en original soit en
copie émise par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.
13.5 L’associé unique assume tous les pouvoirs conférés par la Loi à l’assemblée générale des associés. Les décisions
de l’associé unique seront consignées en procès-verbaux.
Art. 14. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote.
14.1 Les associés peuvent être convoqués ou consultés par tout gérant de la Société. Le conseil de gérance doit
convoquer ou consulter les associés à la demande des associés représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de
la Société.
14.2 Les associés sont convoqués ou consultés par écrit, soit en original ou par télégramme, télex, facsimile ou courrier
électronique.
14.3 Une convocation écrite à toute assemblée des associés sera donnée à tous les associés au moins huit (8) jours
avant la date fixée de l’assemblée, sauf en cas d’urgence, auquel cas la nature de ces circonstances sera précisée dans la
convocation de ladite assemblée.
14.4 Les assemblées des associés de la Société seront tenues aux lieu et heure précisés dans les convocations res-
pectives des assemblées.
14.5 Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés à l’assemblée des associés et se considèrent eux-
mêmes comme dûment convoqués et informés de l’ordre du jour de l’assemblée, l’assemblée pourra se tenir sans
convocation préalable.
14.6 Un associé peut prendre part à toute assemblée générale des associés de la Société en désignant une autre
personne (associé ou non) comme mandataire, un tel mandat sera donné par écrit, soit en original, soit en copie envoyé
par télégramme, télex, facsimile ou courrier électronique.
14.7 Les décisions collectives ne sont valablement prises que dans la mesure où elles sont adoptées par des associés
détenant plus de la moitié (1/2) du capital social. Si ce chiffre n’est pas atteint à la première assemblée ou première
consultation écrite, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions
seront adoptées à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
14.8 Cependant, les résolutions pour modifier les Statuts ou pour dissoudre et liquider la Société ne peuvent être
adoptées que par la majorité des associés détenant au moins les trois quarts (3/4) du capital social de la Société. Cependant,
en aucun cas la majorité peut obliger un des associés à augmenter sa participation dans la Société.
14.9 Les associés peuvent changer la nationalité de la Société uniquement par vote unanime.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices
Art. 15. Exercice social et assemblée générale annuelle.
15.1 L’exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un
décembre de la même année.
15.2 Chaque année, à la fin de l’exercice social de la Société, le conseil de gérance dresse le bilan et le compte de
pertes et profits de la Société ainsi qu’un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société avec une annexe
résumant tous les engagements de la Société et les dettes des gérant(s), auditeur(s) et des associés de la Société.
15.3 Tout associé peut prendre connaissance de ces inventaires et bilan au siège social de la Société.
15.4 Si le nombre d’associés dépasse vingt-cinq (25) associés, l’assemblée générale annuelle des associés sera tenue au
siège social de la Société ou à tout autre endroit dans la commune du siège social tel que précisé dans la convocation.
15.5 Si le nombre d’associés ne dépasse pas vingt-cinq (25) associés, l’assemblée générale des associés se tiendra au
lieu et heure indiqués dans la convocation respective de l’assemblée.
27406
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Affectation des bénéfices.
16.1. Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société seront affectés à la réserve requise par la loi. Cette
affectation cessera d’être exigée dès que la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social de la Société
tel qu’il est fixé ou tel qu’augmenté ou réduit selon l’article 5.
16.2 L’assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l’affectation du solde des bénéfices nets an-
nuels. Elle pourra en particulier allouer ce bénéfice au paiement d’un dividende, l’affecter à la réserve ou le reporter.
16.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) un état des comptes ou un inventaire ou un rapport est établi par le conseil de gérance;
(ii) cet état des comptes, inventaire ou rapport montre que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime
d’émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder
le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté par les bénéfices reportés et les
réserves distribuables mais réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;
(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est adoptée par les associés de la Société;
(iv) assurance a été obtenue que les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés; et
(v) si, après la clôture de l’exercice social, le montant disponible à la distribution apparaît inférieur au montant distribué
en tant que dividende intérimaire, les associés seront tenus de reverser la différence à la Société.
VI. Dissolution - Liquidation
Art. 17. Dissolution, Liquidation.
17.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, qui n’ont pas
besoin d’être associés, nommés par une résolution de l’associé unique ou de l’assemblée générale des associés qui dé-
terminera leurs pouvoirs et leur rémunération. Sauf disposition contraire prévue par la Loi ou la décision des associés,
les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus larges pour la réalisation des actifs et du paiement des dettes de la
Société.
17.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera distribué
aux associés proportionnellement au nombre d’actions détenues par chaque associé dans la Société.
VII. Dispositions générales
Art. 18. Dispositions générales. Il est fait référence aux dispositions de la Loi et à tout contrat qui peut être conclu
entre les associés de temps à autre (le cas échéant) pour tous les points qui ne font pas l’objet d’une disposition spécifique
dans ces présents Statuts.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social commencera à la date du présent acte et se terminera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Les 500 (cinq cents) parts sociales représentant l’intégralité du capital social ont toutes été souscrites comme suit:
- SOF-10 Lux Master Co S.à r.l., prénommé,
cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Total: cinq cents parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
et ont été intégralement libérées par des versements en numéraire, de sorte que la somme de douze mille cinq cents
euros (EUR 12.500.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu’il en a été justifié au notaire instru-
mentant.
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s’élèvent approximativement à mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250.-).
<i>Résolutions de l’associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l’associé de la Société, représentant l’intégralité du capital social
souscrit a pris les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide de fixer à trois (3) le nombre de gérants et de nommer les personnes suivantes en tant que
gérant de la Société pour une période indéterminée:
(i) M. Thierry DRINKA, né à Laon (France) le 11 octobre 1968, avec adresse professionnelle au L 2166 Luxembourg,
3, rue Mozart,
(ii) M. Julien PETITFRÈRE, né à Thionville (France) le 17 mars 1981, avec adresse professionnelle au L 2166 Luxembourg,
3, rue Mozart,
27407
L
U X E M B O U R G
(ii) M. Jerome SILVEY, né en Pennsylvanie (USA) le 27 juin 1957, avec adresse professionnelle au 591 West Putnam
Avenue, Greenwich, CT 06830, Etats-Unis d’Amérique,
<i>Deuxième résolutioni>
Le siège social de la Société est établi au L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la requête des du mandataire de la partie comparante,
le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une traduction française et qu’en cas de divergence entre le texte anglais et
le texte français, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé à Diekirch, en l’étude du notaire soussigné, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé ensemble avec
le notaire le présent acte.
Signé: J. INDENKLEEF, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 15 janvier 2015. Relation: DAC/2015/666. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.
<i>Le Receveuri>
(signé): THOLL.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Diekirch, le 21 janvier 2015.
Référence de publication: 2015011674/596.
(150013275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 37A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 165.583.
Der Jahresabschluss zum 30. September 2013 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinter-
legt.
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015014381/10.
(150016729) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Mores Pierre S.à r.l. entreprise de constructions, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-4152 Esch-sur-Alzette, 40, rue Jean Jaurès.
R.C.S. Luxembourg B 78.230.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015014474/10.
(150017272) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
MAXimmo, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9740 Boevange, Maison 72.
R.C.S. Luxembourg B 92.246.
Il résulte d'une réunion du Conseil d'Administration du 05.01.2015, que le siège social de la société a été transféré de
son adresse actuelle
L - 9744 Deiffelt Maison 44
à l'adresse suivante:
L - 9740 BOEVANGE Maison 72
Pour extrait sincère et conforme
Signature
Référence de publication: 2015014462/14.
(150016910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
27408
Alonely S.A.
Barraud Investments S.à r.l.
Ciresia
Clamans Counselling S.à r.l.
Constructions & Management Paul S.à r.l.
COSOS (Complete Solutions & Services) S.à r.l.
Craftwave S.à r.l.
CRC CF (LUX) S.à r.l.
Creatherm SA
CTL Participations S.A.
CWEI (Luxembourg) Energy S.à r.l.
CWEI (Luxembourg) Power S.à r.l.
Daobo
Degomex Holding Sàrl
Den Daimerléck, S.à r.l.
Diacine
Diani
Domco S.à r.l.
Dry Mix Solutions Holdings S.à r.l.
Elimmo S.à.r.l.
Entreprise de Peinture Jean-Pierre Wersant & Fils s.à r.l.
Field Investment S.A.
H3 Brand S.à r.l.
Hendrickx Dries S.à r.l.
Hotel-Restaurant Lanners Sàrl
HPF Holding S.A. - SPF
Hydraganymed S.A.
Ilidor S.à r.l.
ILP Acquisitions S.à r.l.
IREEF - Europapark Cologne PropCo S.à r.l.
Kahala LuxCo
LCN IPPT 1
Lux Germes Compléments Vitalité S.à r.l.
Mabledon Holdings UK S.à r.l.
Mangaki
MAXimmo, s.à r.l.
Midarex S.A.
Mores Pierre S.à r.l. entreprise de constructions
PH International Holdings I S.à r.l.
Rodange Investments S.A.
RPTRE I S.à r.l.
Soclair Equipements S.A.
SOF-10 Starlight 26 EUR S.à r.l.
Square 41 S.à r.l.
Structured Solutions
Visitation S.A.