logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 551

27 février 2015

SOMMAIRE

A.G. Consulting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26414

AMM Finance Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26414

Cannon Street Project S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

26417

Capital Financial Holdings Luxembourg SA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26415

Carta Investments S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

26421

Cedar Trust S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26429

Digital Services XXXIV S.à r.l.  . . . . . . . . . .

26435

Groupe PROCEDO SA  . . . . . . . . . . . . . . . . .

26448

MGE Giunchetto Wind Park S.A.  . . . . . . . .

26405

Milos S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26405

MPK Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

26402

Olky Payment Service Provider S.à r.l.  . . .

26402

Opportunity Two  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26402

Orbis Europe S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26403

Orkor Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26402

Orkor Luxco C S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26402

OXEA FINANCE & Cy S.C.A. . . . . . . . . . . .

26403

OXEA Finance S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26403

OXEA Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26403

Pall Mall Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26403

Parabel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26406

Patentportfolio S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26404

PH International Holdings I S.à r.l. . . . . . . .

26406

Rainbow Bridel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26407

Rainbow Bridel SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26407

Rain Man SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26406

Rain Man SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26406

Rain Man SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26407

Red 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26405

Rushold S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26408

Saint Amand GP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26407

Sammarc S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26408

Schomberg (Clinic) Properties S.à r.l. . . . .

26409

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l.  . . . . . . .

26408

SCP OCN Finco Lux S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

26408

Services-Expert S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26409

Société de Gestion Hotelière et de Com-

merces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26409

Taurus Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

26409

TS Car S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26448

Tulsi Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26412

Urban Garden S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26412

US International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26412

UT Luxembourg Holding II S.à r.l.  . . . . . . .

26413

Valdor&K Lux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26413

YeS - Sales & Management S.à r.l.  . . . . . . .

26448

Yum! Finance Holdings III S.à r.l. (en abré-

gé YFH III)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26406

ZIV Group Investment I S.à r.l.  . . . . . . . . . .

26446

26401

L

U X E M B O U R G

MPK Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2339 Luxembourg, 11, rue Christophe Plantin.

R.C.S. Luxembourg B 53.763.

Les statuts coordonnés au 16/12/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26/01/2015.

Me Cosita Delvaux
<i>Notaire

Référence de publication: 2015013702/12.
(150016242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Opportunity Two, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-4940 Bascharage, 111-115, avenue de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 138.966.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Bascharage, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013734/10.
(150016375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Orkor Luxco C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 192.689.

Les statuts coordonnés au 16 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015013735/11.
(150015827) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Orkor Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 177.728.

Les statuts coordonnés au 16 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2015013736/11.
(150015491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Olky Payment Service Provider S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, 1, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 165.776.

L’annexe aux comptes annuels du 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013738/10.
(150015190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

26402

L

U X E M B O U R G

Orbis Europe S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 173.220.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2015013739/11.
(150016351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

OXEA Finance S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 153.453.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013743/10.
(150015534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 153.693.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013744/10.
(150015536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

OXEA Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 153.422.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013745/10.
(150015515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pall Mall Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 136.431.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze.
Le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),

agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-
Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.

A comparu:

BARINVEST S.A., société de droit de Suisse ayant le siège social à 19 via Cantonale, CH-6901 Lugano, enregistrée au

Registre de Commerce du Tessin sous le numéro CHE-107.990.919,

ici représentée par M. Max MAYER, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de

Luxembourg),

26403

L

U X E M B O U R G

en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire

et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, par son représentant susnommé, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit

ses déclarations et constatations:

I.- Que la société anonyme PALL MALL INVEST S.A., ayant son siège social à L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume

Schneider, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 136.431, constituée suivant
acte reçu par devant Maître Joseph ELVINGER, actant en remplacement de Maître Jean Seckler, en date du 22 janvier
2008, publié au Mémorial C numéro 701 du 21 mars 2008.

II.- Que le capital social de la société anonyme PALL MALL INVEST S.A., pré-désignée, s'élève actuellement à trente-

et-un mille euros (EUR 31.000,-), représenté par trois mille cents (3.100) actions d’une valeur nominale de dix euros
(EUR 10,-) chacune.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société anonyme PALL MALL

INVEST S.A..

IV.- Que l’activité de la société PALL MALL INVEST S.A. ayant cessé et que la comparante prononce la dissolution

anticipée de la prédite société avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

V.- Que la comparante, en tant qu’actionnaire unique, se désigne comme liquidateur de la société.
VI.- Qu’en cette qualité, elle requiert le notaire instrumentant d’acter qu’elle déclare avoir réglé tout le passif de la

société dissoute et avoir transféré tous les actifs à son profit.

VII.- Que la comparante est investie de tous les éléments actifs de la société et répondra personnellement de tout le

passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

L’actionnaire  unique  déclare en outre avoir  connaissance des  dettes  fiscales existantes  et s’engage à procéder au

règlement de celles-ci à première demande ainsi qu’à tout autre paiement requis par des tiers ultérieurement à la disso-
lution. Tout paiement non réglé à ce jour et réclamé dans le future sera à charge de l’actionnaire unique.

L’actionnaire unique déclare également que décharge est accordée aux administrateurs ayant agi pour PALL MALL

INVEST S.A. et qu’aucune responsabilité ne doit leur être tenue.

VIII.- Que partant, la liquidation de la société anonyme PALL MALL INVEST S.A. est à considérer comme faite et

clôturée.

IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Qu'il y a lieu de procéder à l’annulation des actions et du registre des actions.
XI.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

social de la société dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à mille six cent vingt-cinq euros, sont à charge de la

société dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom, état et demeure, il

a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 09 janvier 2015. Relation GAC/2015/367. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015013764/60.
(150016365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Patentportfolio S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 119.920.

EXTRAIT

In der außerordentlichen Generalversammlung der Patentportfolio S.à. r.l. am 01.01.2015 wurde folgendes beschlos-

sen:

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft mit Wirkung zum 1. Januar 2015 wird bestellt:
Herr Marc Molitor, wohnhaft: 129 avenue du X septembre, 2551 Luxembourg.

26404

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 06.01.2015.

Pour avis conforme
Marc Molitor
<i>Directeur

Référence de publication: 2015013752/17.
(150016397) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Milos S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 145.857.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 20

<i>janvier 2015

La démission de Monsieur Gioacchino GALIONE de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée.
La société CUSTOM S.A., RCS Luxembourg N B124470, avec siège social au 10 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
MILOS S.A.

Référence de publication: 2015013689/15.
(150015763) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

MGE Giunchetto Wind Park S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 117.207.

EXTRAIT

L'assemblée générale ordinaire réunie à Luxembourg le 31 décembre 2014 a nommé comme nouvel administrateur

de la société:

- Monsieur Marc Koeune, né le 4 octobre 1969 à Luxembourg, domicilié professionnellement au 18, rue de l'Eau L-1449

Luxembourg.

en remplacement de Monsieur Sébastien Gravière.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en l'an 2016.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2015013685/15.
(150015999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Red 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 144.391.

Il est porté à connaissance de tiers que:
- Monsieur Stewart Kam-Cheong a démissionné de sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 21 janvier 2015.
- Monsieur Hermann-Günter Schommarz a démissionné de sa fonction de Gérant de la Société avec effet au 21 janvier

2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013806/14.
(150015830) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

26405

L

U X E M B O U R G

PH International Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Yum! Finance Holdings III S.à r.l. (en abrégé YFH III)).

Capital social: EUR 2.269.559.656,53.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 180.788.

Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013777/10.
(150016398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Parabel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 122.165.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ordentlichen Generalversammlung Abgehalten am Firmensitz Ausserordentlich am 16. Dezember

<i>2014 um 11.00 Uhr

Die Versammlung verlängert einstimmig bis zur Generalversammlung, die im Jahre 2020 stattfinden wird, folgende

Mandate:

- Herr Wilhelmus Johannes SEP, Delegierter des Verwaltungsrates, geboren am 21.11.1959 in Nijmegen (NL), wohnhaft

in NL-3335 EG Zwijndrecht, Opera 27

- Frau Marchje W. KOSTER-KWAKERNAAK, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 17.03.1955 in Reeuwijk (NL),

beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn, 7, route du Vin

- Frau Silke KOSTER, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 29.03.1981 in Trier (D), beruflich wohnhaft in L-5401 Ahn,

7, route du Vin

Das Mandat des Aufsichtskommissars FIRELUX S.A., eingeschrieben im Handelsregister Luxemburg unter der Nummer

B 84 589, mit Sitz in L-9053 Ettelbrück, 45, Avenue J.F. Kennedy wird ebenfalls verlängert bis zur Generalversammlung
die im Jahre 2020 stattfinden wird.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Der Verwaltungsrat

Référence de publication: 2015013769/22.
(150015931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Rain Man SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 80.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013814/9.
(150015518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Rain Man SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 80.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013815/9.
(150015698) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

26406

L

U X E M B O U R G

Rain Man SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 80.418.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013816/9.
(150015699) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Rainbow Bridel SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 137.406.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013817/9.
(150016192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Rainbow Bridel SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 137.406.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013818/9.
(150016193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Saint Amand GP, Société Anonyme.

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 14, Porte de France.

R.C.S. Luxembourg B 180.546.

- L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 5 Décembre 2014 a décidé de créer deux

classes d'administrateurs, une classe A et une classe B. L'Assemblée Générale Extraordinaire approuve la poursuite des
mandats de Mr. Eric FORT et Mr. Max WELBES en qualité d'administrateurs de classe A.

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires a pris acte de la démission de:
- Summit Trust International S.A. ayant son siège social 6, Place des Eaux-Vives, CH-1200 Genève, SUISSE représenté

par Melle. Kim MORGAN ayant la même adresse professionnelle

et a nommé pour son remplacement:
- Mme Sara SPEED, ayant pour adresse professionnelle 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
en sa qualité d'administrateur classe B pour une période prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire

qui se tiendra en 2015.

- L'Assemblée Général Extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 30 Décembre 2014 a décidé de révoquer:
* Ernst &amp; Young 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
et de nommer:
* KPMG Luxembourg S.à.r.l, 9 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
en qualité de Réviseur d'entreprises agréé pour une période prenant fin lors de la prochaine Assemblée Générale

Ordinaire qui se tiendra en 2015.

<i>Pour Saint Amand GP
Société anonyme
RBC Investor Services Bank S.A.
Société Anonyme

Référence de publication: 2015013833/27.
(150016391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

26407

L

U X E M B O U R G

Rushold S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 130.028.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2015013832/14.
(150016217) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.571.

Par résolutions prises en date du 19 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Flavio Porciani, avec adresse professionnelle au Berkeley Square House, 5 

th

 Floor, Berkeley Square,

W1J 6BR Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

2. Acceptation de la démission de Darren Glatt, avec adresse professionnelle au 745, Fifth Avenue, 27 

th

 Floor, NY

10151 New York, Etats-Unis de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013867/17.
(150016185) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

SCP OCN Finco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 15.000,00.

Siège social: 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 193.578.

Par résolutions prises en date du 19 janvier 2015, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination de Flavio Porciani, avec adresse professionnelle au Berkeley Square House, 5 

th

 Floor, Berkeley Square,

W1J 6BR Londres, Royaume-Uni, au mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat et pour une période venant
à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice social se clôturant au 31
décembre 2015 et qui se tiendra en 2016;

2. Acceptation de la démission de Darren Glatt, avec adresse professionnelle au 745, Fifth Avenue, NY 10151 New

York, Etats-Unis de son mandat de gérant de catégorie A, avec effet immédiat;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013868/17.
(150016184) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Sammarc S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 119.729.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue au siège social à Luxembourg, le 22

<i>janvier 2015

La démission de Monsieur Gioacchino GALIONE de son poste de commissaire aux comptes de la société est acceptée

et décharge lui a été donnée.

26408

L

U X E M B O U R G

La société CUSTOM S.A., RCS Luxembourg N B124470, avec siège social au 10 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

est nommée nouveau commissaire aux comptes de la société. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Gé-
nérale Statutaire de l'an 2015.

Pour extrait sincère et conforme
SAMMARC S.A.

Référence de publication: 2015013861/16.
(150015858) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Schomberg (Clinic) Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 129.958.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013836/10.
(150015301) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Services-Expert S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5485 Wormeldange-Haut, 20, Henneschtgaass.

R.C.S. Luxembourg B 148.971.

Les comptes annuels au 31-12-2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015013876/11.
(150016041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Société de Gestion Hotelière et de Commerces, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 60.341.

Les comptes annuels au 30 Décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015013890/10.
(150015482) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Taurus Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 172.261.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

Taurus Petroleum (USA) LLC, a limited liability company having its registered office at 2711 Centerville Road, Suite

400, Wilmington DE 19808, County of New Castle, Delaware (United States of America) and registered with the State
of Delaware, Department of State, Division of Corporations under number 3307020 (the “Sole Shareholder”);

here represented by Ms. Carmen ANDRE, Lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a proxy

established on 8 December 2014.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

26409

L

U X E M B O U R G

It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “Taurus Luxembourg S.à r.l.”, governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 6C Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies Register under number B 172261 and incorporated pursuant to a deed of Maître Edouard Delosch, notary
residing in Diekirch, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 16 October 2012, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2850 page 136760 dated 23 November 2012 (hereafter referred to as the “Company”).
The Company’s articles of incorporation (the “Articles”) have not been amended since that time.

The share capital of the Company is currently set at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000.-) represented

by two hundred (200) shares (parts sociales) with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100.-)
each, all fully subscribed and entirely paid up.

All this having been declared, the appearing party, holding 100% of the share capital of the Company, represented as

stated here above, has immediately proceeded to hold an extraordinary general meeting and has decided to vote on all
items of the following agenda:

a) Approval of the interim financial statements established for the period from 1 

st

 January 2014 to the day of putting

the Company into liquidation (the “Interim Financial Statements”);

b) Vote on the discharge of the board of directors (“conseil de gérance”) of the Company for the performance of

their duties for the period from 1 

st

 January 2014 to the day of putting the Company into liquidation;

c) Early dissolution of the Company and putting of the Company into liquidation;
d) Appointment of a liquidator (“liquidateur”) and determination of its powers; and
e) Miscellaneous.

<i>First resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to approve the Interim Financial Statements.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to grant discharge to the members of the board of directors (“conseil de gérance”)

of the Company with respect to the performance of their duties for the period from 1 

st

 January 2014 to the date hereof.

<i>Third resolution

In compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time (the “Law”),

the Sole Shareholder RESOLVES to dissolve the Company and to start liquidation proceedings.

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder DECIDES to appoint as liquidator (“liquidateur”) of the Company:
- MAS Luxembourg, S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws

of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6C Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand-
Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 91999 (the
“Liquidator”).

The aforesaid Liquidator must realise the whole of the assets and liabilities of the Company. The Liquidator is exempted

from the obligation of drawing up an inventory, and may in this respect rely fully on the books of the Company, especially
the Interim Financial Statements drawn up as at 19 December 2014.

The Liquidator may under its own responsibility and regarding special or specific transactions, delegate such part of

its powers as it may deem fit, to one or several representatives.

The Liquidator binds validly and without limitation the Company in the process of being liquidated.
The Liquidator has the authority to perform and execute all transactions provided for in Articles 144 and 145 of the

Law, without specific authorisation therefore from the general shareholder’s meeting.

The Liquidator may pay advances on the liquidation surplus after having paid the debts or made the necessary provisions

for the payment of the debts or it may transfer all assets and liabilities of the Company to its sole shareholder upon
commitment of the latter to pay any debts incurred presently or in the future.

<i>Closure of the meeting

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing person,

the present deed is worded in English, followed by a French version, on request of the same appearing person and in case
of discrepancies between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately EUR 1,000.-.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.
The document having been read to the person appearing, he signed together with the notary the present original deed.

26410

L

U X E M B O U R G

Suit la version française du texte qui précède:

En l’an deux mille quatorze, le dix-neuvième jour de décembre,
Par-devant, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Taurus Petroleum (USA) LLC, une limited liability company ayant son siège social au 2711 Centerville Road, Suite 400,

Wilmington DE 19808, County of New Castle, Delaware (Etats-Unis d’Armérique) et immatriculée auprès de l’Etat de
Delaware, Département de l’Etat, Division des Sociétés sous le numéro 3307020 (l’«Associé Unique»);

ici représentée par Madame Carmen ANDRE, Juriste, avec adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée le 8 décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisées avec elles.

La partie comparante, représentée comme indiquée ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu’elle est l’Associé Unique d’une société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Taurus Luxem-

bourg S.à r.l.», régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C Rue Gabriel Lippmann,
5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg sous le numéro B 172261 et constituée suivant acte du notaire Maître Edouard Delosch, notaire de résidence
à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 16 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2850 page 136760 en date du 23 novembre 2012 (ci-après désignée comme la «Société»). Les statuts
de la Société (les «Statuts») n’ont pas été modifiés depuis cette date.

Le capital social de la Société s’élève actuellement à vingt mille Dollars des Etats Unis (USD 20.000,-) représenté par

deux cents (200) parts sociales d'une valeur nominale de cent Dollars des Etats Unis (USD 100,-) chacune, toutes entiè-
rement souscrites et libérées.

Ceci ayant été déclaré, la partie comparante, dûment représentée comme décrit ci-dessus, détenant 100% du capital

social de la Société, a immédiatement procédé à la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et a décidé de voter
sur tous les points de l’agenda reproduit ci-après:

a) Approbation des états financiers intérimaires établis pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 au jour de la mise

en liquidation de la Société (les “Etats Financiers Intérimaires”);

b) Vote sur la décharge au conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leur mandat durant la période allant du

er

 janvier 2014 au jour de la mise en liquidation de la Société;

c) Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation de la Société;
d) Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs; et
e) Divers.

<i>Première résolution

L’Associé Unique DECIDE d’approuver les Etats Financiers Intérimaires.

<i>Seconde résolution

L’Associé Unique DECIDE d’accorder décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’accomplis-

sement de leurs mandats pour la période allant du 1 

er

 janvier 2014 jusqu’à ce jour.

<i>Troisième résolution

Conformément à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (la «Loi»), l’Associé Unique

DÉCIDE de dissoudre la Société et de procéder à sa mise en liquidation volontaire.

<i>Quatrième résolution

L’Associé Unique DÉCIDE de nommer en tant que liquidateur de la Société:
- MAS Luxembourg, S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social au 6C Rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91999 (le «Liquidateur»).

Le Liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la Société. Le Liquidateur est dispensé

de l’obligation de dresser un inventaire et peut à ce titre se référer pleinement aux écritures de la Société sur la comp-
tabilité de la Société, en particulier les Etats Financiers Intérimaires au 19 décembre 2014.

Le Liquidateur pourra sous sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou

partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires.

Le Liquidateur peut engager valablement et sans limitation la Société en cours de liquidation.
Le Liquidateur dispose du pouvoir pour toutes les opérations prévus aux Articles 144 et 145 de la Loi, sans avoir

besoin d’être préalablement autorisés par l’assemblée générale de l’associé.

26411

L

U X E M B O U R G

Le Liquidateur peut payer des avances sur le boni de liquidation après avoir payé les dettes ou avoir fait les provisions

nécessaires pour le paiement des dettes ou il peut transférer tout l’actif et le passif de la Société à son associé unique sur
accord de ce dernier de payer toutes les dettes actuelles encourues ou futures.

<i>Clôture de l’assemblée

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, déclare qu'à la demande de la comparante, le présent acte est

écrit en anglais, suivi d'une version en langue française. A la demande de la même comparante, il est déclaré qu'en cas de
désaccord entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais prévaudra.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou

mises à sa charge en raison des présentes est évalué à EUR 1.000,-.

DONT ACTE notarié, dressé et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite à la personne comparante, celle-ci a signé l’original du présent acte avec le notaire instrumentant.
Signé: C. ANDRÉ, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62929. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015013919/142.
(150015504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Tulsi Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2155 Luxembourg, 91, Muehlenweg.

R.C.S. Luxembourg B 172.522.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales daté du 12 octobre 2014 que le propriétaire unique du capital de

la société est comme suit:

MR SATI LILA DHAR
91, Muehlenweg
L-2155 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 parts

Luxembourg, le 12 octobre 2014.

<i>Pour la société
Mr SATI LILA DHAR

Référence de publication: 2015013953/16.
(150016306) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Urban Garden S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1911 Luxembourg, 36, rue du Laboratoire.

R.C.S. Luxembourg B 163.545.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 12 janvier 2015

L'Actionnaire unique décide avec effet immédiat de transférer le siège social de la société au 36, rue du laboratoire à

L-1911 Luxembourg.

Référence de publication: 2015013958/10.
(150015685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

US International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1520 Luxembourg, 11, rue Adolphe Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 46.527.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

26412

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 25 janvier 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L - 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015013960/14.
(150015649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

UT Luxembourg Holding II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 103.594.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

(conforme Art. 316 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales).

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Johannes de Zwart
<i>Gérant

Référence de publication: 2015013961/13.
(150015772) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Valdor&amp;K Lux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-4761 Pétange, 27, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 160.867.

DISSOLUTION

L'an deux mil quatorze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Gérard LECUIT, notaire de résidence à Luxembourg.

A COMPARU:

Monsieur Hugues HUBERT, indépendant, né le 28 juillet 1965 à Bouillon, demeurant à 4, rue Laiche, B-6824 Florenville

(Belgique),

ici représenté par Monsieur Jean Claude BUFFIN, comptable, résidant professionnellement au Pétange,
en vertu d'une procuration sous seing privé du 20 décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire du comparant et le notaire ins-

trumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Lequel comparant, représenté comme dit-est, a requis le notaire instrumentant d'acter:
- Qu'il est le seul et l'unique actionnaire de la société VALDOR&amp;K LUX S.A., ayant son siège social à L-4761 Pétange,

27, route de Luxembourg, immatriculée au RCS Luxembourg sous le numéro B 160.867 (ci-après dénommée la «Société»),
constituée par le notaire instrumentant en date du 27 avril 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associa-
tions, numéro 1593 du 16 juillet 2011; Les statuts n'ayant pas été modifiés depuis;

- que le capital social de la Société s'élève à trente-et-un mille euros (31.000,- EUR) représenté par trois mille cents

(3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune, entièrement libérées;

- que le comparant, précité, est le seul propriétaire de toutes les actions et qu'il déclare avoir parfaite connaissance

des statuts et de la situation financière de la Société;

- que le comparant, représenté comme mentionné ci-avant, en sa qualité d'actionnaire unique de la Société, a décidé

de procéder à la dissolution anticipée et immédiate de la Société et de la mettre en liquidation;

- que l'actionnaire unique, en sa qualité de liquidateur de la Société et au vu du bilan de la Société au 19 décembre

2014, déclare que tout le passif de la Société, y compris le passif lié à la liquidation de la Société, est réglé ou dûment
provisionné;

Le comparant déclare encore que:
- l'activité de la Société a cessé;
- l'actionnaire unique est investi de l'entièreté de l'actif de la Société et déclare prendre à sa charge l'entièreté du passif

de la Société qu'il soit connu et impayé, ou inconnu et non encore payé, le bilan au 19 décembre 2014 étant seulement
un des éléments d'information à cette fin;

- suite aux résolutions ci-avant, la liquidation de la Société est à considérer comme accomplie et clôturée;
- décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société;

26413

L

U X E M B O U R G

- il y a lieu de procéder à l'annulation de toutes les actions et/ou du registre des actionnaires;
- les livres et documents de la Société devront être conservés pendant la durée légale de cinq ans à L-4761 Pétange,

27, route de Luxembourg.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison de présentes, sont évalués approximativement à mille euros (1.000,-EUR).

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant connu du notaire par ses nom, prénom

usuels, état et demeure, il a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: J.-C. BUFFIN, G. LECUIT.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63596. Reçu soixante-quinze euros

(EUR 75,-).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Référence de publication: 2015013964/57.
(150016360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

A.G. Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1143 Luxembourg, 15, rue Astrid.

R.C.S. Luxembourg B 70.737.

<i>Extrait du Procès-verbal des décisions prises par l'administrateur unique en date du 23 janvier 2015

<i>Première résolution

Afin de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au

porteur, l'administrateur unique décide de nommer FASCOLUX S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois
ayant son siège social au 15, rue Astrid, L-1143 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg, sous le numéro B 168121 en qualité de dépositaire.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour A.G.CONSULTING S.A.

Référence de publication: 2015014008/15.
(150017242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

AMM Finance Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-8210 Mamer, 106, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 99.080.

EXTRAIT

Le siège social de la société a été transféré à l'adresse suivante:
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Grand-Duché de Luxembourg
Ce transfert prend effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Mamer, le 27.01.2015.

Pour extrait conforme
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015014049/17.
(150017318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

26414

L

U X E M B O U R G

Capital Financial Holdings Luxembourg SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 106.025.

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem (Luxembourg),

a comparu:

la société «FOTSO GROUP HOLDINGS LIMITED», une société de droit chypriote, ayant son siège social à Agiou

Paviou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P C 1105 Nicosie, République de Chypre, enregistrée au Registre des Sociétés
de la République de Chypre sous le numéro HE 177373,

ici représentée par Monsieur Jean-Pierre VERLAINE, employé privé, demeurant professionnellement au 3/a rue Guil-

laume Kroll L-1882 Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée le 17 décembre 2014,

agissant en sa qualité de seul et unique actionnaire de la société «Capital Financial Holdings Luxembourg S.A.» (la

«Société»), une société anonyme, établie et ayant son siège social actuellement au 16 rue Jean l’Aveugle L-1148 Luxem-
bourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, section B sous le numéro 106025 constituée
suivant acte notarié en date du 7 janvier 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 557
du 9 juin 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés en dernier lieu suivant acte notarié en date du 4 décembre 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 144 du 18 janvier 2008.

Laquelle partie comparante, agissant en sa qualité d’actionnaire unique de la Société a requis le notaire soussigné d’acter

les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’actionnaire unique décide de transférer le siège social de la société de L-1148 Luxembourg, 16 rue Jean l’Aveugle à

L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

<i>Deuxième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’objet social de la société et décide de modifier en conséquence l’article 3

des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 3. Objet. L’objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou

indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration,
la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou

indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les
opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d'immeubles.

La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques,

qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.»

<i>Troisième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 5 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 5. Capital Social. Le capital social souscrit est fixé à dix-sept millions trente et un mille euros (EUR 17.031.000,-)

représenté par dix-sept millions trente et un mille (17.031.000) actions d’une valeur nominale d’un euro (EUR 1,-) cha-
cune.»

<i>Quatrième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Nature des Actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l’actionnaire, sous réserve des

restrictions prévues par la loi.

Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire,

selon le cas, répondant aux conditions de l’Article 42, (2), de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle
qu’amendée. Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Luxembourg dans lequel les actions au porteur
sont inscrites au nom de l’actionnaire propriétaire des actions.

26415

L

U X E M B O U R G

La société reconnaît les personnes au nom desquelles les actions sont enregistrées dans le registre des actionnaires

comme les pleins propriétaires de ces actions.

A la demande des actionnaires, des certificats d’inscription nominatifs seront délivrés aux actionnaires par la Société

ou par le dépositaire en cas d’actions au porteur.»

<i>Cinquième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 10 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 10. Conseil d’Administration. La société sera administrée par un conseil d'administration composé de trois

membres au moins, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires de la société. Toutefois, lorsque la société est constituée par
un  actionnaire  unique  ou  que,  à  une  assemblée  générale  des  actionnaires,  il  est  constaté  que  celle-ci  n’a  plus  qu’un
actionnaire unique, la composition du conseil d’administration peut être limitée à un (1) membre jusqu’à l’assemblée
générale ordinaire suivant la constatation de l’existence de plus d’un actionnaire.

Les administrateurs seront élus par l’assemblée générale des actionnaires qui fixe leur nombre, leurs émoluments et

la durée de leur mandat. Les administrateurs sont élus pour un terme qui n'excédera pas six (6) ans, jusqu'à ce que leurs
successeurs soient élus.

Les administrateurs seront élus à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés.
Tout administrateur pourra être révoqué avec ou sans motif à tout moment par décision de l’assemblée générale des

actionnaires.

Au cas où le poste d'un administrateur devient vacant à la suite de décès, de démission ou autrement, cette vacance

peut être temporairement comblée jusqu'à la prochaine assemblée générale, aux conditions prévues par la loi du 10 août
1915 sur les sociétés commerciales, telle qu’amendée.»

<i>Sixième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 14 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 14. Représentation de la Société. La Société sera engagée soit par la signature collective de deux (2) adminis-

trateurs dont obligatoirement celle de l’administrateur-délégué, soit par la signature unique de l’administrateur-délégué,
soit  par  la  signature  unique  de  toute(s)  personne(s)  à  laquelle  (auxquelles)  pareils  pouvoirs  de  signature  auront  été
délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d’administration est composé d’un seul membre, la société
sera engagée par sa seule signature.»

<i>Septième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 13 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 13. Délégation de Pouvoirs. Le conseil d’administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la

société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être
actionnaires de la société.»

<i>Huitième résolution

L’actionnaire décide d’accepter la démission des membres du conseil d’administration et décide de leur donner dé-

charge pour l’exécution de leur mandat jusqu’à ce jour.

L’actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouvel administrateur unique de la Société pour une période

d’un an, son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale de l’année 2016: Monsieur Guy Arlette, demeurant
professionnellement à L-1882 Luxembourg, 3/A rue Guillaume Kroll.

<i>Neuvième résolution

L’actionnaire décide d’accepter la démission du commissaire et décide de lui donner décharge pour l’exécution de son

mandat jusqu’à ce jour.

L’actionnaire unique décide de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes de la Société pour une période

de un an, son mandat venant à échéance lors de l’assemblée générale de l’année 2016: Engelwood Management &amp; Con-
sulting S.à r.l., ayant son siège social à L-1882 Luxembourg, 3/A rue Guillaume Kroll.

<i>Dixième résolution

L’actionnaire décide d’instaurer un capital autorisé de trente millions d’euros (30.000.000.- EUR) qui sera représenté

par trente millions (30.000.000) actions d’une valeur nominale d’un euros (EUR 1.-) chacune.

L’assemblée autorise le conseil d’administration en outre à émettre des emprunts obligataires convertibles dans le

cadre du capital autorisé.

Après avoir entendu le rapport du conseil d’administration prévu par l’article 32-3 (5) de la loi concernant les sociétés

commerciales, l’assemblée autorise le conseil d‘administration à procéder à des augmentations de capital dans le cadre
du capital autorisé et notamment avec l’autorisation de limiter ou de supprimer le droit préférentiel de souscription des

26416

L

U X E M B O U R G

actionnaires lors de l’émission d’actions nouvelles et lors de l’émission d’obligations convertibles dans le cadre du capital
autorisé.

Ce rapport restera annexé aux présentes.
Cette autorisation est valable pour un période de cinq ans expirant le 18 décembre 2019.

<i>Onzième résolution

L’actionnaire unique décide de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 6. Modification du Capital Social. Le capital social souscrit peut être augmenté ou réduit par décision de l’as-

semblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

Le capital social de la société pourra être porté de son montant actuel à trente millions d’euros (30.000.000.- EUR)

qui sera représenté par trente millions (30.000.000) actions d’une valeur nominale d’un euros (EUR 1.-) chacune.

Le Conseil d’administration est autorisé et mandaté:
- à réaliser cette augmentation de capital en une seule fois ou par tranches successives par émission d'actions nouvelles,

à libérer par voie de versements en espèces, d'apports en nature, par transformation de créances ou encore, sur appro-
bation de l’assemblée générale annuelle, par voie d'incorporation de bénéfices ou réserves de capital;

- à fixer le lieu et la date de l’émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions et modalités de

souscription et de libération des actions nouvelles.

- à supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel des actionnaires quant à l’émission ci-dessus mentionnée

d'actions supplémentaires contre apports en espèces ou en nature.

Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans prenant fin le 18 décembre 2019 et peut être renouvelée

par une assemblée générale des actionnaires quant aux actions du capital autorisé qui d'ici là n'auront pas été émises par
le Conseil d’administration.

A la suite de chaque augmentation de capital réalisée et dûment constatée dans les formes légales, le premier alinéa

de cet article se trouvera modifié de manière à correspondre à l’augmentation intervenue; cette modification sera cons-
tatée dans la forme authentique par le Conseil d’administration ou par toute personne qu'il aura mandatée à ces fins.

De même, le Conseil d’administration est autorisé à émettre des emprunts obligataires convertibles sous forme d’ob-

ligations au porteur ou autre, sous quelque dénomination que ce soit et payables en quelque monnaie que ce soit, étant
entendu que toute émission d’obligations convertibles ne pourra se faire que dans le cadre du capital autorisé. Le Conseil
d’administration déterminera la nature, le prix, le taux d’intérêt, les conditions d’émission et de remboursement et toutes
autres conditions y ayant trait. Un registre des obligations nominatives sera tenu au siège social de la société.

Le capital social souscrit et autorisé de la société peuvent être augmentés ou réduits par décision de l’assemblée

générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée racheter ses propres actions.».

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée par le notaire, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire

instrumentant le présent procès-verbal.

Signé: J.P.VERLAINE, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 29 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18373. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015014110/148.
(150016696) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Cannon Street Project S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 146.542.

L'an deux mille quinze, le six janvier.
Par-devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A COMPARU:

Rolle Real Estate Investments Limited, une société des Iles Vierges Britanniques, ayant son siège social à Trust Offices,

197 Main Street, Road Town, Iles Vierges Britanniques, et inscrite auprès du Registrar of Corporate Affairs sous le numéro
1436273, (l'«Associé Unique»);

Ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employée, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu

d'une procuration établie le 22 décembre 2014.

26417

L

U X E M B O U R G

Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la partie comparante et le notaire instru-

mentant, restera annexée au présent acte pour les besoins d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme stipulé ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
Qu'elle est l'Associé Unique d'une société à responsabilité limitée existant sous la dénomination de «Cannon Street

Project S.àr.l.», une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre
de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 146.542 et constituée suivant acte reçu par Maître
Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 4 juin 2009, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations numéro 1280 du 3 juillet 2009 (ci-après désignée comme la «Société») et dont les
statuts de la Société (les «Statuts») ont été modifiés en dernier lieu suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en
date du 25 août 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1959 en date du 8 octobre
2009.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à douze mille cinq cents Euros (EUR 12.500) représenté par cinq

cents (500) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25) chacune, toutes entièrement souscrites et
libérées.

L'Associé Unique, dûment représenté comme décrit ci-dessus, a reconnu être dûment informé des résolutions à

prendre, a décidé de voter sur tous les points de l'agenda reproduit ci-après:

a) Modification de l'article 3 des statuts de la Société («Objet») afin de lui donner la teneur suivante:
«L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans des

sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii) l'acqui-
sition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions,
d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'acquisition, la
propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut conclure
tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y relatif.

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de

notes et d'autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.

La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du

groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui
serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des
garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que
la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation
requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie
de ses avoirs.

La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue

de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
tout autre risque.

De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et

de supervision et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet
social.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, la Société pourra effectuer
toute opération commerciale industrielle ou financière, ainsi que toute transaction concernant des biens meubles ou
immeubles, qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.»

b) Divers.
En conséquence et sur base de l'agenda repris ci-dessus, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L'Associé Unique DECIDE de modifier l'objet social de la Société et en conséquence de modifier l'article 3 des Statuts

de la Société, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 3. Objet. L'objet de la Société est (i) la détention de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit,

dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, des entités de type partenariats (partnerships) ou d'autres entités, (ii)
l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre,
d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et (iii) l'ac-
quisition, la propriété, l'administration, le développement, la gestion et la disposition de son portefeuille. La Société peut
conclure tout contrat relatif à l'acquisition, la souscription ou la gestion des instruments précités et au financement y
relatif.

26418

L

U X E M B O U R G

La Société peut emprunter sous toute forme et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes, de

notes et d'autres instruments convertibles ou non, sans offre au public.

La Société peut accorder une assistance et prêter des fonds à ses filiales, sociétés affiliées, à toute autre société du

groupe ainsi qu'à toutes autres entités ou personnes, étant entendu que la Société ne conclura aucune transaction qui
serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation requise. Elle pourra également fournir des
garanties et octroyer des sûretés en faveur de parties tierces afin de garantir ses propres obligations ou bien les obligations
de ses filiales, sociétés affiliées ou toute autre société du groupe, ainsi qu'à toute autre entité ou personne pourvu que
la Société ne conclut pas une transaction qui serait considérée comme une activité réglementée sans obtenir l'autorisation
requise. La Société pourra également hypothéquer, gager, transférer, grever ou autrement hypothéquer tout ou partie
de ses avoirs.

La Société peut généralement employer toute technique et utiliser tout instrument relatif à ses investissements en vue

de leur gestion efficace, y compris la conclusion de toute transaction à terme ainsi que des techniques et instruments
destinés à protéger la Société contre le risque de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
tout autre risque.

De manière générale elle peut accorder son assistance à des sociétés affiliées, prendre toute mesure de contrôle et

de supervision et mener toute opération qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet
social.

La Société peut employer ses fonds en investissant dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout

autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, la Société pourra effectuer
toute opération commerciale industrielle ou financière, ainsi que toute transaction concernant des biens meubles ou
immeubles, qu'elle jugerait utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature qu'ils soient, incombant à la société à raison du

présent acte, sont estimés à neuf cents Euros (900,-EUR).

<i>Déclaration

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle la langue anglaise, déclare qu'à la demande du comparant, le présent

acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête dudit comparant, en cas de divergence entre
le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte ayant été donnée à la mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec

le notaire.

Suit la traduction anglaise du texte qui précède:

Before us Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

THERE APPEARED:

Rolle Real Estate Investments Limited, a British Virgin Islands company, with registered office at Trust Offices, 197

Main Street, Road Town, British Virgin Islands, and registered with the Registrar of Corporate Affairs under number
1436273, (the “Sole Shareholder”);

hereby represented by Mrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of a proxy

established on 22 

nd

 of December 2014.

The said proxy after having been signed "ne varietur" by the attorney of the appearing party and the undersigned notary

will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
It is the Sole Shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the

name of “Cannon Street Project S.àr.l.” a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand-Duchy of
Luxembourg, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 146.542 and incorporated
pursuant to a deed of Maître Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, dated 4 

th

 June 2009,

published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1280 on 3 

rd

 of July 2009 (hereafter referred

to as the “Company”). The Company's articles of incorporation (the “Articles”) have been amended pursuant to a deed
of Maître Seckler, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, on the 25 

th

 of August 2009, published in

the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1959, the 8 

th

 of October 2009.

The share capital of the Company is currently set at twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) represented

by five hundred (500) shares (parts sociales), with a par value of twenty-five Euros (EUR 25) each, all subscribed and fully
paid-up.

26419

L

U X E M B O U R G

The Sole Shareholder, duly represented as stated hereinabove, having recognized to be fully informed of the resolutions

to be taken, has decided to vote on all items of the following agenda:

a) Amendment of Article 3 of the articles of incorporation of the Company (“Object”), so that it shall henceforth read

as follows:

“The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever in Luxembourg

and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner
as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any
kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its portfolio. The
Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the aforementioned
instruments and the financing thereof.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments

convertible or not, without a public offer.

The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company

as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be
considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and in-
struments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other
risks.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or
financial operations and any transactions with respect to movable or immovable property, which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.”

b) Miscellaneous.
Consequently, on the basis of the above agenda, the Sole Shareholder has taken the following sole resolution:

<i>Sole resolution

The Sole Shareholder RESOLVES to amend the corporate object of the Company and consequently to amend Article

3 of the Articles of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

“ Art. 3. Object. The object of the Company is (i) the holding of participations and interests in any form whatsoever

in Luxembourg and foreign companies, partnerships or other entities, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in
any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other
securities of any kind, and (iii) the acquisition, ownership, administration, development, management and disposal of its
portfolio. The Company may enter into any agreements relating to the acquisition, subscription or management of the
aforementioned instruments and the financing thereof.

The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, debentures, notes and other instruments

convertible or not, without a public offer.

The Company may grant assistance and lend funds to its subsidiaries, affiliated companies, to any other group company

as well as to other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which would be
considered as a regulated activity without obtaining the required licence. It may also give guarantees and grant security
in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other
group company as well as other entities or persons provided that the Company will not enter into any transaction which
would be considered as a regulated activity without obtaining the required licence. The Company may further mortgage,
pledge, transfer, encumber or otherwise hypothecate all or some of its assets.

The Company may generally employ any techniques and utilize any instruments relating to its investments for the

purpose of their efficient management, including the entry into any forward transactions as well as techniques and in-
struments designed to protect the Company against credit risk, currency fluctuations, interest rate fluctuations and other
risks.

In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and

carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or

immovable assets in any kind or form. In a general fashion the Company may carry out any commercial, industrial or

26420

L

U X E M B O U R G

financial operations and any transactions with respect to movable or immovable property, which it may deem useful in
the accomplishment and development of its purposes.”

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of the present deed are estimated at approximately nine hundred euros (900,-EUR).

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing person and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 13 janvier 2015. Relation GAC/2015/416. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015014109/201.
(150016914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Carta Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 488.111,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 175.331.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December,
before us, Maître Marc Loesch, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

was held

an extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Carta Investments S.à r.l., a private limited

liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 175.331 and having a share
capital of four hundred six thousand three hundred thirty United States Dollars (USD 406,330.-) (the Company). The
Company  has  been  incorporated  on  January  17,  2013  pursuant  to  a  deed  of  Maître  Jean  Seckler,  notary  residing  in
Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on April 12,
2013 number 876. The articles of association of the Company have amended for the last time on December 19, 2013
pursuant to a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on February 25, 2014 number 500.

There appeared:

1. Ludvik Unit Trust (formerly Lava Unit Trust), a trust established and existing under the laws of England and Wales,

acting through its trustee, Deutsche Transnational Trustee Corporation Inc., a Swiss Branch having its address at 3, place
des Bergues, 1201 Geneva, Switzerland and registered with the Registre de Commerce du canton de Genève under
number CH 660.0.906.006-8 (Ludvik Unit Trust),

here represented by Frank Stolz, notary clerk, with professional address in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Lu-

xembourg, by virtue of a proxy given under private seal on December 10, 2014;

2. Ursula Unit Trust (formerly Crystal Unit Trust), a trust established and existing under the laws of England and Wales,

acting through its trustee, Deutsche Transnational Trustee Corporation Inc., prenamed (Ursula Unit Trust),

here represented by Frank Stolz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on December 10, 2014;
3. Ridgewood Unit Trust, a trust established and existing under the laws of Jersey, acting through its trustee, Cidel

Trust Services Inc., a corporation having its registered office at R.G. Hodge Plaza, 3 rd Floor, Wickams Cay 1, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands and registered with the Register of the British Virgin Islands under number 635739 (Rid-
gewood Unit Trust),

here represented by Frank Stolz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on December 12, 2014; and

26421

L

U X E M B O U R G

4. Summerville Unit Trust, a trust established and existing under the laws of Jersey, acting through its trustee, Cidel

Trust  Services  Inc.,  prenamed  (Summerville  Unit  Trust  and  together  with  Ludvik  Unit  Trust,  Ursula  Unit  Trust  and
Ridgewood Unit Trust, the Shareholders),

here represented by Frank Stolz, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal on December 12, 2014.
The said proxies, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned

notary, shall remain attached to this notarial deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing parties, represented as described above, have requested the undersigned notary to record the fol-

lowing:

I. That the Shareholders hold all the shares in the share capital of the Company;
II. That the agenda of the Meeting is worded as follows:
1. Waiver of convening notices;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of eighty-one thousand seven hundred eighty-one United

Stated Dollars (USD 81,781.-) in order to bring the share capital of the Company from its present amount of four hundred
six thousand three hundred thirty United States Dollars (USD 406,330.-), represented by (i) seventy-three thousand eight
hundred seventy-eight (73,878) class A shares (the Class A Shares), (ii) seventy-three thousand eight hundred seventy-
eight (73,878) class B shares (the Class B Shares), (iii) one hundred seventy-four thousand seven hundred fifty-seven
(174,757) class C shares (the Class C Shares) and (iv) eighty-three thousand eight hundred seventeen (83,817) class D
shares (the Class D Shares),, all such shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, to four
hundred eighty-eight thousand one hundred eleven United States Dollars (USD 488,111.-), by way of the issue of (i)
fourteen thousand eight hundred sixty-nine (14,869) new Class A Shares, (ii) fourteen thousand eight hundred sixty-nine
(14,869) new Class B Shares, (iii) thirty-five thousand one hundred seventy-three (35,173) new Class C Shares and (iv)
sixteen thousand eight hundred seventy (16,870) new Class D Shares, all such shares having a par value of one United
States Dollar (USD 1.-) per share, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares of the
relevant class.

3. Subscriptions to and payments of the increase of the share capital as described in item 2. above by contributions in

kind.

4. Subsequent amendment to the first (1 

st

 ) paragraph of article six (6) of the articles of association of the Company

(the Articles) in order to reflect the increase of the share capital adopted under item 2. above.

5. Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the increase of share capital adopted

under item 2. above with power and authority given to any manager of the Company (each an Authorized Representative),
each individually, to proceed in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares
in the register of shareholders of the Company.

6. Miscellaneous.
III. That the Shareholders have taken the following resolutions unanimously:

<i>First Resolution:

The entirety of the corporate share capital being represented at the present Meeting, the Shareholders resolve to

waive the convening notices, considering themselves as duly convened and declaring having perfect knowledge of the
agenda which has been communicated to them in advance.

<i>Second Resolution:

The Shareholders resolve to increase and hereby increase the share capital of the Company by an amount of eighty-

one thousand seven hundred eighty-one United Stated Dollars (USD 81,781.-) in order to bring the share capital of the
Company  from  its  present  amount  of  four  hundred  six  thousand  three  hundred  thirty  United  States  Dollars  (USD
406,330.-), represented by (i) seventy-three thousand eight hundred seventy-eight (73,878) Class A Shares, (ii) seventy-
three  thousand  eight  hundred  seventy-eight  (73,878)  Class  B  Shares,  (iii)  one  hundred  seventy-four  thousand  seven
hundred fifty-seven (174,757) Class C Shares and (iv) eighty-three thousand eight hundred seventeen (83,817) Class D
Shares, all such shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-) per share, to four hundred eighty-eight
thousand one hundred eleven United States Dollars (USD 488,111.-), by way of the issue of (i) fourteen thousand eight
hundred sixty-nine (14,869) new Class A Shares, (ii) fourteen thousand eight hundred sixty-nine (14,869) new Class B
Shares, (iii) thirty-five thousand one hundred seventy-three (35,173) new Class C Shares and (iv) sixteen thousand eight
hundred seventy (16,870) new Class D Shares, all such shares having a par value of one United States Dollar (USD 1.-)
per share, with such shares having the same rights and obligations as the existing shares of the relevant class.

<i>Third Resolution:

The Shareholders resolve to accept and record the following subscriptions to and full payments of the capital increase

as follows:

26422

L

U X E M B O U R G

<i>Subscriptions - Payments

1) Ludvik Unit Trust, prenamed, hereby declares that it subscribes to fourteen thousand eight hundred sixty-nine

(14,869) new Class A Shares and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting in a claim in an amount of
fourteen thousand eight hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) (the Claim 1) that Ludvik Unit Trust
has against the Company.

The contribution in kind of the Claim 1 from Ludvik Unit Trust to the Company is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim 1 is evidenced to the undersigned notary by inter alia (i) the

interim balance sheet of the Company as at December 18, 2014 signed for approval by the management of the Company
and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of Ludvik Unit Trust and acknowledged and approved
by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the interim balance sheet (the Balance Sheet) shows a Claim 1 in an amount of at least fourteen thousand eight

hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) payable by the Company to Ludvik Unit Trust;

- Ludvik Unit Trust holds the Claim 1, is solely entitled to the Claim 1 and possesses the power to dispose of the

Claim 1;

- the Claim 1 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Claim 1 contributed to the Company is, as per the attached

Balance Sheet, of at least fourteen thousand eight hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) and since the
date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to
the Company;

- the Claim 1 contributed to the Company is freely transferable by Ludvik Unit Trust to the Company and is not subject

to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim 1 to the Company have been or will be accomplished by

Ludvik Unit Trust immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution of the
Claim 1 by Ludvik Unit Trust to the Company and upon the contribution of the Claim 1 by Ludvik Unit Trust to the
Company, the Company will become the full owner of the Claim 1 which will be extinguished by way of a confusion
(extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

2) Ursula Unit Trust, prenamed, hereby declares that it subscribes to fourteen thousand eight hundred sixty-nine

(14,869) new Class B Shares and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting in a claim in an amount of
fourteen thousand eight hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) (the Claim 2) that Ursula Unit Trust
has against the Company.

The contribution in kind of the Claim 2 from Ursula Unit Trust to the Company is to be allocated to the nominal share

capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim 2 is evidenced to the undersigned notary by inter alia (i) the

interim balance sheet of the Company as at December 18, 2014 signed for approval by the management of the Company
and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of Ursula Unit Trust and acknowledged and approved
by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the interim balance sheet (the Balance Sheet) shows a Claim 2 in an amount of at least fourteen thousand eight

hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) payable by the Company to Ursula Unit Trust;

- Ursula Unit Trust holds the Claim 2, is solely entitled to the Claim 2 and possesses the power to dispose of the

Claim 2;

- the Claim 2 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Claim 2 contributed to the Company is, as per the attached

Balance Sheet, of at least fourteen thousand eight hundred sixty-nine United States Dollars (USD 14,869.-) and since the
date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to
the Company;

- the Claim 2 contributed to the Company is freely transferable by Ursula Unit Trust to the Company and is not subject

to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim 2 to the Company have been or will be accomplished by

Ursula Unit Trust immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution of the
Claim 2 by Ursula Unit Trust to the Company and upon the contribution of the Claim 2 by Ursula Unit Trust to the
Company, the Company will become the full owner of the Claim 2 which will be extinguished by way of a confusion
(extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

3) Ridgewood Unit Trust, prenamed, hereby declares that it subscribes to thirty-five thousand one hundred seventy-

three (35,173) new Class C Shares and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting in a claim in an amount
of thirty-five thousand one hundred seventy-three United States Dollars (USD 35,173.-) (the Claim 3) that Ridgewood
Unit Trust has against the Company.

26423

L

U X E M B O U R G

The contribution in kind of the Claim 3 from Ridgewood Unit Trust to the Company is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim 3 is evidenced to the undersigned notary by inter alia (i) the

interim balance sheet of the Company as at December 18, 2014 signed for approval by the management of the Company
and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of Ridgewood Unit Trust and acknowledged and
approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the interim balance sheet (the Balance Sheet) shows a Claim 3 in an amount of at least thirty-five thousand one

hundred seventy-three United States Dollars (USD 35,173.-) payable by the Company to Ridgewood Unit Trust;

- Ridgewood Unit Trust holds the Claim 3, is solely entitled to the Claim 3 and possesses the power to dispose of the

Claim 3;

- the Claim 3 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Claim 3 contributed to the Company is, as per the attached

Balance Sheet, of at least thirty-five thousand one hundred seventy-three United States Dollars (USD 35,173.-) and since
the date of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made
to the Company;

- the Claim 3 contributed to the Company is freely transferable by Ridgewood Unit Trust to the Company and is not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim 3 to the Company have been or will be accomplished by

Ridgewood Unit Trust immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution
of the Claim 3 by Ridgewood Unit Trust to the Company and upon the contribution of the Claim 3 by Ridgewood Unit
Trust to the Company, the Company will become the full owner of the Claim 3 which will be extinguished by way of a
confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

4) Summerville Unit Trust, prenamed, hereby declares that it subscribes to sixteen thousand eight hundred seventy

(16,870) new Class D Shares and fully pays up such shares by a contribution in kind consisting in a claim in an amount of
sixteen thousand eight hundred seventy United States Dollars (USD 16,870.-) (the Claim 4) that Summerville Unit Trust
has against the Company.

The contribution in kind of the Claim 4 from Summerville Unit Trust to the Company is to be allocated to the nominal

share capital account of the Company.

The valuation of the contribution in kind of the Claim 4 is evidenced to the undersigned notary by inter alia (i) the

interim balance sheet of the Company as at December 18, 2014 signed for approval by the management of the Company
and (ii) a certificate issued on the date hereof by the management of Summerville Unit Trust and acknowledged and
approved by the management of the Company. It results from such certificate that, as of the date of such certificate:

- the interim balance sheet (the Balance Sheet) shows a Claim 4 in an amount of at least sixteen thousand eight hundred

seventy United States Dollars (USD 16,870.-) payable by the Company to Summerville Unit Trust;

- Summerville Unit Trust holds the Claim 4, is solely entitled to the Claim 4 and possesses the power to dispose of

the Claim 4;

- the Claim 4 is certain and will be due and payable on its due date without deduction (certaine, liquide et exigible);
- based on generally accepted accounting principles, the Claim 4 contributed to the Company is, as per the attached

Balance Sheet, of at least sixteen thousand eight hundred seventy United States Dollars (USD 16,870.-) and since the date
of the Balance Sheet, no material changes have occurred which would have depreciated the contribution made to the
Company;

- the Claim 4 contributed to the Company is freely transferable by Summerville Unit Trust to the Company and is not

subject to any restrictions or encumbered with any pledge or lien limiting its transferability or reducing its value; and

- all formalities to transfer the legal ownership of the Claim 4 to the Company have been or will be accomplished by

Summerville Unit Trust immediately upon receipt of a certified copy of the notarial deed documenting the contribution
of the Claim 4 by Summerville Unit Trust to the Company and upon the contribution of the Claim 4 by Summerville Unit
Trust to the Company, the Company will become the full owner of the Claim 4 which will be extinguished by way of a
confusion (extinction par confusion) for the purposes of article 1300 of the Luxembourg Civil Code.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing resolutions, the Shareholders resolve to amend the first (1 

st

 ) paragraph of article

six (6) of the Articles in order to reflect the above changes which shall henceforth read as follows:

“ Art. 6. The corporate capital is set at four hundred eighty-eight thousand one hundred eleven United States Dollars

(USD 488,111.-) represented by eighty-eight thousand seven hundred forty-seven (88,747) class A shares (the Class A
Shares), eighty-eight thousand seven hundred forty-seven (88,747) class B shares (the Class B Shares), two hundred nine
thousand nine hundred thirty (209,930) class C shares (the Class C Shares) and one hundred thousand six hundred eighty-
seven (100,687) class D shares (the Class D Shares and together with the Class A Shares, the Class B Shares and the
Class D Shares, the Shares), all with a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each.”

26424

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth Resolution:

The Shareholders resolve to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the increase of

share capital as adopted above and empowers and authorizes any Authorized Representative, each individually, to proceed
in the name and on behalf of the Company with the registration of the newly issued shares in the register of shareholders
of the Company.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, on the day named at the beginning of this

document.

This document having been read to the proxyholder of the appearing parties, who is known to the undersigned notary

by his/her surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing parties signed the present
deed together with the undersigned notary.

Suit la traduction en français du texte qui précède:

L’an deux mille quatorze, le dix-huitième jour du mois de décembre, pardevant nous, Maître Marc Loesch, notaire de

résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

s’est tenue

une assemblée générale extraordinaire (l’Assemblée) des associés de Carta Investments S.à r.l., une société à respon-

sabilité limitée constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 175.331, et ayant un capital social de quatre cent six mille trois cent
trente Dollars Américains (USD 406.330,-) (la Société). La Société a été constituée le 17 janvier 2013 suivant un acte de
Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations numéro 876 du 12 avril 2013. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le
19 décembre 2013 suivant un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de
Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 500 du 25 février 2014.

Ont comparu:

1. Ludvik Unit Trust (anciennement Lava Unit Trust), un trust établi et existant selon les lois d’Angleterre et des Pays-

Bas, agissant par l’intermédiaire de son fiduciaire, Deutsche Transnational Trustee Corporation Inc., une succursale suisse
ayant son adresse au 3, place des Bergues, 1201 Genève, Suisse et immatriculée auprès du Registre de Commerce du
canton de Genève sous le numéro CH 660.0.906.006-8 (Ludvik Unit Trust),

ici représenté par Frank Stolz, clerc de notaire, ayant son adresse professionnelle à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché

de Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 10 décembre 2014;

2. Ursula Unit Trust (anciennement Crystal Unit Trust), un trust établi et existant selon les lois d’Angleterre et des

Pays-Bas, agissant par l’intermédiaire de son fiduciaire, Deutsche Transnational Trustee Corporation Inc., prénommé
(Ursula Unit Trust),

ici représenté par Frank Stolz, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 10 décembre 2014;
3. Ridgewood Unit Trust, un trust établi et existant selon les lois de Jersey, agissant par l’intermédiaire de son fiduciaire,

Cidel Trust Services Inc., une société ayant son siège social à R.G. Hodge Plaza, 3 

rd

 Floor, Wickhams Cay 1, Road Town,

Tortola, Iles Vierges Britanniques et immatriculée auprès du Registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 635739
(Ridgewood Unit Trust),

ici représenté par Frank Stolz, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 12 décembre 2014;

et

4. Summerville Unit Trust, un trust établi et existant selon les lois de Jersey, agissant par l’intermédiaire de son fiduciaire,

Cidel Trust Services Inc., prénommé (Summerville Unit Trust et ensemble avec Ludvik Unit Trust, Ursula Unit Trust et
Ridgewwod Unit Trust, les Associés),

ici représenté par Frank Stolz, prénommé, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 12 décembre 2014.
Lesquelles procurations, après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes ainsi que par

le notaire soussigné, resteront annexées au présent acte notarié pour être soumises avec lui aux formalités de l’enregis-
trement.

Lesquelles parties comparantes, représentées tel que décrit ci-dessus, ont requis le notaire soussigné d’acter ce qui

suit:

26425

L

U X E M B O U R G

I. Que les Associés détiennent toutes les parts sociales dans le capital social de la Société;
II. Que l’ordre du jour de l’Assemblée est le suivant:
1. Renonciation aux formalités de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-un Dollars

Américains (USD 81.781,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre cent six mille
trois cent trente Dollars Américains (USD 406.330,-), représenté par (i) soixante-treize mille huit cent soixante dix-huit
(73.878) parts sociales de catégorie A (les Parts Sociales de Catégorie A), (ii) soixante-treize mille huit cent soixante dix-
huit (73.878) parts sociales de catégorie B (les Parts Sociales de Catégorie B), (iii) cent soixante-quatorze mille sept cent
cinquante-sept (174.757) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales de Catégorie C) et (iv) quatre-vingt-trois mille
huit cent dix-sept (83.817) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de Catégorie D), toutes ces parts sociales
ayant une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) par part sociale, à quatre cent quatre-vingt-huit mille cent
onze Dollars Américains (USD 488.111,-) par l’émission de (i) quatorze mille huit cent soixante-neuf (14.869) nouvelles
Parts Sociales de Catégorie A, (ii) quatorze mille huit cent soixante-neuf (14.869) nouvelles Parts Sociales de Catégorie
B, (iii) trente-cinq mille cent soixante-treize (35.173) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et (iv) seize mille huit cent
soixante-dix (16.870) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, toutes ces parts sociales ayant une valeur nominale d’un
Dollar Américain (USD 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales
existantes de la catégorie concernée.

3. Souscriptions à et libérations de l’augmentation du capital social telle que décrite au point 2. ci-dessus par des apports

en nature.

4. Modification subséquente du premier (1 

er

 ) paragraphe de l’article six (6) des statuts de la Société (les Statuts) afin

de refléter l’augmentation du capital social adoptée au point 2. ci-dessus.

5. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social adoptée au point

2. ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société (chacun un Représentant Autorisé), chacun
individuellement, afin de procéder au nom et pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement
émises dans le registre des associés de la Société.

6. Divers.
III. Que les Associés ont pris les résolutions suivantes à l’unanimité:

<i>Première résolution:

L’entièreté du capital social étant représentée à la présente Assemblée, les Associés décident de renoncer aux for-

malités de convocation, se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre
du jour qui leur a été communiqué à l’avance.

<i>Deuxième résolution:

Les Associés décident d’augmenter le capital social de la Société d’un montant de quatre-vingt-un mille sept cent quatre-

vingt-un Dollars Américains (USD 81.781,-) afin de porter le capital social de la Société de son montant actuel de quatre
cent six mille trois cent trente Dollars Américains (USD 406.330,-), représenté par (i) soixante-treize mille huit cent
soixante dix-huit (73.878) Parts Sociales de Catégorie A, (ii) soixante-treize mille huit cent soixante dix-huit (73.878)
Parts Sociales de Catégorie B, (iii) cent soixante-quatorze mille sept cent cinquante-sept (174.757) Parts Sociales de
Catégorie C et (iv) quatre-vingt-trois mille huit cent dix-sept (83.817) Parts Sociales de Catégorie D, toutes ces parts
sociales ayant une valeur nominale d’un Dollar Américain (USD 1,-) par part sociale, à quatre cent quatre-vingt-huit mille
cent onze Dollars Américains (USD 488.111,-) par l’émission de (i) quatorze mille huit cent soixante-neuf (14.869) nou-
velles  Parts  Sociales  de  Catégorie  A,  (ii)  quatorze  mille  huit  cent  soixante-neuf  (14.869)  nouvelles  Parts  Sociales  de
Catégorie B, (iii) trente-cinq mille cent soixante-treize (35.173) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et (iv) seize mille
huit cent soixante-dix (16.870) nouvelles Parts Sociales de Catégorie D, toutes ces parts sociales ayant une valeur nominale
d’un Dollar Américain (USD 1,-) par part sociale, ces parts sociales ayant les mêmes droits et obligations que les parts
sociales existantes de la catégorie concernée.

<i>Troisième résolution:

Les Associés décident d’accepter et d’enregistrer les souscriptions suivantes ainsi que les libérations intégrales de

l’augmentation du capital comme suit:

<i>Souscriptions - Libérations

1) Ludvik Unit Trust, prénommé, déclare par la présente qu’il souscrit à quatorze mille huit cent soixante-neuf (14.869)

nouvelles Parts Sociales de Catégorie A et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en
une créance d’un montant de quatorze mille huit cent soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-) (la Créance 1)
que Ludvik Unit Trust détient envers la Société.

L’apport en nature de la Créance 1 de Ludvik Unit Trust à la Société sera alloué au compte du capital social nominal

de la Société.

26426

L

U X E M B O U R G

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 1 est documentée au notaire soussigné, entre autres, par (i) le bilan

intérimaire de la Société au 18 décembre 2014 signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat
émis à la date des présentes par la gérance de Ludvik Unit Trust et pris en considération et approuvé par la gérance de
la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- le bilan intérimaire en annexe (le Bilan) montre la Créance 1 d’un montant d’au moins quatorze mille huit cent

soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-) payable par la Société à Ludvik Unit Trust;

- Ludvik Unit Trust est le seul titulaire de la Créance 1 et possède le droit d’en disposer;
- la Créance 1 est certaine, liquide et exigible à sa date d’effet sans déduction aucune;
- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance 1 apportée à la Société est, conformément

au Bilan, d’au moins quatorze mille huit cent soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-), et aucun changement
substantiel n’est intervenu depuis la date du Bilan qui aurait pu déprécier l’apport fait à la Société;

- la Créance 1 apportée à la Société est librement cessible par Ludvik Unit Trust à la Société et n’est grevée d’aucun

nantissement ou usufruit qui pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités requises pour la cession de la propriété légale de la Créance 1 à la Société ont été ou seront

accomplies par Ludvik Unit Trust immédiatement suivant réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant
l’apport de la Créance 1 par Ludvik Unit Trust à la Société et au moment de l’apport de la Créance 1 par Ludvik Unit
Trust à la Société, la Société deviendra la seule propriétaire de la Créance 1, laquelle sera éteinte par voie de confusion
pour les besoins de l’article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

2) Ursula Unit Trust, prénommé, déclare par la présente qu’il souscrit à quatorze mille huit cent soixante-neuf (14.869)

nouvelles Parts Sociales de Catégorie B et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en
une créance d’un montant de quatorze mille huit cent soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-) (la Créance 2)
que Ursula Unit Trust détient envers la Société.

L’apport en nature de la Créance 2 d’Ursula Unit Trust à la Société sera alloué au compte du capital social nominal de

la Société.

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 2 est documentée au notaire soussigné, entre autres, par (i) le bilan

intérimaire de la Société au 18 décembre 2014 signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat
émis à la date des présentes par la gérance d’Ursula Unit Trust et pris en considération et approuvé par la gérance de la
Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- le bilan intérimaire en annexe (le Bilan) montre la Créance 2 d’un montant d’au moins quatorze mille huit cent

soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-) payable par la Société à Ursula Unit Trust;

- Ursula Unit Trust est le seul titulaire de la Créance 2 et possède le droit d’en disposer;
- la Créance 2 est certaine, liquide et exigible à sa date d’effet sans déduction aucune;
- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance 2 apportée à la Société est, conformément

au Bilan, d’au moins quatorze mille huit cent soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-), et aucun changement
substantiel n’est intervenu depuis la date du Bilan qui aurait pu déprécier l’apport fait à la Société;

- la Créance 2 apportée à la Société est librement cessible par Ursula Unit Trust à la Société et n’est grevée d’aucun

nantissement ou usufruit qui pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités requises pour la cession de la propriété légale de la Créance 2 à la Société ont été ou seront

accomplies par Ursula Unit Trust immédiatement suivant réception d’une copie certifiée de l’acte notarié documentant
l’apport de la Créance 2 par Ursula Unit Trust à la Société et au moment de l’apport de la Créance 2 par Ursula Unit
Trust à la Société, la Société deviendra la seule propriétaire de la Créance 2, laquelle sera éteinte par voie de confusion
pour les besoins de l’article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

3) Ridgewood Unit Trust, prénommé, déclare par la présente qu’il souscrit à trente-cinq mille cent soixante-treize

(35.173) nouvelles Parts Sociales de Catégorie C et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature
consistant en une créance d’un montant de trente-cinq mille cent soixante-treize Dollars Américains (USD 35.173,-) (la
Créance 3) que Ridgewood Unit Trust détient envers la Société.

L’apport en nature de la Créance 3 de Ridgewood Unit Trust à la Société sera alloué au compte du capital social

nominal de la Société.

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 3 est documentée au notaire soussigné, entre autres, par (i) le bilan

intérimaire de la Société au 18 décembre 2014 signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat
émis à la date des présentes par la gérance de Ridgewood Unit Trust et pris en considération et approuvé par la gérance
de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- le bilan intérimaire en annexe (le Bilan) montre la Créance 3 d’un montant d’au moins trente-cinq mille cent soixante-

treize Dollars Américains (USD 35.173,-) payable par la Société à Ridgewood Unit Trust;

- Ridgewood Unit Trust est le seul titulaire de la Créance 3 et possède le droit d’en disposer;
- la Créance 3 est certaine, liquide et exigible à sa date d’effet sans déduction aucune;

26427

L

U X E M B O U R G

- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance 3 apportée à la Société est, conformément

au Bilan, d’au moins quatorze mille huit cent soixante-neuf Dollars Américains (USD 14.869,-), et aucun changement
substantiel n’est intervenu depuis la date du Bilan qui aurait pu déprécier l’apport fait à la Société;

- la Créance 3 apportée à la Société est librement cessible par Ridgewood Unit Trust à la Société et n’est grevée

d’aucun nantissement ou usufruit qui pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités requises pour la cession de la propriété légale de la Créance 3 à la Société ont été ou seront

accomplies par Ridgewood Unit Trust immédiatement suivant réception d’une copie certifiée de l’acte notarié docu-
mentant l’apport de la Créance 3 par Ridgewood Unit Trust à la Société et au moment de l’apport de la Créance 3 par
Ridgewood Unit Trust à la Société, la Société deviendra la seule propriétaire de la Créance 3, laquelle sera éteinte par
voie de confusion pour les besoins de l’article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

4) Summerville Unit Trust, prénommé, déclare par la présente qu’il souscrit à seize mille huit cent soixante-dix (16.870)

nouvelles Parts Sociales de Catégorie D et libère intégralement ces parts sociales par un apport en nature consistant en
une créance d’un montant de seize mille huit cent soixante-dix Dollars Américains (USD 16.870,-) (la Créance 4) que
Summerville Unit Trust détient envers la Société.

L’apport en nature de la Créance 4 de Summerville Unit Trust à la Société sera alloué au compte du capital social

nominal de la Société.

L’évaluation de l’apport en nature de la Créance 4 est documentée au notaire soussigné, entre autres, par (i) le bilan

intérimaire de la Société au 18 décembre 2014 signé pour approbation par la gérance de la Société et (ii) un certificat
émis à la date des présentes par la gérance de Summerville Unit Trust et pris en considération et approuvé par la gérance
de la Société. Il résulte de ce certificat que, à la date dudit certificat:

- le bilan intérimaire en annexe (le Bilan) montre la Créance 4 d’un montant d’au moins seize mille huit cent soixante-

dix Dollars Américains (USD 16.870,-) payable par la Société à Summerville Unit Trust;

- Summerville Unit Trust est le seul titulaire de la Créance 4 et possède le droit d’en disposer;
- la Créance 4 est certaine, liquide et exigible à sa date d’effet sans déduction aucune;
- fondée sur les principes comptables généralement acceptés, la Créance 4 apportée à la Société est, conformément

au Bilan, d’au moins seize mille huit cent soixante-dix Dollars Américains (USD 16.870,-), et aucun changement substantiel
n’est intervenu depuis la date du Bilan qui aurait pu déprécier l’apport fait à la Société;

- la Créance 4 apportée à la Société est librement cessible par Summerville Unit Trust à la Société et n’est grevée

d’aucun nantissement ou usufruit qui pourrait limiter sa cessibilité ou réduire sa valeur; et

- toutes les formalités requises pour la cession de la propriété légale de la Créance 4 à la Société ont été ou seront

accomplies par Summerville Unit Trust immédiatement suivant réception d’une copie certifiée de l’acte notarié docu-
mentant l’apport de la Créance 4 par Summerville Unit Trust à la Société et au moment de l’apport de la Créance 4 par
Summerville Unit Trust à la Société, la Société deviendra la seule propriétaire de la Créance 4, laquelle sera éteinte par
voie de confusion pour les besoins de l’article 1300 du Code Civil luxembourgeois.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des résolutions qui précèdent, Les Associés décident de modifier le premier paragraphe de l’article

six (6) des Statuts afin de refléter les modifications ci-dessus, qui aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quatre-vingt-huit mille cent onze Dollars Américains (USD

488.111,-), représenté par quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-sept (88.747) parts sociales de catégorie A (les Parts
Sociales de Catégorie A), quatre-vingt-huit mille sept cent quarante-sept (88.747) parts sociales de catégorie B (les Parts
Sociales de Catégorie B), deux cent neuf mille neuf cent trente (209.930) parts sociales de catégorie C (les Parts Sociales
de Catégorie C) et cent mille six cent quatre-vingt-sept (100.687) parts sociales de catégorie D (les Parts Sociales de
Catégorie D, et ensemble avec les Parts Sociales de Catégorie A, Parts Sociales de Catégorie B et Parts Sociales de
Catégorie C, les Parts Sociales), toutes d’une valeur nominale de un Dollar Américain (USD 1,-) chacune.»

<i>Cinquième résolution:

Les Associés décident de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter l’augmentation du capital social

adoptée ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout Représentant Autorisé, chacun individuellement, afin de pro-
céder au nom et pour le compte de la Société à l’inscription des parts sociales nouvellement émises dans le registre des
associés de la Société.

<i>Estimation des frais

Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du

présent acte sont estimés à mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare par les présentes qu’à la demande des parties comparantes,

le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la demande des mêmes parties comparantes, en cas
de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, date qu’en tête des présentes.

26428

L

U X E M B O U R G

Après  lecture  faite  au  mandataire  des  parties  comparantes,  connu  du  notaire  par  son  nom,  prénom,  état  civil  et

demeure, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 31 décembre 2014. REM/2014/2907. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 27 janvier 2015.

Référence de publication: 2015014111/433.
(150016890) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Cedar Trust S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde.

R.C.S. Luxembourg B 126.462.

L’AN DEUX MILLE QUATORZE,
LE DIX-SEPT DECEMBRE
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Nadra Moussalem, dirigeant, né le 04 juillet 1976 à Cannes (F) et demeurant 64, rue Cortambert, F-75116

Paris,

ici dûment représenté par Madame Stéphanie RAGNI, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg

en vertu d’une procuration lui délivrée sous seing privé en date du 11 novembre 2014, laquelle procuration est restée
annexée à un acte du notaire soussigné du 12 novembre 2014.

La comparante, telle que représentée ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Que ladite comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée «CEDAR TRUST S.à r.l.», ayant son

siège social situé à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 126.462, constituée par acte de Maître Joseph Elvinger, notaire
alors de résidence à Luxembourg, en date du 21 mars 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 1104 en date du 08 juin 2007 (la «Société»), les statuts ayant été modifiés pour la dernière fois par acte du notaire
soussigné en date du 12 novembre 2014, en cours de publication.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, agissant en sa qualité de mandataire de la prédite société

CEDAR TRUST S.à r.l. déclare que dans ledit acte du 12 novembre 2014, enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14
novembre  2014,  LAC/2014/53577  et  déposé  auprès  du  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  sous  le  numéro
L140215618 en date du 4 décembre 2014, une erreur matérielle s’est glissée, cette erreur matérielle consistant au fait
que la traduction de l’acte en langue anglaise a été erronément omise.

Afin de rectifier cette erreur, il convient de compléter l’acte initial du 12 novembre 2014 avec la traduction anglaise

suivante:

“In the year two thousand fourteen, on the twelfth day of the month of November.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

there appeared:

Mr Nadra Moussalem, executive manager, born on July 04, 1976 in Cannes (F) and residing 64 rue Cortambert, F-75116

Paris,

Hereby duly represented by Mrs Stéphanie RAGNI, private employee, resising in Luxembourg by virtue of a proxy

given under private seal on November 11, 2014.

Said proxy, signed "ne varietur" by the proxy holder of the appearing parties and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereabove, has requested the undersigned notary to enact the following:
That the said appearing party is the only shareholder of the private limited liability company «CEDAR TRUST S.à r.l.»,

having its registered office located at L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adélaïde, registered with Luxembourg Trade
and Companies Register at section B under number 126.462, incorporated by deed of Maître Joseph Elvinger, notary of
residence in Luxembourg, on March 21, 2007, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro
1104 dated June 08, 2007 (the «Company»). The bylaws have not been amended until the date hereof.

All  this  being  declared,  the  appearing  party,  holding  one  hundred  percent  (100%)  of  the  corporate  capital  of  the

company, represented as stated hereabove, acting in lieu of the extraordinary general meeting and certifying having been
duly informed previously of the agenda as follows:

26429

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1. Change of the management process of the Company by setting up either a board of managers or a single manager,

and subsequent amendment of Title III of the bylaws of the Company, including articles 8, 9, 10 and 11 thereof, in order
to give them the following wording:

«Title III. - Management

8. Management. The Company is managed by one or more managers. Should more than one manager be appointed,

they will form the board of managers. The manager(s) need(s) not to be shareholders of the Company.

The general meeting of Shareholders will define its/their remuneration. This remuneration may be amended the same

way.

Any manager may be replaced or removed ad nutum at any time pursuant to a decision of the general meeting of

Shareholders.

The board of managers or the single manager (as the case may be) may, from time to time, delegate part of their

powers for specific tasks to one or several «ad hoc» agents. These agents need not to be shareholder(s) or manager(s)
of the Company.

The board of managers or the single manager (as the case may be) will determine each agent's powers, responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of such office.
In case of several managers, the relevant decisions will be taken at the meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint a chairman from among its members. In the case of a tied vote, the chairman shall

have a casting vote. The chairman will chair all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman,
the board of managers shall be presided over by any manager who is present at such meeting and appointed as a chairman
pro tempore. The board of managers may also appoint a secretary, who is not necessarily a manager, to be in charge of
the drafting the minutes of the meetings of the board of managers or the execution of any other task entrusted by the
board of managers.

A meeting of the board of managers may be convened by any manager.
Convening notices of any meeting of the board of managers must be given and sent to each manager at least 2 (two)

days before the date scheduled for the relevant meeting except in circumstances of emergency. In case of emergency,
the nature of such emergency must be stated in the minutes of the relevant meeting of the board of managers.

Any convening notice must mention the time and the place of the meeting as well as the relevant agenda.
Convening notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers verbally, in writing or by

telefax, electronic means or by any other appropriate mean of communication.

Any manager may waive such convening notice in writing or by telefax, electronic means or by any other appropriate

mean of communication.

This notice may be waived if all the managers are present or duly represented.
Separate convening notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule

previously adopted by a resolution of the board of managers. A manager may act at a meeting of the board of managers
by appointing in writing or by telefax or electronic means another manager to represent him/her/it.

A manager may represent several other managers.
A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate.

The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of com-

munication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting.

The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented

at a meeting of the board of managers.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be signed by the chairman of the board of managers

or the chairman pro tempore, as the case may be. Any extract or copy of such minutes shall be signed by the relevant
chairman.

Written resolutions approved and signed by all managers shall be deemed to have been passed at the meeting of the

board of managers.

Such circular resolutions shall consist of one or several documents containing the same resolutions.
Such circular resolutions may be circulated by ordinary mail, telefax, electronic means or by any other appropriate

mean of communication.

The manager assumes, by reason of such position, no personal liability in relation to any commitment validly made by

it/him/her in the name of the Company. As agent of the Company, the manager is responsible for the correct performance
of its/her/his duties. The Company shall indemnify and hold harmless any manager or duly authorized agent (including
their respective heirs, executors and administrators) against any expenses reasonably incurred by him/her/it in connection
with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his office with the Company, or, at its

26430

L

U X E M B O U R G

request, of any other company of whom the Company is a shareholder or creditor and from whom he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, the indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such party may be entitled.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the fact that one or more of the managers or duly authorized agents of the Company is interested in, or is a director,
manager or associate, officer or employee of such other company or firm.

Any manager or duly authorized agent of the Company who renders services as a director, manager, officer or em-

ployee of any company or firm with whom the Company shall contract or be otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or duly authorized agent of the Company may have any personal interest in any trans-

action submitted for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or agent shall
inform forthwith the board of managers of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction,
and such circumstance shall be reported to the next following meeting of shareholders. For the purpose of this provision,
the term «personal interest» shall include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers or the single manager
(as the case may be) at its sole discretion.

9. Powers. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders

fall within the competence of the board of managers or the single manager (as the case may be).

10. Representation of the Company. In dealing with third parties, the single manager or, in case of several managers,

the board of managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects to the extent permitted by the
Articles.

The Company shall validly be bound by the sole signature of the single manager and in case of several managers, by

the joint signature of two managers.

11. Delegation and duly authorized agents. The board of managers or the single manager (as the case may be) may,

from time to time, delegate part of their powers for specific tasks to one or several «ad hoc» agents. These agents need
not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers or the single manager (as the case may be) will determine each agent's powers, responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of such office.»;

2. Subsequent amendment of article 2 of the bylaws of the Company and in particular sections 2.3 and 2.4 in order to

give them the following wording:

« 2.3. However, the board of managers or the single manager (as the case may be) is authorised to transfer the

registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the board of managers or the single manager (as the case may be).»;

3. Subsequent amendment of article 7 of the bylaws and in particular section 7.4 in order to give them the following

wording:

« 7.4. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share

without the prior written consent of the board of managers or the single manager (as the case may be).»;

4. Subsequent amendment of article 12 of the bylaws and in particular section 12.1 in order to give them the following

wording:

« 12.1. All powers not expressly reserved to the board of managers or the single manager (as the case may be) by law

or by the Articles fall within the competence of the general meeting of Shareholders.»;

5. Subsequent amendment of article 13 of the bylaws of the Company and in particular sections 13.1 and 13.3 (section

13.2 shall remain unchanged) in order to give them the following wording:

« 13.1. Shareholders meetings may always be convened by the board of managers or the single manager (as the case

may be).»

26431

L

U X E M B O U R G

« 13.3. Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
board of managers or the single manager (as the case may be).»;

6. Subsequent amendment of article 15 of the bylaws and in particular section 15.2 in order to give them the following

wording:

« 15.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the board of managers or the

single manager (as the case may be). The board of managers or the single manager (as the case may be) prepares an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.»;

7. Subsequent amendment of article 16 of the bylaws of the Company and in particular sections 16.3 et 16.5 (section

16.4 shall remain unchanged) in order to give them the following wording:

« 16.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the board of managers or the single manager (as the case may be) shall propose that cash
available for remittance be distributed.»

« 16.5. Interim dividends may be paid out upon decision of the board of managers or the single manager (as the case

may be) provided that:

16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year

for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from reserves
available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pursuant to
the law or the Articles.»; and

8. Approval of the resignations of the co-managers and further appointment of a single manager.
has taken the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the management process of the Company by setting up either a board of

managers or a single manager, and subsequently amend Title III of the bylaws of the Company, including articles 8, 9, 10
and 11 thereof in order to give them the following wording:

«Title III. - Management

8. Management. The Company is managed by one or more managers. Should more than one manager be appointed,

they will form the board of managers. The manager(s) need(s) not to be shareholders of the Company.

The general meeting of Shareholders will define its/their remuneration. This remuneration may be amended the same

way.

Any manager may be replaced or removed ad nutum at any time pursuant to a decision of the general meeting of

Shareholders.

The board of managers or the single manager (as the case may be) may, from time to time, delegate part of their

powers for specific tasks to one or several «ad hoc» agents. These agents need not to be shareholder(s) or manager(s)
of the Company.

The board of managers or the single manager (as the case may be) will determine each agent's powers, responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of such office.
In case of several managers, the relevant decisions will be taken at the meeting of the board of managers.

The board of managers shall appoint a chairman from among its members. In the case of a tied vote, the chairman shall

have a casting vote. The chairman will chair all meetings of the board of managers. In case of absence of the chairman,
the board of managers shall be presided over by any manager who is present at such meeting and appointed as a chairman
pro tempore. The board of managers may also appoint a secretary, who is not necessarily a manager, to be in charge of
the drafting the minutes of the meetings of the board of managers or the execution of any other task entrusted by the
board of managers.

A meeting of the board of managers may be convened by any manager.
Convening notices of any meeting of the board of managers must be given and sent to each manager at least 2 (two)

days before the date scheduled for the relevant meeting except in circumstances of emergency. In case of emergency,
the nature of such emergency must be stated in the minutes of the relevant meeting of the board of managers.

Any convening notice must mention the time and the place of the meeting as well as the relevant agenda.
Convening notices of any meeting of the board of managers will be given to all managers verbally, in writing or by

telefax, electronic means or by any other appropriate mean of communication.

Any manager may waive such convening notice in writing or by telefax, electronic means or by any other appropriate

mean of communication.

This notice may be waived if all the managers are present or duly represented.

26432

L

U X E M B O U R G

Separate convening notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule

previously adopted by a resolution of the board of managers. A manager may act at a meeting of the board of managers
by appointing in writing or by telefax or electronic means another manager to represent him/her/it.

A manager may represent several other managers.
A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other

similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate.

The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of com-

munication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting.

The board of managers may deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented

at a meeting of the board of managers.

The resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented.
Decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be signed by the chairman of the board of managers

or the chairman pro tempore, as the case may be. Any extract or copy of such minutes shall be signed by the relevant
chairman.

Written resolutions approved and signed by all managers shall be deemed to have been passed at the meeting of the

board of managers.

Such circular resolutions shall consist of one or several documents containing the same resolutions.
Such circular resolutions may be circulated by ordinary mail, telefax, electronic means or by any other appropriate

mean of communication.

The manager assumes, by reason of such position, no personal liability in relation to any commitment validly made by

it/him/her in the name of the Company. As agent of the Company, the manager is responsible for the correct performance
of its/her/his duties. The Company shall indemnify and hold harmless any manager or duly authorized agent (including
their respective heirs, executors and administrators) against any expenses reasonably incurred by him/her/it in connection
with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his office with the Company, or, at its
request, of any other company of whom the Company is a shareholder or creditor and from whom he is not entitled to
be indemnified, except in relation to matters as to which he/she/it shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding
to be liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, the indemnification shall be provided only
in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person
to be indemnified did not commit such breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other
rights to which such party may be entitled.

No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated

by the fact that one or more of the managers or duly authorized agents of the Company is interested in, or is a director,
manager or associate, officer or employee of such other company or firm.

Any manager or duly authorized agent of the Company who renders services as a director, manager, officer or em-

ployee of any company or firm with whom the Company shall contract or be otherwise engage in business shall not, by
reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any
matters with respect to such contract or other business.

In the event that any manager or duly authorized agent of the Company may have any personal interest in any trans-

action submitted for approval to the board of managers conflicting with that of the Company, such manager or agent shall
inform forthwith the board of managers of such personal interest and shall not consider or vote upon any such transaction,
and such circumstance shall be reported to the next following meeting of shareholders. For the purpose of this provision,
the term «personal interest» shall include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving
such other company or entity as may from time to time be determined by the board of managers or the single manager
(as the case may be) at its sole discretion.

9. Powers. All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders

fall within the competence of the board of managers or the single manager (as the case may be).

10. Representation of the Company. In dealing with third parties, the single manager or, in case of several managers,

the board of managers will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to
carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects to the extent permitted by the
Articles.

The Company shall validly be bound by the sole signature of the single manager and in case of several managers, by

the joint signature of two managers.

11. Delegation and duly authorized agents. The board of managers or the single manager (as the case may be) may,

from time to time, delegate part of their powers for specific tasks to one or several «ad hoc» agents. These agents need
not to be shareholder(s) or manager(s) of the Company.

The board of managers or the single manager (as the case may be) will determine each agent's powers, responsibilities

and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of such office.»

26433

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 2 of the

bylaws of the Company and in particular sections 2.3 and 2.4 in order to give them the following wording:

« 2.3. However, the board of managers or the single manager (as the case may be) is authorised to transfer the

registered office of the Company within the City of Luxembourg.

2.4. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would

prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be tem-
porarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measure will however
not have any effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered
office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made
by the board of managers or the single manager (as the case may be).».

<i>Third resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 7 of the

bylaws of the Company and in particular section 7.4 in order to give them the following wording:

« 7.4. In addition, each Shareholder agrees that it will not transfer, pledge or grant a security interest in any Share

without the prior written consent of the board of managers or the single manager (as the case may be).».

<i>Fourth resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 12 of the

bylaws and in particular section 12.1 in order to give them the following wording:

« 12.1. All powers not expressly reserved to the board of managers or the single manager (as the case may be) by law

or by the Articles fall within the competence of the general meeting of Shareholders.»;

<i>Fifth resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 13 of the

bylaws of the Company and in particular sections 13.1 and 13.3 (section 13.2 shall remain unchanged) in order to give
them the following wording:

« 13.1. Shareholders meetings may always be convened by the board of managers or the single manager (as the case

may be).»;

« 13.3. Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the

Shareholder(s) for approval. The Shareholder(s) shall also specifically vote as to whether discharge is to be given to the
board of managers or the single manager (as the case may be).».

<i>Sixth resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 15 of the

bylaws and in particular section 15.2 in order to give them the following wording:

« 15.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the board of managers or the

single manager (as the case may be). The board of managers or the single manager (as the case may be) prepares an
inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.».

<i>Seventh resolution

Further to the first resolution passed above, the sole shareholder resolves to amend subsequently article 16 of the

bylaws of the Company and in particular sections 16.3 et 16.5 (section 16.4 shall remain unchanged) in order to give them
the following wording:

« 16.3. To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted

by law and by these Articles, the board of managers or the single manager (as the case may be) shall propose that cash
available for remittance be distributed.»;

« 16.5. Interim dividends may be paid out upon decision of the board of managers or the single manager (as the case

may be) provided that:

16.5.1 interim accounts have been drawn-up and show that the funds available for distribution are sufficient; and
16.5.2 the amount to be distributed does not exceed the total profits realised since the end of the last financial year

for which the annual accounts have been approved, increased by any profits carried forward and sums drawn from reserves
available for distribution and reduced by losses carried forward and any sums to be allocated to any reserve pursuant to
the law or the Articles.».

26434

L

U X E M B O U R G

<i>Eighth resolution

The sole shareholder resolves to approve the resignation of the current co-managers:
- Mr Nadra Moussalem, identified above, et
- Me Arsène Kronshagen, residing 22, rue Marie-Adélaïde L-2128 Luxembourg,
with effect at the date hereof, and resolves to appoint with effect at the date hereof as single manager of the Company

for an unlimited period of time:

- Mr Eric Stael, companies director, born on June 1 

st

 , 1970 in Libourne (France), residing 56 rue de Hamm, L-1713

Luxembourg.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be

charged to it in connection with the present deed have been estimated at about EUR 1,500.-.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in French followed by an English version. On request of the same appearing parties
and in case of discrepancies between the English and the French text, the French version will be prevailing.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this document.”
Après que ceci ait été déclaré, la comparante, es-qualité qu’elle agit, requiert le notaire instrumentaire de faire les

rectifications nécessaires partout où cela s'impose.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu’en tête des présentes.
Et après lecture et interprétation donnée au comparant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom, état et

demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: S. RAGNI, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61756. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015014114/350.
(150016906) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Digital Services XXXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.000,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.945.

STATUTES

In the year two thousand and fifteen, on the seventh day of January,
Before us Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Rocket Internet AG, a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the laws of Germany with its statutory

seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the local court of Charlottenburg
(Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117
Berlin, Germany;

here represented by Julien De Mayer, legal counsel, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given

in Berlin on 5 January 2015.

Said proxy, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this

deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such  appearing  party  has  requested  the  officiating  notary  to  enact  the  deed  of  incorporation  of  a  private  limited

company (société à responsabilité limitée) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

26435

L

U X E M B O U R G

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name

Digital  Services  XXXIV  S.à  r.l.  (hereinafter  the  “Company”)  which  shall  be  governed  by  the  law  of  10  August  1915
concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio in view of its realisation by sale, exchange or otherwise.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of

managers. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution
of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at fifteen thousand euro (EUR 15,000), represented by fifteen thousand (15,000)

shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 The Company may redeem its own shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.

26436

L

U X E M B O U R G

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital.

7.5 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties through the notification of

the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.6 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by the surviving shareholders at a majority of three quarters of the share capital.
Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents, descendants or the surviving
spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

C. Decisions of the shareholders

Art. 8. Collective decisions of the shareholders.
8.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these articles

of association.

8.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
8.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

8.4 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 9. General meetings of shareholders. In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, at least

one general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in Luxembourg
at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices
of meeting. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived
any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
10.2 Save for a higher majority provided in these articles of association or by law, collective decisions of the Company’s

shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If this majority is not reached in a first meeting or proposed written resolution, the shareholders may be convened
a second time with the same agenda or receive such proposed written resolution a second time by registered letter,
decisions are validly adopted in so far as they are adopted by a majority of the votes validly cast whichever is the fraction
of the share capital represented.

Art. 11. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 12. Amendments of the articles of association. Any amendment of the articles of association requires the approval

of (i) a majority of shareholders (ii) representing three quarters of the share capital at least.

D. Management

Art. 13. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
13.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

13.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

13.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 14. Appointment, removal and term of office of managers.
14.1 The manager(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remune-

ration and term of office.

14.2 The managers shall be appointed and may be removed from office at any time, with or without cause, by a decision

of the shareholders representing more than half of the Company’s share capital.

26437

L

U X E M B O U R G

14.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 15. Vacancy in the office of a manager.
15.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the replaced  manager  by  the  remaining  managers  until the  next meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

15.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 16. Convening meetings of the board of managers.
16.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

16.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers twenty-four (24) hours at

least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document
being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location
determined in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

16.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 17. Conduct of meetings of the board of managers.
17.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

17.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

17.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

17.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

17.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

17.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event where the general meeting of shareholders has appointed different classes
of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only be validly
taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which may be
represented).

17.7. The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

Art. 18. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
18.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

18.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

26438

L

U X E M B O U R G

Art. 19. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers
and class B managers), the Company will only be validly bound by the joint signatures of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

E. Audit and supervision

Art. 20. Auditor(s).
20.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

20.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

20.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
20.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

20.5. An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 21. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 22. Annual accounts and allocation of profits.
22.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

22.2. From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

22.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

22.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

22.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

22.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 23. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
23.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed may
not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable
reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles
of association do not allow to be distributed.

23.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the

liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders
deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided,
the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the
Company.

24.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among

the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

26439

L

U X E M B O U R G

H. Final clause - Governing law

Art. 25. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.

<i>Transitional provisions

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 December

2015.

2. Interim dividends may be distributed during the Company’s first financial year.

<i>Subscription and payment

The fifteen thousand (15,000) shares issued have been subscribed by Rocket Internet AG, aforementioned, for the

price of fifteen thousand euro (EUR 15,000).

The shares so subscribed are fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of fifteen thousand euro (EUR

15,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of fifteen thousand euro (EUR 15,000) is entirely allocated to the share capital.

<i>Verification

The notary executing this deed declares that the conditions fixed in art. 183 of the law on commercial companies have

been fulfilled.

<i>Expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be

borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately EUR 1,800.

<i>Resolutions of the sole shareholder

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening

requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The registered office of the Company is set at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
2. The following person is appointed as class A manager of the Company for an unlimited term:
- Mr Christian Senitz, born in Aschersleben, Germany, on 27 January 1978, professionally residing at Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

The following persons are appointed as class B managers of the Company for an unlimited duration:
- Mr Ulrich Binninger, born in Trier, Germany, on 30 August 1966, professionally residing at 19, rue des Lilas, L-8035

Strassen, Luxembourg;

- Mr Julien De Mayer, born in Etterbeek, Belgium on 9 April 1982, professionally residing at 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.

3. Any one manager of the Company, regardless of his category, is authorized to sign solely, on behalf of the sole

shareholder, the shareholders register of the Company that will be created upon incorporation of the Company.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a German translation; at the request of the same appearing party and in case
of divergence between the English and the German text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am siebten Januar.
Vor uns, Cosita Delvaux, Notar mit Amtssitz in Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg,

IST ERSCHIENEN:

Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des

Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Deutschland.

hier vertreten durch Julien De Mayer, legal counsel, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 5.

Januar 2015, ausgestellt in Berlin.

Besagte  Vollmacht,  welche  von  der  erschienenen  Partei  und  dem  unterzeichnenden  Notar  ne  varietur  paraphiert

wurde, wird der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

26440

L

U X E M B O U R G

Die erschienene Partei hat den amtierenden Notar ersucht, die Gründung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée) zu beurkunden, welche sie mit der folgenden Satzung gründen möchte:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée)

mit dem Namen Digital Services XXXIV S.à r.l. (die “Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10.
August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderli-
chen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) aufgeteilt in fünfzehntausend

(15.000) Anteile mit einem Nominalwert von einem Euro (EUR 1) pro Anteil.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

26441

L

U X E M B O U R G

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden.

7.5 Jede Übertragung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel 1690 des Code Civil

wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung zugestimmt
hat.

7.6 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters an neue Gesellschafter nur mit Zustimmung von

Gesellschaftern mit einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals übertragen werden. Eine derartige Zu-
stimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in
übertragen werden oder jedem anderem gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 8. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
8.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

8.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
8.3 Falls und solange die Gesellschaft nicht mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, dürfen gemeinsame Ent-

scheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In diesem
Fall  erhält  jeder  Gesellschafter  den  Text  der  Beschlüsse  oder  Entscheidungen  in  ausformulierter  Form  und  übt  sein
Stimmrecht schriftlich aus.

8.4 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 9. Gesellschafterversammlung. Falls die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, muss jährlich

innerhalb von sechs (6) Monaten vor dem Ende des Geschäftsjahres mindestens eine Gesellschafterversammlung in Lu-
xemburg am Sitz der Gesellschaft oder an einem anderen Ort abgehalten werden, wie in der Einberufungsbekanntmachung
zu dieser Versammlung genauer bestimmt. Andere Gesellschafterversammlungen finden an dem Ort und zu der Zeit statt,
welcher in der entsprechenden Einberufungsbekanntmachung genauer bestimmt werden. Falls alle Gesellschafter in einer
Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf sämtliche Einberufungsformalitäten verzichtet haben, kann die Ge-
sellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung oder Veröffentlichung abgehalten werden.

Art. 10. Quorum und Abstimmung.
10.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
10.2 Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes, die ein höheres Mehrheitsverhältnis vor-

sehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die mehr als die
Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Falls diese Mehrheit in einer ersten Gesellschafterversammlung oder einer ersten
schriftlichen Konsultation der Gesellschafter nicht erreicht wird, können die Anteilseigner ein weiteres Mal mit derselben
Tagesordnung einberufen werden oder per Einschreiben dieselben schriftlichen Beschlussvorschläge erhalten und Ent-
scheidungen werden wirksam mit der Mehrheit der wirksam abgegebenen Stimmen gefasst, unabhängig vom Anteil des
durch sie vertretenen Gesellschaftskapitals.

Art. 11. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 12. Änderung der Satzung. Eine Änderung der Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer Mehrheit der Gesell-

schafter, die mindestens (ii) eine Mehrheit von drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertritt.

D. Geschäftsführung

Art. 13. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
13.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

26442

L

U X E M B O U R G

13.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

13.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 14. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
14.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

14.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund durch einen Beschluss von Gesellschaftern, die mehr als die

Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, ernannt oder abberufen werden.

14.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 15. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
15.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

15.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 16. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
16.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

16.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen unterzeichneten Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung
zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss
des Rates der Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

16.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnen.

Art. 17. Durchführung von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

17.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

17.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

17.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

17.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

17.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-

26443

L

U X E M B O U R G

schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

17.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 18. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

18.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

18.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 19. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 20. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
20.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

20.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
20.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

20.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

20.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 21. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 22. Jahresabschluss und Gewinne.
22.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

22.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

26444

L

U X E M B O U R G

22.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

22.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

22.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen  Vorschriften  und  den  Bestimmungen  dieser  Satzung  wie  der  verbleibende  Bilanzgewinn  der  Gesellschaft
verwendet werden soll.

22.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 23. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
23.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres
angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungs-
weise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem
Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

23.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 24. Liquidation.
24.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Abwicklung durch

einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden, die über die
Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes
bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögenswerte und die
Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

24.2 Der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss wird

an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Anteile verteilt.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 25. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.

<i>Übergangsbestimmungen

1. Das erste Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am Tag der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember

2015.

2. Abschlagsdividenden können auch während des ersten Geschäftsjahres der Gesellschaft ausgeschüttet werden.

<i>Zeichnung und Zahlung

Die fünfzehntausend (15.000) ausgegebenen Anteile wurden durch Rocket Internet AG, vorbenannt, zum Preis von

fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) gezeichnet.

Die Einlage für so gezeichnete Anteile wurde vollständig in bar erbracht, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe

von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde.

Die gesamte Einlage von in Höhe von fünfzehntausend Euro (EUR 15.000) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Feststellung

Der unterzeichnete Notar hat festgestellt, dass die Bedingungen des Artikels 183 des Gesetzes über die Handelsge-

sellschaften erfüllt sind.

<i>Auslagen

Die der Gesellschaft aufgrund oder im Zusammenhang mit ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare

und Auslagen werden auf EUR 1.800 geschätzt.

<i>Beschlüsse des Alleingesellschafters

Der Gründungsgesellschafter, welcher das gesamte Gesellschaftskapital repräsentiert und welcher auf eine formelle

Einberufungsbekanntmachung verzichtet, hat daraufhin folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Sitz der Gesellschaft ist in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
2. Die folgende Person wird für unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer der Kategorie A der Gesellschaft ernannt:

26445

L

U X E M B O U R G

- Herr Christian Senitz, geboren am 27. Januar 1978 in Aschersleben, Deutschland, geschäftsansässig in Johannisstrasse

20, D-10117 Berlin.

Die folgenden Personen werden für unbegrenzte Zeit als Kategorie B Geschäftsführer bestellt:
- Herr Ulrich Binninger, geboren am 30. August 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig in 19, rue des Lilas,

L-8035 Strassen, Luxemburg.

- Herr Julien De Mayer, geboren am 9 April 1982 in Etterbeek, Belgien, geschäftsansässig in 5, Heienhaff, L-1736

Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

3. Jeder einzelne der Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, ist ermächtigt, das Anteilinha-

berregister, welches am Tag der Gründung der Gesellschaft erstellt wird, allein im Namen und für Rechnung des alleinigen
Gesellschafters zu unterzeichnen.

Worüber diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen wurde.
Der beurkundende Notar, welcher die englische Sprache beherrscht, erklärt hiermit auf Ersuchen der erschienenen

Partei, dass diese Urkunde auf Anfrage der erschienenen Partei auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen
Übersetzung. Auf Ersuchen derselben erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen
und dem deutschen Text, soll die englische Fassung vorrangig sein.

Nachdem das Dokument dem Bevollmächtigten der erschienenen Partei verlesen wurde, welche dem Notar mit Na-

men, Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, hat der Bevollmächtigte die Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

Gezeichnet: J. DE MAYER, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 09 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/705. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum

Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 27. Januar 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015014186/584.
(150016961) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 janvier 2015.

ZIV Group Investment I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.036.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen.
On the thirtieth day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned.

APPEARED:

The limited partnership NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP, registered with the «Jersey

Financial Services Commission» under number LP8355, with its registered office at Jersey, St. Helier, 26, New Street,

here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Lu-

xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present

deed in order to be recorded with it.

The appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) "ZIV Group Investment I S.à r.l.", with registered

office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B number 127036, has been incorporated
by a deed of Maître Joseph ELVINGER, notary residing in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on April 4, 2007,
published in the Mémorial C number 1161 of June 14, 2007 and whose articles of association have been amended by a
deed of the undersigned notary, on December 14, 2007, published in the Mémorial C number 463 of February 22, 2008
(the "Company").

2) That the Company's capital is fixed at thirty three thousand eight hundred and seventy five Euro (EUR 33,875.-)

represented by one thousand three hundred and fifty five (1,355) sharequotas with a nominal value of twenty five Euro
(EUR 25.-) each.

3) That the appearing party is the holder of all the sharequotas of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.

26446

L

U X E M B O U R G

5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company

has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.

6) That the appearing party in its capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to settle

any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.

7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing

debt of the Company pursuant to point 6).

8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the sharequotas of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the

former registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

<i>Costs

The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or

charged to the Company as a result of the present deed, is approximately EUR 950.-

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above

appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status

and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la version française de l’acte:

L'an deux mille quatorze.
Le trente décembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

A COMPARU:

La société en commandite simple NMÁS1 PRIVATE EQUITY FUND N°2 LIMITED PARTNERSHIP, enregistrée au

«Jersey Financial Services Commission» sous le numéro LP8355, avec siège social à Jersey, St. Helier, 26, New Street,

représentée par M. Max MAYER, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster, (Grand-Duché de Lu-

xembourg) en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée.

Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent

acte avec lequel elle sera enregistrée.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée "ZIV Group Investment I S.à r.l.", ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 6,

rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 127036, a été constituée suivant acte de Maître Joseph EL-
VINGER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 avril 2007, publié au Mémorial C
numéro 1161 du 14 juin 2014 et dont les statuts ont été modifiés suivant acte du notaire soussigné, le 14 décembre 2007,
publié au Mémorial C numéro 463 du 22 février 2008 (la "Société").

2) Que le capital de la Société est fixé à trente-trois mille huit cent soixante-quinze Euros (EUR 33.875,-) représenté

par mille trois cent cinquante-cinq (1.355) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq Euros (EUR 25,-) chacune.

3) Que la comparante est l’associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d’établir, de signer, d'exécuter

et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.

6) Que la comparante en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif

présent et futur de la Société dissoute.

7) Que la comparante déclare qu’elle reprend tout l’actif de la Société et qu’elle s’engagera à régler tout le passif de

la Société indiqué au point 6).

8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l’exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l’annulation des parts sociales de la Société dissoute.

26447

L

U X E M B O U R G

11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l’ancien siège

social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,

ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 950,- EUR.

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la

personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-

meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/213. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015011751/99.
(150013120) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

YeS - Sales &amp; Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen.

R.C.S. Luxembourg B 145.265.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signatures
<i>Gérant

Référence de publication: 2015011745/12.
(150012901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

TS Car S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3222 Bettembourg, 35A, route de Dudelange.

R.C.S. Luxembourg B 140.116.

Monsieur Serge Thiébaut cède 16 parts sociales lui appartenant de la société TS CAR Sàrl à la société SEMA Sàrl, avec

numéro RCSL B175009, 11, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

<i>Pour la gérance
Signature

Référence de publication: 2015011718/12.
(150013123) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Groupe PROCEDO SA, Société Anonyme.

Siège social: L-1318 Luxembourg-Merl, 58, rue des Celtes.

R.C.S. Luxembourg B 154.180.

Le bilan au 31 décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Version abrégée du dépôt des comptes annuels (art.81 de la Loi du 19 décembre 2002)
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015013437/10.
(150016302) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

26448


Document Outline

A.G. Consulting S.A.

AMM Finance Sicav

Cannon Street Project S.à r.l.

Capital Financial Holdings Luxembourg SA

Carta Investments S.à r.l.

Cedar Trust S.à r.l.

Digital Services XXXIV S.à r.l.

Groupe PROCEDO SA

MGE Giunchetto Wind Park S.A.

Milos S.A.

MPK Luxembourg S.à r.l.

Olky Payment Service Provider S.à r.l.

Opportunity Two

Orbis Europe S.A.

Orkor Luxco 2 S.à r.l.

Orkor Luxco C S.à r.l.

OXEA FINANCE &amp; Cy S.C.A.

OXEA Finance S.à r.l.

OXEA Holding S.à r.l.

Pall Mall Invest S.A.

Parabel S.A.

Patentportfolio S.à r.l.

PH International Holdings I S.à r.l.

Rainbow Bridel SA

Rainbow Bridel SA

Rain Man SA

Rain Man SA

Rain Man SA

Red 1 S.à r.l.

Rushold S.A.

Saint Amand GP

Sammarc S.A.

Schomberg (Clinic) Properties S.à r.l.

SCP OCN Acquisition Lux S.à r.l.

SCP OCN Finco Lux S.à r.l.

Services-Expert S.A.

Société de Gestion Hotelière et de Commerces

Taurus Luxembourg S.à r.l.

TS Car S.à r.l.

Tulsi Sàrl

Urban Garden S.A.

US International S.A.

UT Luxembourg Holding II S.à r.l.

Valdor&amp;K Lux S.A.

YeS - Sales &amp; Management S.à r.l.

Yum! Finance Holdings III S.à r.l. (en abrégé YFH III)

ZIV Group Investment I S.à r.l.