This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 539
26 février 2015
SOMMAIRE
Aquariolux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25872
Architecture and Engineering S.A. . . . . . . .
25872
Emerging Energy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
Financière Tesalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25870
Financière Tesalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25870
Financière Tesalia S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25870
First Data International Luxembourg S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25870
Green-Man S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
GSCF Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25867
Hesperussa Société en Commandite Spé-
ciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25865
Hines Global REIT HoldCo S.à r.l. . . . . . . .
25829
Histrio S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25829
Hôtel de la Sûre SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25828
Hotel Group Maas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25830
Iberint S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25830
I.C. Dom-Com S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25828
Ilyeum SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25830
IMG S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25830
Immo Guillaume Schneider S.A. . . . . . . . .
25831
Immo-Weimerskirch II S.A. . . . . . . . . . . . . .
25831
Indigo Gold Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .
25829
ING (L) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25831
ING (L) Patrimonial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25832
Inpeco Group S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25832
Intercontinental Group for Commerce In-
dustry and Finance S.A., SPF . . . . . . . . . . .
25828
Iris International S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25827
Isotherma S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25827
J.C. Immo-Performance S.A. . . . . . . . . . . . .
25827
Jeancel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25833
JL Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25828
J Manhattan Luxco S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . .
25827
JM Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25833
John De Wilde International S.A. . . . . . . . .
25827
Kartesia GP S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25835
Kartesia Management . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25835
LBPOL IV (Lux) S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25863
Lsref3 Tiger Investements S.à .r.l. . . . . . . .
25858
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l. . . . .
25851
MaForm S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25855
Montesquieu & Associés S.à.r.l. . . . . . . . . . .
25871
NN Luxury S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25871
Pafin Participations S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
Parcip S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
PC-Broker.Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
PricewaterhouseCoopers Academy S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25826
Rally Lux Holding One S.à r.l. . . . . . . . . . . .
25871
25825
L
U X E M B O U R G
Pafin Participations S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 8, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 73.645.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012308/9.
(150014161) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Parcip S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.
R.C.S. Luxembourg B 34.584.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012309/9.
(150014242) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
PwC Academy, PricewaterhouseCoopers Academy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2182 Luxembourg, 2, rue Gerhard Mercator.
R.C.S. Luxembourg B 66.026.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012297/9.
(150013753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
PC-Broker.Com, Société Anonyme.
Siège social: L-2550 Luxembourg, 14, avenue du X Septembre.
R.C.S. Luxembourg B 71.635.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012314/9.
(150013642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Green-Man S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1521 Luxembourg, 139, rue Adolphe Fischer.
R.C.S. Luxembourg B 157.448.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012072/9.
(150013612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Emerging Energy S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 173.707.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015011972/9.
(150013931) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.
25826
L
U X E M B O U R G
J Manhattan Luxco S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 791.791,00.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 140.031.
Les statuts coordonnés ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012779/10.
(150014518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
J.C. Immo-Performance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8314 Capellen, 8, Domaine Beaulieu.
R.C.S. Luxembourg B 97.007.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012780/10.
(150014499) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
John De Wilde International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4740 Pétange, 5, rue Prince Jean.
R.C.S. Luxembourg B 85.954.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012781/10.
(150014684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Isotherma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9911 Troisvierges, 5, rue de Wilwerdange.
R.C.S. Luxembourg B 95.688.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012777/10.
(150015021) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Iris International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 173.225.
<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 11 Décembre 2012i>
Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
les Administrateurs élisent en leur sein Monsieur Cyril WOLKONSKY à la fonction de Président du Conseil d'Adminis-
tration et ce pour toute la durée de son mandat d'Administrateur A.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Certifié sincère et conforme
<i>POUR IRIS INTERNATIONAL S.A.i>
Référence de publication: 2015012776/14.
(150014722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25827
L
U X E M B O U R G
I.C. Dom-Com S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 133.127.
La liste des signataires autorisés de la Société au 16 janvier 2015 a été déposée au registre de commerce et des sociétés
de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012749/11.
(150014648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF, Société Anonyme - Société de
Gestion de Patrimoine Familial.
Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 14.070.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenu le 30 décembre 2014i>
Le Conseil d'Administration prend connaissance de la démission de Monsieur Joseph WINANDY en sa qualité d'Ad-
ministrateur.
En vertu des articles 51, alinéa 5 et 52 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, le Conseil d'Adminis-
tration décide de nommer provisoirement au poste d'administrateur:
Monsieur Jean-Charles THOUAND
Né le 25 août 1971 à Metz (France)
Demeurant 183, rue de Luxembourg L-8077 Bertrange
Le nouvel administrateur terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire, sous réserve légale d'approbation
de sa nomination par la prochaine Assemblée Générale.
Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Koen LOZIE en tant que Président du Conseil d'Adminis-
tration.
Copie certifiée conforme
- / JALYNE S. A
Signatures
Référence de publication: 2015012773/23.
(150014875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
JL Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1274 Howald, 65, rue des Bruyères.
R.C.S. Luxembourg B 109.011.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012784/10.
(150014901) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Hôtel de la Sûre SA, Société Anonyme.
Siège social: L-9650 Esch-sur-Sûre, 1, rue du Pont.
R.C.S. Luxembourg B 103.612.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012748/10.
(150014780) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25828
L
U X E M B O U R G
Indigo Gold Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 165.398.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012750/10.
(150014936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Hines Global REIT HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 354.755,00.
Siège social: L-1150 Luxembourg, 205, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 159.314.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extraiti>
Suite au procès-verbal de la décision de l'associé unique de Hines Global REIT HoldCo S.à r.l. (la «Société») prise en
date du 31 décembre 2014, il a été décidé:
- de clôturer la liquidation de la Société en date du 31 décembre 2014;
- de donner décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation pour l'exécution de leurs mandats respectifs
pendant la liquidation;
- de conserver les livres et documents sociaux de la Société pendant cinq (5) ans à l'ancien siège social de la Société
situé au 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
Pour extrait analytique conforme
Hines Global REIT European Holdings LLC
<i>Associé uniquei>
Référence de publication: 2015012738/22.
(150014613) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Histrio S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 44, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 83.580.
LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement rendu en date du 15 janvier 2015 le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière
commerciale, a prononcé la dissolution et ordonné la liquidation de:
- La société à responsabilité HISTRIO SARL (RCS B83580), avec siège social à L-1930 Luxembourg, 44, avenue de la
Liberté, de fait inconnue à cette adresse,
Le même jugement a nommé juge-commissaire Laurent LUCAS, juge au tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
et désigné liquidateur Maître Maïka SKOROCHOD, avocat, demeurant à Luxembourg
Il a ordonné aux créanciers de faire la déclaration de leurs créances au Greffe du Tribunal de Commerce avant le 06
février 2015
Pour extrait conforme
Maître Maïka SKOROCHOD
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015012742/19.
(150014567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25829
L
U X E M B O U R G
Hotel Group Maas, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.
R.C.S. Luxembourg B 177.512.
L'associé unique de la Société, anciennement CHEETEE GROUP INC. a changé sa dénomination sociale en CH GROUP
P&S INC. en date du 17 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen, le 22 janvier 2015.
<i>Pour la Sociétéi>
Référence de publication: 2015012745/13.
(150014525) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Iberint S.A., Société Anonyme Soparfi.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 27.857.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 17 décembre 2014i>
La démission de Madame Rosina CEUPPENS de son mandat d'Administrateur est acceptée.
Madame Ann-Myriam DONCK, Administrateur de Sociétés, demeurant au Gracansko Borje 24,1000 Zagred, Croatie
est nommée nouvel Administrateur. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Statutaire de l'an 2018.
Fait à Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Certifié sincère et conforme
Signatures
<i>Administrateur / Administrateuri>
Référence de publication: 2015012753/15.
(150014960) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Ilyeum SA, Société Anonyme.
Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 151.585.
EXTRAIT
Il résulte d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 18 décembre 2014 que:
- L'assemblée accepte la démission des administrateurs suivants:
* Monsieur Luc Hilger
* Monsieur Guy Lanners
* Monsieur John Weber
- L'assemblée décide de nommer en tant qu'administrateur unique Monsieur Mohammed Chouiter, né le 5 mai 1972
à Berkane (Maroc), demeurant à B-1081 Koekelberg (Belgique), 2, rue de Neck.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra en l'année 2020.
Pour extrait sincère et conforme
Référence de publication: 2015012757/17.
(150014727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
IMG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 183.241.
Par décision du Conseil de Gérance du 16 décembre 2014, il a été décidé:
- de nommer M. Claudio Patalano en tant que Président du Conseil de Gérance avec effet immédiat.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
25830
L
U X E M B O U R G
IMG S.à r.l.
Société à Responsabilité Limitée
Signatures
Référence de publication: 2015012759/13.
(150015202) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
IGS S.A., Immo Guillaume Schneider S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 12, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 124.042.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 23 janvier 2015 que:
(i) la démission des personnes suivantes a été acceptée:
- Monsieur Bruno BEERNAERTS, Administrateur de catégorie B et président du conseil d'administration, et ce avec
effet immédiat;
- Monsieur Ian ROBERTS, Administrateur de catégorie A, et ce avec effet immédiat; et
- Madame Aurore CALVI, Administrateur de catégorie C et administrateur-délégué, et ce avec effet au 15 octobre
2014.
(ii) les personnes suivantes ont été nommées:
- Monsieur Dominique GOSSART, né le 19 mai 1965 à Tournai, Belgique, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie B et administrateur-délégué à la gestion
journalière, avec effet immédiat, et ce jusqu'à l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre
2016; et
- Monsieur Livio GAMBARDELLA, né le 2 décembre 1975 à Terlizzi, Italie, résidant professionnellement au 16, avenue
Pasteur L-2310 Luxembourg, a été nommé en tant qu'administrateur de catégorie A, avec effet immédiat, et ce jusqu'à
l'assemblée générale ordinaire approuvant les comptes clos au 31 décembre 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012760/25.
(150015264) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Immo-Weimerskirch II S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange.
R.C.S. Luxembourg B 163.799.
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2015.i>
<i>1 i>
<i>èrei>
<i> résolutioni>
Les actionnaires approuvent à l'unanimité le transfert du siège social de L-1213 Luxembourg, 2, rue Caroline Baldauff-
Rothermel à L-2430 Luxembourg, 27, rue Michel Rodange.
Pour extrait conforme
Signature
<i>Le Président de l'assemblée générale ordinairei>
Référence de publication: 2015012763/14.
(150015392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
ING (L), Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 44.873.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2015i>
<i>Conseil d'Administrationi>
- Démission de Monsieur André van den Heuvel en date du 1
er
mars 2014;
- Ratification de la cooptation avec effet au 1
er
avril 2014 de Monsieur Gerard Roelofs, 65 Schenkkade, 2595AS, la
Haye, Pays-Bas;
25831
L
U X E M B O U R G
- Nomination de Monsieur Gerard Roelofs;
- Nomination de Madame Sophie Mosnier, ManagementPlus S.A., 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Confirmation du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595 AS, la Haye, Pays-Bas
- Monsieur Johannes Stoter, 65 Schenkkade, 2595 AS, la Haye, Pays-Bas
- Monsieur Benoit De Belder, 65 Schenkkade, 2595 AS, la Haye, Pays-Bas
Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, pour une période
d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation
Elise Valentin / Kathleen Carnevali
Référence de publication: 2015012769/27.
(150015180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Inpeco Group S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.
R.C.S. Luxembourg B 127.821.
EXTRAIT
Le Conseil d'administration, en date du 21 janvier 2015, a pris à l'unanimité la résolution suivante:
Prise d'acte de la démission de Monsieur Sébastien Gravière de son mandat d'administrateur de catégorie B, avec effet
au 20 janvier 2015.
Pour extrait conforme
Signature
Référence de publication: 2015012772/13.
(150015228) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 24.401.
<i>Extrait du Procès-Verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2015i>
<i>Conseil d'Administrationi>
- Démission de Monsieur André van den Heuvel en date du 1
er
mars 2014;
- Ratification de la cooptation avec effet au 1
er
avril 2014 de Monsieur Gerard Roelofs, 65 Schenkkade, 2595AS, la
Haye, Pays-Bas;
- Nomination de Monsieur Gerard Roelofs;
- Nomination de Madame Sophie Mosnier, ManagementPlus S.A., 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg.
Confirmation du mandat des administrateurs suivants:
- Monsieur Dirk Buggenhout, 65 Schenkkade, 2595AS, la Haye, Pays-Bas
- Monsieur Johannes Stoter, 65 Schenkkade, 2595AS, la Haye, Pays-Bas
- Monsieur Benoit De Belder, 65 Schenkkade, 2595AS, la Haye, Pays-Bas
Les mandats des administrateurs sont accordés jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2016.
<i>Réviseur d'Entreprisesi>
Reconduction de mandat de la société Ernst & Young, 7 rue Gabriel Lippmann à L-5365 Munsbach, pour une période
d'un an, jusqu'à la prochaine assemblée qui se tiendra en 2016.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
25832
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 22 janvier 2015.
ING Investment Management Luxembourg S.A.
Par délégation
Elise Valentin / Mathieu Thiry
Référence de publication: 2015012770/27.
(150015281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Jeancel, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8009 Strassen, 163-165, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 126.964.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue au siège social le 8 décembre 2014 à 16h00i>
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jeancel S.à r.l. a pris les résolutions suivantes:
L'assemblée prononce la clôture de la liquidation et constate que la société Jeancel S.à r.l., en liquidation, a définitive-
ment cessé d'exister. Les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq ans suivant
la liquidation auprès de la société PARFININDUS S.à r.l., 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015012783/15.
(150014821) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
JM Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 123.621.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen.
On the thirty-first day of December.
Before us Maître Danielle KOLBACH, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg acting in
replacement of her prevented colleague Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,
who last named shall remain depositary of the present deed.
Appeared:
Mr. Jaroslaw MIKOS, businessman, born on January 20, 1967 in Sierpc, Poland, and residing at 51H/52 Wlodarzewska
Street, 02-384 Warsaw, Poland,
here represented by Mr. Max MAYER, private employee, residing professionally in Junglinster (Grand-Duchy of Lu-
xembourg), by virtue of a proxy given under private seal.
Such proxy having been signed "ne varietur" by the notary and the proxyholder, will remain attached to the present
deed in order to be recorded with it.
This appearing party, represented as said before, declares and requests the notary to act:
1) That the private limited company (société à responsabilité limitée) "JM Holdings S.à r.l.", with registered office at
L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B number 123621, has been incorporated by a
deed of Maître Emile SCHLESSER, notary residing at Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), on January 11, 2007,
published in the Mémorial C number 426 of March 22, 2007, and which articles of association have been amended by the
undersigned notary, on March 14, 2007, published in the Mémorial C number 1228 of June 21, 2007, (the "Company").
2) That the Company's capital is fixed at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by two
hundred and fifty (250) sharequotas of fifty euro (EUR 50.-) each.
3) That the appearing party is the holder of all the sharequotas of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints himself as liquidator of the Company; and in his capacity as liquidator of the
Company has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do
anything necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in his capacity as liquidator of the Company declares that he irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
25833
L
U X E M B O U R G
7) That the appearing party declares that he takes over all the assets of the Company and that he will assume any
existing debt of the Company pursuant to point 6).
8) That the liquidation of the Company is to be construed as definitely terminated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That all the sharequotas of the dissolved Company have been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved Company shall be kept for the duration of five years at least at the
former registered office at L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately EUR 950.-.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English and French, states herewith that on request of the above
appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing
person and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the mandatory, known to the notary by his surname, Christian name, civil status
and residence, the latter signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la version française de l'acte:
L'an deux mille quatorze.
Le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, (Grand-Duché de Luxembourg),
agissant en remplacement de son confrère empêché Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-
Duché de Luxembourg), lequel dernier restera dépositaire de la minute.
A comparu:
Monsieur Jaroslaw MIKOS, entrepreneur, né le 20 janvier 1967 à Sierpc, Pologne, et demeurant à 51 H/52 Wlodar-
zewska Street, 02-384 Varsovie, Pologne,
représenté par M. Max MAYER, employé privé, domicilié professionnellement à Junglinster (Grand-Duché de Luxem-
bourg),
en vertu d'une procuration sous seing privé lui délivrée.
Laquelle procuration, après avoir été signée “ne varietur” par le notaire et le mandataire, restera annexée au présent
acte avec lequel elle sera enregistrée.
Lequel comparant, représenté comme dit ci-avant, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée "JM Holdings S.à r.l.", ayant son siège à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène
Ruppert, R.C.S. Luxembourg section B numéro 123621, a été constituée suivant acte de Maître Emile SCHLESSER, notaire
de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial C numéro
426 du 22 mars 2007 et dont les statuts ont été modifié suivant acte du notaire soussigné, en date du 14 mars 2007,
publié au Mémorial C numéro 1228 du 21 juin 2007 (la "Société").
2) Que le capital de la Société est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par deux cent cinquante
(250) parts sociales de cinquante euros (EUR 50,-) chacune.
3) Que le comparant est l'associé unique de la Société.
4) Que le comparant a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que le comparant se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6) Que le comparant en sa qualité de liquidateur de la Société déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif
présent et futur de la Société dissoute.
7) Que le comparant déclare qu'il reprend tout l'actif de la Société et qu'il s'engagera à régler tout le passif de la Société
indiqué au point 6).
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation des parts sociales de la Société dissoute.
11) Que les livres et documents de la Société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
25834
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de 950,- EUR.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais et le français, constate par les présentes qu'à la requête de la
personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même
personne et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, connu du notaire par nom, prénom usuel, état et de-
meure, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Max MAYER, Danielle KOLBACH.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/224. Reçu soixante-quinze euros 75,00
€.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2015012785/102.
(150014529) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Kartesia Management, Société Anonyme,
(anc. Kartesia GP S.A.).
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 179.289.
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
Was held
an extraordinary general meeting of shareholders (the "Meeting") of "Kartesia GP S.A.", a public limited company
(société anonyme), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg
Register of Trade and Companies under number B 179.289 (the "Company"). The Company was incorporated pursuant
to a notarial deed enacted on 2 August 2013 and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2110 of 30 August 2013.
The Meeting is chaired by Mrs Régis Galiotto, professionally residing in Luxembourg, as chairman, who appointed Mrs
Solange Wolter-Schieres, professionally residing in Luxembourg, as secretary.
The Meeting elected Mr Frédéric Pelé, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer.
The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to record
that:
- All the shares being registered shares, a convening notice reproducing the agenda of the present Meeting was sent
by registered mail to each of the registered shareholders of the Company on 11 December 2014 in accordance with
article 10 of the articles of incorporation of the Company so that the Meeting is properly constituted and can validly
consider all items of the agenda.
- That the shareholders present or represented and the number of their shares are shown on an attendance list, signed
by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list as well as the proxies will be
annexed to this document to be filed with the registration authorities.
- It results from said attendance list that all the thirty-one thousand (31,000) outstanding shares are represented so
that the Meeting may validly take resolutions on the items of the agenda.
- The agenda of the Meeting is the following:
1. Renaming the company. Change of the corporate name of the Company from "Kartesia GP S.A." into "Kartesia
Management".
2. Change of object. Change of corporate purpose from acting as a general partner to an alternative investment fund
manager under the Luxembourg law of 12 July 2013 on alternative investment fund managers (the "AIFM Law").
3. Capital increase. Increase of the share capital of the Company from thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) to five
hundred thousand euros (EUR 500,000.-) divided into:
- Fifty-four thousand five hundred (54,500) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Mr Damien
Scaillierez, born on 21 May 1969 in Angers, France, with professional address at Bond Street House - 14 Clifford Street
W1S4JU London, United Kingdom;
25835
L
U X E M B O U R G
- Thirty-six thousand five hundred (36,500) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Mr Matthieu
Delamaire, born on 17 May 1975 in Saint-Malo, France, with professional address at Gachard House, 88 rue Gachard,
B-1050 Brussels;
- Fifty-four thousand five hundred (54,500) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Mr Jaime Prieto,
born on 2 June 1976 in Madrid, Spain with professional address at Bond Street House - 14 Clifford Street W1S4JU London,
United Kingdom;
- One hundred thousand (100,000) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Sagard SAS, a société
par actions simplifiée, having its registered office at 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France and registered with the
Paris register of commerce and companies under number 439 725 524 Siret 00029;
- Fifty-four thousand five hundred (54,500) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Sextant
Patrimoine S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law with registered office at 412F,
route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg ("RCS") under the number B 168.358; and
- Two hundred thousand (200,000) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) subscribed by Sienna Capital S.à r.l.,
a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law with registered office at 19-21, route d'Arlon,
L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under the number B 178.406.
4. Amendment to register of shareholders. Amending the register of shareholders of the Company in order to reflect
the above capital increase and to give power to Alter Domus Alternative Asset Fund Administration S.à r.l., a private
limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, (“Alter Domus”), acting in its
capacity of central administration agent of the Company, (i) to proceed on behalf and in the name of the Company with
the registration of the newly issued shares in the register of shareholders of the Company, including for the avoidance
of doubt, the signature of the said register, and (ii) to see to any formalities in connection therewith, if any.
5. Subordinated shareholder loan. Approval of the unsecured subordinated shareholder loans whereby the sharehol-
ders make available to the Company loans of an aggregate amount of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-)
divided as follows:
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Mr Damien Scaillierez;
- Fifty-four thousand seven hundred and fifty euros (EUR 54,750.-) made available by Mr Matthieu Delamaire;
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Mr Jaime Prieto;
- One hundred and fifty thousand euros (EUR 150,000.-) made available by Sagard SAS;
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Sextant Patrimoine S.à r.l.; and
- Three hundred thousand euros (EUR 300,000.-) made available by Sienna Capital S.à r.l.
6. General update of the articles of incorporation. Amendments to the articles of incorporation of the Company in
order to perform a general legal and regulatory update, notably further to the adoption of the AIFM Law, and related
applicable regulations.
7. Restatement of the articles of incorporation. Restatement of the articles of incorporation in order to reflect the
amendments adopted by the Meeting and to harmonise content and format.
After deliberation, the following resolutions were unanimously taken by the Meeting:
<i>First resolutioni>
The Meeting RESOLVES to change the corporate name of the Company from "Kartesia GP S.A." into "Kartesia Ma-
nagement".
<i>Second resolutioni>
The Meeting RESOLVES to change the corporate purpose of the Company from acting as a general partner to an
alternative investment fund manager under the AIFM Law.
<i>Third resolutioni>
The Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company to the extent of four hundred and sixty-nine
thousand Euro (EUR 469,000.-) so as to raise it from its present amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000.-) up
to five hundred thousand euro (EUR 500,000.-) by the issue of four hundred and sixty-nine thousand (469,000) shares
having a par value of one Euro (EUR 1,-) each.
The Meeting RESOLVES to accept the subscription of all the new shares by the following shareholders:
- Mr Damien Scaillierez, born on 21 May 1969 in Angers, France, with professional address at Bond Street House - 14
Clifford Street W1S4JU London, United Kingdom, to the extent of fifty-one thousand one hundred and twenty-one
(51,121) shares, for a subscription price of fifty-one thousand one hundred and twenty-one Euros (EUR 51,121);
25836
L
U X E M B O U R G
- Mr Matthieu Delamaire, born on 17 May 1975 in Saint-Malo, France, with professional address at Gachard House,
88 rue Gachard, B-1050 Brussels, to the extent of thirty-four thousand two hundred and thirty-seven (34,237) shares,
for a subscription price of thirty-four thousand two hundred and thirty-seven Euros (EUR 34,237);
- Mr Jaime Prieto, born on 2 June 1976 in Madrid, Spain with professional address at Bond Street House - 14 Clifford
Street W1S4JU London, United Kingdom, to the extent of fifty-one thousand one hundred and twenty-one (51,121)
shares, for a subscription price of fifty-one thousand one hundred and twenty-one Euros (EUR 51,121);
- Sagard SAS, a société par actions simplifiée, having its registered office at 24/32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, France
and registered with the Paris register of commerce and companies under number 439 725 524 Siret 00029, to the extent
of ninety-three thousand eight hundred (93,800) shares, for a subscription price of ninety-three thousand eight hundred
Euros (EUR 93,800);
- Sextant Patrimoine S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law with registered
office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Com-
merce et des Sociétés, Luxembourg ("RCS") under the number B 168.358, to the extent of fifty-one thousand one hundred
and twenty-one (51,121) shares, for a subscription price of fifty-one thousand one hundred and twenty-one Euros (EUR
51,121), and
- Sienna Capital S.à r.l., a société à responsabilité limitée incorporated under Luxembourg law with registered office
at 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under the number B
178.406, to the extent of one hundred and eighty-seven thousand six hundred (187,600) shares for a subscription price
of one hundred and eighty-seven thousand six hundred Euros (EUR 187,600).
All the subscribers are here represented by Mr Frédéric Pelé, prenamed, by virtue of the aforementioned proxies.
All the four hundred and sixty-nine thousand (469,000) new shares have been fully paid up by the subscribers by
payment in cash so that the amount of four hundred and sixty-nine thousand Euro (EUR 469,000) is as now available to
the Company as has been proved to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve the amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect
the above capital increase and to give power to Alter Domus, acting in its capacity of central administration agent of the
Company, (i) to proceed on behalf and in the name of the Company with the registration of the newly issued shares in
the register of shareholders of the Company, including for the avoidance of doubt, the signature of the said register, and
(ii) to see to any formalities in connection therewith, if any.
<i>Fifth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to approve the unsecured subordinated shareholder loans whereby the shareholders make
available to the Company loans of an aggregate amount of seven hundred fifty thousand euro (EUR 750,000.-) divided as
follows:
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Mr Damien Scaillierez;
- Fifty-four thousand seven hundred and fifty euros (EUR 54,750.-) made available by Mr Matthieu Delamaire;
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Mr Jaime Prieto;
- One hundred and fifty thousand euros (EUR 150,000.-) made available by Sagard SAS;
- Eighty-one thousand seven hundred and fifty euros (EUR 81,750.-) made available by Sextant Patrimoine S.à r.l.; and
- Three hundred thousand euros (EUR 300,000.-) made available by Sienna Capital S.à r.l.
<i>Sixth resolutioni>
The Meeting RESOLVES to amend the articles of incorporation of the Company in order to perform a general legal
and regulatory update, notably further to the adoption of the AIFM Law, and related applicable regulations.
<i>Seventh resolutioni>
The Meeting RESOLVES to restate the articles of incorporation which shall henceforth read as follows:
ARTICLES OF INCORPORATION
Chapter I - Form, Name, Duration, Object, Registered Office
Art. 1. Form, Name. There exists among the existing shareholders and all those who may become owner of shares in
the future, a public limited liability company ("société anonyme") under the name of "Kartesia Management" (hereinafter
the "Management Company").
The Management Company shall be governed by the present articles of incorporation (the "Articles") and by the law
of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Company Law"), by the law of 12 July 2013 on alternative
investment fund managers, as amended (the "AIFM Law"), and by Chapter 16 of the law of 17 December 2010 relating
to undertakings for collective investment (the "UCI Law").
25837
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Duration. The Management Company is established for an unlimited period of time. The Management Company
may be dissolved at any moment by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendments
of these Articles, as prescribed in article Art. 33 hereafter.
Art. 3. Object. In accordance with article 125 (2) of the UCI Law, the purpose of the Management Company is to act
as designated management company and manager of alternative investment funds ("AIFs") within the meaning of Directive
2011/61/EU and Chapter 2 of the AIFM Law. The activities of the Management Company as alternative investment fund
manager will be limited to those referred to in Annex I of the AIFM Law (i.e. portfolio management and risk management
of AIFs, administrative and marketing services and activities related to the assets of the AIFs).
The Management Company shall carry out any activities connected with the management, administration and promo-
tion of AIFs. In particular, it may, on behalf of AIFs, enter into any contract, purchase, sell, exchange and deliver any
securities, property or real estate assets and, more generally, assets constitutive of authorised investments of the AIFs,
proceed to or initiate any registrations and transfers in its name or in third parties' name in the register of shares or
debentures of any Luxembourg or foreign companies, and exercise on behalf of the AIFs and the holders of units or shares
of the AIFs, all rights and privileges, especially all voting rights attached to the securities constituting the assets of the
AIFs. The Management Company may further incorporate and/or acquire shares or other securities in or issued by any
of its subsidiary companies for the account of the AIFs managed by it. The foregoing powers shall not be considered as
exhaustive, but only as declaratory.
In addition, under the conditions and within the limits laid down by Luxembourg laws and regulations, the Management
Company may also enter into the following transactions for the accounts of the AIFs it manages, it being understood that
the Management Company will not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity that
would be considered as a regulated activity of the financial sector:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit equity, bonds, notes, promissory notes, cash, cash equivalent instruments and other
equity and/or debt instruments;
- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security within the limits of and in accordance with the
provisions of Luxembourg Law.
The Management Company may also carry out any activities connected directly or indirectly to, and/or deemed useful
and/or necessary for the accomplishment of its object, remaining, however, within the limitations set forth, but to the
largest extent permitted by the AIFM Law and article 125 (2) of the UCI Law.
Art. 4. Registered Office. The registered office of the Management Company is established in Luxembourg City, in the
Grand Duchy of Luxembourg. The registered office may be transferred to any other place inside the municipality of the
Management Company's registered office by a decision of the board of directors of the Management Company (the "Board
of Directors").
Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution of
the Board of Directors.
In the event that the Board of Directors determines that events of force majeure have occurred or are imminent that
would interfere with the normal activities of the Management Company at its registered office, or with the ease of
communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad
until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the
nationality of the Management Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office abroad,
will remain a Luxembourg company.
Chapter II - Share Capital
Art. 5. Share Capital. The share capital of the Management Company amounts to five hundred thousand euro (EUR
500,000.-) represented by five hundred thousand (500,000) shares, each with a par value of one euro (EUR 1.-) per share.
The five hundred thousand (500,000) shares have all been fully paid in cash.
Art. 6. Increase or Redemption of Share Capital. The capital of the Management Company may be increased or reduced
by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles, as prescribed
in article Art. 33 hereafter.
Art. 7. Shares. The Management Company will issue shares in registered form only. A register of shareholders shall
be kept at the registered office of the Management Company. Such register shall set forth the name of each shareholder,
his residence or elected domicile, the number of shares held by him, the amounts paid in on each such share, and the
transfer of shares and the dates of such transfers.
Art. 8. Transfer of Shares. Shares issued by the Management Company may only be transferred with the prior approval
of the Board of Directors. If the Board of Directors refuses its consent, it has to present, if the shareholder so requests,
within a reasonable time a buyer who is willing to buy such shares on conditions corresponding to the value based on
the balance sheet.
25838
L
U X E M B O U R G
Chapter III - Meetings of Shareholders
Art. 9. Powers of the General Meeting of Shareholders. Any regularly convened meeting of the shareholders of the
Management Company shall represent the entire body of shareholders of the Management Company. It shall have the
broadest powers to order or ratify acts relating to the operations of the Management Company provided such powers
are not expressly reserved to the Board of Directors or the supervisory board of the Management Company (the "Su-
pervisory Board").
Art. 10. Annual General Meeting of Shareholders and Other Shareholders' meetings. The annual general meeting of
shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg, at the registered office of the Management
Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of the meeting, on the second Friday
of June at 2pm. If such day is not a business day, the annual general meeting shall be held on the following business day.
The annual general meeting may be held outside of the Grand Duchy of Luxembourg if, in the absolute and final judgment
of the Board of Directors, force majeure circumstances so require.
Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of
meeting.
Art. 11. Vote, Proxy. The quorum and delays required by law shall govern the notice for and conduct of the meetings
of shareholders of the Management Company, unless otherwise provided herein.
Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any meeting of the shareholders by appointing another
person as his proxy in writing or by cable, telegram, telex or facsimile transmission.
Any shareholder may participate in a meeting of shareholders by conference call, video conference or similar means
of communications equipment complying with technical features which guarantee an effective participation in the meeting
allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis. The participation in a
meeting of shareholders by these means is equivalent to a participation in person at such meeting of shareholder.
Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a meeting of shareholders will be passed by
a simple majority of those present or represented.
The Board of Directors may determine all other conditions that must be fulfilled by shareholders to take part in any
meeting of shareholders.
Art. 12. Notice of General Meetings of Shareholders. Shareholders will meet upon call by the Board of Directors, the
Supervisory Board or the independent auditor, pursuant to a notice setting forth the agenda sent by registered mail at
least eight (8) days prior to the meeting to each shareholder at the shareholder's address in the register of shareholders.
General meetings may also be called upon the request of shareholders representing at least ten per cent (10%) of the
share capital of the Management Company. If, however, all of the shareholders are present or represented at a meeting
of shareholders and if they state that they have been informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held
without prior convening notice.
Art. 13. General Meetings of Shareholders. The shareholders' meeting is presided over by the chairman of the Board
of Directors or in his absence, by the vice-chairman or by a director designated by the Board of Directors. The chairman
of the meeting appoints the secretary for the meeting. The meeting chooses two scrutineers upon proposal of the
chairman of the meeting.
Art. 14. Minutes of General Meetings of Shareholders. The minutes of any meeting shall be signed by the chairman of
the shareholder's meeting, the secretary and the scrutineers of the meeting and by shareholders who so request. Copies
or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman,
or by the secretary, or by two directors.
Chapter IV - Board of Directors
Art. 15. Appointment of Board of Directors. Unless otherwise provided for in these Articles, the provisions of article
60bis-1 to 60bis-19 of the Company Law regarding public limited companies having a management board and a supervisory
board shall be applicable.
The Management Company shall be managed by the Board of Directors, composed of at least three (3) members, who
need not be shareholders of the Management Company.
The members of the Board of Directors shall be appointed by the Supervisory Board, which shall determine their
number, remuneration, if any, and term of office. The term of the office of a member of the Board of Directors may not
exceed six (6) years and the members of the Board of Directors shall hold office until their successors are elected. The
members of the Board of Directors may be re-elected for consecutive terms of office.
The members of the Board of Directors are appointed by a simple majority vote of the members of the Supervisory
Board.
Subject to the terms and conditions of any shareholders' agreement that may be entered into from time to time, any
member of the Board of Directors may be removed at any time with or without cause by the Supervisory Board.
25839
L
U X E M B O U R G
In the event of a legal entity being appointed as member of the Board of Directors, such legal entity shall appoint a
permanent representative who will exercise the mandate in the name and on behalf of such legal entity. The legal entity
may withdraw its representative only by appointing a successor at the same time.
In the event of a vacancy in the office of a members of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise,
this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next meeting of the Supervisory Board, in compliance with
the applicable legal provisions.
Art. 16. Powers of the Board of Directors. The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all
acts of administration and disposition in the interest of the Management Company and of the AIFs managed by it. All
powers not expressly reserved by the law of these Articles to the general meeting of shareholders shall fall within the
competence of the Board of Directors or the Supervisory Board. The Board of Directors has in particular power to
determine the investment policy following the principles of risk spreading of the AIFs managed by it and the course and
conduct of the management and business affairs of the Management Company.
Art. 17. Delegation of Powers. The Board of Directors may from time to time appoint officers of the Management
Company (such as a general manager, administrative manager or other officers) considered necessary for the operation
and management of the Management Company and delegate to them its powers to conduct the daily management and
affairs of the Management Company (including the right to sign on behalf of the Management Company). The officers in
their turn may delegate their powers if they are authorized to do so by the Board of Directors. In particular, the Board
of Directors will appoint, in accordance with the requirements of the AIFM Law, at least two (2) officers as "dirigeants"
to effectively conduct the business of the Management Company. Any such appointment may be revoked at any time by
the Board of Directors. Any officers of the Management Company need not be directors or shareholders of the Mana-
gement Company and may be engaged by a service agreement. The officers appointed shall have the powers and duties
given to them by the Board of Directors.
Art. 18. Meetings of Board of Directors. The Board of Directors may choose from among its members a chairman,
and may choose among its members one or more vice-chairmen. It may also choose a secretary, who need not be a
director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board of Directors. The Board of
Directors shall meet upon call by the chairman or two directors, at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman shall preside over all meetings the Board of Directors, but in his absence the Board of Directors may
by a simple majority appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority present at any such
meeting.
Art. 19. Notice of Meetings of Board of Directors. Written notice of any meeting of the Board of Directors shall be
given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances
of emergency, in which case the nature and the reasons of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting.
This notice may be waived by the consent, in writing or by e-mail, cable, telegram, telex, facsimile transmission or any
other similar means of communication, of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings
held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.
Art. 20. Vote, Proxy. Any director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing or by e-
mail, cable, telegram, telefax or telex, facsimile transmission or any other means of communication another director as
his proxy. One director may replace several of his colleagues.
Any director may participate in a meeting of the Board of Directors by conference call or similar means of commu-
nication, whereby all persons participating in the meeting can hear each other. The participation in a meeting by such
means shall constitute presence in person at such meeting.
The Board of Directors can deliberate or act validly only if the majority of the directors are present or represented.
Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. In the
event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman shall have a casting
vote.
The directors may also approve by unanimous vote a circular resolution, by expressing their consent on one or several
separate instruments in writing or by e-mail, telex, telegram or facsimile, confirmed in writing, which shall all together
constitute appropriate minutes evidencing such decision. The date of such a resolution shall be the date of the last
signature.
Art. 21. Minutes of Meetings of Board of Directors. The minutes of any meeting of the Board of Directors shall be
signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting.
Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the
chairman, or by the secretary, or by two directors.
The directors may only act at duly convened meetings of the Board of Directors, or by written consent in accordance
with article Art. 19 hereof.
Art. 22. Conflict of Interest. No contract or other transaction between the Management Company and any other
entity or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Management
25840
L
U X E M B O U R G
Company is interested in such contract or transaction, or is a director, associate, officer or employee of such other entity
or firm.
Any director or officer of the Management Company who serves as a director, associate, officer or employee of any
entity or firm with which the Management Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason
of such affiliation with such other entity or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters
with respect to such contract or other business.
In the event that any director or officer of the Management Company may have any personal interest in any transaction
of the Management Company, such director or officer shall make known to the Board of Directors such personal interest
and shall not consider or vote upon any such transaction; and such transaction and such director's or officer's personal
interest therein shall be reported to the next succeeding meeting of shareholders.
The Management Company shall try to avoid any conflict of interest and when they cannot be avoided, ensure that
the AIFs managed by it are fairly treated.
Art. 23. Indemnification. The Management Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors
and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to
which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Management Company,
or, at its request, of any other entity of which the Management Company is a shareholder or creditor and from which
he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action,
suit or proceeding to be liable for gross negligence or fault or misconduct; in the event of a settlement, indemnification
shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Management Company
is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of
indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.
Art. 24. Signing Authority. The Management Company will be bound by the joint signatures of any two directors of
the Management Company, or by the joint signatures of a director and any duly authorized person, or by the joint
signatures of the two persons to which the conduct of the Management Company's business will be entrusted in accor-
dance with article Art. 17 of the present Articles, or in any other way determined by a resolution of the Board of Directors.
Chapter V - Supervisory board
Art. 25. Composition. The operations of the Management Company shall be supervised by a supervisory board com-
posed of five (5) members who need not be shareholders of the Management Company.
The members of the Supervisory Board are appointed by a simple majority of votes in the general meeting of share-
holders who also resolves on their remuneration, if any. The term of the office of a member of the Supervisory Board
may not exceed six (6) years and the members of the Supervisory Board shall hold office until their successors are elected.
Any member of the Supervisory Board may be removed at any time with or without cause by a simple majority of votes
in the general meeting of shareholders.
The members of the Supervisory Board may be re-elected for consecutive terms of office.
In the event of a legal entity being appointed as member of the Supervisory Board, such legal entity shall appoint a
permanent representative who will exercise the mandate in the name and on behalf of such legal entity. The legal entity
may withdraw its representative only by appointing a successor at the same time.
Art. 26. Powers. The Supervisory Board has such powers as foreseen in articles 60bis-11 and the following of the
Company Law. The Supervisory Board does not take an active part in the management of the Management Company and
has no competence in this regard.
The Supervisory Board has no power to bind the Management Company towards third parties. As a matter of internal
organisation of the Management Company, the consent from the Supervisory Board may be required for certain mana-
gement decisions of the Management Company as specified in any shareholders' agreement that may be entered into
from time to time and the Supervisory Board may be consulted by the Board of Directors prior to certain decisions as
specified in any shareholders' agreement that may be entered into from time to time.
The Board of Directors shall make a written quarterly report to the Supervisory Board on the current situation of
business of the Management Company and shall provide the Supervisory Board with the following information within the
following timeframe:
1) within thirty days after the end of each calendar quarter with the quarterly balance sheet, income statement and
schedules;
2) promptly with any information and documents susceptible of having a significant impact on the Management Com-
pany's situation of business.
The Supervisory Board is entitled to the broadest information to be given by the Board of Directors and it may at any
time, access the accounting books and any other Management Company's documents and it may scrutinize in any way
deemed necessary for the accomplishment of its tasks.
No member of the Supervisory Board can be member of the Board of Directors at the same time.
25841
L
U X E M B O U R G
Art. 27. Meetings. The Supervisory Board shall choose, from among its members a chairman, and may choose from
among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a member of the Supervisory Board,
and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board and of the general meetings
of shareholders.
The Supervisory Board shall meet at least every three (3) months and at any other moment, upon call by the chairman,
two of its members, or the Board of Directors at the place indicated in the notice of meeting.
The chairman of the Supervisory Board shall preside at all meetings of shareholders and of the Supervisory Board but
in his absence, the shareholders or the Supervisory Board, as the case may be, may appoint another person as chairman
pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.
Written notice of any meeting of the Supervisory Board must be given to the members of the Supervisory Board at
least forty-eight hours in advance of the date scheduled for the meeting by means of facsimile, electronic mail or any
other similar means of communication to be confirmed in writing, except in case of emergency, in which case the nature
and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each
member of the Supervisory Board in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication
to be confirmed in writing. A special convening notice will not be required for a board meeting to be held at a time and
location determined in a prior resolution adopted by the Supervisory Board.
Any member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing or
by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication to be confirmed in writing, another member
of the Supervisory Board as his proxy, it being specified that one member of the Supervisory Board may represent more
than one (1) colleague.
Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or
by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The
participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.
Art. 28. Voting. Subject to the terms and conditions of any shareholders' agreement that may be entered into from
time to time, the quorum of a meeting of the Supervisory Board shall be three (3) members of the Supervisory Board.
Decisions of the Supervisory Board shall be adopted upon a simple majority vote of the members present or repre-
sented. In case of a tie vote the chairman of the Supervisory Board shall have a casting vote.
Resolutions in writing approved and signed by all members of the Supervisory Board by circular means shall have the
same effect as resolutions passed at a meeting of the Supervisory Board. Such approval may be in a single or in several
separate documents and may be evidenced by letter, telefax or telex.
Chapter VI - Auditing
Art. 29. Independent Auditor. The operations of the Management Company, including particularly its books and fiscal
affairs and the filing of any tax returns or other reports required by the laws of Luxembourg, shall be supervised by one
or more independent auditors, qualifying as réviseurs d'entreprises agréés, justifying of adequate professional experience
and who shall not otherwise be affiliated with the Management Company.
The auditors shall be elected by the shareholders at the general meeting of shareholders which shall determine their
number, their remuneration and their term of office which may not exceed six years.
The auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders with or without cause.
Chapter VII - Financial Year, Distribution of Profits
Art. 30. Financial Year. The accounting year of the Management Company shall begin on the first (1) day of January
and shall terminate on the thirty-first (31) day of December of each year.
Art. 31. Distribution of Profits. From the annual net profits of the Management Company, five per cent (5%) shall be
allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such reserve
amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Management Company as stated in article Art. 5 hereof or as increased
or reduced from time to time.
The general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of
and may declare dividends from time to time, as it in its discretion believes best suits the corporate purpose and policy.
The dividend declared may be paid in any currency selected by the Board of Directors and may be paid at such places
and times as may be determined by the Board of Directors. The Board of Directors may make a final determination of
the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. Interim dividends may be
paid in compliance with the provisions set forth by law.
Chapter VIII - Dissolution, Liquidation
Art. 32. Dissolution, Liquidation. In the event of a dissolution of the Management Company, the liquidation shall be
carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the general meeting
of shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.
25842
L
U X E M B O U R G
Chapter IX - Amendment of the Articles
Art. 33. Amendments of the Articles. These Articles may be amended from time to time by a meeting of shareholders,
subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.
Chapter X - Applicable Law
Art. 34. Applicable Law. All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Com-
pany Law and the AIFM Law and, to the extent applicable, the UCI Law.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it, have been estimated at about ER 3,000.-.
There being no further business on the Agenda, the Meeting was thereupon closed.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surnames,
Christian names, civil status and residences, the members of the bureau signed together with Us, the notary, the present
original deed.
Follows the French translation:
En l'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
S'est tenue
une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'"Assemblée") de "Kartesia GP S.A.", une société anonyme
constituée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxem-
bourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro B 179.289 (ci-après la "Société"). La Société a été constituée en vertu d'un acte notarié daté du 2 août 2013 et
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2110 du 30 août 2013.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Régis Galiotto, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg, qui nomme
comme secrétaire Madame Solange Wolter-Schieres, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.
La réunion élit comme scrutateur Monsieur Frédéric Pelé, ayant sa résidence professionnelle à Luxembourg.
Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
- Toutes les actions étant nominatives, une convocation reproduisant l'ordre du jour de la présente Assemblée a été
envoyée par lettre recommandée à chacun des actionnaires enregistrés de la Société le 11 décembre 2014 en application
de l'article 10 des statuts de la Société, de sorte que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut considérer vala-
blement tous les points de l'ordre du jour.
- Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste
de présence, signée par le président, le secrétaire, le scrutateur et le notaire instrumentant. Ladite liste de présence ainsi
que les procurations resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.
- Qu'il résulte de ladite liste de présence que toutes les trente et une mille (31.000) actions émises sont représentées
de sorte que l'Assemblée peut valablement adopter des résolutions concernant les points figurant à l'ordre du jour.
- Que la présente Assemblée a pour
<i>Ordre du jour:i>
1. Changement de la dénomination sociale de la société. Changement de la dénomination sociale de la Société de
"Kartesia GP S.A." à "Kartesia Management".
2. Changement de l'objet social de la société. Changement de l'objet social de la Société qui n'agira désormais plus en
qualité de gérant mais en qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément à la loi luxembour-
geoise du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (la "Loi GFIA").
3. Augmentation du capital social. Augmentation du capital social de la Société de trente et un mille euros (EUR 31.000,-)
à cinq cent mille euros (EUR 500.000,-) représenté par:
- Cinquante-quatre mille cinq cents (54.500) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Mr
Damien Scaillierez, né le 21 mai 1969 à Angers, France, ayant sa résidence professionnelle à Bond Street House - 14
Clifford Street W1S4JU Londres, Royaume-Uni;
25843
L
U X E M B O U R G
- Trente-six mille cinq cents (36.500) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Mr Matthieu
Delamaire, né le 17 mai 1975 à Saint-Malo, France, ayant sa résidence professionnelle à Gachard House, 88 rue Gachard,
B-1050 Bruxelles, Belgique;
- Cinquante-quatre mille cinq cents (54.500) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Mr.
Jaime Prieto, né le 2 juin 1976 à Madrid, Espagne, ayant sa résidence professionnelle à Bond Street House - 14 Clifford
Street W1S4JU Londres, Royaume-Uni;
- Cent mille (100.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Sagard SAS, une société par
actions simplifiée, ayant son siège social à 24/32 rue Jean Goujoun, 75008 Paris, France et inscrite auprès du registre de
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 725 524 Siret 00029;
- Cinquante-quatre mille cinq cents (54.500) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Sextant
Patrimoine S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social
à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés ("RCS") sous le numéro B 168.358; et
- Deux cent mille (200.000) actions d'une valeur nominale de un euro (EUR 1.-) souscrites par Sienna Capital S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège social à 19-21 route
d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du RCS sous le numéro B 178.406.
4. Modification du registre des actionnaires. Modifier le registre des actionnaires de la Société de manière à refléter
l'augmentation de capital énoncée ci-dessus et de donner pouvoir à Alter Domus Alternative Asset Fund Administration
S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et existante selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant
son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, ("Alter Domus"), agissant en qualité d'agent d'adminis-
tration centrale de la Société, (i) de procéder pour et au nom de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises
dans le registre des actionnaires de la Société, y compris, à des fins de clarification, la signature dudit registre, et (ii)
d'effectuer toutes les formalités en connexion avec ceci, le cas échéant.
5. Prêt d'actionnaire non privilégié. Approbation des prêts d'actionnaire non privilégiés, par lesquels les actionnaires
mettent à disposition de la Société des prêts d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) divisé
comme suit:
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Mr Damien Scaillierez;
- Cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 54.750,-) mis à disposition par Mr Matthieu Delamaire;
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Mr Jaime Prieto;
- Cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) mis à disposition par Sagard SAS;
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Sextant Patrimoine S.à r.l.; et
- Trois cent mille euros (EUR 300.000,-) mis à disposition par Sienna Capital S.à r.l.
6. Mise à jour globale des statuts de la société. Modification des statuts de la Société afin d'effectuer une mise à jour
légale et réglementaire générale, et plus particulièrement suite à l'adoption de la Loi GFIA et des règlements connexes
applicable à la Société.
7. Modification des statuts. Modification des statuts afin que ceux-ci reflètent les changements adoptés par l'Assemblée
et d'harmoniser le contenu et la forme.
Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité par l'Assemblée:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide de changer la dénomination sociale de la Société de "Kartesia GP S.A." à "Kartesia Management".
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier l'objet social de la Société qui n'agira désormais plus en qualité de gérant mais en
qualité de gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément à la Loi GFIA.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de quatre cent soixante-neuf mille Euros
(EUR 469.000,-) pour le porter de son montant actuel de trente et un mille Euros (EUR 31.000,-) à cinq cent mille Euros
(EUR 500.000,-) par l'émission de quatre cent soixante-neuf mille (469.000) actions ayant une valeur nominale d'un Euro
(EUR 1,-) chacune.
Toutes les nouvelles actions ont été souscrites par les actionnaires comme suit:
- Mr Damien Scaillierez, né le 21 mai 1969 à Angers, France, ayant sa résidence professionnelle à Bond Street House
- 14 Clifford Street W1S4JU Londres, Royaume-Uni, à concurrence de cinquante et un mille cent vingt et une (51.121)
actions au prix de souscription de cinquante et un mille cent vingt et un Euros (EUR 51.121,-);
- Mr Matthieu Delamaire, né le 17 mai 1975 à Saint-Malo, France, ayant sa résidence professionnelle à Gachard House,
88 rue Gachard, B-1050 Bruxelles, Belgique, à concurrence de trente-quatre mille deux cent trente-sept (34.237) actions
au prix de souscription de trente-quatre mille deux cent trente-sept Euros (EUR 34.237);
25844
L
U X E M B O U R G
- Mr. Jaime Prieto, né le 2 juin 1976 à Madrid, Espagne, ayant sa résidence professionnelle à Bond Street House - 14
Clifford Street W1S4JU Londres, Royaume-Uni, à concurrence de cinquante et un mille cent vingt et une (51.121) actions
au prix de souscription de cinquante et un mille cent vingt et un Euros (EUR 51.121,-);
- Sagard SAS, une société par actions simplifiée, ayant son siège social à 24/32 rue Jean Goujoun, 75008 Paris, France
et inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 439 725 524 Siret 00029, à concurrence
de quatre-vingt-treize mille huit cents (93.800) actions au prix de souscription de quatre-vingt-treize mille huit cents Euros
(EUR 93.800,-);
- Sextant Patrimoine S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son
siège social à 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés ("RCS") sous le numéro B 168.358, à concurrence de cinquante et un mille cent vingt et une
(51.121) actions au prix de souscription de cinquante et un mille cent vingt et un Euros (EUR 51.121,-); et
- Sienna Capital S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée selon les lois luxembourgeoises, ayant son siège
social à 19-21 route d'Arlon, L-8009 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite auprès du RCS sous le numéro B
178.406., à concurrence de cent quatre-vingt-sept mille six cents (187.600) actions au prix de souscription de cent quatre-
vingt-sept mille six cents Euros (EUR 187.600,-).
Tous les souscripteurs sont ici représentés par Monsieur Frédéric Pelé, prénommé, en vertu de procurations dont
mention ci-avant.
Toutes les quatre cent soixante-neuf mille (469.000) actions nouvelles ont été entièrement libérées par les souscri-
pteurs par versement en espèces, de sorte que le montant de quatre cent soixante-neuf mille Euros (EUR 469.000) est
dès à présent à la libre disposition de la Société ainsi qu'il a été justifié au notaire instrumentant.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver la modification du registre des actionnaires de la Société de manière à refléter l'aug-
mentation de capital énoncée ci-dessus et de donner pouvoir à Alter Domus agissant en qualité d'agent d'administration
centrale de la Société, (i) de procéder pour et au nom de la Société à l'inscription des actions nouvellement émises dans
le registre des actionnaires de la Société, y compris, à des fins de clarification, la signature dudit registre, et (ii) d'effectuer
toutes les formalités en connexion avec ceci, le cas échéant.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide d'approuver les prêts d'actionnaires non privilégiés par lesquels les actionnaires mettent à dispo-
sition de la Société des prêts d'un montant de sept cent cinquante mille euros (EUR 750.000,-) divisé comme suit:
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Mr Damien Scaillierez;
- Cinquante-quatre mille sept cent cinquante euros (EUR 54.750,-) mis à disposition par Mr Matthieu Delamaire;
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Mr Jaime Prieto;
- Cent cinquante mille euros (EUR 150.000,-) mis à disposition par Sagard SAS;
- Quatre-vingt-un mille sept cent cinquante euros (EUR 81.750,-) mis à disposition par Sextant Patrimoine S.à r.l.; et
- Trois cent mille euros (EUR 300.000,-) mis à disposition par Sienna Capital S.à r.l.
<i>Sixième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les statuts de la Société afin d'effectuer une mise à jour légale et réglementaire générale,
et plus particulièrement suite à l'adoption de la Loi GFIA et des règlements connexes applicables à la Société.
<i>Septième résolutioni>
L'Assemblée décide de modifier les statuts qui auront désormais la teneur suivante:
Chapitre I
er
- Forme, Dénomination, Durée, Objet, Siège social
Art. 1
er
. Forme, Dénomination. Il existe entre les actionnaires actuels et tous ceux qui deviendront actionnaires par
la suite, une société anonyme sous la dénomination de "Kartesia Management" (ci-après la "Société de Gestion").
La Société de Gestion sera régie par les présents statuts (les "Statuts") ainsi que par la loi du 10 août 1915 relative aux
sociétés commerciales, (la "Loi sur les Sociétés") telle que modifiée, par la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires
de fonds d'investissement alternatifs, telle que modifiée (la "Loi GFIA") et par le Chapitre 16 de la loi du 17 décembre
2010 relative aux organismes de placement collectifs (la "Loi OPC").
Art. 2. Durée. La Société de Gestion est établie pour une période illimitée. Elle peut être dissoute à tout moment par
décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, ainsi qu'il est
précisé à l'article 33 ci-après.
Art. 3. Objet. Conformément à l'article 125 (2) de la Loi OPC, l'objet social de la Société de Gestion est d'agir en
qualité de société de gestion désignée et/ou gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ("FIA") au sens de la Di-
rective 2011/61/UE et du Chapitre 2 de la Loi GFIA. Les activités que la Société de Gestion mènera en qualité de
gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs se limiteront à celles visées par l'Annexe 1 de la Loi GFIA (à savoir
25845
L
U X E M B O U R G
gestion de portefeuille et/ou gestion du risque lié à des FIA, services administratifs et de commercialisation ainsi qu'aux
activités liées aux actifs des FIA).
La Société de Gestion conduira toutes les actions en rapport avec la gestion, l'administration et la promotion de FIA.
En particulier, elle pourra, pour le compte de FIA, conclure des contrats, acheter, vendre, échanger et délivrer toute
valeur mobilière, propriété et actif immobilier et, plus généralement, tout actif constituant un investissement autorisé
pour des FIA, procéder à ou initier toute inscription et tout transfert en son nom ou au nom de tiers dans le registre
d'actions ou d'obligations de toute société luxembourgeoise ou étrangère, et exercer pour le compte des FIA et des
détenteurs de parts ou d'actions de FIA tous droits et privilèges, en particulier tous droits de vote attachés aux titres
constituant les actifs des FIA. La Société de Gestion pourra en outre constituer et/ou acquérir des actions ou autres titres
dans ou émis par ses filiales pour le compte des FIA qu'elle gère. La liste des pouvoirs énumérés ci-avant ne doit pas être
considérée comme limitative, mais simplement comme exemplative.
La Société de Gestion a également pour objet, en accord avec les conditions et dans les limites posées par les lois et
règlements luxembourgeois, de conclure les accords suivants pour le compte des FIA qu'elle gère, étant entendu que la
Société de Gestion ne peut conclure une opération qui l'engagerait dans toute activité qui serait considérée comme une
activité réglementée du secteur financier:
- emprunter de l'argent sous quelque forme que ce soit et obtenir toute sorte de crédit;
- avancer, prêter, ou mettre en dépôt des titres de capital, obligations, titres de créance, billets à ordre, argent liquide,
ou tout instrument ou titre de capital et/ou de dette équivalent à de l'argent liquide;
- conclure toute garantie, nantissement, ou tout autre sûreté dans les limites imposées et en conformité avec le droit
luxembourgeois.
La Société de Gestion pourra également mener toutes activités liées directement ou indirectement à, et/ou réputées
utiles et/ou nécessaires pour l'accomplissement de son objet social, en restant toutefois dans les limites prévues par les
dispositions de la Loi GFIA et de l'article 125 (2) de la Loi OPC.
Art. 4. Siège Social. Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut
être transféré à tout autre endroit à l'intérieur de la commune du siège social de la Société de Gestion par décision du
conseil d'administration de la Société de Gestion (le "Conseil d'Administration").
Il peut être créé, par simple décision du Conseil d'Administration, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-
Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.
Au cas où le Conseil d'Administration décide que des événements de force majeure de nature à compromettre l'activité
normale de la Société de Gestion au siège social, ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger
se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation
complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la
Société de Gestion, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège social, restera une société de droit luxembour-
geois.
Chapitre II - Capital Social
Art. 5. Capital Social. Le capital social de la Société de Gestion est fixé à cinq cent mille euros (EUR 500,000,-),
représenté par cinq cent mille (500,000) actions, chacune d'entre elles ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-)
par action. Les cinq cent mille (500,000) actions ont toutes été totalement libérées en numéraire.
Art. 6. Augmentation ou Diminution de Capital. Le capital de la Société de Gestion peut être augmenté ou réduit par
résolution des actionnaires prise conformément aux dispositions exigées pour la modification des présents Statuts, telles
qu'établies à l'article 33 ci-après.
Art. 7. Actions. La Société de Gestion émettra des actions nominatives. Un registre des actionnaires sera tenu au siège
social de la Société de Gestion. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu,
le nombre d'actions qu'il détient, la somme libérée pour chacune de ces actions ainsi que le transfert des actions et les
dates de ces transferts.
Art. 8. Transfert d'Actions. Les actions émises par la Société de Gestion ne pourront être transférées, qu'avec l'accord
préalable du Conseil d'Administration. En cas de non-agrément, le Conseil d'Administration peut être requis par l'ac-
tionnaire de lui présenter dans un délai raisonnable un acheteur désireux de reprendre ses actions sur la base de la valeur
déterminée au bilan.
Chapitre III - Assemblées des Actionnaires
Art. 9. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des Actionnaires. L'assemblée générale des actionnaires de la Société de
Gestion régulièrement convoquée représente tous les actionnaires de la Société de Gestion. Elle a les pouvoirs les plus
larges pour ordonner ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société de Gestion sous réserve des pouvoirs
expressément réservés au Conseil d'Administration ou au conseil de surveillance de la Société de Gestion (le "Conseil
de Surveillance").
25846
L
U X E M B O U R G
Art. 10. Assemblée Générale Annuelle et Autres Assemblées. L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra
conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg, au siège social de la Société de Gestion, ou à tout autre endroit
à Luxembourg qui sera fixé dans l'avis de convocation, le deuxième vendredi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour n'est
pas un jour ouvrable, l'assemblée générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée générale
annuelle peut avoir lieu en dehors du Grand-Duché de Luxembourg si, sur base d'une décision absolue et définitive du
Conseil d'Administration, des circonstances de force majeure le justifient.
D'autres assemblées générales des actionnaires pourront se tenir aux lieu et heure spécifiés dans les avis de convo-
cation.
Art. 11. Vote, Procuration. Les quorums et délais requis par la loi régleront les avis de convocation et la conduite des
assemblées générales des actionnaires de la Société de Gestion dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé dans
les présents Statuts.
Toute action donne droit à une voix. Tout actionnaire pourra prendre part aux assemblées générales des actionnaires
en désignant par écrit au par câble, par télégramme, par télex ou par télécopie une autre personne comme son mandataire.
Tout actionnaire peut participer aux assemblées des actionnaires par conférence téléphonique, visio-conférence ou
tout autre moyen de communication dont les spécificités techniques garantissent une participation effective à l'assemblée,
permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre en permanence. La participation à une assemblée
des actionnaires par ces moyens est réputée équivalente à une présence physique à l'assemblée des actionnaires.
Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou les présents Statuts, les décisions de l'assemblée
générale des actionnaires sont prises à la majorité des actionnaires présents ou représentés.
Le Conseil d'Administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour prendre part
à l'assemblée générale des actionnaires.
Art. 12. Convocation des Assemblées Générales. Las assemblées générales des actionnaires seront convoquées par
le Conseil d'Administration, le Conseil de Surveillance ou le réviseur d'entreprises agréé, à la suite d'un avis énonçant
l'ordre du jour, envoyé par recommandé au moins huit (8) jours avant l'assemblée à tout actionnaire à son adresse portée
au registre des actionnaires. Elles peuvent l'être également sur la demande d'actionnaires représentant dix pour cent
(10%) au moins du capital social de la Société de Gestion.
Cependant, si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale et s'ils affirment avoir été
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, celle-ci pourra être tenue sans avis de convocation préalable.
Art. 13. Assemblées des Actionnaires. L'assemblée est présidée par le président du Conseil d'Administration ou en
son absence, par le vice-président ou un administrateur désigné par le Conseil d'Administration. Le président de l'as-
semblée nomme le secrétaire pour la durée de la réunion. L'assemblée choisit deux scrutateurs sur proposition du
président de l'assemblée.
Art. 14. Procès-verbaux des Assemblées des Actionnaires. Les procès-verbaux de chaque assemblée sont signés par
le président de l'assemblée, le secrétaire et les scrutateurs de l'assemblée et les actionnaires qui en font la demande. Les
copies ou extraits des procès-verbaux qui peuvent être produits dans le cadre de procédures judiciaires ou autres sont
signés par le président, ou par le secrétaire, ou par deux administrateurs.
Chapitre IV - Conseil d'Administration
Art. 15. Nomination des Membres du Conseil d'Administration. Sauf indication contraire des présents Statuts, les
dispositions des articles 60 bis-1 à 60 bis-19 de la Loi sur les Sociétés concernant les sociétés anonymes à directoire et
conseil de surveillance seront applicables.
La Société de Gestion sera dirigée par le Conseil d'Administration, composé au minimum de trois (3) membres, qui
n'auront pas nécessairement la qualité d'actionnaire de la Société de Gestion.
Les membres du Conseil d'Administration seront nommés par le Conseil de Surveillance, qui fixera leur nombre, leur
rémunération, le cas échéant, et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un membre du Conseil d'Administration
ne pourra dépasser six (6) ans et les membres du Conseil d'Administration resteront en fonction jusqu'à la nomination
de leur successeur. Les membres du Conseil d'Administration sont rééligibles pour des mandats successifs.
Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par un vote à la majorité simple des membres du Conseil de
Surveillance.
Sous réserve des termes et conditions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment, tout
membre du Conseil d'Administration pourra être révoqué à tout moment ad nutum par le Conseil de Surveillance.
En cas de nomination d'une personne morale en qualité de membre du Conseil d'Administration, ladite personne
morale devra désigner un représentant permanent pour exercer le mandat en son nom et pour son compte. La personne
morale ne pourra retirer son représentant que par la nomination concomitante d'un successeur.
En cas de vacance parmi les membres du Conseil d'Administration pour cause de décès, retraite, ou toute autre raison,
il pourra être pourvu à cette vacance à titre provisoire jusqu'à la prochaine réunion du Conseil de Surveillance, dans le
respect des dispositions légales applicables.
25847
L
U X E M B O U R G
Art. 16. Pouvoirs du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus
pour passer tout acte d'administration et de disposition dans l'intérêt de la Société de Gestion et des FIA gérés par lui.
Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou par ces Statuts à l'assemblée générale des action-
naires ou au Conseil de Surveillance relèvent de la compétence du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration
a en particulier le pouvoir de déterminer la politique d'investissement, selon les principes de diversification des risques
des FIA gérés par lui ainsi que le cadre et la conduite de la gestion et des affaires de la Société de Gestion.
Art. 17. Délégation de Pouvoirs. Le Conseil d'Administration peut de temps à autre nommer des dirigeants de la
Société de Gestion (comme un directeur général, directeur administratif ou autres agents) nécessaires pour le fonction-
nement et la gestion de la Société de Gestion et leur déléguer ses pouvoirs de conduite de la gestion et des affaires
quotidiennes de la Société de Gestion (en ce compris le droit de signer au nom de la Société de Gestion). Les dirigeants
peuvent ensuite déléguer leurs pouvoirs s'ils y ont été autorisés par le Conseil d'Administration. En particulier, le Conseil
d'Administration nommera, conformément aux exigences de la Loi GFIA, au moins deux (2) agents en tant que «diri-
geants» afin de mener efficacement les activités de la Société de Gestion. Une telle nomination peut être révoquée à tout
moment par le Conseil d'Administration. Tous les dirigeants de la Société de Gestion doivent être administrateurs ou
actionnaires de la Société de Gestion et ils peuvent être engagés par un contrat de service. Les dirigeants nommés auront
les pouvoirs et fonctions attribués par le Conseil d'Administration.
Art. 18. Réunions du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration pourra choisir parmi ses membres un
président et pourra élire en son sein un ou plusieurs vice-présidents, il pourra également désigner un secrétaire qui n'a
pas besoin d'être un administrateur et qui devra dresser les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.
Le Conseil d'Administration se réunira sur la convocation du président ou de deux administrateurs, au lieu indiqué dans
l'avis de convocation.
Le président du Conseil d'Administration présidera les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le
Conseil d'Administration désignera à la majorité simple des personnes présentes à la réunion un autre administrateur
pour assumer la présidence pro tempore de ces réunions.
Art. 19. Convocation des Réunions du Conseil d'Administration. Avis écrit de toute réunion du Conseil d'Adminis-
tration sera donné à tous les administrateurs au moins vingt-quatre (24) heures avant l'heure prévue pour la réunion,
sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés dans l'avis de convocation. On
pourra passer outre à cette convocation à la suite de l'assentiment, par écrit ou transmis par courriel, câble, télégramme,
télex ou télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, de chaque administrateur. Une convocation spéciale
ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans
une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.
Art. 20. Vote, Procuration. Tout administrateur pourra se faire représenter à toute réunion du Conseil d'Adminis-
tration en désignant par écrit, courriel, câble, télégramme, télécopieur ou télex, fac-similé ou tout autre moyen de
communication un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses
collègues.
Tout administrateur pourra participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique ou
d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre
les unes les autres. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.
Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et agir que si la majorité des administrateurs est présente ou repré-
sentée,
Les décisions sont prises à la majorité des votes des administrateurs présents ou représentés. Au cas où, lors d'une
réunion du conseil, il y a égalité des voix en faveur et en défaveur d'une résolution, le président aura voix prépondérante.
Les administrateurs peuvent également adopter, par un vote unanime, des résolutions circulaires, en exprimant leur
consentement dans un ou plusieurs documents distincts par écrit ou par télex, télégramme ou fac-similé, confirmé par
écrit, qui constitueront une fois tous rassemblés des procès-verbaux tenant lieu de preuve de cette décision. La date
d'une telle décision sera la date de la dernière signature.
Art. 21. Procès-verbaux des Réunions du Conseil d'Administration. Les procès-verbaux des réunions du Conseil
d'Administration seront signés par le président ou, en son absence, par l'administrateur qui aura assumé la présidence en
son absence.
Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par
le secrétaire ou par deux administrateurs.
Les administrateurs ne pourront agir que dans le cadre de réunions du Conseil d'Administration régulièrement con-
voquées, ou par confirmation écrite conformément à l'article 19.
Art. 22. Conflits d'Intérêts. Aucun contrat et aucune transaction que la Société de Gestion pourra conclure avec
d'autres entités ou sociétés ne pourront être affectés ou viciés par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs, directeurs
ou fondés de pouvoir de la Société de Gestion auraient un intérêt quelconque dans tel autre contrat ou transaction, ou
par le fait qu'ils seraient administrateur, associé, directeur, fondé de pouvoir ou employé de cette autre société ou firme.
25848
L
U X E M B O U R G
L'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société de Gestion, qui est administrateur, directeur, associé,
fondé de pouvoir ou employé d'une société ou firme avec laquelle la Société de Gestion passe des contrats, ou avec
laquelle elle est autrement en relations d'affaires, ne sera pas par là même privé du droit de délibérer, de voter et d'agir
en ce qui concerne des matières en relation avec pareil contrat ou pareilles affaires.
Au cas où un administrateur, directeur ou fondé de pouvoir de la Société de Gestion aurait un intérêt opposé dans
quelque affaire de la Société de Gestion, cet administrateur, directeur ou fondé de pouvoir devra informer le Conseil
d'Administration de son intérêt opposé et il ne délibérera et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; rapport devra
être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt opposé de pareil administrateur, directeur ou fondé de pouvoir à la
prochaine assemblée générale des actionnaires.
La Société de Gestion cherche à éviter tout conflit d'intérêts et si elle ne peut l'éviter, elle s'assure que les FIA qu'elle
gère sont gérés honnêtement.
Art. 23. Indemnisation. La Société de Gestion pourra indemniser tout administrateur, directeur ou fondé de pouvoir,
ses héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs, des dépenses raisonnablement occasionnées par toutes ac-
tions ou tous procès auxquels il aura été partie en sa qualité d'administrateur, de directeur ou fondé de pouvoir de la
Société de Gestion, ou pour avoir été, à la demande de la Société de Gestion, administrateur, directeur ou fondé de
pouvoir de toute autre société dont la Société de Gestion est actionnaire ou créditrice et par laquelle il ne serait pas
indemnisé, sauf le cas où dans pareils actions ou procès il sera finalement condamné pour négligence ou fautes graves ou
mauvaise administration; en cas d'arrangement extrajudiciaire, une telle indemnité ne sera accordée que si la Société de
Gestion est informée par son avocat-conseil que l'administrateur, directeur ou fondé de pouvoir en question n'a pas
commis un tel manquement à ses devoirs. Le droit à indemnisation n'exclura pas d'autres droits dans le chef de l'admi-
nistrateur, directeur ou fondé de pouvoir.
Art. 24. Pouvoir de Signature. La Société de Gestion sera engagée par la signature conjointe de deux administrateurs
de la Société de Gestion, ou par la signature conjointe d'un administrateur et d'une personne dûment autorisée, ou par
la signature conjointe des deux personnes auxquelles la gestion des affaires de la Société de Gestion devra être déléguée
en vertu de l'article 17 des présents Statuts, ou de toute autre manière déterminée par une résolution du Conseil
d'Administration.
Chapitre V - Conseil de surveillance
Art. 25. Composition. Les opérations de la Société de Gestion seront soumises au contrôle d'un conseil de surveillance
composé de cinq (5) membres, qui n'auront pas nécessairement la qualité d'actionnaire de la Société de Gestion.
Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés à la majorité simple des voix de l'assemblée générale des
actionnaires, qui fixe également leur rémunération, le cas échéant. La durée du mandat d'un membre du Conseil de
Surveillance ne pourra pas dépasser six (6) ans, et les membres du Conseil de Surveillance resteront en fonction jusqu'à
l'élection de leur successeur. Tout membre du Conseil de Surveillance pourra être révoqué à tout moment ad nutum à
la majorité simple des voix de l'assemblée générale des actionnaires.
Les membres du Conseil de Surveillance sont rééligibles pour des mandats successifs.
En cas de nomination d'une personne morale en qualité de membre du Conseil de Surveillance, ladite personne morale
devra désigner un représentant permanent pour exercer le mandat en son nom et pour son compte de ladite personne
morale. La personne morale ne pourra retirer son représentant que par la nomination concomitante d'un successeur.
Art. 26. Pouvoirs. Le Conseil de Surveillance a les pouvoirs prévus aux articles 60 bis-11 et suivants de la Loi sur les
Sociétés. Le Conseil de Surveillance ne prend pas part activement à la direction de la Société de Gestion, et n'a aucune
compétence à cet égard.
Le Conseil de Surveillance n'a pas le pouvoir d'engager la Société de Gestion envers les tiers. A titre de mesure
d'organisation interne de la Société de Gestion, le consentement du Conseil de Surveillance pourra être requis pour
certaines décisions de Conseil d'Administration telles que stipulées par tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu
à tout moment, et le Conseil de Surveillance pourra être consulté par le directoire avant certaines décisions telles que
stipulées par tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout moment.
Le Conseil d'Administration rendra compte trimestriellement par écrit au Conseil de Surveillance de la situation
actuelle de l'activité de la Société de Gestion et fournira au Conseil de Surveillance les éléments suivants, dans les délais
indiqués ci-après:
1) Dans les trente jours suivant la fin de chaque trimestre civil, le bilan, compte de résultat et annexe;
2) Sans délai, tous renseignements et documents susceptibles d'avoir un impact significatif sur la situation de l'activité
de la Société de Gestion.
Le Conseil de Surveillance a droit à l'information la plus étendue devant lui être fournie par le Conseil d'Administration
et pourra accéder à tout moment aux livres comptables et à tous autres documents de la Société de Gestion, et pourra
effectuer toute inspection qu'il jugera utile à l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre du Conseil de Surveillance ne pourra exercer simultanément les fonctions de membre du Conseil
d'Administration.
25849
L
U X E M B O U R G
Art. 27. Réunions. Le Conseil de Surveillance désignera parmi ses membres un président, et pourra désigner parmi
ses membres un vice-président. Il pourra également désigner un secrétaire, qui n'aura pas nécessairement la qualité de
membre du Conseil de Surveillance, et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de
Surveillance et des assemblées générales d'actionnaires.
Le Conseil de Surveillance se réunira au moins tous les trois (3) mois, et à tout autre moment sur convocation du
président, de deux de ses membres, ou du Conseil d'Administration, au lieu indiqué par l'avis de convocation.
Le président du Conseil de Surveillance présidera toutes les assemblées générales des actionnaires et les réunions du
Conseil de Surveillance; cependant en son absence, les actionnaires ou le Conseil de Surveillance, selon le cas, pourront
désigner un président de séance par un vote à la majorité des présents à ladite assemblée ou réunion.
Toute réunion du Conseil de Surveillance devra être convoquée par notification écrite, par télécopie, courrier élec-
tronique ou tout autre moyen de communication similaire confirmé par écrit, donné aux membres du Conseil de
Surveillance au moins quarante-huit (48) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas
la nature et les motifs de l'urgence devront être mentionnés dans l'avis. Cette notification pourra être omise en cas
d'agrément par chacun des membres du Conseil de Surveillance donné par écrit, par télécopie, courrier électronique ou
tout autre moyen de communication similaire, confirmé par écrit. Aucun avis de convocation particulier ne sera nécessaire
pour une réunion du Conseil de Surveillance devant se tenir au lieu et à la date fixée par une précédente résolution du
Conseil de Surveillance.
Tout membre du Conseil de Surveillance pourra se faire représenter par un autre membre à toute réunion du Conseil
de Surveillance en mandatant ce dernier par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de com-
munication similaire confirmé par écrit, étant précisé qu'un membre du Conseil de Surveillance pourra représenter plus
d'un (1) collègue.
Tout membre du Conseil de Surveillance pourra assister à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence
téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire permettant à tous les participants à la réunion de s'en-
tendre. La participation à une réunion par ces moyens est équivalente à une participation en personne à la réunion.
Art. 28. Vote. Sous réserve des termes et conditions de tout pacte d'actionnaires qui pourrait être conclu à tout
moment, le quorum d'une réunion du Conseil de Surveillance sera de trois (3) membres du Conseil de Surveillance.
Les décisions du Conseil de Surveillance seront adoptées par un vote à la majorité simple des membres du Conseil de
Surveillance présents ou représentés. En cas d'égalité, le président du Conseil de Surveillance aura voix prépondérante.
Une résolution écrite adoptée et signée par tous les membres du Conseil de Surveillance au moyen d'une circulaire
aura les mêmes effets qu'une résolution adoptée en réunion du Conseil de Surveillance. Cette acceptation pourra résulter
d'un document unique ou de documents distincts, et pourra prendre la forme d'une lettre, d'une télécopie ou d'un télex.
Chapitre VI - Révision des Comptes
Art. 29. Réviseur d'Entreprises. Les opérations de la Société de Gestion, comprenant notamment la tenue de sa
comptabilité, les questions fiscales et l'établissement de toutes déclarations d'impôts ou autres déclarations prévues par
la loi luxembourgeoise, seront surveillées par un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréés, justifiant d'une expérience
professionnelle adéquate et qui ne sera/seront par ailleurs pas associé(s) à la Société de Gestion.
L'assemblée générale des actionnaires désignera le(s) réviseur(s) et déterminera leur nombre, leur rémunération et la
durée de leurs fonctions qui ne pourra excéder six années.
Le(s) réviseur(s) en fonction pourra(ont) être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale
des actionnaires.
Chapitre VII - Année Sociale, Distribution des Profits
Art. 30. Année Sociale. L'exercice social commencera le premier (1
er
) janvier et se terminera le trente et un (31)
décembre de chaque année.
Art. 31. Distribution des Profits. Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société de Gestion cinq pour cent (5%)
qui seront affectés à la réserve prévue par la loi. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que et aussi longtemps
que la réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société de Gestion tel qu'il est prévu à l'article Art. 5
des Statuts ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.
L'assemblée générale des actionnaires décidera de l'usage à faire du solde du bénéfice net annuel et décidera de la
répartition des dividendes quand elle le jugera conforme à l'objet et aux buts de la Société de Gestion.
Les dividendes annoncés pourront être payés en toute monnaie choisie par le Conseil d'Administration et pourront
être payés aux temps et lieux choisis par le Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration déterminera souve-
rainement le taux de change applicable à l'échange des dividendes en la monnaie de paiement.
Des acomptes sur dividendes pourront être versés en conformité avec les conditions prévues par la loi.
25850
L
U X E M B O U R G
Chapitre VIII - Dissolution et Liquidation
Art. 32. Dissolution, Liquidation. En cas de dissolution de la Société de Gestion, il sera procédé à la liquidation par les
soins d'un ou plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par
l'assemblée générale des actionnaires effectuant cette dissolution et qui déterminera leurs pouvoirs et leur rémunération.
Chapitre IX - Modification des Statuts
Art. 33. Modification des Statuts. Les présents Statuts pourront être modifiés en temps et lieu qu'il appartiendra par
une assemblée générale des actionnaires soumise aux conditions de quorum et de vote requises par les lois luxembour-
geoises.
Chapitre X - Droit Applicable
Art. 34. Droit Applicable. Toutes les matières non régies par les présents Statuts sont régies conformément à la Loi
sur les Sociétés et la Loi GFIA, ainsi que, le cas échéant, à la Loi OPC.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, sont à la charge de la Société ou seront
mis à sa charge, ont été estimés à environ EUR 3,000,-
Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A la demande des comparants le notaire, qui parle et comprend l'anglais, a établi le présent acte en anglais suivi d'une
version française. Sur demande des comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le
texte anglais fait foi.
Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures, les
membres du bureau ont tous signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: R. GALIOTTO, F. PELE, S. WOLTER et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 29 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63796. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 21 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012792/892.
(150014560) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 1.995.972,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 193.839.
IM JAHRE ZWEITAUSENDVIERZEHN, AM SECHSZEHNTEN DEZEMBER
Vor Uns der unterzeichnenden Notarin Cosita DELVAUX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen:
MaForm Holding AG, eine nach schweizerischem Recht gegründete Gesellschaft mit Sitz in Bellerivestrasse 29, 8008
Zürich eingetragen im Handelsregister von Zürich unter der Nummer CHE-109.290.158 (die "Alleinige Anteilsinhaberin"),
vertreten durch Me Jean-Luc Fisch, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxembourg ermächtigt durch Vollmacht
vom 16 Dezember 2014 die dieser Urkunde beizufügen und mit ihr einzureichen ist,
Als alleinige Anteilsinhaberin der und im Besitz aller fünfundfünfzigtausend (55,000) Anteile in der MaForm Holding
Luxembourg S.a.r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der 1 rue Goethe, L-1637 Luxemburg, ge-
gründet durch Urkunde des unterzeichnenden Notars am 16. Dezember 2014, die noch nicht im Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“).
Die alleinige Anteilsinhaberin erklärte und ersuchte den unterzeichnenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
1. Die alleinige Anteilsinhaberin der Gesellschaft hält das Gesamtkapital der Gesellschaft eingeteilt in fünfundfünfzig-
tausend (55.000) ausgegebenen Anteile der Gesellschaft.
2. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
- Erhöhung des Gesellschaftskapitals vom aktuellen Betrag von fünfundfünfzigtausend Euro (55.000 EUR) auf eine Million
neunhundertfünfundneunzigtausend neunhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 1.995.972) durch die Ausgabe von einer Mil-
25851
L
U X E M B O U R G
lion neunhundertvierzigtausend neunhundertzweiundsiebzig (1.940.972) Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro
(EUR 1) zu einem Ausgabepreis von insgesamt einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro und zweiund-
sechzig Cent (EUR91.001.210,62); Zeichnung der neu auszugebenden Anteil durch die Zeichner und Bezahlung des
Ausgabepreises durch die Einbringung von Aktien der Fabryki Mebli Forte S.A. mit Sitz in ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrow
Mazowiecka eingetragen im Handelsregister von Warschau, 14te Handelsdivision des Nationalen Gerichtsregisters unter
der Nummer 0000021840 wie in der folgenden Tabelle bei ihrem Namen angegeben:
Zeichner
Zahl der
gezeichneten
Anteile durch
den Zeichner
Zahl der
Eingebrachten
Aktien der
Fabryki Mebli
Forte S.A.
MaForm Holding AG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.753.472
7.013.889
Maria Florczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187.500
750.000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.940.972
7.763.889
Feststellung des Berichts von der Geschäftsführung der Gesellschaft über die Bewertung der Sacheinlage; Genehmigung
des Wertes der Sacheinlage und der Ausgabe der Neuen Anteile; Zuteilung des Betrags des Nennwerts aus dem Zeich-
nungsbetrag in das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft und Zuteilung des verbleibenden Betrags in das freie
ausschüttbare Anteilsagio der Gesellschaft; entsprechende Abänderung des Artikels 5 der Gründungssatzung der Ge-
sellschaft wie folgt:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf eine Million neun-
hundertfünfundneunzigtausend neunhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 1.995.972), eingeteilt in eine Million neunhun-
dertfünfundneunzigtausend neunhundertzweiundsiebzig (1.995.972) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je
einem Euro (EUR 1). Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die
Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden.
Verfügbares Anteilsagio kann ausgeschüttet werden.
Im Anschluss wurde der folgende Beschluss gefasst:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Es wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital vom aktuellen Betrag von fünfundfünfzigtausend Euro (55.000 EUR) auf
eine Million neunhundertfünfundneunzigtausend neunhundertzweiundsiebzig Euro (EUR 1.995.972) zu erhöhen durch die
Ausgabe von einer Million neunhundertvierzigtausend neunhundertzweiundsiebzig (1.940.972) neuen Anteilen mit einem
Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Ausgabepreis von insgesamt einundneunzig Millionen ein tausend zwei-
hundertzehn Euro und zweiundsechzig Cent (EUR91.001.210,62).
Die neuen Anteile wurden von den Zeichnern,, gezeichnet wie folgt:
1. MaForm Holding AG, obengenannt, vertreten wie anfangs erwähnt, welche hiermit erklärt eine Million siebenhun-
dertdreiundfünfzigtausend vierhundertzweiundsiebzig (1,753,472) neue Anteile zu zeichnen mit einem Nennwert von je
einem Euro (EUR1,-) und diese Aktien vollständig einzuzahlen zu einem totalen Ausgabepreis von zweiundachtzig Millionen
zweihundertzehntausend dreihundertsechsundneunzig Euros zwölf Cents (EUR 82.210.396,12) durch die Einbringung von
sieben Millionen dreizehntausend achthundertneunundachtzig (7.013.889) Aktien der Fabryki Mebli Forte S.A. mit Sitz in
ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrów Mazowiecka eingetragen im Handelsregister von Warschau, 14te Handelsdivision des
Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000021840, welche zugeteilt werden dem Stammkapital der Gesell-
schaft für den Betrag von einhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert Euro (EUR 187.500,-), sowie dem frei aus-
schüttbaren Anteilsagio der Gesellschaft für den Betrag von achtzig Millionen vierhundertsechsundfünfzigtausend
neunhundertvierundzwanzig Euros zwölf Cents (EUR 80.456.924,12)
2. Maria Florczuk, geboren am 17. Oktober 1981 in Wolomin (Polen), wohnhaft in Florianska 6/17 03-707 Warschau,
Polen, vertreten durch Me Jean-Luc Fisch, vorgenannt, ermächtigt durch Vollmacht vom 16 Dezember 2014 die dieser
Urkunde beizufügen und mit ihr einzureichen ist, welche hiermit erklärt einhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert
(187.500) neue Anteile zu zeichnen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR1,-) und diese Aktien vollständig ein-
zuzahlen zu einem totalen Ausgabepreis von acht Millionen siebenhundertneunzigtausend achthundertvierzehn Euros
fünfzig Cents (EUR 8.790.814,50) durch die Einbringung von siebenhundertfünfzigtausend (750.000) Aktien der Fabryki
Mebli Forte S.A. mit Sitz in ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrów Mazowiecka eingetragen im Handelsregister von Warschau,
14te Handelsdivision des Nationalen Gerichtsregisters unter der Nummer 0000021840, welche zugeteilt werden dem
Stammkapital der Gesellschaft für den Betrag von einhundertsiebenundachtzigtausend fünfhundert Euro (EUR 187.500,-),
sowie dem frei ausschüttbaren Anteilsagio der Gesellschaft für den Betrag von acht Millionen sechshundertdreitausend
dreihundertvierzehn Euros fünfzig Cents (EUR 8.603.314,50)
Es wurde beschlossen, den Wert der Sacheinlage von einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro und
zweiundsechzig Cent (EUR91.001.210,62) zu genehmigen und den Bericht der Geschäftsführung der Gesellschaft über
die Bewertung der Sacheinlage vom 16 Dezember 2014 (welche in Kopie der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage
beiliegen wird, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden registriert zu werden) festzustellen, dessen Schlussfolge-
rung wie folgt lautet:
25852
L
U X E M B O U R G
“The Board of Managers values the Contribution in Kind consisting of 7,763,889 fully paid shares of Fabryki Mebli Forte
S.A., to be at least equal to the subscription price of the 1,940,972 Shares to be issued by the Company being
EUR191.001.210,62.”
Ein Nachweis der Einbringung der Kapitaleinlage wurde dem unterzeichnenden Notar gezeigt.
Es wurde beschlossen, den Betrag des Nennwerts aus dem Zeichnungsbetrag in Höhe von einer Million neunhun-
dertvierzigtausend neunhundertzweiundsiebzig Euros (EUR 1.940.972) in das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft
zuzuteilen und den verbleibenden Betrag von neunundachtzig Millionen sechzigtausend zweihundertachtunddreissig Euros
zweiundsechzig Cents (EUR 89.060.238,62) in das freie ausschüttbare Anteilsagio der Gesellschaft.
Es wurde beschlossen, Artikel 5 der Gründungssatzung der Gesellschaft wie in der Tagesordnung dargestellt entspre-
chend abzuändern.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen, wurde der außergewöhnliche Beschluss des Alleinigen Anteilsin-
habers geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten in jedweder Form welche von der Gesellschaft aufgrund ihrer Erhö-
hung des Stammkapitals zu tragen sind, werden auf EUR 7.000,- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, bezeugt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei die vorliegende Urkunde auf Deutsch angefertigt wurde, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf
Ersuchen derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen
Fassung, geht die deutsche Fassung vor.
Verfasst in Luxemburg, an dem Tag, der am Anfang der Urkunde genannt ist.
Nach Verlesung der Urkunde hat die erschienene Partei vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Folgt die Englische Übersetzung des Vorherstehenden Textes:
In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of the month of December.
Before Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
MaForm Holding AG, a company incorporated under the laws of Switzerland, having its registered office in Belleri-
vestrasse 29, 8008 Zürich and registered with the Handelsregister des Kantons Zürich under number CHE-109.290.158
(the "Sole Shareholder"), represented by Me Jean-Luc Fisch, attorney, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated
16 December 2014 which shall be registered together with the present deed,
being the sole shareholder and holding all the fifty-five thousand (55,000) shares in issue in MaForm Holding Luxem-
bourg S.à.r.l., a societe a responsabilite limitee having its registered office at rue Goethe, L-1637 Luxembourg, incorpo-
rated on 16 December 2014 by deed of the undersigned notary, not yet published in the Memorial C, Recueil des Societes
et Associations (the “Company”).
The sole shareholder declared and requested the notary to record as follows:
1. The sole shareholder is the sole holder of all of the shares in issue in the Company and the entire issued share
capital, represented by fifty-five thousand (55,000) ordinary shares.
2. The item on which resolutions are to be passed on is the following:
- Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of fifty-five thousand euro (EUR55,000)
to one million nine hundred ninety-five thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR1,995,972) by the issue of one
million nine hundred forty thousand nine hundred seventy-two (1,940,972) new shares each with a nominal value of one
Euro (EUR1) and a total issue price of ninety-one million one thousand two hundred and ten Euro and sixty-two cents
(EUR91,001,210.62); subscription to such new shares by the subscribers and payment of the total issue price by the
contribution in kind of shares issued by Fabryki Mebli Forte S.A. with registered office at ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrow
Mazowiecka registered at the District Court of the Capital City of Warsaw, 14
th
Commercial Division of the National
Court Register under KRS number 0000021840 as set forth against their respective name in the table below:
Subscribers
Number of
shares
subscribed
by the
Subscriber
Number of
contributed
shares of
Fabryki
Mebli
Forte S.A.
MaForm Holding AG, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,753,472
7,013,889
Maria Florczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187,500
750,000
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,940,972
7,763,889
Acknowledgement of the report of the board of managers of the Company on the valuation of such contribution in
kind; approval of the valuation of the contribution in kind; allocation of an amount equal to the nominal value of the new
25853
L
U X E M B O U R G
shares so issued to the share capital and the balance to the freely distributable share premium of the Company; conse-
quential amendment of article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
„ Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at one million nine hundred ninety-five thousand
nine hundred seventy-two Euro (EUR1,995,972) represented by one million nine hundred ninety-five thousand nine
hundred seventy-two (1,995,972) shares with a nominal value of one Euro (EUR1) each. The share capital of the Company
may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of
these articles of association.
Any available share premium shall be distributable."
The following resolution was adopted:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of fifty-five thousand Euro
(EUR 55,000) to one million nine hundred ninety-five thousand nine hundred seventy-two Euro (EUR1,995,972) by the
issue of one million nine hundred forty thousand nine hundred seventy-two (1,940,972) new ordinary shares of the
Company with a nominal value of one euro (EUR1) each for a total aggregate subscription price of ninety-one million one
thousand two hundred and ten Euro and sixty-two cents (EUR91,001,210.62).
The new shares so issued have been subscribed by the subscribers, as follows:
1. MaForm Holding AG, prenamed, represented as stated above, who hereby declares to subscribe to one Million
seven hundred fifty-three thousand four hundred seventy-two (1,753,472) new shares having a nominal value of one Euro
(EUR1,-) each and to fully pay up such new shares at a total subscription price of eight Millions seven hundred ninety
thousand eight hundred fourteen Euros fifty Cents (EUR 8,790,814.50), by way of contribution in kind of seven Million
thirteen thousand eight hundred eighty-nine(7,013,889) shares issued by Fabryki Mebli Forte S.A. with registered office
at ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrów Mazowiecka registered at the District Court of the Capital City of Warsaw, 14
th
Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000021840, which is allocated to the share
capital of the Company for an amount of one Million seven hundred fifty-three thousand four hundred seventy-two Euros
(EUR1,753,472) and to the share premium account for an amount of eighty Millions four hundred fifty-six thousand nine
hundred twenty-four Euros twelve Cents (EUR 80,456,924.12)
2. Maria Florczuk, born on 17 October 1981 in Wolomin (Poland) residing at Florianska 6/17 03-707 Warsaw, Poland,
duly represented by Me Jean-Luc Fisch, prenamed, pursuant to a proxy dated 16 December 2014 which shall be registered
together with the present deed,, who hereby declares to subscribe to one hundred eighty-seven thousand five hundred
(187,500) new shares having a nominal value of one Euro (EUR1,-) each and to fully pay up such new shares by way of
contribution in kind of seven hundred fifty thousand (750,000) shares issued by Fabryki Mebli Forte S.A. with registered
office at ul. Biała 1, PL 07-300 Ostrów Mazowiecka registered at the District Court of the Capital City of Warsaw, 14
th
Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000021840, which is allocated to the share
capital of the Company for an amount of one hundred eighty-seven thousand five hundred Euros (EUR 187,500) and to
the share premium account for an amount of eight Million six hundred and three thousand three hundred fourteen Euros
fifty cents (EUR 8,603,314.50) It is resolved to approve the valuation of the contribution in kind at ninety-one million one
thousand two hundred and ten Euro and sixty-two cents (EUR91,001,210.62) and to acknowledge the report on such
contribution in kind from the board of managers of the Company dated 16 December 2014, which shall remain annexed
to this deed to be submitted with it to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:
“The Board of Managers values the Contribution in Kind consisting of 7,763,889 fully paid shares of Fabryki Mebli Forte
S.A., to be at least equal to the global subscription price of the 1,940,972 Shares to be issued by the Company being
EUR91,001,210.62,.”
Evidence of the payment to the Company of the subscription price has been shown to the undersigned notary.
It was then resolved to allocate an amount equal to the nominal value of the shares so issued amounting to one million
nine hundred forty thousand nine hundred seventy-two Euros (EUR 1,940,972) to the issued share capital account and
the balance of eighty-nine Millions sixty thousand two hundred thirty-eight Euros and sixty-two cents (EUR 89,060,238.62)
to the freely distributable share premium account. It was resolved to amend article 5 of the articles of association of the
Company so as to reflect the above resolution as set forth in the agenda.
There being no further business on the agenda the decision of the sole shareholder was closed.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR 7,000.-.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,
this deed is drafted in German, followed by an English translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the German and the English version, the German version shall prevail.
Done in Luxembourg on the day beforementionned.
25854
L
U X E M B O U R G
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Gezeichnet: J.-L. FISCH, C. DELVAUX.
Enregistré a Luxembourg Actes Civils, le 18 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61055. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 22. Januar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015012851/206.
(150015071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
MaForm S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 91.031.210,00.
Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.
R.C.S. Luxembourg B 193.855.
IM JAHRE ZWEITAUSENDVIERZEHN, AM ZWEUINDZWANZIGSTEN DEZEMBER
Vor Uns der unterzeichnenden Notarin Cosita DELVAUX, mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Lu-
xemburg,
ist erschienen:
MaForm Holding Luxembourg S.à.r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der 1, rue Goethe, L-1637
Luxemburg, gegründet durch Urkunde des unterzeichnenden Notars am 16. Dezember 2014, die noch nicht im Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde (die "Alleinige Anteilshaberin"), vertreten durch Me Namik
Ramic, Rechtsanwalt, mit beruflicher Adresse in Luxemburg ermächtigt durch Vollmacht vom 16 Dezember 2014 die
dieser Urkunde beizufügen und mit ihr einzureichen ist,
Als alleinige Anteilshaberin der und im Besitz aller dreißigtausend (30.000) Anteile in der MaForm S.à.r.l., einer Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in der 1, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, gegründet durch Urkunde des
unterzeichnenden Notars am 16. Dezember 2014, die noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
veröffentlicht wurde (die „Gesellschaft“).
Die alleinige Anteilshaberin erklärte und ersuchte den unterzeichnenden Notar, Folgendes zu beurkunden:
1. Die alleinige Anteilshaberin der Gesellschaft hält das Gesamtkapital der Gesellschaft eingeteilt in dreißigtausend
(30.000) ausgegebenen Anteile der Gesellschaft.
2. Die Tagesordnung lautet wie folgt:
- Erhöhung des Gesellschaftskapitals vom aktuellen Betrag von dreißigtausend Euro (30.000 EUR) auf einundneunzig
Millionen einunddreißig tausend zweihundertzehn Euro (EUR 91.031.210) durch die Ausgabe von einundneunzig Millionen
ein tausend zweihundertzehn (91.001.210) Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR 1) zu einem Ausga-
bepreis von insgesamt einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro und zweiundsechzig Cent
(EUR91.001.210,62); Zeichnung der neu auszugebenden Anteile durch die Alleinige Anteilshaberin und Bezahlung des
Ausgabepreises durch die Einbringung von 7.763.889 Aktien der Fabryki Mebli Forte S.A. mit Sitz in ul. Biala 1, PL 07-300
Ostrów Mazowiecka eingetragen im Handelsregister von Warschau, 14te Handelsdivision des Nationalen Gerichtsregis-
ters unter der Nummer 0000021840; Feststellung des Berichts von der Geschäftsführung der Gesellschaft über die
Bewertung der Sacheinlage; Genehmigung des Wertes der Sacheinlage und der Ausgabe der Neuen Anteile; Zuteilung
des Betrags des Nennwerts aus dem Zeichnungsbetrag in das ausgegebene Stammkapital der Gesellschaft und Zuteilung
des verbleibenden Betrags in das freie ausschüttbare Anteilsagio der Gesellschaft; entsprechende Abänderung des Artikels
5 der Gründungssatzung der Gesellschaft wie folgt:
„ Art. 5. Gesellschaftskapital. Das ausgegebene Gesellschaftskapital der Gesellschaft beläuft sich auf einundneunzig
Millionen einunddreißig tausend zweihundertzehn Euro (EUR 91.031.210), eingeteilt in einundneunzig Millionen
einunddreißig tausend zweihundertzehn (91.031.210) Gesellschaftsanteile mit einem Nennwert von je einem Euro (EUR
1). Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Gesellschafter in der für die Abänderung der
Satzung vorgesehenen Art und Weise erhöht oder verringert werden.
Verfügbares Anteilsagio kann ausgeschüttet werden.“
Im Anschluss wurde der folgende Beschluss gefasst:
<i>Alleiniger Beschlussi>
Es wurde beschlossen, das Gesellschaftskapital vom aktuellen Betrag von dreißigtausend Euro (30.000 EUR) auf ei-
nundneunzig Millionen einunddreißig tausend zweihundertzehn Euro (EUR 91.031.210) zu erhöhen durch die Ausgabe
von einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn (91.001.210) Anteilen mit einem Nennwert von je einem Euro
25855
L
U X E M B O U R G
(EUR 1) zu einem Ausgabepreis von insgesamt einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro und zweiund-
sechzig Cent (EUR91.001.210,62).
Die neuen Anteile wurden von der Alleinige Anteilshaberin vertreten durch Me Namik Ramic, vorgenannt, gezeichnet
und vollständig eingezahlt zu einem totalen Ausgabepreis von einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro
und zweiundsechzig Cent (EUR91.001.210,62) durch die Einbringung von sieben Millionen siebenhundertdreiundsechzig-
tausend achthundertneunundachtzig (7.763.889) Aktien der Fabryki Mebli Forte S.A. mit Sitz in ul. Biala 1, PL 07-300
Ostrów Mazowiecka eingetragen im Handelsregister von Warschau, 14te Handelsdivision des Nationalen Gerichtsregis-
ters unter der Nummer 0000021840, welche dem Stammkapital der Gesellschaft zugeteilt werden für den Betrag von
einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro (EUR91.001.210), sowie dem frei ausschüttbaren Anteilsagio
der Gesellschaft für den Betrag von zweiundsechzig Cents (EUR 0,62).
Es wurde beschlossen, den Wert der Sacheinlage von einundneunzig Millionen ein tausend zweihundertzehn Euro und
zweiundsechzig Cent (EUR91.001.210,62) zu genehmigen und den Bericht der Geschäftsführung der Gesellschaft über
die Bewertung der Sacheinlage vom 16 Dezember 2014 (welche in Kopie der vorliegenden notariellen Urkunde als Anlage
beiliegen wird, um gleichzeitig bei den Registrierungsbehörden registriert zu werden) festzustellen, dessen Schlussfolge-
rung wie folgt lautet:
“The Board of Managers values the Contribution in Kind consisting of 7,763,889 fully paid shares of Fabryki Mebli Forte
S.A., to be at least equal to the subscription price of the 91,001,210 Shares to be issued by the Company being
EUR91.001.210,62.”
Ein Nachweis der Einbringung der Kapitaleinlage wurde dem unterzeichnenden Notar gezeigt.
Es wurde beschlossen, Artikel 5 der Gründungssatzung der Gesellschaft wie in der Tagesordnung dargestellt entspre-
chend abzuändern.
Da keine weiteren Tagesordnungspunkte anstehen, wurde der außergewöhnliche Beschluss des Alleinigen Anteilsha-
bers geschlossen.
<i>Kosteni>
Die Kosten, Ausgaben, Vergütungen oder Lasten in jedweder Form welche von der Gesellschaft aufgrund ihrer Erhö-
hung des Stammkapitals zu tragen sind, werden auf EUR 7.000,- geschätzt.
Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, bezeugt hiermit, dass auf Ersuchen der oben erschie-
nenen Partei die vorliegende Urkunde auf Deutsch angefertigt wurde, gefolgt von einer englischen Übersetzung; auf
Ersuchen derselben erschienenen Personen und im Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen
Fassung, geht die deutsche Fassung vor.
Verfasst in Luxemburg, an dem Tag, der am Anfang der Urkunde genannt ist.
Nach Verlesung der Urkunde hat die erschienene Partei vorliegende Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.
Folgt die Englische Übersetzung des Vorherstehenden textes:
IN THE YEAR TWO THOUSAND FOURTEEN, ON THE TWENTY SECOND DAY OF THE MONTH OF DE-
CEMBER.
Before Maître Cosita DELVAUX, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
MaForm Holding Luxembourg S.à.r.l. (the "Sole Shareholder"), a société a responsabilité limitée having its registered
office at 1, rue Goethe, L-1637 Luxemburg, incorporated on 16 December 2014 by deed of the undersigned notary, not
yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (“Mémorial”), represented by Me Namik Ramic,
attorney, residing in Luxembourg pursuant to a proxy dated 16 December 2014 which shall be registered together with
the present deed,
being the sole shareholder and holding all the thirty thousands (30,000) shares in issue in MaForm S.a.r.l., a société a
responsabilité limitée having its registered office at rue Goethe, L-1637 Luxemburg, incorporated on 16 December 2014
by deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial (the “Company”).
The sole shareholder declared and requested the notary to record as follows:
1. The sole shareholder is the sole holder of all of the shares in issue in the Company and the entire issued share
capital, represented by thirty thousand (30,000) ordinary shares.
2. The item on which resolutions are to be passed on is the following:
- Increase of the issued share capital of the Company from its current amount of thirty thousand euro (EUR 30,000)
to ninety-one million thirty-one thousand two hundred and ten Euro (EUR91,031,210) by the issue of ninety-one million
one thousand two hundred and ten (91,001,210) new shares each with a nominal value of one Euro (EUR1) and a total
issue price of ninety-one million one thousand two hundred and ten Euro and sixty-two cents (EUR 91,001,210.62);
subscription to such new shares by the sole shareholder of the Company and payment of the total issue price by the
contribution in kind of 7,763,889 shares issued by Fabryki Mebli Forte S.A. with registered office at ul. Biala 1, PL 07-300
Ostrów Mazowiecka registered at the District Court of the Capital City of Warsaw, 14
th
Commercial Division of the
25856
L
U X E M B O U R G
National Court Register under KRS number 0000021840; acknowledgement of the report of the board of managers of
the Company on the valuation of such contribution in kind; approval of the valuation of the contribution in kind; allocation
of an amount equal to the nominal value of the new shares so issued to the share capital; consequential amendment of
the article 5 of the articles of incorporation of the Company to read as follows:
Art. 5. Share capital. The issued share capital of the Company is set at ninety-one million thirty-one thousand two
hundred and ten Euro (EUR91,031,210) represented by to ninety-one million thirty-one thousand two hundred and ten
(91,031,210) shares with a nominal value of one Euro (EUR1) each. The share capital of the Company may be increased
or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of
association.
Any available share premium shall be distributable.”
Thereafter the following resolution was passed:
<i>Sole resolutioni>
It is resolved to increase the issued share capital of the Company from its current amount of thirty thousand euro
(EUR 30,000) to ninety-one million thirty-one thousand two hundred and ten Euro (EUR91,031,210) by the issue of
ninety-one million one thousand two hundred and ten (91,001,210) new ordinary shares of the Company with a nominal
value of one euro (EUR1) each for a total aggregate subscription price of ninety-one million one thousand two hundred
and ten Euro and sixty-two cents (EUR 91,001,210.62).
The new shares so issued have been subscribed by the sole shareholder, represented by Me Namik Ramic, prenamed,
and the subscription price was entirely paid by the sole shareholder through the contribution in kind to the Company of
7,763,889 shares issued by Fabryki Mebli Forte S.A. with registered office at ul. Biala 1, PL 07-300 Ostrów Mazowiecka
registered at the District Court of the Capital City of Warsaw, 14
th
Commercial Division of the National Court Register
under KRS number 0000021840 of which an amount of ninety-one million one thousand two hundred and ten Euro (EUR
91,001,210) is allocated to the share capital account of the Company and an amount of sixty-two cents (EUR0.62) is
allocated to the share premium of the Company.
It is resolved to approve the valuation of the contribution in kind at ninety-one million one thousand two hundred and
ten Euro and sixty-two cents (EUR 91,001,210.62) and to acknowledge the report on such contribution in kind from the
board of managers of the Company dated 16 December 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted
with it to the formality of registration, the conclusion of which reads as follows:
“The Board of Managers values the Contribution in Kind consisting of 7,763,889 fully paid shares of Fabryki Mebli Forte
S.A., to be at least equal to the subscription price of the 91,001,210 Shares to be issued by the Company being euro
91,001,210.62.”
Evidence of the transfer of the contribution in kind was shown to the undersigned notary.
In consequence of the issue of shares, the sole shareholder resolved to amend article 5 of the articles of association
of the Company so as to reflect the above resolution as set forth in the agenda.
All items on the agenda have thus been resolved on.
<i>Expensesi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be
charged to it in connection with its capital increase at the fixed rate registration tax perception, have been estimated at
about EUR 7,000.-.
There being no further business on the agenda the decision of the sole shareholder was closed.
The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the party hereto,
this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same party, in case of divergences
between the English and the French version, the English version shall prevail.
Done in Luxembourg, on the day beforementionned.
After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.
Gezeichnet: N. RAMIC, C. DELVAUX.
Enregistré a Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63298. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum
Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxemburg, den 23. Januar 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015012852/156.
(150014914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25857
L
U X E M B O U R G
Lsref3 Tiger Investements S.à .r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.900,00.
Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.
R.C.S. Luxembourg B 192.147.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December,
Before Us Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
THERE APPEARED:
LSREF3 Tiger Holdings S.à r.l, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and
existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum,
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of GBP 10,900.- (ten
thousand nine hundred pound sterling) and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies
(Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the RCS) under number B 192116 (the Sole Shareholder),
hereby represented by Me Delphine GOMES, with professional address in Luxembourg,
by virtue of a power of attorney, given in Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg on 16 December 2014,
which proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the
undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
The Sole Shareholder, represented as stated above, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned
notary to act that it represents the entire share capital of LSREF3 Tiger Investments S.à r.l., a Luxembourg private limited
liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du
Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 12,500.- (twelve thousand five
hundred euro), registered with the RCS under number B 192147 and incorporated pursuant to a deed of Maître Martine
Schaeffer dated 13 November 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number
3874 on 15 December 2014 (the Company). The article of association of the Company have been amended for the last
time by a deed of Maître Martine Schaeffer dated 9 December 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations.
The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
A. The entire issued share capital represented by 100 (one hundred) shares is held by the Sole Shareholder.
B. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this
extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.
C. The agenda of the meeting is as follows:
(1) Amendment of the corporate object of the Company and consequential amendment of article 2 of the Articles so
as to read as follows:
“ Art. 2. Object. The Company may carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the creation, acqui-
sition, holding and/or disposal, in any form and by any means, of participations, rights and interests in, and obligations of,
any form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, and the administration, management, control and/or
development of those participations, rights, interests and obligations.
The Company may, by any means whatsoever, use its funds to establish, manage, develop and/or dispose of all of its
assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and/or dispose of any kinds of property, tangible
and intangible, movable and immovable, to participate in the creation, acquisition, development and/or control of any
form of Luxembourg and foreign companies and enterprises, to acquire by any means, establish, own, manage, develop
and/or dispose of any portfolio of securities and intellectual property rights of whatever origin and to realise them by
way of sale, transfer, assignment, exchange or otherwise.
The Company may borrow in any form and proceed by private placement to the issue of bonds, notes and debentures
or any kind of debt or equity securities.
The Company may lend funds including without limitation resulting from any borrowings of the Company or from the
issue of any equity or debt securities of any kind, to its subsidiaries, affiliated companies or any other company or entity
as it deems fit.
The Company may give guarantees and/or grant security in favour of third parties to secure its obligations and/or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies and any other company, pledge, transfer, encumber or otherwise create
security over some or all of its assets and grant loans, advances and/or assistance, in any form whatsoever, to its subsi-
diaries, affiliated companies and third parties.
The Company may take any measure and carry out any operation, including but not limited to commercial, industrial,
financial, personal and real estate operations, which are directly or indirectly connected with, or may favour the deve-
lopment of, its corporate purpose.”;
25858
L
U X E M B O U R G
(2) Conversion of the Company's share capital from EUR (euro) to GBP (pound sterling) in order to be converted
from an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to GBP 9,906.25 (nine thousand nine hundred six
pound sterling twenty-five pence) by applying the EUR/GPB exchange rate prevailing on the website of the European
Central Bank at a rate of EUR 1.- (one euro) amounting to GBP 0,7925 (zero pound sterling and seven thousand nine
hundred twenty-five pence), reflecting the applicable exchange rate as at 12 December 2014; consequential reclassification
of the existing 100 (one hundred) shares of a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, into
990,625 (nine hundred ninety thousand six hundred twenty-five) shares of a nominal value of GBP 0.01 (one penny) each;
(3) Increase of the share capital of the Company by an amount of GBP 993.75 (nine hundred ninety-three pound sterling
seventy-five pence) in order to bring the share capital of the Company from its converted amount of GBP 9,906.25 (nine
thousand nine hundred six pound sterling twenty-five pence) to an amount of GBP 10,900.- (ten thousand nine hundred
pound sterling) by way of the issuance of 99,375 (ninety-nine thousand three hundred seventy-five) new ordinary shares,
having a nominal value of GBP 0.01 (one penny) each (collectively, the New Shares);
(4) Subscription to and payment in cash of the New Shares by the Sole Shareholder by way of an aggregate contribution
in cash of GBP 565,942.81 (five hundred sixty-five thousand nine hundred forty-two pound sterling eighty-one pence) to
be allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of GBP 993.75 (nine hundred ninety-three pound
sterling seventy-five pence), and (b) to the share premium account for an amount of GBP 564,949.06 (five hundred sixty-
four thousand nine hundred forty-nine pound sterling six pence);
(5) Subsequent amendment of the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect the changes proposed
above; and
(6) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and
authority to any manager of the Company and/or any employee of Lone Star Capital Investments S.à r.l. (LSCI), to proceed,
under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the name change of the Company, (ii) to the registration of
the New Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (iii) to the performance of any
formalities in connection therewith.
The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as
follows
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the corporate object of the Company and consequently to amend article 2
of the Articles as set forth in the agenda.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to convert the Company's share capital from EUR (euro) to GBP (pound sterling) in
order to convert it from an amount of EUR 12,500.- (twelve thousand five hundred euro) to GBP 9,906.25 (nine thousand
nine hundred six pound sterling twenty-five pence) by applying the EUR/GPB exchange rate prevailing on the website of
the European Central Bank at a rate of EUR 1.- (one euro) amounting to GBP 0,7925 (zero pound sterling and seven
thousand nine hundred twenty-five pence), reflecting the applicable exchange rate as at 12 December 2014 and reclassify
the existing 100 (one hundred) shares of a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, into 990,625
(nine hundred ninety thousand six hundred twenty-five) shares of a nominal value of GBP 0.01 (one penny) each.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of GBP 993.75.- (nine
hundred ninety-three pound sterling seventy-five pence) in order to bring the share capital of the Company from its
converted amount of GBP 9,906.25 (nine thousand nine hundred six pound sterling twenty-five pence) to an amount of
GBP 10,900.- (ten thousand nine hundred pound sterling) by way of the issuance of 99,375 (ninety-nine thousand three
hundred seventy-five) New Shares in consideration of a contribution in cash by the Sole Shareholder of an aggregate
amount of GBP 565,942.81 (five hundred sixty-five thousand nine hundred forty-two pound sterling eighty-one pence)
allocated as explain here after.
<i>Fourth resolutioni>
The Sole Shareholder, duly represented as stated above, hereby accepts the subscription of the New Shares and their
full payment as follows:
<i>Subscription - Paymenti>
The Sole Shareholder, represented as stated above, hereby declares to (i) subscribe to 99,375 (ninety-nine thousand
three hundred seventy-five) New Shares, having a nominal value of GBP 0.01 (one penny) and (ii) fully pay up such New
Shares by way of a contribution in cash of GBP 565,942.81 (five hundred sixty-five thousand nine hundred forty-two
pound sterling eighty-one pence), which is allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of GBP 993.75.-
(nine hundred ninety-three pound sterling seventy-five pence), and (b) to the share premium account for an amount of
GBP 564,949.06 (five hundred sixty-four thousand nine hundred forty-nine pound sterling six pence).
25859
L
U X E M B O U R G
All the New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the Sole Shareholder so that the
aggregate subscription amount of GBP 565,942.81 (five hundred sixty-five thousand nine hundred forty-two pound sterling
eighty-one pence) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary who expressly
bears witness to it.
<i>Fifth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to subsequently amend the first paragraph of article 6 of the Articles in order to reflect
the above resolutions, so that it reads henceforth as follows in its English version:
" Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 10,900.- (ten thousand nine hundred
pound sterling), represented by 1,090,000 (one million ninety thousand) ordinary shares having a nominal value of GBP
0.01 (one penny) each."
<i>Sixth resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and
hereby empowers and authorizes any manager of the Company and/or any employee of LSCI, to proceed, under his/her
sole signature, on behalf of the Company (i) to the name change of the Company, (ii) to the registration of the New
Shares issued by the Company and subscribed by the Sole Shareholder and (iii) to the performance of any formalities in
connection therewith.
<i>Estimate of costsi>
The amount of expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the
Company as a result of the present deed is estimated to be approximately EUR 1,800.-.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of
the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the proxy-
holder of the appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will
be prevailing.
Whereof, the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties which is known by the undersigned notary
by his surname, name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the
notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre,
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg.
A COMPARU:
LSREF3 Tiger Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à
l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital
social de GBP 10.900,- (dis mille neuf cent livres sterling) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés,
Luxembourg (le RCS) sous le numéro B 192116 (l'Associé Unique),
ici représentée par Maître Delphine GOMES, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg,
en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,
restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de LSREF3 Tiger Investments
S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-
Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, ayant un capital social de EUR 12.500,-
(douze mille cinq cents euros) et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 192147 et constituée suivant un acte de
Maître Martine Schaeffer en date du 13 novembre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
numéro 3874 le 15 décembre 2014 (la Société). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant
un acte de Maître Martine Schaeffer en date du 9 décembre 2014, pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations.
La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
A. La totalité du capital social, représentée par 100 (cent) parts sociales, est détenu par l'Associé Unique.
B. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la
Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être vala-
blement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.
C. L'ordre du jour est le suivant:
25860
L
U X E M B O U R G
(1) Modification de l'objet social de la Société et modification en conséquence de l'article 2 des Statuts de sorte qu'il
ait la teneur suivante:
« Art. 2. Objet. La Société pourra accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la
constitution, l'acquisition, la détention et/ou la cession, sous quelque forme que ce soit et selon tous les moyens, de
participations, droits et intérêts et obligations, dans toute société et entreprise luxembourgeoise et étrangère, ainsi que
l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations, droits, intérêts et obligations.
La Société peut utiliser ses fonds par tous les moyens pour constituer, administrer, développer et vendre ses porte-
feuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, pour acquérir, investir dans et/ou vendre toute sorte de
propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, pour participer à la création, l'acquisition, le déve-
loppement et/ou le contrôle de toute forme de sociétés ou entreprises luxembourgeoises ou étrangères, pour acquérir
par tout moyen, établir, détenir, gérer, développer et/ou vendre tout portefeuille de valeurs mobilières et de brevets de
n'importe quelle origine, et pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder par voie de placement privé à l'émission
d'obligations, de titres obligataires et de certificats de créance ou de titres de créance ou de participation de quelque
nature que ce soit.
La Société peut prêter des fonds, y compris et ce, sans limitation, ceux résultant d'emprunts de la Société ou de
l'émission de tout titre de participation ou de créance de quelque nature que ce soit, à ses filiales, sociétés affiliées ou
toute autre société ou entité qu'elle juge appropriée.
La Société peut également consentir des garanties et/ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses
obligations et/ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou de toute autre société, nantir, céder, grever de charges
ou créer des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs et accorder des prêts, avances et/ou assistance, sous
n'importe quelle forme, à ses filiales, sociétés affiliées et tierces parties.
La Société peut prendre toutes mesures et accomplir toutes opérations, incluant mais n'étant pas limité à des opéra-
tions commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à
son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.»;
(2) Conversion du capital social de la Société d'EUR (euros) en GBP (livres sterling) afin d'être converti d'un montant
de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) en GBP 9.906,25 (neuf mille neuf cent six livres sterling vingt-cinq pennies)
par l'application du taux de change EUR/GBP prévalant sur le site internet de la Banque Centrale Européenne à un taux
de EUR 1,- (un euro) correspondant à GBP 0,7925 (zéro livre sterling et sept mille neuf cent vindt-cinq pennies), refletant
le taux de change applicable au 12 décembre 2014; reclassement en conséquence des 100 (cent) parts sociales existantes
d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euro) chacune, en 990.625 (neuf cent quatre-vingt dix mille six cent
vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 0,01 (un penny) chacune;
(3) Augmentation du capital social de la Société par un montant de GBP 993,75 (neuf cent quatre-vingt-treize livres
sterling soixante-quinze pennies) afin d'augmenter le capital social de son montant converti de GBP 9.906,25 (neuf mille
neuf cent six livres sterling vingt-cinq pennies) à un montant de GBP 10.900,- (dix mille neuf cent livres sterling) par voie
de création et d'émission de 99.375 (quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-quinze) nouvelles parts sociales or-
dinaires, ayant une valeur nominale de GBP 0,01 (un penny) chacune (collectivement, les Nouvelles Parts Sociales);
(4) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé Unique par un apport en numéraire pour un
montant total de souscription de GBP 565.942,81 (cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quarante-deux livres sterling
quatre-vingt-un pennies) à être alloué (a) au capital social de la Société pour un montant de GBP 993,75 (neuf cent quatre-
vingt-treize livres sterling soixante-quinze pennies), et (b) au compte de prime d'émission pour un montant de GBP
564.949,06 (cinq cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-neuf livres sterling six pennies);
(5) Par conséquent, modification du premier paragraphe de l'article 6 des Statuts comme suit afin de refléter l'aug-
mentation de capital proposée ci-dessus; et
(6) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec
pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de Lone Star Capital Investments S.à r.l.
(LSCI), afin d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du changement de dénomi-
nation de la Société, (ii) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales et (iii) la réalisation de toute formalité en relation avec
ce point.
Ceci ayant été déclaré, l'Associé Unique représenté comme indiqué ci avant, a requis le notaire soussigné de prendre
acte des résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier l'objet social de la Société et de modifier en conséquence de l'article 2 des Statuts
tel que défini dans l'ordre du jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Associé Unqiue décide de convertir le capital social de la Société d'EUR (euros) en GBP (livres sterling) afin de le
convertir d'un montant de EUR 12.500,- (douze mille cinq cents euros) en GBP 9.906,25 (neuf mille neuf cent six livres
25861
L
U X E M B O U R G
sterling vingt-cinq pennies) par l'application du taux de change EUR/GBP prévalant sur le site internet de la Banque
Centrale Européenne à un taux de EUR 1,- (un euro) correspondant à GBP 0,7925 (zéro livre sterling et sept mille neuf
cent vingt-cinq pennies), refletant le taux de change applicable au 12 décembre 2014 et de reclasser les 100 (cent) parts
sociales existantes d'une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euro) chacune, en 990.625 (neuf cent quatre-vingt
dix mille six cent vingt-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de GBP 0,01 (un penny) chacune.
<i>Troisième résolutioni>
L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de GBP 993,75 (neuf cent quatre-
vingt-treize livres sterling soixante-quinze pennies) afin de porter le capital social de la Société de son montant converti
de GBP 9.906,25 (neuf mille neuf cent six livres sterling vingt-cinq pennies) à un montant total de GBP 10.900,- (dix mille
neuf cent livres sterling), par voie d'émission de 99.375 (quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent soixante-quinze) Nouvelles
Parts Sociales en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé Unique d'un montant total de GBP 565.942,81 (cinq
cent soixante-cinq mille neuf cent quarante-deux livres sterling quatre-vingt-un pennies) alloué comme expliqué ci-après.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-avant, approuve la souscription des Nouvelles Parts Sociales
et leur libération intégrale de la manière suivante:
<i>Souscription - Libérationi>
L'Associé Unique, susmentionné, représenté telle que décrit ci-dessus, déclare (i) souscrire 99.375 (quatre-vingt-dix-
neuf mille trois cent soixante-quinze) Nouvelles Parts Sociales, ayant une valeur nominale de GBP 0,01 (un penny) et (ii)
libérer entièrement ces Nouvelles Parts Sociales au moyen d'un apport en numéraire total de GBP 565.942,81 (cinq cent
soixante-cinq mille neuf cent quarante-deux livres sterling quatre-vingt-un pennies), qui est alloué (a) au capital social de
la Société pour un montant de GBP 993,75 (neuf cent quatre-vingt-treize livres sterling soixante-quinze pennies), et (b)
au compte de prime d'émission pour un montant de GBP 564.949,06 (cinq cent soixante-quatre mille neuf cent quarante-
neuf livres sterling six pennies).
L'ensemble des Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites et libérées en numéraire par
l'Associé Unique, de sorte que la somme de GBP 565.942,81 (cinq cent soixante-cinq mille neuf cent quarante-deux livres
sterling quatre-vingt-un pennies) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé au notaire instrumentaire
qui le constate expressément.
<i>Cinquième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des Statuts de façon à y refléter les résolutions
prises ci-dessus, de façon à lui donner la teneur suivante dans la version française des Statuts:
« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social de la Société est fixé à la somme de GBP 10.900,- (dix mille neuf cent
livres sterling), représenté par 1.090.000 (un million quatre-vingt-dix mille) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
de GBP 0,01 (un penny) chacune.»
<i>Sixième résolutioni>
L'Associé Unique décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin d'y refléter les changements repris
ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de LSCI, afin d'effectuer, par
sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription du changement de dénomination de la Société, (ii) l'in-
scription des Nouvelles Parts Sociales et (iii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.
<i>Estimation des coûtsi>
Les dépenses, frais, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui seront supportés par la Société ou
pour lesquels elle est responsable, en conséquence du présent acte, sont estimés approximativement à EUR 1.750,-.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête du mandataire des parties comparantes,
le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de ce même mandataire des parties
comparantes, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.
Dont acte, fait et passé en date des présentes, au Grand-Duché de Luxembourg.
Et après lecture faite au mandataire des parties comparantes, ledit mandataire a signé ensemble avec le notaire, l'original
du présent acte.
Signé: D. GOMES, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62046. Reçu soixante-quinze euros
75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-
bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.
25862
L
U X E M B O U R G
Luxembourg, le 21 janvier 2015.
Me Cosita DELVAUX.
Référence de publication: 2015012842/278.
(150014661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
LBPOL IV (Lux) S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 116.170.
In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth of December,
Before Us, Maître Roger Arrensdorff, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, a private limited liability company (société à responsabilité limitée) with status of a
SICAR (société d'investissement en capital à risque) with variable share capital, incorporated and existing under the laws
of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, and
registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under number 106.232;
here represented by Ms. Christie Lemaire-Legrand, employee, with professional address at 2, Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, by virtue of a power of attorney established on 16 December 2014.
The said proxy, signed "ne varietur" by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the
present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company ("société à responsabilité limitée")
existing in Luxembourg under the name of "LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.", having its registered office at 2 Avenue Charles de
Gaulle, L-1653 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, section B, under num-
ber 116.170, incorporated by a deed of Maître Joseph Elvinger, Notary in Luxembourg, of 31 March 2006, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1326 of 10 July 2006, and whose bylaws have been last
amended by a deed of Maître Joseph Elvinger, prenamed, of 19 December 2007, published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2348 of 25 September 2008.
II. The Company's share capital is fixed at nine hundred and thirty-four thousand six hundred and fifty Euros (EUR
934,650.-) represented by thirty-seven thousand three hundred and eighty-six (37,386) shares with a nominal value of
twenty-five Euro (EUR 25.-) each.
III. The sole shareholder resolves to dissolve the Company anticipatively and to put it into liquidation.
IV. The sole shareholder resolves to appoint Mr. Christophe Mathieu, Belgian Citizen, born on 18 January 1978 in
Verviers (Belgium), having his professional address at 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, as liquidator of
the Company.
The liquidator has the most extended powers as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies
law. He may carry out all the deeds provided by article 145 without previous general meeting authorization if required
by law.
All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realise the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the sole
shareholder, in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
V. The sole shareholder resolves to give full discharge to the members of the Board of Managers of the Company for
the accomplishment of their mandate unless the liquidation reveals faults in the execution of their duty.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever which will be borne by the Company as a result
of the present sole shareholder's meeting are estimated at approximately six hundred and ten Euro (EUR 610.-).
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French translation.
On request of the same appearing person and in case of divergence between the English and the French text, the
English version will prevail.
25863
L
U X E M B O U R G
Whereof, the present notarised deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this docu-
ment.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by his
Surname, Christian name, civil status and residence, he signed together with Us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction en langue française du texte qui précède.
L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.
Par-devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg.
A comparu:
LBREP II Europe S.à r.l., SICAR, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant le statut de SICAR
(société d'investissement en capital à risque) à capital variable, dont le siège social est au 2, Avenue Charles de Gaulle,
L-1653 Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 106.232;
ici représentée par Madame Christie Lemaire-Legrand, employée privée, ayant son adresse professionnelle au 2, Ave-
nue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 16 décembre 2014. Laquelle
procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire, demeurera
annexée aux présentes pour être enregistrée en même temps.
Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. Le comparant est l'associé unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination
"LBPOL IV (Lux) S.à.r.l." (la "Société"), ayant son siège social au 2, Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 116.170, con-
stituée suivant acte de Maître Joseph Elvinger, Notaire à Luxembourg, reçu en date du 31 mars 2006, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1326 du 10 juillet 2006, et dont les statuts ont été modifiés pour la
dernière fois suivant acte de Maître Joseph Elvinger, susnommé, reçu en date du 19 décembre 2007, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2348 du 25 septembre 2008.
II. Le capital social est fixé à neuf cent trente-quatre mille six cent cinquante Euros (EUR 934.650,-) représenté par
trente-sept mille trois cent quatre-vingt six (37,386) parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25.-)
chacune.
III. L'associé unique décide la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation volontaire.
IV. L'associé unique décide de nommer M. Christophe Mathieu, de nationalité belge, né le 18 janvier 1978 à Verviers
(Belgique), ayant son adresse professionnelle au 2 Avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme liquidateur de
la Société.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis de la loi sur les sociétés commerciales.
Il peut accomplir les actes prévus à l'article 145 sans recourir à l'autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle
est requise.
Pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins de
la liquidation, de réaliser l'actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en nature ou
en numéraire.
Il peut notamment, et sans que l'énumération qui suit soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens tant meubles
qu'immeubles et tous droits y relatifs; donner mainlevée, avec renonciation à tous droits réels, privilèges, hypothèques
et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions; dispenser le conservateur
des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et de privilèges; céder tous
rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas de paiements ordinaires d'administration; remettre
toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridictions; renoncer aux voies de
recours ou à des prescriptions acquises.
V. L'associé unique décide de donner décharge aux membres du Conseil de Gérance de la Société, sauf si la liquidation
fait apparaître des fautes dans l'exécution de tâches qui leur incombaient.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de six cent dix Euros (EUR 610,-).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête du comparant représenté
par son mandataire, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.
A la requête de cette même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version
anglaise fera foi.
Dont Procès-verbal, fait et passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire par son nom et prénom, état
et demeure, il a signé avec nous notaire, le présent acte.
25864
L
U X E M B O U R G
Signé: LEMAIRE-LEGRAND, ARRENSDORFF.
Enregistré à Luxembourg, le 24 décembre 2014. Relation: LAC / 2014 / 63378. Reçu douze euros 12,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012831/117.
(150015064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Hesperussa Société en Commandite Spéciale, Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-2562 Luxembourg, 2, place de Strasbourg.
R.C.S. Luxembourg B 193.861.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement («the Agreement») of Hesperussa Société en Commandite Spécialei>
<i>a special limited partnership, executed on December 4th , 2014i>
1. Partners who are jointly and severally liable. Porta Management S.à r.l. a company existing and incorporated under
the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg with its registered office located at 2, Place de Strasbourg, L-2562 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg, entered into the Luxembourg Trade and Companies Register under the number
B192648, hereinafter referred to as the „General Partner".
2. Name, Partnership's Purpose, Registered Office, Financial year.
2.1 Name:
The Partnership shall have the name: Hesperussa Société en Commandite Spéciale.
2.2 Purpose:
2.2.1 The Partnership's purpose is to invest, acquire and take participations and interests, in any form whatsoever, in
any kind of Luxembourg or foreign companies or entities and to acquire through participations, contributions, purchases,
options or in any other way any securities, rights, interests, patents, trademarks and licenses or other property as the
Partnership shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, encumber, sell or dispose of the same, in whole or in
part, for such consideration as the Partnership may think fit.
2.2.2 The Partnership may also enter into, assist or participate in any financial, commercial and other transactions, and
grant to any company or entity associated in any way with the Partnership, in which the partnership has a direct or indirect
financial or other interest, any assistance, loan, advance or guarantee, as well as borrow and raise money in any manner
and secure the payment of any money borrowed.
2.2.3 The Partnership may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
2.2.4 The Partnership may take any action and perform operation which is, directly or indirectly, related to its purpose
in order to facilitate the accomplishment of such purpose.
2.2.5 The Partnership may (a) engage in such other activities as the General Partner deems necessary, advisable,
convenient or incidental to the foregoing and (b) engage in any lawful acts or activities not inconsistent with the foregoing.
2.3 Registered Office:
The Partnership shall have its registered office at 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand Duchy of Lu-
xembourg.
2.4 Financial Year:
The financial year of the Partnership for the financial and Partnership accounting purposes shall be the calendar year
starting from January 1
st
and ending on December 31
st
.
3. Designation of the manager and signatory powers.
3.1 The management, control and operation of and the determination of policy with respect to the Partnership and
its investments and other activities shall be vested exclusively in the General Partner, which is hereby authorized and
empowered on behalf and in the name of the Partnership and in its own name, if necessary or appropriate, but subject
to the other provisions of this Agreement, to carry out any and all of the purposes of the Partnership and to perform all
acts and enter into and perform all contracts and other undertakings that they may in their sole discretion deem necessary,
advisable, convenient or incidental thereto.
3.2 All powers not expressly reserved to the Limited Partner by the Law or the Agreement fall within the competence
of the General Partner, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the object
of the Partnership. However, the General Partner should request the prior approval of all the Limited Partners in order
to transfer or dispose any assets of the Partnership for an amount higher than 100,000 EUR.
3.3 The Partnership shall be bound by the sole signature of the General Partner, or in case of plurality of General
Partners, by the sole signature of any General Partner or by the sole signature of any person to whom the power to sign
25865
L
U X E M B O U R G
on behalf of the Partnership has been validly delegated by the General Partner (s) in accordance with article 6.4. of the
Agreement.
3.4 The General Partner may at any time appoint one or several ad hoc agent(s) to perform specific tasks. The General
Partner will determine the powers and remuneration (if any) of such agent(s), the duration of the period of representation
and any other relevant condition of the agency. The agent(s) so appointed are in any case revocable ad nutum by decision
of the General Partner (s).
3.5 On any matter involving a conflict of interest or a potential conflict of interest of which the General Partner or its
affiliates are aware, the General Partner will be guided by its good faith judgment as to the best interests of the Partnership
and shall take such actions as are determined by the General Partner, as the case may be, to be necessary or appropriate
to ameliorate such conflicts of interest.
3.6 The General Partner will report on the results of its management and administration to the Partners.
4. Liability.
4.1 The General Partner will be personally jointly and severally liable with the Partnership for all liabilities that cannot
be covered by the assets of the Partnership.
4.2 The General Partner shall not be liable to the Partnership or any (Limited) Partner, and each Limited Partner by
accepting herein Agreement does release the General Partner, for any act or omission, including any mistake of fact or
error in judgment, taken, suffered or made by the General Partner in good faith and in the belief that such act or omission
is in or is not contrary to the best interests of the Partnership and is within the scope of authority granted to the General
Partner in this Agreement.
5. Date on which the Partnership commences and Date on which it ends. The Partnership is formed for an unlimited
period of time.
Suit la traduction en français du texte qui précède:
1. Associés commandités tenus conjointement et solidairement responsables. Porta Management S.à.r.l., une société
à responsabilité limitée constituée et régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social sis au 2, Place de Strasbourg,
L-2562 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés no. B192648,
décrit ci-après en tant que „Associé Commandité".
2. Dénomination, Objet social, Siège social, Exercice social.
2.1 Nom:
La dénomination de la Société en commandite spéciale est: Hesperussa Société en Commandite Spéciale.
2.2 Objet social:
2.2.1 L'objet de la Société est d'investir, d'acquérir et de prendre des participations et intérêts, sous quelque forme
que ce soit, dans n'importe quelle société ou entité Luxembourgeoise ou étrangère et acquérir au travers de participations,
de contributions, d'achats, d'options ou de toutes autres manières tous titres, droits, intérêts, brevets, marques et licences
ou d'autres biens que la Société jugera approprié, et plus généralement de détenir, gérer, développer, grever, vendre ou
disposer, en tout ou en partie, pour telle contrepartie que la Société peut penser appropriée.
2.2.2 La Société peut également conclure, assister ou participer à toutes transactions financières, commerciales ou
autres et accorder à toute société ou entité associée de n'importe quelle manière avec la Société, dans laquelle la Société
a un intérêt financier ou autre, direct ou indirect, toute assistance, prêt, avance ou garantie ainsi qu'emprunter et lever
des fonds de quelque manière que ce soit et d'assurer le paiement de toute somme empruntée.
2.2.3 La Société peut utiliser toutes techniques, moyens légaux, et instruments pour gérer ses investissements effica-
cement et se protéger elle-même contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres risques.
2.2.4 La Société peut prendre toute action et effectuer toute opération qui est, directement ou indirectement, liée à
son objet afin de faciliter la réalisation de cet objet.
2.2.5 La Société peut (a) s'engager dans d'autres activités considérées comme nécessaires, recommandables, appro-
priées ou accessoires et (b) s'engager dans tout acte légal ou activité non-incomptable avec ce qui précède.
2.3 Siège Social:
La Société a son siège social au 2 Place de Strasbourg, L-2562 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.
2.4 Exercice social:
L'exercice social de la Société sera l'année calendrier commençant le 1
er
janvier de chaque année et se terminant le
31 décembre de la même année.
3. Désignation des gérants et pouvoir de signature.
3.1 La gestion, le contrôle et le fonctionnement et la définition de la politique de la Société et de ses investissements
et d'autres activités seront dévolus exclusivement à l'Associé Commandité, qui est autorisé et habilité pour le compte et
au nom de la Société et en son nom propre, si nécessaire ou approprié, mais sous réserve des autres dispositions du
présent accord, à procéder à n'importe quel et tous les objectifs de la Société et à effectuer tous les actes et conclure et
25866
L
U X E M B O U R G
exécuter tous les contrats et autres engagements qu'il peut à sa seule discrétion juger nécessaires, souhaitables, pratiques
ou accessoires.
3.2 Tous les pouvoirs non expressément réservés aux Associés Commanditaires par la loi ou par le présent accord
relèvent de la compétence de l'Associé Commandité, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes
et opérations conformes à l'objet de la Société. Cependant, l'Associé Commandité devra demander l'accord préalable de
l'ensemble des Associés Commanditaires afin de transférer ou vendre tout actif de la Société pour un montant supérieur
à 100,000.- EUR.
3.3 La Société sera engagée par la seule signature de l'Associé Commandité, ou en cas de pluralité des Associés
Commandités, par la seule signature de n'importe quel Associé Commandité ou par la seule signature de toute personne
à qui le pouvoir de signer au nom de la Société a été valablement délégué par le /les Associé(s) Commandité(s) en accord
avec l'article 6.4 du présent accord.
3.4 L'Associé Commandité peut à tout moment nommer un ou plusieurs agent(s) ad hoc afin d'effectuer certaines
tâches spécifiques. L'Associé Commandité déterminera les pouvoirs et la rémunération (le cas échéant) de cet/ces agent
(s), la durée de la période de représentation et de toute autre condition de l'accord. Le/les agent(s) ainsi désigné(s) est/
sont révocable(s) ad nutum par décision de l'/des Associé(s) Commandité(s).
3.5 Pour tout sujet impliquant un conflit d'intérêt ou la possibilité d'un conflit d'intérêt dont l'Associé Commandité ou
ses affiliés en seraient informés, l'Associé Commandité sera guidé par son jugement de bonne foi dans le meilleur intérêt
de la Société et prendra toutes actions qui seront jugées par l'Associé Commandité, le cas échéant, comme nécessaires
ou appropriées pour améliorer tout conflit d'intérêt.
3.6 L'Associé Commandité reportera les résultats de sa gestion et de son administration aux Associés Commanditaire.
4. Responsabilité.
4.1 L'Associé Commandité sera personnellement conjointement et solidairement responsable avec la Société pour
tous les engagements qui ne pourraient être couverts par les actifs de la Société.
4.2 L'Associé Commandité ne sera pas responsable envers la Société ou envers tout Associé Commanditaire, et chaque
Associé Commanditaire en donnant son accord sur le présent contrat libère l'Associé Commandité de toute responsa-
bilité, pour tout acte ou omission, ce y compris tout erreur de fait ou erreur de jugement, commise, affectée ou prise
par l'Associé Commandité de bonne foi et dans la mesure où tel acte ou omission est dans, ou n'est pas contraire au
meilleur intérêt de la Société et est dans le périmètre de responsabilité confiée à l'Associé Commandité dans le cadre du
présent accord.
5. Date de création de la Société et son terme. La Société est créée pour une durée indéterminée.
THE GENERAL PARTNER
Maciej Grabski / David Luksenburg
<i>Director A / Director Bi>
Référence de publication: 2015012737/139.
(150014423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
GSCF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 29.500,00.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 4A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 133.250.
In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December.
Before us, Maître Martine Schaffer, notary, residing in Luxembourg.
There appeared:
Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws
of Luxembourg, with registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), with
a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-) registered with the Luxembourg Register of
Commerce and Companies under number B 131.972, hereinafter referred to as the “Sole Shareholder”,hereby repre-
sented by Mr. Liridon Elshani, employee, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy given on the 11
December 2014.
The said proxy shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.
The appearing party has requested the undersigned notary to document that the Shareholder is the sole shareholder
of GSCF Holding S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), incorporated
by a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, of 31
st
October 2007, registered with the Lu-
xembourg Register of Commerce and Companies under number B133.250, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2808 of December 5, 2007(the ”Company”). The articles of the Company have been
25867
L
U X E M B O U R G
amended for the last time by notary, Martine Schaeffer on 24 September 2009 and published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 2110 of October, 27 2009.
The appearing party representing all the two hundred and ninety-five (295) shares of the Company, and acting in its
capacity as Sole Shareholder of the Company has recognized to be fully informed of the resolutions to be taken on the
basis of the following agenda:
<i>Agendai>
1. Dissolution of the Company and decision to put the Company into liquidation.
2. Appointment of the liquidator.
3. Determination of the powers to be granted to the liquidator.
4. Miscellaneous.
The appearing party has requested the undersigned notary to document the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve the Company and put it into liquidation with immediate effect.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint THEMIS LEX, represented by Bertrand Moupfouma, a Law firm incorporated
under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 15, rue du Fort Bourbon, L- 1249 Luxem-
bourg, as liquidator of the Company.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves that, the aforesaid liquidator has the mission to realize all of the assets and liabilities of
the Company.
The liquidator in performing his duties shall be exempted from the obligation of drawing up an inventory, may in this
respect rely fully on the books of the Company and shall have the broadest powers to carry out any act of administration,
management or disposal concerning the Company, whatever the nature or size of the operation.
The liquidator shall have the corporate signature and shall be empowered to represent the Company towards third
parties, including in court either as a plaintiff or as defendant.
The liquidator may waive all property and similar rights, charges, registration of any charge, seizure, attachment or
other opposition.
The liquidator may in the name and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem shares issued
by the Company.
The liquidator may under his own responsibility, distribute advances on the liquidation profits to the Sole Shareholder.
The liquidator has the authority to perform and execute all operations provided for in articles 144 and 145 of the law
of August 10
th
, 1915 on commercial companies, as amended, without a specific authorization of the Sole Shareholder.
The liquidator may under his own responsibility grant for the duration as set by him to one or more proxy holders
such part of his powers as he deems fit for the accomplishment of specific transactions.
The Company in liquidation is validly bound towards third parties without any limitation by the sole signature of the
liquidator for all deeds and acts including those involving any public official or notary public.
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result
of this deed are estimated at approximately at one thousand and three hundred euro (EUR 1,300.).
The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the above appearing person, the present
deed is worded in and in case of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The deed having been read to the person appearing, who is known to the notary by his surname, first name, civil status
and residence, the said person signed together with Us notary this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous, Maitre Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
A comparu:
Henderson Joint Ventures Property Funds Management S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit
luxembourgeois, ayant son siège social au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),
avec un capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 131.972, ci-après désignée par: «l’Associé Unique»,
25868
L
U X E M B O U R G
représentée aux fins des présentes par M. Liridon Elshani, employé, domicilié professionnellement au Luxembourg, en
vertu d’une procuration donnée le 11 Décembre 2014.
Cette procuration sera annexée au présent acte pour les effets de l’enregistrement.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter que l’Associé est l’associé unique de GSCF Holding
S.à r.l., une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), constituée suivant acte de Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, le 31
Octobre 2007, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B133.250, publié
au Mémorial C numéro 2808 du 5 Décembre 2007 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la
dernière fois suivant l’acte de Maitre Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, le 24 Septembre 2009, publié
au Mémorial C numéro 2110 du 27 Octobre 2009.
Lequel comparant représentant les deux cents quatre-vingt-quinze (295) parts sociales et ainsi agissant en sa qualité
d’associé unique, a reconnu être pleinement informé des résolutions devant être prises sur la base de l’ordre du jour
suivant:
<i>Ordre du jouri>
1. Dissolution de la Société et décision de mettre la société en liquidation.
2. Nomination d’un liquidateur.
3. Détermination des pouvoirs à conférer au liquidateur.
4. Divers.
Lequel comparant a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses résolutions:
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide la dissolution de la Société et la mise en liquidation de celle-ci, avec effet immédiat.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer THEMIS LEX représenté par M. Bertrand Moupfouma, un cabinet d’avocat régi
par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg (Grand-Duché de
Luxembourg), comme liquidateur de la Société
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide que le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l’actif et apurer le passif de la Société.
Le liquidateur dans l’exercice de ses fonctions est dispensé de dresser inventaire, peut se référer aux écritures de la
société, disposera des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes d’administration, de gestion et de disposition
intéressant la Société, quelle que soit la nature ou l’importance des opérations en question.
Le liquidateur disposera de la signature sociale et sera habilité à représenter la Société vis-à-vis des tiers, notamment
en justice, que ce soit en tant que demandeur ou en tant que défendeur.
Le liquidateur peut renoncer à des droits de propriété ou à des droits similaires, à des gages, ou des actions en rescision,
il peut accorder mainlevée, avec ou sans quittance, de l’inscription de tout gage, saisie ou autre opposition.
Le liquidateur peut, au nom et pour le compte de la Société et conformément à la loi, racheter des actions émises par
la Société.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité distribuer des avances sur le boni de liquidation à l’Associé Unique
Le liquidateur a le pouvoir d’accomplir et d’exécuter toutes les opérations prévues par les articles 144 et 145 de la loi
sur les sociétés commerciales du 10 Août 1915 telle que modifiée, sans autorisation spécifique préalable de l’Associé
Unique.
Le liquidateur peut sous sa propre responsabilité et pour une durée qu’il fixe, confier à un ou plusieurs mandataires
de pouvoirs qu’il estime appropriés pour l’accomplissement de certains actes en particulier.
La Société en liquidation est valablement et sans limitation engagée envers des tiers par la signature du liquidateur,
pour tous les actes y compris ceux impliquant tout fonctionnaire public ou notaire.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges quelconques qui incombent à la Société des suites de ce document sont
estimés à mille trois cents euros (EUR 1.300,-).
Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant ci-avant, le
présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant, en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentaire par son nom,
prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.
25869
L
U X E M B O U R G
Signé: L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 23 décembre 2014. Relation: LAC/2014/62811. Reçu douze euros Eur 12.-
<i>Le Receveuri> (signé): Irène THILL.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de
Commerce.
Luxembourg, le 21 janvier 2015.
Référence de publication: 2015012730/135.
(150015204) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
First Data International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 111.072.
Il est porté à la connaissance des tiers qu'à la suite d'un contrat de transfert de parts daté du 18 Décembre 2014, First
Data International Luxembourg V S.à r.l. a transféré ses 125 parts détenues dans ta Société à la société First Data Inter-
national Luxembourg II S.à r.l. dont le siège social sis à 2-8 avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, enregistrée
auprès du Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B132175.
First Data International Luxembourg II S.à r.l. est désormais l'actionnaire unique de la société First Data International
Luxembourg S.à r.l et détient 125 parts sociales.
Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Xavier de Cillia
<i>Gérant Bi>
Référence de publication: 2015012686/17.
(150015227) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Financière Tesalia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 155.538.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012699/10.
(150014709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Financière Tesalia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 155.538.
Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012700/10.
(150014714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Financière Tesalia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1728 Luxembourg, 4, rue du Marché-aux-Herbes.
R.C.S. Luxembourg B 155.538.
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012701/10.
(150015107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25870
L
U X E M B O U R G
Montesquieu & Associés S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 11, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 112.510.
<i>Extrait du conseil des associés du 19 décembre 2014i>
Il résulte de la réunion des Associés de la Société Montesquieu & Associés S.à r.l. qui s'est tenue en date du 19 décembre
2014, à son siège social: 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg.
L'unanimité des associés présents et représentés a donné son accord pour:
- La démission de Philippe SCHMIT de son poste de gérant;
- La nomination de Nicolas FROIDEFOND, demeurant professionnellement 11, avenue de la Liberté, L-1931 Luxem-
bourg, comme gérant de Montesquieu & Associés S.à r.l.
- La cession d'une part sociale de Philippe SCHMIT au profit de Nicolas FROIDEFOND.
A l'issue de ces opérations, le capital social de Montesquieu & Associés S.à r.l. s'établira comme suit:
- PRINCETON PROPERTY, S.à r.l.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 parts sociales
- Nicolas FROIDEFOND: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 part sociale
Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Nicolas FROIDEFOND
<i>Le géranti>
Référence de publication: 2015012861/21.
(150014664) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
Rally Lux Holding One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2440 Luxembourg, 61, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 102.130.
Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015012982/10.
(150014514) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
NN Luxury S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 185.044.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement des actionnaires de la société,
tenue en date du 26 décembre 2014, que
L'assemblée a pris note de la démission du commissaire aux comptes KSANTEX S. à r.l. (immatriculée au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B152619) avec effet au 31 décembre 2014 à minuit.
L'assemblée a décidé de nommer en tant que nouveau Commissaire aux Comptes la société SEPRA INVEST S. à r. l.
(immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B169294), avec siège social
établi au 51, rue de Strasbourg, L-2561 Luxembourg, à compter du 1
er
janvier 2015. Son mandat prendra fin lors de
l'assemblée générale annuelle de l'an 2020.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 26 décembre 2014.
Pour extrait conforme
<i>Pour le Conseil d'Administrationi>
Référence de publication: 2015012905/20.
(150015344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.
25871
L
U X E M B O U R G
Aquariolux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8030 Strassen, 41, rue du Kiem.
R.C.S. Luxembourg B 113.950.
DISSOLUTION
L’an deux mil quatorze, le trente et un décembre,
Par-devant Maître Camille MINES, notaire de résidence à Capellen,
Ont comparu:
Monsieur Samuel KLEEBLATT, commerçant, né à Hadera, Israël, le 18 janvier 1950, demeurant à B-6747 Chatillon,
23, rue du Fourneau, et
Madame Marina GLYADENTSEVA, sans état, née à Kemerovo Oblast, Russie, le 17 novembre 1979, demeurant à
B-6747 Chatillon, 23, rue du Fourneau.
Lesquels ont déclaré:
Qu'ensemble ils sont les seuls associés de la société à responsabilité limitée AQUARIOLUX s.à r.l. avec siège à L-8030
Strassen, 41, rue du Kiem, constituée aux termes d’un acte reçu par le notaire Paul BETTINGEN, de résidence à Nie-
deranven, en date du 05 janvier 2006, publié au Mémorial C numéro 859 du 02 mai 2006, inscrite au Registre de Commerce
de Luxembourg sous le numéro B 113950 et dont les statuts ont été modifiés aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire actée par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 04 août 2009, publiée
au Mémorial C numéro 1656 du 27 août 2009,
Que la société a cessé toute activité commerciale.
Que les comptes sociaux sont parfaitement connus des associés et sont approuvés par eux.
Que tout le passif de la société a été apuré et que tout l’actif a été distribué aux associés.
Que les associés n’ont plus de revendication envers la société.
Ceci approuvé, les comparants ont pris à l’unanimité les résolutions suivantes:
1. La société AQUARIOLUX s.à r.l. est dissoute et liquidée avec effet immédiat.
2. Pour autant que de besoin, Monsieur KLEEBLATT, préqualifié, est à considérer comme liquidateur, qui est également
personnellement et solidairement avec les associés responsables des frais des présentes.
3. Les documents de la société seront conservés pendant un délai de cinq ans au domicile des associés.
4. Au cas où, par impossible, une dette ou une créance aurait échappé au liquidateur, les associés susdits en suppor-
teraient les frais ou en feraient le bénéfice.
Dont acte, fait et passé à Capellen, en l’étude du notaire instrumentant.
Et après lecture faite et interprétation donnée de tout ce qui précède aux comparants, connus du notaire par nom,
prénom, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: S. KLEEBLATT, M. GLYADENTSEVA, C. MINES.
Enregistré à Luxembourg Actes Civiles 1, le 6 janvier 2015. Relation: 1LAC/2015/249. Reçu soixante-quinze euros 75,-
€.
<i>Le Receveuri> (signé): I. Thill.
POUR COPIE CONFORME.
Capellen, le 19 janvier 2015.
Référence de publication: 2015013175/42.
(150015882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.
Architecture and Engineering S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 15, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 108.156.
Philippe NOCQUET démissionne à effet du 16 septembre 2013 de son poste d'administrateur.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
P/° Philippe NOCQUET.
Référence de publication: 2015013176/10.
(150016248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 26 janvier 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
25872
Aquariolux S.à r.l.
Architecture and Engineering S.A.
Emerging Energy S.A.
Financière Tesalia S.A.
Financière Tesalia S.A.
Financière Tesalia S.A.
First Data International Luxembourg S.à r.l.
Green-Man S.à r.l.
GSCF Holding S.à r.l.
Hesperussa Société en Commandite Spéciale
Hines Global REIT HoldCo S.à r.l.
Histrio S.àr.l.
Hôtel de la Sûre SA
Hotel Group Maas
Iberint S.A.
I.C. Dom-Com S. à r.l.
Ilyeum SA
IMG S.à r.l.
Immo Guillaume Schneider S.A.
Immo-Weimerskirch II S.A.
Indigo Gold Holding S.à r.l.
ING (L)
ING (L) Patrimonial
Inpeco Group S.A.
Intercontinental Group for Commerce Industry and Finance S.A., SPF
Iris International S.A.
Isotherma S.à r.l.
J.C. Immo-Performance S.A.
Jeancel
JL Investments S.à r.l.
J Manhattan Luxco S.àr.l.
JM Holdings S.à r.l.
John De Wilde International S.A.
Kartesia GP S.A.
Kartesia Management
LBPOL IV (Lux) S.à.r.l.
Lsref3 Tiger Investements S.à .r.l.
MaForm Holding Luxembourg S.àr.l.
MaForm S.à r.l.
Montesquieu & Associés S.à.r.l.
NN Luxury S.A.
Pafin Participations S.A.
Parcip S.A.
PC-Broker.Com
PricewaterhouseCoopers Academy S.à r.l.
Rally Lux Holding One S.à r.l.