logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 508

24 février 2015

SOMMAIRE

Callaway Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24353

CapLinden S.A., Société de Gestion de Pa-

trimoine Familial - SPF  . . . . . . . . . . . . . . . .

24352

Celistics Luxembourg S. à r.l.  . . . . . . . . . . .

24350

CoBzz S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24383

Colorado S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24346

Eastpharma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24344

Eastpharma S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24344

Ecotechnology International S.A.  . . . . . . . .

24345

ECP International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24383

ECP International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

24345

Emeraude Participations S.A.  . . . . . . . . . . .

24345

Emerging Energy S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24345

Esther Seven S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

FinAcc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

First Financial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

Fleet Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

Foxitec S.A. SPF  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24338

Garage Rodenbourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

24343

gategroup Financial Services S.à r.l. . . . . . .

24344

Geogare 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24342

Geoholding  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24342

Global Fashion Holding S.A. . . . . . . . . . . . . .

24354

Golden Park Hotel Holding S.A.  . . . . . . . . .

24341

Grace Lodge Care Investments S.à r.l.  . . .

24343

Gresham Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24342

Group Lumina SICAV SIF  . . . . . . . . . . . . . .

24342

HF Immobilier S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24343

Landscape Internet Active Server Europe

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24340

Longitude Library Holdings S.à r.l. . . . . . . .

24340

LSF6 Lux Investments I S. à r.l. . . . . . . . . . .

24382

LSF7 Silverstone S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24384

LuxcoSITQ 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24339

Luxembourg Investment Company 31

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24340

Munsterfred Property S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

24339

Mylan Luxembourg 7 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

24339

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

24352

Quorum Licensing Luxco S.à r.l. . . . . . . . . .

24340

Simply Solutions, S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

24383

Techno Services S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24348

TTG Cayuga Bavaria Holdco S.à r.l.  . . . . .

24341

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.  . . . . . . . . . .

24340

Valoris 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24341

VBTECH S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24341

Wood Industries S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .

24344

24337

L

U X E M B O U R G

Esther Seven S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 131.879.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015011988/10.
(150014353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

FinAcc, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 5, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 154.504.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

CREDIT SUISSE FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A.

Référence de publication: 2015012004/10.
(150014104) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

First Financial S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 82.419.

En date du 16 janvier 2015, GLOBAL TRUST ADVISORS S.A., 26-28 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, a dénoncé

tout office de domiciliation de la société FIRST FINANCIAL S.A., société anonyme immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés sous le numéro B82419.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012021/11.
(150014317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Foxitec S.A. SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 35.276.

<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue à Luxembourg le 3 mars 2014 à 15.00 heures.

Le conseil décide à l'unanimité:
- de renouveler le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur Joeri STEEMAN;

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2015012031/11.
(150014384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Fleet Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 148.815.

Le dépôt rectificatif des comptes annuels au 31 décembre 2012 déposés au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg le 22 novembre 2013, sous la référence L130198638 a été déposé au registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012006/12.
(150014050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24338

L

U X E M B O U R G

Mylan Luxembourg 7 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 32-36, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 150.331.

Le présent document est établi en vue de mettre à jour les informations inscrites auprès du Registre de Commerce

et des Sociétés de Luxembourg.

L'adresse professionnelle de Monsieur Alan Roy WEINER, gérant de classe A de la Société, doit se lire désormais

comme suit:

- 1000, Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, Etats-Unis d'Amérique
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Mylan Luxembourg 7 S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2015012233/17.
(150013979) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

LuxcoSITQ 6, Société Civile.

Capital social: EUR 50.000,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg E 3.971.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

En date du 16 décembre 2014, les associés de la Société ont décidé de la dissolution et liquidation volontaire de la

Société avec la nomination de LuxcoSITQ 1 en tant que liquidateur. En date du 16 décembre 2014, les associés de la
Société ont, par ailleurs, décidé de clôturer la liquidation et de donner décharge (quitus) au liquidateur pour l'exécution
de son mandat de liquidateur de la Société.

Les associés ont décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés au 25A, Boulevard Royal,

L-2449 Luxembourg pendant une période de cinq ans minimum.

Pour extrait, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Un Mandataire

Référence de publication: 2015012168/18.
(150013999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Munsterfred Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 123.196.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par l'actionnaire unique de la société en date du 16 Janvier 2015:
1. de changer le siège social de la société de l'adresse actuelle 6, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg à la

nouvelle adresse 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg et ce, avec effet au 1 

er

 janvier 2015;

2. les démissions de Monsieur Marc Chong Kan et Benjamin Chouraki, tous deux gérants de classe B ont été acceptées

avec effet au 31 décembre 2014.

3. les nominations de Monsieur Nicholas Procopenko, gérant de Classe B, et résident professionnellement au 12, rue

Jean Engling, L-1466 Luxembourg, et de Monsieur Benoît Bauduin, gérant de Classe B, et résident professionnellement
au 12, rue Jean Engling, L-1466 Luxembourg ont été acceptées avec effet au 1 

er

 janvier 2015

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Référence de publication: 2015012231/19.
(150014028) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24339

L

U X E M B O U R G

Landscape Internet Active Server Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6973 Rameldange, 10, Am Beiebierg.

R.C.S. Luxembourg B 87.096.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012161/9.
(150013853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-2180 Luxembourg, 6, rue Jean Monnet.

R.C.S. Luxembourg B 140.847.

<i>Extrait des résolutions prises par les Gérants Commandités en date du 31 décembre 2014

- le siège social de la Société est transféré du 5, rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg au 6, rue Jean Monnet

L-2180 Luxembourg avec effet au 31 décembre 2014.

Certifié sincère et conforme

Référence de publication: 2015012445/11.
(150014315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Longitude Library Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Quorum Licensing Luxco S.à r.l.).

Siège social: L-2121 Luxembourg, 208, val des Bons Malades.

R.C.S. Luxembourg B 189.873.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le jeudi 22 janvier 2015.

<i>Pour la société
Me Martine DECKER
<i>Notaire

Référence de publication: 2015012163/13.
(150013932) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Luxembourg Investment Company 31 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 193.358.

<i>Demande de dépôt rectificatif qui remplace la version déposé le 12/01/2015 sous le numéro L150005593

<i>Extrait du contrat de cession de parts sociales de la Société daté du 2 janvier 2015

En vertu de l'acte de transfert de parts sociales, daté du 2 janvier 2015, Tenor Special Situation I, LLC a transféré

12.488 parts sociales détenues dans la Société à la société Tenor KRY (Barbados) SRL, ayant son siège social à The Grove,
21 Pine Road, Belleville, St. Michael, Barbados, BB11113, enregistré auprès du registre Societies with restricted liability
act of Barbados sous le numéro 1166 et non pas à la société Tenor Opportunity Associates LLC.

Le capital social de la Société se compose comme suit désormais:
- 12 parts sociales sont détenues par Tenor Opportunity Associates LLC
- 12.488 parts sociales sont détenues par Tenor KRY (Barbados) SRL
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015012171/21.
(150014245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24340

L

U X E M B O U R G

Valoris 1, Société Anonyme.

Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.

R.C.S. Luxembourg B 147.343.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012435/10.
(150013658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

VBTECH S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 2, rue Pletzer.

R.C.S. Luxembourg B 146.268.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 novembre 2014.

Delphine MUNIER.

Référence de publication: 2015012448/10.
(150014465) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

TTG Cayuga Bavaria Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 22, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 172.871.

Le bilan de la société au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015012430/12.
(150014119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Golden Park Hotel Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 117.405.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 janvier 2015

Après avoir délibéré, l'actionnaire unique a décidé de:
1) Révoquer Me Delphine MAYER de son mandat d'administrateur;
2) Révoquer Me Eyal GRUMBERG de son mandat d'administrateur;
3) Révoquer Me Vanessa MOROLLI de son mandat d'administrateur;
4) Révoquer Monsieur Yosef BARAZANI de son mandant d'administrateur unique;
5) Nommer en qualité d'administrateur unique pour une durée indéterminée la société KRASPEDON MANAGEMENT

LIMITED, ayant son siège social à Akropoleos 59-61, SAVVIDES, 3 

e

 étage, Bureau 301, STROVOLOS, 2012, NICOSIA,

CYPRUS, inscrite au «Department of Registrar of Companies and official Receiver» chypriote sous le numéro HE 172094,
représentée par Monsieur Nicos AVRAAMIDES, né le 18 décembre 1947 à NICOSIA, CYPRUS, demeurant à G.Seferi,
7-9, Bureau 23, 1076, NICOSIA, CYPRUS.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'actionnaire unique lève la séance à 11.15 heures.

Luxembourg, le 16/01/2015.

GOLDEN PARK HOTEL HOLDING S.A.
Signature

Référence de publication: 2015012067/22.
(150013592) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24341

L

U X E M B O U R G

Geogare 2, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8264 Mamer, 23, Ro'dewé.

R.C.S. Luxembourg B 77.556.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012048/10.
(150013798) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Geoholding, Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 38.176.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015012049/10.
(150013797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Group Lumina SICAV SIF, Société en Commandite par Actions.

R.C.S. Luxembourg B 171.661.

La convention de domiciliation conclue entre l'agent domiciliataire CACEIS BANK LUXEMBOURG, société anonyme

immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 91 985, avec siège
social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, et GROUP LUMINA SICAV SIF, immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroB171661, avec siège social au 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, a été
résiliée avec effet au 1 

er

 octobre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Caceis Bank Luxembourg

Référence de publication: 2015012043/13.
(150014033) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Gresham Holding S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 69.833.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions prises par le Conseil d'Administration lors d'une réunion tenue en date du 16 décembre 2014

que:

- La démission de Mme Ana FLORES sa fonction d'administrateur de la société avec effet au 24 septembre 2014 a été

acceptée;

- M. Paul TORI, né le 03 avril 1968 à Lima (Pérou), demeurant professionnellement au 38, boulevard Napoléon I 

er

 ,

L-2210 Luxembourg a été nommé comme nouveau membre du Conseil d'Administration en remplacement de M. Ana
FLORES, Administrateur démissionnaire avec effet au 24 septembre 2014.

- Le mandat des Administrateur prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Annuelle des actionnaires qui se tiendra

en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2015012073/21.
(150014164) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24342

L

U X E M B O U R G

HF Immobilier S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean Engling.

R.C.S. Luxembourg B 150.970.

<i>Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue le 11 décembre 2014 à 12h30

- A l'unanimité,
L'Assemblée décide de nommer à la fonction d'Administrateur, Monsieur Vincent ADAM, né le 22 avril 1966 à Bastogne

(Belgique) résidant professionnellement 38, Cité Aischdall à L-8480 Eischen (Luxembourg), pour une durée de deux ans.
Ce mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017.

Pour extrait conforme
HUGUES ... / Signature

Référence de publication: 2015012091/14.
(150014025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Grace Lodge Care Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 20.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 152.615.

Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales signé en date du 23 décembre 2014 que Patron Healthcare LP, ayant

son siège social Suite 7B &amp; 8B, Town Range, GX11 1AA Gibraltar, enregistré sous le numéro 068, représenté par son
associé commandité, Patron Healthcare GP Limited, ayant son siège social Suite 7B &amp; 8B, 50 Town Range, GX11 1AA
Gibraltar., a cédé les 20,000 parts sociales qu'elle détenait dans la Société à Patron Healthcare 2 LP, ayant son siège social
Suite 7B &amp; 8B, Town Range, GX11 1AA Gibraltar, enregistré sous le numéro 095, représenté par son associé commandité,
Patron Healthcare GP 2 Limited, ayant son siège social Suite 7B &amp; 8B, 50 Town Range, GX11 1AA Gibraltar.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait
La société

Référence de publication: 2015012042/16.
(150013738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Garage Rodenbourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.300.000,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 33, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 93.897.

Il résulte des résolutions de l'associé unique de la société Garage Rodenbourg S.à r.l. (la «Société») du 8 janvier 2015

que:

1 La démission de Monsieur Jacques Rodenbourg de son mandat de gérant a été acceptée par la Société avec effet au

28 novembre 2014.

2 La société à responsabilité limitée Rodenbourg Participations, inscrite au registre de commerce sous le numéro

B93943, ayant son siège social 33 boulevard Prince Henri L-1724 Luxembourg, a été nommée gérant pour la période du
29 novembre 2014 au 30 juin 2015.

3 Il a été apporté les limitations suivantes aux pouvoirs des gérants:
La société sera engagée par la signature unique d'un des gérants pour toutes les opérations d'une valeur inférieure ou

égale à cinquante mille euros (50.000,-EUR) et par la signature conjointe de deux gérants pour toutes opérations d'une
valeur supérieure à ce plafond. Les gérants ne sont pas autorisés à vendre des parts sociales détenues par la Société dans
des filiales et/ou des propriétés immobilières de la Société et/ou de ses filiales et/ou des fonds de commerces détenus
par  la  Société  et/ou  de  ses  filiales  ni  d'engager  la  Société  et/ou  ses  filiales  sur  des  projets  immobiliers,  à  moins  que
l'assemblée générale des associés ne les y autorise expressément. En outre, la nomination par la Société, via ses gérants,
de gérants dans ses filiales est soumise à l'accord préalable de l'assemblée générale des associés de la Société.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015012046/24.
(150014410) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24343

L

U X E M B O U R G

Wood Industries S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3378 Livange, 3, rue de Turi.

R.C.S. Luxembourg B 157.649.

Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Signature.

Référence de publication: 2015011742/10.
(150013415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.467.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011949/10.
(150013721) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Eastpharma S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 4.467.800,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 119.476.

Par résolutions signées en date du 29 décembre 2014, l'associé unique a décidé de nommer ERNST &amp; YOUNG, avec

siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, au mandat de réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat
et pour une période venant à échéance lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice
social se clôturant au 31 décembre 2014 et qui se tiendra en 2015;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011948/14.
(150013718) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

gategroup Financial Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 40.562.600,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 12, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 86.446.

<i>Décision des actionnaires du 17 décembre 2014

Démission
Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Mike Hargett à effet du 17 décembre 2014.
Nominations
Les actionnaires ont décidé de nommer gérant de type A pour une durée indéterminée avec effet au 17 décembre

2014:

- Madame Kristin Brown née à Washington D.C. (USA) le 21/09/1968, domiciliée à: Balz Zimmermannstrasse 7, 8302

Kloten (Suisse)

- Monsieur Schaun Rixon né à Rochhampton (Australie) le 23/06/1970, domicilié à: Balz Zimmermannstrasse 7, 8302

Kloten (Suisse)

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Signature.

Référence de publication: 2015011766/20.
(150013856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24344

L

U X E M B O U R G

Ecotechnology International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 167.929.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015011960/9.
(150014291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

ECP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.000.

Je soussigné Riccardo PALMA vous notifie officiellement par la présente lettre, ma démission avec effet au 1 

er

 octobre

2014 de mon poste de délégué à la gestion journalière de la société ECP International S.A. ayant son siège social 13, rue
Aldringen à Luxembourg, immatriculée au RCS sous le numéro B 129000.

Luxembourg, le 27 juillet 2014.

Signature.

Référence de publication: 2015011963/11.
(150013724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Emeraude Participations S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1945 Luxembourg, 3, rue de la Loge.

R.C.S. Luxembourg B 114.240.

Nous vous informons par ce courrier de notre décision de renoncer, avec effet immédiat, au mandat de Commissaire

aux Comptes qui nous avait été confié au sein de votre société.

Luxembourg, le 15 janvier 2015.

Myriam Francq
<i>Administrateur

Référence de publication: 2015011969/12.
(150013645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

Emerging Energy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 173.707.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement en date du 6 janvier 2015

Sont nommés administrateurs, leur mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes

annuels au 31 décembre 2014:

<i>Administrateur de catégorie A:

- Monsieur Etienne GERMAIN, directeur financier d'entreprises, demeurant au 137, avenue Victor Hugo, F-75116

Paris.

- Monsieur Antonin BACOT, contrôleur financier, demeurant au 66, rue Notre-Dame de Nazareth, F-75003 Paris

<i>Administrateur de catégorie B:

- Monsieur Philippe PONSARD, ingénieur commercial, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle,

L-1653 Luxembourg.

Est nommé commissaire aux comptes, son mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les

comptes annuels au 31 décembre 2014:

- AUDIEX S.A., société anonyme, 9, rue du laboratoire, L - 1911 Luxembourg
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011973/22.
(150013938) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

24345

L

U X E M B O U R G

Colorado S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 152.626.

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of December.
Before us, Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Ipanema II LLC, a limited liability company, incorporated under the laws of the State of Delaware, having its registered

office at 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, United States of America and registered with the
Secretary of State of the State of Delaware under number 4721485,

here represented by Mrs Antje Reibold, Rechtsanwältin, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in New York, New York, on 19 December 2014,

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed

to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of Colorado S.à r.l. (hereinafter the “Company”), a société à responsabilité

limitée, having its registered office at 19, rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade
and Companies’ Register under number B 152626, incorporated pursuant to a notarial deed on 15 April 2010, published
in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. number 1150 on 2 June 2010. The articles of association have
not been amended since.

The appearing party representing the entire share capital declares having waived any notice requirement and may

validly deliberate on all the items of the following agenda:

<i>Agenda

1. Approval of the interim balance sheet dated 15 December 2014 as opening balance sheet of the liquidation.
2. Dissolution and liquidation of the Company.
3. Appointment of liquidators and determination of their powers.
4. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to approve the interim balance sheet dated 15 December 2014 as opening balance sheet

of the liquidation.

<i>Second resolution

In compliance with articles 141 to 151 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the

“Law”) the sole shareholder resolves to dissolve and liquidate the Company.

<i>Third Resolution

The sole shareholder resolves to appoint (i) Mr. Markus Summer, born in Feldkirch, Austria, on 9 April 1973, profes-

sionally residing at 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein as class A liquidator, (ii) Mr. Johannes Burger, born in
Bregenz, Austria, on 30 August 1960, professionally residing at 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein as class A
liquidator (each the “Class A Liquidator”) and (iii) AIM Services S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated
and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’
Register under number B 74 676, having its registered office at 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg, as class B liquidator (the “Class B Liquidator”).

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator have the broadest powers as provided for by articles 144

to 148bis of the Law.

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator are hereby expressly empowered to carry out all such

acts as provided for by article 145 of the Law without requesting further authorisations of the sole shareholder.

The liquidators are relieved from drawing-up inventory and may refer to the accounts of the Company.
The Company will be bound by the joint signature of any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator.
Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator may, under their responsibility, for special or specific

operations, delegate to one or more proxyholders such powers as they determine and for the period as they think fit.

Any Class A Liquidator together with the Class B Liquidator may distribute the Company’s assets to the sole share-

holder in cash and/or in kind in their sole discretion. Such distribution may take the form of advance payments on future
liquidation proceeds.

24346

L

U X E M B O U R G

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing party,

this deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing party and in case
of discrepancy between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L’an deux mille quatorze, le trentième jour du mois de décembre.
Par-devant nous, Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

Ipanema II LLC, une société à responsabilité limitée, constituée sous les lois de l’Etat du Delaware, ayant son siège

social au 1209, Orange Street, USA – 19801 Wilmington, Delaware, Etats Unis d’Amérique et immatriculée auprès du
Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 4721485,

ici représentée par Madame Antje Reibold, Rechstanwältin, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une

procuration donnée à New York, New York, le 19 décembre 2014.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au

présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d’enregistrement.

La comparante est l’associé unique de Colorado S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée,

ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152626, constituée selon acte notarié en
date du 15 avril 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1150 en date du 2 juin 2010. Les
statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

La comparante représentant l’intégralité du capital social déclare avoir renoncé à toute formalité de convocation et

peut valablement délibérer sur tous les points figurant à l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1. Approbation du bilan intérimaire en date du 15 décembre 2014 comme bilan d’ouverture de la liquidation.
2. Dissolution et liquidation de la Société.
3. Nomination de liquidateurs et détermination de leurs pouvoirs.
4. Divers.
Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l’ordre du jour, l’associé unique adopte les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’associé unique décide d’approuver le bilan intérimaire en date du 15 décembre 2014 comme bilan d’ouverture de la

liquidation.

<i>Deuxième résolution

Conformément aux articles 141 à 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que

modifiée (la «Loi») l’associé unique décide de dissoudre et de liquider la Société.

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de nommer (i) Monsieur Markus Summer, né à Feldkirch, Autriche, le 9 avril 1973, résidant

professionnellement au 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, comme liquidateur de classe A, (ii) Monsieur Johan-
nes Burger, né à Bregenz, Autriche, le 30 août 1960, résidant professionnellement au 6 Heiligkreuz, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein, comme liquidateur de classe A (chacun un «Liquidateur de Classe A») et (iii) AIM Services S.à r.l., une
société à responsabilité limitée, constituée et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 74676, ayant son siège social au 14, rue
Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, comme liquidateur de classe B (le «Liquidateur de Classe
B»).

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, disposent des pouvoirs les plus étendus

tels que prévus aux articles 144 à 148bis de la Loi.

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, sont par la présente expressément autorisés

à accomplir tous les actes visés à l’article 145 de la Loi sans devoir requérir des autorisations supplémentaires auprès de
l’associé unique.

Les liquidateurs sont dispensés de dresser un inventaire et peuvent se référer aux comptes de la Société.
La Société sera engagée par la signature conjointe d’un Liquidateur de Classe A ensemble avec le Liquidateur de Classe

B.

24347

L

U X E M B O U R G

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, pourront, sous leur responsabilité, pour

des opérations spéciales ou déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires une partie de leurs pouvoirs dont ils
fixeront l’étendue et la durée.

Chaque Liquidateur de Classe A, ensemble avec le Liquidateur de Classe B, pourront distribuer, à leur discrétion, les

actifs de la Société à l’associé unique en espèce et/ou en nature. Cette distribution pourra prendre la forme d’une avance
sur le boni de liquidation.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l’anglais, déclare qu’à la demande de la comparante, le présent acte est

rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu’à la demande de la même comparante et en cas de
divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence,

ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: A. REIBOLD, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 7 janvier 2015. Relation: EAC/2015/500. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015011153/124.
(150012683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Techno Services S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 155.722.

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "TECHNO SERVICES S.A.", a société anonyme having its

registered office at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, registered at the “Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg” under the number B155.722, incorporated by a deed of the undersigned notary dated
September 10 

th

 , 2010, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 2384 on November

th

 , 2010. Which Articles of Association have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74,

avenue Victor Hugo,

who appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at the same address.
The meeting elects as scrutineer Mr Gianpiero SADDI, prenamed.
The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed “ne varietur” by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the one thousand (1.000) shares are represented. The meeting

is therefore regularly constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which
the shareholders have been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1. Transfer of the Company's registered office to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange and subsequent amend-

ment of article 2 of the articles of association of the Company;

2. Miscellanous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolution:

<i>First resolution

The meeting decides to transfer the registered office of the Company from its current address 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, with immediate effect and subsequent
amendment of article 2 of the articles of incorporation, which should be read as follows:

Art. 2. Paragraph 1. The registered office of the Company is established in Bertrange."

24348

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting notes that the professional address of two directors Mr. Simon BAKER and Mrs Corinne NÉRÉ and the

registered office of the “Commissaire aux Comptes”, the company “CITADEL ADMINISTRATION S.A.” have changed
to 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente et un décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «TECHNO SERVICES S.A.», avec siège

social au 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 155.722, constituée suivant acte reçu par par le notaire instrumentaire en date du 24
septembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2384 du 6 novembre 2010, dont
les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnel-

lement à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo,

qui désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement à la même

adresse.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, prénommé.
Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il résulte de la liste de présence, que toutes les mille (1.000) actions sont représentés. La réunion est donc

régulièrement constituée et peut valablement délibérer et décider sur l'ordre du jour de la réunion citée ci-dessus, dont
les actionnaires ont été informés avant la réunion.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de la société au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, et modification subséquente

de l'article 2 des statuts;

2. Divers.
Ce fait exposé et reconnu exact par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris la résolution suivante:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle, à savoir 15-17, avenue Gaston

Diderich, L-1420 Luxembourg au 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, avec effet immédiat et de modifier l'article
2 des statuts qui se lira désormais comme suit:

« Art. 2. (premier alinéa). Le siège social est établi à Bertrange.».

<i>Deuxième résolution

L'assemblée constate que l'adresse professionnelle de deux administrateurs, Mr. Simon BAKER et Mme Corinne NÉRÉ

et le siège social du Commissaire aux Comptes, la société «CITADEL ADMINISTRATION S.A.», ont été transférée au
33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

24349

L

U X E M B O U R G

Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: G. Saddi, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 12 janvier 2015. Relation: 2LAC/2015/830. Reçu soixante-quinze euros Eur

75.-

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Référence de publication: 2015010261/101.
(150011370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Celistics Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 145.874.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, on thirty first of December,
before Maître Anja HOLTZ, public notary residing in Esch-sur-Alzette.

There appeared:

Celistics Holdings, S.L., a company incorporated and organized under the Laws of Spain, having its registered office at

2, Plaza de Colón, Torre I, Planta 15, E-28001 Madrid, Spain, duly represented by Mrs Monica NARDON, employee,
professionally residing in LUXEMBOURG, 11-13, boulevard de la Foire, by virtue of a power of attorney, given under
private seal (the ‘Sole Shareholder') on 30 

th

 of december in Madrid/Spain subsequently to a general power of attorney

given to Mr. Jesus Alberto De Marin Munoz before Jose Miguel Garcia Lombardia, public notary in Madrid, on the 12 

th

of December 2012.

Said proxy, after having been initialled and signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, will

remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party through its proxy holder has requested the notary to state that:
- it holds all the shares in the Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”) existing

under the name of Celistics Luxembourg S.à r.l., registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
the number B 145874, with registered office at 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (the ‘Company');

- the Company has been incorporated pursuant to a notarial deed dated April 2, 2009, published in the Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations, 979, of 11 May 2009;

- the Company's capital is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred Euros) represented by 1,000 (thousand)

shares with a par value of EUR 12,50 (twelve fifty Euros) each;

- the Sole Shareholder hereby resolved to proceed with the dissolution of the Company with effect from today;
- the Sole Shareholder assumes the role of liquidator of the Company;
- the Sole Shareholder as liquidator of the Company declares that the activity of the Company has ceased, that the

known liabilities of the Company have been settled or fully provided for, that the Sole Shareholder is vested with all the
assets and hereby expressly declares that it will take over and assume all outstanding liabilities (if any) of the Company,
in particular those hidden or any known but unpaid and any as yet unknown liabilities of the Company before any payment
to itself;

- the Sole Shareholder waives the requirement to appoint an auditor to the liquidation (commissaire à la liquidation)

and to hear a report of an auditor to the liquidation;

- consequently the Company is liquidated and the liquidation is closed;
- the Sole Shareholder has full knowledge of the articles of incorporation of the Company and perfectly knows the

financial situation of the Company;

- the Sole Shareholder grants full discharge to the managers of the Company for its mandate from the date of its

appointment up to the date of the present meeting; and

24350

L

U X E M B O U R G

- the books and records of the dissolved Company shall be kept for five (5) years from the date the date of the present

meeting at the registered office of the Company.

Whereof, the present deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version shall prevail.

The document having been read to the proxy holder of the person appearing, she signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le trente-et-un décembre.
par-devant Maître Anja HOLTZ, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Celistics Holdings, S.L., une société constituée et organisée selon le droit espagnol, domiciliée au 2, Plaza de Colón,

Torre I, Planta 15, E28001 Madrid, Spain, ici dûment représentée Madame Monica NARDON employée, demeurant
professionnellement à Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire, en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le
30 décembre sous seingprivé à Madrid/Espagne, subséquent à une procuration générale donnée à Monsieur Jesus Alberto
De Martin Munoz par devant Maître Jose Miguel Garcia Lombardia, notaire à Madrid, le 12 décembre 2012. (l''Associé
Unique').

Laquelle procuration après signature ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera annexée

au présent acte pour y être soumis ensemble aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:
- le comparant détient toutes les parts sociales de la société à responsabilité limitée existant sous la dénomination

Celistics Luxembourg S.à r.l., immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B
145874, avec siège social au 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg (la ‘Société');

- la Société a été constituée en vertu d'un acte notarié du 2 avril 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et

Associations, 979, du 11 mai 2009;

- le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500,- (douze mille cinq cent Euros) représenté par 1000 (mille) parts

sociales d'une valeur nominale de EUR 12,50- (douze euros cinquante) chacune;

- par la présente l`Associé Unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- l'Associé Unique assume le rôle de liquidateur de la Société;
- l'Associé Unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l'activité de la Société a cessé, que le passif

connu de la Société a été payé ou provisionné, qu'il est investi de tout l'actif et qu'il s'engage expressément à prendre à
sa charge tout passif pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et tout passif impayé ou inconnu à ce
jour avant tout paiement à sa personne;

- l'Associé Unique renonce à la formalité de la nomination d'un commissaire à la liquidation et à la préparation d'un

rapport du commissaire à la liquidation;

- partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée;
- le comparant a pleinement connaissance des statuts de la Société et de la situation financière de celle-ci;
- le comparant donne décharge pleine et entière au gérant de la Société pour leur mandat à compter de la date de sa

nomination jusqu'à la date de la présente assemblée; et

- les documents et pièces relatifs à la Société dissoute seront conservés durant cinq (5) ans à compter de la présente

assemblée au siège de la Société.

Dont acte, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais déclare qu'à la requête de la comparante, le présent acte a été

établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête de cette même partie comparante, et en cas de divergences
entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, celle-ci a signé avec nous notaire le présent acte.
Signé: M. Nardon, Anja Holtz.
Enregistré à Esch-sur-Alzette, le 31 décembre 2014 - EAC/2014/18578 - Reçu soixante-quinze euros = 75 €.-

<i>Le Receveur (signé): A. Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux parties pour servir à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 5 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011146/94.
(150013481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

24351

L

U X E M B O U R G

QSI Finance II (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 164.283.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Qanta Services Inc - Pwr
Société mère de QSI Finance II (Lux) S.à r.l.
TMF Corporates Services S.A. / D. A. Jensen
<i>Gérant A / Gérant B

Référence de publication: 2015012979/15.
(150014557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 janvier 2015.

CapLinden S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion

de Patrimoine Familial.

Siège social: L-8415 Steinfort, 20, rue Herrenfeld.

R.C.S. Luxembourg B 172.184.

L'an deux mil quatorze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Martine DECKER, notaire de résidence à Hesperange;

A comparu:

- Monsieur Markus GEGINAT, consultant en gestion de risque et en reporting réglementaire, demeurant à L-8415

Steinfort, 20, rue Herrenfeld.

Lequel comparant a déclaré être le seul Actionnaire de la société anonyme «CapLinden S.A., Société de Gestion de

Patrimoine Familial -SPF», ayant son siège social à L-8415 Steinfort, 20, rue Herrenfeld, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 172.184,

constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 16 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations, Numéro 2794 du 17 novembre 2012, et dont les statuts ont été modifiés une seule fois
suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 16 décembre 2013, publié audit Mémorial C, numéro 395, le
12 février 2014.

L'Actionnaire unique, représentant l'intégralité du capital social, s'est réuni en lieu et place de l'assemblée générale

extraordinaire des actionnaires, et a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Actionnaire unique décide de changer la forme juridique des titres représentatifs du capital social de la Société en

actions nominatives. Les titres au porteur existants seront annulés et remplacés par l'inscription des actions dans un
registre des actionnaires tenu au siège social de la Société.

<i>Deuxième résolution

Suite à ce qui précède, l'Actionnaire unique décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 6 afférent des statuts, comme suit:

« Art. 6. (alinéa 4). Les actions sont nominatives.»

Dont acte, fait et passé à Hesperange, en l'étude du notaire instrumentant, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel,

état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. Geginat, M. Decker.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. Relation: LAC/2014/63466. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR EXPÉDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Hesperange, le 16 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011144/38.
(150012747) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

24352

L

U X E M B O U R G

Callaway Invest S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 56.242.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le trente décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

"The AMS Foundation", société de droit panaméen avec siège social à P.H. Edificio Mossfon, Segundo Piso, Calle 54

Este, Ciadad de Panama (République de Panama),

ici représentée par Monsieur Max MAYER employé, demeurant professionnellement à Junglinster, 3, route de Lu-

xembourg, en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le
mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être formalisée avec lui.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter comme suit

leurs déclarations:

I.- Que la société anonyme société de gestion de patrimoine familial "Callaway Invest S.A.", ayant son siège social à

L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section
B, numéro 56242, constituée suivant acte reçu par Maître Edmond Schroeder, notaire de résidence à Mersch, en date
du 10 septembre 1996, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 613 du 27 novembre 1996.
Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à
Bascharage, en date du 14 septembre 2010 publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 2390 du
08 novembre 2010.

II.- Que le capital social de la société s'élève actuellement à deux cent quarante-sept mille huit cent quatre-vingt-treize

euros et cinquante-deux cents (247'893,52- EUR), représenté par mille (1'000) actions sans désignation de valeur nomi-
nale.

III.- Que la comparante est devenue propriétaire de toutes les actions de la susdite société «Callaway Invest S.A.».
IV.- Que l’activité de la société «Callaway Invest S.A.» a cessé et que la comparante, en tant que seule et unique associée

de la Société (l’"Associé unique") prononce la dissolution anticipée de la Société et sa mise en liquidation.

V. Que l’Associée unique déclare avoir pleine connaissance des statuts de la Société et qu'elle connaît parfaitement la

situation financière de la Société.

VI. Que l’Associée unique, en sa qualité de liquidateur de la Société, déclare que l’activité de la Société a cessé et que

le passif connu de la Société a été payé ou provisionné.

VII. Que l’Associée unique est investie de tout l’actif et qu'elle s'engage expressément à prendre à sa charge tout passif

pouvant éventuellement encore exister à charge de la Société et impayé ou inconnu à ce jour au prorata de sa participation
dans la Société

VIII. Que, partant, la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée.
IX.- Que décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la société

pour l’exécution de leurs mandats jusqu'à ce jour.

X.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans à l’ancien siège social à

L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires résultant du présent acte, évalués à 1.200,-EUR euros, sont à charge de la société dissoute.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 07 janvier 2015. Relation GAC/2015/194. Reçu soixante-quinze euros 75,00

€.

<i>Le Receveur (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2015011157/52.
(150012897) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

24353

L

U X E M B O U R G

Global Fashion Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Seningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 190.907.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth day of December.
Before us, Maître Carlo WERSANDT, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Global Fashion Holding S.A. (hereinafter the “Company”), a

société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 190907, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736
Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing
in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations on 11 November 2014 N° 3333. The articles of association were not amended since.

The meeting opened at 06:30 p.m. with Mr. Alexander Olliges, Rechtsanwalt, in the chair.
The chairman designated Ms. Elena Medagli, Rechtsanwältin, as secretary.
The meeting elects Mr. Luis A. Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, as scrutineer.
The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary

to record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their

shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented
shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the
same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled ne varietur by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to

be filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented and all the shareholders present

or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and thus waive
any convening formalities.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda:
IV. The agenda of the present meeting is the following:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital of the Company by an amount of forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand

nine hundred ninety-eight euro (EUR 49,999,998) so as to raise it from its current amount of thirty-one thousand euro
(EUR 31,000) up to fifty million thirty thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR 50,030,998) through the issue of
forty-nine  million  nine  hundred  ninety-nine  thousand  nine  hundred  ninety-eight  (49,999,998)  common  shares  with  a
nominal value of one euro (EUR 1) each, for a price of two billion fifty-five million nine hundred ninety-nine thousand
nine hundred eighteen euro (EUR 2,055,999,918), paid up by a contribution in kind consisting of all shares of Bigfoot
GmbH.

2. Acknowledgement of the special report of the board of directors with respect to the creation of an authorised

capital and decision to create an authorised capital which shall, excluding the share capital, be set at six million five hundred
eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653) represented by six million five hundred eighty-six thou-
sand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares of the Company, with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

3. Amendment and full restatement of the articles of association.
4. Acceptance of the resignation of Mr. Ulrich Binninger, Mr. Christian Senitz and Mr. Alexander Kudlich as directors

of the Company and granting of full discharge for the exercise of their mandate.

5. Appointment of Mrs. Maggie Fanari, Mr. Daniel Grossman, Mr. Scott Collins, Mr. Christian Winter, Mr. Daniel Shinar,

Mr. Peter Kimpel, Mr. Lorenzo Grabau, Mr. Alexis Babeau, Mr. Christoph Barchewitz, Mr. Jens Grede and Mr. Oliver
Samwer as additional directors of the Company.

6. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders after deliberation unanimously

took, and required the notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the Company’s share capital by an amount of forty-nine million

nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR 49,999,998) so as to raise it from its current
amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) up to fifty million thirty thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR
50,030,998)  through  the  issue  of  forty-nine  million  nine  hundred  ninety-nine  thousand  nine  hundred  ninety-eight
(49,999,998) common shares having a nominal value of one euro (EUR 1) each.

24354

L

U X E M B O U R G

The forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-eight (49,999,998) new common shares

issued were subscribed as follows:

1. Twelve million five hundred ninety-eight thousand seventy-eight (12,598,078) common shares have been subscribed

by Kinnevik New Ventures AB, a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden, registered with
the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under number 556736-2412, with registered address in Skeppsbron 18,
10313 Stockholm, Sweden, for the price of five hundred eighteen million nine hundred sixty-two thousand seven hundred
forty-one euro (EUR 518,962,741). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of twenty-four thousand three hundred eighty-three (24,383) shares of Bigfoot GmbH, a German Gesellschaft mit bes-
chränkter Haftung, having its registered office at Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Germany and registered with register
of the local court of Charlottenburg, Germany, under number HRB 127304 B (“Bigfoot”);

2. Fifteen million three hundred sixty-two thousand seven hundred ninetyseven (15,362,797) common shares have

been subscribed by Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft)
existing under the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Ger-
many, under no. HRB 159634 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, for the price
of six hundred thirty-one million three hundred thirty-six thousand three hundred nine euro (EUR 631,336,309). The
subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of twenty-nine six hundred sixty-one
(29,661) shares of Bigfoot;

3. One million six hundred ninety thousand fifty-eight (1,690,058) common shares have been subscribed by GeRo

Fashion Commerce UG (haftungsbeschränkt), a business enterprise company (Unternehmergesellschaft) existing under
the laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany, under
number HRB 129735 B, with registered address in Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Germany, for the price of sixty-
nine million four hundred fifty-three thousand one hundred seventy-two euro (EUR 69,453,172). The subscription price
has been fully paid up through a contribution in kind consisting of three thousand two hundred sixty-three (3,263) shares
of Bigfoot;

4. Two million six hundred sixteen thousand one hundred forty-five (2,616,145) common shares have been subscribed

by  TEV  Global  Invest  II  GmbH,  a  limited  liability  company  existing  under  the  laws  of  Germany,  registered  with  the
commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24967, with registered address in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, for the price of one hundred seven million five hundred ten
thousand eight hundred forty-eight euro (EUR 107,510,848). The subscription price has been fully paid up through a
contribution in kind consisting of five thousand fifty-one (5,051) shares of Bigfoot;

5. Two million six hundred twenty-five thousand nine hundred eighty-six (2,625,986) common shares have been sub-

scribed by Summit Partners RKT S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under number B 169548, having its registered office in 5, rue de Plébiscite, L-2341 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, for the price of one hundred seven million nine hundred fifteen thousand two hundred
sixty-five euro (EUR 107,915,265). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of five thousand seventy (5,070) shares of Bigfoot;

6. One hundred fifty-six thousand four hundred twenty (156,420) common shares have been subscribed by Karrick

Limited, a limited company existing under the laws of Guernsey, registered with the Guernsey Registry under number
41823, with registered address in Park Place, Park Street, St. Peter Port, Guernsey, GY 1 1EE, Guernsey, for the price
of six million four hundred twenty-eight thousand one hundred two euro (EUR 6,428,102). The subscription price has
been fully paid up through a contribution in kind consisting of three hundred two (302) shares of Bigfoot;

7. One million four hundred twenty-two thousand seven hundred ninetyeight (1,422,798) common shares have been

subscribed by Saturn 2 S.à r.l., a limited liability company (societé à responsabilité limitée) existing under the laws of the
Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 180356, having its registered office in 47, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg, for the price of fifty-eight million four hundred seventy thousand eighty-four euro (EUR
58,470,084). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of two thousand seven
hundred forty-seven (2,747) shares of Bigfoot;

8. Five hundred eighty-one thousand one hundred thirty-five (581,135) common shares have been subscribed by Pe-

troenergy Limited, a limited company existing under the laws of the Republic of Cyprus, registered with the Department
of Registrar of Companies and official Receiver under number HE 232838, with registered address in 2 Louki Akrita str,
Lakatemeia, 2333, Nicosia, Cyprus, for the price of twenty-three million eight hundred eighty-one thousand eight hundred
twenty-five euro (EUR 23,881,825). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of one thousand one hundred twenty-two (1,122) shares of Bigfoot;

9. Three hundred twenty-five thousand seven hundred eighty-eight (325,788) common shares have been subscribed

by  JaToPa  GmbH,  a  limited  liability  company  existing  under  the  laws  of  Germany  with  its  statutory  seat  in  Munich,
Germany, registered with the commercial register of the local court of Munich, Germany, under number HRB 198609,
with registered address in Maximilianstraße 21, 80539 Munich, Germany, for the price of thirteen million three hundred

24355

L

U X E M B O U R G

eighty-eight thousand three hundred four euro (EUR 13,388,304). The subscription price has been fully paid up through
a contribution in kind consisting of six hundred twenty-nine (629) shares of Bigfoot;

10. Three hundred twelve thousand eight hundred forty (312,840) common shares have been subscribed by Kering

Netherlands B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) existing under the laws of the Netherlands, with
its registered office in Amsterdam, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register,
under number 33168497, with registered address in Amstelplein 1, Rembrandttoren, 1096HA Amsterdam, the Nether-
lands, for the price of twelve million eight hundred fifty-six thousand two hundred four euro (EUR 12,856,204). The
subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of six hundred four (604) shares of
Bigfoot;

11. Two hundred ninety thousand five hundred sixty-eight (290,568) common shares have been subscribed by Ver-

linvest S.A., a stock corporation existing under the laws of Belgium, registered with the Registrar of Legal Entities in
Brussels under number 0455.030.364 with registered address in Place Flagey 18, 1050 Brussels, Belgium, for the price of
eleven million nine hundred forty thousand nine hundred thirty-three euro (EUR 11,940,933). The subscription price has
been fully paid up through a contribution in kind consisting of five hundred sixty-one (561) shares of Bigfoot;

12. Five hundred sixty-one thousand nine hundred seventy-one (561,971) common shares have been subscribed by

Aismare Limited, a limited company incorporated in England and Wales, registered with the Companies House of the
United Kingdom under number 07634146, with registered address in 34A Station Road, Cuffley, Potters Bar, EN6 4HE,
United  Kingdom,  for  the  price  of  twenty-three  million  ninety-four  thousand  two  hundred  seventy-seven  euro  (EUR
23,094,277). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one thousand eighty-
five (1,085) shares of Bigfoot;

13. Two hundred fifty thousand six hundred eighty-six (250,686) common shares have been subscribed by BNY Mellon

Trust Company (Ireland) Limited, a limited company existing under the laws of Ireland, registered with the Companies
Registration Office Ireland under number 223184, in its capacity as trustee of Eureka Fund, a sub-trust of Marshall Wace
Investment Strategies, with registered address in Guild House, Guild Street, IFSC, Dublin 1, Ireland, for the price of ten
million three hundred one thousand nine hundred seventy-seven euro (EUR 10,301,977). The subscription price has been
fully paid up through a contribution in kind consisting of four hundred eighty-four (484) shares of Bigfoot;

14. One million one hundred twenty-four thousand nine hundred seventy-nine (1,124,979) common shares have been

subscribed by E-commerce Holdings LP, a limited partnership existing under the laws of the Cayman Islands with regis-
tered address in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, for the price of forty-six
million two hundred thirty-one thousand one hundred seventy-one euro (EUR 46,231,171). The subscription price has
been fully paid up through a contribution in kind consisting of two thousand one hundred seventy-two (2,172) shares of
Bigfoot;

15. Eight hundred seventy-four thousand eight hundred eleven (874,811) common shares have been subscribed by

Tetral S.A., a stock corporation (société anonyme) existing under the laws of Switzerland, with its statutory seat in Pully,
Switzerland,  registered  with  the  Federal  Commercial  Registry  office  (at  the  Canton  of  Vaud)  under  number
CH-550.1.000.845-3 with registered address in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Switzerland, for the price of thirty-
five million nine hundred fifty thousand four hundred eighty-one euro (EUR 35,950,481). The subscription price has been
fully paid up through a contribution in kind consisting of one thousand six hundred eighty-nine (1,689) shares of Bigfoot;

16. One hundred fifty-six thousand four hundred twenty (156,420) common shares have been subscribed by Verwal-

tung Tiefgarage Rotherbaum GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the
commercial register of the local court of Hamburg, Germany, under number HRB 59587 with registered address in
Stubbenhuk 7, 20459 Hamburg, Germany, for the price of six million four hundred twenty-eight thousand one hundred
two euro (EUR 6,428,102). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of three
hundred two (302) shares of Bigfoot;

17. One hundred fifty-six thousand four hundred twenty (156,420) common shares have been subscribed by Financial

Mathematics S.A., a stock corporation (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
registered with the Luxembourg Companies’ and Trade Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B 114827, having its registered office 6, Rue Adolphe, L - 1116, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for the price
of six million four hundred twenty-eight thousand one hundred two euro (EUR 6,428,102). The subscription price has
been fully paid up through a contribution in kind consisting of three hundred two (302) shares of Bigfoot;

18. Three hundred thirty-seven thousand seven hundred one (337,701) common shares have been subscribed by E-

Fashion  S.à  r.l.,  a  limited  liability  company  (societé  à  responsabilité  limitée)  existing  under  the  laws  of  Luxembourg,
registered with the Luxembourg Trade and Companies’Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number
B 177487 having its registered office in 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for the price
of thirteen million eight hundred seventy-seven thousand eight hundred seventy euro (EUR 13,877,870). The subscription
price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of six hundred fifty-two (652) shares of Bigfoot;

19. One hundred eighty-seven thousand four hundred ninety-six (187,496) common shares have been subscribed by

Kaltroco Limited, a limited company existing under the laws of Jersey, registered with the JFSC Companies Registry under
number 60595 with registered address in Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, Jersey, for the

24356

L

U X E M B O U R G

price of seven million seven hundred five thousand one hundred seventy-five euro (EUR 7,705,175). The subscription
price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of three hundred sixty-two (362) shares of Bigfoot;

20. Four hundred twenty-four thousand seven hundred sixteen (424,716) common shares have been subscribed by

LTG International Limited, a private limited company existing under the laws of England and Wales, registered with the
Companies House of the United Kingdom under number 02882173, with seat in Chelsea House, West Gate, London
W5 1DR, United Kingdom, for the price of seventeen million four hundred fifty-three thousand seven hundred sixty-four
euro (EUR 17,453,764). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of eight
hundred twenty (820) shares of Bigfoot;

21. Three hundred sixty-eight thousand seven hundred seventy-eight (368,778) common shares have been subscribed

by Santerna Holdings Limited, a limited company existing under the laws of the Republic of Cyprus, registered with the
Department of Registrar of Companies and official Receiver under number 279671, with registered address in 1 Katalanou
Street, 1 

st

 floor, office/flat 101, 2121 Aglantzia, Nicosia, Cyprus, for the price of fifteen million one hundred fiftyfour

thousand  nine  hundred  eighty-four  euro  (EUR  15,154,984).  The  subscription  price  has  been  fully  paid  up  through  a
contribution in kind consisting of seven hundred twelve (712) shares of Bigfoot;

22. One hundred fifty-six thousand four hundred twenty (156,420) common shares have been subscribed by Fidelity

Funds  SICAV  in  respect  of  Fidelity  Funds  European  Smaller  Companies  Pool  (F/ESM),  registered  in  the  Commercial
Register of Companies in Luxembourg under number B 34036, with registered address in 2a, Rue Albert Borschette,
L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for the price of six million four hundred twenty-eight thousand one
hundred two euro (EUR 6,428,102). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of three hundred two (302) shares of Bigfoot;

23. Fifty-four thousand three hundred eighty-five (54,385) common shares have been subscribed by Bwide Net UG

(haftungsbeschränkt) &amp; Co. KG, a limited partnership existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin,
Germany, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany, under number HRA
45900 B, with registered address in Eichenstr. 19, 12623 Berlin, Germany, for the price of two million two hundred thirty-
four thousand nine hundred fifty-nine euro (EUR 2,234,959). The subscription price has been fully paid up through a
contribution in kind consisting of one hundred five (105) shares of Bigfoot;

24. Four hundred ten thousand seven hundred thirty-two (410,732) common shares have been subscribed by Putnam

Funds Trust, on behalf of its series Putnam Capital Spectrum Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of sixteen million eight hundred seventy-nine thousand
eighty-nine euro (EUR 16,879,089). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of seven hundred ninety-three (793) shares of Bigfoot;

25. One hundred seventy-eight thousand six hundred ninety-two (178,692) common shares have been subscribed by

Putnam Funds Trust, on behalf of its series Putnam Equity Spectrum Fund, a Massachusetts Business Trust with registered
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of seven million three hundred forty-three
thousand three hundred seventy-three euro (EUR 7,343,373). The subscription price has been fully paid up through a
contribution in kind consisting of three hundred forty-five (345) shares of Bigfoot;

26. Two hundred eighteen thousand five hundred seventy-three (218,573) common shares have been subscribed by

Putnam Voyager Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA
02109,  USA,  for  the  price  of  eight  million  nine  hundred  eighty-two  thousand  two  hundred  eighty-eight  euro  (EUR
8,982,288). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of four hundred twenty-
two (422) shares of Bigfoot;

27. Forty-nine thousand two hundred four (49,204) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust,

on behalf of its series Putnam VT Voyager Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post
Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of two million twenty-two thousand forty-five euro (EUR 2,022,045).
The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of ninety-five (95) shares of Bigfoot;

28. Sixty thousand six hundred (60,600) common shares have been subscribed by The Putnam Fund for Growth and

Income, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for
the price of two million four hundred ninety thousand three hundred sixty-six euro (EUR 2,490,366). The subscription
price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one hundred seventeen (117) shares of Bigfoot;

29. Fifteen thousand twenty (15,020) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust, on behalf of its

series Putnam VT Growth and Income Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of six hundred seventeen thousand two hundred forty-nine euro (EUR
617,249). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of twenty-nine (29) shares
of Bigfoot;

30. Eighty-two thousand three hundred fifty-three (82,353) common shares have been subscribed by Putnam Multi-

Cap Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA, for the price of three million three hundred eighty-four thousand three hundred eight euro (EUR 3,384,308). The
subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one hundred fifty-nine (159) shares
of Bigfoot;

24357

L

U X E M B O U R G

31. Sixteen thousand five hundred seventy-four (16,574) common shares have been subscribed by Putnam Variable

Trust, on behalf of its series Putnam VT Multi-Cap Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of six hundred eighty-one thousand one hundred eleven
euro (EUR 681,111). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of thirty-two
(32) shares of Bigfoot;

32. Nine thousand three hundred twenty-three (9,323) common shares have been subscribed by Putnam Investment

Funds, on behalf of its series Putnam Growth Opportunities Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of three hundred eighty-three thousand one hundred
thirty euro (EUR 383,130). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of
eighteen (18) shares of Bigfoot;

33. Five thousand one hundred seventy-nine (5,179) common shares have been subscribed by IG Putnam U.S. Growth

Fund, a mutual fund trust incorporated in Canada with business address at One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA (formerly: c/o I.G. Investment Management Ltd., 447 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3C 3B6, Canada), for
the price of two hundred twelve thousand eight hundred thirty-two euro (EUR 212,832). The subscription price has been
fully paid up through a contribution in kind consisting of ten (10) shares of Bigfoot;

34. One thousand thirty-six (1,036) common shares have been subscribed by Putnam World Trust.. Putnam U.S. Large

Cap Growth Fund, an Irish UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) with business
address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA (formerly: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland), afore-
mentioned, for the price of forty-two thousand five hundred seventy-five euro (EUR 42,575). The subscription price has
been fully paid up through a contribution in kind consisting of two (2) shares of Bigfoot;

35. Thirty-six thousand two hundred fifty-six (36,256) common shares have been subscribed by Putnam Investors Fund,

a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price
of one million four hundred eighty-nine thousand nine hundred forty-five euro (EUR 1,489,945). The subscription price
has been fully paid up through a contribution in kind consisting of seventy (70) shares of Bigfoot;

36. Five thousand one hundred seventy-nine (5,179) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust,

on behalf of its series Putnam VT Investors Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post
Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of two hundred twelve thousand eight hundred thirty-two euro
(EUR 212,832). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of ten (10) shares
of Bigfoot;

37. One thousand thirty-six (1,036) common shares have been subscribed by Putnam Funds Trust, on behalf of its

series Putnam Multi Cap Core Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA, for the price of forty-two thousand five hundred seventy-five euro (EUR 42,575). The sub-
scription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of two (2) shares of Bigfoot;

38. Twenty-three thousand eight hundred twenty-six (23,826) common shares have been subscribed by Putnam In-

ternational Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA, for the price of nine hundred seventy-nine thousand one hundred thirty-three euro (EUR 979,133). The
subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of forty-six (46) shares of Bigfoot;

39. Two thousand five hundred ninety (2,590) common shares have been subscribed by International Equity Class

(Putnam), a corporation incorporated in Canada with business address at One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA (formerly c/o Mackenzie Financial Corporation, 180 Queen Street West, Toronto, Ontario M5V 3K1, Canada), for
the price of one hundred six thousand four hundred thirty-six euro (EUR 106,436). The subscription price has been fully
paid up through a contribution in kind consisting of five (5) shares of Bigfoot;

40. Nine thousand three hundred twenty-three (9,323) common shares have been subscribed by Putnam Variable

Trust, on behalf of its series Putnam VT International Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of three hundred eighty-three thousand one hundred
thirty euro (EUR 383,130). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of
eighteen (18) shares of Bigfoot;

41. Twenty thousand two hundred (20,200) common shares have been subscribed by Putnam Global Equity Fund, a

Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price
of eight hundred thirty thousand one hundred twenty-two euro (EUR 830,122). The subscription price has been fully paid
up through a contribution in kind consisting of thirty-nine (39) shares of Bigfoot;

42. Five thousand one hundred seventy-nine (5,179) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust,

on behalf of its series Putnam VT Global Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of two hundred twelve thousand eight hundred thirty-two
euro (EUR 212,832). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of ten (10)
shares of Bigfoot;

43. Eight thousand two hundred eighty-seven (8,287) common shares have been subscribed by Putnam Investment

Funds, on behalf of its series Putnam International Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address
at One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of three hundred forty thousand five hundred fifty-five

24358

L

U X E M B O U R G

euro (EUR 340,555). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of sixteen
(16) shares of Bigfoot;

44. One thousand five hundred fifty-four (1,554) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust, on

behalf of its series Putnam VT International Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One
Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of sixty-three thousand eight hundred sixty-two euro (EUR
63,862). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of three (3) shares of
Bigfoot;

45. One thousand thirty-six (1,036) common shares have been subscribed by Putnam Asset Allocation Funds, on behalf

of its series Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at
One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, of forty-two thousand five hundred seventy-five euro (EUR 42,575).
The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of two (2) shares of Bigfoot;

46. Two thousand seventy-two (2,072) common shares have been subscribed by Putnam Funds Trust, on behalf of its

series Putnam Emerging Markets Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA, of eighty-five thousand one hundred forty-nine euro (EUR 85,149). The subscription
price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of four (4) shares of Bigfoot;

47. Three thousand six hundred twenty-five (3,625) common shares have been subscribed by Putnam International

Growth Equity Trust, a Massachusetts investment funds trust with registered address at One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, of one hundred forty-eight thousand nine hundred seventy euro (EUR 148,970). The subscription price
has been fully paid up through a contribution in kind consisting of seven (7) shares of Bigfoot;

48. Four million two hundred fifty-eight thousand thirty-five (4,258,035) common shares have been subscribed by

Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag) existing under the laws of Sweden, with its statutory seat in
Stockholm, Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket), under number 556815-4958 with
registered address in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden, for the price of one hundred seventy-four million nine
hundred eighty-four thousand five hundred forty-nine euro (EUR 174,984,549). The subscription price has been fully paid
up through a contribution in kind consisting of eight thousand two hundred twenty-one (8,221) shares of Bigfoot;

49. Two hundred seven thousand one hundred seventy-eight (207,178) common shares have been subscribed by

Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))
incorporated  and existing under  the laws  of  Germany  registered with the commercial  register  at the  local court of
Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, with registered address in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,
for the price of eight million five hundred fourteen thousand nine euro (EUR 8,514,009). The subscription price has been
fully paid up through a contribution in kind consisting of four hundred (400) shares of Bigfoot;

50. Four hundred forty-six thousand four hundred seventy (446,470) common shares have been subscribed by TEC

Global Invest I GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, Germany, registered with the
commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24965 with registered address in
Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, for the price of eighteen million three hundred forty-seven
thousand seven hundred forty-eight euro (EUR 18,347,748). The subscription price has been fully paid up through a
contribution in kind consisting of eight hundred sixty-two (862) shares of Bigfoot;

51. Fifty-five thousand nine hundred thirty-nine (55,939) common shares have been subscribed by Dritte PMB Mana-

gement GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the commercial register
of the local court of Hamburg, Germany, under number HRB 112289 with registered address in Neuer Jungfernstieg 5,
20354 Hamburg, Germany, for the price of two million two hundred ninety-eight thousand eight hundred twenty-one
euro (EUR 2,298,821). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one
hundred eight (108) shares of Bigfoot;

52. One million one hundred ninety-four thousand nine hundred one (1,194,901) common shares have been subscribed

by AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Com-
merce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420
Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, for the price of forty-nine million one hundred four thousand six hundred
twenty-five euro (EUR 49,104,625). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting
of two thousand three hundred seven (2,307) shares of Bigfoot;

53. Twenty-five thousand eight hundred ninety-seven (25,897) common shares have been subscribed by TEC Global

Invest II GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the commercial 17 register
of the local court of Duisburg, Germany, under no. HRB 24964 with registered address in Wissollstraße 5-43, 45478
Mülheim an der Ruhr, Germany, for the price of one million sixty-four thousand two hundred forty-one euro (EUR
1,064,241). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of fifty (50) shares of
Bigfoot;

54. Five thousand one hundred seventy-nine (5,179) common shares have been subscribed by Mercura Capital GmbH

(formerly Schuler-Beteiligungen GmbH), a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under
the laws of Germany, registered with the commercial register at the local court of Munich, Germany, under no. HRB
200948, having its business address at Schließstättstraße 22, 82319 Starnberg, Germany, for the price of two hundred

24359

L

U X E M B O U R G

twelve thousand eight hundred thirty-two euro (EUR 212,832). The subscription price has been fully paid up through a
contribution in kind consisting of ten (10) shares of Bigfoot;

55. Five hundred eighteen (518) common shares have been subscribed by Putnam Variable Trust, on behalf of its series

Putnam VT Growth Opportunities Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA, of twenty-one thousand two hundred eighty-seven euro (EUR 21,287). The subscription
price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one (1) share of Bigfoot;

56. Five hundred eighteen (518) common shares have been subscribed by Putnam Funds Trust, on behalf of its series

Putnam Asia Pacific Equity Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA, of twenty-one thousand two hundred eighty-seven euro (EUR 21,287). The subscription price
has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one (1) share of Bigfoot; and

57. Five hundred eighteen (518) common shares have been subscribed by Putnam Asset Allocation Funds, on behalf

of its series Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund, a Massachusetts Business Trust with registered address at
One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, for the price of twenty-one thousand two hundred eighty-seven euro
(EUR 21,287). The subscription price has been fully paid up through a contribution in kind consisting of one (1) share of
Bigfoot.

The total value of the contributions listed 1 to 57 above amounts to two billion fifty-five million nine hundred ninety-

nine  thousand  nine  hundred  eighteen  euro  (EUR  2,055,999,918),  which  the  shareholders  and  subscribers  expressly
approve and has been confirmed in a report from Ernst &amp; Young S.A., a société anonyme, incorporated and existing under
the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 47771,
in accordance with articles 26-1 and 32-1 of the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended.
The conclusion of the report was the following:

“Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that

the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 49,999,998 shares
with a nominal value of EUR 1 each to be issued with total related share premium of EUR 2,005,999,920, hence total
consideration amounting to EUR 2,055,999,918.”

The report, having been initialled by the notary and the proxyholder of the appearing parties, will remain attached to

this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The total contribution in the amount of two billion fifty-five million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred

eighteen euro (EUR 2,055,999,918) consists of forty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-
eight euro (EUR 49,999,998) for the share capital and two billion five million nine hundred ninety-nine thousand nine
hundred twenty euro (EUR 2,005,999,920) for the share premium.

Then, the parties listed 2 to 57 above, join the extraordinary general meeting of the shareholders and resolve together

with the parties listed under 1 above, on the subsequent items of the agenda. The proxies of all subscribing parties, intialled
“ne varietur” by the proxy holders of the appearing parties and the notary will remain annexed to the present deed to
be filed at the same time with the registration authorities.

<i>Second resolution

After due consideration of the special report by the board of directors of the Company on the creation of the au-

thorised capital, which the general meeting of shareholders approves, the general meeting of shareholders resolves to
create an authorised capital which shall, excluding the share capital, be set at six million five hundred eighty-six thousand
six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653) represented by six million five hundred eighty-six thousand six hundred
fifty-three (6,586,653) common shares:

During a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders’ resolution creating the authorised

capital in the Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations, or, as the case may be, of the resolution to renew or to
increase the authorised capital pursuant to the Company’s articles of association, the board of directors is hereby au-
thorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments
convertible into common shares for the purpose of delivery of shares upon exercise or conversion, as applicable, of the
Company's stock options or other equity-based awards granted under any management incentive plan of the Company
or issues of common shares to certain managers or other employees of the group of companies of which the Company
is the parent company, within the limit of the authorized capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and
specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders.

Such authorisation may be renewed through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the

manner required for an amendment to the articles of association of the Company, each time for a period not exceeding
five (5) years.

The authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of sha-

reholders adopted in the manner required for the amendment of the Company’s articles of association.

24360

L

U X E M B O U R G

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the Company’s articles of association which

shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Global Fashion

Holding S.A. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription in any other manner as well as
the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or

of any entity in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same group
of entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist any such entity in any other manner.

2.3 The Company may further provide any and all financial management services, including, but not limited to treasury

management services, currencies management services, interest rate and foreign exchange risk management to any entity
in which it holds a direct or indirect controlling interest.

2.4 The Company may raise funds, especially through borrowing in any form, and may issue any kind of notes, securities

or debt instruments, bonds and debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of any
type.

2.5 A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, registration or in any other manner as well

as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.6 The Company shall not act as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative

Investment  Fund  Managers  and  shall  not  carry  out  any  other  activity  which  would  be  subject  to  supervision  by  the
Commission de Surveillance du Secteur Financier.

2.7 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, technical, intellectual property or

other activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.
4.1 The Company's registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's

registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors. It may be
transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting
of shareholders.

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution

of the board of directors.

B. Share capital - Common shares - Register of common shares - Ownership and transfer of common

shares

Art. 5. Share capital.
5.1 The Company has an issued share capital of fifty million thirty thousand nine hundred ninety-eight euro (EUR

50,030,998), represented by fifty million thirty thousand nine hundred ninety-eight 50,030,998) common shares with a
nominal value of one Euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association in accordance with the Law or as set
out in article 6 hereof.

5.3 Subject to article 6.2 of these articles of association, any new common shares to be paid for in cash will be offered

by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of common shares held by them in the Com-
pany's issued share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential
subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of the opening of
the subscription as published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, Mémorial C, Recueil des Sociétés

24361

L

U X E M B O U R G

et Associations (the "Mémorial") and two (2) Luxembourg newspapers in accordance with the Law or, in case all the
common shares are in registered form, from the date of notification of the shareholders by registered letter. However,
subject to the provisions of the Law, the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the
Company's issued share capital or (ii) on the occasion of an authorization granted to the board of directors to increase
the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder
(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment
to these articles of association.

Art. 6. Authorized Capital.
6.1 The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at six million five hundred eighty-six

thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of six million five hundred eighty-six thousand six
hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

6.2 The board of directors is hereby authorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common

shares and to issue any other instruments convertible into common shares for the purpose of delivery of shares upon
exercise or conversion, as applicable, of the Company's stock options or other equity-based awards granted under any
management incentive plan of the Company or issues of common shares to certain managers or other employees of the
group of companies of which the Company is the parent company, within the limit of the authorized capital, to such
persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential
subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of
the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the Mémorial. This authorization may be renewed once
or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment
of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.3 The authorized capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of

shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 7. Common Shares.
7.1 The Company's share capital is divided into common shares, each of them having the same nominal value. The

common shares of the Company are in registered form. No fractional common shares shall be issued.

7.2 The common shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law and these articles of association.

The Company may repurchase its common shares and hold them in treasury subject to the conditions of the Law.

7.3 The Company will recognize only one holder per common share. In case a common share is owned by several

persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has
the right to suspend the exercise of all rights attached to that common share until such representative has been appointed.

7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

7.5 A register of common shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for

inspection by any shareholder.

This register shall contain all the information required by the Law and ownership of shares is established by registration

in said share register, without prejudice to the conditions for transfer by book-entries provided for in article 7.6 of these
articles of association. Certificates of such registration shall be issued by the Company upon request and at the expense
of the relevant shareholder and, in the situation described by article 7.6 of these articles of association, to the Depositary
(as defined below). All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made
to the latest address communicated by the shareholder to the Company. The board of directors may decide that no entry
shall be made in the share register and no notice of a transfer shall be recognized by the Company during the period
starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of the relevant general meeting.

7.6 Where common shares are in registered form and are recorded in the Company's register of common shares in

the name of or on behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry
interests in the accounts of a financial institution or a professional depositary or sub-depositary (any such institution,
depositary and sub-depositary being referred to hereinafter as a "Depositary"), the Company, subject to having received
from the Depositary a proper certification of such record position, will permit the Depositary of such book-entry interests
to exercise the rights attached to the common shares corresponding to the book-entry interests of the relevant share-
holder, including receiving notices of general meetings, admission to and voting at general meetings (the "Certificates").
The board of directors may determine formal requirements with which such Certificates must comply.

C. General meeting of shareholders

Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general

meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the
entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly
reserved to it by the Law and by these articles of association.

24362

L

U X E M B O U R G

Art. 9. Convening general meetings of shareholders.
9.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company

or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Thursday
of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be
held on the next following business day. Other general meeting of shareholders of the Company may at any time be
convened by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meetings.

9.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance with the provisions of the Law and these articles

of association and in the event the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance
with the publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. If all shareholders are present
or represented, the meeting may be held without prior notice or publication.

9.3 In the event the common shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders

recorded in the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted
to the general meeting of shareholders. If the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange,
the board of directors may determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date
for admission to the general meeting of shareholders (the "Record Date"). In such case, any shareholder who wishes to
attend the general meeting must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be
determined by the board of directors in the convening notice. In case of common shares held through a Depositary, a
shareholder wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such Depositary one or more
Certificates regarding the number of common shares recorded in his name on the Record Date. No entry shall be made
in the share register and no notice of transfer shall be recognized by the Company or a registrar acting for the Company
in the period between the Record Date and the date of a general meeting ending at the closing of such general meeting
if so decided by the board of directors. In the event of a transfer of common shares held in book-entry form in the period
between the Record Date and the date of the general meeting, the transferor is authorized and empowered by the
transferee to participate in such general meeting and, in particular, exercise the voting rights attached to such common
shares. The Certificates should be submitted to the Company (or its agent appointed in the convening notice) no later
than five (5) business days prior to the date of the relevant general meeting. Proxies and voting forms relating to such
general meeting must be remitted at the same time. The board of directors may set a shorter period for the submission
of the Certificate, proxies or voting forms.

9.4 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy.
9.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company or its agent specified

in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and the board of directors
shall determine their content.

9.6 The board of directors may determine other terms or set conditions that must be respected by a shareholder to

participate in any meeting of shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).

Art. 10. Quorum and vote.
10.1 Each common share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.
10.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of

shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes
validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

10.3 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.
10.4 Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding at least

two-thirds of the aggregate number of common shares issued in the Company:

(i) any amendment of these articles of association;
(ii) the winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;
(iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares (other than realized through the

authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association); and

(iv) any reduction of the share capital or any redemption or repurchase by the Company of any shares.
In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the consent of shareholders holding at least two-

thirds of the shares of the relevant class at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding
sentence.

The creation, allotment or issue of securities in the Company other than shares, or the grant of any option or rights

to subscribe for or to convert any instrument into shares or other securities in the Company (other than realized through
the authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association) shall require the consent of the sha-
reholders with majority set out in the first sentence of this article 10.4.

Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding more than

fifty per cent (50%) of the aggregate number of shares issued in the Company:

(i) the adoption of statutory accounts of the Company and any consolidated group accounts;
(ii) the payment or declaration of any dividend or other distribution by the Company; and

24363

L

U X E M B O U R G

(iii) the appointment or change of the Company's auditor.
The conclusion, termination or amendment of (a) silent partnerships and sub-participations in the Company or (b)

enterprise agreements of the Company within the meaning of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation
Act shall require the consent of the shareholders with majority set out in the fourth sentence of this article 10.4.

D. Management

Art. 11. Board of directors.
11.1 The Company shall be managed by a board of directors. The board of directors is vested with the broadest

powers to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the
actions reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

11.2 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in

connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any
other person(s) appointed by the board of directors, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers
shall be determined by a resolution of the board of directors.

11.3 The board of directors may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.
11.4 The board of directors is composed of at least three (3) directors. The board of directors must choose from

among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a vice-chairman and it may choose a secretary,
who does not need to be a shareholder or a member of the board of directors.

Art. 12. Election and removal of directors and term of the office.
12.1 Directors may be re-elected for successive terms. The directors are elected by a simple majority vote of the

common shares represented in a general meeting. Any director may be removed at any time without cause and prior
notice by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the common shares represented.

12.2 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy,

retirement, dismissal or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by a person designated by the
remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appoint-
ment.

Art. 13. Rules of procedure of the board of directors and board committees.
13.1 The board of directors determines its rules of conduct in a resolution and establishes such rules in writing.
13.2 The board of directors shall establish an audit committee (the "Audit Committee"), a nominating committee (the

"Nominating Committee") and a compensation committee (the "Compensation Committee"). The board may further
(but shall not be obliged to unless required by law), establish one or more additional committees. The board shall de-
termine the purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable for all
committees which are established.

13.3 In particular, the responsibilities and organization of the Audit Committee, the Nomination Committee and the

Compensation Committee shall be determined in a charter for each such committee by the board of directors. The board
of directors may also issue general principles and codes of conduct for the Company and its group.

13.4 Audit Committee: the Audit Committee shall be composed of at least three (3) members and the board of

directors shall appoint the members of the Audit Committee and shall designate one (1) of such members as the chair-
person of the Audit Committee. The purpose of the Audit Committee is (i) to oversee the accounting and financial
reporting processes of the Company, the audits of the financial statements of the Company, the Company's internal
control and recommending to the board of directors the choice of the Company's approved independent auditor (réviseur
d'entreprises agréé); and (ii) to perform such other duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the
regulations of the stock exchange(s) on which the shares of the Company are listed, as well as any other duties entrusted
to it by the board of directors. The board of directors shall allocate to the Audit Committee the necessary resources
and authority to fulfill its functions. The members of the Audit Committee may receive remuneration from the Company
in consideration of their services as members of the Audit Committee.

13.5 Nominating Committee: the Nominating Committee shall be composed of at least three (3) members and the

board of directors shall appoint the members of the Nominating Committee and shall designate one (1) of such members
as the chairperson of the Nominating Committee. The purpose of the Nominating Committee is to (i) assist the board
of directors in discharging the board of directors' responsibilities regarding (a) the identification of qualified candidates
to become directors of the Company, (b) the selection or recommendation to the board of directors regarding the
selection of nominees for election as directors at the next annual meeting of shareholders (or extraordinary meeting of
shareholders at which directors are to be elected), (c) the selection or recommendation of selection to the board of
directors regarding the selection of candidates to fill any vacancies on the board of directors and board committees, (d)
the assignment and rotation of directors of the board to various board committees, (e) oversight of the evaluation of the
board of directors and its various committees, and (f) assistance with the selection of candidates for future executive
officers as well as the promotion and changes in position of incumbent executive officers; and (ii) to perform such other
duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the shares
of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors

24364

L

U X E M B O U R G

shall allocate to the Nominating Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members
of the Nominating Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as members
of the Nominating Committee.

13.6 Compensation Committee: the Compensation Committee shall be composed of at least three (3) members and

the board of directors shall appoint the members of the Compensation Committee and shall designate one (1) of such
members as the chairperson of the Compensation Committee. The purpose of the Compensation Committee is (i) to
discharge or assist the board of directors in discharging the board of directors' responsibilities relating to review and
approval of the Company's compensation programs and the compensation of the Company's executive officers (including
the Company's subsidiaries), including by designing (in consultation with management and the board of directors), eva-
luating and approving the compensation plans, policies and programs of the Company and (ii) to perform such other
duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the shares
of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors
shall allocate to the Compensation Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members
of the Compensation Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as
members of the Compensation Committee.

13.7 The Board may in particular pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile,

electronic mail or any other similar means of communication, provided that each of the directors participates in such
resolution by circular means. The directors may express their consent separately on one or several documents. The date
of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 14. Dealing with third parties.
14.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2)

directors or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such power may have been delegated by the
board of directors.

14.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signatures

of any person to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly and within the limits of such
delegation.

Art. 15. Indemnification.
15.1 The members of the board of directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations

of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to mandatory
provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors or officer of the Company shall
be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably
incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party
or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him
in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or
proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses"
shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

15.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) against any liability to the Company or its

shareholders by reason of willful misconduct, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in
the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted
in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been
approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.

15.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any

director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director
or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained
herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers,
may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual
indemnification to any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide
upon from time to time.

15.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or pro-

ceeding of the character described in this article 15 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof
upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately deter-
mined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 16. Conflicts of interest.
16.1 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a personal interest in a transaction

submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interests, such director must
inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the
board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction.
Such conflict of interest shall be reported to the next general meeting.

24365

L

U X E M B O U R G

16.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or

invalidated by the fact that a director has a personal interest in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or
employee of such other company or firm.

E. Auditors

Art. 17. Independent auditor(s).
17.1 The Company's annual accounts shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs

d'entreprises agréés), appointed by the general meeting of shareholders at the board of directors' recommendation (itself
acting upon recommendation of the Audit Committee). The general meeting of shareholders shall determine the number
of auditor(s) and the term of their office.

17.2 An approved independent auditor may be dismissed at any time with cause (or with his approval) by the general

meeting of shareholders. An approved independent auditor may be reappointed.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 18. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and shall end on

the thirty-first of December of the same year.

Art. 19 Profits.
19.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors shall draw up or shall cause

to be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with
the Law.

19.2 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts
to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

19.3 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how

the remainder of the annual net profits will be allocated. Each common share shall be entitled to receive the same amount.

19.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing

shareholder agrees with such allocation. In the case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be
reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

19.5 If the common shares are held through a Depositary, the Company will make dividend payments and any other

payments in cash, common shares or other securities only to the Depositary recorded in the register or in accordance
with its instructions, and such payment will fully discharge of the Company's obligations in this respect.

19.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable

revert back to the Company.

Art. 20. Interim dividends - Share premium and additional premiums.
20.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.
20.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 21. Liquidation.
21.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators,

individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution
which shall determine the liquidators' powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have
the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

21.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realization of assets and

the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of common shares
of the Company held by them.

H. Governing law

Art. 22. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance

with the Law.”

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to accept the resignation of Mr. Ulrich Binninger, Mr. Christian Senitz

and Mr. Alexander Kudlich as directors of the Company with immediate effect and grants them full discharge for the
exercise of their mandate.

24366

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint the following persons as additional directors of the Company

for a period ending on the date of the annual general meeting held in 2016:

(i) Mr. Alexis Babeau, born on 10 December 1964, residing at Via Zorzi 30, 6900 Paradiso, Switzerland;
(ii) Mr. Christoph Barchewitz, born on 10 September 1978 in Wiesbaden, Germany, residing at 3, Burlington Gardens,

London W1S 3EP, UK;

(iii) Mr. Scott Collins, born on 26 June 1965 in Ann Arbor, Michigan, USA, residing at 3, Old Burlington Street, 3 

rd

Floor, London W1S 3AE, United Kingdom;

(iv) Mrs. Maggie Fanari, born on 16 July 1979 in Edmonton, Canada, residing at 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario

M2M4H5, Canada;

(v) Mr. Lorenzo Grabau, born on 19 August 1965 in Rome, Italy, residing at c/o Investment AB Kinnevik, P.O. Box

2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden;

(vi) Mr. Jens Grede, born on 25 February 1978 in Balinge, Sweden, residing at 17 Claremont Square London N1 9LY,

United Kingdom;

(vii) Mr. Daniel Grossman, born on 5 March 1971 in Antwerp, Belgium, residing at Avenue de Sumatra 12, B-1180

Brussels, Belgium;

(viii) Mr. Peter Kimpel, born on 10 June 1968 in Freiburg im Breisgau, Germany, residing at Johannisstraße 20, 10117

Berlin, Germany;

(ix) Mr. Oliver Samwer, born on 9 September 1972 in Cologne, Germany, residing at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,

Germany;

(x) Mr. Daniel Shinar, born on 22 June 1981 in Israel, residing at 3, Azrieli Center, Triangular Tower 45 

th

 Floor Tel-

Aviv 67023, Israel; and

(xi) Mr. Christian Winter, born on 17 November 1971 in Dortmund, residing at Hevener Str., 64, 44797, Bochum,

Germany.

The board of directors is henceforth composed as follows:
- Mr. Alexis Babeau;
- Mr. Christoph Barchewitz;
- Mr. Scott Collins;
- Mrs. Maggie Fanari;
- Mr. Lorenzo Grabau;
- Mr. Daniel Grossman;
- Mr. Jens Grede;
- Mr. Peter Kimpel;
- Mr. Oliver Samwer;
- Mr. Daniel Shinar; and
- Mr. Christian Winter.

<i>Declaration

The general meeting of shareholders hereby declares that the contributions listed 1 to 57 above, consisting of all ninety-

six thousand five hundred ninety-five (96,595) shares of Bigfoot, aforementioned, constitute the Bigfoot Contribution as
referred to in the deed of incorporation of the Company dated 1 October 2014.

There being no further business, the meeting is closed.

<i>Costs

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are

estimated at 7,300.- EUR.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this

document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the

said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am neunzehnten Tag des Monats Dezember.

24367

L

U X E M B O U R G

Vor uns, Maître Carlo WERSANDT, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,
wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Global Fashion Holding S.A. (die „Gesellschaft”)

abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 190907, mit Sitz in 5,
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 1. Oktober 2014 gemäß einer Urkunde 37
des Notars Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 11. November 2014 im
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3333, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seitdem nicht
geändert.

Die Versammlung wird um 17 Uhr unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, eröffnet.
Der Vorsitzende beruft Frau Elena Medagli, Rechtsanwältin, zur Schriftführerin.
Die Versammlung wählt Herrn Luis Aguerre Enríquez, Doctor en Derecho, zum Stimmzähler.
Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und bittet der Vorsitzende den

Notar, Folgendes festzuhalten:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien

erscheinen  auf  einer  Anwesenheitsliste,  die  von  den  anwesenden  Aktionären,  den  Bevollmächtigten  der  vertretenen
Aktionäre, vom Rat der Versammlung und vom unterzeichnenden Notar unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde
beigefügt werden, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten, welche von den erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur paraphiert wurden, werden

der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass das gesamte Gesellschaftskapital anwesend oder vertreten ist und alle

anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine Ladung erhalten zu haben und vor dieser Versammlung über die
Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein und verzichten somit auf jegliche Ladungsformalitäten.

III. Diese Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der fol-

genden Tagesordnung beraten:

IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einunddreißigtausend Euro

(EUR 31.000) um einen Betrag von neunundvierzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertachtund-
neunzig Euro (EUR 49.999.998) auf einen Betrag von fünfzig Millionen dreißigtausendneunhundertachtundneunzig Euro
(EUR  50.030.998)  durch  die  Ausgabe  von  neunundvierzig  Millionen  neunhundertneunundneunzigtausendneunhunder-
tachtundneunzig  (49.999.998)  Aktien  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1),  zu  einem  Preis  von  zwei
Milliarden fünfundfünfzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertachtzehn Euro (EUR 2.055.999.918),
eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus Aktien der Bigfoot GmbH.

2. Kenntnisnahme des Zusatzberichts des Verwaltungsrats über die Schaffung eines genehmigten Kapitals und Beschluss

bezüglich der Schaffung eines genehmigten Kapitals welches, ausschließlich des Gesellschaftskapitals, sechs Millionen fünf-
hundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig  Euro  (EUR  6.586.653)  betragen  soll,  bestehend  aus  sechs
Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien der Gesellschaft mit einem
Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

3. Änderung und vollständige Neufassung der Satzung.
4.  Annahme  des  Rücktritts  von  Herrn  Ulrich  Binninger,  Herrn  Christian  Senitz  und  Herrn  Alexander  Kudlich  als

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft und vollständige Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

5. Ernennung von Frau Maggie Fanari, Herrn Daniel Grossman, Herrn Scott Collins, Herrn Christian Winter, Herrn

Daniel Shinar, Herrn Peter Kimpel, Herrn Lorenzo Grabau, Herrn Alexis Babeau, Herrn Christoph Barchewitz, Herrn
Jens Grede und Herrn Oliver Samwer als weitere Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft.

6. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Hauptversammlung der Aktionäre nach Beratung

einstimmig die folgenden Beschlüsse und ersucht den Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen

Betrag von einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000) um einen Betrag von neunundvierzig Millionen neunhundertneu-
nundneunzigtausendneunhundertachtundneunzig Euro (EUR 49.999.998) auf einen Betrag von fünfzig Millionen dreißig-
tausendneunhundertachtundneunzig  Euro  (EUR  50.030.998)  durch  die  Ausgabe  von  neunundvierzig  Millionen
neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertachtundneunzig (49.999.998) Aktien mit einem Nominalwert von je ei-
nem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

Die  neunundvierzig  Millionen  neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertachtundneunzig  (49.999.998)  neuen

ausgegebenen Aktien wurden wie folgt gezeichnet:

24368

L

U X E M B O U R G

1. Zwölf Millionen fünfhundertachtundneunzigtausendachtundsiebzig (12.598.078) Aktien wurden von Kinnevik New

Ventures AB, einer Gesellschaft (aktiebolag) bestehend unter dem Recht Schwedens, eingetragen im Handelsregister
Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556736-2412, mit Sitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden,
zum Preis von fünfhundertachtzehn Millionen neunhundertzweiundsechzigtausendsiebenhunderteinundvierzig Euro (EUR
518.962.741) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus vierund-
zwanzigtausenddreihundertdreiundachtzig  (24.383)  Aktien  der  Bigfoot  GmbH,  einer  deutschen  Gesellschaft  mit  be-
schränkter Haftung mit Sitz in Johannisstrasse 20, 10117 Berlin, Deutschland und eingetragen im Register des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 127304 B („Bigfoot“);

2. Fünfzehn Millionen dreihundertzweiundsechzigtausendsiebenhundertsiebenundneunzig (15.362.797) Aktien wurden

von Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), einer Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit
Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, zum Preis von sechshunderteinunddreißig Millionen dreihundert-
sechsunddreißigtausenddreihundertneun Euro (EUR 631.336.309) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig einge-
zahlt  durch  eine  Sacheinlage  bestehend  aus  neunundzwanzigtausendsechshunderteinundsechzig  (29.661)  Aktien  der
Bigfoot;

3. Eine Million sechshundertneunzigtausendachtundfünfzig (1.690.058) Aktien wurden von GeRo Fashion Commerce

UG (haftungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsre-
gister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 129735 B, mit Sitz in Tamara-Danz-Straße
1, 10243 Berlin, Deutschland, zum Preis von neunundsechzig Millionen vierhundertdreiundfünfzigtausendeinhundertzwei-
undsiebzig  Euro  (EUR  69.453.172)  gezeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig  eingezahlt  durch  eine  Sacheinlage
bestehend aus dreitausendzweihundertdreiundsechzig (3.263) Aktien der Bigfoot;

4. Zwei Millionen sechshundertsechzehntausendeinhundertfünfundvierzig (2.616.145) Aktien wurden von TEV Global

Invest II GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Han-
delsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24967, mit Sitz in Wissollstraße 5-43,
45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, zum Preis von einhundertsieben Millionen fünfhundertzehntausendachthun-
dertachtundvierzig Euro (EUR 107.510.848) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sach-
einlage bestehend aus fünftausendeinundfünfzig (5.051) Aktien der Bigfoot;

5. Zwei Millionen sechshundertfünfundzwanzigtausendneunhundertsechsundachtzig (2.625.986) Aktien wurden von

Summit Partners RKT S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Re-
gistre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 169548, mit Sitz in 5, rue de Plébiscite, L-2341 Luxemburg,
Großherzogtum  Luxemburg,  zum  Preis  von  einhundertsieben  Millionen  neunhundertfünfzehntausendzweihundertfün-
fundsechzig Euro (EUR 107.915.265) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage
bestehend aus fünftausendsiebzig (5.070) Aktien der Bigfoot;

6. Einhundertsechsundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (156.420) Aktien wurden von Karrick Limited, einer Gesell-

schaft  (limited  company)  bestehend  unter  dem  Recht  von  Guernsey,  eingetragen  im  Handelsregister  von  Guernsey
(Guernsey Registry) unter der Nummer 41823, mit Sitz in Park Place, Park Street, St. Peter Port, Guernsey, GY 1 1EE,
Guernsey, zum Preis von sechs Millionen vierhundertachtundzwanzigtausendeinhundertzwei Euro (EUR 6.428.102) ge-
zeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig  eingezahlt  durch  eine  Sacheinlage  bestehend  aus  dreihundertzwei  (302)
Aktien der Bigfoot;

7. Eine Million vierhundertzweiundzwanzigtausendsiebenhundertachtundneunzig (1.422.798) Aktien wurden von Sa-

turn 2 S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Com-
merce  et  des  Sociétés)  unter  der  Nummer  B  180356,  mit  Sitz  in  47,  Avenue  John  F.  Kennedy,  L-1855  Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, zum Preis von achtundfünfzig Millionen vierhundertsiebzigtausendvierundachtzig Euro (EUR
58.470.084) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zweitau-
sendsiebenhundertsiebenundvierzig (2.747) Aktien der Bigfoot;

8. Fünfhunderteinundachtzigtausendeinhundertfünfunddreißig (581.135) Aktien wurden von Petroenergy Limited, ei-

ner Gesellschaft (limited company) bestehend unter dem Recht der Republik Zypern, eingetragen beim Referat Handels-
register und Konkursverwaltung (Department of Registrar of Companies and official Receiver) unter der Nummer HE
232838, mit Sitz in 2 Louki Akrita str, Lakatemeia, 2333, Nikosia, Zypern, zum Preis von dreiundzwanzig Millionen acht-
hunderteinundachtzigtausendachthundertfünfundzwanzig  Euro  (EUR  23.881.825)  gezeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde
vollständig  eingezahlt  durch  eine  Sacheinlage  bestehend  aus  eintausendeinhundertzweiundzwanzig  (1.122)  Aktien  der
Bigfoot;

9. Dreihundertfünfundzwanzigtausendsiebenhundertachtundachtzig (325.788) Aktien wurden von JaToPa GmbH, einer

Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  München,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 198609,
mit Sitz in Maximilianstraße 21, 80539 München, Deutschland, zum Preis von dreizehn Millionen dreihundertachtun-
dachtzigtausenddreihundertvier Euro (EUR 13.388.304) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch
eine Sacheinlage bestehend aus sechshundertneunundzwanzig (629) Aktien der Bigfoot;

24369

L

U X E M B O U R G

10. Dreihundertzwölftausendachthundertvierzig (312.840) Aktien wurden von Kering Netherlands B.V., einer Gesell-

schaft  (Besloten  Vennootschap)  bestehend  unter  dem  Recht  der  Niederlande,  mit  Sitz  in  Amsterdam,  Niederlande,
eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 33168497, mit Sitz in Amstelplein 1, Rem-
brandttoren, 1096HA Amsterdam, die Niederlande, zum Preis von zwölf Millionen achthundertsechsundfünfzigtausend-
zweihundertvier Euro (EUR 12.856.204) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage
bestehend aus sechshundertvier (604) Aktien der Bigfoot;

11. Zweihundertneunzigtausendfünfhundertachtundsechzig (290.568) Aktien wurden von Verlinvest S.A., einer Akti-

engesellschaft bestehend unter dem Recht Belgiens, eingetragen im Registrar of Legal Entities in Brüssel unter der Nummer
0455.030.364, mit Sitz in Place Flagey 18, 1050 Brüssel, Belgien, zum Preis von elf Millionen neunhundertvierzigtausend-
neunhundertdreiunddreißig Euro (EUR 11.940.933) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine
Sacheinlage bestehend aus fünfhunderteinundsechzig (561) Aktien der Bigfoot;

12. Fünfhunderteinundsechzigtausendneunhunderteinundsiebzig (561.971) Aktien wurden von Aismare Limited, einer

Gesellschaft (limited company) gegründet in England und Wales, eingetragen im Companies House of the United Kingdom
unter der Nummer 07634146, mit Sitz in 34A Station Road, Cuffley, Potters Bar, EN6 4HE, Vereinigtes Königreich, zum
Preis von dreiundzwanzig Millionen vierundneunzigtausendzweihundertsiebenundsiebzig Euro (EUR 23.094.277) gezeich-
net. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus eintausendfünfundachtzig (1.085)
Aktien der Bigfoot;

13. Zweihundertfünfzigtausendsechshundertsechsundachtzig (250.686) Aktien wurden von BNY Mellon Trust Com-

pany (Ireland) Limited, einer Gesellschaft (limited company) bestehend unter dem Recht Irlands, eingetragen im Com-
panies Registration Office Ireland unter der Nummer 223184, in ihrer Eigenschaft als Treuhänderin der Eureka Fund,
einer Untertreuhandgesellschaft der Marshall Wace Investment Strategies, mit Sitz in Guild House, Guild Street, IFSC,
Dublin  1,  Irland,  zum  Preis  von  zehn  Millionen  dreihunderteinstausendneunhundertsiebenundsiebzig  Euro  (EUR
10.301.977) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus vierhun-
dertvierundachtzig (484) Aktien der Bigfoot;

14. Eine Million einhundertvierundzwanzigtausendneunhundertneunundsiebzig (1.124.979) Aktien wurden von E-com-

merce  Holdings  LP,  einer  Gesellschaft  (limited  partnership)  bestehend  unter  dem  Recht  der  Kaimaninseln  (Cayman
Islands), mit Sitz in 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005, Cayman Islands, zum Preis von sechs-
undvierzig Millionen zweihunderteinunddreißigtausendeinhunderteinundsiebzig Euro (EUR 46.231.171) gezeichnet. Der
Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zweitausendeinhundertzweiundsiebzig
(2.172) Aktien der Bigfoot;

15. Achthundertvierundsiebzigtausendachthundertelf (874.811) Aktien wurden von Tetral S.A., einer Aktiengesell-

schaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht der Schweiz, mit satzungsmäßigem Sitz in Pully, Schweiz, eingetragen
im Handelsregister des Kantons Vaud (Federal Commercial Registry office) unter der Nummer CH-550.1.000.845-3, mit
Sitz in Avenue Général Guisan 70, 1009 Pully, Schweiz, zum Preis von fünfunddreißig Millionen neunhundertfünfzigtau-
sendvierhunderteinundachtzig Euro (EUR 35.950.481) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch
eine Sacheinlage bestehend aus eintausendsechshundertneunundachtzig (1.689) Aktien der Bigfoot;

16. Einhundertsechsundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (156.420) Aktien wurden von Verwaltung Tiefgarage Ro-

therbaum  GmbH,  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im
Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 59587, mit Sitz in Stubbenhuk 7, 20459
Hamburg,  Deutschland,  zum  Preis  von  sechs  Millionen  vierhundertachtundzwanzigtausendeinhundertzwei  Euro  (EUR
6.428.102) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus dreihundert-
zwei (302) Aktien der Bigfoot;

17. Einhundertsechsundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (156.420) Aktien wurden von Financial Mathematics S.A.,

einer Aktiengesellschaft (société anonyme) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen
im  Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés)  unter  der  Nummer  B
114827, mit Sitz in 6, Rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum Preis von sechs Millionen
vierhundertachtundzwanzigtausendeinhundertzwei Euro (EUR 6.428.102) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig
eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus dreihundertzwei (302) Aktien der Bigfoot;

18. Dreihundertsiebenunddreißigtausendsiebenhunderteins (337.701) Aktien wurden von E-Fashion S.à r.l., einer Ge-

sellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums
Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 177487, mit Sitz in 6,
Rue Adolphe, L-1116 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, zum Preis von dreizehn Millionen achthundertsiebenund-
siebzigtausendachthundertsiebzig Euro (EUR 13.877.870) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch
eine Sacheinlage bestehend aus sechshundertzweiundfünfzig (652) Aktien der Bigfoot;

19. Einhundertsiebenundachtzigtausendvierhundertsechsundneunzig (187.496) Aktien wurden von Kaltroco Limited,

einer Gesellschaft (limited company) bestehend unter dem Recht von Jersey, eingetragen im JFSC Companies Registry
unter der Nummer 60595, mit Sitz in Lime Grove House, Green Street, St. Helier, Jersey JE1 2ST, Jersey, zum Preis von
sieben Millionen siebenhundertfünftausendeinhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 7.705.175) gezeichnet. Der Bezugspreis
wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus dreihundertzweiundsechzig (362) Aktien der Bigfoot;

24370

L

U X E M B O U R G

20. Vierhundertvierundzwanzigtausendsiebenhundertsechzehn (424.716) Aktien wurden von LTG International Ltd.,

einer Gesellschaft (private limited company) bestehend unter dem Recht von England und Wales, eingetragen im Com-
panies House of the United Kingdom unter der Nummer 02882173, mit Sitz in Chelsea House, West Gate, London W5
1DR, Vereinigtes Königreich, zum Preis von siebzehn Millionen vierhundertdreiundfünfzigtausendsiebenhundertvierund-
sechzig Euro (EUR 17.453.764) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage beste-
hend aus achthundertzwanzig (820) Aktien der Bigfoot;

21. Dreihundertachtundsechzigtausendsiebenhundertachtundsiebzig (368.778) Aktien wurden von Santerna Holdings

Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited company) bestehend unter dem Recht der Republik Zypern,
eingetragen beim Referat Handelsregister und Konkursverwaltung (Department of Registrar of Companies and official
Receiver) unter der Nummer 279671, mit Sitz in 1 Katalanou Street, 1 

st

 floor, office/flat 101, 2121 Aglantzia, Nikosia,

Zypern,  zum  Preis  von  fünfzehn  Millionen  einhundertvierundfünfzigtausendneunhundertvierundachtzig  Euro  (EUR
15.154.984) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus siebenhun-
dertzwölf (712) Aktien der Bigfoot;

22. Einhundertsechsundfünfzigtausendvierhundertzwanzig (156.420) Aktien wurden von Fidelity Funds SICAV in res-

pect of Fidelity Funds European Smaller Companies Pool (F/ESM), eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 34036, mit Sitz in 2a, Rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum
Luxemburg, zum Preis von sechs Millionen vierhundertachtundzwanzigtausendeinhundertzwei Euro (EUR 6.428.102) ge-
zeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig  eingezahlt  durch  eine  Sacheinlage  bestehend  aus  dreihundertzwei  (302)
Aktien der Bigfoot;

23. Vierundfünfzigtausenddreihundertfünfundachtzig (54.385) Aktien wurden von Bwide Net UG (haftungsbeschränkt)

&amp; Co. KG, einer Gesellschaft (limited partnership) bestehend unter deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRA
45900 B, mit Sitz in Eichenstr. 19, 12623 Berlin, Deutschland, zum Preis von zwei Millionen zweihundertvierunddreißig-
tausendneunhundertneunundfünfzig  Euro  (EUR  2.234.959)  gezeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig  eingezahlt
durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundertfünf (105) Aktien der Bigfoot;

24. Vierhundertzehntausendsiebenhundertzweiunddreißig (410.732) Aktien wurden von Putnam Funds Trust, han-

delnd für ihre series Putnam Capital Spectrum Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA, zum Preis von sechzehn Millionen achthundertneunundsiebzigtausendneunundachtzig Euro (EUR
16.879.089) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus siebenhun-
dertdreiundneunzig (793) Aktien der Bigfoot;

25. Einhundertachtundsiebzigtausendsechshundertzweiundneunzig (178.692) Aktien wurden von Putnam Funds Trust,

handelnd für ihre series Putnam Equity Spectrum Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von sieben Millionen dreihundertdreiundvierzigtausenddreihundertdreiund-
siebzig Euro (EUR 7.343.373) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend
aus dreihundertfünfundvierzig (345) Aktien der Bigfoot;

26. Zweihundertachtzehntausendfünfhundertdreiundsiebzig (218.573) Aktien wurden von Putnam Voyager Fund, ein

Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von acht Millionen
neunhundertzweiundachtzigtausendzweihundertachtundachtzig Euro (EUR 8.982.288) gezeichnet. Der Bezugspreis wur-
de vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus vierhundertzweiundzwanzig (422) Aktien der Bigfoot;

27. Neunundvierzigtausendzweihundertvier (49.204) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre

series Putnam VT Voyager Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA, zum Preis von zwei Millionen zweiundzwanzigtausendfünfundvierzig Euro (EUR 2.022.045) gezeichnet. Der Bezugs-
preis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus fünfundneunzig (95) Aktien der Bigfoot;

28. Sechzigtausendsechshundert (60.600) Aktien wurden von The Putnam Fund for Growth and Income, ein Massa-

chusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von zwei Millionen
vierhundertneunzigtausenddreihundertsechsundsechzig Euro (EUR 2.490.366) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde voll-
ständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundertsiebzehn (117) Aktien der Bigfoot;

29. Fünfzehntausendzwanzig (15.020) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre series Putnam VT

Growth and Income Fund, ein Massachusetts Business Trust, mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
zum Preis von sechshundertsiebzehntausendzweihundertneunundvierzig Euro (EUR 617.249) gezeichnet. Der Bezugspreis
wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus neunundzwanzig (29) Aktien der Bigfoot;

30. Zweiundachtzigtausenddreihundertdreiundfünfzig (82.353) Aktien wurden von Putnam Multi-Cap Growth Fund,

ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von drei Millionen
dreihundertvierundachtzigtausenddreihundertacht Euro (EUR 3.384.308) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig
eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundertneunundfünfzig (159) Aktien der Bigfoot;

31. Sechzehntausendfünfhundertvierundsiebzig (16.574) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre

series Putnam VT Multi-Cap Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, zum Preis von sechshunderteinundachtzigtausendeinhundertelf Euro (EUR 681.111) gezeichnet. Der
Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zweiunddreißig (32) Aktien der Bigfoot;

24371

L

U X E M B O U R G

32. Neuntausenddreihundertdreiundzwanzig (9.323) Aktien wurden von Putnam Investment Funds, handelnd für ihre

series Putnam Growth Opportunities Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, zum Preis von dreihundertdreiundachtzigtausendeinhundertdreißig Euro (EUR 383.130) gezeichnet. Der
Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus achtzehn (18) Aktien der Bigfoot;

33. Fünftausendeinhundertneunundsiebzig (5.179) Aktien wurden von IG Putnam U.S. Growth Fund, einer Gesellschaft

(mutual fund trust) gegründet in Kanada, mit Geschäftssitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA (vormals:
c/o I.G. Investment Management Ltd., 447 Portage Avenue, Winnipeg, Manitoba R3C 3B6, Kanada), zum Preis von zwei-
hundertzwölftausendachthundertzweiunddreißig  Euro  (EUR  212.832)  gezeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig
eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zehn (10) Aktien der Bigfoot;

34. Eintausendsechsunddreißig (1.036) Aktien wurden von Putnam World Trust.. Putnam U.S. Large Cap Growth Fund,

einem irischen OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) mit Geschäftssitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA (vormals: 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland), zum Preis von zweiundvierzigtausend-
fünfhundertfünfundsiebzig  Euro  (EUR  42.575)  gezeichnet.  Der  Bezugspreis  wurde  vollständig  eingezahlt  durch  eine
Sacheinlage bestehend aus zwei (2) Aktien der Bigfoot;

35. Sechsunddreißigtausendzweihundertsechsundfünfzig (36.256) Aktien wurden von Putnam Investors Fund, ein Mas-

sachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von einer Million
vierhundertneunundachtzigtausendneunhundertfünfundvierzig Euro (EUR 1.489.945) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde
vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus siebzig (70) Aktien der Bigfoot;

36. Fünftausendeinhundertneunundsiebzig (5.179) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre series

Putnam VT Investors Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA,
zum Preis von zweihundertzwölftausendachthundertzweiunddreißig Euro (EUR 212.832) gezeichnet. Der Bezugspreis
wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zehn (10) Aktien der Bigfoot;

37. Eintausendsechsunddreißig (1.036) Aktien wurden von Putnam Funds Trust, handelnd für ihre series Putnam Multi

Cap Core Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis
von zweiundvierzigtausendfünfhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 42.575) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig
eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zwei (2) Aktien der Bigfoot;

38.  Dreiundzwanzigtausendachthundertsechsundzwanzig  (23.826)  Aktien  wurden  von  Putnam  International  Equity

Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von
neunhundertneunundsiebzigtausendeinhundertdreiunddreißig Euro (EUR 979.133) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde
vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus sechsundvierzig (46) Aktien der Bigfoot;

39. Zweitausendfünfhundertneunzig (2.590) Aktien wurden von International Equity Class (Putnam), einer Gesellschaft

(corporation) gegründet in Kanada, mit Geschäftssitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA (vormals c/o
Mackenzie Financial Corporation, 180 Queen Street West, Toronto, Ontario M5V 3K1, Kanada), zum Preis von einhun-
dertsechstausendvierhundertsechsunddreißig Euro (EUR 106.436) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig einge-
zahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus fünf (5) Aktien der Bigfoot;

40. Neuntausenddreihundertdreiundzwanzig (9.323) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre

series Putnam VT International Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, zum Preis von dreihundertdreiundachtzigtausendeinhundertdreißig Euro (EUR 383.130) gezeichnet. Der
Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus achtzehn (18) Aktien der Bigfoot;

41. Zwanzigtausendzweihundert (20.200) Aktien wurden von Putnam Global Equity Fund, ein Massachusetts Business

Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von achthundertdreißigtausendeinhundert-
zweiundzwanzig Euro (EUR 830.122) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage
bestehend aus neununddreißig (39) Aktien der Bigfoot;

42. Fünftausendeinhundertneunundsiebzig (5.179) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre series

Putnam VT Global Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA, zum Preis von zweihundertzwölftausendachthundertzweiunddreißig Euro (EUR 212.832) gezeichnet. Der Bezugs-
preis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zehn (10) Aktien der Bigfoot;

43. Achttausendzweihundertsiebenundachtzig (8.287) Aktien wurden von Putnam Investment Funds, handelnd für ihre

series Putnam International Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, zum Preis von dreihundertvierzigtausendfünfhundertfünfundfünfzig Euro (EUR 340.555) gezeichnet. Der
Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus sechzehn (16) Aktien der Bigfoot;

44. Eintausendfünfhundertvierundfünfzig (1.554) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre series

Putnam VT International Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA
02109, USA, zum Preis von dreiundsechzigtausendachthundertzweiundsechzig Euro (EUR 63.862) gezeichnet. Der Be-
zugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus drei (3) Aktien der Bigfoot;

45. Eintausendsechsunddreißig (1.036) Aktien wurden von Putnam Asset Allocation Funds, handelnd für ihre series

Putnam Dynamic Asset Allocation Growth Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square,
Boston, MA 02109, USA, zum Preis von zweiundvierzigtausendfünfhundertfünfundsiebzig Euro (EUR 42.575) gezeichnet.
Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zwei (2) Aktien der Bigfoot;

24372

L

U X E M B O U R G

46. Zweitausendzweiundsiebzig (2.072) Aktien wurden von Putnam Funds Trust, handelnd für ihre series Putnam

Emerging Markets Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109,
USA, zum Preis von fünfundachtzigtausendeinhundertneunundvierzig Euro (EUR 85.149) gezeichnet. Der Bezugspreis
wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus vier (4) Aktien der Bigfoot;

47. Dreitausendsechshundertfünfundzwanzig (3.625) Aktien wurden von Putnam International Growth Equity Trust,

einer Gesellschaft nach dem Recht von Massachusetts (Massachusetts investment funds trust) mit Sitz in One Post Office
Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis von einhundertachtundvierzigtausendneunhundertsiebzig Euro (EUR 148.970)
gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus sieben (7) Aktien der
Bigfoot;

48. Vier Millionen zweihundertachtundfünfzigtausendfünfunddreißig (4.258.035) Aktien wurden von Kinnevik Online

AB, einer Gesellschaft (aktiebolag) bestehend unter schwedischem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Stockholm, Schwe-
den, eingetragen im Handelsregister in Schweden (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit Sitz in Skeppsbron
18, 10313 Stockholm, Schweden, zum Preis von einhundertvierundsiebzig Millionen neunhundertvierundachtzigtausend-
fünfhundertneunundvierzig Euro (EUR 174.984.549) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine
Sacheinlage bestehend aus achttausendzweihunderteinundzwanzig (8.221) Aktien der Bigfoot;

49.  Zweihundertsiebentausendeinhundertachtundsiebzig  (207.178)  Aktien  wurden  von  Bambino  53.  V  V  UG  (haf-

tungsbeschränkt), einer Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und bestehend unter deutschem Recht,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit
Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, zum Preis von acht Millionen fünfhundertvierzehntausendneun Euro
(EUR 8.514.009) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus vier-
hundert (400) Aktien der Bigfoot;

50. Vierhundertsechsundvierzigtausendvierhundertsiebzig (446.470) Aktien wurden von TEC Global Invest I GmbH,

einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im  Handelsregister  des
Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24965, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an
der  Ruhr,  Deutschland,  zum  Preis  von  achtzehn  Millionen  dreihundertsiebenundvierzigtausendsiebenhundertachtund-
vierzig Euro (EUR 18.347.748) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend
aus achthundertzweiundsechzig (862) Aktien der Bigfoot;

51. Fünfundfünfzigtausendneunhundertneununddreißig (55.939) Aktien wurden von Dritte PMB Management GmbH,

einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im  Handelsregister  des
Amtsgerichts Hamburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 112289, mit Sitz in Neuer Jungfernstieg 5, 20354 Hamburg,
Deutschland,  zum  Preis  von  zwei  Millionen  zweihundertachtundneunzigtausendachthunderteinundzwanzig  Euro  (EUR
2.298.821) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einhundertacht
(108) Aktien der Bigfoot;

52. Eine Million einhundertvierundneunzigtausendneunhunderteins (1.194.901) Aktien wurden von AI European Hol-

dings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht
des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Com-
merce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 15-17, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, zum Preis von neunundvierzig Millionen einhundertviertausendsechshundertfünfundzwanzig
Euro (EUR 49.104.625) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus
zweitausenddreihundertsieben (2.307) Aktien der Bigfoot;

53. Fünfundzwanzigtausendachthundertsiebenundneunzig (25.897) Aktien wurden von TEC Global Invest II GmbH,

einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im  Handelsregister  des
Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24964, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an
der  Ruhr,  Deutschland,  zum  Preis  von  einer  Million  vierundsechzigtausendzweihunderteinundvierzig  Euro  (EUR
1.064.241) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus fünfzig (50)
Aktien der Bigfoot;

54. Fünftausendeinhundertneunundsiebzig (5.179) Aktien wurden von Mercura Capital GmbH (vormals Schuler-Be-

teiligungen  GmbH),  einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im
Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 200948, mit Geschäftssitz in Schließ-
stättstraße 22, 82319 Starnberg, Deutschland, zum Preis von zweihundertzwölftausendachthundertzweiunddreißig Euro
(EUR 212.832) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus zehn (10)
Aktien der Bigfoot;

55. Fünfhundertachtzehn (518) Aktien wurden von Putnam Variable Trust, handelnd für ihre series Putnam VT Growth

Opportunities Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum
Preis von einundzwanzigtausendzweihundertsiebenundachtzig Euro (EUR 21.287) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde
vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Bigfoot;

56. Fünfhundertachtzehn (518) Aktien wurden von Putnam Funds Trust, handelnd für ihre series Putnam Asia Pacific

Equity Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston, MA 02109, USA, zum Preis
von einundzwanzigtausendzweihundertsiebenundachtzig Euro (EUR 21.287) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollstän-
dig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Bigfoot; und

24373

L

U X E M B O U R G

57. Fünfhundertachtzehn (518) Aktien wurden von Putnam Asset Allocation Funds, handelnd für ihre series Putnam

Dynamic Asset Allocation Balanced Fund, ein Massachusetts Business Trust mit Sitz in One Post Office Square, Boston,
MA 02109, USA, zum Preis einundzwanzigtausendzweihundertsiebenundachtzig Euro (EUR 21.287) gezeichnet. Der Be-
zugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Sacheinlage bestehend aus einer (1) Aktie der Bigfoot.

Der Gesamtwert der Einlagen unter 1 bis 57 beträgt zwei Milliarden fünfundfünfzig Millionen neunhundertneunund-

neunzigtausendneunhundertachtzehn Euro (EUR 2.055.999.918), was von den Aktionären und Zeichnern ausdrücklich
genehmigt  und  in  einem  Bericht  der  Ernst  &amp;  Young  S.A.,  einer  Aktiengesellschaft  (société  anonyme),  gegründet  und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 7, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 47771,
im Einklang mit den Artikeln 26-1 und 32-1 des Gesetzes von 1915 über Handelsgesellschaften, in seiner aktuellen Fassung,
bestätigt wurde. Die Schlussfolgerung des Berichts lautet wie folgt:

„Auf der Grundlage der durchgeführten und oben beschriebenen Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt ge-

worden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Wert der Sacheinlage nicht mindestens der Anzahl und dem
Nominalwert der 49.999.998 Aktien mit einem Nominalwert von je 1 EUR entspricht, welche mit dem gesamten ver-
bundenen Agio von 2.005.999.920 EUR ausgegeben werden, wodurch die gesamte Gegenleistung 2.055.999.918 EUR
beträgt.“

Der Bericht wurde vom Notar und dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien paraphiert und wird der vorlie-

genden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die gesamte Einlage in Höhe von zwei Milliarden fünfundfünfzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneun-

hundertachtzehn Euro (EUR 2.055.999.918) besteht aus neunundvierzig Millionen neunhundertneunundneunzigtausend-
neunhundertachtundneunzig  Euro  (EUR  49.999.998)  für  das  Gesellschaftskapital  und  zwei  Milliarden  fünf  Millionen
neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertzwanzig Euro (EUR 2.005.999.920) für das Agio.

Daraufhin schließen sich die Parteien 2 bis 57 der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre an und be-

schließen  gemeinsam  mit  den  unter  Punkt  1  genannten  Parteien  über  die  nachfolgenden  Tagesordnungspunkte.  Die
Vollmachten aller Zeichnungsparteien, welche von den Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar „ne
varietur“ paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

<i>Zweiter Beschluss

Nach ordnungsgemäßer Beratschlagung über den Zusatzbericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft über die Schaf-

fung des genehmigten Kapitals, welchen die Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt, beschließt die Hauptversamm-
lung  der  Aktionäre  die  Schaffung  eines  genehmigten  Kapitals  welches,  ausschließlich  des  Gesellschaftskapitals,  sechs
Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR 6.586.653) betragen soll, bestehend
aus sechs Millionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien.

Der Verwaltungsrat ist hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des

Gesellschafterbeschlusses zur Schaffung des genehmigten Kapitals im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
oder gegebenenfalls des Gesellschafterbeschlusses zur Erneuerung oder Erhöhung des genehmigten Kapitals gemäß der
Satzung der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien auszugeben, Aktienbezugsoptionen für
Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben, um die Zuteilung von Aktien,
folgend auf die Ausübung oder Umwandlung der Aktienoptionen oder anderer aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen
eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Gesellschaft vorzunehmen, oder Aktien an
bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, von welcher die Gesellschaft das Mutter-
unternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Bedingungen erfolgt, die der
Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung
der neu auszugebenden Aktien zu gewähren.

Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen
Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher

in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

<i>Dritter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesell-

schaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Global Fashion

Holding S.A. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesell-
schaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

24374

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren jegliche Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Ge-

sellschaft sowie für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält,
oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, einräumen und Kredite gewähren, Leistungen
erbringen oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für jede Gesellschaft, an welcher sie eine direkte oder indirekte Kontroll-

mehrheit hält, Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermö-
gensverwaltung (treasury management), Währungsmanagement (currencies management services), Zins- (interest rate)
und Devisenkursrisikomanagement (foreign exchange risk management).

2.4 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher

Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligati-
onen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.5 Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten

durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art,
(ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich dieses geistigen Eigentums und dieser gewerblichen Schutzrechte, und (iii) das
Halten und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.6 Die Gesellschaft wird nicht als alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die

Verwalter  alternativer  Investmentfonds  handeln  und  wird  keine  anderen  Tätigkeit  durchführen,  die  der  Aufsicht  der
Commission de Surveillance du Secteur Financier unterliegen würde.

2.7 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller, finanzieller und technischer Na-

tur, sowie solche, welches geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser
Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst

werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann

der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversamm-
lung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede
andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.2 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großher-

zogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Aktien - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt fünfzig Millionen dreißigtausendneunhundertachtundneunzig Euro

(EUR 50.030.998), bestehend aus 57 fünfzig Millionen dreißigtausendneunhundertachtundneunzig (50.030.998) Aktien mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) pro Aktie.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine

Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von
1915 oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Vorbehaltlich des Artikels 6.2 dieser Satzung werden alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu zahlen sind,

bevorzugt den bestehenden Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am ausgegebenen Gesellschaftskapital
jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt
werden kann. Dieser Zeitraum beträgt nicht weniger als dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Zeich-
nungszeitraums,  welcher  im  Amtsblatt  des  Großherzogtums  Luxemburg,  dem  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et
Associations (das „Mémorial“) und in zwei (2) Luxemburger Tageszeitungen im Einklang mit dem Gesetz von 1915 ver-
öffentlicht wird, oder, falls alle Aktien Namensaktien sind, ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung der Aktionäre durch
Einschreiben. Jedoch kann, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, die Hauptversammlung der Aktionäre (i)
im Rahmen eines Beschlusses über die Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder (ii) anlässlich einer dem
Verwaltungsrat eingeräumten Berechtigung zur Erhöhung des von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftskapitals
das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss begrenzen oder aufheben, oder den Verwaltungsrat
hierzu ermächtigen. Ein solcher Beschluss ist im Einklang mit den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung zu fassen.

24375

L

U X E M B O U R G

Art. 6. Genehmigtes Kapital.
6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, sechs Mil-

lionen fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR 6.586.653), aufgeteilt in sechs Millionen
fünfhundertsechsundachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1).

6.2 Der Verwaltungsrat ist hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung

des betreffenden Gesellschafterbeschlusses im Mémorial im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt, Aktien aus-
zugeben, Aktienbezugsoptionen für Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszu-
geben, um die Zuteilung von Aktien, folgend auf die Ausübung oder Umwandlung der Aktienoptionen oder anderer
aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Ge-
sellschaft vorzunehmen, oder Aktien an bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe,
von welcher die Gesellschaft das Mutterunternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter
solchen Bedingungen erfolgt, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären
ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder
mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Sat-
zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf
(5) Jahre beträgt.

6.3 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, wel-

cher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Aktien.
7.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien aufgeteilt, die alle den gleichen Nominalwert haben. Die

Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben.

7.2 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung frei übertragbar.

Die Gesellschaft kann entsprechend den Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Aktien zurückerwerben und als eigene
Aktien halten.

7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Stammaktie von mehreren Personen

gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Ge-
sellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie solange auszusetzen, bis
eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz,

noch ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

7.5 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann.

Dieses Register enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum an
Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden, unbeschadet der Bedingungen für
Übertragungen im Wege der Umbuchung von Bucheffekten, wie in Artikel 7.6 dieser Satzung vorgesehen. Zertifikate
über die Eintragung werden auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs an diesen und, in dem in Artikel 7.6
dieser Satzung vorgesehenen Fall, an die Verwahrungsstelle (wie unten definiert) ausgegeben. Alle einem eingetragenen
Aktionär zuzustellenden Mitteilungen und Bescheide gelten als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie an die letzte von
diesem Aktionär an die Gesellschaft kommunizierte Adresse geschickt wurden. Der Verwaltungsrat kann beschließen,
weder einen Eintrag im Aktienregister vorzunehmen, noch eine Übertragungsmitteilung während eines Zeitraums ab dem
Stichtag (wie unten definiert) bis zum Ablauf der betreffenden Hauptversammlung von der Gesellschaft anzuerkennen.

7.6 Handelt es sich bei den Aktien um Namensaktien und sind diese im Aktienregister der Gesellschaft im Namen oder

für Rechnung eines Wertpapierabwicklungssystems oder des Betreibers eines solchen Systems eingetragen und als Buch-
effekte in den Geschäftsbüchern eines Kreditinstituts oder einer professionellen Verwahrungsstelle oder Unterverwah-
rungsstelle verzeichnet (wobei solche Kreditinstitute, Verwahrungsstellen und Unterverwahrungsstellen im Folgenden als
„Verwahrungsstelle“ bezeichnet werden), räumt die Gesellschaft der betreffenden Verwahrungsstelle, nach Vorlage eines
Nachweises durch die Verwahrungsstelle über die Eintragung der Bucheffekte, die Ausübung der mit den Aktien verbun-
denen Rechte entsprechend der Bucheffekte des betreffenden Aktionärs, einschließlich des Erhalts von Einberufungen zu
Hauptversammlungen,  die  Zulassung  zu  Hauptversammlungen  und  ein  Stimmrecht  bei  Hauptversammlungen  ein  (die
„Zertifikate“). Der Verwaltungsrat kann Formvorschriften festlegen, denen diese Zertifikate entsprechen müssen.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 8. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Haupt-

versammlung  der  Aktionäre  aus.  Jede  regelmäßig  einberufene  Hauptversammlung  der  Aktionäre  repräsentiert  die
Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915
oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 9. Einberufung der Hauptversammlung.
9.1 Die Jahreshauptversammlung wird am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an einem anderen in der Einberufung

bestimmten Ort in Luxemburg am letzten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Ist

24376

L

U X E M B O U R G

dieser Tag kein Werktag in Luxemburg, so ist die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abzuhalten.
Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können zu jeder Zeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden und an
dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

9.2 Hauptversammlungen der Aktionäre müssen im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser

Satzung und, falls die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, in Übereinstimmung mit den die Gesellschaft
betreffenden Publizitätspflichten dieser ausländischen Börse, einberufen werden. Falls alle Aktionäre anwesend sind, ist
keine Einberufung oder vorherige Mitteilung notwendig.

9.3 Falls die Aktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse zum Handel zugelassen sind, sind alle am Tag

der Hauptversammlung der Aktionäre im Aktienregister geführten Aktionäre dazu berechtigt, zur Hauptversammlung
der Aktionäre zugelassen zu werden. Sind die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert, so kann der
Verwaltungsrat ein/e dem der Hauptversammlung vorangehende/s Datum und Uhrzeit als Stichtag zur Zulassung zur
Hauptversammlung der Aktionäre bestimmen (der „Stichtag“). In einem solchen Fall muss jeder Aktionär, der an der
Hauptversammlung teilnehmen möchte, die Gesellschaft spätestens am Stichtag auf die vom Verwaltungsrat im Einberu-
fungsbescheid festgelegte Weise darüber in Kenntnis setzen. Werden Aktien durch eine Verwahrungsstelle gehalten, muss
ein Aktionär, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, von dieser Verwahrungsstelle ein oder
mehrere Zertifikate erhalten, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen registrierten Aktien am Stichtag ausweist. In
der Zeit zwischen dem Stichtag und dem Ablauf der Hauptversammlung darf weder ein Eintrag im Aktienregister vorge-
nommen werden, noch darf eine Mitteilung einer Aktienübertragung von der Gesellschaft oder einem im Auftrag der
Gesellschaft handelnden Registerführer anerkannt werden, wenn dies vom Verwaltungsrat entschieden wird. Bei einer
Übertragung von Aktien in Form von Bucheffekten in der Zeit zwischen dem Stichtag und dem Datum der Hauptver-
sammlung ist der Veräußerer vom Erwerber ermächtigt, an einer solchen Hauptversammlung teilzunehmen und insbe-
sondere die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die Zertifikate sollten bei der Gesellschaft (oder dem
in der Einberufung ernannten Vertreter) nicht später als fünf (5) Werktage vor dem Tag der betreffenden Hauptver-
sammlung eingereicht werden. Vollmachten und Stimmzettel bezüglich solcher Hauptversammlungen müssen zur gleichen
Zeit übermittelt werden. Der Verwaltungsrat kann einen kürzeren Zeitraum für die Übermittlung der Zertifikate sowie
der Vollmachten oder Stimmzetteln festlegen.

9.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person bevoll-

mächtigt.

9.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme durch eine Stimmkarte abgeben, welche per Post oder Fax an den Sitz der

Gesellschaft  oder  an  den  in  der  Einberufung  genannten  Vertreter  gesendet  wird.  Die  Aktionäre  können  nur  solche
Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, deren Inhalt durch den Verwaltungsrat
bestimmt wird.

9.6 Der Verwaltungsrat kann in der Einberufung weitere Bedingungen festlegen, die ein Aktionär zur Teilnahme an

einer Versammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht begrenzt auf längere Mitteilungsfristen).

Art. 10. Quorum und Stimmrecht.
10.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.
10.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in

einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit
einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von 62 dem dabei vertretenen Anteil am Gesell-
schaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

10.3 Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.
10.4 Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die

mindestens zwei Drittel (2/3) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) eine Änderung dieser Satzung;
(ii) die Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
(iii) eine Änderung des Gesellschaftskapitals oder die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von Aktien (sofern nicht

über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen); und

(iv) eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals oder die Einziehung oder der Rückkauf von Aktien durch die Gesell-

schaft.

Für die Änderung von Rechten einer Aktienklasse bedarf es zusätzlich zu den Voraussetzungen des vorhergehenden

Satzes der Zustimmung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel (2/3) aller Aktien der betreffenden Klasse halten.

Die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von anderen Wertpapieren als Aktien in der Gesellschaft oder die Bewilligung

von Optionen oder Bezugsrechten oder die Umwandlung jeglicher Instrumente in Aktien oder andere Sicherheiten der
Gesellschaft (sofern nicht über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen),
erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz dieses Artikels 10.4 festgelegten Mehrheit.

Beschlüsse der Hauptversammlung hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktio-

nären, die mehr als fünfzig Prozent (50%) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

24377

L

U X E M B O U R G

(i) die Genehmigung von gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüssen der Gesellschaft und konsolidierten Konzernab-

schlüssen;

(ii) die Auszahlung oder die Festsetzung von Dividenden oder anderen Ausschüttungen durch die Gesellschaft; und
(iii) die Ernennung oder die Neubesetzung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft.
Der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung von (a) stillen Beteiligungen und Unterbeteiligungen an der Gesell-

schaft oder (b) Unternehmensverträgen der Gesellschaft im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)
erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz des Artikels 10.4 dieser Satzung festgelegten Mehrheit.

D. Geschäftsführung

Art. 11. Verwaltungsrat.
11.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden

Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschafts-
zwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung
der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

11.2 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung

der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, oder einer oder mehreren durch den Verwaltungsrat
dazu befugten Personen mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberu-
fung und ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

11.3 Der Verwaltungsrat kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.
11.4 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat

wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen stellvertretenden Vorsit-
zenden und einen Schriftführer ernennen, der weder Aktionär, noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 12. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.
12.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der in einer Hauptversammlung vertretenen Aktien ernannt. Ein Verwaltungsrats-
mitglied kann jederzeit und ohne Grund und vorherige Mitteilung von der Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher
Mehrheit der vertretenen Aktien abberufen werden.

12.2 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen

Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch eine von den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern ernannte
Person bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die endgültige Neubesetzung entscheidet, vo-
rübergehend ausgefüllt werden.

Art. 13. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse.
13.1 Der Verwaltungsrat beschließt seine Geschäftsordnung in einem Beschluss und stellt diese in schriftlicher Form

auf.

13.2 Der Verwaltungsrat richtet einen Prüfungsausschuss (der „Prüfungsausschuss“), einen Nominierungsausschuss

(der „Nominierungsausschuss“) und einen Vergütungsausschuss (der „Vergütungsausschuss“) ein. Der Verwaltungsrat
kann des Weiteren einen oder mehrere weitere Ausschüsse einrichten (ist aber nicht dazu verpflichtet, es sei denn, dies
ist gesetzlich vorgeschrieben). Der Verwaltungsrat bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zuständigkeiten sowie
die Verfahrensweisen und andere Regeln, die für alle eingerichteten Ausschüsse gelten, soweit anwendbar.

13.3 Die Zuständigkeiten und die Organisation des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Ver-

gütungsausschusses  werden  durch  den  Verwaltungsrat  ausdrücklich  in  einer  Charter  für  jeden  dieser  Ausschüsse
festgelegt. Der Verwaltungsrat kann zudem allgemeine Grundsätze und einen Verhaltenskodex für die Gesellschaft und
ihre Unternehmensgruppe festlegen.

13.4 Prüfungsausschuss: der Prüfungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der Ver-

waltungsrat ernennt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsitzenden
des Prüfungsausschusses. Der Zweck des Prüfungsausschusses ist (i) die Überwachung der Rechnungslegungs- und Fi-
nanzberichterstattung  (reporting)  der  Gesellschaft,  der  Abschlussprüfung  der  Gesellschaft,  die  interne  Kontrolle  der
Gesellschaft und Empfehlung des Wirtschaftsprüfers (réviseur d’entreprises agréé) der Gesellschaft an den Verwaltungs-
rat;  und  (ii)  die  Einhaltung  anderer  Verpflichtungen,  welche  ihm  nach  anwendbarem  Recht  zukommen  und  ggf.  die
Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln,
sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem
Prüfungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder
des Prüfungsausschusses können von der Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses erhalten.

13.5 Nominierungsausschuss: der Nominierungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen

und der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Nominierungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder
als Vorsitzenden des Nominierungsausschusses. Der Zweck des Nominierungsausschusses ist (i) die Unterstützung des
Verwaltungsrats bei der Erfüllung der Verpflichtungen des Verwaltungsrats hinsichtlich (a) der Identifizierung qualifizierter

24378

L

U X E M B O U R G

Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, (b) der Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat
zur Auswahl von Kandidaten für die Wahl als Verwaltungsratsmitglied bei der nächsten jährlichen Hauptversammlung
(oder  außerordentlichen  Hauptversammlung,  bei  welcher  Verwaltungsratsmitglieder  ernannt  werden  sollen),  (c)  der
Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat zur Auswahl von Kandidaten zur Besetzung von freien Stellen beim
Verwaltungsrat und den Ausschüssen, (d) der Zuweisung und dem turnusgemäßen Wechsel von Verwaltungsratsmitglie-
dern in verschiedene Ausschüsse, (e) der Überwachung der Beurteilung des Verwaltungsrats und seiner verschiedenen
Ausschüsse, und (f) der Unterstützung bei der Auswahl von Kandidaten als künftige Führungskräfte sowie bei der Beför-
derung und dem Positionswechsel von Führungskräften; und (ii) die Einhaltung anderer Verpflichtungen, welche ihm nach
anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der
Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat
betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Nominierungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung
seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses können von der Gesellschaft eine Ver-
gütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten.

13.6 Vergütungsausschuss: der Vergütungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der

Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Vergütungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsit-
zenden des Vergütungsausschusses. Der Zweck des Vergütungsausschusses ist (i) die Entlastung oder Unterstützung des
Verwaltungsrats bei der Erfüllung seiner Pflichten hinsichtlich der Überprüfung und Genehmigung der Bonusprogramme
und der Vergütung der Führungskräfte der Gesellschaft (einschließlich der Tochtergesellschaften der Gesellschaft), ein-
schließlich der Erstellung (in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat), Beurteilung und Geneh-
migung der Vergütungspläne, der Vergütungspolitik und Bonusprogramme der Gesellschaft und (ii) die Einhaltung anderer
Verpflichtungen, welche ihm nach anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an
welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit
denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Vergütungsausschuss die notwendigen Mittel
und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses können von der
Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Vergütungsausschusses erhalten.

13.7 Der Verwaltungsrat kann insbesondere Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax,

E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen, vorausgesetzt, dass alle Verwaltungsratsmitglieder an
diesem Beschluss teilnehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustimmung auf einem oder mehreren Doku-
menten getrennt erteilen. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 14. Geschäfte mit Dritten.
14.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2)

beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en), der
(denen) eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

14.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder

Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der(denen) diese Vollmacht übertragen wurde.

Art. 15. Entschädigung.
15.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nicht persönlich für die Schulden oder sonstigen Verpflichtungen der

Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie für die Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich. Vorbehaltlich zwing-
ender gesetzlicher Vorschriften soll jede Person, die Mitglied des Verwaltungsrats oder sonstiger Mandatsträger der
Gesellschaft ist oder war, im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Maße durch die Gesellschaft von jeglicher Haftung
oder von angemessenen Kosten freigestellt werden, die im Zusammenhang mit Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder
sonstigen Verfahren, in die die betreffende Person als Partei oder in sonstiger Weise aufgrund ihres bestehenden oder
ehemaligen Mandatsverhältnisses mit der Gesellschaft involviert ist oder war, oder im Zusammenhang mit der Begleichung
oder Beseitigung derselben, eintreten. Die Begriffe „Anspruch“, „Rechtsmittel“, „Klage“ oder sonstigen „Verfahren“ er-
fassen sämtliche bestehenden oder drohende Ansprüche, Rechtsmittel, Klagen oder sonstige Verfahren (ob zivilrechtli-
cher, strafrechtlicher oder sonstiger Natur, einschließlich in weiteren Instanzen), und die Worte „Haftung“ und „Kosten“
sollen ohne Einschränkung Anwaltskosten, Unkosten, Urteile, zu Begleichungsoder Vergleichszwecken gezahlte Beträge
und sonstige Verbindlichkeiten umfassen.

15.2 Ein Verwaltungsratsmitglied soll nicht entschädigt werden, wenn (i) die Haftung des Verwaltungsratsmitglieds

gegenüber  der  Gesellschaft  oder  den  Aktionären  aus  vorsätzlicher,  arglistiger,  grob  fahrlässiger  oder  rücksichtsloser
Verletzung der Mandatspflichten entstand, (ii) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, bezüglich welcher das be-
treffende Verwaltungsratsmitglied wegen arglistigem und nicht im Interesse der Gesellschaft liegenden Handeln rechts-
kräftig verurteilt wurde, oder (iii) es sich um Zahlungen aus einem Vergleich handelt, sofern nicht durch ein zuständiges
Gericht oder durch den Verwaltungsrat bestätigt.

15.3 Das Recht auf Entschädigung ist individuell, es berührt in keiner Weise sonstige gegenwärtige oder zukünftige

Rechte eines Verwaltungsratsmitglieds und besteht einmal entstanden fort, auch wenn die betreffende Person in der Folge
nicht länger Verwaltungsratsmitglied ist, und kommt seinen Erben, dem Testamentsvollstrecker und dem Verwalter zu-
gute.  Keine  der  hierin  enthaltenen  Bestimmungen  soll  etwaige  vertragliche  oder  sonstige  gesetzlich  vorgesehene
Entschädigungsrechte von Angestellten, Verwaltungsratsmitgliedern oder Mandatsträgern beschränken oder berühren.

24379

L

U X E M B O U R G

Die Gesellschaft ist ausdrücklich befugt, vertragliche Entschädigungen an Angestellte, einschließlich Verwaltungsratsmit-
glieder oder Mandatsträger der Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu gewähren.

15.4 Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung von Ansprüchen, Rechtsmitteln,

Klagen oder sonstigen Verfahren im Sinne dieses Artikels 15 sollen, vor der endgültigen Entscheidung über ihre Erstat-
tungsfähigkeit,  von  der  Gesellschaft  vorgestreckt  werden,  sofern  sich  der  betreffende  leitende  Angestellte  oder  das
Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese an die Gesellschaft zurück zu erstatten, sollte sich
im Nachhinein herausstellen, dass dem betreffenden Mandatsträger oder dem Verwaltungsratsmitglied kein Entschädi-
gungsanspruch gemäß dieses Artikels zusteht.

Art. 16. Interessenkonflikt.
16.1 Soweit gesetzlich erforderlich hat jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einer Transaktion, die dem Verwal-

tungsrat  zur  Entscheidung  vorliegt,  direkt  oder  indirekt  ein  persönliches  Interesse  hat,  welches  den  Interessen  der
Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt zu informieren und dafür zu sorgen, dass
die Erklärung im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen wird. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf
weder an der Beratung über die in Frage stehend Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Über einen solchen
Interessenkonflikt ist auf der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten.

16.2 Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird

durch die Tatsache, dass ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einer solchen Gesellschaft oder Firma
hat oder durch die Tatsache, dass er Verwaltungsratsmitglied, Partner, leitender Angestellter, Vertreter, Berater oder
Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist, beeinflusst oder ungültig.

E. Wirtschaftsprüfer

Art. 17. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.
17.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sind von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschafts-

prüfern (réviseurs d’entreprises agréés), die von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats (welcher
selbst auf Vorschlag des Prüfungsausschusses handelt) ernannt werden, zu prüfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre
bestimmt die Anzahl des/der Wirtschaftsprüfer/s und ihre Amtszeit.

17.2 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann jederzeit mit Grund (oder mit seiner Zustimmung) durch die Haupt-

versammlung der Aktionäre abberufen werden. Ein zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann wiederernannt
werden.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 18. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 19. Gewinne.
19.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit

den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Ver-
lustrechnung.

19.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals beträgt.

19.3 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wie der verbleibende

jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll. Jede Aktie erhält den gleichen Betrag.

19.4 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der

gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rück-
lage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals nicht
übersteigt.

19.5 Werden Aktien von einer Verwahrungsstelle gehalten, so tätigt die Gesellschaft Dividendenzahlungen oder andere

Barzahlungen, durch Aktien oder andere Wertpapiere nur an die im Aktienregister benannte Verwahrungsstelle im Ein-
klang mit ihren Anweisungen, und eine solche Zahlung befreit die Gesellschaft von jeglichen Verpflichtungen in dieser
Angelegenheit.

19.6 Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht wurden, fallen an die Gesell-

schaft zurück.

Art. 20. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
20.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden aus-

zahlen.

20.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

24380

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 21. Liquidation.
21.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt,

welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt
und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquida-
toren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten
der Gesellschaft.

21.2 Sofern nicht anders in dieser Satzung festgelegt, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung

der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft
gehaltenen Aktien verteilt.

H. Anwendbares recht

Art. 22. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des

Gesetzes von 1915.“

<i>Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Annahme der Rücktritte von Herrn Ulrich Binninger, Herrn

Christian Senitz und Herrn Alexander Kudlich als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung und
die vollständige Entlastung für die Ausübung ihrer Mandate.

<i>Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die Ernennung der folgenden Personen als weitere Verwaltungsrats-

mitglieder der Gesellschaft bis zur Jahreshauptversammlung der Aktionäre, die im Jahre 2016 abgehalten wird:

(i) Herr Alexis Babeau, geboren am 10. Dezember 1964, wohnhaft in Via Zorzi 30, 6900 Paradiso, Schweiz;
(ii) Herr Christoph Barchewitz, geboren am 10. September 1978 in Wiesbaden, Deutschland, wohnhaft in 3, Burlington

Gardens, London W1S 3EP, Vereinigtes Königreich;

(iii) Herr Scott Collins, geboren am 26. Juni 1965 in Ann Arbor, Michigan, USA, wohnhaft in 3, Old Burlington Street,

rd

 Floor, London W1S 3AE, Vereinigtes Königreich;

(iv) Frau Maggie Fanari, geboren am 16. Juli 1979 in Edmonton, Kanada, wohnhaft in 5650 Yonge Street, Toronto,

Ontario M2M4H5, Kanada;

(v) Herr Lorenzo Grabau, geboren am 19. August 1965 in Rom, Italien, wohnhaft in c/o Investment AB Kinnevik, P.O.

Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Schweden;

(vi) Herr Jens Grede, geboren am 25. Februar 1978 in Balinge, Schweden, wohnhaft in 17 Claremont Square London

N1 9LY, Vereinigtes Königreich;

(vii) Herr Daniel Grossman, geboren am 5. März 1971 in Antwerpen, Belgien, wohnhaft in Avenue de Sumatra 12,

B-1180 Brüssel, Belgien;

(viii) Herr Peter Kimpel, geboren am 10. Juni 1968 in Freiburg im Breisgau, Deutschland, wohnhaft in Johannisstrasse

20, 10117 Berlin, Deutschland;

(ix) Herr Oliver Samwer, geboren am 9. September 1972 in Köln, Deutschland, wohnhaft in Johannisstrasse 20, 10117

Berlin, Deutschland;

(x) Herr Daniel Shinar, geboren am 22. Juni 1981 in Israel, wohnhaft 3, Azrieli Center, Triangular Tower 45 

th

 Floor

Tel-Aviv 67023, Israel; und

(xi) Herr Christian Winter, geboren am 17. November 1971 in Dortmund, wohnhaft in Hevener Str. 64, 44797 Bo-

chum, Deutschland.

Der Verwaltungsrat ist nunmehr wie folgt zusammengesetzt:
- Herr Alexis Babeau;
- Herr Christoph Barchewitz;
- Herr Scott Collins;
- Frau Maggie Fanari;
- Herr Lorenzo Grabau;
- Herr Daniel Grossman;
- Herr Jens Grede;
- Herr Peter Kimpel;
- Herr Oliver Samwer;
- Herr Daniel Shinar; und
- Herr Christian Winter.

24381

L

U X E M B O U R G

<i>Erklärung

Die Hauptversammlung der Aktionäre erklärt hiermit, dass die unter 1 bis 57 aufgelisteten Einlagen, bestehend aus

allen sechsundneunzigtausendfünfhundertfünfundneunzig (96.595) Aktien der Bigfoot, vorbenannt, die Bigfoot Contribu-
tion gemäß des Gründungsaktes der Gesellschaft vom 1. Oktober 2014 darstellen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist, wird die Versammlung geschlossen.

<i>Kosten

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr 7.300,- EUR, geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, in der Amtsstube des amtierenden Notars, Datum wie eingangs

erwähnt.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist den erschienenen Parteien, welche dem Notar mit Namen, Vornamen und Wohnsitz

bekannt sind, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesen erschienenen Parteien unterzeichnet worden.

Signé: A. OLLIGES, E. MEDAGLI, L. A. A. ENRIQUEZ, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62723. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 02 janvier 2014.

Référence de publication: 2015010623/1625.
(150012003) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 janvier 2015.

LSF6 Lux Investments I S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 221.750,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 137.049.

Le 7 janvier 2015, l'associé unique de la Société (i) a pris acte de la démission de M. Michael Duke Thomson, en tant

que gérant A de la Société, avec effet au 31 décembre 2014 et (ii) a approuvé la nomination comme gérant A de la Société,
avec effet au 1 

er

 janvier 2015, de:

-  M.  Patrick  Steinhauser, né le  21 avril  1975  à Baden-Baden  (Allemagne), résidant professionnellement à l'Atrium

Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

Il résulte de ce qui précède, qu'avec effet au 1 

er

 janvier 2015, le conseil de gérance de la Société est constitué des

gérants A suivants, élus pour une durée indéterminée:

- M. Patrick Steinhauser, gérant A;
- M. Philippe Detournay, gérant A; et
- M. Philippe Jusseau, gérant A.

<i>Conseil de gérance:

- M. Patrick Steinhauser, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

- M. Philippe Detournay, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A; et

- M. Philippe Jusseau, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 janvier 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015009938/29.
(150010687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

24382

L

U X E M B O U R G

ECP International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 13, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 129.000.

Je soussigné, vous notifie par la présente et prie de bien vouloir accepter ma démission avec effet immédiat, de mes

fonctions d'administrateur de votre société.

Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Federico Franzina.

Référence de publication: 2015011961/10.
(150013724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 janvier 2015.

CoBzz S.à r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Simply Solutions, S.à r.l.).

Siège social: L-1511 Luxembourg, 195, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 148.363.

L’an deux mil quatorze, le trente-et-un décembre.
Pardevant Maître Karine REUTER, notaire de résidence à Pétange.

A comparu:

Madame Alix Marie Madeleine VAN ORMELINGEN, salariée, née le 21 décembre 1977 à Uccle (Belgique), demeurant

à L-1511 Luxembourg, 195 Avenue de la Faïencerie.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
Madame Alix Marie Madeleine VAN ORMELINGEN est l’associée unique de la société à responsabilité limitée
Simply Solutions S.à r.l.
établie et ayant son siège social à L-4002 Esch-sur-Alzette, 66 rue de Luxembourg,
constituée suivant acte reçu par Maître Christine DOERNER, notaire de résidence à Bettembourg en date du 9 sep-

tembre 2009, publiée au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés en date du 20 octobre 2009, numéro 2051, page 98443,
inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B 148.363.

En sa qualité d’associée unique de la dite société, la partie comparante a pris les résolutions suivantes:

<i>Première Résolution

L’associée unique constate qu’il y a une erreur matérielle dans les statuts initiaux en ce qui concerne la valeur nominale

des parts sociales. L’associée unique décide de procéder à cette modification, la valeur nominale des parts étant de douze
euros cinquante cents (12,50 €) et par conséquent de modifier l’article 4 des statuts pour lui conférer dorénavant la
teneur suivante:

«Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500,00 €), représenté par mille parts (1.000) de douze

euros et cinquante cents (12,50 €) chacune.»

<i>Deuxième Résolution

L’associée unique décide de changer la dénomination sociale de la société en «CoBzz S.à.r.l.» et décide par conséquent

de modifier l’article 1 

er

 des statuts pour lui conférer dorénavant la teneur suivante:

«  Art. 1 

er

 .  La société a la forme d’une société à responsabilité limitée sous la dénomination de CoBzz S.à.r.l. et a

son siège sur le territoire de la Commune de Luxembourg»

<i>Troisième Résolution

L’associée unique décide de transférer le siège social de la société à L-1511 Luxembourg, 195 avenue de la Faïencerie.

<i>Quatrième Résolution

L’associée unique décide de modifier l’objet social de la société et par conséquent de modifier l’article 2 des statuts

pour leur conférer dorénavant la teneur suivante:

« Art. 2. La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, la prestation de

services et de conseils, la mise en relation, l’intermédiation, en gestion d'entreprises, en stratégie, communication et
organisation, en conseil et développement, tant aux entreprises qu'aux particuliers ceci autant au Grand-Duché de Lu-
xembourg qu'à l’étranger ainsi que toutes prestations de services annexes ou complémentaires en matière industrielle,
commerciale, mobilière et immobilière directement et indirectement liées à cet objet.

Elle a également pour objet, l’achat, vente, location de tous produits en général dont l’activité n'est pas réglementée.»

24383

L

U X E M B O U R G

<i>Déclaration en matière de blanchiment

Le(s) associé(s) /actionnaires déclare(nt), en application de la loi du 12 novembre 2004, telle qu'elle a été modifiée par

la suite, être le(s) bénéficiaire(s) réel(s) de la société faisant l’objet des présentes et certifient que les fonds/biens/droite
servant à la libération du capital social ne proviennent pas respectivement que la société ne se livre(ra) pas à des activités
constituant une infraction visée aux articles 506-1 du Code Pénal et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie (blanchiment) ou des actes de terrorisme tels
que définis à l’article 135-1 du Code Pénal (financement du terrorisme).

<i>Evaluation des frais

Le montant des frais, dépenses et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à

sa charge à raison du présent acte, s'élèvent à la somme de MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (1.350,-€). A
l’égard du notaire instrumentant, toutes les parties comparantes et / ou signataires des présentes reconnaissent être
solidairement tenues du paiement des frais, dépenses et honoraires découlant des présentes.

DONT ACTE, fait et passé à Pétange, date qu’en tête des présentes.
Après lecture faite et interprétation donnée au représentant de la comparante, connu du notaire par nom, prénom

usuel, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

Signés: A.M.M. VAN ORMELINGEN, K. REUTER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 19 janvier 2015. Relation: EAC/2015/1391. Reçu cent cinquante euros 150,-

<i>Le Receveur

 (signé): M. HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME.

PETANGE, le 20 janvier 2015.

Référence de publication: 2015011643/64.
(150012727) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 21 janvier 2015.

LSF7 Silverstone S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 151.008.

Le 7 janvier 2015, l'associé unique de la Société (i) a pris acte de la démission de M. Michael Duke Thomson, en tant

que gérant A de la Société, avec effet au 31 décembre 2014 et (ii) a approuvé la nomination comme gérant A de la Société,
avec effet au 1 

er

 janvier 2015, de:

-  M.  Patrick  Steinhauser, né le  21 avril  1975  à Baden-Baden  (Allemagne), résidant professionnellement à l'Atrium

Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duché de Luxembourg.

Il résulte de ce qui précède, qu'avec effet au 1 

er

 janvier 2015, le conseil de gérance de la Société est constitué des

gérants A suivants, élus pour une durée indéterminée:

- M. Patrick Steinhauser, gérant A;
- M. Philippe Detournay, gérant A; et
- M. Philippe Jusseau, gérant A.

<i>Conseil de gérance:

- M. Patrick Steinhauser, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

- M. Philippe Detournay, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A; et

- M. Philippe Jusseau, résidant professionnellement à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070

Bertrange, Grand Duché de Luxembourg, Gérant A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Le 7 janvier 2015.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2015009940/29.
(150010685) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 janvier 2015.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

24384


Document Outline

Callaway Invest S.A.

CapLinden S.A., Société de Gestion de Patrimoine Familial - SPF

Celistics Luxembourg S. à r.l.

CoBzz S.à r.l.

Colorado S.à r.l.

Eastpharma S.à r.l.

Eastpharma S.à r.l.

Ecotechnology International S.A.

ECP International S.A.

ECP International S.A.

Emeraude Participations S.A.

Emerging Energy S.A.

Esther Seven S.à r.l.

FinAcc

First Financial S.A.

Fleet Holdings S.A.

Foxitec S.A. SPF

Garage Rodenbourg S.à r.l.

gategroup Financial Services S.à r.l.

Geogare 2

Geoholding

Global Fashion Holding S.A.

Golden Park Hotel Holding S.A.

Grace Lodge Care Investments S.à r.l.

Gresham Holding S.A.

Group Lumina SICAV SIF

HF Immobilier S.A.

Landscape Internet Active Server Europe S.à r.l.

Longitude Library Holdings S.à r.l.

LSF6 Lux Investments I S. à r.l.

LSF7 Silverstone S.à r.l.

LuxcoSITQ 6

Luxembourg Investment Company 31 S.à.r.l.

Munsterfred Property S.à r.l.

Mylan Luxembourg 7 S.à r.l.

QSI Finance II (Lux) S.à r.l.

Quorum Licensing Luxco S.à r.l.

Simply Solutions, S.à r.l.

Techno Services S.A.

TTG Cayuga Bavaria Holdco S.à r.l.

Valauchanrus Sopaneer S.C.A.

Valoris 1

VBTECH S.A.

Wood Industries S.à r.l.