This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 405
13 février 2015
SOMMAIRE
Belmond Lux Treasury S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19418
BRP Luxembourg Holdings I . . . . . . . . . . . .
19423
Cofima I S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19403
Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19402
Diplomatic Finance Association Internatio-
nal S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19400
Dome Capital S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19400
Donatello Sicav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19400
DSM Lux GmbH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19399
DS Turkey 8 S. à r. l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19397
Ebony Finance S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19398
Eco-Immo s.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19401
Econocom Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . .
19397
EDI Construction S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19402
Eggborough HoldCo 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . .
19398
Else 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19399
Else 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19398
Elvafin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19394
EMM Euromultimédia S.A. . . . . . . . . . . . . . .
19394
EMM Euromultimédia S.A. . . . . . . . . . . . . . .
19395
EMM Euromultimédia S.A. . . . . . . . . . . . . . .
19395
Ennis S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19396
Enoc S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19396
Enterprise Systems Technologies S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19394
Entreprise de Façades Miotto Romain et
Fils Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19397
Envipro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19396
Equinix (Luxembourg) Investments S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19394
ERA-GDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19396
Escalion S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19399
Eschersheimer Landstrasse 19-21 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19399
Eurofins Analyses Environnementales pour
les Industriels France LUX Holding . . . . .
19395
Eurofins Analyses pour la Construction
France LUX Holding . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19395
Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à
r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19395
EVI UK Holding S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19434
Evo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19420
Façonnable S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19424
Faneos Invest S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19401
First State Investments Fund Management
S. à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19401
FR Group Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
19404
General Mills Luxembourg One S.à r.l. . . .
19417
Haro S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19396
Itaú Funds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19433
Limba Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19394
LVS Luxembourg I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . .
19433
M.C. Facades S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19440
Munsterfred Property S.à r.l. . . . . . . . . . . . .
19401
Nade Luxco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19424
Neptune Properties S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
19423
Sethial S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19419
19393
L
U X E M B O U R G
Elvafin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1538 Luxembourg, 2, place de France.
R.C.S. Luxembourg B 24.996.
Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015007894/10.
(150008679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
EMM Euromultimédia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 50.278.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015007895/10.
(150008352) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Limba Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 178.880.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Limba Luxco 2 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015008142/11.
(150008787) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Equinix (Luxembourg) Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 38.359.551,65.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 43, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 157.466.
Les comptes annuels consolidés de la maison mère au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce
et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 Janvier 2015.
Référence de publication: 2015007867/11.
(150008728) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Enterprise Systems Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2529 Howald, 45, rue des Scillas.
R.C.S. Luxembourg B 175.518.
Les comptes annuels au 30 septembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
IF CORPORATE SERVICES
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg
Signature
Référence de publication: 2015007863/12.
(150008442) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19394
L
U X E M B O U R G
EMM Euromultimédia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 50.278.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015007896/10.
(150008353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
EMM Euromultimédia S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 50.278.
Les comptes annuels clos au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015007897/10.
(150008354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 165.607.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2014.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015007871/11.
(150009464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 192.284.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 18 décembre 2014.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015007873/11.
(150009391) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding, Société à responsabilité
limitée.
Siège social: L-1526 Luxembourg, 23, Val Fleuri.
R.C.S. Luxembourg B 165.609.
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 22 décembre 2014.
Pour statuts coordonnés
Référence de publication: 2015007872/12.
(150009463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19395
L
U X E M B O U R G
ERA-GDL, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1741 Luxembourg, 149, rue de Hollerich.
R.C.S. Luxembourg B 61.816.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015007907/9.
(150009374) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Enoc S.A., Société Anonyme,
(anc. Haro S.A.).
Siège social: L-4831 Rodange, 88, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 81.176.
<i>Extrait de la résolution prise lors de l'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2014i>
L'Assemblée a révoqué Mr. Brice Robinot de son poste d'administrateur unique avec effet immédiat.
L'Assemblée a décidé de nommer Mr. Christian Robinot, demeurant à L-4220 Esch-sur-Alzette, 20, rue de Luxem-
bourg, au poste d'administrateur unique pour une période indéterminée.
Référence de publication: 2015007902/11.
(150008683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Envipro S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 54.854.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 7 janvier 2015 que:
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt,
L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 14 janvier 2015.
<i>Pour la société ENVIPRO S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015007904/14.
(150008422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Ennis S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 122.836.
EXTRAIT
En date du 13 janvier 2015, l'associé unique de la Société, a pris les résolutions suivantes:
- la démission de Erik Johan Cornelis Schoop en tant que gérant de la Société, est acceptée avec effet au 09 janvier
2015;
- Christian Schwab, né à Duisburg, Allemagne le 11 janvier 1971, avec adresse professionnelle au 15, rue Edward
Steichen, L-2540 Luxembourg, est nommé nouveau gérant de la Société avec effet au 09 janvier 2015 et pour une durée
indéterminée.
A compter du 09 janvier 2015, le conseil de gérance se compose comme suit:
- Virginia Strelen, gérant;
- Christian Schwab, gérant;
Pour extrait conforme.
Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Référence de publication: 2015007901/20.
(150008837) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19396
L
U X E M B O U R G
Entreprise de Façades Miotto Romain et Fils Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9142 Burden, 26, Um Kettenhouscht.
R.C.S. Luxembourg B 172.882.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2015007903/14.
(150008326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
DS Turkey 8 S. à r. l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 145.478.
En date du 15 décembre 2014 et avec effet immédiat, Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guil-
laume Kroll, L-1882 Luxembourg, a démissionné de son mandat de gérant de la société DS TURKEY 8 Sàrl, avec siège
social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le
numéro B 145478.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Alter Domus Luxembourg S.à r.l.
<i>Mandaté par le démissionnairei>
Référence de publication: 2015007850/15.
(150008310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Econocom Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 25.950.
<i>Extrait du procès-verbal des décisions de l'actionnaire unique en date du 4 novembre 2014 à Zaventemi>
L'actionnaire unique décide d'accepter la démission de Monsieur Charles de Stoop, Hunsberg, né le 17 janvier 1972 à
Kortrijk en Belgique et résidant au 105, Hunsberg, 1785 Merchtem, Belgique, en qualité d'administrateur de la Société
avec effet immédiat.
L'actionnaire unique décide de nommer en remplacement de Monsieur Charles de Stoop, Monsieur Lionel Le Camus,
né le 11 novembre 1972 à Versailles en France et résidant 4, Rue d'Arlon, 8399 Windhof, Luxembourg, en qualité d'ad-
ministrateur, jusqu'à l'échéance du mandat de celui-ci, soit jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2018.
L'actionnaire unique décide de nommer Monsieur Philippe-Hervé Hoffman, né le 19 septembre 1963 à Lille en France
et résidant 4, Rue d'Arlon, 8399 Windhof, Luxembourg en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat.
L'actionnaire unique décide que son mandat prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017
statuant sur les comptes 2016.
<i>Extrait du procès-verbal du conseil d'administration en date du 19 décembre 2014 à Zaventemi>
Le Président informe les membres présents de la proposition de nomination de Monsieur Philippe-Hervé Hoffman, né
le 19 septembre 1963 à Lille en France et résidant à 4, Rue d'Arlon, 8399 Windhof, Luxembourg en qualité d'Adminis-
trateur délégué.
Cette proposition est acceptée à l'unanimité. Monsieur Philippe-Hervé Hoffman exercera ses fonctions jusqu'à
l'échéance de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2017 statuant sur
les comptes 2016.
Référence de publication: 2015008865/25.
(150009809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
19397
L
U X E M B O U R G
Else 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.601.
<i>Extrait des résolutions des associés prises en date du 16 janvier 2015i>
Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Neil Hasson en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2014.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015008848/12.
(150010295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Ebony Finance S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2450 Luxembourg, 15, boulevard Roosevelt.
R.C.S. Luxembourg B 168.757.
EXTRAIT
Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue au siège social le 7 janvier 2015 que:
- les titres au porteur de la société sont déposés auprès de Roosevelt Services S.A., domiciliée 15, boulevard Roosevelt,
L-2450 Luxembourg.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
<i>Pour la société EBONY FINANCE S.A.
i>FIDUCIAIRE FERNAND FABER
Référence de publication: 2015008864/14.
(150009818) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Eggborough HoldCo 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 49.986,90.
Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.
R.C.S. Luxembourg B 152.042.
<i>Extrait rectificatif du dépôt L150008987i>
L'associé unique de la Société, par résolutions écrites datées du 16 janvier 2015 et avec effet immédiat, a décidé:
1 d'accepter la démission de Peter COLEMAN et Jason CLARKE en tant que gérants de catégorie A de la Société et
de Julien GOFFIN, Hugo FROMENT et Christoph TSCHEPE en tant que gérants de catégorie B de la Société.
2 de nommer
- M. Marek SPURNÝ, né le 20 novembre 1974 à Olomouc (République Tchèque), résidant professionnellement au
Parížská 26, Prague, 110 00, République Tchèque en tant que gérant de catégorie A de la Société pour une période
indéfinie;
- Mme Sharon CALLAHAN, née le 19 octobre 1969 à New York (Etats-Unis d'Amérique), résidant professionnelle-
ment au 20, rue de la Poste, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la
Société pour une période indéfinie; et
- M. Phillip WILLIAMS, né le 22 octobre 1968 à Carmarthen (Royaume-Uni), résidant professionnellement au 20, rue
de la Poste, L-1536 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B de la Société pour
une période indéfinie.
Dès lors, le conseil de gérance de la Société est composé de la manière suivante:
- M. Marek SPURNÝ, gérant de catégorie A;
- Mme Sharon CALLAHAN, gérant de catégorie B; et
- M. Phillip WILLIAMS, gérant de catégorie B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Eggborough HoldCo 2 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015008846/28.
(150010034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
19398
L
U X E M B O U R G
DSM Lux GmbH, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 6, Beelerstrooss.
R.C.S. Luxembourg B 96.497.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2015008840/10.
(150010299) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Eschersheimer Landstrasse 19-21 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 41, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 179.791.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Eschersheimer Landstrasse 19-21 S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015008853/10.
(150009714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Else 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 129.586.
<i>Extrait des résolutions des associés prises en date du 16 janvier 2015i>
Les associés de la Société ont décidé comme suit:
- d'accepter la démission de Neil Hasson en tant que gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2014.
Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Référence de publication: 2015008847/12.
(150010296) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Escalion S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 180.273.
<i>Extrait suite à la cession de parts sociales du 25 septembre 2014i>
Il résulte du contrat de transfert de parts sociales, daté du 25 septembre 2014, que les parts sociales de la Société ont
été transférées avec effet immédiat de la manière suivante:
- TwiniQ BV, une «besloten vennootschap» constituée et régie selon les lois des Pays-Bas et ayant son siège social au
120, Water Acker, 1965SX Heemskerk, Pays-Bas, immatriculée auprès du registre des sociétés «handelregisten» sous le
numéro 34391928, en tant que cédant, a cédé 750 parts sociales à Gattyan Group S.à r.l., une société à responsabilité
limitée constituée et régie selon les lois de Luxembourg, ayant son siège social au 44, Avenue J.F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180.190.
De sorte que, depuis le 25 septembre 2014, l'unique associé de la Société est Gattyan Group S.à r.l., tel que précité.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Fait à Luxembourg, le 02 octobre 2014.
<i>Pour la Société
i>Signature
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015008852/22.
(150009973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
19399
L
U X E M B O U R G
Dome Capital S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 34.242,00.
Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.
R.C.S. Luxembourg B 124.842.
- En vertu de l'acte de transfert des parts qui a pris effet à partir de 20 octobre 2014,
Dome Group Guarantee Company Limited a transféré 17.121 parts sociales détenues dans la Société à GI Partners
Fund II L.P., ayant son siège social à 160 Greentree Drive, Suite 101, Kent County, Dover, Delaware 19904, Etats-Unis
d'Amérique.
- Les parts sociales de la Société sont réparties comme suit:
* GI Partners Fund II L.P, 24.473 parts sociales
* GI Partners Side Fund II L.P., 9.769 parts sociales
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Référence de publication: 2015007818/17.
(150009099) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Donatello Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 19-21, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 106.552.
<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration du 5 Août 2014i>
En date du 5 Août 2014, le Conseil d'Administration a décidé de coopter, avec effet 5 Août 2014, Monsieur Ubaldo
Migliorati, demeurant professionnellement à L-1724 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 19-21 Boulevard du
Prince Henri, en qualité d’Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée ordinaire des Actionnaires, en remplacement
de Monsieur Edoardo Tubia, démissionnaire.
Certifié sincère et conforme
DONATELLO SICAV
Société Européenne de Banque
Société Anonyme
<i>Banque Domiciliataire
i>Signature
Référence de publication: 2015008838/18.
(150010094) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 janvier 2015.
Diplomatic Finance Association International S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 114.125.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration tenue le 9 janvier 2015i>
Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions aux porteur, le Conseil
d'Administration réuni à Luxembourg en date du 9 janvier 2015 a décidé de nommer la société anonyme A.T.T.C. Control
s.a. (RCS Luxembourg B 60319) avec siège social sis au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions de dépo-
sitaire agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.
<i>Administrateur / Administrateur
i>A.T.T.C. s.a. / A.T.T.C. s.a.
<i>Gérant / Gérant
i>N. Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015007817/19.
(150008937) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19400
L
U X E M B O U R G
Eco-Immo s.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-7481 Tuntange, 3, rue de Hollenfels.
R.C.S. Luxembourg B 170.599.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015007883/9.
(150008579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Munsterfred Property S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.
R.C.S. Luxembourg B 123.196.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Référence de publication: 2015008204/10.
(150009125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Faneos Invest S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.
R.C.S. Luxembourg B 187.765.
<i>Extrait des résolutions du conseil d'administration tenue le 9 janvier 2015i>
Conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions aux porteurs, le
Conseil d'Administration réuni à Luxembourg en date du 9 janvier 2015 a décidé de nommer la société anonyme A.T.T.C.
Control s.a. (RCS Luxembourg B 60319) avec siège social sis au 16, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, aux fonctions
de dépositaire agréé.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
A.T.T.C. s.a.
<i>Administrateur / Gérant
i>N. Patteet / K. Van Huynegem
<i>Administrateur-délégué / Administrateur-déléguéi>
Référence de publication: 2015007932/17.
(150008269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
First State Investments Fund Management S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: AUD 260.000,00.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.
R.C.S. Luxembourg B 128.117.
L'actionnaire unique de la Société a décidé par voie de résolution circulaire en date du 18 décembre 2014 de renouveler
le mandat de PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg en sa qualité
de réviseur d'entreprises agréé de la Société jusqu'aux prochaines résolutions de la Société qui statueront sur les comptes
annuels de la Société au 30 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Esch-sur-Alzette, le 15 janvier 2015.
<i>Pour FIRST STATE INVESTMENTS FUND MANAGEMENT S.à r.l.
i>Société à responsabilité limitée
RBC Investor Services Bank S.A.
Société anonyme
Référence de publication: 2015007939/18.
(150009323) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19401
L
U X E M B O U R G
EDI Construction S.A., Société Anonyme - Fonds d'Investissement Spécialisé.
Siège social: L-2732 Luxembourg, 2, rue Wilson.
R.C.S. Luxembourg B 158.077.
CLÔTURE DE LIQUIDATION
<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue à la société le 31 décembre 2014i>
L'assemblée a prononcé la clôture de la liquidation et a constaté que la société anonyme EDI CONSTRUCTION S.A.
- EN LIQUIDATION VOLONTAIRE a définitivement cessé d'exister.
L'assemblée a décidé que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une durée de cinq
années à partir d'aujourd'hui à son ancien siège social, à savoir le 2, rue Wilson; L - 2732 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait sincère et conforme
Gérard ESCALIER
<i>Le liquidateuri>
Référence de publication: 2015007885/17.
(150009423) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.
Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
R.C.S. Luxembourg B 193.626.
<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “Limited Partnership Agreement”) of Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp.,i>
<i>a special limited partnership, executed on 12 i>
<i>thi>
<i> January 2015i>
1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services XL (GP) S.à r.l., a société à responsabilité limitée
incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number in the process of being registered with the R.C.S. Luxembourg (the “General Partner”).
2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp. (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign
companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds)
and the provision through its foreign subsidiaries of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.
The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds
a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.
The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership
exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.
(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.
3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the
General Partner.
The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and
otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).
The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.
4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 12
th
January 2015, for an indefinite term.
19402
L
U X E M B O U R G
Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:
<i>Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement“) der Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp., eineri>
<i>Partnerschaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partnership), geschlossen am 12. Januar 2015i>
1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services XL (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, Eintragung
beim Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) wurde beantragt (die „Komplementä-
rin“).
2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp. (die „Gesellschaft“)
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-
schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen durch ausländische Tochtergesellschaften (im Bereich ECommerce bezüglich Waren und Dienstleistungen
jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistun-
gen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder
Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.
Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann
jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.
(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.
3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-
renden Komplementärin.
Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger
Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.
Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,
rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.
4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 12. Januar 2015 für eine unbegrenzte Dauer
gegründet.
Référence de publication: 2015007809/77.
(150009432) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Cofima I S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 76-78, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 116.302.
<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 29 décembre 2014i>
Le siège social de la société est transféré du 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg au 76-78 Grand Rue, L-1160
Luxembourg avec effet au 1
er
janvier 2015.
Pour extrait conforme
Luxembourg, le 13 janvier 2015.
Référence de publication: 2015006175/12.
(150006534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
19403
L
U X E M B O U R G
FR Group Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 61.862.138,20.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 12F, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 170.433.
In the year two thousand fourteen, on the ninth day of December,
before us Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,
there appeared:
(1) Montagu IV LP, a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, with registered office at 2, More
London Riverside, GB - SE1 2AP London and registered with the Companies House London under number LP014211
(“Montagu IV LP”),
hereby represented by Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 9, 2014;
(2) Montagu IV (Non-US) LP, a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, with registered office
at 2, More London Riverside, GB - SE1 2AP London and registered with the Companies House London under number
LP014367 (“Montagu IV (Non-US) LP”),
hereby represented by Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 9, 2014;
(3) Montagu IV (US) LP, a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, with registered office at
2, More London Riverside, GB - SE1 2AP London and registered with the Companies House London under number
LP014212 (“Montagu IV (US) LP”),
hereby represented by Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 9, 2014; and
(4) Montagu IV (B) LP, a limited partnership governed by the laws of the United Kingdom, with registered office at 2,
More London Riverside, GB - SE1 2AP London and registered with the Companies House London under number
LP014213 (“Montagu IV (B) LP”, together with Montagu IV LP, Montagu IV (Non-US) LP and Montagu IV (US) LP, the
“Shareholders”),
hereby represented by Me Maxime Bertomeu-Savalle, lawyer, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given on December 9, 2014.
The said proxies shall be annexed to the present deed.
The Shareholders have requested the undersigned notary to record that the Shareholders are all the shareholders of
FR GROUP HOLDINGS S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of fifty-two million three hundred eighty-one thousand eight
hundred eighty-eight euro and twenty-two cents (EUR 52,381,888.22), with registered office at 12F, rue Guillaume Kroll,
L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary dated 20
July 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2156 of 30 August 2012 and regis-
tered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 170433 (the "Company"). The articles
of association of the Company have been amended for the last time following a deed of the undersigned notary, dated
25 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2338 of 2 September 2014.
The Shareholders recognised to be fully informed of the resolutions to be taken on the basis of the following agenda,
which is known to the Shareholders:
<i>Agendai>
1 To create a new class of class D shares consisting of class D1 shares, class D2 shares, class D3 shares, class D4
shares, class D5 shares, class D6 shares, class D7 shares, class D8 shares, class D9 shares and class D10 shares, having
the rights and privileges as defined in the articles of association of the Company following their amendment pursuant to
item 5 of the agenda.
2 To increase the share capital of the Company by an amount of nine million four hundred eighty thousand two hundred
fifty euro (EUR 9,480,250.-) so as to raise it from its present amount of fifty-two million three hundred eighty-one thousand
eight hundred eighty-eight euro and twenty-two cents (EUR 52,381,888.22) to an amount of sixty-one million eight
hundred sixty-two thousand one hundred thirty-eight euro and twenty-two cents (EUR 61,862,138.22).
3 To issue ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D1 shares, ninety-four
million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D2 shares, ninety-four million eight hundred
two thousand five hundred (94,802,500) new class D3 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D4 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class
D5 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D6 shares, ninety-four
million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D7 shares, ninety-four million eight hundred
19404
L
U X E M B O U R G
two thousand five hundred (94,802,500) new class D8 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D9 shares and ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new
class D10 shares with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, having the rights and privileges as defined in the
articles of association of the Company following their amendment pursuant to item 5 of the agenda.
4 To accept subscriptions for these new shares with payment of a share premium in an aggregate amount of eighty-
five million three hundred twenty-two thousand two hundred fifty euro (EUR 85,322,250.-) by the shareholders of the
Company and to accept full payment in cash for these new shares.
5 To amend article 5 of the articles of association of the Company so as to reflect the foregoing proposed resolutions.
have requested the undersigned notary to record the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to create a new class of class D shares consisting of class
D1 shares, class D2 shares, class D3 shares, class D4 shares, class D5 shares, class D6 shares, class D7 shares, class D8
shares, class D9 shares and class D10 shares, having the rights and privileges as defined in the articles of association of
the Company following their amendment pursuant to the fifth resolution below.
<i>Second resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to increase the share capital of the Company by an amount
of nine million four hundred eighty thousand two hundred fifty euro (EUR 9,480,250.-) so as to raise it from its present
amount of fifty-two million three hundred eighty-one thousand eight hundred eighty-eight euro and twenty-two cents
(EUR 52,381,888.22) to an amount of sixty-one million eight hundred sixty-two thousand one hundred thirty-eight euro
and twenty-two cents (EUR 61,862,138.22).
<i>Third resolutioni>
The extraordinary general meeting of the shareholders resolved to issue ninety-four million eight hundred two thou-
sand five hundred (94,802,500) new class D1 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D2 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class
D3 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D4 shares, ninety-four
million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D5 shares, ninety-four million eight hundred
two thousand five hundred (94,802,500) new class D6 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D7 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class
D8 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D9 shares and ninety-
four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D10 shares, with a nominal value of one
euro cent (EUR 0.01) each, having the rights and privileges as defined in the articles of association of the Company following
their amendment pursuant to the fifth resolution below.
<i>Subscriptions - Paymentsi>
Thereupon appeared:
(1) Montagu IV LP, prenamed, represented as above mentioned, which declared to subscribe for eighty-two million
four hundred nineteen thousand four hundred twenty-nine (82,419,429) new class D1 shares, eighty-two million four
hundred nineteen thousand four hundred twenty-nine (82,419,429) new class D2 shares, eighty-two million four hundred
nineteen thousand four hundred twenty-nine (82,419,429) new class D3 shares, eighty-two million four hundred nineteen
thousand four hundred twenty-nine (82,419,429) new class D4 shares, eighty-two million four hundred nineteen thousand
four hundred twenty-nine (82,419,429) new class D5 shares, eighty-two million four hundred nineteen thousand four
hundred twenty-nine (82,419,429) new class D6 shares, eighty-two million four hundred nineteen thousand four hundred
twenty-nine (82,419,429) new class D7 shares, eighty-two million four hundred nineteen thousand four hundred twenty-
nine (82,419,429) new class D8 shares, eighty-two million four hundred nineteen thousand four hundred twenty-nine
(82,419,429) new class D9 shares and eighty-two million four hundred nineteen thousand four hundred thirty (82,419,430)
new class D10 shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, with payment of a share premium in a total
amount of seventy-four million one hundred seventy-seven thousand four hundred eighty-six euro and sixteen cents (EUR
74,177,486.16), and to fully pay in cash for these shares.
(2) Montagu IV (Non-US) LP, prenamed, represented as above mentioned, which declared to subscribe for three
million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D1 shares, three million one hundred
fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D2 shares, three million one hundred fifty-nine thousand
four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D3 shares, three million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-
nine (3,159,459) new class D4 shares, three million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459)
new class D5 shares, three million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D6
shares, three million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D7 shares, three
million one hundred fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D8 shares, three million one hundred
fifty-nine thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D9 shares and three million one hundred fifty-nine
thousand four hundred fifty-nine (3,159,459) new class D10 shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01)
19405
L
U X E M B O U R G
each, with payment of a share premium in a total amount of two million eight hundred forty-three thousand five hundred
thirteen euro and ten cents (EUR 2,843,513.10), and to fully pay in cash for these shares.
(3) Montagu IV (US) LP, prenamed, represented as above mentioned, which declared to subscribe for one million seven
hundred eighty-five thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D1 shares, one million seven hundred eighty-five
thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D2 shares, one million seven hundred eighty-five thousand two
hundred fifteen (1,785,215) new class D3 shares, one million seven hundred eighty-five thousand two hundred fifteen
(1,785,215) new class D4 shares, one million seven hundred eighty-five thousand two hundred fifteen (1,785,215) new
class D5 shares, one million seven hundred eighty-five thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D6 shares,
one million seven hundred eighty-five thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D7 shares, one million seven
hundred eighty-five thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D8 shares, one million seven hundred eighty-five
thousand two hundred fifteen (1,785,215) new class D9 shares and one million seven hundred eighty-five thousand two
hundred seventeen (1,785,217) new class D10 shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, with
payment of a share premium in a total amount of one million six hundred six thousand six hundred ninety-three euro
and seventy cents (EUR 1,606,693.70), and to fully pay in cash for these shares.
(4) Montagu IV (B) LP, prenamed, represented as above mentioned, which declared to subscribe for seven million four
hundred thirty-eight thousand three hundred ninety-seven (7,438,397) new class D1 shares, seven million four hundred
thirty-eight thousand three hundred ninety-seven (7,438,397) new class D2 shares, seven million four hundred thirty-
eight thousand three hundred ninety-seven (7,438,397) new class D3 shares, seven million four hundred thirty-eight
thousand three hundred ninety-seven (7,438,397) new class D4 shares, seven million four hundred thirty-eight thousand
three hundred ninety-seven (7,438,397) new class D5 shares, seven million four hundred thirty-eight thousand three
hundred ninety-seven (7,438,397) new class D6 shares, seven million four hundred thirty-eight thousand three hundred
ninety-seven (7,438,397) new class D7 shares, seven million four hundred thirty-eight thousand three hundred ninety-
seven (7,438,397) new class D8 shares, seven million four hundred thirty-eight thousand three hundred ninety-seven
(7,438,397) new class D9 shares and seven million four hundred thirty-eight thousand three hundred ninety-four
(7,438,394) new class D10 shares, with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, with payment of a share
premium in a total amount of six million six hundred ninety-four thousand five hundred fifty-seven euro and four cents
(EUR 6,694,557.04), and to fully pay in cash for these shares.
The amount of ninety-four million eight hundred two thousand five hundred euro (EUR 94,802,500.-) was thus as from
that moment at the disposal of the Company, evidence thereof having been submitted to the undersigned notary.
<i>Fourth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to accept said subscriptions and payments and to allot
the ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D1 shares, ninety-four million
eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D2 shares, ninety-four million eight hundred two thou-
sand five hundred (94,802,500) new class D3 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D4 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class
D5 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D6 shares, ninety-four
million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new class D7 shares, ninety-four million eight hundred
two thousand five hundred (94,802,500) new class D8 shares, ninety-four million eight hundred two thousand five hundred
(94,802,500) new class D9 shares and ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) new
class D10 shares, according to the above mentioned subscriptions.
<i>Fifth resolutioni>
The extraordinary general meeting of shareholders resolved to amend article 5 of the articles of incorporation of the
Company so as to reflect the foregoing resolutions.
As a result, article 5 of the articles of association of the Company shall from now on read as follows:
“ Art. 5. Issued Capital. The subscribed capital of the Company is set at sixty-one million eight hundred sixty-two
thousand one hundred thirty-eight euro and twenty-two cents (EUR 61,862,138.22) divided into
- two hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand five hundred and two (263,809,502) class A1 shares
(the "Class A1 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand five hundred and two
(263,809,502) class A2 shares (the "Class A2 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand
five hundred and two (263,809,502) class A3 shares (the "Class A3 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred
and nine thousand five hundred and two (263,809,502) class A4 shares (the "Class A4 Shares"), two hundred sixty-three
million eight hundred and nine thousand five hundred and two (263,809,502) class A5 shares (the "Class A5 Shares"), two
hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand five hundred and two (263,809,502) class A6 shares (the
"Class A6 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand five hundred and two (263,809,502)
class A7 shares (the "Class A7 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred and nine thousand five hundred
and two (263,809,502) class A8 shares (the "Class A8 Shares"), two hundred sixty-three million eight hundred and nine
thousand five hundred and two (263,809,502) class A9 shares (the "Class A9 Shares"), two hundred sixty-three million
eight hundred and nine thousand five hundred twenty-four (263,809,524) class A10 shares (the "Class A10 Shares" and
19406
L
U X E M B O U R G
together with the Class A1 Shares, Class A2 Shares, Class A3 Shares, Class A4 Shares, Class A Shares, Class A6 Shares,
Class A7 Shares, Class A8 Shares, Class A9 Shares, the "Class A Shares");
- one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class B1
shares (the "Class B1 Shares"), one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-eight
(161,470,338) class B2 shares (the "Class B2 Shares"), one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand three
hundred thirty-eight (161,470,338) class B3 shares (the "Class B3 Shares"), one hundred sixty-one million four hundred
seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class B4 shares (the "Class B4 Shares"), one hundred sixty-
one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class B5 shares (the "Class B5
Shares"), one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class
B6 shares (the "Class B6 Shares"), one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-
eight (161,470,338) class B7 shares (the "Class B7 Shares"), one hundred sixty-one million four hundred seventy thousand
three hundred thirty-eight (161,470,338) class B8 shares (the "Class B8 Shares"), one hundred sixty-one million four
hundred seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class B9 shares (the "Class B9 Shares"), one hundred
sixty-one million four hundred seventy thousand three hundred thirty-eight (161,470,338) class B10 shares (the "Class
B10 Shares" and together with the Class B1 Shares, Class B2 Shares, Class B3 Shares, Class B4 Shares, Class B Shares,
Class B6 Shares, Class B7 Shares, Class B8 Shares, Class B9 Shares, the "Class B Shares");
- ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C1 shares (the “Class C1 Sha-
res”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C2 shares (the “Class C2
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C3 shares (the “Class C3
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C4 shares (the “Class C4
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C5 shares (the “Class C5
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C6 shares (the “Class C6
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C7 shares (the “Class C7
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C8 shares (the “Class C8
Shares”), ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand thirty-eight (98,539,038) class C9 shares (the “Class C9
Shares”) and ninety-eight million five hundred thirty-nine thousand fifty-eight (98,539,058) class C10 shares (the “Class
C10 Shares”, together with the Class C1 Shares, the Class C2 Shares, the Class C3 Shares, the Class C4 Shares, the Class
C5 Shares, the Class C6 Shares, the Class C7 Shares, the Class C8 Shares and the Class C9 shares, the “Class C Shares”);
- ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D1 shares (the “Class D1 Shares”),
ninety-four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D2 shares (the “Class D2 Shares”), ninety-
four million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D3 shares (the “Class D3 Shares”), ninety-four
million eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D4 shares (the “Class D4 Shares”), ninety-four million
eight hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D5 shares (the “Class D5 Shares”), ninety-four million eight
hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D6 shares (the “Class D6 Shares”), ninety-four million eight
hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D7 shares (the “Class D7 Shares”), ninety-four million eight
hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D8 shares (the “Class D8 Shares”), ninety-four million eight
hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D9 shares (the “Class D9 Shares”) and ninety-four million eight
hundred two thousand five hundred (94,802,500) class D10 shares (the “Class D10 Shares”, together with the Class D1
Shares, the Class D2 Shares, the Class D3 Shares, the Class D4 Shares, the Class D5 Shares, the Class D6 Shares, the
Class D7 Shares, the Class D8 Shares and the Class D9 shares, the “Class C Shares”);
with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each (together referred to as the "Shares" and each a "Share"), all
of which are fully paid up. The Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares and the Class D Shares which are
in issue are together referred to as the “Classes of Shares” and each a “Class of Shares”.
The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the
Articles of Incorporation (especially as regards the rights with respect to the Distributions (as defined below) or by the
Laws).
In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any Share in
addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment
of Shares, which are linked to a Class of Shares, which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset
any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the
Legal Reserve. Upon the issue of new Shares, the Company shall, out of share premium paid-in on such Shares, allot ten
per cent (10%) of the nominal value of the newly issued Shares to the reserve required by law (the “Legal Reserve”) in
order to ensure that the Legal Reserve amounts at all time to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company
in accordance with the Laws.
The capital contribution including any share premium attached to it, made in consideration of the issue of each Class
of Shares (the "Contribution"), as well as any income such as dividend, interest or other revenue deriving from the
Targeted Investment (as defined below) relating to each such Class of Shares to the extent re-invested (all together the
"Contributions"), shall be invested pursuant to the investment policy determined by the Board of Managers for the
investment established in respect of the relevant Class or Classes of Shares (each a "Targeted Investment"). Consequently,
each Class of Shares will be linked to a particular Targeted Investment.
19407
L
U X E M B O U R G
The Targeted Investment linked to the Class A Shares and the share premium attached to the Class A Shares, consists
in the participations the Company holds or will hold directly or indirectly, as from time to time, in Brassica Midco S.A.
(the “Class A Targeted Investment”).
The Targeted Investment linked to the Class B Shares and the share premium attached to the Class B Shares, consists
in the participations the Company holds or will hold directly or indirectly, as from time to time, in Devix Midco (the
“Class B Targeted Investment”).
The Targeted Investment linked to the Class C Shares and the share premium attached to the Class C Shares consists
in the participations the Company holds or will hold directly or indirectly, as from time to time, in Apharma Luxco (the
“Class C Targeted Investment”).
The Targeted Investment linked to the Class D Shares and the share premium attached to the Class D Shares consists
in the participations the Company holds or will hold directly or indirectly, as from time to time, in Sebia Capital S.à r.l.
(the “Class D Targeted Investment”).
For each Class of Shares, the Board of Managers shall keep track, in the books of the Company, of (i) the Contributions,
(ii) any income on the Targeted Investment, as well as (iii) any charges attributable to the Targeted Investment linked to
each Class of Shares. For this purpose, the Board of Managers will prepare a set of analytical accounts for each Class of
Shares.
The net asset value of each Class of Shares (the "Net Asset Value") is determined by aggregating the value of the
Targeted Investment and of any other asset of every kind and nature allocated to that Class of Shares and by deducting
all liabilities allocated to that Class of Shares (such as loans, administrative expenses, tax liabilities, etc.). Where any asset
is derived from another asset as a result of an exchange of assets, merger, contribution in kind, or similar operations,
such derivative asset shall be attributed in the books of the Company to the same Class of Shares as the assets from
which it was derived and on each revaluation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant
Class of Shares.
In the case where any expense of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Class of
Shares, such expense shall be allocated between the various Classes of Shares according to the following formula:
Expenses not linked to a specific investment X Aggregate nominal value of the shares of the Class of Shares concerned,
plus share premium attributed to that Class of Shares (if any) / Aggregate nominal value of the shares of all Classes of
Shares, plus aggregate amount of share premium attributed to all Classes of Shares
To the extent permissible by the Laws, including without limitation, compliance with the legal requirement to create
a Legal Reserve, and subject to the following, each Class of Shares shall be entitled to an exclusive right to distributions
by way of (i) dividend, (ii) redemption of own Shares, (iii) reduction of the subscribed capital, (iv) reduction of a reserve
and (v) liquidation made by the Company (the "Distributions") up to the Net Asset Value of the Class of Shares concerned
(to be allocated between the holders of such Class of Shares in accordance with the below distribution rules of this article
5).
Any Class of Shares shall only be entitled to Distributions to the extent that it has a positive Net Asset Value.
If the Company resolves to make Distributions, the amount allocated to this effect shall be distributed to the holders
of Shares in accordance with the following rules and only with respect to Classes of Shares the Net Asset Value of which
is positive:
(i) the Class A Shares shall be entitled, on a pro rata and pari passu basis, to a cumulative dividend representing the
distributable amount derived by the Company in relation to the Class A Targeted Investment.
In this respect the Class A Shares shall be entitled to a cumulative dividend in the following order of priority: first (i)
each Class A1 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point nineteen per cent
(0.19%) per annum of the nominal value of such share; then (ii) each Class A2 Share shall be entitled to a cumulative
dividend in an amount of not less than zero point eighteen per cent (0.18%) per annum of the nominal value of such share;
then (iii) each Class A3 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point seventeen
per cent (0.17%) per annum of the nominal value of such share; then (iv) each Class A4 Share shall be entitled to a
cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixteen per cent (0.16%) per annum of the nominal value of
such share; then (v) each Class A5 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero
point fifteen per cent (0.15%) per annum of the nominal value of such share; then (vi) each Class A6 Share shall be entitled
to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fourteen per cent (0.14%) per annum of the nominal
value of such share; then (vii) each Class A7 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than
zero point thirteen per cent (0.13%) per annum of the nominal value of such share; then (viii) each Class A8 Share shall
be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twelve per cent (0.12%) per annum of the
nominal value of such share; then (ix) each Class A9 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point eleven per cent (0.11%) per annum of the nominal value of such share; then (x) each Class A10 Share
shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point ten per cent (0.10%) per annum of the
nominal value of such share (together the “Profit Entitlement A”).
Any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement A shall be allocated in whole to the last
outstanding class of Class A Shares in the reverse numerical order of the Class A Shares.
19408
L
U X E M B O U R G
(ii) the Class B Shares shall be entitled, on a pro rata and pari passu basis, to a cumulative dividend representing the
distributable amount derived by the Company in relation to the Class B Targeted Investment.
In this respect the Class B Shares shall be entitled to a cumulative dividend in the following order of priority: first (i)
each Class B1 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point nineteen per cent
(0.19%) per annum of the nominal value of such share; then (ii) each Class B2 Share shall be entitled to a cumulative
dividend in an amount of not less than zero point eighteen per cent (0.18%) per annum of the nominal value of such share;
then (iii) each Class B3 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point seventeen
per cent (0.17%) per annum of the nominal value of such share; then (iv) each Class B4 Share shall be entitled to a
cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixteen per cent (0.16%) per annum of the nominal value of
such share; then (v) each Class B5 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero
point fifteen per cent (0.15%) per annum of the nominal value of such share; then (vi) each Class B6 Share shall be entitled
to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fourteen per cent (0.14%) per annum of the nominal
value of such share; then (vii) each Class B7 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than
zero point thirteen per cent (0.13%) per annum of the nominal value of such share; then (viii) each Class B8 Share shall
be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twelve per cent (0.12%) per annum of the
nominal value of such share; then (ix) each Class B9 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point eleven per cent (0.11%) per annum of the nominal value of such share; then (x) each Class B10 Share
shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point ten per cent (0.10%) per annum of the
nominal value of such share (together the “Profit Entitlement B”).
Any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement B shall be allocated in whole to the last
outstanding class of Class B Shares in the reverse numerical order of the Class B Shares.
(iii) the Class C Shares shall be entitled, on a pro rata and pari passu basis, to a cumulative dividend representing the
distributable amount derived by the Company in relation to the Class C Targeted Investment.
In this respect the Class C Shares shall be entitled to a cumulative dividend in the following order of priority: first (i)
each Class C1 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point nineteen per cent
(0.19%) per annum of the nominal value of such share; then (ii) each Class C2 Share shall be entitled to a cumulative
dividend in an amount of not less than zero point eighteen per cent (0.18%) per annum of the nominal value of such share;
then (iii) each Class C3 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point seventeen
per cent (0.17%) per annum of the nominal value of such share; then (iv) each Class C4 Share shall be entitled to a
cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixteen per cent (0.16%) per annum of the nominal value of
such share; then (v) each Class C5 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero
point fifteen per cent (0.15%) per annum of the nominal value of such share; then (vi) each Class C6 Share shall be entitled
to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fourteen per cent (0.14%) per annum of the nominal
value of such share; then (vii) each Class C7 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than
zero point thirteen per cent (0.13%) per annum of the nominal value of such share; then (viii) each Class C8 Share shall
be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twelve per cent (0.12%) per annum of the
nominal value of such share; then (ix) each Class C9 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point eleven per cent (0.11%) per annum of the nominal value of such share; then (x) each Class C10 Share
shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point ten per cent (0.10%) per annum of the
nominal value of such share (together the “Profit Entitlement C”).
Any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement C shall be allocated in whole to the last
outstanding class of Class C Shares in the reverse numerical order of the Class C Shares.
(iv) the Class D Shares shall be entitled, on a pro rata and pari passu basis, to a cumulative dividend representing the
distributable amount derived by the Company in relation to the Class D Targeted Investment.
In this respect the Class D Shares shall be entitled to a cumulative dividend in the following order of priority: first (i)
each Class D1 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point nineteen per cent
(0.19%) per annum of the nominal value of such share; then (ii) each Class D2 Share shall be entitled to a cumulative
dividend in an amount of not less than zero point eighteen per cent (0.18%) per annum of the nominal value of such share;
then (iii) each Class D3 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point seventeen
per cent (0.17%) per annum of the nominal value of such share; then (iv) each Class D4 Share shall be entitled to a
cumulative dividend in an amount of not less than zero point sixteen per cent (0.16%) per annum of the nominal value of
such share; then (v) each Class D5 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero
point fifteen per cent (0.15%) per annum of the nominal value of such share; then (vi) each Class D6 Share shall be entitled
to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point fourteen per cent (0.14%) per annum of the nominal
value of such share; then (vii) each Class D7 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than
zero point thirteen per cent (0.13%) per annum of the nominal value of such share; then (viii) each Class D8 Share shall
be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point twelve per cent (0.12%) per annum of the
nominal value of such share; then (ix) each Class D9 Share shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not
less than zero point eleven per cent (0.11%) per annum of the nominal value of such share; then (x) each Class D10 Share
shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than zero point ten per cent (0.10%) per annum of the
nominal value of such share (together the “Profit Entitlement D”).
19409
L
U X E M B O U R G
Any remaining dividend amount after allocation of the Profit Entitlement D shall be allocated in whole to the last
outstanding class of Class D Shares in the reverse numerical order of the Class D Shares.
Subject to the conditions set by the Laws and in compliance with the foregoing provisions, the Manager(s) or, as the
case may be, the Board of Managers may pay out an advance payment on dividends to the shareholders. The Manager(s)
or, as the case may be, the Board of Managers determine(s) the amount and the date of payment of any such advance
payment.”
<i>Expensesi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed
are estimated at six thousand five hundred Euros (EUR 6,500.-).
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.
Whereupon, the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the
beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,
first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le neuvième jour du mois de décembre,
par devant nous Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,
ont comparu:
(1) Montagu IV LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 2, More London
Riverside, GB - SE1 2AP Londres, immatriculé au Companies House London sous le numéro LP014211 («Montagu IV
LP»),
représentée aux fins des présentes par Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2014;
(2) Montagu IV (Non-US) LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 2, More
London Riverside, GB - SE1 2AP Londres, immatriculé au Companies House London sous le numéro LP014367 («Montagu
IV (Non-US) LP»),
représentée aux fins des présentes par Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2014;
(3) Montagu IV (US) LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 2, More
London Riverside, GB - SE1 2AP Londres, immatriculé au Companies House London sous le numéro LP014212 («Montagu
IV (US) LP»),
représentée aux fins des présentes par Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2014;
(4) Montagu IV (B) LP, un limited partnership régi par les lois du Royaume-Uni, ayant son siège social au 2, More
London Riverside, GB - SE1 2AP Londres, immatriculé au Companies House London sous le numéro LP014213 («Montagu
IV (B) LP», collectivement avec Montagu IV LP, Montagu IV (Non-US) LP et Montagu IV (US) LP, les «Associés»),
représentée aux fins des présentes par Maître Maxime Bertomeu-Savalle, avocat, demeurant à Luxembourg,
aux termes d'une procuration sous seing privé donnée le 9 décembre 2014.
Les prédites procurations resteront annexées aux présentes.
Les Associés ont requis le notaire instrumentant d'acter que les Associés sont tous les associés de FR GROUP HOL-
DINGS S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant un capital
social de cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes
(EUR 52.381.888,22), ayant son siège social au 12F, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand-Duché du Luxem-
bourg, constituée par acte du notaire soussigné en date du 20 juillet 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations numéro 2156 du 30 août 2012 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg
sous le numéro B 170.433 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par acte du
notaire soussigné, en date du 25 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2338 du
2 septembre 2014.
Les Associés, représentés comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informés des déci-
sions à intervenir sur base de l'ordre du jour suivant:
<i>Ordre du jouri>
1 Création d'une nouvelle catégorie de parts sociales de catégorie D comprenant des parts sociales de catégorie D1,
des parts sociales de catégorie D2, des parts sociales de catégorie D3, des parts sociales de catégorie D4, des parts
19410
L
U X E M B O U R G
sociales de catégorie D5, des parts sociales de catégorie D6, des parts sociales de catégorie D7, des parts sociales de
catégorie D8, des parts sociales de catégorie D9 et des parts sociales de catégorie D10, ayant les droits et privilèges
définis dans les statuts de la Société à la suite de leur modification telle que proposée au point 5 de l'ordre du jour.
2 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de neuf millions quatre cent quatre-vingt mille deux cent
cinquante euros (EUR 9.480.250,-) pour le porter de son montant actuel de cinquante-deux millions trois cent quatre-
vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes (EUR 52.381.888,22) à un montant de soixante-
et-un millions huit cent soixante-deux mille cent trente-huit euros et vingt-deux centimes (EUR 61.862.138,22).
3 Émission de quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D1, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D2, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D3, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D4, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D5, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D6, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D7, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D8, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D9 et quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D10 d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droits et privilèges définis dans
les statuts de la Société à la suite de leur modification telle que proposée au point 5 de l'ordre du jour.
4 Acceptation des souscriptions de ces nouvelles parts sociales par les associés de la Société avec paiement d'une
prime d'émission d'un montant total de quatre-vingt-cinq millions trois cent vingt-deux mille deux cent cinquante euros
(EUR 85.322.250,-) à libérer intégralement en espèces.
5 Modification de l'article 5 des statuts de la Société, afin de refléter l'augmentation de capital, afin de refléter les points
précédents de l'ordre du jour.
ont requis le notaire soussigné d'acter les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de créer une nouvelle catégorie de parts sociales de caté-
gorie D comprenant des parts sociales de catégorie D1, des parts sociales de catégorie D2, des parts sociales de catégorie
D3, des parts sociales de catégorie D4, des parts sociales de catégorie D5, des parts sociales de catégorie D6, des parts
sociales de catégorie D7, des parts sociales de catégorie D8, des parts sociales de catégorie D9 et des parts sociales de
catégorie D10, ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, ayant les droits et privilèges définis
dans les statuts de la Société à la suite de leur modification telle que prévue à la cinquième résolution ci-dessous.
<i>Deuxième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence
de neuf millions quatre cent quatre-vingt mille deux cent cinquante euros (EUR 9.480.250,-) pour le porter de son montant
actuel de cinquante-deux millions trois cent quatre-vingt-un mille huit cent quatre-vingt-huit euros et vingt-deux centimes
(EUR 52.381.888,22) à un montant de soixante-et-un millions huit cent soixante-deux mille cent trente-huit euros et
vingt-deux centimes (EUR 61.862.138,22).
<i>Troisième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'émettre quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux
mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D1, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille
cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D2, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq
cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D3, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D4, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D5, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D6, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D7, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D8, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D9 et quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) nouvelles parts sociales de catégorie D10 d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,
ayant les droits et privilèges définis dans les statuts de la Société à la suite de leur modification telle que prévue à la
cinquième résolution ci-dessous.
<i>Souscriptions - Paiementsi>
Ensuite ont comparu:
(1) Montagu IV LP, prénommée, représentée tel que décrit ci-dessus, qui a déclaré souscrire à quatre-vingt-deux
millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie D1, quatre-
vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie
19411
L
U X E M B O U R G
D2, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de
catégorie D3, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts
sociales de catégorie D4, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nou-
velles parts sociales de catégorie D5, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent vingt-neuf
(82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie D6, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille quatre cent
vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie D7, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-neuf mille
quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie D8, quatre-vingt-deux millions quatre cent dix-
neuf mille quatre cent vingt-neuf (82.419.429) nouvelles parts sociales de catégorie D9, quatre-vingt-deux millions quatre
cent dix-neuf mille quatre cent trente (82.419.430) nouvelles parts sociales de catégorie D10 d'une valeur nominale d'un
centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de soixante-quatorze
millions cent soixante-dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-six euros et seize centimes (EUR 74.177.486,16), à libérer
intégralement en espèces.
(2) Montagu IV (Non-US) LP, prénommée, représentée tel que décrit ci-dessus, qui a déclaré souscrire à trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D1, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D2, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D3, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D4, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D5, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D6, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D7, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D8, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D9, trois millions
cent cinquante-neuf mille quatre cent cinquante-neuf (3.159.459) nouvelles parts sociales de catégorie D10 d'une valeur
nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de deux
millions huit cent quarante-trois mille cinq cent treize euros et dix centimes (EUR 2.843.513,10), à libérer intégralement
en espèces.
(3) Montagu IV (US) LP, prénommée, représentée tel que décrit ci-dessus, qui a déclaré souscrire à un million sept
cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D1, un million sept cent
quatre-vingt-cinq mille deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D2, un million sept cent quatre-
vingt-cinq mille deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D3, un million sept cent quatre-vingt-
cinq mille deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D4, un million sept cent quatre-vingt-cinq
mille deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D5, un million sept cent quatre-vingt-cinq mille
deux cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D6, un million sept cent quatre-vingt-cinq mille deux
cent quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D7, un million sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent
quinze (1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D8, un million sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quinze
(1.785.215) nouvelles parts sociales de catégorie D9 et un million sept cent quatre-vingt-cinq mille deux cent dix-sept
(1.785.217) nouvelles parts sociales de catégorie D10 d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune,
avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total d'un million six cent six mille six cent quatre-vingt-treize euros
et soixante-dix centimes (EUR 1.606.693,70), à libérer intégralement en espèces.
(4) Montagu IV (B) LP, prénommée, représentée tel que décrit ci-dessus, qui a déclaré souscrire à sept millions quatre
cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles parts sociales de catégorie D1, sept millions
quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles parts sociales de catégorie D2, sept
millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles parts sociales de catégorie
D3, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles parts sociales de
catégorie D4, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles parts so-
ciales de catégorie D5, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397) nouvelles
parts sociales de catégorie D6, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (7.438.397)
nouvelles parts sociales de catégorie D7, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-dix-sept
(7.438.397) nouvelles parts sociales de catégorie D8, sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent quatre-vingt-
dix-sept (7.438.397) nouvelles parts sociales de catégorie D9 et sept millions quatre cent trente-huit mille trois cent
quatre-vingt-quatorze (7.438.394) nouvelles parts sociales de catégorie D10 d'une valeur nominale d'un centime d'euro
(EUR 0,01) chacune, avec paiement d'une prime d'émission d'un montant total de six million six cent quatre-vingt-quatorze
mille cinq cent cinquante-sept euros et quatre centimes (EUR 6.694.557,04), à libérer intégralement en espèces.
Le montant de quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents euros (EUR 94.802.500,-) a dès lors été
à la disposition de la Société, la preuve ayant été rapportée au notaire soussigné.
<i>Quatrième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé d'accepter lesdites souscriptions et lesdits paiements et
d'émettre les quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D1, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D2, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
19412
L
U X E M B O U R G
catégorie D3, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D4, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D5, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D6, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D7, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D8, quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D9 et quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) nouvelles parts sociales de
catégorie D10 conformément aux souscriptions ci-dessus mentionnées.
<i>Cinquième résolutioni>
L'assemblée générale extraordinaire des associés a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société, afin de
refléter les résolutions qui précédent.
En conséquence, l'article 5 des statuts de la Société aura dorénavant la teneur suivante:
« Art. 5. Capital Émis. Le capital émis de la Société est fixé à soixante-et-un millions huit cent soixante-deux mille cent
trente-huit euros et vingt-deux centimes (EUR 61.862.138,22) divisé en:
- deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A1
(les «Parts Sociales de Catégorie A1»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502)
parts sociales de catégorie A2 (les «Parts Sociales de Catégorie A2»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf
mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A3 (les «Parts Sociales de Catégorie A3»), deux cent
soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A4 (les «Parts Sociales
de Catégorie A4»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de
catégorie A5 (les «Parts Sociales de Catégorie A5»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux
(263.809.502) parts sociales de catégorie A6 (les «Parts Sociales de Catégorie A6»), deux cent soixante-trois millions
huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A7 (les «Parts Sociales de Catégorie A7»),
deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A8 (les
«Parts Sociales de Catégorie A8»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf mille cinq cent deux (263.809.502)
parts sociales de catégorie A9 (les «Parts Sociales de Catégorie A9»), deux cent soixante-trois millions huit cent neuf
mille cinq cent deux (263.809.502) parts sociales de catégorie A10 (les «Parts Sociales de Catégorie A10», et collective-
ment avec les Parts Sociales de Catégorie A1, les Parts Sociales de Catégorie A2, les Parts Sociales de Catégorie A3, les
Parts Sociales de Catégorie A4, les Parts Sociales de Catégorie A5, les Parts Sociales de Catégorie A6, les Parts Sociales
de Catégorie A7, les Parts Sociales de Catégorie A8, les Parts Sociales de Catégorie A9, les Parts Sociales de Catégorie
A10, les «Parts Sociales de Catégorie A»);
- cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de
catégorie B1 (les «Parts Sociales de Catégorie B1»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent
trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B2 (les «Parts Sociales de Catégorie B2»), cent soixante-et-un mil-
lions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B3 (les «Parts Sociales
de Catégorie B3»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts
sociales de catégorie B4 (les «Parts Sociales de Catégorie B4»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille
trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B5 (les «Parts Sociales de Catégorie B5»), cent soixante-
et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B6 (les «Parts
Sociales de Catégorie B6»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338)
parts sociales de catégorie B7 (les «Parts Sociales de Catégorie B7»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-
dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B8 (les «Parts Sociales de Catégorie B8»), cent
soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit (161.470.338) parts sociales de catégorie B9
(les «Parts Sociales de Catégorie B9»), cent soixante-et-un millions quatre cent soixante-dix mille trois cent trente-huit
(161.470.338) parts sociales de catégorie B10 (les «Parts Sociales de Catégorie B10», et collectivement avec les Parts
Sociales de Catégorie B1, les Parts Sociales de Catégorie B2, les Parts Sociales de Catégorie B3, les Parts Sociales de
Catégorie B4, les Parts Sociales de Catégorie B5, les Parts Sociales de Catégorie B6, les Parts Sociales de Catégorie B7,
les Parts Sociales de Catégorie B8, les Parts Sociales de Catégorie B9, les Parts Sociales de Catégorie B10, les «Parts
Sociales de Catégorie B»);
- quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie C1 (les
«Parts Sociales de Catégorie C1»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts
sociales de catégorie C2 (les «Parts Sociales de Catégorie C2»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille
trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie C3 (les «Parts Sociales de Catégorie C3»), quatre-vingt-dix-huit
millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie C4 (les «Parts Sociales de Caté-
gorie C4»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie
C5 (les «Parts Sociales de Catégorie C5»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit
(98.539.038) parts sociales de catégorie C6 (les «Parts Sociales de Catégorie C6»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq
cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie C7 (les «Parts Sociales de Catégorie C7»),
quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts sociales de catégorie C8 (les «Parts
Sociales de Catégorie C8»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille trente-huit (98.539.038) parts so-
19413
L
U X E M B O U R G
ciales de catégorie C9 (les «Parts Sociales de Catégorie C9»), quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent trente-neuf mille
cinquante-huit (98.539.058) parts sociales de catégorie C10 (les «Parts Sociales de Catégorie C10», et collectivement
avec les Parts Sociales de Catégorie C1, les Parts Sociales de Catégorie C2, les Parts Sociales de Catégorie C3, les Parts
Sociales de Catégorie C4, les Parts Sociales de Catégorie C5, les Parts Sociales de Catégorie C6, les Parts Sociales de
Catégorie C7, les Parts Sociales de Catégorie C8, les Parts Sociales de Catégorie C9, les Parts Sociales de Catégorie C10,
les «Parts Sociales de Catégorie C»);
- quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D1 (les «Parts
Sociales de Catégorie D1»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de
catégorie D2 (les «Parts Sociales de Catégorie D2»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents
(94.802.500) parts sociales de catégorie D3 (les «Parts Sociales de Catégorie D3»), quatre-vingt-quatorze millions huit
cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D4 (les «Parts Sociales de Catégorie D4»), quatre-
vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D5 (les «Parts Sociales de
Catégorie D5»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie
D6 (les «Parts Sociales de Catégorie D6»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500)
parts sociales de catégorie D7 (les «Parts Sociales de Catégorie D7»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille
cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D8 (les «Parts Sociales de Catégorie D8»), quatre-vingt-quatorze
millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D9 (les «Parts Sociales de Catégorie
D9»), quatre-vingt-quatorze millions huit cent deux mille cinq cents (94.802.500) parts sociales de catégorie D10 (les
«Parts Sociales de Catégorie D10», et collectivement avec les Parts Sociales de Catégorie D1, les Parts Sociales de
Catégorie D2, les Parts Sociales de Catégorie D3, les Parts Sociales de Catégorie D4, les Parts Sociales de Catégorie D5,
les Parts Sociales de Catégorie D6, les Parts Sociales de Catégorie D7, les Parts Sociales de Catégorie D8, les Parts
Sociales de Catégorie D9, les Parts Sociales de Catégorie D10, les «Parts Sociales de Catégorie D»);
ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune (collectivement les «Parts Sociales» et individuel-
lement une «Part Sociale»), celles-ci étant entièrement libérées.
Les Parts Sociales de Catégorie A, les Parts Sociales de Catégorie B, les Parts Sociales de Catégorie C et les Parts
Sociales de Catégorie D qui sont émises, sont collectivement désignées comme les «Catégories de Parts Sociales» et
individuellement comme une «Catégorie de Parts Sociales»).
Les droits et obligations inhérents aux Parts Sociales sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts (en particulier
concernant les droits aux Distributions (tels que définis ci-après) ou des Lois).
En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes
d'émission payées sur les Parts Sociales en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être
utilisé pour régler le prix des Parts Sociales, qui sont rattachées à une Catégorie de Parts Sociales, que la Société a
rachetées à ses associés, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes aux associés ou pour
affecter des fonds à la Réserve Légale. Lors de l'émission de nouvelles Parts Sociales, la Société devra allouer à partir de
la prime d'émission versée sur ces Parts Sociales, dix pour cent (10%) de la valeur nominale de ces Parts Sociales nou-
vellement émises à une réserve légale (la «Réserve Légale») afin de s'assurer que le montant de la Réserve Légale soit en
tout temps égal à dix pour cent (10%) du capital souscrit de la Société conformément aux Lois.
L'apport en capital, y compris toute prime d'émission qui s'y rapporte, fait en contrepartie de l'émission de chaque
Catégorie de Parts Sociales (l'«Apport»), ainsi que tout revenu sous forme de dividende, d'intérêts ou de tout autre
revenu provenant de l'Investissement Visé (tel que défini ci-dessous) relatif à chaque Catégorie de Parts Sociales dans la
mesure où il est réinvesti (collectivement les «Apports») seront investis conformément à la politique d'investissement
déterminée par le Conseil de Gérance pour l'investissement établi au regard de la ou des Catégories de Parts Sociales
concernées (individuellement un «Investissement Visé»). Par conséquent, chaque Catégorie de Parts Sociales sera liée à
un Investissement Visé spécifique.
L'Investissement Visé rattachés aux Parts Sociales de Catégorie A et la prime d'émission qui se rapporte aux Parts
Sociales de Catégorie A consistent en les participations que la Société détient ou va détenir indirectement, de temps en
temps, dans Brassica Midco S.A. (l'«Investissement Visé de Catégorie A»).
L'Investissement Visé rattachés aux Parts Sociales de Catégorie B et la prime d'émission qui se rapporte aux Parts
Sociales de Catégorie B consistent en les participations que la Société détient ou va détenir indirectement, de temps en
temps, dans Devix Midco (l'«Investissement Visé de Catégorie B»).
L'Investissement Visé rattachés aux Parts Sociales de Catégorie C et la prime d'émission qui se rapporte aux Parts
Sociales de Catégorie C consistent en les participations que la Société détient ou va détenir indirectement, de temps en
temps, dans Apharma Luxco (l'«Investissement Visé de Catégorie C»).
L'Investissement Visé rattachés aux Parts Sociales de Catégorie D et la prime d'émission qui se rapporte aux Parts
Sociales de Catégorie D consistent en les participations que la Société détient ou va détenir indirectement, de temps en
temps, dans Sebia Capital S.à r.l. (l'«Investissement Visé de Catégorie D»).
Pour chaque Catégorie de Parts Sociales, le Conseil de Gérance conservera la trace, dans les livres de la Société (i)
des Apports, (ii) de tout revenu sur l'Investissement Visé, et (iii) de toutes charges attribuables à l'Investissement Visé lié
à chaque Catégorie de Parts Sociales. A cette fin, le Conseil de Gérance établira des comptes analytiques pour chaque
Catégorie de Parts Sociales.
19414
L
U X E M B O U R G
La valeur nette d'inventaire de chaque Catégorie de Parts Sociales (la «Valeur Nette d'Inventaire») est déterminée en
ajoutant à la valeur de l'Investissement Visé tout autre actif de toute sorte et de toute nature lié à cette Catégorie de
Parts Sociales et en déduisant tout le passif lié à cette Catégorie de Parts Sociales (tels que les prêts, les dépenses
administratives, les charges fiscales, etc.). Lorsqu'un actif dérive d'un autre actif en raison d'un échange d'actifs, d'une
fusion, d'un apport en nature ou d'opérations similaires, cet actif dérivé sera attribué dans les livres de la Société à la
même Catégorie de Parts Sociales que les actifs dont il est dérivé et à chaque réévaluation d'un actif, l'augmentation ou
la diminution de valeur sera appliquée à la Catégorie de Parts Sociales concernée.
Lorsqu'une dépense de la Société ne peut être considérée comme étant attribuable à une Catégorie de Parts Sociales
particulière, cette dépense sera attribuée à l'ensemble des Catégories de Parts Sociales selon la formule suivante:
Dépenses non liées à un investissement spécifique X Valeur nominale totale des parts sociales de la Catégorie de Parts
Sociales concernée, plus (le cas échéant) la prime d'émission allouée à cette Catégorie de Parts Sociales / Valeur nominale
totale des parts sociales appartenant à toutes les Catégories de Parts Sociales, plus le montant total des primes d'émission
allouées à toutes les Catégories de Parts Sociales
Dans la mesure de ce qui est permis par les Lois, en ce compris, mais sans limitation, l'observation de l'exigence légale
de créer une Réserver Légale, et sous réserve de ce qui suit, chaque Catégorie de Parts Sociales aura un droit exclusif
aux distributions faites sous forme de (i) dividendes, (ii) rachat de Parts Sociales propres, (iii) de réduction du capital
souscrit (iv) de réduction d'une réserve et (v) de liquidation par la Société (les «Distributions») dans la limite de la Valeur
Nette d'Inventaire de la Catégorie de Parts Sociales concernée (et devant être réparti entre les détenteurs de cette
Catégorie de Parts Sociales conformément aux règles de distribution de cet article 5).
Chaque Catégorie de Parts Sociales aura uniquement droit aux Distribution à condition qu'elle ait une Valeur Nette
d'Inventaire positive.
Si la Société décide de faire des Distributions, le montant alloué à cette fin sera distribué aux détenteurs de Parts
Sociales conformément aux règles suivantes et seulement en ce qui concerne les Catégories de Parts Sociales dont la
Valeur Nette d'Inventaire est positive:
(i) Les Parts Sociales de Catégorie A confèrent le droit, au pro rata et sur une base pari passu, de recevoir un dividende
cumulé représentant le montant distribuable établi par la Société en lien avec l'Investissement Visé de Catégorie A.
A cet égard, les Parts Sociales de Catégorie A confèrent le droit de recevoir des distributions cumulatives dans l'ordre
de priorité suivant: d'abord (i) chaque Part Sociale de Catégorie A1 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule dix-neuf pour cent (0,19%) par année de la valeur nominale de cette part
sociale; ensuite (ii) chaque Part Sociale de Catégorie A2 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant
au minimum égal à zéro virgule dix-huit pour cent (0,18%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iii)
chaque Part Sociale de Catégorie A3 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal
à zéro virgule dix-sept pour cent (0,17%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iv) chaque Part
Sociale de Catégorie A4 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule
seize pour cent (0,16%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (v) chaque Part Sociale de Catégorie
A5 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quinze pour cent
(0,15%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vi) chaque Part Sociale de Catégorie A6 confère le
droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quatorze pour cent (0,14%) par
année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vii) chaque Part Sociale de Catégorie A7 confère le droit de
recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule treize pour cent (0,13%) par année de la
valeur nominale de cette part sociale; puis (viii) chaque Part Sociale de Catégorie A8 confère le droit de recevoir un
dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule douze pour cent (0,12%) par année de la valeur nominale
de cette part sociale; puis (ix) chaque Part Sociale de Catégorie A9 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule onze pour cent (0,11%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
puis (x) chaque Part Sociale de Catégorie A10 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
minimum égal à zéro virgule dix pour cent (0,10%) par année de la valeur nominale de cette part sociale (collectivement
le «Droit au Bénéfice A»).
Le montant restant du dividende après l'allocation du Droit au Bénéfice A sera alloué intégralement à la dernière
Catégorie de Parts Sociales A dans l'ordre numérique inverse des Parts Sociales de Catégorie A.
(ii) Les Parts Sociales de Catégorie B confèrent le droit, au pro rata et sur une base pari passu, de recevoir un dividende
cumulé représentant le montant distribuable établi par la Société en lien avec l'Investissement Visé de Catégorie B.
A cet égard, les Parts Sociales de Catégorie B confèrent le droit de recevoir un dividende cumulatif dans l'ordre de
priorité suivant: d'abord (i) chaque Part Sociale de Catégorie B1 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un
montant au minimum égal à zéro virgule dix-neuf pour cent (0,19%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
ensuite (ii) chaque Part Sociale de Catégorie B2 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
minimum égal à zéro virgule dix-huit pour cent (0,18%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iii)
chaque Part Sociale de Catégorie B3 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal
à zéro virgule dix-sept pour cent (0,17%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iv) chaque Part
Sociale de Catégorie B4 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule
seize pour cent (0,16%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (v) chaque Part Sociale de Catégorie
19415
L
U X E M B O U R G
B5 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quinze pour cent
(0,15%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vi) chaque Part Sociale de Catégorie B6 confère le
droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quatorze pour cent (0,14%) par
année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vii) chaque Part Sociale de Catégorie B7 confère le droit de
recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule treize pour cent (0,13%) par année de la
valeur nominale de cette part sociale; puis (viii) chaque Part Sociale de Catégorie B8 confère le droit de recevoir un
dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule douze pour cent (0,12%) par année de la valeur nominale
de cette part sociale; puis (ix) chaque Part Sociale de Catégorie B9 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule onze pour cent (0,11%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
puis (x) chaque Part Sociale de Catégorie B10 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
minimum égal à zéro virgule dix pour cent (0,10%) par année de la valeur nominale de cette part sociale (collectivement
le «Droit au Bénéfice B»).
Le montant restant du dividende après l'allocation du Droit au Bénéfice B sera alloué intégralement à la dernière
Catégorie de Parts Sociales B dans l'ordre numérique inverse des Parts Sociales de Catégorie B.
(iii) Les Parts Sociales de Catégorie C confèrent le droit, au pro rata et sur une base pari passu, de recevoir un dividende
cumulé représentant le montant distribuable établi par la Société en lien avec l'Investissement Visé de Catégorie C.
A cet égard, les Parts Sociales de Catégorie C confèrent le droit de recevoir un dividende cumulatif dans l'ordre de
priorité suivant: d'abord (i) chaque Part Sociale de Catégorie C1 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un
montant au minimum égal à zéro virgule dix-neuf pour cent (0,19%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
ensuite (ii) chaque Part Sociale de Catégorie C2 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
minimum égal à zéro virgule dix-huit pour cent (0,18%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iii)
chaque Part Sociale de Catégorie C3 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal
à zéro virgule dix-sept pour cent (0,17%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iv) chaque Part
Sociale de Catégorie C4 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule
seize pour cent (0,16%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (v) chaque Part Sociale de Catégorie
C5 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quinze pour cent
(0,15%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vi) chaque Part Sociale de Catégorie C6 confère le
droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quatorze pour cent (0,14%) par
année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vii) chaque Part Sociale de Catégorie C7 confère le droit de
recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule treize pour cent (0,13%) par année de la
valeur nominale de cette part sociale; puis (viii) chaque Part Sociale de Catégorie C8 confère le droit de recevoir un
dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule douze pour cent (0,12%) par année de la valeur nominale
de cette part sociale; puis (ix) chaque Part Sociale de Catégorie C9 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule onze pour cent (0,11%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
puis (x) chaque Part Sociale de Catégorie C10 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
minimum égal à zéro virgule dix pour cent (0,10%) par année de la valeur nominale de cette part sociale (collectivement
le «Droit au Bénéfice C»).
Le montant restant du dividende après l'allocation du Droit au Bénéfice C sera alloué intégralement à la dernière
Catégorie de Parts Sociales C dans l'ordre numérique inverse des Parts Sociales de Catégorie C.
(iv) Les Parts Sociales de Catégorie D confèrent le droit, au pro rata et sur une base pari passu, de recevoir un dividende
cumulé représentant le montant distribuable établi par la Société en lien avec l'Investissement Visé de Catégorie D.
A cet égard, les Parts Sociales de Catégorie D confèrent le droit de recevoir des distributions cumulatives dans l'ordre
de priorité suivant: d'abord (i) chaque Part Sociale de Catégorie D1 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule dix-neuf pour cent (0,19%) par année de la valeur nominale de cette part
sociale; ensuite (ii) chaque Part Sociale de Catégorie D2 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant
au minimum égal à zéro virgule dix-huit pour cent (0,18%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iii)
chaque Part Sociale de Catégorie D3 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal
à zéro virgule dix-sept pour cent (0,17%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (iv) chaque Part
Sociale de Catégorie D4 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule
seize pour cent (0,16%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (v) chaque Part Sociale de Catégorie
D5 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quinze pour cent
(0,15%) par année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vi) chaque Part Sociale de Catégorie D6 confère le
droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule quatorze pour cent (0,14%) par
année de la valeur nominale de cette part sociale; puis (vii) chaque Part Sociale de Catégorie D7 confère le droit de
recevoir un dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule treize pour cent (0,13%) par année de la
valeur nominale de cette part sociale; puis (viii) chaque Part Sociale de Catégorie D8 confère le droit de recevoir un
dividende cumulatif d'un montant au minimum égal à zéro virgule douze pour cent (0,12%) par année de la valeur nominale
de cette part sociale; puis (ix) chaque Part Sociale de Catégorie D9 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif
d'un montant au minimum égal à zéro virgule onze pour cent (0,11%) par année de la valeur nominale de cette part sociale;
puis (x) chaque Part Sociale de Catégorie D10 confère le droit de recevoir un dividende cumulatif d'un montant au
19416
L
U X E M B O U R G
minimum égal à zéro virgule dix pour cent (0,10%) par année de la valeur nominale de cette part sociale (collectivement
le «Droit au Bénéfice D»).
Le montant restant du dividende après l'allocation du Droit au Bénéfice D sera alloué intégralement à la dernière
Catégorie de Parts Sociales D dans l'ordre numérique inverse des Parts Sociales de Catégorie D.
Sous réserve des conditions fixées par les Lois et conformément aux dispositions qui précèdent, les Gérants, ou le
cas échéant, le Conseil de Gérance, peuvent payer un acompte sur dividende aux associés. Les Gérants ou, le cas échéant,
le Conseil de Gérance, détermineront le montant et la date de paiement de cet acompte sur dividende.»
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges de toute nature payable par la Société en raison du présent acte sont
estimés à six mille cinq cents Euros (EUR 6.500.-).
Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant
ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom
usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.
Signé: M. Bertomeu-Savalle, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 16 décembre 2014. REM/2014/2721. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): P. MOLLING.
Pour expédition conforme.
Mondorf-les-Bains, le 9 janvier 2015.
Référence de publication: 2015006340/787.
(150006544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
General Mills Luxembourg One S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 2.595.800,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 173.584.
Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 9 janvier 2015 les décisions suivantes ont été prises:
- Démission du gérant A suivant à compter du 6 janvier 2015:
Madame Nathalie S.E. Chevalier, née le 2 mars 1977 à Kapellen, Belgique, avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Démission du gérant B suivant à compter du 6 janvier 2015:
Madame Stéphanie Jung-Schut, née le 24 novembre 1975 à Metz, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Nomination du gérant A suivant à compter du 6 janvier 2015 pour une durée indéterminée:
Monsieur Sébastien R. Rimlinger, né le 23 septembre 1975 à Sarreguemines, France, avec adresse professionnelle au
46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
- Nomination du gérant B suivant à compter du 6 janvier 2015 pour une durée indéterminée:
Monsieur Fabrice Rota, né le 19 février 1975 à Mont-Saint-Martin, France, avec adresse professionnelle au 46A, avenue
J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.
Résultant des décisions susmentionnées, le conseil de gérance de la Société est comme suit:
- Franciscus W.J.J. Welman, gérant A;
- Sébastien R. Rimlinger, gérant A;
- Patrick Leonardus Cornelis van Denzen, gérant B;
- Fabrice Rota, gérant B.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
General Mills Luxembourg One S.à r.l.
Sébastien R. Rimlinger
<i>Gérant Ai>
Référence de publication: 2015006357/30.
(150006344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
19417
L
U X E M B O U R G
Belmond Lux Treasury S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
R.C.S. Luxembourg B 181.151.
DISSOLUTION
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second day of December.
Before Us Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.
Appeared:
Belmond Interfin Ltd, a company existing under the laws of Bermuda, with registered office at Canon's Court, 22
Victoria Street, PO Box HM 1179, Hamilton, Bermuda, registered with the Registrar of Companies under the number
EC48194 (the "appearing party"),
represented byMrs Cristiana VALENT, employee, residing professionally at L-6130 Junglinster, 3, route de Luxem-
bourg,
by virtue of a proxy delivered to him under private seal.
Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxy-holder and the undersigned notary, shall remain annexed
to the present deed, to be filed with the registration authorities.
This appearing party, through its mandatory, declares and requests the notary to act:
This appearing party declares and requests the notary to act:
1) That the private limited liability company Belmond Lux Treasury S.à r.l., having its registered office at L-5365 Muns-
bach, 6C, rue Gabriel Lippmann, R.C.S. Luxembourg number B 181151, has been incorporated by deed of the undersigned
notary on the 7
th
October 2013, published in the Mémorial C number 2983 of the 26
th
November 2013, and whose
articles of incorporation have been modified for the last time by deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in
Luxembourg, on the 6
th
March 2014, published in the Mémorial C number 1330 of the 23
rd
May 2014 (the "Company").
2) That the Company's capital is fixed at twenty thousand United States Dollars (USD 20,000), divided into one hundred
(100) shares with a par value of two hundred Unites States Dollar (USD 200) each, fully paid up.
3) That the appearing party is the holder of all the shares of the Company.
4) That the appearing party has decided to dissolve and to liquidate the Company, which has discontinued all activities.
5) That the appearing party appoints itself as liquidator of the Company; and in its capacity as liquidator of the Company
has full powers to sign, execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything
necessary or useful so to bring into effect the purposes of this deed.
6) That the appearing party in his capacity as liquidator of the Company declares that it irrevocably undertakes to
settle any presently known and unknown unpaid liabilities of the dissolved Company.
7) That the appearing party declares that it takes over all the assets of the Company and that it will assume any existing
debt of the Company pursuant to point 6).
8) That the liquidation of the Company is thus to be construed as definitely terminated and liquidated.
9) That full and entire discharge is granted to the managers for the performance of their assignment.
10) That the shareholders register of the dissolved company has been cancelled.
11) That the corporate documents of the dissolved company shall be kept for the duration of five years at least at the
former registered office in L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Costsi>
The amount, approximately at least, of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or
charged to the Company as a result of the present deed, is approximately eight hundred fifty Euro.
<i>Statementi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present notarial deed was drawn up at Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, the latter signed together with Us, the notary, the present original
deed.
Suit la version en langue française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre.
Pardevant Nous Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.
19418
L
U X E M B O U R G
A comparu:
Belmond Interfin Ltd, une société de droit des Bermudes, avec siège social à Canon's Court, 22 Victoria Street, PO
Box HM 1179, Hamilton, Bermudes, immatriculée auprès du Registrar of Companies sous le numéro EC48194 (la "com-
parante"),
ici représentée par Madame Cristiana VALENT, employé privé, demeurant professionnellement à L-6130 Junglinster,
3, route de Luxembourg,
en vertu d'une procuration lui délivrée sous seing privé.
Ladite procuration, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au
présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.
Laquelle comparante, par son mandataire, déclare et requiert le notaire instrumentaire d'acter:
1) Que la société à responsabilité limitée Belmond Lux Treasury S.à r.l., ayant son siège social à L-5365 Munsbach, 6C,
rue Gabriel Lippmann, R.C.S. Luxembourg numéro B 181151, a été constituée suivant acte reçu par le notaire instru-
mentant en date du 7 octobre 2013, publié au Mémorial C numéro 2983 du 26 novembre 2013, et dont les statuts ont
été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg en
date du 6 mars 2014, publié au Mémorial C numéro 1330 du 23 mai 2014 (la "Société").
2) Que le capital de la Société est fixé à vingt mille dollars américains (USD 20.000), représenté par cent (100) parts
sociales d'une valeur nominale de deux cents dollars américain (USD 200) chacune, entièrement libérées.
3) Que la comparante est l'associée unique de la Société.
4) Que la comparante a décidé de dissoudre et de liquider la Société, qui a interrompu ses activités.
5) Que la comparante se désigne comme liquidateur de la Société et aura pleins pouvoirs d'établir, de signer, d'exécuter
et de délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour
mettre en exécution les dispositions du présent acte.
6) Que la comparante déclare de manière irrévocable reprendre tout le passif présent et futur de la Société dissoute.
7) Que la comparante déclare qu'elle reprend tout l'actif de la Société et qu'elle s'engagera à régler tout le passif de
la Société indiqué au point 6).
8) Que la liquidation de la Société est à considérer comme définitivement close.
9) Que décharge pleine et entière est donnée aux gérants pour l'exécution de leur mandat.
10) Qu'il a été procédé à l'annulation du registre des parts sociales de la société dissoute.
11) Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au moins à l'ancien siège
social L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société,
ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, s'élève approximativement à la somme de huit cent cinquante euros.
<i>Constatationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la comparante le
présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même comparante et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ce dernier a signé avec Nous notaire le présent acte.
Signé: Cristiana VALENT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 30 décembre 2014. Relation GRE/2014/5407. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015006063/97.
(150007434) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
Sethial S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-8506 Redange-sur-Attert, Zone d'Activités Economiques Solupla.
R.C.S. Luxembourg B 14.710.
Les statuts coordonnés de la société, rédigés en suite de l’assemblée générale du 16.12.2014, ont été déposés au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Capellen.
Référence de publication: 2015007492/11.
(150007892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 janvier 2015.
19419
L
U X E M B O U R G
Evo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.
R.C.S. Luxembourg B 182.618.
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-second of December.
Before Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
is held
an Extraordinary General Meeting of the shareholders of the company established in Luxembourg under the name
"EVO S.A.", registered with the RCS Luxembourg under number B 182 618, having its registered office in Luxembourg
at 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg incorporated by notarial deed of Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in
Luxembourg, on the 3
rd
of December 2013 published in the Mémorial, Associations number C 193 of the 22
nd
of January
2014. The articles of incorporation have been amended latest pursuant to a deed of the same notary dated February 11
th
, 2014, published in the Mémorial, Associations number C 1087 of the 29
th
of April 2014. The meeting opened under
the chairmanship of Martine Bruwier, residing professionally at 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg. The chairman ap-
pointed as secretary Marilyn KRECKÉ, private employee, residing professionally at L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor
Hugo. The meeting elected as scrutineer Mister Gianpiero SADDI, private employee, residing professionally at the same
address.
The Chairman then states that:
I. It appears from an attendance list established and certified by the officers that the hundred shares (100) shares with
a nominal value of three hundred and ten euros (EUR 310, -) each, representing the entire of the share capital of thirty-
one thousand euros (EUR 31,000.-) are duly represented at this meeting which consequently is formally constituted and
may deliberate and validly decide on the items on the agenda, hereinafter reproduced, all represented shareholders having
agreed to meet without prior notice.
The attendance list, signed by the shareholders all represented, will remain attached to these minutes together with
the proxies to be submitted with the formalities of registration.
II.- The agenda of this meeting is as follows:
1. Create two categories of directors A and B;
2. Change of the directors signing authority to bind the company;
3. Appointment of two new directors;
4. Allocation of directors to their respective category;
5. Amendment of Articles 5 and 6 of the Articles of Incorporation;
6. Miscellaneous.
The Assembly, after approving the statement of the Chairman and having verified that it was regularly constituted,
discussed the agenda and after deliberation, then unanimously passed the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Assembly decides to create two categories of directors, namely the A and B directors, directors which the
assembly will assign a signing authority "A" or signing authority "B" on their appointment.
<i>Second resolutioni>
The Assembly resolves that henceforth the Company will be bound by the joint signatures of one A Director and one
B Director.
<i>Third resolutioni>
The meeting appoints as new directors:
a) Julia Dyachenko, private employee, born on the 16
th
of December 1979 in Moscow and residing at 60, Letiya
Oktyabrya street, 19-325, Moscow (Russia);
b) Anastasia Tarasova, private employee, born on the 19
th
of March 1983 in Moscow and residing Kirovogradskaya
street, building 24, apartment 11, Moscow (Russia);
The terms of their mandate will expire at the end of the annual general meeting to be held in 2020.
<i>Fourth resolutioni>
The directors of the company are assigned to categories A and B as follows:
1. Is appointed as A director:
- Martine Bruwier, employee, born on the 8
th
of July 1970 in Verviers (Belgium) and residing professionally at 1, rue
Bender, L-1229 Luxembourg;
19420
L
U X E M B O U R G
2. Are appointed as B directors:
- Julia Dyachenko, private employee, residing at 60, Letiya Oktyabrya street, 19-325, Moscow (Russia);
- Anastasia Tarasova, employee, residing Kirovogradskaya street, building 24, apartment 11, Moscow (Russia);
<i>Fifth resolutioni>
Following the above resolutions, the Assembly resolves to amend articles 5 and 6 of the articles of incorporation,
which will henceforth have the following wording:
“ Art. 5. The Company is managed by one or more directors. If several directors have been appointed, the Company
shall be managed by a Board of Directors composed of at least three members, who need not to be shareholders.
The directors will be or A Director or B Director. In the appointment of a director, the General Assembly will assign
him a signing authority "A" or signing authority "B".
The Sole Director, or the Directors, in case of plurality of directors, shall be appointed for a maximum period of six
years and they shall be re-eligible; they may be removed at any time.
In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors have the right to provisionally fill the
vacancy; in this case, such a decision must be ratified by the next general meeting.”
“ Art. 6. All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall
within the competence of the Sole Director, or in case of plurality of directors, of the Board of Directors.
In case of plurality of directors, decisions on transactions having a value exceeding 100,000 Euro are subject to the
affirmative decision of the shareholders representing the majority of the company's capital.
The Company shall be bound by the sole signature of its Sole Director, and, in case of plurality of directors, by the
joint signatures of an A Director and a B Director.
In case of plurality of directors, the Board of Directors may elect a Chairman.
The Board of Directors can validly deliberate and act only if the majority of its members are present or represented,
a proxy between Directors, which may be given by letter, telegram, telefax or e-mail being permitted.
Directors may vote in writing including letter, telegram, telefax, e-mail as well as by teleconference. In all circumstances,
they shall be recorded in minutes and signed by all Directors participating at the meeting. A written decision, approved
and signed by all the Directors shall have the same effect as a decision taken at a meeting of the Board of Directors.
Decisions of the Board of Directors may also be taken by circular way.
Resolutions of the Board of Directors shall require a majority vote.»
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing
persons, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing persons
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing person, who is known to the notary, by her surname, Christian
name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre.
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
S'est tenue
une Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme établie à Luxembourg sous la déno-
mination de "EVO S.A.", inscrite au R.C.S. Luxembourg sous le numéro B 182.618, ayant son siège social à Luxembourg
au 1, rue Bender à L-1229 Luxembourg, constituée par acte de Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à
Luxembourg en date du 3 décembre 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 193 du
22 janvier 2014. Les statuts de la société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire en
date du 11 février 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1087 du 29 avril
2014.
La séance est ouverte sous la présidence de Martine Bruwier, domiciliée professionnellement au 1, rue Bender, L-1229
Luxembourg.
Monsieur le Président désigne comme secrétaire Marilyn KRECKÉ, employée privée, demeurant professionnellement
à L-1750 Luxembourg, 74, avenue Victor Hugo.
L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Gianpiero SADDI, employé privé, demeurant professionnellement à la
même adresse.
Madame le Président expose ensuite:
I.- Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que les cent actions (100) ayant
une valeur nominale de trois cent dix euros (EUR 310,-) chacune, représentant l'intégralité du capital social de trente et
19421
L
U X E M B O U R G
un mille euros (EUR 31.000,-) sont dûment représentées à la présente assemblée qui en conséquence est régulièrement
constituée et peut délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour, ci-après reproduits,
tous les actionnaires représentés ayant accepté de se réunir sans convocations préalables.
Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous représentés, restera annexée au présent procès-
verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregistrement.
II.- Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:
1. Création de deux catégories d'administrateurs A et B;
2. Modifications des pouvoirs de signature des administrateurs pour engager la société;
3. Nomination de deux nouveaux administrateurs;
4. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective;
5. Modification des articles 5 et 6 des statuts;
6. Divers.
L'Assemblée, après avoir approuvé l'exposé de Madame le Président et après s'être reconnue régulièrement consti-
tuée, a abordé l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes:
<i>Première résolutioni>
L'Assemblée décide créer deux catégories d'administrateurs A et B, administrateurs auxquels l'assemblée donnera
pouvoir de signature "A" ou pouvoir de signature "B" lors de leur nomination.
<i>Deuxième résolutioni>
L'Assemblée décide que dorénavant la société se trouvera engagée par les signatures conjointes d'un administrateur
A et d'un administrateur B.
<i>Troisième résolutioni>
L'Assemblée nomme comme nouveaux administrateurs:
a) Madame Julia Dyachenko, employée privée, née le 16 décembre 1979 à Moscou et domiciliée au 60, rue Letiya
Oktyabrya, 19-325, Moscou (Russie);
b) Madame Anastasia Tarasova, employée privée, née le 19 mars 1983 à Moscou et domiciliée rue Kirovogradskaya,
immeuble 24, appt 11, Moscou, (Russie);
Leur mandat prendra fin à l'issue de l'assemblé générale annuelle ordinaire qui se tiendra en l'an 2020.
<i>Quatrième résolutioni>
L'Assemblée décide d'affecter les administrateurs de la société dans les catégories A et B de la manière suivante:
1. Est appelé aux fonctions d'administrateur A:
- Madame Martine Bruwier, employée privée, née le 8 juillet 1970 à Verviers - Belgique et domiciliée professionnel-
lement au 1, rue Bender, L-1229 Luxembourg;
2. Sont appelés aux fonctions d'administrateurs B:
- Madame Julia Dyachenko, employée privée, domiciliée au 60, rue Letiya Oktyabrya, 19-325, Moscou (Russie);
- Madame Anastasia Tarasova, employée privée, domiciliée rue Kirovogradskaya, immeuble 24, appt 11, Moscou (Rus-
sie);
<i>Cinquième résolutioni>
L'Assemblée décide, suite aux résolutions qui précèdent, de modifier les articles 5 et 6 des statuts, qui auront désormais
la teneur suivante:
« Art. 5. La Société est administrée par un ou plusieurs administrateurs. En cas de pluralité d'administrateurs, la Société
doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.
Les administrateurs seront soit Administrateur A ou Administrateur B. Lors de la nomination d'un administrateur,
l'assemblée générale lui donnera pourvoir de signature «A» ou pouvoir de signature «B».
Les administrateurs ou l'administrateur unique sont nommés pour une durée qui ne peut pas dépasser six ans; ils sont
rééligibles et toujours révocables.
En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement;
dans ce cas, l'Assemblée Générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»
« Art. 6. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l'objet social; tout ce qui n'est pas réservé à l'Assemblée Générale par la loi ou les présents statuts est de sa compétence.
En cas de pluralité d'administrateurs, les décisions sur les transactions ayant une valeur supérieure à 100.000 euros
sont soumises à la décision positive des actionnaires représentant la majorité du capital de la Société.
19422
L
U X E M B O U R G
La Société se trouve engagée par la seule signature de son administrateur unique et, en cas de pluralité d'administra-
teurs, par la signature conjointe d'un administrateur A et d'un administrateur B.
En cas de pluralité d'administrateurs, le conseil d'administration élit en son sein son président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, le mandat
entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme, télécopie ou e-mail, étant admis.
Les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, lettre, télégramme, télécopie, e-mail, ainsi que par télécon-
férence. En toute circonstance, un procès-verbal sera dressé et signé par tous les administrateurs qui ont participé. Les
résolutions par écrit approuvées et signées par tous les administrateurs auront les mêmes effets que les résolutions
adoptées lors des réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut également prendre ses décisions
par voie circulaire.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.»
Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-
parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.
Signé: M. Bruwier, M. Krecké, G. Saddi et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 02 janvier 2015. 2LAC/2015/69. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-
<i>Le Receveuri>
(signé): Paul MOLLING.
POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication
au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 14 janvier 2015.
Référence de publication: 2015007930/182.
(150008954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Neptune Properties S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1610 Luxembourg, 4-6, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 163.233.
Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 3 Septembre 2014.
NEPTUNE PROPERTIES S.à r.l.
Rachel Hafedh
<i>Géranti>
Référence de publication: 2015008254/14.
(150009055) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
BRP Luxembourg Holdings I, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.
R.C.S. Luxembourg B 165.045.
Veuillez prendre note qu'une erreur s'est glissée lors du dépôt de la décision prise par le conseil de gérance en date
du 15 novembre 2014 auprès du registre de Commerce et des Sociétés, sous la référence L150000885 en date du 05
janvier 2015.
Il convient de lire que la société BRP Luxembourg Holdings I a son siège au 13-15 avenue de la Liberté, L-1931
Luxembourg et non pas au 13-15 avenue de la Liberté, L-1935 Luxembourg.
Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour BRP Luxembourg Holdings I
i>Intertrust (Luxembourg) S.à r.l.
Référence de publication: 2015007728/16.
(150009491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
19423
L
U X E M B O U R G
Nade Luxco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 179.513.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Nade Luxco 1 S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2015008244/11.
(150008916) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Façonnable S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25C, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 193.595.
STATUTES
In the year two thousand and fourteen, on the twenty-third day of December.
Before the undersigned, Jean SECKLER, a notary resident in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Façonnable Group Limited, a company incorporated under the laws of Dubai, having its registered office at Level 4,
Office 413, Liberty House, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 333840, Dubai, United Arab Emirates, registered
under the commercial license number CL0594,
here represented by Mr Max MAYER, employee, whose professional address is 3, route de Luxembourg L-6130
Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given in Nice, on 19 December 2014,
After signature ne varietur by the authorised representative of the appearing party and the undersigned notary, the
power of attorney will remain attached to this deed to be registered with it.
The appearing party, represented as set out above, have requested the undersigned notary to state as follows the
articles of incorporation of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorpo-
rated:
I. Name - Registered office - Object - Duration
Art. 1. Name. The name of the company is “Façonnable S.à r.l.” (the Company). The Company is a private limited
liability company (société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular
the law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the
Articles).
Art. 2. Registered office.
2.1. The Company's registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred
within that municipality by a resolution of the board of managers. It may be transferred to any other location in the Grand
Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the
amendment of the Articles.
2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a
resolution of the board of managers. If the board of managers determines that extraordinary political or military deve-
lopments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal
activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad,
the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely
ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary
transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
Art. 3. Corporate object.
3.1. The Company's object is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enter-
prises in any form whatsoever, and the management of those participations. The Company may in particular acquire, by
subscription, purchase and exchange or in any other manner, any stock, shares and other participation securities, bonds,
debentures, certificates of deposit and other debt instruments and, more generally, any securities and financial instruments
issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any
company or enterprise. Further, it may invest in the acquisition and management of a portfolio of patents, trademarks,
or other intellectual property rights of any nature or origin.
19424
L
U X E M B O U R G
3.2. The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement
only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. It may lend funds, including, without limitation, the proceeds
of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. It may also give guarantees and pledge,
transfer, encumber or otherwise create and grant security over some or all of its assets to guarantee its own obligations
and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the
avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated financial sector activities without having obtained the
requisite authorisation.
3.3. The Company may use any techniques, legal means and instruments to manage its investments efficiently and
protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.
3.4. The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect
to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.
3.5. The Company may start, manage and carry on, directly or indirectly, any activity related to the holding, the
commercialization and/or the disposal of patents, trademarks, domain names, copyrights and any intellectual property
rights of any nature and origin.
Art. 4. Duration.
4.1. The Company is formed for an unlimited period.
4.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.
II. Capital - Shares
Art. 5. Capital.
5.1. The share capital is set at one hundred thousand euro (EUR 100,000), represented by one hundred thousand
(100,000) shares in registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each.
5.2. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in
accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.
Art. 6. Shares.
6.1. The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.
6.2. The shares are freely transferable between shareholders.
6.3. When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.
6.4. When the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject
to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.
6.5. A share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by,
the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
6.6. A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on
request.
6.7. The Company may redeem its own shares, provided:
(i) it has sufficient distributable reserves for that purpose; or
(ii) the redemption results from a reduction in the Company's share capital.
III. Management - Representation
Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company shall be managed by one or more managers appointed by a resolution of the shareholders, which
sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
7.2. The managers may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the shareholders.
Art. 8. Board of managers. If several managers are appointed, they shall constitute the board of managers (the Board).
The shareholders may decide to appoint managers of two different classes, i.e. one or several class A managers and one
or several class B managers.
8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the
Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate
object.
(ii) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.
8.2. Procedure
(i) The Board shall meet at the request of any two (2) managers, at the place indicated in the convening notice, which
shall be in Luxembourg.
19425
L
U X E M B O U R G
(ii) Written notice of any Board meeting shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,
except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.
(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they
have full knowledge of the agenda for the meeting. A manager may also waive notice of a meeting, either before or after
the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a
schedule previously adopted by the Board.
(iv) A manager may grant to another manager a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.
(v) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board
resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the managers present or represented, provided that if
the shareholders have appointed one or several class A managers and one or several class B managers, at least one (1)
class A manager and one (1) class B manager votes in favour of the resolution. Board resolutions shall be recorded in
minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the managers present
or represented.
(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means
of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation
by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.
(vii) Circular resolutions signed by all the managers (Managers'Circular Resolutions) shall be valid and binding as if
passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature.
8.3. Representation
(i) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of the sole manager or, in case
of a plurality of managers, the joint signature of a Class A Manager and a Class B manager.
(ii) The Company shall also be bound towards third parties by the signature of any person to whom special powers
have been delegated by the Board. In particular, the Board may delegate to any manager the duty to sign, execute and/
or ratify actions or documents duly approved by the Board.
Art. 9. Sole manager. If the Company is managed by a sole manager, all references in the Articles to the Board, the
managers or any manager are to be read as references to the sole manager, as appropriate.
Art. 10. Liability of the managers. The managers shall not be held personally liable by reason of their office for any
commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles
and the Law.
IV. Shareholders
Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders' written resolutions.
11.1. Powers and voting rights
(i) Unless resolutions are taken in accordance with article 11.1.(ii), resolutions of the shareholders shall be adopted
at a general meeting of shareholders (each a General Meeting).
(ii) If the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), resolutions of the shareholders
may be adopted in writing (Written Shareholders - Resolutions).
(iii) Each share entitles the holder to one (1) vote.
11.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board. The Board must convene a General Meeting
following a request from shareholders representing more than half of the share capital.
(ii) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders at least eight (8) days prior to the date of
the meeting, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in
the notice.
(iii) When resolutions are to be adopted in writing, the Board shall send the text of such resolutions to all the share-
holders. The shareholders shall vote in writing and return their vote to the Company within the timeline fixed by the
Board. Each manager shall be entitled to count the votes.
(iv) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.
(v) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the
agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.
(vi) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order
to be represented at any General Meeting.
(vii) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by shareholders owning more than one-half of the
share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting, the shareholders shall be convened by registered
letter to a second General Meeting and the resolutions shall be adopted at the second General Meeting by a majority of
the votes cast, irrespective of the proportion of the share capital represented.
19426
L
U X E M B O U R G
(viii) The Articles may only be amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least
three-quarters of the share capital.
(ix) Any change in the nationality of the Company and any increase in a shareholder's commitment to the Company
shall require the unanimous consent of the shareholders.
(x) Written Shareholders' Resolutions are passed with the quorum and majority requirements set forth above and
shall bear the date of the last signature received prior to the expiry of the timeline fixed by the Board.
Art. 12. Sole shareholder. When the number of shareholders is reduced to one (1):
(xi) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;
(xii) any reference in the Articles to the shareholders, the General Meeting, or the Written Shareholders' Resolutions
is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and
(xiii) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.
V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision
Art. 13. Financial year and approval of annual accounts.
13.1. The financial year begins on the first (1) of January and ends on the thirty-first (31) of December of each year.
13.2. Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss accounts, together with an inventory
stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the
debts owed by its managers and shareholders to the Company.
13.3. Any shareholder may inspect the inventory and balance sheet at the registered office.
13.4. The balance sheet and profit and loss accounts must be approved in the following manner:
(i) if the number of shareholders of the Company does not exceed twenty-five (25), within six (6) months following
the end of the relevant financial year either (a) at the annual General Meeting or (b) by way of Written Shareholders'
Resolutions; or
(ii) if the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), at the annual General Meeting.
Art. 14. Auditors.
14.1. When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more approved external
auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The shareholders shall appoint the approved external auditors, if any, and
determine their number and remuneration and the term of their office.
14.2. If the number of shareholders of the Company exceeds twenty-five (25), the Company's operations shall be
supervised by one or more commissaires (statutory auditors), unless the law requires the appointment of one or more
approved external auditors (réviseurs d'entreprises agréés). The commissaires are subject to reappointment at the annual
General Meeting. They may or may not be shareholders.
Art. 15. Allocation of profits.
15.1. Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the
Legal Reserve). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the
share capital.
15.2. The shareholders shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the
payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable
legal provisions.
15.3. Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions:
(i) the Board must draw up interim accounts;
(ii) the interim accounts must show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available
for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed the profits made since the end of
the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by profits carried forward and
distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;
(iii) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim
dividends; and
(iv) taking into account the assets of the Company, the rights of the Company's creditors must not be threatened by
the distribution of an interim dividend.
If the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the Board has the right to
claim the reimbursement of dividends not corresponding to profits actually earned and the shareholders must immediately
refund the excess to the Company if so required by the Board.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the shareholders adopted with the consent of a
majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders shall appoint
one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number,
19427
L
U X E M B O U R G
powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators shall have full power to realise
the Company's assets and pay its liabilities.
16.2. The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the share-
holders in proportion to the shares held by each of them.
VII. General provisions
17.1. Notices and communications may be made or waived, Managers' Circular Resolutions and Written Shareholders
Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, e-mail or any other means of electronic communication.
17.2. Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with
Board meetings may also be granted by a manager, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
17.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed
equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers' Circular Resolutions, the resolutions adopted by the
Board by telephone or video conference or the Written Shareholders' Resolutions, as the case may be, may appear on
one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same
document.
17.4. All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law
and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any agreement entered into by the shareholders from time
to time.
<i>Transitional provisioni>
The Company's first financial year shall begin on the date of this deed and shall end on the thirty-first (31) day of
December 2015.
<i>Subscription and paymenti>
Façonnable Group Limited, represented as stated above, subscribes for one hundred thousand (100,000) shares in
registered form, having a nominal value of one euro (EUR 1) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash
of one hundred thousand euro (EUR 100,000),
The amount of one hundred thousand euro (EUR 100,000) is at the Company's disposal and evidence of such amount
has been given to the undersigned notary.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever to be borne by the Company in connection with its
incorporation are estimated at approximately EUR 1,600.-
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, its sole shareholder, representing the entire subscribed capital,
adopted the following resolutions:
1. The following are appointed as managers of the Company for a period of 3 years:
Mr Moustapha El-Solh, businessman, born on August 30, 1970, at Beyrouth, Lebanon, resident at 27, avenue Princesse
Grace, Le Formentor, 98000 Monaco - Principauté de Monaco, as Class A manager.
Mr Franz Duclos, manager, born on 15 November 1975 at Mont-Saint-Aignan (France), professionally resident at 25C,
boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as Class B manager.
2. The registered office of the Company is located at 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duchy of
Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states at the request of the appearing party that this
deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies, the English version prevails.
This notarial deed is drawn up in Junglinster, on the date stated above.
After reading this deed aloud, the notary signs it with the authorised representatives of the appearing party.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le ving-troisième jour de décembre,
Par devant le soussigné Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Façonnable Group Limited, une société régie par les lois de Dubai, dont le siège social se situe à Level 4, Office 413,
Liberty House, Dubai International Financial Centre, P.O. Box 333840, Dubai, Emirats Arabes Unis, enregistrée sous le
numéro de licence commerciale CL0594,
19428
L
U X E M B O U R G
représentée par Monsieur Max MAYER, employé, avec adresse professionnelle au 3, route de Luxembourg L-6130
Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Nice, le 19 décembre 2014.
Après avoir été signées ne varietur par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant, lesdites
procurations resteront annexées au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.
Les parties comparantes, représentées comme indiqué ci-dessus, ont prié le notaire instrumentant d'acter de la façon
suivante les statuts d'une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Dénomination. Le nom de la société est "Façonnable S.à r.l." (la Société).
La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier
par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les
Statuts).
Art. 2. Siège social.
2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans
cette même commune par décision du conseil de gérance. Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du
Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des
Statuts.
2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger
par décision du conseil de gérance. Lorsque le conseil de gérance estime que des développements ou événements ex-
traordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements
sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre
le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de
ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert
provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.
Art. 3. Objet social.
3.1. L'objet de la Société est la prise de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou
entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par
souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations,
créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs mobilières et instru-
ments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion
et au contrôle de toute société ou entreprise. Elle peut en outre investir dans l'acquisition et la gestion d'un portefeuille
de brevets, marques ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit.
3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,
uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de tous types de titres et ins-
truments de dette ou de capital. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment les revenus de tous emprunts,
à ses filiales, sociétés affiliées, ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir,
céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses
propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre
société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier
sans avoir obtenu l'autorisation requise.
3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investis-
sements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et
autres risques.
3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions
concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet
social.
3.5. La Société peut constituer, gérer et exercer, directement ou indirectement, toute activité en lien avec la détention,
la commercialisation et/ou la mise à disposition de brevets, de marques, de nom de domaines, de droits d'auteurs et de
tout autre droit de propriété intellectuelle de toute nature et origine.
Art. 4. Durée.
4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
4.2. La Société ne sera pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insol-
vabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.
II. Capital - Parts sociales
Art. 5. Capital.
5.1. Le capital social est fixé à cent mille euros (EUR 100.000), représenté par cent mille (100.000) parts sociales sous
forme nominative, ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.
19429
L
U X E M B O U R G
5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée
selon les modalités requises pour la modification des Statuts.
Art. 6. Parts sociales.
6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
6.3. Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.
6.4. Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord
préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.
6.5. Une cession de parts sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à
la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.
6.6. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
6.7. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition:
(i) qu'elle ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet; ou
(ii) que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.
III. Gestion - Représentation
Art. 7. Nomination et révocation des gérants.
7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur
mandat. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
7.2. Les gérants sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision des associés.
Art. 8. Conseil de gérance. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront le conseil de gérance (le Conseil). Les
associés peuvent décider de nommer des gérants de deux différentes classes, à savoir un ou plusieurs gérants de classe
A et un ou plusieurs gérants de classe B.
8.1. Pouvoirs du conseil de gérance
(i) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux associés sont de la compétence du
Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.
(ii) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.
8.2. Procédure
(i) Le Conseil se réunit sur convocation de deux (2) gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui sera au
Luxembourg.
(ii) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les gérants au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées
dans la convocation à la réunion.
(iii) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux
déclare avoir parfaitement connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la con-
vocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées
pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.
(iv) Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.
(v) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.
Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, à la
condition que lorsque les associés ont nommé un ou plusieurs gérants de classe A et un ou plusieurs gérants de classe
B, au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B votent en faveur de la décision. Les décisions du Conseil sont
consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous
les gérants présents ou représentés.
(vi) Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio-conférence ou par tout autre moyen
de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se
parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement con-
voquée et tenue.
(vii) Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (des Résolutions Circulaires des Gérants) sont valables et
engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue
et portent la date de la dernière signature.
8.3. Représentation
(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du gérant unique, respectivement
par les signatures conjointes d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B.
(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute personne à qui des pouvoirs spéciaux
ont été délégués par le Conseil. En particulier, le Conseil peut déléguer à tout gérant la tâche de signer, exécuter ou
ratifier des actions ou documents dûment approuvées par le Conseil.
19430
L
U X E M B O U R G
Art. 9. Gérant unique. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux
gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.
Art. 10. Responsabilité des gérants. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle
concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
conformes aux Statuts et à la Loi.
IV. Associés
Art. 11. Assemblées générales des associés et résolutions écrites des associés.
11.1. Pouvoirs et droits de vote
(i) Sauf lorsque des résolutions sont adoptées conformément à l'article 11.1. (ii), les résolutions des associés sont
adoptées en assemblée générale des associés (chacune une Assemblée Générale).
(ii) Si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), les résolutions des associés peuvent être
adoptées par écrit (des Résolutions Ecrites des Associés).
(iii) Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
11.2. Convocations, quorum, majorité et procédure de vote
(i) Les associés peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil. Le Conseil doit convoquer
une Assemblée Générale à la demande des associés représentant plus de la moitié du capital social.
(ii) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant
la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence doivent être
précisées dans la convocation à ladite assemblée.
(iii) Lorsque des résolutions sont adoptées par écrit, le Conseil communique le texte des résolutions à tous les associés.
Les associés votent par écrit et envoient leur vote à la Société dans le délai fixé par le Conseil. Chaque gérant est autorisé
à compter les votes.
(iv) Les Assemblées Générales sont tenues au lieu et heure précisés dans les convocations.
(v) Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et
informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
(vi) Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à
toute Assemblée Générale.
(vii) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social.
Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale, les associés sont convoqués par lettre recommandée
à une seconde Assemblée Générale et les décisions sont adoptées par l'Assemblée Générale à la majorité des voix
exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.
(viii) Les Statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant
au moins les trois-quarts du capital social.
(ix) Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la
Société exige le consentement unanime des associés.
(x) Des Résolutions Ecrites des Associés sont adoptées avec le quorum de présence et de majorité détaillés ci-dessus.
Elles porteront la date de la dernière signature reçue avant l'expiration du délai fixé par le Conseil.
Art. 12. Associé unique. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1):
(i) l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale;
(ii) toute référence dans les Statuts aux associés, à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Ecrites des Associés est
considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier; et
(iii) les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.
V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle
Art. 13. Exercice social et approbation des comptes annuels.
13.1. L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.
13.2. Chaque année, le Conseil doit dresser le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant
la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes
du ou des gérants et du ou des associés envers la Société.
13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.
13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes doivent être approuvés de la façon suivante:
(i) si le nombre des associés de la Société ne dépasse pas vingt-cinq (25), dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice
social en question, soit (a) par l'Assemblée Générale annuelle, soit (b) par voie de Résolutions Ecrites des Associés; ou
(ii) si le nombre des associés de la Société dépasse vingt-cinq (25), par l'Assemblée Générale annuelle.
19431
L
U X E M B O U R G
Art. 14. Commissaires / réviseurs.
14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, dans les cas
prévus par la loi. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises agréés, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur
rémunération et la durée de leur mandat.
14.2. Si la Société a plus de vingt-cinq (25) associés, ses opérations sont surveillées par un ou plusieurs commissaires,
à moins que la loi ne requière la nomination d'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés. Le mandat des commissaires
peut être renouvelé par l'Assemblée Générale annuelle. Ils peuvent être associés ou non.
Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi (la
Réserve Légale). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital
social.
15.2. Les associés décident de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Ils peuvent allouer ce bénéfice au
paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.
15.3. Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
(i) Le Conseil établit des comptes intérimaires;
(ii) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime
d'émission) sont disponibles pour une distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser le
montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas
échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes
à affecter à la réserve légale;
(iii) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes
intérimaires; et
(iv) compte tenu des actifs de la Société, les droits des créanciers de la Société ne doivent pas être menacés.
Si les dividendes intérimaires qui ont été distribués dépassent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, le
Conseil a le droit de réclamer la répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis et les
associés doivent immédiatement reverser l'excès à la Société à la demande du Conseil.
VI. Dissolution - Liquidation
16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre)
des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nommeront un ou plusieurs liquidateurs,
qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération.
Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et
payer les dettes de la Société.
16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux associés
proportionnellement aux parts sociales détenues par chacun d'entre eux.
VII. Dispositions générales
17.1. Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions
Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Ecrites des Associés peuvent être établies par écrit, par téléfax, e-mail
ou tout autre moyen de communication électronique.
17.2. Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux
réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le
Conseil.
17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions
légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Gérants, des
résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Ecrites des Associés, selon le
cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique
document.
17.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des
dispositions légales d'ordre public, à tout accord présent ou futur conclu entre les associés.
<i>Disposition transitoirei>
Le premier exercice social de la Société commence à la date du présent acte et s'achèvera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et libérationi>
Façonnable Group Limited, représentée comme indiqué ci-dessus, déclare souscrire à cent mille (100.000) parts so-
ciales sous forme nominative, d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune, et les libérer intégralement par un apport
en numéraire d'un montant de cent mille euros (EUR 100.000), Le montant de cent mille euros (EUR 100.000) est à la
disposition de la Société, comme il a été prouvé au notaire instrumentant.
19432
L
U X E M B O U R G
<i>Fraisi>
Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution
s'élèvent approximativement à 1.600,-EUR.
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique de la Société, représentant l'intégralité du capital
social souscrit, a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées en qualité de gérants de la Société pour une durée de 3 ans:
2. Monsieur Moustapha el-Solh, dirigeant d'entreprise, né à Beyrouth, Liban, le 30 août 1970, résidant au 27, avenue
Princesse Grace, Le Formentor, 98000 Monaco, Principauté de Monaco, en tant que gérant de Classe A.
Monsieur Franz Duclos, gérant, né à Mont-Saint-Aignan (France) le 15 novembre 1975, résidant professionnellement
au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de Classe B.
3. Le siège social de la Société est établi au 25C, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante que le présent
acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et qu'en cas de divergences, la version anglaise fait foi.
Fait et passé à Junglinster, à la date qu'en tête des présentes.
Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.
Signé: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 31 décembre 2014. Relation GRE/2014/. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €
<i>Le Receveur ff.i> (signé): Claire PIERRET.
Référence de publication: 2015007931/500.
(150008765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Itaú Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 80.545.
Le conseil d'Administration décide à l'unanimité des voix de transférer le siège social siégeant au 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg au 49, avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg avec effet au 19 Décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 31 Décembre 2014.
<i>Un mandatairei>
Référence de publication: 2015006397/12.
(150007048) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
LVS Luxembourg I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 25.000,00.
Siège social: L-1660 Luxembourg, 60, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 169.971.
EXTRAIT
En date du 11 décembre 2014, l'associé unique de la Société a décidé (i) d'accepter la démission de Monsieur Sansal
Ozdemir en tant que gérant B de la Société avec effet au 19 décembre 2014 et (ii) de nommer Monsieur Paul Lawrence,
avec adresse professionnelle au 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant
que gérant B de la Société avec effet au 11 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 13 janvier 2015.
<i>Pour LVS Luxembourg I S.à r.l.i>
Référence de publication: 2015006518/16.
(150007279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 janvier 2015.
19433
L
U X E M B O U R G
EVI UK Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: GBP 10.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 193.621.
STATUTEN
Im Jahre zweitausendundvierzehn, am elften Dezember.
Vor Maître Henri Hellinckx, Notar mit Amtswohnsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
IST ERSCHIENEN:
Institutional Investment Partners GmbH, handelnd in ihrer Kapazität als Kapitalverwalter für AEW Europe Value In-
vestors, eine deutsche Gesellschaft mit Gesellschaftssitz in der Hamburger Allee 45, D-60486 Frankfurt am Main,
Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter der Nummer
HRB 90129;
vertreten durch Régis Galiotto, Notarsekretär, mit Berufsanschrift in Luxembourg, aufgrund einer Vollmacht unter
Privatschrift.
Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten
Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.
In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.
Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter
der Bezeichnung "EVI UK Holding S.à r.l." (die Gesellschaft).
Art. 2. Gesellschaftszweck. Ausschließlicher Zweck der Gesellschaft ist das direkte und/oder indirekte Halten von
Beteiligungen an Gesellschaften, deren Zweck der Erwerb, die Bebauung und Verwaltung von Grundstücken oder grunds-
tücksgleichen Rechten, die in einem Staat des EWR oder Vollmitgliedstaat der OECD belegen sind.
Die Gesellschaft darf sonst alle Aktivitäten ausführen, die direkt oder indirekt in Zusammenhang mit dem Gesell-
schaftszweck stehen.
Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.
Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxembourg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum
Luxemburg verlegt werden. Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des
Geschäftsführerrats verlegt werden.
Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.
Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt GBP 10.500 (zehntausendfünfhundert Britische Pfund),
eingeteilt in 105 (einhundertfünf) Anteile mit einem Nennwert von je GBP 100 (hundert Britische Pfund) pro Anteil.
Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung
durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.
Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht
auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.
Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die
Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.
Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter
Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.
Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens
drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.
In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915
über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.
Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,
soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.
19434
L
U X E M B O U R G
Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses
durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.
Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Bes-
tehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.
Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer
bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.
Die Gesellschafterversammlung kann jederzeit den Geschäftsführer, oder wenn mehrere Geschäftsführer bestellt
wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.
Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten
und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen
Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.
Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführer hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflichtet;
bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die gemeinschaftliche Unterschrift zweier Geschäftsführer
verpflichtet.
Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, zwei Ge-
schäftsführer gemeinschaftlich, können ihre Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere
adhoc-Bevollmächtigte (Prokuristen) delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von
mehreren Geschäftsführern, der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, die ihre Befugnisse delegieren, legen die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.
Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein
Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.
Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden
im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von zwei Geschäftsführern gemeinsam einberufen werden.
Wenn alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung infor-
miert wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit
und an einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine
gesonderte Einberufung entbehrlich.
Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer
zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel (wie oben beschrieben) teilnimmt, gilt als persönlich anwesend; eine solche über Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilneh-
menden oder vertretenen Geschäftsführern, im Falle einer von einem Vorsitzenden geleiteten Sitzung von diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen
Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen
Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse en-
thalten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.
19435
L
U X E M B O U R G
Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en
nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.
Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder
bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.
Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-
nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.
Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-
lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).
Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befu-
gnisse der Gesellschafterversammlung auf sich.
Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-
zunehmen, unabhängig von seiner Kapitalbeteiligung. Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie Anteile auf ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.
Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch
eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.
Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten
Dezember eines jeden Jahres.
Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.
Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.
Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach
Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.
Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere
Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.
Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-
prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach den Artikeln 256 und 215 des
Gesetzes von 1915 keine Anwendung findet.
Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt
werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:
Institutional Investment Partners GmbH, handelnd in ihrer Kapazität als
Kapitalverwalter für AEW Europe Value Investors, oben genannt: . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (einhundertfünf) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (einhundertfünf) Anteile
Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von GBP 10.500 (zehntausendfünfhundert Britische
Pfund) ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar
gegenüber erbracht.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.
19436
L
U X E M B O U R G
<i>Kosteni>
Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich
auf ungefähr eintausend fünfhundert Euro (EUR 1.500,-).
<i>Generalversammlung des Gesellschafters nach der Gründungi>
Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der oben genannte Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete
Gesellschaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:
1. der Geschäftsführerrat hat 2 (zwei) Mitglieder. Zu Geschäftsführern der Gesellschaft werden folgende Personen für
eine unbestimmte Zeit ernannt:
(1) Bruno Bagnouls, geboren am 9. Mai 1971 in Nancy, Frankreich, mit Berufsanschrift in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxemburg; und (2) Jean-Philippe Fiorucci, geboren am 8. Juni 1972 in Villerupt, Frankreich, mit Berufsanschrift in 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg;
2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erscheinenden
Partei diese Urkunde in deutscher Sprache verfasst und mit einer englischen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des deutschen vom englischen Text der deutsche Text maßgebend ist.
Worüber, die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten, Datum in Luxemburg erstellt wird.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden hat der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-
zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.
There follows the English translation of the foregoing:
In the year two thousand and fourteen, on the eleventh day of December.
Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Institutional Investment Partners GmbH, acting in its capacity as asset manager for AEW Europe Value Investors, a
company incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Hamburger Allée 45, D-60486 Frankfurt
am Main, Germany, and registered with the commercial register of the local court (Amtsgericht) of Frankfurt am Main
under the number HRB 90129;
hereby represented by Régis Galiotto, notary's clerk, residing professionally at Luxembourg, by virtue of a power of
attorney, given under private seal.
Said power of attorney, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the
undersigned notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration
authorities.
Such appearing party, in the capacity in which it acts has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.
Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "EVI UK
Holding S.à r.l." (the Company).
Art. 2. Corporate object. The sole purpose of the company is the direct and / or indirect holding of participations in
companies whose purpose is the acquisition, development and management of real property and equivalent rights, which
are located in a state of the EEA or a full member state of the OECD.
The Company may otherwise perform all the activities that are directly or indirectly related to the corporate purpose.
Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.
Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-
dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company or by way of a resolution of an extraordinary general meeting of its
shareholders.
The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.
Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at GBP 10,500 (ten thousand five hundred British
Pounds), represented by 105 (one hundred and five) shares, having a nominal value of GBP 100 (one hundred British
Pounds) each.
Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole
shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.
19437
L
U X E M B O U R G
Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct
proportion to the number of shares in existence.
Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted
per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.
Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely
transferable.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the general
meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.
The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-
quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.
The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as
amended (the Companies Act) will apply.
Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the
Company has sufficient distributable reserves and profits to that effect.
The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of
a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.
Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The Company may have one
shareholder or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights,
insolvency, liquidation or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders.
Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,
they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.
The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager
or, in case of plurality, any one of them.
In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in
all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.
All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders
fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.
The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the
joint signature of any two managers.
The manager, or in case of plurality of managers, any two managers may sub-delegate their powers for specific tasks
to one or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine
this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.
In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the
managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members is present or represented at a meeting of the board of managers.
A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting
of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.
In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,
in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any two managers
jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been
informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and
places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-
mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, video-conference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, video-conference or
by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
19438
L
U X E M B O U R G
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers
attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached
to the minutes of the relevant meeting.
Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the
minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.
Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their
position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.
Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the
registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.
Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective
notices of meeting.
As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead
of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).
Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the
general meeting of the shareholders.
In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number
of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.
However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in
number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.
Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January of each year and ends on 31 December of the
same year.
Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and
the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of
the value of the Company's assets and liabilities.
Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.
Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after
deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent.
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent.
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.
Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several
liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.
Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs
only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An external auditor needs to
be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on
the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.
Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for
which no specific provision is made in these articles of association.
<i>Subscription and paymenti>
All shares have been subscribed as follows:
Institutional Investment Partners GmbH, acting in its capacity as asset manager
for AEW Europe Value Investors, prenamed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (one hundred and five) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 (one hundred and five) shares
All shares have been fully paid-up by means of a contribution in cash in an amount of GBP 10,500 (ten thousand five
hundred British Pounds), so that the sum of GBP 10,500 (ten thousand five hundred British Pounds) is at the free disposal
of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.
19439
L
U X E M B O U R G
<i>Transitory provisioni>
The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a
result of the present deed are estimated to be approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).
<i>Extraordinary general meetingi>
Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company
has herewith adopted the following resolutions:
1. The number of managers of the Company is set at 2 (two). The meeting appoints as managers of the Company, for
an unlimited period, the following persons:
(1) Bruno Bagnouls, born on 9 May 1971 in Nancy, France, with professional address at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882
Luxembourg, and (2) Jean-Philippe Fiorucci, born on 8 June 1972 in Villerupt, France, with professional address at 5, rue
Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg.
2. The registered office is established at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder
of the appearing party, the present deed is worded in German followed by an English version. At the request of the same
proxyholder of the appearing party and in case of divergences between the German and English versions, the German
version will prevail.
Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial
deed.
This notarial deed, having been read to the proxyholder of the appearing party, which is known to the notary by his
surname, name, civil status and residence, the said proxyholder of the appearing party signed the present deed together
with the notary.
Gezeichnet: R. GALIOTTO und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 19 décembre 2014. Relation: LAC/2014/61580. Reçu soixante-quinze euros (75.-
EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.
Luxemburg, den 14. Januar 2015.
Référence de publication: 2015007928/359.
(150009053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
M.C. Facades S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2442 Luxembourg, 340, rue de Rollingergrund.
R.C.S. Luxembourg B 160.016.
EXTRAIT
Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social
fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se répartit comme suit:
Monsieur Antonio José Amaral Monteiro
Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Monsieur Francisco Marto De Jesus Pereira Camelo
Cinquante parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
L'assemblée décide de prendre acte du changement de la fonction de Monsieur Francisco Marto De Jesus Pereira
Camelo de gérant administratif en gérant technique pour une durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 04 décembre 2014.
M.C. FACADES S.ar.l.
Signatures
Référence de publication: 2015008178/21.
(150009255) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 janvier 2015.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
19440
Belmond Lux Treasury S.à r.l.
BRP Luxembourg Holdings I
Cofima I S.A.
Digital Services XL Top-Holding S.C.Sp.
Diplomatic Finance Association International S.A.
Dome Capital S.à r.l.
Donatello Sicav
DSM Lux GmbH
DS Turkey 8 S. à r. l.
Ebony Finance S.A.
Eco-Immo s.à r.l.
Econocom Luxembourg S.A.
EDI Construction S.A.
Eggborough HoldCo 2 S.à r.l.
Else 1 S.à r.l.
Else 2 S.à r.l.
Elvafin S.A.
EMM Euromultimédia S.A.
EMM Euromultimédia S.A.
EMM Euromultimédia S.A.
Ennis S.à r.l.
Enoc S.A.
Enterprise Systems Technologies S.à r.l.
Entreprise de Façades Miotto Romain et Fils Sàrl
Envipro S.A.
Equinix (Luxembourg) Investments S.à r.l.
ERA-GDL
Escalion S.à r.l.
Eschersheimer Landstrasse 19-21 S.à r.l.
Eurofins Analyses Environnementales pour les Industriels France LUX Holding
Eurofins Analyses pour la Construction France LUX Holding
Eurofins Clinical Testing Holding Lux S.à r.l.
EVI UK Holding S.à r.l.
Evo S.A.
Façonnable S.à r.l.
Faneos Invest S.A.
First State Investments Fund Management S. à r.l.
FR Group Holdings S.à r.l.
General Mills Luxembourg One S.à r.l.
Haro S.A.
Itaú Funds
Limba Luxco 2 S.à r.l.
LVS Luxembourg I S.à r.l.
M.C. Facades S.à r.l.
Munsterfred Property S.à r.l.
Nade Luxco 1 S.à r.l.
Neptune Properties S.à r.l.
Sethial S.à r.l.