logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 313

5 février 2015

SOMMAIRE

Aberdeen Global II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14978

Amlelux S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15013

Association des Parents d'Elèves de l'Ecole

Fondamentale de Strassen  . . . . . . . . . . . . .

15014

Association des Parents d'Elèves de l'En-

seignement Primaire de Strassen
(A.P.E.E.P:)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15014

Attert Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15016

BBL Holding S.A., SPF . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14982

Bilux S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15017

CEP IV Investment 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . .

14985

Chauffage-Sanitaire Claude Schreiber S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14984

CJ Lux Holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14985

Clean Fuels (South America) S.A.  . . . . . . .

14986

Coil Architectes S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

14984

Combourg (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . .

14984

Compagnie de Bourbon S.A.  . . . . . . . . . . . .

14984

Corvin S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15019

Cronos Recherches Cliniques S.A.  . . . . . . .

15021

Development Finance Initiative (DFI)  . . . .

14983

Development Finance Initiative (DFI)  . . . .

14983

Digital Services XXIV S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

14987

DSG S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14981

EDEF Principals S.C.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14986

Eginter S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14983

Eqestar Capital S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14983

Eqestar Capital S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14985

Eqestar Capital S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14986

Eqestar Capital S.P.F. S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

14985

Eurobatitech S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14981

Euroclass Multimedia Holding S.A.  . . . . . .

14980

Euroklima  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14980

Euro Partner S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14984

European Property SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

14979

European Property SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

14978

European Property SICAV-FIS  . . . . . . . . . .

14979

Eurtrans S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14980

Expansion Immobilière S.A. . . . . . . . . . . . . .

14979

Fablon S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14980

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

14979

First Data International Luxembourg IV

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14981

Foothill Financing S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

14981

Friture au Gourmet s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

14982

Giulianova S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14982

Glenn Funds S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14982

Shiatsu-Ki S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15024

SOLIFIN (Luxembourg) S.A.  . . . . . . . . . . . .

14978

Thalassa Financial S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

15023

UFG Fund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15022

V.D.L. Développement S.A.  . . . . . . . . . . . . .

15023

14977

L

U X E M B O U R G

SOLIFIN (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange.

R.C.S. Luxembourg B 65.994.

Je soussigné Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, certifie qu'en

application de l'article 273 de la loi sur les sociétés commerciales du Grand-Duché de Luxembourg, du 10 août 1915, que

(i) suivant acte reçu par mon ministère en date du 30 octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et

Associations, numéro 3416 du 17 novembre 2014, le conseil d'administration de la société anonyme SOLIFIN (Luxem-
bourg) S.A., ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange, inscrite auprès du Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 65.994, et le conseil d'administration de la société anonyme Viking
Global Holding S.A., ayant son siège social à L-1320 Luxembourg, 54, rue de Cessange, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B numéro 52.895, ont établi un projet commun de fusion, aux termes
duquel la société «SOLIFIN (Luxembourg) S.A.» absorbe la société «Viking Global Holding S.A.».

(ii) Conformément au projet de fusion, la fusion devient définitive à défaut de convocation d'une assemblée générale

par un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins cinq pour cent (5%) des actions du capital
souscrit ou du rejet du projet de fusion par celle-ci, un mois après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations du projet de fusion.

(iii)  Ledit  projet  de  fusion  a  été  publié  au  Mémorial  C,  Recueil  des  Sociétés  et  Associations  numéro  3416  du  17

novembre 2014, et jusqu'au 19 décembre 2014, personne ne s'est opposé à la fusion des deux (2) sociétés.

(iv) Le notaire instrumentant confirme qu'une telle assemblée générale n'a pas été requise et que dès lors la fusion

entre la société absorbante et la société absorbée est devenue effective à partir du 18 décembre 2014, et que la société
«Viking Global Holding S.A.» a donc définitivement cessé d'exister.

Junglinster, le 22 décembre 2014.

Maître Jean SECKLER
<i>Notaire

Référence de publication: 2014208592/28.
(140233146) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Aberdeen Global II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 136.363.

Les comptes annuels au 30 juin 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207567/10.
(140232652) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

European Property SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.555.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Aktionärsversammlung (die „Versammlung“) der Gesellschaft vom 10. Dezember 2014

<i>Vierter Beschluss

Die Versammlung beschliesst, die Amtszeit des Verwaltungsratsmitglieds Herr Dominique Moerenhout auf weitere 5

Jahre zu verlängern, so dass diese bis zur jährlichen Aktionärsversammlung, die im Jahre 2019 abgehalten wird, und bis
Nachfolger ernannt und genehmigt sind, zu bestätigen.

<i>Fünfter Beschluss

Die  Versammlung  beschließt,  Deloitte  S.A.  als  Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft bis  zur  jährlichen Aktionärsver-

sammlung, die im Jahre 2015 abgehalten wird, und bis Nachfolger ernannt und genehmigt sind, zu bestätigen.

Référence de publication: 2015003010/16.
(150002954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14978

L

U X E M B O U R G

European Property SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.555.

Der konsolidierte Jahresabschluss vom 30.09.2014 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg

hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015003009/11.
(150002910) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Expansion Immobilière S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 41, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 132.215.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015003013/14.
(150002922) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

European Property SICAV-FIS, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 137.555.

Herr Sven Rein ist geschäftsansässig in der
121, avenue de la Faïencerie
L - 1511 Luxembourg

Luxembourg, den 07.01.2015.

Référence de publication: 2015003011/12.
(150002954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2221 Luxembourg, 297, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 141.460.

<i>Assemblée générale extraordinaire du 06 janvier 2015

En présence des associés, représentant l'intégralité du capital social, a été pris à l'unanimité des voix la résolution

suivante:

<i>Résolution unique

L'adresse de la société sera la suivante: 297, rue de Neudorf, L-2221 Luxembourg.
L'art. 4 des statuts de la société constituée suivant acte reçu par le notaire Emile Schlesser en date du 5 septembre

2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 2372 du 29 septembre 2008 restera inchangé.

Fait à Luxembourg, le 06 janvier 2015.

Marc Kieffer / Lucienne Simon
<i>Gérant/associé / Associée

Référence de publication: 2015003037/17.
(150002629) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14979

L

U X E M B O U R G

Euroklima, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 12.142.

Le Bilan au 31 décembre 2010 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015003033/10.
(150002253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Euroclass Multimedia Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 19, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 67.071.

EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue en date du 31 décembre 2014:
- Madame Valérie RAVIZZA, née le 6 mars 1968 à Mont-Saint-Martin (France) avec adresse professionnelle 19, Bou-

levard Grande-duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, a été élue en remplacement de Monsieur Bertrand MICHAUD,
administrateur de classe B démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra
en 2017.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 07 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003032/15.
(150002694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Eurtrans S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1946 Luxembourg, 9-11, rue de Louvigny.

R.C.S. Luxembourg B 78.436.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d’administration de la Société à Luxembourg en date du 1 

<i>er

<i> janvier 2015

Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la Société tenue en date du 1 

er

 janvier 2015

qu'il a été décidé, sur base de l'article 1 

er

 des statuts de la Société, de transférer le siège social de la Société du 19, Rue

Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg au 9-11, rue de Louvigny L-1946 Luxembourg, avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 06 janvier 2015.

Eric VERBERCKT
<i>Administrateur-délégué

Référence de publication: 2015003036/15.
(150003086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Fablon S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8041 Strassen, 27, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 24.658.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2015003042/14.
(150002704) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14980

L

U X E M B O U R G

Foothill Financing S.à r.l., Société à responsabilité limitée de titrisation.

Capital social: USD 20.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 145.841.

<i>Extrait des résolutions prises par l'associée unique en date du 15 décembre 2014

1. L'associée unique prend acte de et accepte la démission de Monsieur Luc HANSEN de son mandat de gérant de

catégorie B.

2. L'associée unique décide de nommer pour une durée indéterminée, Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en

sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, comme nouveau
gérant de catégorie B.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003039/16.
(150002975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

First Data International Luxembourg IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 54.143.625,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 132.660.

<i>Extrait des décisions prises par les associés de la Société du 31 DECEMBRE 2014

Le 31 Décembre 2014, l'associé unique de First Data international Luxembourg IV S.à r.l. a pris la résolution suivante:
- D'accepter la démission de Mr. Barry Cooper en qualité de Gérant A de la Société avec effet au 31 Décembre 2014;

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Luxembourg Corporation Company SA
Signatures
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015003038/15.
(150002213) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Eurobatitech S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1531 Luxembourg, 14, rue de la Fonderie.

R.C.S. Luxembourg B 42.979.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003031/10.
(150002190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

DSG S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.708.

Veuillez noter que l'adresse de Monsieur Pieter KODDE, gérant de catégorie A, se situe désormais au 24, Grimes

Road, Old Greenwich, 06870-2018 Connecticut, Etats-Unis d'Amérique.

Luxembourg, le 07 janvier 2015.

Pour avis sincère et conforme
<i>Pour DSG S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015002994/13.
(150002832) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14981

L

U X E M B O U R G

Glenn Funds S.à r.l., Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.

Capital social: EUR 100.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 181.080.

<i>Extrait des décisions prises par l'associé unique en date du 17 décembre 2014

1. Mme Katia CAMBON a démissionné de son mandat de gérante de catégorie A.
2. M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant pro-

fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été nommé comme gérant de catégorie A pour une
durée indéterminée.

Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour Glenn Funds S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2015003065/17.
(150002403) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Giulianova S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Petrusse.

R.C.S. Luxembourg B 164.918.

<i>Extrait des décisions prises par le Conseil d'administration de la société, en date du 29 Décembre 2014:

A compter du 1 

er

 Janvier 2015 et conformément à l'article 2 des statuts, la gérance acte le changement de siège social

de la société et décide de transférer celui-ci du L-2340 Luxembourg, 25 rue Philippe II, vers le L-2320 Luxembourg 94A
Boulevard de la Petrusse.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 Décembre 2014.

<i>Pour la société
Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015003064/15.
(150002387) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Friture au Gourmet s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4833 Rodange, 11, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 47.866.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003053/10.
(150002199) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

BBL Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

R.C.S. Luxembourg B 157.768.

EXTRAIT

La Société, en sa qualité de domiciliataire, a décidé de dénoncer le siège social de la société BBL Holding S.A., SPF

ayant actuellement son siège social au 51, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, dûment enregistrée au Registre du Com-
merce et des Sociétés sous le numéro B 157 768, avec effet à ce jour.

En conséquence, le contrat de domiciliation signé entre la Société et BBL Holding S.A. le 1 

er

 août 2012 est dénoncé

avec effet immédiat.

Référence de publication: 2015002875/12.
(150002930) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14982

L

U X E M B O U R G

Eqestar Capital S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.435.

Jean LAMBERT,
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
née le 02 Mai 1952 à Luxembourg.
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de catégorie B de la société anonyme
Eqestar Capital SPF S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B155435
Date effective: 29 décembre 2014

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Jean LAMBERT.

Référence de publication: 2015003001/16.
(150002247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Eginter S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 8.839.661,00.

Siège social: L-8399 Windhof, 11, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 19.916.

En date du 10 décembre 2014, Monsieur Xavier Pauwels a démissionné de son mandat de gérant de catégorie B à la

date effective du 12 décembre 2014, Monsieur Jean-Jacques Bernard, avec adresse professionnelle au 9 rue des Trois
Cantons, L-8399 Windhof, a été nommé gérant de catégorie B à la date effective du 12 décembre 2014 et le siège social
de la Société a été transféré au 9, rue des Trois Cantons, L-8399 Windhof à la date effective du 12 décembre 2014.

L'adresse professionnelle de Madame Muriel Bourgeois, gérant de catégorie B, a été transférée au 9, rue des Trois

Cantons, L-8399 Windhof à compter de cette date.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

A Windhof, le 15 décembre 2014.

Référence de publication: 2015003000/16.
(150002679) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Development Finance Initiative (DFI), Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 147.398.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015002975/11.
(150003085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Development Finance Initiative (DFI), Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 147.398.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2015002974/11.
(150003059) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14983

L

U X E M B O U R G

Compagnie de Bourbon S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1117 Luxembourg, 34, rue Albert 1er.

R.C.S. Luxembourg B 97.520.

<i>Extrait du rapport de la réunion du conseil d'administration tenue à 10.00 heures le 5 janvier 2015

<i>Extrait des résolutions

1. Le Conseil constate que le siège social de la société a été transféré du 8, Place Winston Churchill, L-1340 Luxem-

bourg, au 34, Rue Albert 1 

er

 , L-1117 Luxembourg avec effet au 1 

er

 janvier 2015.

Référence de publication: 2015002953/11.
(150003093) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Combourg (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 159.939.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
Signature

Référence de publication: 2015002951/13.
(150002561) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Coil Architectes S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8395 Septfontaines, 2-4, Sellergronn.

R.C.S. Luxembourg B 108.140.

Les comptes annuels au 31.12.13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2015002950/10.
(150002409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Chauffage-Sanitaire Claude Schreiber S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4732 Pétange, 54, rue de l'Eglise.

R.C.S. Luxembourg B 69.349.

Le Bilan abrégé au 31 Décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015002944/10.
(150002194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Euro Partner S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1750 Luxembourg, 112, avenue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 59.254.

Les comptes annuels clos au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015003029/10.
(150002987) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14984

L

U X E M B O U R G

Eqestar Capital S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.435.

Claudia HERBER,
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
née le 6 Septembre 1965 à Irmenach (Allemagne),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de catégorie B de la société anonyme
Eqestar Capital SPF S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B155435
Date effective: 29 décembre 2014

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Claudia HERBER.

Référence de publication: 2015003004/16.
(150002247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Eqestar Capital S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.435.

Patrice YANDE,
Demeurant professionnellement au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
née le 30 juin 1969 à Saint-Mard (Belgique),
démissionne, par la présente, du mandat d'Administrateur de catégorie B de la société anonyme
Eqestar Capital SPF S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg,
enregistrée au RCS Luxembourg sous le numéro B155435
Date effective: 29 décembre 2014

Luxembourg, le 5 janvier 2015.

Patrice YANDE.

Référence de publication: 2015003003/16.
(150002247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

CEP IV Investment 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 186.771.

Statuts coordonnés, suite à une assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de

résidence à Esch/Alzette, en date du 25 septembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 27 octobre 2014.

Référence de publication: 2015002942/11.
(150002740) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

CJ Lux Holdings, Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.000.000,00.

Siège social: L-1610 Luxembourg, 8-10, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 190.857.

L'adresse professionnelle de Monsieur Tamas HORVATH, gérant de la Société, est désormais située au 8-10, Avenue

de la Gare, L-1610 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2015002946/11.
(150002269) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14985

L

U X E M B O U R G

Clean Fuels (South America) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 41, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 151.934.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil d'Administration en date du 15 décembre 2014

- Il est pris acte de la démission, avec effet au 12 décembre 2014, de M. Luis Miguel Dias Da Silva Santos et M. Juan

Miguel Martin Iglesias de leur poste d'administrateur de catégorie A.

M. Luis Miguel Dias Da Silva Santos démissionne également de son poste de Président du Conseil d'Administration.
- Cooptation en tant qu'administrateur de catégorie A, avec effet au 12 décembre 2014, de M. Philippe Lambert, né

le 2 décembre 1971, fiscaliste, demeurant professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen en remplacement
de M. Luis Miguel Dias Da Silva Santos jusqu'à l'assemblée générale de 2015.

- Élection, avec effet au 12 décembre 2014, de M. Philippe Lambert, né le 2 décembre 1971, fiscaliste, demeurant

professionnellement à L-8362 Grass, 4, rue de Kleinbettingen en tant que Président du Conseil d'Administration. Son
mandat viendra à échéance lors de l'assemblée générale de 2015.

Luxembourg, le 15 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
CLEAN FUELS (SOUTH AMERICA) S.A.
<i>Le Conseil d'Administration

Référence de publication: 2015002947/21.
(150002349) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

EDEF Principals S.C.S., Société en Commandite simple.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 7, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 180.825.

EXTRAIT

Suite à des changements de dénominations il y lieu de modifier les noms des sociétés cités dans l'objet social afin de

lire:

«Der Zweck der Gesellschaft besteht darin, als eine Kommanditistin im Gründungspartner (Digital East S.C.S.) für die

Digital East Fund 2013 SCA SICAR zu dienen.»

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2015003015/14.
(150002510) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Eqestar Capital S.P.F. S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 155.435.

La, soussignée,
EXAUDIT S.A.
dont le siège social est situé au 19, Rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce

et des sociétés sous le numéro B 124982,

démissionne, par la présente, du mandat de Commissaire aux Comptes de la société anonyme
Eqestar Capital SPF S.A.
ayant son siège social au 19, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg,
enregistrée au R.C.S Luxembourg sous le numéro B155435
Date effective: 29 décembre 2014

Fait à Luxembourg, le 5 janvier 2015.

EXAUDIT S.A.
Signatures

Référence de publication: 2015003002/19.
(150002247) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

14986

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXIV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.965,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.451.

In the year two thousand and fourteen, on the thirteenth day of November.
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG, a limited liability company (Aktiengesellschaft) incorporated and existing under the laws of

Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 159634
B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety nine (12,499) shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Berlin, Germany, on 12 November 2014;

2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmensgesellschaft  (haftungbes-

chränkt)) incorporated and existing under the laws of Germany registered with the commercial register at the local court
of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 126893 B, having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin,
Germany (hereinafter “Bambino 53. V V”),

being the holder of one (1) share,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

Berlin, Germany, on 12 November 2014;

3. Insight Venture Partners VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-71022,
having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter “Insight I”),

becoming the holder of four thousand and twelve (4,012) series A1 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

New York, United States of America, on 11 November 2014;

4. Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the

State Delaware, United States of America, registered with the Secretary of the State of Delaware under number 5289013,
having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware
19801, United States of America (hereinafter “Insight II”),

becoming the holder of one thousand two hundred and seventy two (1,272) series A1 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

New York, United States of America, on 11 November 2014;

5. Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under the laws of the

Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number MC-71029,
having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter “Insight III”),

becoming the holder of one thousand and thirty eight (1,038) series A1 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

New York, United States of America, on 11 November 2014;

6. Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under

the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number
MC-71024, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands (hereinafter
“Insight IV”),

becoming the holder of one hundred and forty three (143) series A1 shares,
here represented by Kristof De Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given in

New York, United States of America, on 11 November 2014;

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties under 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XXIV S.à r.l. (the

“Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxem-
bourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, registered with the Luxembourg Trade and
Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.451 and incorporated pursuant to a
deed of the notary Carlo Wersandt residing in Luxembourg on 18 June 2014, published in the Mémorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 2383 dated 5 September 2014. The articles of association have not been amended since.

14987

L

U X E M B O U R G

The Existing Shareholders representing the whole share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Insight I,
Insight II, Insight III and Insight IV participates and votes for the purpose of Agenda point 8 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have two (2) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”).

2. Conversion of the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one Euro (EUR

1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each,
without cancellation of shares.

3. Acceptance of Insight Venture Partners VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and existing under

the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number
MC-71022, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands, as new sha-
reholder of the Company.

4. Acceptance of Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under

the laws of the State Delaware, United States of America, registered with the Secretary of the State of Delaware under
number 5289013, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Delaware 19801, United States of America, as new shareholder of the Company.

5. Acceptance of Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., a limited partnership incorporated and existing under

the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands under number
MC-71029, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands, as new sha-
reholder of the Company.

6. Acceptance of Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., an exempted limited partnership incorporated and

existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
under number MC-71024, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,
as new shareholder of the Company.

7. Increase of the Company's share capital by an amount of six thousand four hundred and sixty five Euros (EUR 6,465)

so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12,500) up to eighteen thousand
nine hundred and sixty five Euros (EUR 18,965) by issuing six thousand four hundred sixty-five (6,465) Series A1 Shares
with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

8. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eighteen thousand nine hundred sixty-five Euros (EUR 18,965), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (herei-

nafter “Common Shares”) and

5.1.2 six thousand four hundred sixty five (6,465) series A1 shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each

(hereinafter “Series A1 Shares” and also referred to as “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Insight Venture Partners VIII, L.P., (“Insight I”), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. (“Insight II”), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. (“Insight III”), Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. (“Insight IV”) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III and Insight IV together the
“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company
affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third
Party Investor”) which has been approved by the Board of Directors Majority (as defined in Article 25.5 below) (such
investment being a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall
inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to
the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors (or a
company affiliated to an Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG))
subscribe for further Shares.”

9. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

14988

L

U X E M B O U R G

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XXIV S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eighteen thousand nine hundred sixty-five Euros (EUR 18,965), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (herei-

nafter “Common Shares”) and

5.1.2 six thousand four hundred sixty five (6,465) series A1 shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each

(hereinafter “Series A1 Shares” and also referred to as “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Insight Venture Partners VIII, L.P., (“Insight I”), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. (“Insight II”), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. (“Insight III”), Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. (“Insight IV”) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III and Insight IV together the
“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company
affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third
Party Investor”) which has been approved by the Board of Directors Majority (as defined in Article 25.5 below) (such

14989

L

U X E M B O U R G

investment being a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall
inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to
the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors (or a
company affiliated to an Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG))
subscribe for further Shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders, subject to the provisions of any shareholders' agreement

between the shareholders of the Company, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-
along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders of the Company.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by a majority vote of seventy five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (such majority being a
“Super Majority”) and subject to the provisions of any shareholders' agreement between the shareholders of the Com-
pany, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights contained
in any shareholders' agreement between the shareholders of the Company. To the extent that such approval has been
granted, an additional consent to the transfer of shares is not required in the following cases (each a “Privileged Transfer”):

7.4.1 in any case of a Transfer (as defined in Article 8.1 below), assignment or any other disposal of shares by any

Investor to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, Transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a Transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under any simplified

employee participation agreed upon between the shareholders of the Company or (ii) to the Company and/or any Investor
pursuant to a call-option under a vesting scheme pursuant to such simplified employee participation;

7.4.4 in case of any Transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such
transformation procedure.

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any Transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the Transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the
Transfer, assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the

14990

L

U X E M B O U R G

deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any sale of at least 50% of all Shares in the Company, or a swap or a take-over of the Company in an

economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to one another, or (ii)
of the liquidation of the Company or (iii) of any sale or transfer of Shares in the Company either to third parties or other
Shareholders that would result in either more than 50% of the registered share capital or more than 50% of the voting
rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions,
however, in each case except in a case of a Privileged Transfer or (iv) of any distribution of proceeds to Shareholders (by
way of dividends or otherwise) other than a distribution of annual operative profits (each of the events described in (i),
(ii), (iii) and (iv) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”) - subject to the prior
satisfaction of the distributions pursuant to Article 8.2 below and taking into account dividends previously paid due to
sales of subsidiaries - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in case of an
asset Transfer, their shareholding in the registered share capital of the Company or (ii) in case of a share Transfer, the
number of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).

“Transfer” means, with respect to any asset (including without limitation, shares and Intellectual Property Rights), any

transfer, assignment, sale, pledge, hypothecation, Encumbrance (as defined below) or other disposition of that asset or
of any rights or obligations associated with that asset, whether voluntary or involuntary, including an option to do any of
the forgoing.

“Encumbrance”/“Encumbered” means any encumbrance whatsoever, including a mortgage, charge, debenture, pledge,

hypothecation, lien, security interest, title retention, option, right to acquire or purchase, restriction upon sale or transfer,
right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, claims, trust arrangement, agreement to confer
security, other encumbrance or security interest of any kind or other type of preferential arrangement or any equity or
other restriction or limitation of any nature whatsoever (including, without limitation, a title transfer or retention ar-
rangement, any preliminary agreement or other arrangement to create any of the above) having similar effect;

8.2 On a first preferred level (“First Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount equal

to its respective total investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (consisting of the nominal
amount of the Series A Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account
115) paid by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on
the First Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata to the amounts
that would have been allocated to that holder on the First Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.

8.3 After the payments on the First Preferred Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated

on a common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective shares disposed of in con-
nection with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the First Preferred Level shall reduce the
amount to be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall be obliged to
repay any amount received on the First Preferred Level. Any Exit Proceeds remaining unallocated after allocation under
this Article 8.3 shall also be allocated in accordance with this Article 8.3 by applying Article 8.3 repeatedly until all Exit
Proceeds have been allocated to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one or
more transactions, no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and repay any exceeding amount to the
other shareholder) an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds pro rata to the Shares sold
or (ii) the amount of its investment in the Company (payment of purchase price for shelf company, payment of share
capital, including premium, if any, and payments into account 115 of the standard chart of accountants “apport en capitaux
propres non rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (additional amounts)) in
respect of the shares sold. If shares in the Company are sold in more than one transaction, no shareholder shall receive
less proceeds than it would have received if the shares in the Company were sold in one transaction.

8.4 The preferred allocation on the First Preferred Level applies for the benefit of the respective shareholder so long

as the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet received the full amount that is
to be allocated to such shareholder according to the First Preferred Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed (i) with such shareholder's consent in the case of Rocket, Insight I, Insight

II, Insight III and Insight IV and otherwise (ii) without such shareholder's consent, if:

9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration

14991

L

U X E M B O U R G

of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.
10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is

to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion
shall be borne by the Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall
be set off with the compensation for redemption and the compensation for redemption shall be reduced accordingly.
The  shareholder  shall  bear  the  remaining  costs  in  case  the  compensation  for  redemption  does  not  cover  the  costs
allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending

14992

L

U X E M B O U R G

on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority. Any amendment of these articles of
association that materially or adversely affects the rights of the holders of Series A1 Shares require the consent of all of
the holders of those Series A1 Shares.

Art. 17. Shareholders' Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the

consent of the Board of Directors:

17.1.1 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge within

the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Shareholders' resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

17.2.1 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.2 acquisition of the Company's own shares, with the exception of the redemption of shares in accordance with

Article 9.2 and transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;

17.2.3 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.2.4 merger, separation and transformation of the Company.

14993

L

U X E M B O U R G

17.3. Whenever the capital of the Company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal in-capacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by  the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21. Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different

14994

L

U X E M B O U R G

classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the Board of Directors for the legal transactions and measures specified

below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Simple Majority:

22.8.1 approval of the annual plan, in particular the budget plan for each following year;
22.8.2 granting of loans in excess of EUR 250,000.00 p.a., except for loans with direct or indirect subsidiaries of the

Company, i.e. inter-group loans;

22.8.3 entering into (i) contracts containing a definitively committed payment obligation of the Company in excess of

EUR 250,000.00 in the individual case or (ii) in case of an agreement of more than two (2) years during which it cannot
be terminated, EUR 250,000.00 p.a. per agreement;

22.8.4 acquisition, disposition and/or licensing of rights of intellectual property rights, including in particular trademarks

and rights of use for software, other than those on arms' length terms or those in the ordinary course of business;

22.8.5 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred fifty thousand

Euros (EUR 250,000.00) in aggregate;

22.8.6 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.7 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.8 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.9 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

22.8.10 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals;
22.8.11 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party;
22.8.12 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

22.8.13 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing or agreed simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the Company
in a shareholders' agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or Encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of a Simple Majority. The Simple Majority may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager

14995

L

U X E M B O U R G

and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Board of Directors.
25.1 The Company have set up an advisory board (the “Board of Directors”). It consists of five (5) voting members.

The shareholders may by way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members
of the Board of Directors.

25.2 The shareholders' shall only set and/or amend rules of procedure for the Board of Directors by way of unanimous

shareholders' consent.

25.3 The voting members of the Board of Directors shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's

respective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 Three (3) voting members of the Board of Directors shall be nominated, withdrawn or replaced by the share-

holder Rocket (“Rocket Members”) in its sole discretion; and

25.3.2 Two (2) voting members of the Board of Directors shall be nominated, withdrawn or replaced together by the

shareholders Insight I, Insight II, Insight III and Insight IV (“Insight Members”) in their sole discretion.

25.4 The Insight Members shall together be entitled to appoint, withdraw or replace one non-voting member to the

Board of Directors as an observer.

25.5 The Board of Directors shall have a chairman and a deputy chairman yet none of them shall have a casting vote

and/or any additional right and/or authority differing from the other members of the Board of Directors. One of the
Rocket Members shall be the chairman of the Board of Directors. The rules of procedure of the Board of Directors may
provide for further provisions in particular on the self-organization of the Board of Directors. Subject to any consents
or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agreement with respect to the Company,
if any, the Board of Directors shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast ("Simple Majority"); in case
the majority shall include the affirmative vote of the Insight Member such majority is referred to as the "Board of Directors
Majority". The Board of Directors shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

25.6 In addition to any consents or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders' agree-

ment with respect to the Company, if any, the Board of Directors has a consultative function and will not interfere in the
management of the Company.

25.7 The Board of Directors is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

14996

L

U X E M B O U R G

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable - in accordance with the provisions of Article 8 - and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders'  agreement  with  respect  to  the  Company  which  may  be  entered  into  from  time  to  time  between  the
shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter con-
tained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders' agreement with respect to the Company, such
shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

10. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, each acting individually

and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register of the Company.

11. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have two (2) classes of shares, divided into Common Shares and Series A1 Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares,

with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a
nominal value of one Euro (EUR 1) each, without cancellation of shares.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders accepts Insight Venture Partners VIII L.P., an exempted limited partnership in-

corporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of
the  Cayman  Islands  under  number  MC-71022,  having  its  registered  address  at  309  Ugland  House,  KY1-1104  Grand
Cayman, Cayman Islands, as new shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders accepts Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., a limited partnership in-

corporated and existing under the laws of the State Delaware, United States of America, registered with the Secretary
of the State of Delaware under number 5289013, having its registered office at Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, United States of America, as new shareholder of the Company.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders accepts Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., a limited partnership incor-

porated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited Partnerships of the

14997

L

U X E M B O U R G

Cayman Islands under number MC-71029, having its registered address at 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman,
Cayman Islands, as new shareholder of the Company.

<i>Sixth resolution

The general meeting of shareholders accepts Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., an exempted limited

partnership incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, registered with the Registrar of Limited
Partnerships  of  the  Cayman  Islands  under  number  MC-71024,  having  its  registered  address  at  309  Ugland  House,
KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands, as new shareholder of the Company.

<i>Seventh resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of six thousand

four hundred and sixty-five Euros (EUR 6,465) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
Euros (EUR 12,500) up to eighteen thousand nine hundred sixty-five Euros (EUR 18,965) by issuing six thousand four
hundred and sixty five (6,465) Series A1 Shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

<i>Subscription

Six thousand four hundred and sixty-five (6,465) Series A1 Shares have been duly subscribed as follows:
- four thousand and twelve (4,012) Series A1 Shares have been duly subscribed by Insight I, prenamed, here represented

as aforementioned, for the price of four thousand and twelve Euros (EUR 4,012);

- one thousand two hundred and seventy-two (1,272) Series A1 Shares have been duly subscribed by Insight II, pren-

amed, here represented as aforementioned, for the price of one thousand two hundred and seventy-two Euros (EUR
1,272);

- one thousand and thirty-eight (1,038) Series A1 Shares have been duly subscribed by Insight III, prenamed, here

represented as aforementioned, for the price of one thousand and thirty-eight Euros (EUR 1,038);

- one hundred and forty-three (143) Series A1 Shares have been duly subscribed by Insight IV, prenamed, here re-

presented as aforementioned for the price of one hundred and forty-three Euros (EUR 143).

<i>Payment

The six thousand four hundred and sixty-five (6,465) Series A1 Shares subscribed by Insight I, Insight II, Insight III and

Insight IV, aforementioned, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of six thousand four
hundred and sixty-five Euros (EUR 6,465).

The amount of six thousand four hundred and sixty-five Euro (EUR 6,465.-) is as now available to the Company, as

has been proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of six thousand four hundred and sixty-five Euros (EUR 6,465) is entirely allocated to

the share capital.

<i>Eighth resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that:
- Insight I has now become the holder of four thousand and twelve (4,012) Series A1 Shares;
- Insight II has now become the holder of one thousand two hundred and seventy two (1,272) Series A1 Shares;
- Insight III has now become the holder of one thousand thirty eight (1,038) Series A1 Shares;
- Insight IV has now become the holder of one hundred forty three (143) Series A1 Shares.
As a consequence Insight I, Insight II, Insight III and Insight IV, entitled to vote and here represented by Kristof De

Wael, Lawyer, professionally residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxies, joins the general meeting
of shareholders for the purpose of the following resolutions.

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at eighteen thousand nine hundred sixty-five Euros (EUR 18,965), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (herei-

nafter “Common Shares”) and

5.1.2 six thousand four hundred sixty five (6,465) series A1 shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each

(hereinafter “Series A1 Shares” and also referred to as “Series A Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

14998

L

U X E M B O U R G

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Insight Venture Partners VIII, L.P., (“Insight I”), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. (“Insight II”), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. (“Insight III”), Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. (“Insight IV”) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III and Insight IV together the
“Investors” and each an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares to be issued in the
course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a shareholder nor a company
affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG) (a “Third
Party Investor”) which has been approved by the Board of Directors Majority (as defined in Article 25.5 below) (such
investment being a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor or one or more
matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to such capital increase
under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective Investor shall
inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right pursuant to
the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the Investors (or a
company affiliated to an Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG))
subscribe for further Shares.”

<i>Ninth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Tenth Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, each

acting individually and with full power of substitution, to sign solely, the shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,500.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am dreizehnten November.
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG, eine Aktiengesellschaft gegründet und bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Sitz in Johannisstraße
20, 10117 Berlin, Deutschland („Rocket“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Anteilen,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12 No-

vember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmensgesellschaft (haftungsbeschränkt) gegründet und

bestehend nach deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter
der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland („Bambino 53. V V“),

Inhaber eines (1) Anteils,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 12 No-

vember 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. Insight Venture Partners VIII L.P., ein exempted limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer
MC-71022, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands („Insight I“),

zukünftiger Inhaber von viertausendzwölf (4.012) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11 No-

vember 2014, ausgestellt in Vereinigte Staaten von Amerika;

4. Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., ein limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht des

Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of the State of Delaware unter der

14999

L

U X E M B O U R G

Nummer 5289013, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Dela-
ware 19801, Vereinigte Staaten von Amerika („Insight II“),

zukünftiger Inhaber von eintausendzweihundertzweiundsiebzig (1.272) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11 No-

vember 2014, ausgestellt in Vereinigte Staaten von Amerika;

5. Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., ein limited partnership gegründet und bestehend unter dem Recht der

Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer
MC-71029, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands („Insight III“),

zukünftiger Inhaber von eintausendachtunddreißig (1.038) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11 No-

vember 2014, ausgestellt in Vereinigte Staaten von Amerika;

6. Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., ein exempted limited partnership gegründet und bestehend unter

dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
unter der Nummer MC-71024, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands („Insight IV“),

zukünftiger Inhaber von einhundertdreiundvierzig (143) Anteilen der Serie A1,
hier vertreten durch Kristof De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 11 No-

vember 2014, ausgestellt in Vereinigte Staaten von Amerika.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien unter 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services XXIV S.à

r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und
bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, eingetragen
im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 188.451, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß
einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in Luxemburg, welche am 5. September 2014 im Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2383, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem
nicht geändert.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV ausschließlich für die Punkte 8 ff.
der Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt sind:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, wodurch nunmehr zwei (2) Anteilsklassen be-

stehen, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“) und Anteile der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“).

2. Umwandlung ohne Einziehung von Anteilen der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem

Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1).

3. Aufnahme von Insight Venture Partners VIII L.P., ein exempted limited partnership gegründet und bestehend unter

dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
unter  der  Nummer MC-71022, mit  Sitz  in  309 Ugland  House,  KY1-1104 Grand Cayman, Cayman  Islands,  als neuer
Gesellschafter der Gesellschaft.

4. Aufnahme von Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., ein limited partnership gegründet und bestehend unter

dem Recht des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim Secretary of the State of
Delaware unter der Nummer 5289013, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, New
Castle County, Delaware 19801, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

5. Aufnahme von Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., ein limited partnership gegründet und bestehend unter

dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the Cayman Islands
unter  der  Nummer MC-71029, mit  Sitz  in  309 Ugland  House,  KY1-1104 Grand Cayman, Cayman  Islands,  als neuer
Gesellschafter der Gesellschaft.

6. Aufnahme von Insight Venture Partners (Co-Investors) VIII L.P., ein exempted limited partnership gegründet und

bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of Limited Partnerships of the
Cayman Islands unter der Nummer MC-71024, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand Cayman, Cayman Islands,
als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

7. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von sechstausendvierhundertfünfundsechzig Euro (EUR 6.465) auf einen Betrag von
achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig  Euro  (EUR  18.965)  durch  die  Ausgabe  von  sechstausendvierhundertfün-
fundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

8. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

15000

L

U X E M B O U R G

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Euro (EUR 18.965),

bestehend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

5.1.2 sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (die „Anteile der Serie A1“, welche auch als „Anteile der Serie A“bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Insight Venture Partners VIII, L.P. („Insight I“), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. („Insight II“), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. („Insight III“) und Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. („Insight IV“) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV gemeinschaft-
lich  die  „Investoren“und  jeweils  ein  „Investor“)  ist  zur  Zeichnung  einer  Anzahl  weiterer  bei  einer  Kapitalerhöhung
ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder
um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), dem von der Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5
definiert) zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von
einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesell-
schaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition
eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren (oder eine mit einem Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)) weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

9. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XXIV S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Artikel

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

15001

L

U X E M B O U R G

4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Euro (EUR 18.965),

bestehend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

5.1.2 sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (die „Anteile der Serie A1“, welche auch als „Anteile der Serie A“ bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Insight Venture Partners VIII, L.P. („Insight I“), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. („Insight II“), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. („Insight III“) und Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. („Insight IV“) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV gemeinschaft-
lich  die  „Investoren“  und  jeweils  ein  „Investor“)  ist  zur  Zeichnung  einer  Anzahl  weiterer  bei  einer  Kapitalerhöhung
ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder
um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), dem von der Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5
definiert) zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von
einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesell-
schaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition
eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren (oder eine mit einem Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)) weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

15002

L

U X E M B O U R G

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaf-

tervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrechten, Bezugs-
rechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der
Gesellschaft.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Mehrheit von fünf-

undsiebzig  Prozent  (75%)  der  Stimmen  aller  Gesellschafter  der  Gesellschaft  (wobei  eine  solche  Mehrheit  als  eine
„Qualifizierte Mehrheit“ bezeichnet wird) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwi-
schen den Gesellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten
oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung von
Anteilen in den folgenden Fällen (jeweils eine „Bevorzugte Übertragung“) nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung (wie in Artikel 8.1 definiert), einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen

durch einen Investor an eine mit einem solchen Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen
Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt
oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimm-
berechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer
oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, welche zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft
vereinbart wurde, erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im
Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung gemäß einer solchen vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschaf-
ters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile
an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstor-
benen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Liquidations- und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) eines Verkaufs von mindestens 50% aller Anteile an der Gesellschaft oder eines Tausches oder einer

Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen
oder in zeitlicher Nähe zueinander, oder (ii) der Liquidation der Gesellschaft oder (iii) eines Verkaufs oder einer Über-
tragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass
entweder mehr als 50% des eingetragenen Gesellschaftskapitals oder mehr als 50% der Stimmrechte im Besitz der er-
werbenden Partei bzw. Parteien wären (change of control), als Ergebnis einer oder mehrerer verbundener Akquisitionen,
jedoch jeweils nicht im Falle einer Bevorzugten Übertragung oder (iv) einer Verteilung der Erlöse an Gesellschafter (durch
Dividenden oder anderweitig) außer bei einer Verteilung operativer Jahresgewinne (wobei jeder der unter (i), (ii), (iii)
und (iv) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) -
vorbehaltlich der vorherigen Durchführung der Verteilungen gemäß Artikel 8.2 und unter Berücksichtigung von zuvor
aufgrund von Verkäufen von Tochtergesellschaften gezahlten Dividenden - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-
Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am eingetragenen Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Falle einer Vermö-
gensübertragung, oder (ii) entsprechend der Anzahl der im Liquiditätsereignis verkauften Anteile (soweit anwendbar) im
Falle einer Anteilsübertragung, an die Gesellschafter verteilt.

„Übertragung“ bedeutet, im Hinblick auf Vermögenswerte (einschließlich, ohne Beschränkung, Anteile und Rechte des

geistigen Eigentums), eine Übertragung, eine Abtretung, einen Verkauf, eine Verpfändung (pledge), eine Beleihung (hy-
pothecation),  eine  Belastung  (wie  unten  definiert)  oder  andere  Veräußerung  dieses  Vermögenswertes  oder  damit

15003

L

U X E M B O U R G

verbundener Rechte und Pflichten, ob absichtlich oder unabsichtlich, einschließlich einer Option hinsichtlich jeder der
vorgenannten Handlungen.

„Belastung“/„Belastet“ bedeutet Belastungen jedweder Art, einschließlich Hypotheken, Belastungen (charge), Obliga-

tionen, Verpfändungen, Beleihungen, Pfandrechte, Sicherungsrechte, Eigentumsvorbehalte, Optionsrechte, Erwerbsoder
Bezugsrechte, Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Rechte oder Interessen eines
Dritten, Forderungen, Trust-Arrangements, Verträge bezüglich der Einräumung von Sicherheiten, anderer Belastungen
oder anderer Sicherungsrechte jeglicher Art oder anderer Vorzugsvereinbarungen oder Eigenkapital- oder anderer Ein-
schränkungen  oder  Beschränkungen  jedweder  Art  (einschließlich,  ohne  Beschränkung,  Übertragungsabkommen  von
Titeln  oder  Vorbehaltsvereinbarungen,  Vorverträge  oder  andere  Vereinbarungen  bezüglich  einer  der  vorgenannten
Rechte und Vereinbarungen) mit ähnlicher Wirkung;

8.2 Auf einer ersten Vorzugsebene („Erste Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag,

welcher  dem  Betrag  seiner  jeweiligen  Gesamtinvestition  entspricht,  die  er  getätigt  hat,  um  seine  jeweiligen  von  ihm
gehaltenen Anteile der Serie A zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen
Anteile der Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen
Kontenplans), die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für
die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie
A auf einer pro-rata Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Ersten Vorzugsebene verteilt worden
wären, wenn ausreichend Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Ersten Vorzugsebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer

gemeinsamen Ebene („Gemeinsame Ebene“) an alle verkaufenden Gesellschafter auf einer pro rata-Basis entsprechend
den jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden, verteilt. Sämtliche von
einem Gesellschafter auf der Ersten Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhal-
tenden Betrag auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der
Ersten Vorzugsebene erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Exiterlöse, welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels
8.3 nicht zugeteilt wurden, werden auch im Einklang mit diesem Artikel 8.3 durch die wiederholte Anwendung des Artikels
8.3 verteilt, bis alle Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in
einer oder mehreren Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen
Betrag zu erhalten (und übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein
Anteil an der Gesamtheit der Exiterlöse auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner
Investition in die Gesellschaft (Zahlung des Kaufpreises für eine eventuelle Vorratsgesellschaft, Einzahlung des Gesell-
schaftskapitals,  einschließlich  ggf.  des  Agios,  und  Einzahlungen  auf  Konto  115  des  Standardisierten  Luxemburgischen
Kontenplans „apport en capitaux propres non rémunérés par des titres“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxem-
burg  (zusätzliche  Beträge))  in  Bezug  auf  die  verkauften  Anteile.  Werden  Anteile  der  Gesellschaft  in  mehr  als  einer
Transaktion verkauft, so hat kein Gesellschafter weniger Erlöse zu erhalten, als er erhalten hätte, wenn die Anteile der
Gesellschaft in einer Transaktion verkauft worden wären.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung auf der Ersten Vorzugsebene gilt zugunsten des entsprechenden Investors solange, wie

dieser (einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen Betrag, der an diesen Gesellschafter
gemäß der Ersten Vorzugsebene zu verteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können (i) mit der Zustimmung dieses Gesellschafters im Falle von Rocket, Insight I,

Insight II, Insight III und Insight IV und andernfalls (ii) ohne Zustimmung dieses Gesellschafters zurückgekauft werden,
wenn:

9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer

15004

L

U X E M B O U R G

im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern die Ausgleichszahlung für den Rückkauf
die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-
zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

15005

L

U X E M B O U R G

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Ein-
klang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit bilden. Änderungen dieser Satzung, durch
welche  die Rechte  der  Inhaber  der  Anteile  der  Serie  A1  erheblich oder  nachteilig  beeinflusst werden,  bedürfen der
Zustimmung aller Inhaber dieser Anteile der Serie A1.

Art. 17. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Ak-

tiengesetzes (AktG));

17.1.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.

17.2 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

17.2.1 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.2 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme des Rückkaufs von Anteilen gemäß Artikel 9.2 und

Übertragungen gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;

17.2.3 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.2.4 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

15006

L

U X E M B O U R G

D. Rat der Geschäftsführer

Art. 18. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

19.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für den  Fall,  dass  der  alleinige  Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

15007

L

U X E M B O U R G

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung einer Einfachen Mehrheit genehmigt wurden:

22.8.1 Genehmigung des Jahresplans, insbesondere des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.2 Gewährung von Darlehen, die einen Betrag von EUR 250.000 pro Jahr überschreiten, mit der Ausnahme von

Darlehen mit direkten oder indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft, d.h. konzerninterne Darlehen (inter-group
loans);

22.8.3 Abschluss von (i) Verträgen, die eine endgültige Zahlungsverpflichtung der Gesellschaft enthalten, die im Einzelfall

einen Betrag von EUR 250.000,00 übersteigt, oder (ii) im Falle eines Vertrags mit einer Laufzeit von über zwei (2) Jahren,
während welcher dieser nicht gekündigt werden kann, EUR 250.000,00 pro Jahr und Vertrag;

22.8.4 Erwerb, Verfügung und/oder Lizenzierung von Rechten des geistigen Eigentums, insbesondere einschließlich

Handelsmarken und Nutzungsrechten für Software, außer solchen unter marktüblichen Bedingungen oder solchen, die
innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs liegen;

22.8.5 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hundertfünfzigtausend Euro (EUR 250.000,00) überschreiten;

22.8.6 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.7 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
22.8.8 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.9 Einleitung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

22.8.10 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen;
22.8.11 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesell-

schaft an einen Dritten;

22.8.12  Verwendung  des  Jahresergebnisses;  Rücklagen  von  Gewinnen  in  Kapitalreserven  oder  der  Gewinnvortrag

solcher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesell-
schaftsmitteln;

22.8.13 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden oder vereinbarten vereinfachten Mitarbeiterbeteili-
gung, die ggf. zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
einer Einfachen Mehrheit erfordern. Mit einer Einfachen Mehrheit kann die Zustimmung für bestimmte Gruppen und
Arten von Transaktionen und Maßnahmen auch im Voraus erteilt werden.

22.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls
vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer

15008

L

U X E M B O U R G

der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat (der „Beirat“). Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die

Gesellschafter können durch einstimmige Zustimmung die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen
oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung des Beirats nur durch einstimmige Zustimmung festlegen und/

oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 Drei (3) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermes-

sen ernannt, abberufen oder ersetzt (die „Rocket-Mitglieder“); und 25.3.2 Zwei (2) stimmberechtigte Mitglieder des
Beirats werden von den Gesellschaftern Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV nach eigenem Ermessen ernannt,
abberufen oder ersetzt (die „Insight-Mitglieder“).

25.4 Die Insight-Mitglieder sind gemeinsam dazu berechtigt, ein nichtstimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Be-

obachter zu ernennen, abzuberufen oder zu ersetzen.

25.5  Der  Beirat  hat  einen  Vorsitzenden  und  einen  stellvertretenden  Vorsitzenden,  wobei  keiner  von  beiden  eine

entscheidende Stimme und/oder zusätzliche Rechte und/oder Befugnisse hat, die sich von denen der anderen Mitglieder
des Beirats unterscheiden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats
hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Vorbehaltlich an-
derer  Zustimmungs-  oder  Genehmigungserfordernisse  gemäß  dieser  Satzung  und/oder  Gesellschaftervereinbarungen
bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, fasst der Beirat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men („Einfache Mehrheit“); sofern die Mehrheit die Ja-Stimme des Insight-Mitglieds umfasst, wird diese Mehrheit als
„Mehrheit des Beirats“bezeichnet. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

25.6 Neben anderen Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernissen gemäß dieser Satzung und/oder Gesellschaf-

tervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird nicht
in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer / Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

15009

L

U X E M B O U R G

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls - im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 -
verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne,
gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch
vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser
Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
eingehen und durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung
mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft in Widerspruch stehen, so ist die
Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

10. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, dazu zu

ermächtigen, das Anteilsinhaberregister in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmäch-
tigung alleine zu unterzeichnen.

11. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse und ersucht den Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  beschließt,  eine  (1)  weitere  Anteilsklasse  zu  schaffen,  wodurch  nunmehr  zwei  (2)

Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile und Anteile der Serie A1.

15010

L

U X E M B O U R G

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-

minalwert von je einem Euro (EUR 1) ohne Einziehung von Anteilen in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Insight Venture Partners VIII L.P., ein exempted limited partnership ge-

gründet  und  bestehend  unter  dem  Recht  der  Kaimaninseln  (Cayman  Islands),  eingetragen  im  Registrar  of  Limited
Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer MC-71022, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand
Cayman, Cayman Islands, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Insight Venture Partners (Delaware) VIII L.P., ein limited partnership ge-

gründet und bestehend unter dem Recht des Bundesstaates Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika, eingetragen beim
Secretary of the State of Delaware unter der Nummer 5289013, mit Sitz in Corporation Trust Center, 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, Vereinigte Staaten von Amerika, als neuen Gesellschafter der
Gesellschaft.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert Insight Venture Partners (Cayman) VIII L.P., ein limited partnership ge-

gründet  und  bestehend  unter  dem  Recht  der  Kaimaninseln  (Cayman  Islands),  eingetragen  im  Registrar  of  Limited
Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer MC-71029, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104 Grand
Cayman, Cayman Islands, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Sechster Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  akzeptiert  Insight  Venture  Partners  (Co-Investors)  VIII  L.P.,  ein  exempted  limited

partnership gegründet und bestehend unter dem Recht der Kaimaninseln (Cayman Islands), eingetragen im Registrar of
Limited Partnerships of the Cayman Islands unter der Nummer MC-71024, mit Sitz in 309 Ugland House, KY1-1104
Grand Cayman, Cayman Islands, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von sechstausendvierhundertfünfundsechzig Euro (EUR
6.465)  auf  einen  Betrag  von  achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig  Euro  (EUR  18.965)  durch  die  Ausgabe  von
sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR
1,00), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- viertausendzwölf (4.012) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Insight I, vorbenannt, hier vertreten wie

vorerwähnt, zu einem Preis von viertausendzwölf Euro (EUR 4.012) gezeichnet;

- eintausendzweihundertzweiundsiebzig (1.272) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Insight II, vorbe-

nannt,  hier  vertreten  wie  vorerwähnt,  zu  einem  Preis  von  eintausendzweihundertzweiundsiebzig  Euro  (EUR  1.272)
gezeichnet;

- eintausendachtunddreißig (1.038) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Insight III, vorbenannt, hier ver-

treten wie vorerwähnt, zu einem Preis von eintausendachtunddreißig Euro (EUR 1.038) gezeichnet;

- einhundertdreiundvierzig (143) Anteile der Serie A1 wurden ordnungsgemäß von Insight IV, vorbenannt, hier ver-

treten wie vorerwähnt, zu einem Preis von einhundertdreiundvierzig Euro (EUR 143) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV, vorbenannt, gezeichneten sechstausendvierhundertfünfundsechzig

(6.465) Anteile der Serie A1 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von sechstausendvierhundert-
fünfundsechzig Euro (EUR 6.465).

Die Summe von sechstausendvierhundertfünfundsechzig Euro (EUR 6.465,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur freien

Verfügung, wie dies am amtierenden Notar erbracht wurde.

Die Einlage in Höhe von sechstausendvierhundertfünfundsechzig Euro (EUR 6.465) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Achter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass:

15011

L

U X E M B O U R G

- Insight I nun Inhaber von viertausendzwölf (4.012) Anteilen der Serie A1 geworden ist;
- Insight II nun Inhaber von eintausendzweihundertzweiundsiebzig (1.272) Anteilen der Serie A1 geworden ist;
- Insight III nun Inhaber von eintausendachtunddreißig (1.038) Anteilen der Serie A1 geworden ist;
- Insight IV nun Inhaber von einhundertdreiundvierzig (143) Anteilen der Serie A1 geworden ist.
Demzufolge schließen sich Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV, stimmberechtigt und hier vertreten durch Kristof

De Wael, Lawyer, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmachten, der Gesellschafterversammlung
für die folgenden Beschlüsse an.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt achtzehntausendneunhundertfünfundsechzig Euro (EUR 18.965),

bestehend aus

5.1.1  zwölftausendfünfhundert  (12.500)  Stammanteilen  mit  einem  Nominalwert  von  je  einem  Euro  (EUR  1)  (die

„Stammanteile”), und

5.1.2 sechstausendvierhundertfünfundsechzig (6.465) Anteilen der Serie A1 mit einem Nominalwert von je einem Euro

(EUR 1) (die „Anteile der Serie A1“, welche auch als „Anteile der Serie A“bezeichnet werden).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Insight Venture Partners VIII, L.P. („Insight I“), Insight

Venture Partners (Delaware) VIII, L.P. („Insight II“), Insight Venture Partners (Cayman) VIII, L.P. („Insight III“) und Insight
Venture Partners (Co-Investors) VIII, L.P. („Insight IV“) (Rocket, Insight I, Insight II, Insight III und Insight IV gemeinschaft-
lich  die  „Investoren“und  jeweils  ein  „Investor“)  ist  zur  Zeichnung  einer  Anzahl  weiterer  bei  einer  Kapitalerhöhung
ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder
um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), dem von der Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5
definiert) zugestimmt wurde (eine „Investition eines Dritten“) - unabhängig davon, ob diese vom Drittinvestor oder von
einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - die zur Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesell-
schaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu denselben Bedingungen, wie bei einer Investition
eines Dritten. Der jeweilige Investor hat die Gesellschaft durch eine verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen
darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser
Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren (oder eine mit einem Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG)) weitere Anteile zeichnet, entsprechend anwendbar.“

<i>Neunter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Zehnter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kate-

gorie,  dazu  zu  ermächtigen,  das  Anteilsinhaberregister  in  Einzelunterschrift  und  mit  uneingeschränkter  Befugnis  zur
Unterbevollmächtigung alleine zu unterzeichnen.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.500,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: K. DE WAEL und H. HELLINCKX.

15012

L

U X E M B O U R G

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 novembre 2014. Relation: LAC/2014/55405. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR)

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 2. Januar 2015.

Référence de publication: 2015003667/1461.
(150003712) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Amlelux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents.

R.C.S. Luxembourg B 142.084.

L'an deux mille quatorze, le onzième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de la société anonyme “Amlelux S.A.”, établie et

ayant son siège social à L-1319 Luxembourg, 91 rue Cents, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Lu-
xembourg, section B, sous le numéro 142084, (la “Société”), constituée originairement sous la dénomination sociale de
“PARTICIPATION”, suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-
Duché de Luxembourg), en date du 29 septembre 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
numéro 2589 du 23 octobre 2008,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 26 juin

2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1968 du 8 août 2012, contenant notamment
l'adoption par la Société de sa dénomination sociale actuelle.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319

Luxembourg, 91, rue Cents.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Mena MONTEIRO, chef-comptable, demeurant professionnellement

à L-1319 Luxembourg, 91, rue Cents, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Gilles VOGEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1319 Luxem-

bourg, 91, rue Cents, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Ajout à l'objet social de l'alinéa suivant:
“Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter

caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.”

2. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution

L'Assemblée décide d'élargir l'objet social en ajoutant à l'article 2, in fine, l'alinéa reproduit dans l'ordre du jour sous

le point 1.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a

ensuite clôturé l'Assemblée.

15013

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison du présent acte, s'élève approximativement à la somme de neuf cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, états civils et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: G. VOGEL, M. MONTEIRO, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2014 LAC/2014/60526. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015003537/60.
(150003357) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Fondamentale de Strassen, Association sans but lucratif,

(anc. Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Primaire de Strassen (A.P.E.E.P:)).

Siège social: L-8029 Stassen, 10, rue Jean-Pierre Kemp.

R.C.S. Luxembourg F 1.792.

Art. 1 

er

 .  L'association portera la dénomination d'«Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Fondamentale de

Strassen» (Elterevereenegung Stroossen).

Art. 2. L'association a pour objet:
1) De contribuer à la prospérité et au bien-être de l'Ecole Fondamentale de la Commune de Strassen, dans le respect

des lois et des règlements régissant l'enseignement public de notre pays;

2) De favoriser le dialogue constant entre les parents d'une part, le comité d'école, le personnel enseignant et les

autorités scolaires, d'autre part;

3) De collaborer d'une manière constructive à l'éducation scolaire des enfants de l'Ecole Fondamentale de Strassen;
4) De transmettre aux autorités scolaires, les suggestions des parents d'élèves en matière d'administration et d'orga-

nisation; de qualité, de développement et de réussite scolaire.

Art. 3. L'association s'interdit de s'occuper de questions étrangères à son objet et notamment de questions politiques,

idéologiques ou religieuses.

Art. 4. L'association a son siège à Strassen. Le siège social peut être transféré à n'importe quelle adresse à Strassen

par simple décision du conseil d'administration.

Art. 5. Elle est constituée pour une durée illimitée.

Art. 6. Le nombre des membres est illimité sans pouvoir être inférieur à cinq.

Art. 7. Peuvent être membres de l'association, les parents d'élèves et les personnes justifiant qu'ils ont la charge d'un

enfant, élève d'une classe de l'Ecole Fondamentale de Strassen.

Art. 8. Les membres paient une cotisation annuelle dont le montant et les conditions de versement sont déterminées

par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. Le montant maximum de la cotisation ne peut pas
dépasser 50 euros.

Dans un même ménage, les parents d'un ou de plusieurs enfant(s) paient ensemble une seule cotisation.

Art. 9. Sont sortants et ne sont plus rééligibles, les parents dont les enfants ne fréquentent plus au moment de l'as-

semblée générale, une classe de l'Ecole Fondamentale de Strassen. Tout membre de l'association peut à tout moment
démissionner moyennant notification écrite au conseil d'administration. Quiconque ne paie pas de cotisation pendant
deux années consécutives, sera considéré comme démissionnaire.

Art. 10. Pour des actes portant préjudice grave à l'association ou à son objet, l'exclusion d'un membre peut être

prononcée sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale, à la majorité des deux tiers des voix
présentes ou représentées.

Art. 11. L'associé démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social.

Art. 12. L'association est gérée par un conseil d'administration de 5 membres au moins et de 11 membres au plus. Les

membres du conseil d'administration sont élus parmi les membres par l'assemblée générale à la majorité simple des voix
présentes ou représentées. Leur mandat a une durée de 2 ans. Les membres sortants sont rééligibles à condition qu'ils

15014

L

U X E M B O U R G

aient la charge d'un enfant, élève d'une classe de l'Ecole Fondamentale de Strassen. Les élections ont lieu à l'assemblée
générale. Les parents d'un enfant ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration. Ne peuvent être
membres du conseil d'administration, les membres du conseil communal.

Art. 13. Le conseil d'administration élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier.

Art. 14. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont honorifiques.

Art. 15. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins une fois par trimestre scolaire

sur convocation de son président ou de son remplaçant. Il ne pourra délibérer valablement qu'en présence de la majorité
de ses membres. Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal signé par le président
et le secrétaire. Les administrateurs pourront en prendre connaissance sans déplacement du dossier. Les décisions du
conseil d'administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. En cas de partage des
voix, celle du président est prépondérante. Le membre du conseil d'administration qui est absent à plus de trois réunions
consécutives sans excuse, sera considéré comme démissionnaire.

Art. 16. L'association est valablement engagée par la signature conjointe du président et du secrétaire, respectivement

par celle du président et du trésorier.

Art. 17. Les opérations financières de l'association sont surveillées par deux commissaires aux comptes, qui seront

élus par l'assemblée générale à la majorité simple des voix. Leur mandat a une durée de deux ans.

Art. 18. L'année sociale correspond à l'année scolaire.

Art. 19. Le conseil d'administration peut constituer un comité d'organisation qui participe activement aux activités de

l'association.

Art. 20. Le conseil d'administration convoquera une fois par année, une assemblée générale ordinaire. L'ordre du jour

de l'assemblée générale ainsi que la date et le lieu sont établis par le conseil d'administration. Toute convocation de
l'assemblée générale est portée à la connaissance des membres au moins huit jours avant la date fixée par courrier
électronique ou par voie postale. L'ordre du jour doit être joint à cette convocation. Des résolutions pourront être prises
en dehors de l'ordre du jour sur proposition du président ou du conseil d'administration.

Art. 21. L'assemblée générale est régulièrement constituée quel que soit le nombre des membres effectifs présents.

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président ou de son
remplaçant est prépondérante. Les parents d'un ou de plusieurs enfant(s) ne disposent que d'un droit de vote.

Art. 22. Il est rendu compte à l'assemblée générale ordinaire des activités de l'association au cours de l'exercice écoulé

et de la situation financière. L'assemblée approuve les comptes de l'exercice écoulé et le projet de budget du prochain
exercice; le cas échéant, elle procède aux élections prévues par les statuts.

Art. 23. Toute réunion de l'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal portant la signature du président ou de

son remplaçant et du secrétaire; les membres pourront en prendre connaissance sans déplacement du dossier.

Art. 24. Le conseil d'administration pourra convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'il le jugera

utile ou nécessaire. A la suite d'une demande écrite de la part d'un cinquième des membres effectifs, le conseil d'admi-
nistration doit convoquer dans le délai d'un mois, une assemblée générale extraordinaire, en portant à l'ordre du jour,
le motif de la demande. L'assemblée générale extraordinaire pourra se prononcer sur une modification des statuts.

Art. 25. Les ressources de l'association se composent notamment:
a) Des cotisations de ses membres,
b) De subsides,
c) De dons ou legs en sa faveur,
d) Des intérêts de fonds placés.
Cette liste n'est pas limitative.

Art. 26. En cas de dissolution de l'association, l'actif subsistant après extinction du passif sera versé à une oeuvre de

Bienfaisance.

Art. 27. Pour les cas non prévus par les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 21 avril

1928 sur les associations sans but lucratif.

Référence de publication: 2015003543/86.
(150003936) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

15015

L

U X E M B O U R G

Attert Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.504,00.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 192.279.

Il est notifié que notifié qu'en date du 01 Décembre 2014:
- 15,630 parts sociales de classe A des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à BALBRIDIE LTD, une société constituée et existante sous les
lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9297222;

- 15,630 parts sociales de classe B des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à LUPAIA CONSULTING LIMITED, une société constituée et
existante sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 4, Dunstan Road, Tunbridge Wells, Kent TN4 9NE,
Royaume Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales),
sous numéro 9291553;

- 15,630 parts sociales de classe C des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à OGIORNI LTD, une société constituée et existante sous les
lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9288552;

- 15,630 parts sociales de classe D des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à SHERLAND LTD, une société constituée et existante sous
les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9288637;

- 15,630 parts sociales de classe E des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à BALBRIDIE LTD, une société constituée et existante sous les
lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9297222;

- 15,630 parts sociales de classe F des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à LUPAIA CONSULTING LIMITED, une société constituée et
existante sous les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 4, Dunstan Road, Tunbridge Wells, Kent TN4 9NE,
Royaume Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales),
sous numéro 9291553;

- 15,630 parts sociales de classe G des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à OGIORNI LTD, une société constituée et existante sous les
lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9288552;

- 15,630 parts sociales de classe H des 15,630 détenues par Exequtive Partners S.A., une société anonyme constituée

et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 48, Boulevard Grande-Duchesse
Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du
Luxembourg sous numéro B 174367, ont été transférées à SHERLAND LTD, une société constituée et existante sous

15016

L

U X E M B O U R G

les lois du Royaume Uni, ayant son siège social au 1, Edbrook Farm Horn Hill, Cannington Somerset, TA5 2QE, Royaume
Uni et enregistrée auprès du registre des sociétés des Royaume Uni (Companies House of England and Wales), sous
numéro 9288637

Résultant des décisions susmentionnées les 12,504 parts sociales de la Société sont désormais détenues comme suit:
- BALBRIDIE LTD détient 15,630 parts sociales de classe A et 15,630 parts sociales de classe E de la Société;
- LUPAIA CONSULTING LIMITED détient 15,630 parts sociales de classe B et 15,630 parts sociales de classe F de la

Société;

- OGIORNI LTD détient 15,630 parts sociales de classe C et 15,630 parts sociales de classe G de la Société;
- SHERLAND LTD détient 15,630 parts sociales de classe D et 15,630 parts sociales de classe H de la Société;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Attert Holdings S.à r.l.
J.A. Mees
<i>Gérant

Référence de publication: 2015003546/75.
(150003903) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Bilux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 142.995.

DISSOLUTION

In the year two thousand fourteenth, on the twenty-second day of December.
Before Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED:

BICA the Lion Trust, a company incorporated under the laws Jersey, having its registered office at Channel House,

Green Street, St Helier, JE2 4UH Jersey,

represented by Mrs Virginie PIERRU, private employee, residing professionally in L-1466 Luxembourg, 12, rue Jean

Engling, by virtue of a proxy given under private seal, said proxy after having been signed “ne.by the proxyholder acting
on behalf of the appearing party and the undersigned notary shall remain attached to the present deed to be filed with
such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as aforesaid, has requested the undersigned notary to record the following:
The appearing party is the sole shareholder (the “Sole Shareholder”) of “BILUX S.à r.l.”, a private limited liability

company, having its registered office in L-2134 Luxembourg, 58, rue Charles Martel, incorporated by deed of Maître
Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, on November 4 

th

 , 2008, published in Mémorial C, number 2870

on December 1 

st

 , 2008,

registered with the Luxembourg Trade and Companies Register, under number B 142.995 (the “Company”).
The Sole Shareholder, represented as aforesaid, declares that it has full knowledge of the articles of incorporation and

of the financial standing of the Company and decides to dissolve and liquidate the Company with immediate effect.

The subscribed capital of the company is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by five

hundred (500) shares with a par value of twenty-five euro (EUR 25.-) each, all subscribed and fully paid-up.

Being the Sole Shareholder of the shares and liquidator of the Company the appearing party, represented as aforesaid,

declares that all assets have been realised, and property of all assets has been transferred to the sole shareholder that
any and all liabilities towards third parties known to the Company have been entirely paid or duly accounted for. Regarding
any eventual liability presently unknown to the Company and not paid until the date of dissolution, the Sole Shareholder,
irrevocably assumes the obligation to guarantee payment of any such liability, with the result that the liquidation of the
Company is to be considered closed.

The Sole Shareholder, represented as aforesaid, gives discharge to the sole manager for its mandate up to this date.
That the Sole shareholder, represented as aforesaid, declares that the dissolution and liquidation of the Company is

closed and that any registers of the Company recording the issuance of shares or any other securities shall be cancelled.

The corporate books and accounts of the Company will be kept for periods of five years at registered office of the

Company.

In order to perform all the formalities relating to the registrations, the publications, the cancellations, the filing and all

other formalities to be performed by virtue of the present deed, all powers are granted to the bearer of an authentic
copy. However, no confusion of assets and liabilities between the dissolved Company and the share capital of, or reim-
bursement to the sole shareholder will be possible before the end of a period of thirty days (by analogy of the article 69

15017

L

U X E M B O U R G

(2) of the law on commercial companies) from the day of publication and subject to the non-respect by any creditor of
the dissolved Company of the granting of guarantees.

<i>Costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be eight hundred euros (EUR 800.-).

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing party, the present deed is worded

in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English
version will be binding.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the person signed together with the notary

the present deed.

Suit la version allemande du texte qui précède:

Im Jahre zweitausenddreizehn, den zweiundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT mit Amtssitz in Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

BICA the Lion Trust, eine Gesellschaft nach dem Gesetz von Jersey, mit Gesellschaftssitz in Channel House, Green

Street, St Helier, JE2 4UH Jersey,

hier vertreten durch Frau Virginie PIERRU, Privatangestellte, beruflich wohnhaft in L-1466 Luxemburg, 12, rue Jean

Engling, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift, welche Vollmacht vom Bevollmächtigten und dem
amtierenden Notar “ne varietur” unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit derselben ein-
registriert zu werden

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht ihre Erklärungen und

Feststellungen zu beurkunden wie folgt:

Die Partei ist der einzige Aktionär Erscheinen (der "Alleinaktionär") der "BILUX S.à r.l.", mit Sitz in L-2134 Luxemburg,

58, rue Charles Martel, ist gegründet worden gemäß Urkunde aufgenommen durch Notar Martine SCHAEFFER, mit dem
Amtssitz in Luxemburg, am 04. November 2008, veröffenlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,
Nummer 2870 vom 01. Dezember 2008,

eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 142.995, (hiernach

die "Gesellschaft").

Der Alleingesellschafter, wie vorstehend dargestellt, erklärt, dass sie Kenntnis hat und der Satzung und der Bonität

des Unternehmens und beschließt die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung.

Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert (EUR 12.500,-) Euro, aufgeteilt in fünfhundert (500)

Anteile mit einem Nennwert von je fünfundzwanzig (EUR 25.-) Euro.

Die Alleingesellschafterin, als Liquidator der Gesellschaft, erklärt, dass die Tätigkeit der Gesellschaft beendet ist, alle

ausstehenden Verbindlichkeiten der Gesellschaft beglichen worden sind, oder für deren Begleichung Sorge getragen wird,
dass sämtliche Aktiva der Gesellschaft auf die Alleingesellschafterin übergehen, welche erklärt, dass alle Schulden der
Gesellschaft beglichen sind und sie sich verpflichtet alle etwaigen noch nicht beglichenen Schulden zu übernehmen, ehe
eine Zahlung an sich selbst erfolgt.

Der Alleingesellschafter, représentée wie gesagt, erteilt dem alleinigen Geschäftsführer für ict Mandat bis zum heutigen

Tag.

Dass der Alleinaktionärin représentée wie gesagt, erklärte que la Auflösung und Liquidation der Gesellschaft geschlos-

sen ist und dass alle Register der Gesellschaft Aufzeichnung der Ausgabe von Aktien oder Wertpapieren Shall Be Beliebig
Andere abgebrochen.

Die Unternehmens Bücher und Konten der Gesellschaft werden für périodes von fünf Jahren am Sitz der Gesellschaft

gehalten werden.

Der Komparent wurde alsdann vom amtierenden Notar über Artikel 69 (2) des Gesetzes über die Handelsgesell-

schaften belehrt, dass keine Verschmelzung zwischen dem Vermögen der Gesellschaft und dem des Rechtsnachfolgers
und die Übernahme des Gesellschafts-vermögens durch den vormalig alleinigen Gesellschafter, vor Ablauf einer Frist von
dreißig Tagen, ab dem Tag der Veröffentlichung der vorliegenden Urkunde geschehen kann sofern kein Gläubiger der
derzeit aufgelösten und liquidierten Gesellschaft die Gewährung von Sicherheiten verlangt hat.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, beläuft sich auf ungefähr siebenhundertfünfzig
Euro.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, Datum wie eingangs erwähnt.

15018

L

U X E M B O U R G

Nach Vorlesung an den Bevollmächtigten des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, hat dieser mit dem amtierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterzeichnet.

Signé: V. PIERRU, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 02 janvier 2015 2LAC/2015/40. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Paul MOLLING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 08 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003585/104.
(150003935) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Corvin S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers.

R.C.S. Luxembourg B 59.993.

L'an deux mille quatorze, le seizième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire (l'“Assemblée”) des actionnaires de “CORVIN S.A.”, une société anonyme régie

par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1537 Luxembourg, 3, rue des Foyers,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 59993, (la “Société”),
constituée suivant acte reçu par Maître Paul BETTINGEN, notaire de résidence à Niederanven (Grand-Duché de Lu-
xembourg), en date du 26 juin 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 569 du 17
octobre 1997,

et dont les statuts (les “Statuts”) ont été modifiés en vertu d'une résolution prise par l'assemblée générale extraor-

dinaire tenue sous seing privé en date du 24 juillet 2000, contenant notamment la conversion de la devise du capital social
en euros, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 404 du 1 

er

 juin

2001.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Jean BEISSEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537

Luxembourg, 3, rue des Foyers.

Le Président désigne Madame Lynn WALTZING, expert-comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Lu-

xembourg, 3, rue des Foyers, comme secrétaire.

L'Assemblée choisit Monsieur Patrick SCHMIT, comptable, demeurant professionnellement à L-1537 Luxembourg, 3,

rue des Foyers, comme scrutateur.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter:
A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de neuf millions cinq cent cinquante-cinq mille euros

(9.555.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR) à dix
millions six cent cinq mille euros (10.605.000,- EUR), par la création et l'émission de neuf mille cent (9.100) actions
nouvelles avec une valeur nominale de mille cinquante euros (1.050,- EUR) chacune;

2. Souscription des neuf mille cent (9.100) actions nouvelles par la société anonyme de droit suisse “Fintrading SA”,

ayant son siège social à CH-1211 Genève, boulevard Jacques-Dalcroze 2, inscrite au Registre du Commerce du Canton
de Genève sous le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-103.571.156, et libération intégrale par con-
version en capital d'une créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient à l'encontre de la Société;

3. Modification subséquente du premier alinéa de l'article 5 des statuts;
4. Pouvoir et autorité donnés à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour procéder à l'émission

de nouveaux titres au porteur suite à l'émission des nouvelles actions; et

5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre de actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

15019

L

U X E M B O U R G

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de neuf millions cinq cent cinquante-cinq

mille euros (9.555.000,- EUR) afin de le porter de son montant actuel d'un million cinquante mille euros (1.050.000,- EUR)
à dix millions six cent cinq mille euros (10.605.000,- EUR), par la création et l'émission de neuf mille cent (9.100) actions
nouvelles avec une valeur nominale de mille cinquante euros (1.050,- EUR) chacune.

L'apport étant réalisé en nature, la mise en oeuvre du droit préférentiel de souscription, prescrit par la loi en faveur

des actionnaires existant en cas d'émission d'actions nouvelles, n'est pas d'application.

<i>Souscription - Libération

L'Assemblée reconnaît que, cependant avec l'agrément de tous les actionnaires, les neuf mille cent (9.100) actions

nouvelles ont été souscrites par la société “Fintrading SA”, pré-désignée, et libérées entièrement par ladite souscriptrice
moyennant un apport en nature, consistant en la conversion en capital d'une créance certaine, liquide et exigible qu'elle
détient à l'encontre de la Société (l'“Apport”).

<i>Evaluation - Rapport de l'apport

L'Apport autre qu'en numéraire a fait l'objet d'un rapport établi préalablement aux présentes, par le réviseur d'en-

treprises agréé indépendant, la société à responsabilité limitée dénommée “L'Alliance Révision SARL”, établie et ayant
son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg, immatriculé au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 46498, sous la signature de Monsieur Bishen JACMOHONE, lequel rapport établi en date
du 15 décembre 2014, conformément aux articles 26-1 et 32-1 de la loi modifiée sur les sociétés commerciales du 10
août 1915 conclut que:

<i>Conclusion

“Sur base de nos travaux, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des

apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale, des actions à émettre en contrepartie.”

Ledit rapport, après avoir été signé “ne varietur” par les comparants et le notaire instrumentant, restera annexé au

présent acte afin d'être enregistré avec lui.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'accepter lesdites souscriptions et lesdites libérations et d'attribuer les neuf mille cent (9.100)

actions à “Fintrading SA”, mentionnée ci-dessus.

<i>Troisième résolution

En conséquence des résolutions adoptées ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier le premier alinéa de l'article 5 des

Statuts afin de lui donner la teneur suivante:

“Le capital social est fixé à dix millions six cent cinq mille euros (10.605.000,-EUR), représenté par dix mille cent

(10.100) actions avec une valeur nominale de mille cinquante euros (1.050,- EUR) chacune, entièrement libérées.”

<i>Quatrième résolution

L'Assemblée décide d'accorder pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, agissant individuellement, pour

procéder pour le compte de la Société, à la création de nouveaux titres au porteur, suite à l'émission des nouvelles actions.

Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et aucun des actionnaires présents ou représentés

ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à quatre mille huit cents euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: J. BEISSEL, L. WALTZING, P. SCHMIT, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 18 décembre 2014. LAC/2014/61176. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

15020

L

U X E M B O U R G

POUR EXPEDITION CONFORM, délivrée;

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003652/101.
(150003889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

Cronos Recherches Cliniques S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 64.451.

L'an deux mille quatorze,
le dix-sept décembre.
Pardevant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM (Grand-Duché de Luxembourg),

s'est tenue

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires Assemblée») de la société «CRONOS RECHERCHES CLINI-

QUES S.A.», une société anonyme, constituée suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné à la date du 14 mai
1998, lequel acte fut publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») le 03 août 1998, sous
le numéro 563 et page 26997,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous la section B numéro 64 451, établie et ayant son siège

social au 17 rue Beaumont, L-1219 Luxembourg (la «Société»).

Les statuts de la Société furent modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié dressé par le notaire soussigné en

date du 27 décembre 2010, lequel acte fut régulièrement publié au Mémorial, le 03 mai 2011, sous le numéro 882 et page
42297.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Sophie ERK, employée privée, avec adresse professionnelle à

Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Brendan D. KLAPP, employé privé, avec adresse professionnelle à

Belvaux, Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio FERNANDES, employé privé, avec adresse professionnelle

à Luxembourg.

Le Bureau de l’Assemblée étant ainsi constitué, le président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:
I) L'ordre du jour de l’Assemblée est conçu comme suit:

<i>Ordre du jour:

1. - Dissolution anticipée de la Société et décision de la mettre en liquidation, avec effet immédiat.
2. - Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.
3. - Divers.
II) Il a été établi une liste de présence, renseignant les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires ou leurs mandataires et par les membres
du Bureau, sera annexée au présent acte pour être soumis à l’enregistrement en même temps.

Les pouvoirs des actionnaires représentés, signés "ne varietur" par les personnes présentes et le notaire instrumentaire,

resteront également annexés au présent acte.

III) Il résulte de ladite liste de présence que toutes les mille deux cent cinquante (1'250) actions représentant l’intégralité

du capital social sont présentes ou représentées à cette Assemblée, laquelle est dès lors régulièrement constituée et peut
valablement délibérer sur son ordre du jour, dont les actionnaires ont été dûment informés avant cette assemblée.

Après délibération, l’Assemblée prend, chaque fois et à l’unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée DECIDE de procéder à la dissolution anticipée de la Société «CRONOS RECHERCHES CLINIQUES

S.A.» et de prononcer sa mise en liquidation avec effet à ce jour.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée DECIDE de nommer aux fonctions de seul liquidateur de la Société:
Monsieur Enzo ZAFFERANI, administrateur de société, né Serravalle (Italie), le 02 mai 1945, demeurant à Via dei tigli

30, 47895 DOMAGNANO (R.S.M) [Italie].

<i>Troisième résolution

L'Assemblée DECIDE d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants:

15021

L

U X E M B O U R G

- Le Liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi du 10 août 1915 sur les

sociétés commerciales, telle que modifiée.

-  Le  Liquidateur  peut  accomplir  tous  les actes  prévus  à l’article 145 sans demander  l’autorisation de  l’Assemblée

Générale des Actionnaires dans les cas où elle est requise.

- Le Liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de procéder à une inscription automatique; renoncer

à tous droits réels, droits préférentiels, hypothèques, actions résolutoires; enlever les charges, avec ou sans paiement de
toutes les inscriptions préférentielles ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres charges.

- Le Liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se référer aux comptes de la Société.
- Le Liquidateur peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales ou spécifiques, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

- Le Liquidateur pourra distribuer aux actionnaires une avance en numéraire ou en nature sur le boni de liquidation.
- Le Liquidateur sera responsable tant envers les tiers qu'envers la Société, pour l’exécution du mandat qui lui est

donné.

- La signature du Liquidateur lie valablement et sans limitation la Société dans le processus de liquidation.
- Le Liquidateur rédigera un rapport sur les résultats de la liquidation et sur l’emploi des actifs sociaux, comptes et

documents à l’appui.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont procès-verbal.
Plus rien ne figurant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par noms, prénoms

usuels, états et demeures, ces mêmes comparants ont signé avec Nous le notaire le présent acte.

Signé: S. ERK, B. D. KLAPP, A. FERNANDES, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 23 décembre 2014. Relation: EAC/2014/18056. Reçu douze Euros (12.- EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2015003658/75.
(150003555) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 8 janvier 2015.

UFG Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 145.044.

DISSOLUTION

L'AN DEUX MIL QUATORZE, LE DOUZE DECEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg,

A comparu:

La Française AM International, une société anonyme ayant son siège social à L-2530 Luxembourg, 4a, rue Henri Schnadt,

enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 23.447,

ci-après dénommée «l'actionnaire unique»,
ici représentée par deux de ces signatures autorisées, à savoir Madame Isabelle KINTZ, employée à Luxembourg, ayant

le pouvoir de signature A, et Madame Suzanne PROUCHANDY, employée à Luxembourg, ayant le pouvoir de signature
B.

Laquelle partie comparante, représentée comme il est dit ci-avant, a exposé au notaire et l'a prié d'acter ce qui suit:
- que la Société «UFG FUND», une société d'investissement à capital variable sous la forme d'une société anonyme,

établie et existante sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 33, Rue de Gasperich, L-5826
Hesperange, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B145044, ci-après
dénommée «la Société», a été constituée suivant acte reçu en date du 4 mars 2009 par Maître Henri Hellinckx, notaire,
résidant à Luxembourg, acte publié au «Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations» de Luxembourg numéro 623
du 23 mars 2009;

- que les statuts de la société n'ont jamais été modifiés depuis.
- que le capital initial est fixé à trente et un mille euros (31.000 EUR) représenté par des actions entièrement libérées

et sans valeur nominale;

- que l'actionnaire unique est propriétaire de la totalité des actions de la Société;
- que l'actionnaire unique décide de dissoudre et de liquider la Société;
- que la Société ne comporte plus qu'un seul compartiment, à savoir celui dénommé «UFG ALTERAM SELECTION»;

15022

L

U X E M B O U R G

- que l'actionnaire unique prononce la dissolution anticipée de la Société avec effet immédiat;
- que l'actionnaire unique se désigne lui-même comme liquidateur de la société et qu'en cette qualité il requiert le

notaire instrumentant d'acter;

- que le passif en relation avec la clôture de la liquidation est dûment approvisionné, tel que cela ressort d'une situation

comptable arrêtée au 12 décembre 2014;

- qu'il déclare irrévocablement reprendre avec effet à partir de ce jour tout le passif de la Société tel que détaillé dans

la situation en annexe du présent acte;

- que par rapport à d'éventuels passifs de la Société actuellement inconnus et non payés à l'heure actuelle, il assumera

irrévocablement l'obligation de payer tout ce passif éventuel;

- qu'en conséquence tout le passif de ladite Société est réglé;
- que l'actif restant est réparti à l'associé unique en date de ce jour;
- que les déclarations du liquidateur ont fait l'objet d'une vérification, suivant rapport en annexe, conformément à la

loi, par Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 560, Rue de Neudorf, L-2220 Lu-
xembourg, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B67895;

- que partant la liquidation de la Société est à considérer comme faite et clôturée et que la société a cessé d'exister;
- que décharge pleine et entière est donnée aux administrateurs, au réviseur d'entreprises agrée de la Société;
- que les livres et documents de la Société sont conservés pendant cinq ans à l'ancien siège social de la Société, à savoir

au 33, Rue de Gasperich, L - 5826 Hesperange;

- que pour l'accomplissement des formalités relatives aux transcriptions, publications, radiations, dépôts et autres

formalités à faire en vertu des présentes, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition des présentes pour
accomplir toutes les formalités.

<i>Frais

Les coûts, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison

des présentes sont estimés à approximativement EUR 1.600,-.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite en langue du pays aux représentants de la partie comparante, connus du notaire instrumentant par noms,

prénoms, états et demeures, les prédites personnes a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: I. KINTZ, S. PROUCHANDY, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 16 décembre 2014. Relation: LAC/2014/60440. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): C. FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 06 janvier 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015003474/64.
(150002875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

V.D.L. Développement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 105.549.

Les comptes annuels au 31 août 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2015003478/10.
(150002645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Thalassa Financial S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 138.328.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 29 décembre 2014

Est nommé administrateur, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Reno Maurizio TONELLI, licencié en sciences politiques, demeurant professionnellement au 2, avenue

Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg.

15023

L

U X E M B O U R G

Monsieur Reno Maurizio TONELLI terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance

lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 6 janvier 2015.

Référence de publication: 2015003450/16.
(150002957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 janvier 2015.

Shiatsu-Ki S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1924 Luxembourg, 28, rue Emile Lavandier.

R.C.S. Luxembourg B 145.214.

DISSOLUTION

L’an deux mille quatorze, le douze décembre.
Par-devant Nous Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à SANEM, Grand-Duché de Luxembourg,

a comparu:

Madame Elisabeth LAUBRY, épouse THOMAS, née à Paris (9 

ème

 ) le 2 mars 1957, demeurant au 22 rue des Violettes,

F-57100 Thionville.

Lequel comparant, ici personnellement présent, a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit ses

déclarations et constatations:

1.- Qu'il est le seul et unique associé de la société «SHIATSU-KI S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité

limitée  soumise  au  droit  luxembourgeois,  établie  et  ayant  son  siège  social  actuel  au  28  rue  Emile  Lavandier,  L-1924
Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B sous le numéro 145214,
constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 5 mars 2009, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés
et Associations, numéro 703 du 1 

er

 avril 2009;

2.- Que les statuts de la Société furent modifiés suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 1 

er

 octobre

2009, lequel acte de modification des statuts fut publié au Mémorial, le 27 octobre 2009, sous le numéro 2107.

3.- Que le capital social de la Société s’élève actuellement à DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12'400.- EUR)

représenté par cent (100) parts sociales d’une valeur nominale de CENT VINGT-QUATRE EUROS (124.- EUR) chacune,
toutes intégralement libérées;

4.- Que lui, en tant qu'associé unique, est resté depuis le jour de la constitution de la Société, seul et unique propriétaire

de toutes les cent (100) parts sociales de la Société.

5.- Dès lors et qu'en sa qualité d’associé unique le comparant prémentionné déclare dissoudre ladite Société avec effet

immédiat.

6.- Que l’associé unique, en sa qualité de détenteur unique des parts sociales de la Société, déclare avoir parfaite

connaissance des statuts et de la situation financière de la Société et de même déclare avoir reçu tous les actifs de la
Société et qu'il prendra personnellement en charge tout le passif de la Société qu'il soit occulte, connu et inconnu à ce
moment;

7.- Que partant la Société se trouve liquidée;
8.- Que décharge pleine et entière est accordée au gérant unique pour l’exercice de son mandat jusqu'à ce jour;
9.- Que les livres, documents et pièces relatifs à la Société resteront conservés durant cinq ans à l’ancien siège de la

Société, soit au 28 rue Emile Lavandier, L-1924 Luxembourg.

10.- Que l’associé unique déclare prendre à sa charge tous les frais résultant du présent acte.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en l’étude du notaire soussigné, les jour, mois

et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, le comparant prémentionné a signé avec Nous notaire instrumentant le présent acte.
Signé: E. LAUBRY, J.J. WAGNER.
Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 22 décembre 2014. Relation: EAC/2014/17872. Reçu soixante-quinze Euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

Référence de publication: 2014208568/45.
(140232884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

15024


Document Outline

Aberdeen Global II

Amlelux S.A.

Association des Parents d'Elèves de l'Ecole Fondamentale de Strassen

Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Primaire de Strassen (A.P.E.E.P:)

Attert Holdings S.à r.l.

BBL Holding S.A., SPF

Bilux S.à r.l.

CEP IV Investment 1 S.à r.l.

Chauffage-Sanitaire Claude Schreiber S.à r.l.

CJ Lux Holdings

Clean Fuels (South America) S.A.

Coil Architectes S.à r.l.

Combourg (Luxembourg) S.A.

Compagnie de Bourbon S.A.

Corvin S.A.

Cronos Recherches Cliniques S.A.

Development Finance Initiative (DFI)

Development Finance Initiative (DFI)

Digital Services XXIV S.à r.l.

DSG S.à r.l.

EDEF Principals S.C.S.

Eginter S.à r.l.

Eqestar Capital S.P.F. S.A.

Eqestar Capital S.P.F. S.A.

Eqestar Capital S.P.F. S.A.

Eqestar Capital S.P.F. S.A.

Eurobatitech S.à r.l.

Euroclass Multimedia Holding S.A.

Euroklima

Euro Partner S.A.

European Property SICAV-FIS

European Property SICAV-FIS

European Property SICAV-FIS

Eurtrans S.A.

Expansion Immobilière S.A.

Fablon S.à r.l.

Fiduciaire Kieffer Marc S.à r.l.

First Data International Luxembourg IV S.à r.l.

Foothill Financing S.à r.l.

Friture au Gourmet s.à r.l.

Giulianova S.à r.l.

Glenn Funds S.à r.l.

Shiatsu-Ki S.à r.l.

SOLIFIN (Luxembourg) S.A.

Thalassa Financial S.A.

UFG Fund

V.D.L. Développement S.A.