logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 284

4 février 2015

SOMMAIRE

Aberdeen Global II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13594

Adran S.A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13589

Alpha Concept S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

AMP Capital Investors (Luxembourg No.

6) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13631

Amster Property I S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . .

13587

Anci sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13590

Aquarelle Germany S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

13592

Aquarelle Italy S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

Argopal Real Estate S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

13593

Ariodante  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13591

Athena Private Equity 2 S.A.  . . . . . . . . . . . .

13590

Auberge Petite Suisse S.àr.l.  . . . . . . . . . . . .

13590

Automation Conveyor Systems S.A.  . . . . .

13588

Babouille, s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13592

Bedworth S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13593

Blue Marine Investments S.A.  . . . . . . . . . . .

13595

BPER International Sicav  . . . . . . . . . . . . . . .

13622

BPER International Sicav  . . . . . . . . . . . . . . .

13589

BPER International Sicav  . . . . . . . . . . . . . . .

13596

CAHVA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13595

Cardoso S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13594

CD&R Osprey Investment S.à r.l.  . . . . . . . .

13594

CEE Urban Red SCA, SICAV-FIS  . . . . . . . .

13595

CEON Asset Management Luxembourg

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13594

Chamborant S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13599

City Living Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

13624

Compagnie Industrielle et Financière des

Produits Amylacés SICAF/SIF . . . . . . . . . .

13593

Crisalid Luxembourg SA  . . . . . . . . . . . . . . . .

13620

CS Invest Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . .

13627

CS Management Luxembourg S.A.  . . . . . .

13630

Digital Services XXX S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

13600

Elbblick (Juliet) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13590

Finasset S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13620

Fonds Direkt Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13587

ING (L) FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13625

ING (L) Patrimonial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13628

Lux Prime Pension - Sepcav . . . . . . . . . . . . .

13588

Naxsis Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13632

Nikoglobal Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

13631

Parc Faïence S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13593

RSF Europe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13588

SA Contraste Europe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13587

Sol-Line S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13591

Surf International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13592

Tonnerre Investments S.A.  . . . . . . . . . . . . .

13591

Vates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13586

VPC Luxembourg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13596

White House S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13591

13585

L

U X E M B O U R G

Vates, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-5365 Munsbach, 1c, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.548.

Die Aktionäre der Vates (die "Gesellschaft") werden hiermit zur

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

die am Mittwoch, den <i>25. Februar 2015 , um 14.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, 1c, rue Gabriel

Lippmann, L-5365 Munsbach stattfindet, eingeladen um über folgende Tagesordnung zu beraten und abzustimmen.

<i>Tagesordnung:

1. Billigung der Berichte des Verwaltungsrates sowie des Abschlussprüfers für das am 31. Oktober 2014 abgelaufene

Geschäftsjahr

2. Billigung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Oktober 2014 abgelaufene Geschäftsjahr
3. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses per 31. Oktober 2014
4. Entlastung des Verwaltungsrates für die Ausübung des Mandates während des am 31. Oktober 2014 abgelaufenen

Geschäftsjahres

5. Wahl oder Wiederwahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung
6. Genehmigung der Verwaltungsratsvergütungen
7. Sonstiges
Beschlüsse auf die Tagesordnung können ohne Anwesenheitsquorum mit einfacher Mehrheit der Stimmen der anwe-

senden oder vertretenen Aktien gefasst werden.

Um an der Generalversammlung teilnehmen zu können bzw. ihr Stimmrecht durch einen bestellten Bevollmächtigten

auszuüben, müssen Aktionäre sich bis spätestens 20. Februar 2015 bei der Domizilstelle der Gesellschaft, Hauck &amp; Auf-
häuser Investment Gesellschaft S.A. (Fax Nr.: 00352 45 13 14 509, Corporate Services) angemeldet haben bzw. das am
Sitz der Gesellschaft erhältliche Vollmachtsformular ausgefüllt zurückgesendet haben.

Aktionäre von in Wertpapierdepots gehaltenen Aktien müssen mittels einer Bestätigung der depotführenden Stelle

(Sperrbescheinigung) nachweisen, dass ihre Aktien durch die jeweilige depotführende Stelle vom Tage der Ausstellung
der  Bescheinigung  an  und  bis  nach  der  Generalversammlung  gesperrt  sind.  Eine  solche  Sperrbescheinigung  muss  bis
spätestens 20. Februar 2015 am Sitz der Gesellschaft hinterlegt sein.

Der Jahresbericht ist bei der Zentralverwaltungsstelle während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.

Munsbach, im Februar 2015

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015017858/1346/32.

Aquarelle Italy S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.641.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207555/10.
(140232253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Alpha Concept S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 62.093.

La Convention de Domiciliation, conclue en date du 18 octobre 2000 avec la Société Anonyme ALPHA CONCEPT

SA, précédemment avec Siège social à L - 2420 Luxembourg, 11, Avenue Emile Reuter, R.C.S. Luxembourg B 62093, a
été résiliée avec effet au 9 août 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

SOCIETE GENERALE BANK &amp; TRUST

Référence de publication: 2014207593/12.
(140231942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13586

L

U X E M B O U R G

Fonds Direkt Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1445 Strassen, 4, rue Thomas Edison.

R.C.S. Luxembourg B 70.709.

Teilfonds
Fonds Direkt Sicav - Skyline Dynamik, ISIN LU0100002038
Fonds Direkt Sicav - Skyline Klassik, ISIN LU0100001907

Die Aktionäre der Fonds Direkt Sicav werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der aktionäre eingeladen, die am <i>25. Februar 2015 um 11.00 Uhr in 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

mit folgender Tagesordnung abgehalten wird:

<i>Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Wirtschaftsprüfers
2. Billigung der Bilanz zum 30. September 2014 sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das am 30. September

2014 abgelaufene Geschäftsjahr

3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder
4. Wahl oder Wiederwahl der Verwaltungsratsmitglieder und des Wirtschaftsprüfers bis zur nächsten Ordentlichen

Generalversammlung

5. Verwendung der Erträge
Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die ein-

fache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundlage für die Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der
Ordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gem. Art. 26 des Gesetzes vom 17. Dezember
2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot unterhalten, werden gebeten ihre Depotbank mit der Übersendung

einer Depotbestandsbescheinigung, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der Generalversammlung gesperrt gehalten
werden, an die Gesellschaft zu beauftragen. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum 20. Februar
2015 vorliegen.

Entsprechende Vertretungsvollmachten können bei der Domizilstelle der Fonds Direkt Sicav (DZ PRIVATBANK S.A.)

per Fax 00352/44903-4506 oder E-Mail directors-office@dz-privatbank.com angefordert werden.

Aktionäre oder deren Vertreter, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten sich bis spä-

testens 20. Februar 2015 anzumelden.

<i>Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2015017859/755/34.

Amster Property I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 179.036.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207600/9.
(140232695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

SA Contraste Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 46.569.

Les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014208545/11.
(140232596) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13587

L

U X E M B O U R G

Lux Prime Pension - Sepcav, Société d'Epargne-Pension à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 50, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 113.490.

La première Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Lux Prime Pension - SEPCAV tenue le 15 janvier

2015 n'ayant pas atteint le quorum de présence requis, le Conseil d'Administration a l'honneur d'inviter les actionnaires
à une

SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le <i>20 février 2015 à 8h30 au siège social, salle des Pas Perdus, 5ème étage, pour délibérer et voter sur

l'ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Dissolution et mise en liquidation de Lux Prime Pension - SEPCAV;
2. Nomination du(es) Liquidateur(s);
3. Détermination de la mission du(es) Liquidateur(s);
4. Rémunération du(es) Liquidateur(s);
5. Approbation du transfert du produit de liquidation vers un autre support juridique (assurance de groupe) que le

Cotisant mettra en place au profit des affiliés et bénéficiaires conformément à l'article 15 du Règlement de Pension;

6. Détermination de la date et de l'ordre du jour de la deuxième assemblée générale des actionnaires appelée à clore

la liquidation de Lux Prime Pension - SEPCAV;

7. Divers.
Cette Assemblée ne sera plus soumise à aucune condition de quorum et les résolutions devront réunir au moins trois

quarts des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les actionnaires peuvent voter en personne ou par procuration.
Les actionnaires seront admis à l'assemblée sur justification de leur identité. Pour permettre une bonne organisation

de l'assemblée, les actionnaires peuvent faire connaître leur intention de prendre part à celle-ci avant le jour de sa tenue
à : BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg, Funds Domiciliation, Mme Valérie Letellier.

Les actionnaires qui ne pourraient pas assister à cette Assemblée ou se faire autrement représenter sont priés de

compléter et de signer la procuration disponible sur demande au siège social de la Société et de la retourner dûment
complétée  à  l'adresse  suivante  :  BNP  Paribas  Securities  Services,  Succursale  de  Luxembourg,  Funds  Domiciliation,  à
l'attention de Mme Valérie Letellier, 33 rue de Gasperich, L-5826 HESPERANGE . Les procurations données en vue de
la première Assemblée Générale Extraordinaire du 15 janvier 2015 restent valables pour l'Assemblée du 20 février 2015
reconvoquée.

<i>Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015008605/755/35.

Automation Conveyor Systems S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9119 Schieren, 2, rue du Castel.

R.C.S. Luxembourg B 104.102.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207627/10.
(140232034) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

RSF Europe, Société Anonyme.

Siège social: L-7471 Saeul, 10B, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 58.369.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208505/9.
(140233315) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13588

L

U X E M B O U R G

BPER International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.517.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF THE SUB-FUND

BPER International SICAV - Equity Europe (the "Sub-Fund")

The shareholders of the Sub-Fund are hereby informed that the board of directors of the Company (the "Board of

Directors") has decided to update the characteristics of the Sub-Fund as follows:

Current version

Next version

Profile of the typical in-
vestor

The Sub-Fund is suitable for investors wanting
to invest in a broadly diversified equity portfolio.

The Sub-Fund is suitable for investors who wish
to invest in an actively managed portfolio of sha-
res in European companies and are prepared to
accept the risks inherent in shares.

Investment policy

The aim of this Sub-Fund is to invest primarily in
stocks of leading European companies which ha-
ve a powerful market position in their specific
area of activity and have a strong capitalisation.
The Sub-Fund will invest primarily in companies
located in European countries excluded Eastern
Europe countries. Moreover the Sub-Fund will
favour companies with a long-term strategy to
increase profitability. This Sub-Fund may hold li-
quidities on an ancillary basis.

The Sub-Fund invests at least 70% of its assets
in equities and other equity shares of companies
domiciled or chiefly active in Europe. As part of
this investment, the Sub-Fund may invest direct-
ly or indirectly (i.e. in open-ended investment
funds and in line with the investment restrictions
of 10% of the net assets, as set out in the general
investment policy) in European small and/or mid
caps. In accordance with Article 18, investment
guidelines, chapter "Special techniques and ins-
truments relating to transferable securities and
money market instruments", the Sub-Fund is
permitted to use index futures to raise or redu-
ce its market exposure.

According to the above mentioned updating, the Sub-Fund will be renamed "BPER International SICAV - Equity Europe

Opportunity".

In addition, the Board of Directors has decided to increase the flat fee of the Sub-Fund from 1.90% p.a. to 2.05% p.a. .
Shareholders of the Sub-Fund who do not agree with the changes indicated above may redeem their shares free of

charge (excluding any local taxes) during a one month period from the date of this notice.

The effectiveness date of the above mentioned changes will be the 13 March 2015.
The above mentioned changes shall be reflected in the Prospectus dated March 2015 available at the administrative

address of the Company, 33A avenue J.F. Kennedy, L- 1855 Luxembourg.

Luxembourg, 4 February 2015.

<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2015017856/755/39.

Adran S.A, Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 107.451.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 12 décembre 2014

Est nommé administrateur de catégorie B:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L - 1653

Luxembourg, en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire ce jour.

Monsieur Marc ALBERTUS continuera le mandat de l'administrateur démissionnaire jusqu'à la prochaine assemblée

générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2017.

Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 12 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206657/15.
(140230700) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

13589

L

U X E M B O U R G

Anci sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4011 Esch-sur-Alzette, 97, rue de l'Alzette.

R.C.S. Luxembourg B 174.292.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207604/10.
(140233025) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Athena Private Equity 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1510 Luxembourg, 38-40, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 136.914.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extraits des résolutions prises lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 29 Décembre 2014

1. L'assemblée, après avoir pris connaissance du rapport du commissaire à la liquidation, approuve à l'unanimité le

rapport du liquidateur ainsi que les comptes de liquidation.

2. L'assemblée donne à l'unanimité décharge pleine et entière au liquidateur, au commissaire à la liquidation et aux

administrateurs.

3. L'assemblée prononce la clôture de la liquidation de la société.
4. L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq ans

au moins à l'adresse: L - 1510 Luxembourg, 38-40, Avenue de la Faïencerie (auprès de la société «Fideco S.A.»)

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Fideco S.A.

Référence de publication: 2014207623/18.
(140233409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Auberge Petite Suisse S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6310 Beaufort, 11, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 101.174.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207626/10.
(140232036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Elbblick (Juliet) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 127.089.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

En date du 19 décembre 2014 l'associé unique a pris les décisions suivantes:
- Prononce la clôture de la liquidation et constate que la Société a définitivement cessé d'exister à dater du 19 décembre

2014;

- Décide que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir

du 19 décembre 2014 au 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206859/16.
(140231502) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

13590

L

U X E M B O U R G

White House S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8080 Bertrange, 57, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 91.637.

EXTRAIT

Il résulte du procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, tenue en date du

15 décembre 2014 que:

L'assemblée a décidé de nommer en qualité de dépositaire professionnel en charge de la tenue du registre des actions:
- Monsieur PHONG Daniel, jurisconsulte, né le 5 juin 1970 à Vientiane (LAOS), demeurant professionnellement à

L-1143 Luxembourg, 2 rue Astrid,

<i>Pour la société
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014206594/16.
(140229295) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Tonnerre Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach.

R.C.S. Luxembourg B 175.365.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207447/10.
(140231811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Ariodante, Société Anonyme.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 57.116.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'Assemblée Générale Statutaire du 28 mars 2014

- La cooptation de Monsieur Fabrice CAURLA, expert-comptable, né le 04 février 1983 à Esch-sur-Alzette (L), de-

meurant au 3, rue Emile Eischen à L-4107 Esch-sur-Alzette, en tant qu'Administrateur en remplacement de Monsieur
Alain VASSEUR, démissionnaire, est ratifiée. Son mandat viendra à échéance à l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

- La société HIFIN S.A., société anonyme, inscrite auprès du registre de commerce de Luxembourg sous le n° B 49

454 et ayant son siège social à L-1413 Luxembourg, 3, Place Dargent est nommé en tant que nouveau Commissaire aux
Comptes en remplacement de la société TRIPLE A CONSULTING, démissionnaire. Son mandat viendra à échéance à
l'Assemblée Générale Statutaire de 2018.

Certifié sincère et conforme
ARIODANTE

Référence de publication: 2014207613/17.
(140233008) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Sol-Line S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8140 Bridel, 88C, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 120.065.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2015000633/11.
(140235515) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

13591

L

U X E M B O U R G

Aquarelle Germany S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 3A, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 158.633.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207554/10.
(140232254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Surf International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 47.010.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration en date du 22 décembre 2014

Est nommé administrateur en remplacement de Monsieur Luc HANSEN, administrateur démissionnaire:
- Monsieur Marc ALBERTUS, employé privé, demeurant professionnellement au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653

Luxembourg.

Monsieur Marc ALBERTUS terminera le mandat de l'administrateur démissionnaire qui viendra à échéance lors de la

prochaine assemblée générale ordinaire.

Cette cooptation sera soumise à ratification par la prochaine assemblée générale.
Pour extrait conforme.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207412/16.
(140231317) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Babouille, s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8017 Strassen, 18, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 87.980.

EXTRAIT

1) CESSION DE PARTS SOCIALES
En date du 22 décembre 2014 la société accepte les cessions de parts sociales suivantes:
Madame BOULOGNE Christine, née le 1 

er

 décembre 1963 à Longwy, France, demeurant à F-54350 Mont-Saint-

Martin, 37 B, rue du Fond de Piedmont cède:

CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales qu'elle détient,
à
Harry &amp; Cie, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, constituée le 16 octobre 2014, immatriculée

au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B191615, avec pour siège social à L-4031 Esch-
Sur-Alzette, 39, Rue Zénon Bernard, représentée par sa gérante Madame Sarah De Sa, née le 10 avril 1989 à Thionville
(F), domiciliée à L-4031 Esch-Sur-Alzette, 39, Rue Zénon Bernard

Suite à cette cession de parts, les parts sociales sont réparties comme suit:

1.- Harry &amp; Cie, prénommée,
CENT QUATRE VINGT SIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
TOTAL: CENT QUATRE VINGT SIX PARTS SOCIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

2) L'associé unique accepte la démission de la gérante Madame BOULOGNE Christine, née le 1 

er

 décembre 1963 à

Longwy, France, demeurant à F-54350 Mont-Saint-Martin, 37 B, rue du Fond de Piedmont

3) L'associé unique nomme comme nouvelle gérante avec effet au 22 décembre 2014 pour une durée indéterminée

Madame Sarah De Sa, née le 10 avril 1989 à Thionville (F), domiciliée à L-4031 Esch-Sur-Alzette, 39, Rue Zénon Bernard.
La société est valablement engagée par la seule signature de la gérante unique, Madame DE SA Sarah.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014206720/28.
(140231686) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

13592

L

U X E M B O U R G

Bedworth S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3364 Leudelange, 5, rue du Château d'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 181.325.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207656/10.
(140232277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Parc Faïence S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 3B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 78.018.

Les comptes annuels au 15 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207282/10.
(140231085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés SICAF/SIF, Société Anonyme sous la forme

d'une SICAF - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1840 Luxembourg, 40, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 4.367.

<i>Extrait des résolutions prises par le conseil d'administration du 4 décembre 2014:

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration coopte en tant que nouvel administrateur sous réserve de l'ap-

probation de la Commission de Surveillance du Secteur Financier:

- Monsieur Christoph PIEL, avec adresse professionnelle au 40, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg,
Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre

2014.

COMPAGNIE FINANCIERE DE GESTION LUXEMBOURG S.A.
40, Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg

Référence de publication: 2014207713/17.
(140233282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Argopal Real Estate S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 171.682.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 décembre 2014, l'associé unique a décidé de prononcer la

clôture de ta liquidation de la Société

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une

durée de cinq ans à l'adresse suivante:

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

FIDES (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014207561/17.
(140233275) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13593

L

U X E M B O U R G

Cardoso S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-6868 Wecker, 61B, Duchscherstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 97.476.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014207733/10.
(140232454) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

CD&amp;R Osprey Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 22.538,85.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 150.417.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207737/10.
(140232567) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2611 Luxembourg, 51, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 162.192.

Les comptes annuels audités au 31/12/2013 de la société CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l, Société ano-

nyme de droit luxembourgeois, ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014207747/10.
(140233518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Aberdeen Global II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1246 Luxembourg, 2B, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 136.363.

EXTRAIT

En date du 21 novembre 2014, l'assemblée générale annuelle de la Société a réélu:
1. comme membres du conseil d'administration de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui

se tiendra en l'année 2015:

- Monsieur Martin Gilbert
- Monsieur Christopher Little
- Monsieur David van der Stoep
- Monsieur Hugh Young
- Monsieur Bob Hutcheson
- Madame Soraya Hashimzai
- Monsieur Lynn Birdsong
- Monsieur Ronaldo da Frota Nogueira
2. comme réviseur d'entreprises agréé-de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra

en l'année 2015:

- KPMG Audit S.à r.l., 9, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207566/24.
(140232651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13594

L

U X E M B O U R G

CAHVA, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 62, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 152.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 1 

er

 décembre 2014.

Rutsaert Legal
14 rue de Strassen
L-2555 Luxembourg
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014207726/14.
(140232316) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

CEE Urban Red SCA, SICAV-FIS, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds

d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 20, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 170.645.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue à Luxembourg le 23 décembre 2014

Il résulte des résolutions prises par les actionnaires de la Société en date du 23 décembre 2014 que:
1. les actionnaires ont décidé de clôturer la liquidation.
2. les actionnaires ont décidé que les documents et comptes de la Société seront déposés et conservés pour une durée

de cinq ans à partir de cette publication, au 121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 24 décembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014207742/18.
(140232282) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Blue Marine Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1212 Luxembourg, 3, rue des Bains.

R.C.S. Luxembourg B 178.529.

<i>Extrait du procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 15 décembre 2014

Les mandats de l’administrateur unique et du commissaire aux comptes étant échus, l’Assemblée décide de les re-

nouveler pour une période expirant à la date de l’Assemblée Générale Annuelle approuvant les comptes annuels au 31
décembre 2014, comme suit:

<i>Conseil d’Administration:

- Monsieur Ascanio MARTINOTTI, demeurant au 1, rue Jean Baptiste Weicker, L-5255 Sandweiler, administrateur

unique;

<i>Personne chargée du contrôle des comptes:

- DIMEST S.A., ayant son siège social au 3, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, RCS Luxembourg B 176.670, commissaire

aux comptes.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

<i>Pour la Société

Référence de publication: 2014207643/20.
(140233258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

13595

L

U X E M B O U R G

VPC Luxembourg, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op der Haart.

R.C.S. Luxembourg B 172.513.

Les comptes annuels arrêtés au 31/12/13 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

VPC Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée

Référence de publication: 2015000690/12.
(140235086) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

BPER International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.517.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF SUB-FUNDS BPER INTERNATIONAL SICAV - EQUITY ASIA PA-
CIFIC, BPER INTERNATIONAL SICAV - EQUITY EASTERN EUROPE AND BPER INTERNATIONAL

SICAV - EQUITY EMERGING MARKETS

The board of directors of the Company (the "Board of Directors") has decided, in compliance with Article 1 (20)a)

and Chapter 8 of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"),
to effect a merger by absorption (the "Merger") as of 13 March 2015 (the "Effective Date") of the sub-funds "BPER
International SICAV - Equity Asia Pacific" and BPER International SICAV - Equity Eastern Europe" (the "absorbed Sub-
Funds") into sub-fund "BPER International SICAV - Equity Emerging Markets" to be renamed in "BPER International SICAV
- Emerging Markets - Multi Asset Dividend" (the "absorbing Sub-Fund").

General information
With effect as of the Effective Date, all of the assets and liabilities of the absorbed Sub-Funds will be transferred into

the absorbing Sub-Fund and the absorbed Sub-Funds will cease to exist.

The Merger shall become effective and final between the merging sub-funds and vis-à-vis third parties as from the

Effective Date.

Rationale for the Merger
The Merger is intended to proceed to an economical rationalization, to realize synergetic effects and to improve the

operating efficiency of the absorbed Sub-Funds through capital growth and thereby reduce costs to investors.

Impact of the Merger on the shareholders
The number of shares of the absorbing Sub-Fund to be issued will be determined on the Effective Date on the net

asset values of the respective classes of the absorbed Sub-Funds as per 12 March 2015.

The Merger does not have any impact on the tax treatment of the shareholders.

Shares of the share classes of the absorbed Sub-Funds will be converted into shares of the following share class of the

absorbing Sub-Fund:

BPER International SICAV - Equity Asia Pacific (ab-

sorbed Sub-Fund)

BPER International SICAV - Equity Emerging Mar-
kets to be renamed in BPER International SICAV -

Emerging Markets - Multi Asset Dividend (absorbing

Sub-Fund)

Class P

Class P-dist

BPER International SICAV - Equity Eastern Europe

(absorbed Sub-Fund)

BPER International SICAV - Equity Emerging Mar-
kets to be renamed in BPER International SICAV -

Emerging Markets - Multi Asset Dividend (absorbing

Sub-Fund)

Class P

Class P-dist

Such conversions will be effected at the respective conversion rates determined on the Effective Date. Fractional shares

will be issued up to three (3) decimals.

Shareholders of the absorbed Sub-Funds and of the absorbing Sub-Fund who do not agree with the Merger or with

the changes mentioned in this notice to shareholders may request the redemption of all or a part of their shares at the
applicable net asset value of the relevant shares of the absorbed Sub-Funds without any redemption charges (except for

13596

L

U X E M B O U R G

any transaction costs incurred by the absorbed Sub-Funds in effecting redemptions and for any local taxes during the
thirty (30) calendar days following the date of publication of this notice to shareholders). This right will expire five (5)
business days before the date of calculation of the respective share conversion rates. The Merger will be binding on the
remaining investors in the absorbed Sub-Fund after this deadline. After this deadline, it will be allowed to deviate from
the investment policies of the absorbed Sub-Funds as far as needed in order to align their portfolios with the investment
policy of the absorbing Sub-Fund. The following table illustrates the main differences between the merging sub-funds:

BPER International SICAV - Equity Asia Pacific (ab-

sorbed Sub-Fund)

BPER International SICAV - Equity Emerging Mar-
kets to be renamed in BPER International SICAV -

Emerging Markets - Multi Asset Dividend (absorbing

Sub-Fund)

Profile of the typical investor:
Suitability for investors wanting to invest in a broadly diver-
sified equity portfolio.

Profile of the typical investor:
Suitability for investors who focus on income generation and
prefer a broad diversification over different asset classes in
emerging markets. The investors have a long-term invest-
ment horizon and are willing to accept the risk associated
with investments in emerging markets.

Investment Policy:
The absorbed Sub-Fund invests mainly in the equity markets
of Japan, Hong Kong (China), Singapore, Korea and Australia.
In addition, the absorbed Sub-Fund can invest in other
Emerging Asian equity markets, such as, for example Thai-
land and Malaysia.
The absorbed Sub-Fund may hold liquidities on an ancillary
basis.

Investment Policy:
The objective of the absorbing Sub-Fund is the combination
of investments in different asset classes with focus on Emerg-
ing Markets in such a way that the portfolio generates high
income (e.g. dividends, interest payments, payment streams
from derivatives).
To achieve this objective, the absorbing Sub-Fund could in-
vest in traditional asset classes such as equities and bonds as
well as, within the framework of legally permissible instru-
ments, in non-traditional asset classes, focusing for instance
on real estate (e.g. in the form of closed-ended Real Estate
Investment Trusts), infrastructure or commodities.
The absorbing Sub-Fund may furthermore invest up to 100%
of its net assets in UCITS and 30% in other UCI. The ab-
sorbing Sub-Fund may also invest in all legally permissible
instruments, thereby making use of derivative financial ins-
truments, which can be used for hedging purposes and/or
for participation in the anticipated market development.
Furthermore, the absorbing Sub-Fund may invest parts of its
assets through participation in the performance of commo-
dities indices or commodities sub-indices. In doing so, the
absorbing Sub-Fund may enter into swap transactions on the
indices/sub-indices.
The absorbing Sub-Fund may also invest in Exchange Traded
Funds ("ETFs") on commodities indices and sub-indices,
which themselves make use of the previously mentioned
swaps to generate commodities exposure.

Relevant share class:
Class P

Relevant share class:
Class P-dist

Distribution policy:
Accumulating

Distribution policy:
Distribution

Accounting currency:
USD

Accounting currency:
EUR

Fees:
Flat Fee (for the administrative agent, the custodian, the
portfolio manager(s) and the distributor(s)) of maximum
2.000% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.

Fees:
Flat Fee (for the administrative agent, the custodian, the
portfolio manager(s) and the distributor(s)) of maximum
2.100% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.
Please be informed that the Flat Fee (for the administrative
agent, the custodian, the portfolio manager(s) and the dis-
tributor(s)) for the absorbing Sub-Fund has been increased
from 2.000% p.a. calculated daily on the average total net
assets of the respective class during the month concerned
to the abovementioned 2.100% p.a.

13597

L

U X E M B O U R G

BPER International SICAV - Equity Eastern Europe

(absorbed Sub-Fund) (absorbed Sub-Fund)

BPER International SICAV - Equity Emerging Mar-
kets to be renamed in BPER International SICAV -

Emerging Markets - Multi Asset Dividend (absorbing

Sub-Fund)

Profile of the typical investor:
Suitability for investors wanting to invest in a broadly diver-
sified equity portfolio, including investments in Russia.

Profile of the typical investor:
Suitability for investors wanting to focus on income genera-
tion and prefer a broad diversification over different asset
classes in emerging markets. The investors have a long-term
investment horizon and are willing to accept the risk asso-
ciated with investments in emerging markets.

Investment Policy:
The aim of the absorbed Sub-Fund is to invest primarily in
stocks and other equity shares of companies domiciled in
Eastern Europe Countries or which are chiefly active in these
markets.
In addition, the absorbed Sub-Fund is authorized to invest
on an ancillary basis in the equity markets of countries in the
western part of Europe.
The absorbed Sub-Fund may invest to a lesser extent of its
net assets in closed-end undertakings for collective invest-
ments (UCI), in addition to its investments in open-ended
UCIs.
The absorbed Sub-Fund may also invest in securities listed
on the RTS Stock Exchange, on the Moscow Interbank Cur-
rency Exchange and on other regulated markets in Russia
which would further be recognized as such by the Luxem-
bourg authority.
The absorbed Sub-Fund may hold liquidities on an ancillary
basis.

Investment Policy:
The objective of the absorbing Sub-Fund is the combination
of investments in different asset classes with focus on Emerg-
ing Markets in such a way that the portfolio generates high
income (e.g. dividends, interest payments, payment streams
from derivatives).
To achieve this objective, the absorbing Sub-Fund could in-
vest in traditional asset classes such as equities and bonds as
well as, within the framework of legally permissible instru-
ments, in non-traditional asset classes, focusing for instance
on real estate (e.g. in the form of closed-ended Real Estate
Investment Trusts), infrastructure or commodities.
The absorbing Sub-Fund may furthermore invest up to 100%
of its net assets in UCITS and 30% in other UCI. The ab-
sorbing Sub-Fund may also invest in all legally permissible
instruments, thereby making use of derivative financial ins-
truments, which can be used for hedging purposes and/or
for participation in the anticipated market development.
Furthermore, the absorbing Sub-Fund may invest parts of its
assets through participation in the performance of commo-
dities indices or commodities sub-indices. In doing so, the
absorbing Sub-Fund may enter into swap transactions on the
indices/sub-indices.
The absorbing Sub-Fund may also invest in Exchange Traded
Funds ("ETFs") on commodities indices and sub-indices,
which themselves make use of the previously mentioned
swaps to generate commodities exposure.

Relevant share class:
Class P

Relevant share class:
Class P-dist

Distribution policy:
Accumulating

Distribution policy:
Distribution

Fees:
Flat Fee (for the administrative agent, the custodian, the
portfolio manager(s) and the distributor(s)) of maximum
2.200% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.

Fees:
Flat Fee (for the administrative agent, the custodian, the
portfolio manager(s) and the distributor(s)) of maximum
2.100% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.
Please be informed that the Flat Fee (for the administrative
agent, the custodian, the portfolio manager(s) and the dis-
tributor(s)) for the absorbing Sub-Fund has been increased
from 2.000% p.a. calculated daily on the average total net
assets of the respective class during the month concerned
to the abovementioned 2.100% p.a.

Specific rights of the shareholders in respect of the Merger

<i>Redemption and conversion of shares

The issue of shares of the absorbed Sub-Funds will cease on 4 February 2015 (including). Hence, applications for

subscriptions may be submitted to the absorbed Sub-Funds in Luxembourg, at UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., as
administrative agent of the Company, through 3 February 2015, 4 p.m. The last day for redemption of shares of the
absorbed Sub-Funds will be on 6 March 2015, which means that investors may apply for redemption in Luxembourg, at
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., as administrative agent of the Company, through 6 March 2015, 4 p.m.

13598

L

U X E M B O U R G

The  absorbed  Sub-Funds'  investors  who  have  not  proceeded  with  the  redemption  of  their  shares  by  the  above-

mentioned deadline will have their shares of the absorbed Sub-Funds converted into shares of the share class as mentioned
above of the absorbing Sub-Fund at the respective share class conversion rates determined on the effective date of the
Merger. No subscription fee will be levied by the absorbing Sub-Funds on the conversion of shares.

<i>Calculation method of the share class conversion rates
The conversion rates between shares of the absorbed Sub-Funds and shares of the absorbing Sub-Fund will be calcu-

lated on the basis of the net asset values of the respective share classes of the absorbed Sub-Fund on the Effective Date.
The net asset values as of 12 March 2015 will be verified and approved by the independent auditor of the absorbed Sub-
Funds.

<i>Valuation of the assets
For purposes of determining the share class conversion rates, the assets and liabilities of the absorbed Sub-Funds will

be evaluated in accordance with the provisions contained in the prospectus of the Company.

<i>Costs of the Merger
Any fees relating to the preparation and implementation of the Merger will be borne by the absorbed Sub-Funds. Such

costs will not be included in the calculation of the net asset values of the absorbed Sub-Funds. Any legal, advisory or
administrative costs associated with the preparation and the completion of the Merger will not be charged to the absorbed
Sub-Funds or to the absorbing Sub-Fund or to their respective shareholders.

<i>Report of the auditor
Pursuant to Article 71 of the 2010 Law, the Company will appoint for the absorbed Sub-Fund its current independent

auditor, Deloitte S.A. The latter will verify the criteria adopted for the valuation of the assets and liabilities, the calculation
method of the share class conversion rates as well as the actual conversion rates on the date the respective share class
conversion rates are determined. A copy of the auditor's report will be made available to the shareholders at the regis-
tered office of the Company, on demand and without charge.

<i>Custodian
The letter of acknowledgement according to Article 70 of the 2010 Law of the custodian bank of the may be consulted

during usual business opening hours at the registered office of the Company.

Implementation and effective date of Merger
With effect as of the Effective Date, the Merger will result in the shareholders of the absorbed Sub-Funds becoming

shareholders of the absorbing Sub-Fund. Instead of shares in the absorbed Sub-Funds, they will hold shares of the absorbing
Sub-Fund.

The shareholders of the absorbed Sub-Funds and of the absorbing Sub-Fund may request the redemption of their

shares in Luxembourg, at UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., as administrative agent of the Company, through 6 March
2015, 4 p.m. The redemption of shares will be free of any charges for the shareholders of the absorbed Sub-Funds (except
for any transaction costs and any local taxes).

With effect as of the Effective Date, the absorbed Sub-Funds will cease to exist. The net asset value of the absorbed

Sub-Funds will be calculated and published for the last time as per 12 March 2015.

The Merger has been approved by the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF").

The absorbing Sub-Fund shall be reflected in an updated version of the prospectus of the Company to be dated March

2015. Such prospectus, as well the last annual and semi-annual reports of the Company will be available at its registered
office.

The shareholders of the absorbed Sub-Funds and of the absorbing Sub-Fund shall be advised of the fact that an up-to-

date version of the key investor information documents (KIIDs) and any relevant documentation of the absorbing Sub-
Fund will be available free of charge at the Company´s registered office as well as on the following homepage: www.bper.it.,
at section "Privati e Famiglie - Investimenti". Investors of the absorbed Sub-Funds and of the absorbing Sub-Fund are
invited to take knowledge of such KIIDs in order to be aware of the consequence due to the Merger.

Luxembourg, 4 February 2015

<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2015017857/755/221.

Chamborant S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2225 Luxembourg, 22, rue Général Major Lunsford Oliver.

R.C.S. Luxembourg B 169.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

13599

L

U X E M B O U R G

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 juillet 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014207750/10.
(140232359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Digital Services XXX S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 15.001,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 188.474.

In the year two thousand and fourteen, on the seventh day of November.
before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a joint stock corporation (Aktiengesellschaft) under the

laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany (hereinafter “Rocket”),

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) shares, and becoming the holder of four hundred

seventeen (417) series A shares,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Berlin, Germany, on 3 November 2014;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) under

the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister)
at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 126893 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of one (1) share,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Berlin, Germany, on 3 November 2014;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft) under the laws

of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at the
local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business address at Kaiserstraße
14b, 80801 Munich, Germany (hereinafter “Holtzbrinck”), represented by its general partner, HV Holtzbrinck Ventures
Holding GmbH, a limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) existing under the laws of Germany,
registered with the commercial register at the local court of München, Germany, under no. HRB 185098 B, having its
registered address at Kaiserstraße 14 b, 80801 München, Germany,

becoming the holder of two thousand eighty-four (2,084) series A shares,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, Avocat, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given

in Munich, Germany, on 3 November 2014.

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XXX S.à r.l. (the “Com-

pany”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 188.474 and
incorporated pursuant to a deed of the notary Carlo Wersandt, residing in Luxembourg, on 18 June 2014, published in
the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 2514 dated 17 September 2014. The articles of association
have not been amended since.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby Holtzbrinck
participates and votes for the purpose of Agenda point 5 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) additional class of shares, so that the Company will hence have two (2) classes of shares,

divided into common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A shares (hereinafter “Series A Shares”).

2. Decision to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares, with a nominal value of one euro

(EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a nominal value of one euro (EUR 1)
each.

13600

L

U X E M B O U R G

3. Acceptance of HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership (Kommanditgesellschaft)

under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the commercial register (Han-
delsregister) at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA 98863, having its business
address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.

4. Increase of the Company's share capital by an amount of two thousand five hundred one euro (EUR 2,501) so as

to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to fifteen thousand one euro
(EUR 15,001) by issuing two thousand five hundred one (2,501) Series A Shares with a nominal value of one euro (EUR
1) each.

5. Subsequent amendment of article five (5) of the articles of association of the Company so that it shall henceforth

read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand and one Euros (EUR 15,001.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A shares (hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares

hereinafter also referred to as “Preferred Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

6. Full restatement of the articles of association of the Company so that they shall henceforth read as follows:

“A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XXX S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-

13601

L

U X E M B O U R G

traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand and one Euros (EUR 15,001.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A shares (hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares

hereinafter also referred to as “Preferred Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.
6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

(“Rocket”) and the shareholder HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG (“Holtzbrinck”, jointly with Rocket
the “Investors” and each also an “Investor”) to a company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15
et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder or partner, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by
means of a contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the ma-
nagement and policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the
respective Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50 % in any surviving legal entity after such transformation
procedure.

7.5 In the cases provided for in art. 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights of

first refusal, rights of pre-emption or tagalong rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

13602

L

U X E M B O U R G

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,

13603

L

U X E M B O U R G

each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority.

Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:

13604

L

U X E M B O U R G

16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners.

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining managers  until the  next  meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

13605

L

U X E M B O U R G

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the advisory board for the legal transactions and measures specified

below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the advisory board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.7 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;

21.8.8 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the advisory board. The advisory board may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.
21.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 21 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of

13606

L

U X E M B O U R G

managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders may by

way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the advisory board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a unanimous

shareholders' consent.

24.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 Four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by Rocket in its sole discretion; and
24.3.2 One (1) voting member of the advisory board shall be nominated by Holtzbrinck in its sole discretion.
24.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
24.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self-organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

24.6 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

13607

L

U X E M B O U R G

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

7. Subsequently, decision to appoint any manager of the Company, regardless of his category, each acting individually

and with full power of substitution, to update solely, the shareholders register of the Company.

8. Miscellaneous.
Having duly considered each item on the agenda, the general meeting unanimously takes, and requires the undersigned

notary to enact, the following resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) additional class of shares, so that the Company will

hence have two (2) classes of shares, divided into common shares (hereinafter “Common Shares”) and series A shares
(hereinafter “Series A Shares”).

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to convert the existing twelve thousand five hundred (12,500) shares,

with a nominal value of one euro (EUR 1) each, into twelve thousand five hundred (12,500) Common Shares, with a
nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders accepts HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, a limited partnership

(Kommanditgesellschaft) under the laws of Germany with its statutory seat in Munich, Germany, registered with the
commercial register (Handelsregister) at the local court of Munich (Amtsgericht München), Germany, under no. HRA
98863, having its business address at Kaiserstraße 14b, 80801 Munich, Germany, as new shareholder of the Company.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the Company's share capital by an amount of two thousand

five hundred one euro (EUR 2,501) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR
12,500) up to fifteen thousand one euro (EUR 15,001) by issuing two thousand five hundred one (2,501) Series A Shares
with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

Two thousand five hundred one (2,501) Series A Shares have been duly subscribed as follows:
- Four hundred seventeen (417) Series A Shares have been duly subscribed by Rocket, prenamed, here represented

as aforementioned, for the price of four hundred seventeen euro (EUR 417);

- Two thousand eighty-four (2,084) Series A Shares have been duly subscribed by Holtzbrinck, prenamed, here re-

presented as aforementioned, for the price of two thousand eighty-four euro (EUR 2,084).

13608

L

U X E M B O U R G

<i>Payment

The two thousand five hundred one (2,501) Series A Shares subscribed by Rocket and Holtzbrinck, aforementioned,

have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount of two thousand five hundred one euro (EUR
2,501).

The amount of two thousand five hundred and one Euro (EUR 2,501.-) is as now available to the Company as has been

proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of two thousand five hundred one euro (EUR 2,501) is entirely allocated to the share

capital.

<i>Fifth resolution

The general meeting of shareholders acknowledges that Holtzbrinck has now become holder of two thousand eighty-

four (2,084) series A shares.

As a consequence Holtzbrinck, entitled to vote and here represented by Philippe Sylvestre, Avocat, professionally

residing in Luxembourg, by virtue of the aforementioned proxy, joins the general meeting of shareholders for purpose
of the following resolutions

The general meeting of shareholders resolves the amendment of article five (5) of the articles of association of the

Company so that it shall now henceforth read as follows:

“ Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at fifteen thousand and one Euros (EUR 15,001.00), represented by:
5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 two thousand five hundred one (2,501) series A shares (hereinafter “Series A Shares”, the Series A Shares

hereinafter also referred to as “Preferred Shares”), with a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.”

<i>Sixth Resolution

Inter alia as a result of the foregoing, the general meeting of shareholders resolves to fully restate the articles of

association of the Company which shall henceforth read as set out in the agenda of the present deed.

<i>Seventh Resolution

The general meeting of shareholders hereby appoints any manager of the Company, regardless of his category, each

acting individually and with full power of substitution, to update solely, the shareholders register of the Company.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,000.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing party and
in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am siebten November.
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg.

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht

mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  Berlin,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,
(„Rocket“),

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Anteilen und zukünftiger Inhaber von vierhundertsieb-

zehn (417) Anteilen der Serie A,

13609

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 3.

November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht mit

satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutsch-
land, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber eines (1) Anteils,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 3.

November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3. HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditgesellschaft nach deutschem Recht mit sat-

zungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München, Deutschland,
unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland („Holtzbrinck“),
vertreten durch ihren unbeschränkt haftenden Gesellschafter (general patner), HV Holtzbrinck Ventures Holding GmbH,
einer  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  bestehend  unter  deutschem  Recht,  eingetragen  im  Handelsregister  des
Amtsgerichts München, Deutschland, unter der Nummer HRB 185098 B, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801
München, Deutschland,

zukünftiger Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, Avocat, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht vom 3.

November 2014, ausgestellt in München, Deutschland.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services XXX S.à r.l. (die

„Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend
unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 188.474, gegründet am 18. Juni 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Carlo Wersandt, mit Amtssitz in
Luxemburg, welche am 17. September 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 2514, ver-
öffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei Holtzbrinck ausschließlich für die Punkte 5 ff. der Tagesordnung teilnahme-
und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) weiteren Anteilsklasse, wodurch nunmehr insgesamt zwei (2) Anteilsk-

lassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“) und Anteile der Serie A (die „Anteile der Serie A“).

2. Beschluss bezüglich der Umwandlung der bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nomi-

nalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1).

3. Aufnahme von HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, einer Kommanditgesellschaft nach deutschem

Recht mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München,
Deutschland, unter der Nummer HRA 98863, mit Geschäftssitz in Kaiserstraße 14b, 80801 München, Deutschland, als
neuer Gesellschafter der Gesellschaft.

4. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von zweitausendfünfhunderteins Euro (EUR 2.501) auf einen Betrag von fünfzehn-
tausendeins Euro (EUR 15.001) durch die Ausgabe von zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A mit
einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

5. Anschließende Änderung des Artikels fünf (5) der Satzung der Gesellschaft, welcher nunmehr wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendeins Euro (EUR 15.001,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als

„Vorzugsanteile“ bezeichnet werden) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

6. Gänzliche Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

13610

L

U X E M B O U R G

„A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XXX S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigen Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf
sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendeins Euro (EUR 15.001,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als

„Vorzugsanteile“ bezeichnet werden) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

13611

L

U X E M B O U R G

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, die Insolvenz oder ein ver-

gleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern, die

drei Viertel des Gesellschaftskapitals halten (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestimmungen von
Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern, sofern vorhanden, insbesondere hinsichtlich Vorkaufsrech-
ten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaf-
tern übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Zustimmung zur Übertragung
von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“) und den Gesellschafter HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG („Holtzbrinck“,
gemeinschaftlich mit Rocket die „Investoren“ und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit einem solchen Investor
verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert“ oder „Kontrolliert Werden“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch
(a) die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter oder Partner, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile
oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige
Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das
Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor
oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn eine Qualifizierte Mehrheit einer solchen Übertragung zustimmt (wobei die Anteile des verstorbenen Gesellschaf-
ters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Anteile
an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben des verstor-
benen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

13612

L

U X E M B O U R G

8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichzahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag des Inkrafttretens gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung ist dieser Betrag von einem Wirt-

schaftsprüfer  in  der  Eigenschaft  als  Schiedsgutachter,  der  von  den  Gesellschaftern  gemeinschaftlich  ernannt  wird,
festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser auf Ersuchen eines
Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondissement) bestimmt. Die
Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der Gesellschaft und dem
ersuchenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende Teil mit dem Rück-
kaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen
Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann verlangen, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters der Gesellschaft) zu übertragen hat,
auch im Falle eines Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft
benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich EMail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-

13613

L

U X E M B O U R G

zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst wurden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an dem Ort und zu der Zeit statt, welche in

der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4 Jeder Gesellschafter ist dazu berechtigt, bei einer Gesellschafterversammlung von einem anderen durch eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
mit einer Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlungen wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterver-
sammlung anwesenden oder vertretenen Gesellschaftern zu unterzeichnen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.  Eine  Änderung  dieser  Satzung  erfordert  die  Zustimmung  (i)  einer  zahlenmäßigen

Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden.

Art. 16. Gesellschafterbeschlüsse, die eine bestimmte Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßige Mehrheit

der Gesellschafter, (ii) die auch eine Qualifizierte Mehrheit bilden:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss hinsichtlich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));
16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie

13614

L

U X E M B O U R G

Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern.

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese den Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Wahl, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt wer-
den, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie des Einverständnisses ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates
der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Ge-
schäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise ein Geschäftsführer sein muss und der
für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich, oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-

13615

L

U X E M B O U R G

onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann
seine Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreff-
enden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

21.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeinen Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtsverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft und (ii)
zwischen der Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere - einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.7 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.8 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die ggf. zwischen
den Gesellschaftern in einer Gesellschaftervereinbarung vereinbart wurde;

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf und zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforderlich,

so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesellschaf-
terversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung des
Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und Maß-
nahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafter können durch einen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

21.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 21, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, an welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, von dem Vorsitzenden pro tempore und dem Protokollführer (falls

13616

L

U X E M B O U R G

vorhanden), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Protokolle von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem (1) Geschäftsführer
der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge von einem (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einem
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern, wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsame
Unterschrift mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder
deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsame Unterschrift oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter

können durch einstimmige Zustimmung die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herab-
setzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung des Beirats nur durch einstimmige Zustimmung festlegen und/

oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem entsprechenden ernennenden Gesellschafter jedes

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 Vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von Rocket nach eigenem Ermessen ernannt; und
24.3.2 Ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von Holtzbrinck nach eigenem Ermessen ernannt.
24.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter haben.
24.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  hat  weitere  Bestimmungen,
insbesondere  hinsichtlich  der  Selbstorganisation  des  Beirats,  zu  enthalten.  Der  Beirat  fasst  Beschlüsse  mit  einfacher
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht auf ständige Überprüfung und Kontrolle aller Geschäfte

der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

13617

L

U X E M B O U R G

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen eine Aufstellung der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage verhältnismäßig herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Anforderungen und den Regelungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestim-

mungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Andwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter in der Zwischenzeit mit der Gesellschaft eingehen und
durch die bestimmte Regelungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Be-
stimmungen einer Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den
Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

7. Anschließender Beschluss, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner Kategorie, dazu zu

ermächtigen, das Anteilsinhaberregister in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur Unterbevollmäch-
tigung alleine zu aktualisieren.

8. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Beratung über jeden Tagesordnungspunkt fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die

folgenden Beschlüsse und ersucht den Notar, diese zu beurkunden:

<i>Erster Beschluss

Die  Gesellschafterversammlung  beschließt,  eine  (1)  weitere  Anteilsklasse  zu  schaffen,  wodurch  nunmehr  zwei  (2)

Anteilsklassen bestehen, aufgeteilt in Stammanteile (die „Stammanteile“) und Anteile der Serie A (die „Anteile der Serie
A“).

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, die bestehenden zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem No-

minalwert von je einem Euro (EUR 1) in zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteile mit einem Nominalwert von je
einem Euro (EUR 1) umzuwandeln.

13618

L

U X E M B O U R G

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung akzeptiert HV Holtzbrinck Ventures Fund V GmbH &amp; Co. KG, eine Kommanditge-

sellschaft nach deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts  München,  Deutschland,  unter  der  Nummer  HRA  98863,  mit  Geschäftssitz  in  Kaiserstraße  14b,  80801
München, Deutschland, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von zweitausendfünfhunderteins Euro (EUR 2.501) auf einen
Betrag von fünfzehntausendeins Euro (EUR 15.001) durch die Ausgabe von zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen
der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß wie folgt gezeichnet:
- Vierhundertsiebzehn (417) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß von Rocket, vorbenannt, hier vertreten wie

vorerwähnt, zu einem Preis von vierhundertsiebzehn Euro (EUR 417) gezeichnet;

- Zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß von Holtzbrinck, vorbenannt, hier

vertreten wie vorerwähnt, zu einem Preis von zweitausendvierundachtzig Euro (EUR 2.084) gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Rocket und Holtzbrinck, vorbenannt, gezeichneten zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteile der Serie A

wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von zweitausendfünfhunderteins Euro (EUR 2.501).

Die Summe von zweitausendfünfhunderteins Euro (EUR 2.501,-) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung, so

wie die dem Notar erbracht wurde.

Die Einlage in Höhe von zweitausendfünfhunderteins Euro (EUR 2.501) wird vollständig dem Gesellschaftskapital zu-

geführt.

<i>Fünfter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung erkennt an, dass Holtzbrinck nun Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) An-

teilen der Serie A geworden ist.

Demzufolge schließt sich Holtzbrinck, stimmberechtigt und hier vertreten durch Philippe Sylvestre, Avocat, geschäfts-

ansässig in Luxemburg, gemäß der vorbenannten Vollmacht, der Gesellschafterversammlung für die folgenden Beschlüsse
an.

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Artikel fünf (5) der Satzung der Gesellschaft zu ändern, welcher nunmehr

wie folgt lautet:

„ Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt fünfzehntausendeins Euro (EUR 15.001,00), bestehend aus:
5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1,00), und

5.1.2 zweitausendfünfhunderteins (2.501) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“, die im Folgenden auch als

„Vorzugsanteile“ bezeichnet werden) mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1,00).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.“

<i>Sechster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, unter anderem infolge des Vorstehenden, die gänzliche Neufassung der

Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie in der Tagesordnung der vorliegenden Urkunde dargestellt lautet.

<i>Siebter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt hiermit, jeden einzelnen Geschäftsführer der Gesellschaft, ungeachtet seiner

Kategorie, dazu zu ermächtigen, das Anteilsinhaberregister in Einzelunterschrift und mit uneingeschränkter Befugnis zur
Unterbevollmächtigung alleine zu aktualisieren.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.000,- geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg, am eingangs erwähnten Datum.

13619

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 12 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53225. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 30. Dezember 2014.

Référence de publication: 2015000832/1116.
(150000137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Finasset S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.961.

<i>Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale ordinaire du 19 mai 2014

- L'actionnaire unique ratifie la cooptation en tant qu'administrateur de Madame Fleur Ouzilou, employée privée, avec

adresse professionnelle 40, Avenue Monterey à L-2163 Luxembourg jusqu'à l'assemblée devant se tenir en 2014.

- L'actionnaire unique décide de nommer en tant qu'administrateurs Monsieur Cyrille Vallée, employé privé, avec

adresse  professionnelle  40,  avenue  Monterey  à  L-2163  Luxembourg,  Monsieur  Riccardo  Incani,  employé  privé,  avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg et Monsieur Gilles Jacquet, employé privé, avec
adresse professionnelle 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg, Ces mandats se termineront lors de l’assemblée
devant se tenir en 2020.

- L’actionnaire unique décide de renouveler le mandat de commissaire aux comptes la société CO-VENTURES S.A.,

ayant son siège social 40, avenue Monterey à L-2163 Luxembourg. Son mandat se terminera lors de l'assemblée qui
statuera sur les comptes de l'exercice 2020.

Luxembourg, le 19 mai 2014.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014209115/22.
(140234400) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Crisalid Luxembourg SA, Société Anonyme.

Capital social: EUR 31.000,00.

Siège social: L-5635 Mondorf-les-Bains, 10, avenue Marie - Adelaïde.

R.C.S. Luxembourg B 139.780.

L'an deux mille quatorze, le vingt-quatrième jour du mois de décembre.
Par devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «CRISALID Luxembourg S.A.», ayant

son siège social à L-3313 Bergem, 95, Grand-rue, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro B 139.780, constituée par-devant Maître Paul Decker, alors notaire de résidence à Luxem-
bourg, suivant acte reçu le 19 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1791 du 21
juillet 2008, et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés depuis sa constitution (la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Aude GRENOUILLET, employée privée, demeurant professionnellement à Lu-

xembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Anna-Maria GENCO, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

13620

L

U X E M B O U R G

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Anna-Maria GENCO, employée privée, demeurant professionnelle-

ment à Luxembourg.

Le bureau étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence signée par les mandataires des actionnaires
représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste de présence ainsi que les
procurations des actionnaires représentés, signées «ne varietur» par les membres du bureau comparants et le notaire
instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

II. Que toutes les mille (1.000) actions d'une valeur nominale de trente-et-un euros (EUR 31,-), représentant l'intégralité

du capital social, étant présentes ou représentées à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations
d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu
connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Transfert du siège social de L-3313 Bergem, 95, Grand-rue à L-5635 Mondorf-les-Bains, 10, avenue Marie-Adelaïde;
2. Modification subséquente de l'article 4 des statuts de la Société pour le mettre en concordance avec la résolution

qui précède;

3. Renouvellement des mandats des administrateurs actuels de la Société;
4. Renouvellement du mandat d'administrateur délégué actuel de la Société;
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, cette dernière prend à l'unanimité

des voix dans chaque catégorie d'actions les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de son adresse actuelle de L-3313 Bergem, 95,

Grand-rue à l'adresse suivante: L-5635 Mondorf-les-Bains, 10, avenue Marie-Adelaïde.

<i>Deuxième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec la résolution qui précède, l'assemblée générale décide de modifier

l'article 4 des statuts de la Société pour lui donner dorénavant la teneur suivante:

Art. 4. «Le siège de la Société est établi dans la commune de Mondorf-les-Bains.
Le siège social peut être transféré à tout autre endroit de la même commune par une décision du conseil d'adminis-

tration, et à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision des actionnaire(s) délibérant comme
en matière de modification de statuts.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, se sont produits ou seront imminents, le
siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales,
sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert
provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes

exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.»

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé de renouveler les mandats des personnes suivantes Monsieur Luc ERCOLE, Madame

Régis FOLNY et Madame Annie ERCOLE en tant qu'administrateurs de la Société.

La durée du mandat des administrateurs, prénommés, prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires qui se

tiendra en l'an 2020, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale a décidé de renouveler le mandat de la personne suivante Monsieur Luc ERCOLE en tant qu'ad-

ministrateur délégué de la Société.

La durée du mandat de l'administrateur délégué, prénommé, prendra fin lors de l'assemblée générale des actionnaires

qui se tiendra en l'an 2020, à moins qu'une assemblée générale des actionnaires n'en décide autrement.

Tous les points à l'ordre du jour étant épuisés, la séance est levée.

13621

L

U X E M B O U R G

<i>Dépenses

Les dépenses, frais, rémunération ou charges, quelle que soit leur forme, seront payés par la Société ou qui lui seront

imputés en rapport avec sa reclassification du capital social au taux fixe d'enregistrement de la perception fiscale sont
estimés à mille cent euros (EUR 1.100,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux Membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leurs

noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: A. GRENOUILLET, A.-M. GENCO, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 30 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16924. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015000823/83.
(140235552) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

BPER International Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 61.517.

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF SUB-FUNDS BPER INTERNATIONAL SICAV - SHORT TERM AND BPER IN-

TERNATIONAL SICAV - SHORT TERM EUR CORPORATES

I. Information relating to the Merger

The board of directors of the Company (the "Board of Directors") has decided, in compliance with Article 1 (20)a)

and Chapter 8 of the law of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"),
to effect a merger by absorption (the "Merger") as of 13 March 2015 (the "Effective Date") of the sub-fund "BPER Inter-
national SICAV - Short Term" (the "absorbed Sub-Fund") into sub-fund "BPER International SICAV - Short Term EUR
Corporates" (the "absorbing Sub-Fund").

General information
With effect as of the Effective Date, all of the assets and liabilities of the absorbed Sub-Fund will be transferred into

the absorbing Sub-Fund and the absorbed Sub-Fund will cease to exist.

The Merger shall become effective and final between the merging sub-funds and vis-à-vis third parties as from the

Effective Date.

Rationale for the Merger
The Merger is intended to proceed to an economical rationalization, to realize synergetic effects and to improve the

operating efficiency of the absorbed Sub-Fund through capital growth and thereby reduce costs to investors.

Impact of the Merger on the shareholders
The number of shares of the absorbing Sub-Fund to be issued will be determined on the Effective Date on the net

asset values of the respective classes of the absorbed Sub-Fund as per 12 March 2015.

The Merger will have an impact on the tax treatment of the shareholders since the "taxe d'abonnement" rate of the

absorbed Sub-Fund is of 0.01% per annum against 0.05% per annum of the absorbing Sub-Fund.

Shares of the share classes of the absorbed Sub-Fund will be converted into shares of the following share class of the

absorbing Sub-Fund:

BPER International SICAV - Short Term (absorbed Sub-

Fund)

BPER International SICAV - Short Term EUR Corporates

(absorbing Sub-Fund)

Class P

Class P

Such conversions will be effected at the respective conversion rates determined on the Effective Date. Fractional shares

will be issued up to three (3) decimals.

Shareholders of the absorbed Sub-Fund who do not agree with the Merger may request the redemption of all or a

part of their shares at the applicable net asset value of the relevant shares of the absorbed Sub-Fund without any re-
demption charges (except for any transaction costs incurred by the absorbed Sub-Fund in effecting redemptions and for
any local taxes during the thirty (30) calendar days following the date of publication of this notice to shareholders). This
right will expire five (5) business days before the date of calculation of the respective share conversion rates. The Merger

13622

L

U X E M B O U R G

will be binding on the remaining investors in the absorbed Sub-Fund after this deadline. After this deadline, it will be
allowed to deviate from the investment policy of the absorbed Sub-Fund as far as needed in order to align its portfolios
with the investment policy of the absorbing Sub-Fund. The following table illustrates the main differences between the
merging sub-funds:

BPER International SICAV - Short Term (absorbed Sub-
Fund)

BPER International SICAV - Short Term EUR Corporates
(absorbing Sub-Fund)

Profile of the typical investor:
Suitability for investors seeking a broadly diversified portfo-
lio EUR short term instruments with high quality and high
liquidity.

Profile of the typical investor:
Suitability for investors who wish to invest cash in a portfolio
with an average duration not exceeding three years which is
continuously adjusted to suit the prevailing market situation.

Investment Policy:
The aim of the absorbed Sub-Fund is to provide investors
with a safe and continuous return. The absorbed Sub-Fund
will therefore invest in short term fixed income securities,
such as Bonds and Floating Rate Notes, Money Market In-
struments, Euro Commercial Papers (ECP) and Certificates
of Deposits (CD's) issued by issuers world-wide.

Investment Policy:
The absorbing Sub-Fund invests at least two-thirds of its as-
sets in debt securities and claims. The duration of the port-
folio is continually adapted to the prevailing market situation
("short term") but will not exceed three years. At least two-
thirds of the investments are denominated in EUR.
However, the portion of investments in foreign currencies
not hedged against EUR may not exceed 10% of assets.

Allowing for the inclusion of special derivative financial in-
struments and sight, term and time deposits of banks and in
accordance with the investment principles outlined below
and CESRs Guidelines on a common definition of European
money market funds, the entire portfolio may have a weigh-
ted average maturity ("WAM") of 60 days maximum and a
weighted average life ("WAL") of 120 days maximum, with
the residual term of each individual investment may not ex-
ceed 397 days. In the case of floating rate notes, the next
coupon date on which the new interest rate is set is treated
as the final maturity when calculating the weighted average
maturity ("WAM") of the portfolio. In contrast, the final ma-
turity of floating-rate investments is treated as the final
maturity when calculating the weighted average life ("WAL")
and the individual residual maturities of the investments and
the average residual maturity of the portfolio.
The absorbed Sub-Fund may hold ancillary liquid assets.

After deducting cash and cash equivalents, the absorbing
Sub-Fund may invest up to one-third of its assets in money
market instruments. Up to 25% of its assets may be invested
in convertible, exchangeable and warrant-linked bonds as
well as convertible debentures.
In addition, after deducting cash and cash equivalents, the
absorbing Sub-Fund may invest up to 10% of its assets in
equities, equity rights and warrants as well as shares, other
equity shares and dividend-right certificates acquired
through the exercise of conversion and subscription rights
or warrants, or warrants remaining after the separate sale
of ex-issues and any equities acquired with these warrants.
The equities acquired by exercise or subscription must be
sold no later than 12 months after they were acquired.

Accounting currency:
EUR

Accounting currency:
EUR

Fees:
Flat Fee (for the Administrative Agent, the Custodian, the
Portfolio Manager(s) and the Distributor(s)) of maximum
0.600% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.

Fees:
Flat Fee (for the Administrative Agent, the Custodian, the
Portfolio Manager(s) and the Distributor(s)) of maximum
1.000% p.a. calculated daily on the average total net assets
of the respective class during the month concerned.

Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)
1

Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI)
2

Specific rights of the shareholders in respect of the Merger

<i>Redemption and conversion of shares
The  issue  of  shares  of  the  absorbed  Sub-Fund  will  cease  on  4  February  2015  (including).  Hence,  applications  for

subscriptions may be submitted to the absorbed Sub-Fund in Luxembourg, at UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., as
administrative agent of the Company, through 3 February 2015, 4 p.m. The last day for redemption of shares of the
absorbed Sub-Fund will be on 6 March 2015, which means that investors may apply for redemption in Luxembourg, at
UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., as administrative agent of the Company, through 6 March 2015, 4 p.m.

The  absorbed  Sub-Fund's  investors  who  have  not  proceeded  with  the  redemption  of  their  shares  by  the  above-

mentioned deadline will have their shares of the absorbed Sub-Fund converted into shares of the share class as mentioned
above of the absorbing Sub-Fund at the respective share class conversion rates determined on the effective date of the
Merger. No subscription fee will be levied by the absorbing Sub-Fund on the conversion of shares.

<i>Calculation method of the share class conversion rates
The conversion rates between shares of the absorbed Sub-Fund and shares of the absorbing Sub-Fund will be calculated

on the basis of the net asset values of the respective share classes of the absorbed Sub-Fund on the Effective Date. The
net asset values as of 12 March 2015 will be verified and approved by the independent auditor of the absorbed Sub-Fund.

13623

L

U X E M B O U R G

<i>Valuation of the assets
For purposes of determining the share class conversion rates, the assets and liabilities of the absorbed Sub-Fund will

be evaluated in accordance with the provisions contained in the prospectus of the Company.

<i>Costs of the Merger
Any fees relating to the preparation and implementation of the Merger will be borne by the absorbed Sub-Fund. Such

costs will not be included in the calculation of the net asset values of the absorbed Sub-Fund. Any legal, advisory or
administrative costs associated with the preparation and the completion of the Merger will not be charged to the absorbed
Sub-Fund or to the absorbing Sub-Fund or to their shareholders.

<i>Report of the auditor
Pursuant to Article 71 of the 2010 Law, the Company will appoint for the absorbed Sub-Fund its current independent

auditor, Deloitte S.A. The latter will verify the criteria adopted for the valuation of the assets and liabilities, the calculation
method of the share class conversion rates as well as the actual conversion rates on the date the respective share class
conversion rates are determined. A copy of the auditor's report will be made available to the shareholders at the regis-
tered office of the Company, on demand and without charge.

<i>Custodian
The letter of acknowledgement according to Article 70 of the 2010 Law of the custodian bank of the may be consulted

during usual business opening hours at the registered office of the Company.

Implementation and effective date of Merger

With effect as of the Effective Date, the Merger will result in the shareholders of the absorbed Sub-Fund becoming

shareholders of the absorbing Sub-Fund. Instead of shares in the absorbed Sub-Fund, they will hold shares of the absorbing
Sub-Fund.

The shareholders of the absorbed Sub-Fund may request the redemption of their shares in Luxembourg, at UBS Fund

Services (Luxembourg) S.A., as administrative agent of the Company, through 6 March 2015, 4 p.m. . The redemption of
shares will be free of any charges for the shareholders of the absorbed Sub-Fund (except for any transaction costs and
any local taxes).

With effect as of the Effective Date, the absorbed Sub-Fund will cease to exist. The net asset value of the absorbed

Sub-Fund will be calculated and published for the last time as per 12 March 2015.

The Merger has been approved by the Luxembourg supervisory authority, the Commission de Surveillance du Secteur

Financier ("CSSF").

The absorbing Sub-Fund shall be reflected in an updated version of the prospectus of the Company to be dated March

2015. Such prospectus, as well the last annual and semi-annual reports of the Company will be available at its registered
office.

The shareholders of the absorbed Sub-Fund shall be advised of the fact that an up-to-date version of the key investor

information documents (KIIDs) and any relevant documentation of the absorbing Sub-Fund will be available free of charge
at the Company´s registered office as well as on the following homepage: www.bper.it., at section "Privati e Famiglie -
Investimenti" Investors of the absorbed Sub-Fund are invited to take knowledge of such KIIDs in order to be aware of
the consequence due to the Merger.

Luxembourg, 4 February 2015

<i>The Board of Directors

Référence de publication: 2015017855/755/157.

City Living Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

R.C.S. Luxembourg B 161.052.

Les  Associés  de  la  société FISCOGES, société à responsabilité limitée,  dont le  siège  social est situé  au  4,  rue de

Kleinbettingen, L - 8362 Grass, agent domiciliataire de la société CITY LIVING GROUP Sàrl, enregistrée au Registre de
Commerce et des Sociétés sous le numéro B161052 déclarent par la présente la dénonciation du siège, 4, rue de Klein-
bettingen, L-8362 Grass de la société CITY LIVING GROUP Sàrl.

Le 30 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
FISCOGES
Ph. Lambert
<i>Gérant Unique

Référence de publication: 2015000792/15.
(140235621) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

13624

L

U X E M B O U R G

ING (L) FLEX, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 41.873.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on <i>13 February

<i>2015 at 3 p.m. Luxembourg time (the “Meeting”) to consider and resolve upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. As from 7 April 2015 (hereinafter the “Effective Date”), change of the name of the Company from “ING (L) Flex”

to “NN (L) Flex” in order to align with the rebranding of the other ING Investment Management investment entities.

2. As from the Effective Date, subsequent amendment to article 1 - “Name” of the articles of association of the

Company (hereinafter the “Articles”) so as to reflect the new name of the Company. Article 1 shall read as follows:
“There shall exist between the subscribers and all those who shall become shareholders a Company in the form
of a Limited Company under the regime of an Investment Company with Variable Share Capital (SICAV) raising
capital from the public, with the name of NN (L) Flex. The Company shall be governed by the Law of seventeenth
December two thousand and ten (the “2010 Law”) relating to undertakings for collective investments, and by these
articles of association.”

3. As from the Effective Date, amendment to article 7 - “Form of Shares” of the Articles shall be entirely reworded

so as to comply with Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of
shares and units in bearer form. Consequently, article 7 of the Articles shall read as follows:
“Article 7: Form of Shares. The board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer and/
or registered shares to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents of
the Company.
The  board  of  directors  may  decide,  at  its  entire  discretion,  whether  or  not  to  issue  certificates  in  respect  of
registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected
to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.
The share certificates, if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share
certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders, which shall be kept
in compliance with applicable laws.
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares.
Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested
under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will
also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time,
change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company
at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or
immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.
All immobilised bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept
by the bearer shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of
the Company.
Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer share register. Upon written request
by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares regis-
tered for such shareholder in the bearer share register.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney
to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the
exercise of all rights attached to such shares.
The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata
basis.”

13625

L

U X E M B O U R G

4. As from the Effective Date, amendment to article 10 - “Redemption of Shares” of the Articles so as to add clarity

with  regard  to  the  pro-rata  rules  and  priority  in  case  of  redemption  and  conversion  applications  exceeding  a
percentage of the total value of a sub-fund on a Valuation Day as defined in the prospectus of the Company. The
amended seventh paragraph of article 10 shall now read as follows:
“If redemption and conversion (with reference to their redemption proportion) applications exceed a specific
percentage of the total value of a Sub-Fund on a Valuation Day as defined in the prospectus of the Company, the
Company's Board of Directors may decide to (1) suspend all the redemption and conversion applications until
adequate liquidity has been generated to serve these applications or (2) execute pro-rata the redemption and
conversion applications up to an amount that equals the specific percentage and defer the redemption and con-
version applications that exceed the specific percentage to the next valuation date and, if necessary, next valuation
dates, until such applications have been satisfied in full. On such deferred valuation dates the unsatisfied balance of
these redemption and conversion applications shall be met in priority to later requests.”

5. As from the Effective Date, amendment to article 12 - “Termination and amalgamation of compartments or classes

of shares” of the Articles so as to comply with applicable laws. The first paragraph of article 12 shall now read as
follows:
“If the value of the assets of a compartment or any class of shares within a compartment has decreased to, or has
not reached, an amount determined by the Board of Directors to be the minimum level needed for such com-
partment or class of shares to operate in an economically efficient manner, or in the event of a substantial change
in the political, economic or monetary situation, or in the framework of an economic restructuring, the Board of
Directors may decide to compulsorily redeem all the shares of the relevant compartment or class of shares at the
Net  Asset  Value  per  share  (taking  into  account  the  sale  prices  of  investments  and  expenses  relating  thereto)
calculated on the Valuation Day on which such decision takes effect. In accordance with the Law the Company
must inform the (registered) Shareholders in writing of the reasons and the redemption procedure before the
compulsory redemption enters into force. If decision is made to liquidate a compartment or a class of shares, such
notice will be released through registered letter and/or publication in at least one daily Luxembourgish newspaper.
Unless decided in the interest of, or in order to ensure equal treatment between Shareholders, the Shareholders
of the compartment or the class of shares concerned may continue to request the redemption or conversion of
their Shares free of charge (but taking into account the sale prices of investments and expenses relating thereto)
prior the effective date of the compulsory redemption. The issue of Shares will be suspended as soon as the decision
is taken to liquidate a compartment or a class of shares.”

6. As from the Effective Date, amendment to article 13 - “Limitations on the Ownership of Shares” so as to replace

the third indent of the procedure as follows:
“3. the payment of the redemption price shall be made to the owner of these shares and shall be deposited by the
Company with a bank, in Luxembourg or elsewhere (as specified in the redemption notice), for payment to the
shareholder in question against delivery, where applicable, of the certificate(s) representing the shares indicated in
the redemption notice together with the unmatured coupons. As from the deposit of the price under these con-
ditions, any person interested in the shares mentioned in the redemption notice may not assert any rights over
these shares, nor take any action against the Company and its assets, excepting the right of a shareholder, appearing
to be the owner of shares, to receive the price deposited (without interest) at the bank against delivery, where
applicable, of the certificate(s) and the unmatured coupons;”

7. As from the Effective Date, removal of article 30 - “Indemnity” from the Articles.
8. As from the Effective Date, amendment to the former article 34 - “Distributions” (to be renumbered 33) of the

Articles so as to comply with the Law. The third paragraph shall now read as follows:
“Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses
in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of immobilised bearer shares shall be made to
the bearer shares depositary for the benefit of the shareholder, as further specified in the sales documents of the
Company.”

9. As from the Effective Date, creation of a new section 9. “Miscellaneous” to the Articles and creation of a new

article 36 - “Depositary Bank”. This paragraph will read as follows:
“To the extent required by law, the Company shall enter into a depositary bank agreement with a banking or saving
institution as defined by the law of 5 April, 1993 on the financial sector, as amended and in compliance with the
conditions set forth by the Law of 12 July 2013.
The depositary bank shall fulfil the duties and responsibilities as provided for by the 2010 Law and the Law of 12
July 2013.
Where the law of a third country requires that certain financial instruments are held in custody by a local entity
and there are no local entities that satisfy the delegation requirements of the Law of 12 July 2013, the depositary
may discharge itself of its liability under the conditions set out in the Law of 12 July 2013.”

10. As from the Effective Date, subsequent renumbering of articles 30 to 35 of the Articles.

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is

present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes
cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

13626

L

U X E M B O U R G

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary

General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the
Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked

to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department
of ING Investment Management Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 6 February 2015
5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

<i>The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015011760/755/130.

CS Invest Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 189.243.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend vierzehn.
den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN

Die Gesellschaft FREO Group S.à r.l. mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, eingetragen beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 181.015,

hier vertreten durch Herr Jürgen BURGARD, Finanzbuchhalter, beruflich ansässig in L-3260 Bettembourg, 54, route

de Mondorf, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 15. Dezember 2014,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Gesellschaft und dem

amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschaft, vertreten wie vorab erwähnt, ersucht den ausführenden Notar die folgenden Erklärungen und Fests-

tellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft FREO Group S.à r.l., die alleinige Aktionärin der Gesellschaft CS Invest Luxembourg S.A. ist,

mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg
unter der Nummer B 189.243 (NIN 2014 22 15 625).

II.- Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul MEYERS, mit

dem Amtssitze in Rambrouch, am 1. August 2014, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 2772 vom 7. Oktober 2014.

III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (EUR 31.000.-) beläuft, eingeteilt in:
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse A;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse B;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse C;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse D;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse E;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse F;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse G;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse H;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse I; und
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse J; mit einem Nennwert von je EINEM Euro (€ 1.-).
IV.- Dass die Gesellschaft CS Invest Luxembourg S.A. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
V.- Dass die Aktien weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend

machen können.

VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.
Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft CS Invest

Luxembourg S.A. aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt die alleinige Aktionärin FREO Group S.à r.l., vertreten wie vorerwähnt, handelnd

soweit als notwendig als Liquidatorin der Gesellschaft;

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft CS Invest Luxembourg S.A. beglichen wurden, und dass

sie persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für die
Kosten der gegenwärtigen Urkunde;

13627

L

U X E M B O U R G

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist; demnach ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen

anzusehen;

- dass dem Verwaltungsrat sowie dem Kommissar der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen

Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz aufbewahrt

werden;

- dass das Aktienregister in Gegenwart des amtierenden Notars annulliert wurde.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, Am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der Bevollmächtigte der Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. BURGHARD, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2733. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): J.-M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 31 Dezember 2014.

Référence de publication: 2015000825/64.
(140235826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

ING (L) Patrimonial, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.

R.C.S. Luxembourg B 24.401.

Notice is hereby given that an

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

of the shareholders of the Company will be held before notary at the registered office of the Company on <i>13 February

<i>2015 at 3 p.m. Luxembourg time (the “Meeting”) to consider and resolve upon the following agenda:

<i>Agenda:

1. As  from  7  April  2015  (hereinafter  the  “Effective  Date”),  change  of  the  name  of  the  Company  from  “ING  (L)

Patrimonial” to “NN (L) Patrimonial” in order to align with the rebranding of the other ING Investment Manage-
ment investment entities.

2. As from the Effective Date, subsequent amendment to article 1 - “Name and Form” of the articles of association

of the Company (hereinafter the “Articles”) so as to reflect the new name of the Company. Article 1 shall therefore
read as follows:
“There exists among the existing shareholders and those who may become owners of shares in the future, a public
limited company (“société anonyme”) qualifying as an investment company with variable share capital (“société
d'investissement à capital variable”) under the name of “NN (L) Patrimonial” (hereinafter the “Company”). The
Company shall be governed by part I of the law of the seventeenth of December two thousand and ten relating to
undertakings for collective investments, and by these articles of association.”

3. As from the Effective Date, amendment to article 8 - “Form of Shares” of the Articles shall be entirely reworded

so as to comply with Luxembourg law of 28 July 2014 concerning the compulsory deposit and immobilisation of
shares and units in bearer form (the “Law”). Consequently, Article 8 shall read as follows:
“Art. 8. - FORM OF SHARES - The board of directors shall determine whether the Company shall issue bearer
and/or registered shares, to the extent permitted by law and under the conditions specified in the sales documents
of the Company.
The  board  of  directors  may  decide,  at  its  entire  discretion,  whether  or  not  to  issue  certificates  in  respect  of
registered shares, as specified in the sales documents of the Company. In case the board of directors has elected
to issue no certificates, a shareholder shall receive, upon his request, a written confirmation of his shareholding.
The share certificates, if issued, shall comply with the requirements set out under the law of 10 August 1915 on
commercial companies, as amended.
In case share certificates are issued, the board of directors may decide, at its entire discretion, to replace a share
certificate which has been mislaid, mutilated or destroyed, as specified in the sales documents of the Company.
All issued registered shares of the Company shall be registered in the register of shareholders which shall be kept
in compliance with applicable laws.
The inscription of the shareholder's name in the register of shareholders evidences his right of ownership on such
registered shares.

13628

L

U X E M B O U R G

Shareholders entitled to receive registered shares shall provide the Company with all the information requested
under applicable laws, including an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will
also be entered into the register of shareholders.
In the event that a shareholder does not provide an address, the Company may permit a notice to this effect to be
entered into the register of shareholders and the shareholder's address will be deemed to be at the registered
office of the Company, or at such other address as may be so entered into by the Company from time to time,
until another address shall be provided to the Company by such shareholder. A shareholder may, at any time,
change his address as entered into the register of shareholders by means of a written notification to the Company
at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.
At the entire discretion of the board of directors, bearer shares may be issued in book entry bearer form or
immobilised form, as specified in the sales documents of the Company.
All immobilised bearer shares of the Company shall be registered in the bearer share register which shall be kept
by the bearer shares depositary in compliance with applicable laws, as further specified in the sales documents of
the Company.
Ownership of bearer shares will be evidenced by the registration in the bearer share register. Upon written request
by the shareholder concerned, the bearer shares depositary may issue a written confirmation of the shares regis-
tered for such shareholder in the bearer share register.
The Company recognises only one single owner per share. If one or more shares are jointly owned or if the
ownership of shares is disputed, all persons claiming a right to such share(s) have to appoint one single attorney
to represent such share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of the
exercise of all rights attached to such shares.
The Company may decide to issue fractional shares. Such fractional shares shall not be entitled to vote but shall
be entitled to participate in the net assets attributable to the relevant Sub-Fund or class of shares on a pro rata
basis.”

4. As from the Effective Date, amendment to Article 9 - “Classes of Shares” of the Articles so as to replace the third

paragraph by the following:
“Within each class, there may be:
- one or more capitalization share-types; and
- one or more distribution share-types.”

5. As from the Effective Date, amendment to Article 13 - “Limitations on the Ownership of Shares” so as to replace

the third indent of the procedure as follows:
“3. payment of the redemption price will be made to the owner of such shares and will be deposited by the Company
with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the purchase notice) for payment to such owner upon
surrender, where applicable, of the share certificate or certificates representing the shares specified in such notice
together with the unmatured coupons. Upon deposit of such price as aforesaid, no person interested in the shares
specified in such redemption notice shall have any further interest in such shares or any of them, or any claim against
the Company or its assets in respect thereof, except the right of the shareholders appearing as the owner thereof
to receive the price so deposited (without interest) from such bank upon effective surrender, where applicable, of
the share certificate(s) and the unmatured coupons if issued, as aforesaid;”

6. As from the Effective Date, amendment to Article 22 - “Delegation of Power” so as to remove the last paragraph:

“In the event that no entity within the ING Group would be in a position to control the management of the
Company, the Company shall change its name forthwith at the request of ING Luxembourg, to a name not re-
sembling the one specified in article 1 hereof.”

7. As from the Effective Date, removal of article 24 - “Indemnification” from the Articles.
8. As from the Effective Date, subsequent renumbering of articles 25 to 33 of the Articles and update of the relevant

cross-references in the Articles.

9. As from the Effective Date, amendment to the former article 29 - “Distributions” (to be renumbered 28) of the

Articles so as to comply with the Law. The third paragraph shall now read as follows:
“Payments of distributions to holders of registered shares shall be made to such shareholders at their addresses
in the register of shareholders. Payments of distributions to holders of immobilised bearer shares shall be made to
the bearer shares depositary for the benefit of the shareholder, as further specified in the sales documents of the
Company.”

The Meeting will validly deliberate on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is

present or represented. The related resolutions will be validly adopted if approved by at least two thirds of the votes
cast by shareholders of the Company at the Meeting. Each share is entitled to one vote.

If the quorum is not reached, another Extraordinary General Meeting shall be convened. The second Extraordinary

General Meeting shall validly deliberate on the agenda regardless of the proportion of the issued share capital of the
Company present or represented.

Shareholders are invited to attend the Meeting in person. In case they cannot attend the meeting, they are kindly asked

to complete and sign a proxy available at the registered office of the Company and to return it to the Legal Department

13629

L

U X E M B O U R G

of ING Investment Management Luxembourg S.A. at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg not later than 6 February 2015
5 p.m. Luxembourg time by fax (fax number + 352 26 19 68 40), followed by the original by regular mail.

<i>The Board of Directors of the Company.

Référence de publication: 2015011761/755/102.

CS Management Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 189.283.

AUFLÖSUNG

Im Jahre zwei tausend vierzehn.
den neunundzwanzigsten Dezember.
Vor dem unterzeichneten Henri BECK, Notar mit dem Amtssitz in Echternach (Grossherzogtum Luxemburg).

IST ERSCHIENEN

Die Gesellschaft FREO Group S.à r.l. mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, eingetragen beim Handels-

und Gesellschaftsregister in Luxemburg unter der Nummer B 181.015,

hier vertreten durch Herr Jürgen BURGARD, Finanzbuchhalter, beruflich ansässig in L-3260 Bettembourg, 54, route

de Mondorf, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 15. Dezember 2014,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch den Bevollmächtigten der Gesellschaft und dem

amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigefügt bleibt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Gesellschaft, vertreten wie vorab erwähnt, ersucht den ausführenden Notar die folgenden Erklärungen und Fests-

tellungen zu beurkunden wie folgt:

I.- Dass die Gesellschaft FREO Group S.à r.l., die alleinige Aktionärin der Gesellschaft CS Management Luxembourg

S.A. ist, mit Sitz in L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister
Luxemburg unter der Nummer B 189.283 (NIN 2014 22 15 730).

II.- Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch Notar Jean-Paul MEYERS, mit

dem Amtssitze in Rambrouch, am 1. August 2014, veröffentlicht im Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations
Nummer 2764 vom 7. Oktober 2014.

III.- Dass das Gesellschaftskapital sich auf EINUNDDREISSIG TAUSEND EURO (EUR 31.000.-) beläuft, eingeteilt in:
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse A;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse B;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse C;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse D;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse E;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse F;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse G;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse H;
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse I; und
- dreitausendeinhundert (3.100) rückkaufbare Aktien der Klasse J; mit einem Nennwert von je EINEM Euro (€ 1.-).
IV.- Dass die Gesellschaft CS Management Luxembourg S.A. in keinen Rechtsstreit verwickelt ist.
V.- Dass die Aktien weder verpfändet noch durch Dritte belastet sind, noch Dritte irgendwelche Rechte darauf geltend

machen können.

VI.- Dass die Gesellschaft nicht im Besitz von Immobilien und/oder Immobilienanteilen ist.
Nach den vorstehenden Bemerkungen erklärt die Komparentin, vertreten wie vorerwähnt, die Gesellschaft CS Ma-

nagement Luxembourg S.A. aufzulösen.

Infolge dieser Auflösung erklärt die alleinige Aktionärin FREO Group S.à r.l., vertreten wie vorerwähnt, handelnd

soweit als notwendig als Liquidatorin der Gesellschaft;

- dass alle Aktiva realisiert und alle Passiva der Gesellschaft CS Management Luxembourg S.A. beglichen wurden, und

dass sie persönlich für sämtliche Verbindlichkeiten, sofern noch vorhanden, der aufgelösten Gesellschaft haftet sowie für
die Kosten der gegenwärtigen Urkunde;

- dass die Liquidation der Gesellschaft somit vollendet ist; demnach ist die Liquidation der Gesellschaft als abgeschlossen

anzusehen;

- dass dem Verwaltungsrat sowie dem Kommissar der Gesellschaft für die Ausübung ihrer Mandate bis zum heutigen

Tage volle Entlastung erteilt wird;

- dass die Bücher und Dokumente der aufgelösten Gesellschaft während fünf (5) Jahren am Gesellschaftssitz aufbewahrt

werden;

13630

L

U X E M B O U R G

- dass das Aktienregister in Gegenwart des amtierenden Notars annulliert wurde.

WORÜBER URKUNDE, Aufgenommen in Echternach, am Datum wie eingangs erwähnt.
Und nach Vorlesung hat der Bevollmächtigte der Komparentin, dem instrumentierenden Notar nach Namen, gebräu-

chlichem Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: J. BURGHARD, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 30 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2734. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

FÜR  GLEICHLAUTENDE  AUSFERTIGUNG,  auf  Begehr  erteilt,  zwecks  Hinterlegung  beim  Handels-  und  Gesell-

schaftsregister.

Echternach, den 2. Januar 2015.

Référence de publication: 2015000827/64.
(150000125) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 6) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 155.993.

EXTRAIT

En date du 05 décembre 2014, l'associé unique a pris les résolutions suivantes:
- La démission de M. Alan Botfield, en tant que gérant, est acceptée avec effet immédiat;
- Madame Virginia Strelen, avec adresse professionnelle au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg, Grand-Duché

de Luxembourg, est élue nouveau gérant de la Société avec effet immédiat et ce, pour une durée indéterminée.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014208813/14.
(140233653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Nikoglobal Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 2.300.000,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 156.806.

EXTRAIT

KANTONIS S.A. ayant son siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street, Panama, Republic of Panama

a apporté 59.800 parts sociales qu'elle détenait dans la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l., ayant son siège social
à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle lors de la constitution de la société à responsabilité limitée SphereLux,
sise au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n°
192 750.

Il résulte d'une cession de part intervenue en date du 4 décembre 2014 que la société KANTONIS S.A. ayant son

siège social à Mossfon Building, 2 

nd

 Floor, East 54 

th

 Street, Panama, Republic of Panama a cédé 170.200 parts sociales

qu'elle détenait dans la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l., ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue
Charles de Gaulle à la société à responsabilité limitée SphereLux, sise au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le n°192 750.

Cette cession de part a été notifiée et acceptée par la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l. en date du 4 décembre

2014 conformément à l'article 1690 du Code Civil et à la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Suite à cette cession, le capital social de la société NIKOGLOBAL HOLDING S. à r.l. est détenu comme suit:

SphereLux
Société à responsabilité limitée
2, Avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230.000 parts

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206087/28.
(140229006) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

13631

L

U X E M B O U R G

Naxsis Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 177.179.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le dix-huit décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Giuseppe RINALDI, ingénieur commercial et gérant de sociétés, né le 26 novembre 1958 à Haine Saint

Paul (Belgique) et demeurant à B-6230 Pont-à-Celles, 54, rue des Champs, et

2.- Monsieur Christian TILLIEUX, gérant de sociétés, né le 22 janvier 1951 à Etterbeek (Belgique) et demeurant à

B-1420 Braine l’Alleud, 2/9, Clos de l’Aurore.

Les deux comparants sont ici représentés par Monsieur Stéphane ROBERT, salarié, demeurant professionnellement

à L-1526 Luxembourg, 55, Val Fleuri, en en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrées, lesquelles procu-
rations, signées "ne varietur" par le mandataire et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être
formalisées avec lui.

Lesquels comparants, représentés comme dit ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire de documenter comme

suit leurs déclarations:

a.- Que la société à responsabilité limitée “NAXSIS GROUP S.à r.l.”, établie et ayant son siège social à L-8399 Windhof,

3-5, route d’Arlon, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 177.179,
a été constituée suivant acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 3 mai
2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 1570 du 2 juillet 2013, dont les statuts n’ont
pas été modifiés depuis.

b.- Que le capital social est fixé à huit millions cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents euros (EUR 8.194.500,-),

représenté par huit millions cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents (8.194.500) parts sociales d'une valeur nominale
de un euro (EUR 1,-) chacune.

c.- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société.
d.- Que l’activité de la société ayant cessé et que les comparants, en tant qu'associés uniques, siégeant en assemblée

générale extraordinaire modificative des statuts de la société, prononcent la dissolution anticipée de la prédite société,
avec effet immédiat et sa mise en liquidation.

e.- Que les associés se désignent comme liquidateurs de la société.
f.- Que les liquidateurs requièrent le notaire instrumentant d’acter qu'ils déclarent avoir réglé tout le passif de la société

dissoute, moyennant reprise par les associés de l’intégralité de l’actif et du passif, et avoir transféré tous les actifs au profit
des associés.

g.-  Que  les  comparants  sont  investis  de  tous  les  éléments  actifs  de  la  société  et  répondront  personnellement  et

solidairement de tout le passif social et de tous les engagements de la société même inconnus à ce jour.

h.- Que partant, la liquidation de la société est à considérer comme faite et clôturée.
i.- Que décharge pleine et entière est accordée aux gérants de la société pour l’exécution de leur mandat.
j.- Qu'il a été procédé à l’annulation du registre des associés et des parts sociales de la société dissoute.
k.- Que les livres et documents de la société dissoute seront conservés pendant cinq ans au siège social de la société

dissoute.

<i>Frais

Tous les frais et honoraires du présent acte, évalués à la somme de mille cinq cents euros, sont à la charge de la société.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ès-qualité qu'il agit, connu du notaire par nom, prénom,

état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Stéphane ROBERT, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 23 décembre 2014. Relation GRE/2014/5225. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): Claire PIERRET.

Référence de publication: 2014209461/52.
(140234618) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

13632


Document Outline

Aberdeen Global II

Adran S.A

Alpha Concept S.A.

AMP Capital Investors (Luxembourg No. 6) S.à r.l.

Amster Property I S.à r.l.

Anci sàrl

Aquarelle Germany S.A.

Aquarelle Italy S.A.

Argopal Real Estate S.à r.l.

Ariodante

Athena Private Equity 2 S.A.

Auberge Petite Suisse S.àr.l.

Automation Conveyor Systems S.A.

Babouille, s.à r.l.

Bedworth S.à r.l.

Blue Marine Investments S.A.

BPER International Sicav

BPER International Sicav

BPER International Sicav

CAHVA

Cardoso S.à r.l.

CD&amp;R Osprey Investment S.à r.l.

CEE Urban Red SCA, SICAV-FIS

CEON Asset Management Luxembourg S.à r.l.

Chamborant S.à r.l.

City Living Group S.à r.l.

Compagnie Industrielle et Financière des Produits Amylacés SICAF/SIF

Crisalid Luxembourg SA

CS Invest Luxembourg S.A.

CS Management Luxembourg S.A.

Digital Services XXX S.à r.l.

Elbblick (Juliet) S.à r.l.

Finasset S.A.

Fonds Direkt Sicav

ING (L) FLEX

ING (L) Patrimonial

Lux Prime Pension - Sepcav

Naxsis Group S.à r.l.

Nikoglobal Holding S.à r.l.

Parc Faïence S.A.

RSF Europe

SA Contraste Europe

Sol-Line S.à r.l.

Surf International S.A.

Tonnerre Investments S.A.

Vates

VPC Luxembourg

White House S.A.