logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 232

29 janvier 2015

SOMMAIRE

BSO Network Solutions Luxembourg

S.à.r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11099

Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11098

HAB2 Prop Co. C S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

11112

Highstreet II PropCo II S.à.r.l. . . . . . . . . . . .

11105

Join Expérience S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11102

Levhotel S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11136

Lostres S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11136

Novaro Mediterranean S.A.  . . . . . . . . . . . . .

11090

NRGenerating Luxembourg (No.1) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11090

NRGenerating Luxembourg (No.2) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11090

Nsearch S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11095

Nucco 1 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11090

Nucco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11092

Nucco 3 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11092

Nucco 4 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11097

Obika Holdings S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11097

Octogone S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11096

Odyssey Fund Sicav SIF  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11091

Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A.  . .

11091

OPF Immo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11095

Optique Quaring Bonnevoie S.à r.l.  . . . . . .

11092

Oriolan S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11090

Paris-les-Bains S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11096

Partners Group Prime Yield, S.à r.l.  . . . . .

11093

Patrimoine & Conseils S.A.  . . . . . . . . . . . . .

11094

Patron Caldew S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11091

Patron Dieter II S. à r. l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

11093

Patron Investments III S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

11092

PeaksideWert 2 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

11097

Percival Properties  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11094

PetroSantander Luxembourg Holdings S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11096

Photovoltaïque Mergen-Origer  . . . . . . . . . .

11095

Picton S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11093

Porta Nova Participations SA  . . . . . . . . . . .

11096

Pradera Holdco S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11095

Prevprop Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

11094

R.A.L. Management S.A., SPF  . . . . . . . . . . .

11122

Revod Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

11130

RZ Holding S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11133

Sheik Coast S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11135

THOMAS COOK succursale Luxembourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11097

11089

L

U X E M B O U R G

Novaro Mediterranean S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 136.729.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208345/10.
(140232661) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Nucco 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 176.394.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208349/10.
(140232283) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

NRGenerating Luxembourg (No.1) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 27.471.640,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 77.333.

Les  comptes  annuels  de  la  société  pour  l'exercice  clôturé  au  31  décembre  2013  ont  été  déposés  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208346/11.
(140233232) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

NRGenerating Luxembourg (No.2) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: AUD 21.140,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 77.334.

Les  comptes  annuels  de  la  société  pour  l'exercice  clôturé  au  31  décembre  2013  ont  été  déposés  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208347/11.
(140233231) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Oriolan S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 20, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 78.444.

Il est à noter que le siège social des trois administrateurs Management S. à r.l., Director S.à r.l. et Manager S.à r.l. a

été transféré au 20 avenue Pasteur L-2310 Luxembourg.

Il est à noter que le siège social du Commissaire aux comptes Luxfiducia S.à r.l. a été transféré au 20 avenue Pasteur

L-2310 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208370/12.
(140232265) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11090

L

U X E M B O U R G

Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-7737 Colmar-Berg, Zone Industrielle Piret.

R.C.S. Luxembourg B 34.560.

<i>Auszug aus dem Protokoll der Ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 17. Dezember 2014

Es geht hervor dass:
Die Mandate der Verwaltungsratsmitglieder:
- Hans-Peter Walter, wohnhaft 10, Britter Strasse, D-66693 Mettlach, administrateur délégué
- Hermann Joseph Walter, wohnhaft 2A, Auf der Hardt, D-66693 Mettlach, administrateur délégué
- Claude Schmitz, wohnhaft 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
werden um weitere drei Jahre verlängert. Die Mandate enden bei der Generalversammlung der Aktionäre, welche

über die Konten des Jahres 2016 zu befinden hat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014208361/17.
(140232625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Odyssey Fund Sicav SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 181.879.

EXTRAIT

L'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 19 décembre 2014 et a adopté les

résolutions suivantes:

1. L'Assemblée décide de reconduire le mandat de:
- M. Marc Chatel
- M. Guillaume Jalenques de Labeau
- M. Marc Wenda
en tant qu'administrateurs pour un terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Ac-

tionnaires en 2015.

2. L'Assemblée décide de reconduire le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé KPMG Luxembourg S.à r.l. pour un

terme venant à échéance à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires en 2015.

Référence de publication: 2014208360/18.
(140232206) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Patron Caldew S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 190.227.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 22 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet immédiat.
- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet immédiat pour
une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014208378/19.
(140232942) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11091

L

U X E M B O U R G

Nucco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 176.398.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208350/10.
(140232281) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Nucco 3 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 176.407.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208351/10.
(140232280) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Optique Quaring Bonnevoie S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 110, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 45.880.

<i>Extrait de l'A.G. ordinaire du 20 novembre 2014 au siège de la société

1 L'Assemblée accepte la démission de Madame Patricia QUARING, opticienne, née le 28 juillet 1961 à Dudelange,

demeurant op Orkelsbour, L-8833 Wolwelange, de sa fonction de gérante administrative, avec effet immédiat.

2 L'Assemblée décide de nommer comme gérant unique, Monsieur Stephane QUARING, opticien, né le 30 juin 1972

à Dudelange, demeurant à L-5835 Alzingen, 14 rue Hondsbreck, avec pouvoir de signature seul, avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014208368/14.
(140233273) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Patron Investments III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 14.900,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 123.328.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 18. Dezember 2014

Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Rücktritt mit Wirkung zum 18. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Maurice Mougeolle von seinen Mandat

als Geschäftsführer wird angenommen.

- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher

Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 18. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Géraldine Schmit, Geschäftsführerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Jürgen Schlichting, Geschätsführer, mit Anschrift in 24 Deer Ridge Trail, Water Mill, 11976 New-York, USA
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208383/20.
(140232811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11092

L

U X E M B O U R G

Picton S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 129.902.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

<i>Extrait

Suite à l'Assemblée Générale des Associés tenue en date du 19 décembre 2014, les Associés:
- Prononcent la clôture de la liquidation et constatent que la société a définitivement cessé d'exister;
- Décident que les livres et documents sociaux seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à partir

de la date de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations au 15 rue Edward Steichen, L-2540 Lu-
xembourg.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208396/17.
(140232509) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Partners Group Prime Yield, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 30.000.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 114.648.

RECTIFICATIF

<i>Extrait

Suite à une erreur administrative lors du dépôt de l'acte de transfert de parts sociales de la société auprès du Registre

de commerce et des sociétés Luxembourg le 6 mars 2014 référence L140039154, le nom de l'associé unique doit être
modifié afin de lire:

Barfield Nominees Limited A/C PGO01
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208376/18.
(140232649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Patron Dieter II S. à r. l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 124.583.

<i>Auszug aus der Beschlussfassung der alleinigen Gesellschafterin vom 22. Dezember 2014

Die alleinige Gesellschafterin hat folgende Beschlüsse gefasst:
- Der Rücktritt mit Wirkung zum 22. Dezember 2014 von Herrn Emmanuel Mougeolle von seinen Mandat als Ge-

schäftsführer wird angenommen.

- Herr Steve van den Broek, Gesellschaftsverwalter, geboren in Antwerpen (Belgien) am 26. Juli 1970, mit beruflicher

Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, wird zum Geschäftsführer der Gesellschaft ernannt mit Wirkung
zum 22. Dezember 2014 und auf unbestimmte Zeit.

Die Geschäftsführung der Gesellschaft setzt sich seitdem wie folgt zusammen:
- Frau Géraldine Schmit, Geschäftsführerin, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- Herr Steve van den Broek, Geschäftsführer, mit beruflicher Anschrift in 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208379/19.
(140232771) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11093

L

U X E M B O U R G

Patrimoine &amp; Conseils S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 127.373.

<i>Dépôt des comptes annuels remplaçant le dépôt n°L140098589 du 13/06/2014

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 31/12/2013 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2014208377/12.
(140232500) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Percival Properties, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 26-28, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 193.024.

<i>Extrait des résolutions adoptées par les actionnaires de la Société tenue en date du 11 décembre 2014:

1. Totalserve Management (Luxembourg) S.A. a démissionné en tant que gérant de la Société avec effet au 11 décembre

2014.

2. Keimpe Reitsma né le 12.06.1956 à Leiden (Pays-Bas), James Body né le 05.04.1976 à Clare (Irlande) et Christian

Tailleur né le 17.05.1967 à Metz (France) avec adresses professionnelles au 26-28, rue Edward Steichen, L-2540 Luxem-
bourg ont été nommés gérants de la Société avec effet au 11 décembre 2014 pour une période indéterminée.

Pour extrait conforme
<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014208391/16.
(140232312) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Prevprop Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4040 Esch-sur-Alzette, 5, rue Xavier Brasseur.

R.C.S. Luxembourg B 104.403.

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'actionnaire unique de la Société prises en date du 9 décembre 2014 que M. Alexis

Kamarowsky et M. Federigo Cannizzaro di Belmontino ont été révoqués de leur fonction respective d'administrateur de
catégorie B de la Société, avec effet au 9 décembre 2014.

Il résulte des mêmes résolutions que (i) M. Yannick Ceccarelli, né le 20 avril 1984 à Thionville, France, ayant son adresse

professionnelle au 5, rue Xavier Brasseur, L-4040 Esch-sur-Alzette, a été nommé administrateur de catégorie B de la
Société avec effet au 9 décembre 2014 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015 et que
(ii) M. Alexandre Ribeiro, né le 18 mai 1983 à Roanne, France, ayant son adresse professionnelle au 5, rue Xavier Brasseur,
L-4040 Esch-sur-Alzette, a été nommé administrateur de catégorie B de la Société avec effet au 9 décembre 2014 jusqu'à
l'assemblée générale annuelle de la Société qui se tiendra en 2015.

Le conseil d'administration de la Société est donc composé des personnes suivantes:
- Adam Charles Mackie, administrateur de catégorie A
- Ashley James Mackie, administrateur de catégorie A
- Ludovic Blettery, administrateur de catégorie B
- Yannick Ceccarelli, administrateur de catégorie B
- Alexandre Ribeiro, administrateur de catégorie B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Prevprop Properties SA

Référence de publication: 2014208407/26.
(140233065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11094

L

U X E M B O U R G

OPF Immo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Koerich, 3-5, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 108.415.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208367/9.
(140232285) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Nsearch S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6778 Grevenmacher, 2, Schaffmill.

R.C.S. Luxembourg B 67.786.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014208348/9.
(140232722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Pradera Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 86.621.

<i>Rectificatif du dépôt numéro L130194266 déposé le 15/11/2013

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Pradera Holdco S.à r.l.

Référence de publication: 2014208402/13.
(140232687) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Photovoltaïque Mergen-Origer, Société Civile.

Siège social: L-8537 Hostert, 10, rue de Folschette.

R.C.S. Luxembourg E 4.832.

<i>Assemblée générale

L'an deux mille quatorze, le 17 septembre.
Se sont réunis, tous les associés
1. Monsieur Roger Mergen, né à Luxembourg le 03 avril 1960, demeurant à 2, Riesenhaffer-Wee, L-8811 Bilsdorf,
2. Monsieur Michel Mergen, né à Luxembourg le 29 septembre 1961, demeurant à 10, rue de Folschette, L-8537

Hostert,

3. Monsieur Albert Mergen, né à Luxembourg le 3 mars 1963, demeurant à 2, Neimille-Wee, L-8811 Bilsdorf,
4. Monsieur Philippe Origer, né à Ettelbruck le 18 août 1984, demeurant à 5, op der Seerie, L-8561 Schwebach
se sont constitués en assemblée générale extraordinaire à laquelle ils se reconnaissent dûment convoqués et après

avoir constaté que celle-ci était régulièrement constituée, ont à l'unanimité des voix pris les résolutions suivantes:

1. Changement des statuts, notamment l'article 13, qu'il faudra lire

Art. 13. L'exercice social commence le 1 

er

 mai et finit le 30 avril de chaque année.

En conséquence
a. l'exercice social 2014, qui a commencé au 01/01/2014 finira au 30/04/2014.
b. L'exercice social 2015, commencera au 01/05/2014 pour finir au 30/05/2015

Hostert, le 17 septembre 2014.

Mergen Roger / Mergen Michel / Mergen Albert / Origer Philippe.

Référence de publication: 2014208395/23.
(140232201) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11095

L

U X E M B O U R G

Octogone S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3327 Crauthem, 1A, rue de Hellange.

R.C.S. Luxembourg B 153.116.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014208359/10.
(140233360) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Porta Nova Participations SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 9, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 18.699.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 24/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014208400/12.
(140232066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 37.136.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 150.668.

EXTRAIT

Il résulte des décisions prises par l'associé unique de la Société en date du 19 décembre 2014 que les démissions de

Monsieur Marc Daniel CHONG KAN et Monsieur Gabor BERNATH, en tant que gérant A de la Société, ont été acceptées
avec effet immédiat,.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Pour extrait conforme

Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208393/15.
(140233165) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Paris-les-Bains S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5638 Mondorf-les-Bains, 38, rue du Moulin.

R.C.S. Luxembourg B 147.329.

Il résulte d'une cession de parts datée du 18 décembre 2014 que Monsieur Philippe PETIT demeurant 7, Eicherfeld,

L-1462 Luxembourg a cédé 49 parts sociales qu'il détenait dans la société PARIS-LES-BAINS S.à r. l., ayant son siège social
au 38, rue du Moulin, L-5638 Mondorf-les-Bains à Madame Frédérique ANDRESS, demeurant 38, rue du Moulin, L-5638
Mondorf-les-Bains.

La  société  PARIS-LES-BAINS  S.  à  r.  l.  considère  la  présente  cession  comme  dûment  signifiée,  conformément  aux

dispositions de l'article 1690 du Code Civil, respectivement de l'article 190 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales telle que modifiée.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208416/17.
(140232535) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11096

L

U X E M B O U R G

Nucco 4 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 174.389.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014208352/10.
(140232279) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

THOMAS COOK succursale Luxembourg, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1930 Luxembourg, 74, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 154.915.

FERMETURE D'UNE SUCCURSALE

<i>Extrait de la résolution du comité de direction de la maison mère du 25 novembre 2014

Il est décidé de fermer la succursale sise au 74, avenue de la Gare, L-1930 Luxembourg.

Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Référence de publication: 2014208353/11.
(140232997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Obika Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 158.249.

EXTRAIT

Lors l'assemblée générale annuelle des actionnaires tenue en date du 15 décembre 2014, les actionnaires ont décidé

d'adopter la résolution suivante:

1. Le mandat de Deloitte Audit en tant que réviseur d'entreprises agréé a été renouvelé jusqu'à l'assemblée générale

des actionnaires qui doit se tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
Signature
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014208356/16.
(140232179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

PeaksideWert 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 131.652.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 19 décembre 2014, l'associé unique a décidé de prononcer la

clôture de la liquidation de la Société

L'Assemblée a décidé que les livres et documents sociaux de la Société seront déposés et conservés pendant une

durée de cinq ans à l'adresse suivante:

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

FIDES (Luxembourg) S.A.
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014208390/17.
(140233310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

11097

L

U X E M B O U R G

Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp., Société en Commandite spéciale.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 193.184.

<i>Excerpts of the limited partnership agreement (the “Limited Partnership Agreement”) of Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp,,

<i>a special limited partnership, executed on 30 

<i>th

<i> of December 2014

1. Partners who are jointly and severally liable. Digital Services XXIX (GP) S.à r.l., a société à responsabilité limitée

incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 5, Heienhaff,
L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register
under number B 188570 (the “General Partner”).

2. Name, Partnership’s Purpose, Registered Office, Business Year.
(i) Name
The special limited partnership shall have the name: Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp, (the “Partnership”).
(ii) Purpose
The purpose of the Partnership is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies, limited partnerships or other arrangements and in any other form of investment, the acquisition by purchase,
subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and
the administration, management, control and development of its portfolio in order to further the development, marketing
and provision of internet services through foreign subsidiaries (ecommerce covering goods and services of different kinds)
and the provision through its foreign subsidiaries of logistic services, digital services and all other services relating to the
aforementioned business.

The Partnership may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds

a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Partnership.

The Partnership is entitled to pursue any and all activities which directly or indirectly serve its purpose. The Partnership

exercises any and all rights and obligations which pertain to any shares or interests in other companies.

(iii) Registered Office
The Partnership shall have its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
(iv) Business Year
The business year of the Partnership shall be the calendar year.

3. Designation of the manager and signatory powers. The management of the Partnership is incumbent upon the

General Partner.

The General Partner shall manage the Partnership on the basis of the provisions of the Partnership Agreement and

otherwise in the best interest of the Partnership. Any liability of the General Partner vis-à-vis the Partnership or its
Partners shall be limited to willful misconduct (dol) and gross negligence (négligence grave).

The Partnership is validly bound vis-à-vis third parties by the signature of the General Partner that represents it.

4. Date on which the Partnership commences and the date on which it ends. The Partnership commences as from 30

th

 of December 2014, for an indefinite term.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

<i>Auszüge aus dem Gesellschaftsvertrag (dem „Limited Partnership Agreement“) der Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp,, einer

<i>Partnerschaftsgesellschaft nach Luxemburgischen Recht (Special Limited Partnership), geschlossen am 30. Dezember 2014

1. Gesellschafter, die unmittelbar und gesamtschuldnerisch haften. Digital Services XXIX (GP) S.à r.l., eine Gesellschaft

mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), welche den Bestimmungen des Gesetzes des Großherzogtums
Luxemburg unterliegt, mit Geschäftssitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen
im  Luxemburger  Handels-  und  Gesellschaftsregister  (Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés)  unter  der  Nummer  B
188570 (die „Komplementärin“).

2. Name, Zweck der Gesellschaft, Sitz, Geschäftsjahr.
(i) Name
Die Gesellschaft heißt: Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp, (die „Gesellschaft“)
(ii) Zweck der Gesellschaft
Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesell-

schaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form, die Verwaltung, Kontrolle und
Entwicklung ihrer Beteiligungen im Hinblick auf die Entwicklung, das Marketing und die Erbringung von Internetdienst-
leistungen  durch  ausländische  Tochtergesellschaften  (im  Bereich  ECommerce  bezüglich  Waren  und  Dienstleistungen

11098

L

U X E M B O U R G

jeglicher Art) sowie die Erbringung von Logistikdienstleistungen, Digitaldienstleistungen und allen anderen Dienstleistun-
gen, die mit der zuvor genannten Geschäftstätigkeit im Zusammenhang stehen.

Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder die der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, Garantien geben, Sicher-
heiten einräumen, Darlehen gewähren oder die Gesellschaften auf jede andere Weise unterstützen.

Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt ihrem Zweck dienen. Die Gesellschaft kann

jegliche Rechte und Pflichten in Bezug auf Beteiligungen an anderen Gesellschaften ausüben.

(iii) Sitz
Der Sitz der Gesellschaft ist in der rue 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
(iv) Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr wird das Kalenderjahr sein.

3. Wahl des Geschäftsführers und Zeichnungsbefugnisse. Die Geschäftsführung der Gesellschaft obliegt der amtie-

renden Komplementärin.

Die Komplementärin wird die Gesellschaft auf Basis der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages oder in sonstiger

Weise bestmöglich im Interesse der Gesellschaft führen. Jede Haftung der Komplementärin gegenüber der Gesellschaft
wird auf Fälle des Vorsatzes (dol) und der groben Fahrlässigkeit (négligence grave) beschränkt.

Die Gesellschaft wird durch die Unterschrift der Komplementärin, durch welche die Gesellschaft repräsentiert wird,

rechtskräftig gegenüber Dritten verpflichtet.

4. Anfang und Enddatum der Gesellschaft. Die Gesellschaft wird am 30. Dezember 2014 für eine unbegrenzte Dauer

gegründet

Référence de publication: 2015000169/77.
(140235290) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

BSO Network Solutions Luxembourg S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1931 Luxembourg, 45, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 193.170.

STATUTS

L’an deux mille quatorze, le premier jour du mois de décembre.
Par devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

A COMPARU:

La société BSO Holding Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 45, Avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en cours d’immatriculation auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg,

ici représentée par Monsieur Stéphane ALLART, expert-comptable, directeur de société, avec adresse professionnelle

au 45, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, en vertu d’une procuration lui délivrée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire de la partie comparante et le notaire ins-

trumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l’enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d’acter de la façon suivante

les statuts d’une société à responsabilité limitée qui est ainsi constituée:

Art. 1 

er

 .  Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois relatives à une telle entité (ci-

après “La Société”), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-
après “La Loi”), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après “les Statuts”), lesquels spécifient en leurs articles 7, 10, 11
et 14, les règles exceptionnelles s’appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Art. 2. La société prend la dénomination de «BSO Network Solutions S.à r.l.».

Art. 3.
3.1 L'objet de la Société est l’acquisition de participations, tant au Luxembourg qu'à l’étranger, sous quelque forme

que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut en particulier acquérir par voie de souscription, achat,
échange ou d'une quelconque autre manière des actions, parts ou autres valeurs mobilières, obligations, bons de caisse,
certificats  de  dépôts  et  autres  instruments  de  dettes  et  plus  généralement  toutes  valeurs  mobilières  et  instruments
financiers émis par un émetteur public ou privé quel qu'il soit. Elle pourra participer dans la création, le développement,
la gestion et le contrôle de toute société ou entreprise.

3.2 La société a également pour objet toute activité se rapportant à l’informatique au sens le plus large et plus spéci-

fiquement à la fourniture de transit IP et vidéo ainsi que les activités d’hébergement.

11099

L

U X E M B O U R G

3.3 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, excepté par voie d'offre publique. Elle peut émettre

sous forme de placement privé uniquement, des titres, obligations, et tous titres de dettes et/ou de valeurs mobilières.
La Société peut accorder tous crédits y compris les intérêts de prêts et/ou par l’émission de valeurs mobilières à ses
entités affiliées. Elle peut aussi apporter des garanties en faveur de tiers afin d'assurer ses obligations ou les obligations
de ses entités affiliées. La Société peut en outre mettre en gage, transférer, encombrer ou autrement créer une garantie
sur certains de ses actifs.

3.4 La Société peut également constituer, acquérir, mettre en valeur, vendre, établir des contrats de licence, échanger

ou s'intéresser de toute autre manière à tous brevets, marques et tous autres droits intellectuels et immatériels ainsi qu'à
tous autres droits s'y rattachant ou pouvant les compléter.

3.5 La Société peut, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit à l’étranger, réaliser directement ou indirectement

toutes opérations liées à des biens immobiliers et des droits y attachés, y compris mais ne se limitant pas à l’acquisition,
le développement, la vente, la gestion et/ou la location de biens immobiliers et des droits y attachés.

3.6. La Société peut accomplir toutes opérations commerciales ou financières se rapportant à ses biens meubles ou

immeubles, directement ou indirectement liées à son objet.

Art. 4. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 5. Le siège social est établi à Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une délibération de l’assemblée

générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des statuts.

L’adresse du siège social peut-être déplacée à l’intérieur de la commune par simple décision du gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l’étranger.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), divisé en douze mille cinq cents (12.500)

parts sociales de un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

La société peut racheter ses propres parts sociales.
Toutefois, si le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne peut être

décidé que dans la mesure où des réserves distribuables sont disponibles en ce qui concerne le surplus du prix d'achat.
La décision des associés de racheter les parts sociales sera prise par un vote unanime des associés représentant cent pour
cent du capital social, réunis en assemblée générale extraordinaire et impliquera une réduction du capital social par
annulation des parts sociales rachetées.

Art. 7. Sans préjudice des prescriptions de l’article 6, le capital peut-être modifié à tout moment par une décision de

l’associé unique ou par une décision de l’assemblée générale des associés, en conformité avec l’article 14 des présents
Statuts.

Art. 8. Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec

le nombre des parts sociales existantes.

Art. 9. Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

Art. 10. Dans l’hypothèse où il n’y a qu'un seul associé les parts sociales détenues par celui-ci sont librement trans-

missibles.

Dans l’hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales détenues par chacun d’entre eux ne sont transmissibles

que moyennant l’application de ce qui est prescrit par l’article 189 de la Loi.

Art. 11. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l’insolvabilité ou de la

faillite de l’associé unique ou d’un des associés.

Art. 12. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Les gérants ne sont pas obligatoirement associés. Les gérants sont révocables ad nutum.

Dans les rapports avec les tiers, les gérants ont tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et

approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent article aient été
respectés.

Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

La Société sera engagée par la seule signature du gérant unique, et, en cas de pluralité de gérants, par la signature

conjointe de l’ensemble des membres du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

11100

L

U X E M B O U R G

En cas de pluralité de gérants, les résolutions du conseil de gérance seront adoptées à l’unanimité des gérants présents

ou représentés.

Art. 13. Le ou les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux

engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

Art. 14. L’associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l’assemblée générale des associés.
En cas de pluralité d’associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quelque soit le nombre de

part qu'il détient. Chaque associé possède des droits de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les
décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus
de la moitié du capital.

Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts de la Société ne peuvent être adoptés que par une majorité d’associés

détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

Art. 15. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre.

Art. 16. Chaque année, à la fin de l’année sociale, les comptes de la Société sont établis et le gérant, ou en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance, prépare un inventaire comprenant l’indication de la valeur des actifs et passifs
de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance desdits inventaires et bilan au siège social.

Art. 17. Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortis-

sements et charges constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution d'un
fonds de réserve jusqu'à celui-ci atteigne dix pour cent du capital social.

Le solde des bénéfices nets peut être distribué aux associés en proportion avec leur participation dans le capital de la

Société.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués à tout moment, sous réserve du respect des conditions suivantes:
1. Des comptes intérimaires doivent être établis par le gérant ou par le conseil de gérance,
2. Ces comptes intérimaires, les bénéfices reportés ou affectés à une réserve extraordinaire y inclus, font apparaître

un bénéfice,

3. L'associé unique ou l’assemblée générale extraordinaire des associés est seul(e) compétent(e) pour décider de la

distribution d'acomptes sur dividendes.

4. Le paiement n'est effectué par la Société qu'après avoir obtenu l’assurance que les droits des créanciers ne sont pas

menacés.

Art. 18. Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés

ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Art. 19. Pour tout ce qui ne fait pas l’objet d’une prévision spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la

Loi.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

L’associé fondateur déclare souscrire l’intégralité des parts comme suit:

BSO Holding Luxembourg S.à r.l., pré-désignée . . . . . . . . . . . . . . . . . douze mille cinq cents (12.500) parts sociales
TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . douze mille cinq cents (12.500) parts sociales

Le fondateur a déclaré libérer intégralement toutes les parts sociales par un apport en numéraire d’un montant de

douze mille cinq cents euros (EUR 12.500).

Le montant de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500) est à la disposition de la Société, comme il a été prouvé au

notaire instrumentant qui le reconnaît expressément.

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à environ mille cent euros (EUR 1.100,-).

11101

L

U X E M B O U R G

<i>Décisions de l'associé unique

Immédiatement après la constitution de la société, l’associé, représentant la totalité du capital souscrit, a pris les

résolutions suivantes:

1) La Société est administrée pour une durée illimitée par le gérant unique suivant:
- Monsieur Charles-Antoine BEYNEY, Administrateur de Sociétés, né le 29 septembre 1982 à F - Bordeaux, demeurant

1, Beauchamps Place F5, UK - London SW31NG,

2) L'adresse de la Société est fixée à L-1931 Luxembourg, 45, Avenue de la Liberté.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, le prédit mandataire a signé le

présent acte avec le notaire.

Signé: S. ALLART, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 04 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57716. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015000102/156.
(140234853) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 décembre 2014.

Join Expérience S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 176.835.

In the year two thousand and fourteen.
On the twenty-second of December.
Before us the undersigned notary Henri BECK, residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of shareholders of the company JOIN EXPERIENCE S.A., a public limited liability

company (société anonyme), having its registered office at L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register under the number B 176835 (NIN 2013 2206 970), (the "Company"),

incorporated under the initial name BLUE communications S.A. by deed of the undersigned notary on the 22 

nd

 of

April 2013, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 1441 of June 18, 2013.

The articles of association of the Company have been amended for the last time on the 5 

th

 of November 2013 pursuant

to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, which has been published in the Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations number 3175 on the 13 

th

 December 2013.

The Company has a corporate capital of five million Euro (EUR 5,000,000.-), represented by fifty thousand (50,000)

registered class A shares and fifty thousand (50,000) registered class B shares, all with a nominal value of fifty Euro (EUR
50.-) each.

The Meeting is chaired by Mr Jos GLOD, functionary, residing professionally in Luxembourg,
The Chairman appoints as secretary of the Meeting Mrs Vanessa MOROLLI, lawyer, residing professionally in Luxem-

bourg,

The Meeting elects as scrutineer of the Meeting Mr Frank FISCHER, private employee, residing professionally in Lu-

xembourg.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:
That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an

attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy holders, shall remain annexed to this
document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting

can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads

as follows:

11102

L

U X E M B O U R G

<i>Agenda

1.- a) Increase of the corporate capital by the amount of FOUR MILLION EURO (EUR 4,000,000.-) so as to raise it

from its present amount of FIVE MILLION EURO (EUR 5,000,000.-) to the amount of NINE MILLION EURO (EUR
9,000,000.-) by the issue of forty thousand (40,000) new class A shares and forty thousand (40,000) new class B shares,
all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

b) Subscription of forty thousand (40,000) new class A shares by the existing class A shareholders in proportion to

their participation in the corporate capital and partially paying up of the new shares, up to twenty-five percent (25%), by
a payment in cash of the amount of FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 500,000.-).

c) Subscription of forty thousand (40,000) new class B shares by the existing class B shareholders in proportion to

their participation in the corporate capital and fully paying up of the new shares by a payment in cash of the amount of
TWO MILLION EURO (EUR 2,000,000.-).

2.- Amendment of the paragraph 5.1. of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ 5.1. The share capital of the Company is set at nine million Euro (EUR 9,000,000.-) represented by ninety thousand

(90,000) class A shares (the «Class A Shares») and ninety thousand (90,000) class B shares (the «Class B Shares»), all
with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each. “

3.- Miscellaneous.
After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote.

<i>First resolution

<i>a) Increase of the corporate capital

The meeting decides to increase the corporate capital by the amount of FOUR MILLION EURO (EUR 4,000,000.-) so

as to raise it from its present amount of FIVE MILLION EURO (EUR 5,000,000.-) to the amount of NINE MILLION EURO
(EUR 9,000,000.-) by the issue of forty thousand (40,000) new class A shares and forty thousand (40,000) new class B
shares, all vested with the same rights and obligations as the existing shares.

<i>b) Subscription and payment

The forty thousand (40,000) new class A shares have been subscribed and partially paid up by the existing class A

shareholders, in proportion to their participation in the corporate capital, up to twenty-five percent (25%), by a payment
in cash of the amount of FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 500,000.-).

The forty thousand (40,000) new class B shares have been subscribed and fully paid up by the existing class B share-

holders, in proportion to their participation in the corporate capital, by a payment in cash of the amount of TWO MILLION
EURO (EUR 2,000,000.-).

The amount of TWO MILLION FIVE HUNDRED THOUSAND EURO (EUR 2,500,000.-) is forthwith at the free

disposal of the public limited company JOIN EXPERIENCE S.A. as has been proved to the notary by a bank certificate,
who states it expressly.

<i>Second resolution

The meeting decides to amend paragraph 5.1. of article 5 of the articles of incorporation to give it the following reading:

“ 5.1. The share capital of the Company is set at nine million Euro (EUR 9,000,000.-) represented by ninety thousand

(90,000) class A shares (the «Class A Shares») and ninety thousand (90,000) class B shares (the «Class B Shares»), all
with a nominal value of fifty Euro (EUR 50.-) each. “

<i>Third resolution

The meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes

and hereby empowers and authorises any director of the Company to, with full power of substitution, under their sole
signature, proceed in the name and on behalf of the Company, to the registration in the register of shareholders of the
Company (including for the avoidance of any doubt the signature of the said register) of the changes mentioned under
the resolutions above.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

<i>Declaration

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties,
in case of discrepancies between the English and the French texts, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames,

first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original
deed.

11103

L

U X E M B O U R G

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze.
Le vingt-deux décembre.
Pardevant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société JOIN EXPERIENCE S.A., une société anonyme, ayant

son siège social à L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxem-
bourg sous le numéro B 176835 (NIN 2013 2206 970), (la "Société"),

constituée sous la dénomination initiale BLUE communications S.A. suivant acte reçu par le notaire instrumentant en

date du 22 avril 2013, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 1441 du 18 juin 2013.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 5 novembre 2013 en vertu d'un acte de Maître Henri

Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, publié au Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations numéro 3175 du
13 décembre 2013.

La Société a un capital social de CINQ MILLIONS D'EUROS (EUR 5.000.000,-), représenté par CINQUANTE MILLE

(50.000) actions nominatives de catégorie A et CINQUANTE MILLE (50.000) actions nominatives de catégorie B, ayant
toutes une valeur nominale de CINQUANTE EUROS (EUR 50,-) chacune.

L’Assemblée se déroule sous la présidence de Monsieur Jos GLOD, fonctionnaire, demeurant professionnellement à

Luxembourg, Le président nomme comme secrétaire Madame Vanessa MOROLLI, juriste, demeurant professionnelle-
ment  à  Luxembourg,  L’Assemblée  nomme  comme  scrutateur  Monsieur,  Frank  FISCHER,  employé  privé,  demeurant
professionnellement à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
Les actionnaires présents ou représentés à l’assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été

portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés,
demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l’intégralité du capital social est régulièrement

constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objets portés à l’ordre du jour, qui est conçu
comme suit:

<i>Ordre du jour

1.- a) Augmentation du capital social d'un montant de QUATRE MILLIONS D'EUROS (EUR 4.000.000.-) pour le porter

de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (EUR 5.000.000.-) au montant de NEUF MILLIONS D'EUROS
(EUR 9.000.000.-) par la création de quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie A et quarante mille (40.000)
actions nouvelles de catégorie B, toutes jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

b) Souscription des quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie A par les actionnaires de catégorie A exi-

stants au prorata de leur participation dans le capital social et libération partielle des nouvelles actions, à hauteur de
vingtcinq pourcent (25%), par un versement en numéraire du montant de CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000.-).

c) Souscription des quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie B par les actionnaires de catégorie B existants

au prorata de leur participation dans le capital social et libération intégrale des nouvelles actions par un versement en
numéraire du montant de DEUX MILLIONS D'EUROS (EUR 2.000.000.-).

2.- Modification de l’alinéa 5.1.de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions d'Euros (EUR 9.000.000,-), représenté par quatre-vingt-dix

mille (90.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et quatre-vingt-dix mille (90.000) actions de catégorie
B (les «Actions de Catégorie B»), ayant toutes une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune. "

3.- Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l’assemblée, cette dernière, après délibération, prend à l’unanimité les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

<i>a) Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant de QUATRE MILLIONS D'EUROS (EUR 4.000.000.-)

pour le porter de son montant actuel de CINQ MILLIONS D'EUROS (EUR 5.000.000.-) au montant de NEUF MILLIONS
D'EUROS (EUR 9.000.000.-) par la création de quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie A et quarante mille
(40.000) actions nouvelles de catégorie B, toutes jouissant des mêmes droits et obligations que les actions existantes.

<i>b) Souscription et libération

Les quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie A ont été souscrites et partiellement libérées par les ac-

tionnaires de catégorie A existants au prorata de leur participation dans le capital social, à hauteur de vingt-cinq pourcent
(25%), par un versement en numéraire du montant de CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 500.000.-).

11104

L

U X E M B O U R G

Les quarante mille (40.000) actions nouvelles de catégorie B ont été souscrites et entièrement libérées par les ac-

tionnaires de catégorie B existants au prorata de leur participation dans le capital social par un versement en numéraire
du montant de DEUX MILLIONS D'EUROS (EUR 2.000.000.-).

La somme de DEUX MILLIONS CINQ CENT MILLE EUROS (EUR 2.500.000.-) se trouve dès à présent à la libre

disposition de la société anonyme JOIN EXPERIENCE S.A., ainsi qu'il en a été justifié au notaire par une attestation
bancaire, qui le constate expressément.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de modifier l’alinéa 5.1. de l’article 5 des statuts afin de lui donner la teneur suivante:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à neuf millions d'Euros (EUR 9.000.000,-), représenté par quatre-vingt-dix

mille (90.000) actions de catégorie A (les «Actions de Catégorie A») et quatre-vingt-dix mille (90.000) actions de catégorie
B (les «Actions de Catégorie B»), ayant toutes une valeur nominale de cinquante Euros (EUR 50,-) chacune. "

<i>Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier le registre des actionnaires de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et

donne pouvoir et autorité à tout administrateur de la Société, avec tous pouvoirs de substitution, afin de procéder au
nom et pour le compte de la Société, à l’inscription au registre des actionnaires de la Société (y compris, afin éviter tout
doute, la signature dudit registre) des changements mentionnés dans les résolutions ci-dessus.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française, à la requête des mêmes personnes et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version française fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et

demeures, ils ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: J. GLOD, V. MOROLLI, F. FISCHER, Henri BECK.
Enregistré à Echternach, le 24 décembre 2014. Relation: ECH/2014/2662. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 30 décembre 2014.

Référence de publication: 2014209294/172.
(140234080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

Highstreet II PropCo II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 35, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 193.141.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the sixteenth day of December.
Before, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy

of Luxembourg, having a share capital of EUR 100,000 (one hundred thousand Euro), with registered office at L-2163
Luxemburg, 35, avenue Monterey, Grand Duchy of Luxembourg, and in the process of registration with the Luxembourg
Register of Commerce and Companies,

here represented by Mr Patrick Chantrain, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a

power of attorney, given in Luxembourg on 16 December 2014.

Said proxy, after having been initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated.

Art. 1. Name. There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "HIGHS-

TREET II PropCo II S.à r.l." (the Company).

11105

L

U X E M B O U R G

Art. 2. Corporate object. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in

Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any
other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration,
control and development of its portfolio.

In addition, the Company may acquire and sell real estate properties, for its own account, either in the Grand Duchy

of Luxembourg or abroad and it may carry out all operations relating to real estate properties, including the direct or
indirect holding of participations in Luxembourg or foreign companies, the principal object of which is the acquisition,
development, promotion, sale, management and/or lease of real estate properties.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or

indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplish-

ment of these purposes.

Art. 3. Duration. The Company is formed for an unlimited period of time.

Art. 4. Registered office. The registered office is established in Luxembourg.
It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders. It may be transferred within the boundaries of the municipality by a resolution
of the manager/board of managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

Art. 5. Share capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro),

represented by 35,000 (thirty-five thousand) shares having a par value of EUR 1.- (one Euro) per share.

Art. 6. Amendments to the share capital. The share capital may be changed at any time by a decision of the sole

shareholder or by decision of the shareholder meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 7. Profit sharing. Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct

proportion to the number of shares in existence.

Art. 8. Indivisible shares. Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted

per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 9. Transfer of shares. In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely

transferable.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorized by the general

meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No such au-
thorization is required for a transfer of shares among the shareholders.

The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-

quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

The requirements of articles 189 and 190 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as

amended (the Companies Act) will apply.

Art. 10. Redemption of shares. The Company shall have power to acquire shares in its own capital provided that the

Company has sufficient distributable reserves or funds to that effect.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of

a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of
the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall
apply in accordance with article 15 of these articles of association.

Art. 11. Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders. The death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company.

Art. 12. Management. The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed,

they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) are appointed,
revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more
than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager

or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in all circumstances in the name and on behalf

of the Company and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided
the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of the share-

holders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

11106

L

U X E M B O U R G

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in the case of plurality of managers, by the

sole signature of any member of the board of managers.

The manager, or in case of plurality of managers, any manager may subdelegate his powers for specific tasks to one

or several ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating manager will determine this
agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant
conditions of his agency.

In case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the

managers present or represented. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its
members are present or represented at a meeting of the board of managers.

A chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting

of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he
has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the
majority of the managers present or represented at the board meeting.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers,

in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such
meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by any manager.
This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed
on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places
prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-

mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference
call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting
to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by
other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting
and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of
managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by any managers
attending the board meeting, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will
remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the

minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The
date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way
of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

Art. 13. Liability of the manager(s). The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their

position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

Art. 14. General meetings of the shareholders. An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the

registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in
the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective

notices of meeting.

As long as the Company has no more than twenty-five (25) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead

of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be
sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or
telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

Art. 15. Shareholders' voting rights, quorum and majority. The sole shareholder assumes all powers conferred to the

general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions
are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company may only be adopted by the majority in

number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the
Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

Art. 16. Financial year. The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

Art. 17. Financial statements. Each year, with reference to 31 st December, the Company's accounts are established

and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication
of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

11107

L

U X E M B O U R G

Art. 18. Appropriation of profits, reserves. The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent
(5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent
(10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting shall determine how the remainder of the annual net
profits will be disposed of. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay
interim dividends.

Art. 19. Liquidation. At the time of winding up of the Company the liquidation will be carried out by one or several

liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

Art. 20. Statutory auditor - External auditor. In accordance with article 200 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 25 (twenty-five) shareholders. An approved independent
auditor (réviseur d’entreprises agréé) needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the
Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial
accounts of companies, as amended does not apply.

Art. 21. Reference to legal provisions. Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for

which no specific provision is made in these articles of association.

<i>Subscription and Payment

All shares have been subscribed as follows:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,000 (thirty-five thousand) shares

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 35,000.- (thirty-five thousand Euro)

is at the free disposal of the Company; evidence of which has been given to the undersigned notary.

<i>Transitory Provisions

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2015.

<i>Estimate of costs

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euro (EUR 1,200,-).

<i>Extraordinary General Meeting

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company

has herewith adopted the following resolutions:

1. the number of managers is set at 1 (one). The sole shareholder appoints as sole manager of the Company for an

unlimited period of time:

Matthias Sprenker, born on 21 February 1954 in Mülheim an der Ruhr (Germany), with professional address at L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; and

2. the registered office is established at L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party,
in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.
In witness whereof, the undersigned notary, has signed on the date and year first hereabove mentioned.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party

signed together with, the notary, the present original deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am sechzehnten Dezember.
Vor Maître Edouard DELOSCH, Notar mit Amtswohnsitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg.

IST ERSCHIENEN:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l., eine société à responsabilité limitée luxemburgischen Rechts, dessen Ge-

sellschaftskapital EUR 100.000,- (einhunderttausend Euro) beträgt, mit Gesellschaftssitz in L-2163 Luxemburg, 35, avenue
Monterey,  Großherzogtum  Luxemburg,  und  in  der  Registrierungsprozedur  beim  Luxemburger  Handels-  und  Gesell-
schaftsregister,

vertreten durch Herrn Patrick Chantrain, avocat à la Cour, mit Berufsanschrift in Luxemburg, aufgrund einer Vollmacht

unter Privatschrift, ausgestellt in Luxemburg, am 16. Dezember 2014.

11108

L

U X E M B O U R G

Die Vollmacht wird, nach Unterzeichnung ne varietur durch den Vertreter der Erschienenen und den unterzeichneten

Notar dieser Urkunde als Anlage beigefügt und zusammen mit dieser zur Eintragung eingereicht.

In ihrer oben angegebenen Eigenschaft ersucht die Erschienene den unterzeichneten Notar, die Satzung der Gesell-

schaft mit beschränkter Haftung, die sie hiermit gründet, wie folgt zu beurkunden.

Art. 1. Name. Es besteht hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) unter

der Bezeichnung..HIGHSTREET II PropCo II S.à r.l... (die Gesellschaft).

Art. 2. Gesellschaftszweck. Zweck der Gesellschaft ist, Beteiligungen an luxemburgischen oder ausländischen Gesell-

schaften in welcher Form auch immer und alle anderen Arten von Investitionen vorzunehmen im Wege des Erwerbs oder
der Veräußerung von Wertpapieren durch Kauf oder Verkauf, Tausch oder durch Zeichnung oder in jeder anderen Art
und Weise, sowie die Verwaltung, Kontrolle und Verwertung ihres Portfolios.

Die Gesellschaft darf außerdem auf eigene Rechnung in Luxemburg und im Ausland Immobilien erwerben und veräu-

ßern, und sie darf alle Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Immobiliengeschäften stehen, ausführen, unter anderem
direkte oder indirekte Beteiligungen an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften halten, deren Hauptzweck der
Erwerb und die Veräußerung, aber auch die Verwaltung, Vermietung von Immobilien und die Durchführung von Baupro-
jekten ist.

Die Gesellschaft darf Kredite an Gesellschaften vergeben, an denen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung hält,

sowie an Gesellschaften, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder diese Gesellschaften in einer anderen Art
und Weise unterstützen.

Die Gesellschaft darf alle Aktivitäten kommerzieller, industrieller und finanzieller Natur ausführen, die direkt oder

indirekt in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen oder den Gesellschaftszweck fördern.

Art. 3. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Art. 4. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg.
Durch einfachen Beschluss der Gesellschafterversammlung kann der Sitz an jeden anderen Ort im Großherzogtum

Luxemburg verlegt werden.

Er kann innerhalb der Gemeinde durch einfachen Beschluss des Geschäftsführers oder des Geschäftsführerrats verlegt

werden.

Die Gesellschaft kann Büros und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten und unterhalten.

Art. 5. Kapital der Gesellschaft. Das Gesellschaftskapital beträgt EUR 35.000 (fünfunddreizigtausend Euro), eingeteilt

in 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile mit einem Nennwert von je EUR 1,- (ein Euro) pro Anteil.

Art. 6. Änderungen des Gesellschaftskapitals. Das Gesellschaftskapital kann jederzeit gemäß Artikel 15 dieser Satzung

durch einen Beschluss des Alleingesellschafters oder der Gesellschafterversammlung geändert werden.

Art. 7. Gewinnbeteiligung. Jedem Anteil entspricht ein im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Anteile stehendes Anrecht

auf die Aktiva und die Gewinne der Gesellschaft.

Art. 8. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind einzelne Anteile unteilbar; pro Anteil erkennt die

Gesellschaft nur einen Inhaber an. Mitinhaber müssen gegenüber der Gesellschaft eine einzige Person als ihren Vertreter
benennen.

Art. 9. Übertragung von Gesellschaftsanteilen. Anteile eines Alleingesellschafters sind frei übertragbar.
Bei mehreren Gesellschaftern kann die Übertragung von Anteilen auf Dritte im Wege eines Rechtsgeschäfts unter

Lebenden nur mit Genehmigung durch die Gesellschafterversammlung erfolgen, wobei für eine solche Genehmigung eine
Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten. Für die
Übertragung von Anteilen unter Gesellschaftern der Gesellschaft bedarf es einer solchen Genehmigung nicht.

Die Übertragung der Anteile an Dritte im Falle des Todes eines Gesellschafters bedarf der Zustimmung von mindestens

drei Vierteln der überlebenden Gesellschafter.

In jedem Fall müssen die Bestimmungen der Artikel 189 und 190 des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915

über die Handelsgesellschaften (Gesetz von 1915) eingehalten werden.

Art. 10. Rückkauf von Anteilen. Die Gesellschaft ist ermächtigt, Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital zu kaufen,

soweit sie über genügend verfügbare Reserven verfügt.

Die Gesellschaft kann Anteile an ihrem eigenen Gesellschaftskapital nur auf Grund eines entsprechenden Beschlusses

durch die Gesellschafterversammlung bzw. durch einen entsprechenden Alleingesellschafterbeschluss zu den in dem zum
Eigenanteilserwerb ermächtigenden Beschluss festgelegten Bedingungen erwerben oder veräußern. Derartige Beschlüsse
unterliegen hinsichtlich der Beschlussfähigkeit und der erforderlichen Mehrheit den in Artikel 15 der Satzung niederge-
legten Voraussetzungen einer Satzungsänderung.

Art. 11. Tod, Aberkennung der bürgerlichen Rechte, Zahlungsunfähigkeit oder Konkurs der Gesellschafter. Das Be-

stehen der Gesellschaft bleibt unberührt vom Tode, der Aberkennung der bürgerlichen Rechte, der Zahlungsunfähigkeit
oder dem Konkurs eines Gesellschafters. Dies gilt auch im Falle eines Alleingesellschafters.

11109

L

U X E M B O U R G

Art. 12. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Wenn mehrere Geschäftsführer

bestellt werden, bilden sie einen Geschäftsführerrat. Der (die) Geschäftsführer muss (müssen) kein(e) Gesellschafter sein.
Der (die) Geschäftsführer wird (werden) durch die Gesellschafterversammlung ernannt, abberufen und ersetzt, wobei
eine Mehrheit nach Stimmen erreicht werden muss, die mindestens die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertritt.

Die  Gesellschafterversammlung  kann  jederzeit  den  Geschäftsführer,  oder  wenn  mehrere  Geschäftsführer  bestellt

wurden, jeden von ihnen ad nutum (ohne Angabe von Gründen) abberufen und ersetzen.

Der oder die Geschäftsführer haben umfassende Vertretungsmacht, die Gesellschaft gegenüber Dritten zu vertreten

und alle Handlungen und Geschäfte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen, auszuführen, sofern die
Regelungen dieses Artikels 12 beachtet werden.

Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern, der Geschäftsführerrat, ist zuständig in allen

Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich durch Gesetz oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung zuge-
wiesen sind.

Wenn die Gesellschaft nur einen Geschäftsführers hat, wird sie durch die Unterschrift des Geschäftsführers verpflich-

tet; bei Mehrheit von Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers
verpflichtet.

Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder, im Fall einer Mehrheit von Geschäftsführern, jeder einzelne

Geschäftsführer kann seine Befugnisse in Anbetracht bestimmter Handlungen an einen oder mehrere ad-hoc-Bevoll-
mächtigte delegieren. Die Gesellschafterversammlung, der Geschäftsführer, oder im Fall von mehreren Geschäftsführern,
der jeweilige oder die jeweiligen Geschäftsführer, der (die) seine (ihre) Befugnisse delegiert (delegieren), legt (legen) die
Verantwortlichkeiten und die Vergütung des Bevollmächtigten (wenn das Mandat vergütet wird), die Dauer der Bevoll-
mächtigung und alle anderen relevanten Bedingungen fest.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, werden die Beschlüsse des Geschäftsführerrates mit der

Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Wenn die Gesellschaft
mehrere Geschäftsführer hat, können Beschlüsse nur gefasst werden und kann der Geschäftsführerrat nur handeln, wenn
mehr als die Hälfte der Geschäftsführer anwesend oder vertreten ist.

Der Geschäftsführerrat darf einen Vorsitzenden auf Zeit für jede Sitzung des Geschäftsführerrates wählen. Sofern ein

Vorsitzender gewählt worden ist, führt dieser den Vorsitz der Sitzung, für die er gewählt wurde. Der Vorsitzende auf
Zeit, sofern einer gewählt worden ist, wird von der Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer gewählt.

Wenn die Gesellschaft mehr als einen Geschäftsführer hat, muss jede Sitzung wenigstens 24 (vierundzwanzig) Stunden

im Voraus schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gegenüber jedem Geschäftsführer einberufen werden, außer im Falle von
Dringlichkeit. Eine Sitzung des Geschäftsführerrates kann von jedem Geschäftsführer einzeln einberufen werden. Wenn
alle Geschäftsführer, ob anwesend oder vertreten, in der Sitzung erklären, dass sie über die Tagesordnung informiert
wurden, kann auf die Einberufung verzichtet werden. Wenn eine Sitzung des Geschäftsführerrates zu einer Zeit und an
einem Ort abgehalten wird, die vorher in einem Beschluss des Geschäftsführerrates festgelegt wurden, ist eine gesonderte
Einberufung entbehrlich.

Jeder Geschäftsführer kann sich vertreten lassen, indem er per Brief, Fax oder E-Mail einen anderen Geschäftsführer

zu seinem Vertreter bestellt. Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung per Telefonkonferenz, Videokonferenz oder
durch jedes andere ähnliche Kommunikationsmittel, das es den an der Sitzung teilnehmenden Geschäftsführern erlaubt,
persönlich ausgewiesen an der Sitzung und an ihrer Beratung teilzunehmen. Ein Geschäftsführer, der an einer Sitzung des
Geschäftsführerrates im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz, oder über jedes andere, ähnliche Kommunikations-
mittel  (wie  oben  beschrieben)  teilnimmt,  gilt  als  persönlich  anwesend;  eine  solche  über  Fernkommunikationsmittel
abgehaltene Sitzung gilt als am Sitz der Gesellschaft abgehalten. Die Beschlüsse des Geschäftsführerrates werden in einem
Sitzungsprotokoll festgehalten, welches am Sitz der Gesellschaft aufbewahrt wird und von den an der Sitzung teilnehm-
enden  oder  vertretenen  Geschäftsführern,  im  Falle  einer  von  einem  Vorsitzenden  geleiteten  Sitzung  von  diesem,
unterschrieben wird. Die Vertretungsvollmachten, sofern diese ausgestellt wurden, sind dem Protokoll als Anlage beizu-
fügen

Ungeachtet der vorhergehenden Bestimmungen können Beschlüsse des Geschäftsführerrates auch auf schriftlichen

Wege gefasst werden (Umlaufbeschlüsse) und aus einem oder mehreren Dokumenten, bestehen die die Beschlüsse ent-
halten, wenn sie von allen Mitgliedern des Verwaltungsrates unterschrieben werden. Als Datum der Beschlussfassung
eines solchen Umlaufbeschlusses gilt das Datum der letzten Unterschrift. Ein Umlaufbeschluss gilt als Sitzung, die in Lu-
xemburg stattgefunden hat.

Art. 13. Verbindlichkeiten des Geschäftsführers/der Geschäftsführer. Der/Die Geschäftsführer (je nachdem) haftet/en

nicht persönlich für im Rahmen ihrer Funktion ordnungsgemäß im Namen der Gesellschaft eingegangene Verbindlichkei-
ten.

Art. 14. Generalversammlung der Gesellschafter. Eine jährliche Generalversammlung des Alleingesellschafters oder

bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter wird am Sitz der Gesellschaft abgehalten, oder an jedem an-
deren in der Gemeinde des Gesellschaftssitzes befindlichen Ort, der im Einberufungsschreiben angegeben wird.

Andere Versammlungen des Alleingesellschafters oder bei einer Mehrheit von Gesellschaftern der Gesellschafter kön-

nen jederzeit an jedem beliebigen Ort abgehalten werden, der im jeweiligen Einberufungsschreiben angegeben wird.

11110

L

U X E M B O U R G

Solange die Gesellschaft nicht mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat, dürfen Gesellschafterbeschlüsse schrift-

lich von allen Gesellschaftern gefasst werden, ohne dass es einer Generalversammlung bedarf. In diesem Fall, muss ein
präziser Entwurf des Beschlusses oder der anzunehmenden Beschlüsse an jeden Gesellschafter geschickt werden, und
jeder Gesellschafter gibt seine Stimme schriftlich ab (die Abstimmung kann durch Brief, Fax oder E-Mail erfolgen).

Art. 15. Stimmrecht der Gesellschafter, Beschlussfähigkeit und Mehrheit. Ein Alleingesellschafter vereinigt alle Befug-

nisse der Gesellschafterversammlung auf sich.

Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern hat jeder Gesellschafter das Recht, an gemeinsamen Entscheidungen teil-

zunehmen,  unabhängig  von  seiner  Kapitalbeteiligung.  Jeder  Gesellschafter  hat  so  viele  Stimmen,  wie  Anteile  auf  ihn
entfallen. Im Falle einer Mehrheit von Gesellschaftern werden gemeinsame Beschlüsse rechtskräftig angenommen, wenn
sie durch Gesellschafter, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten, angenommen werden.

Änderungen der Satzung der Gesellschaft können, sofern das Gesetz von 1915 nichts anderes zulässt, jedoch nur durch

eine Stimmenmehrheit von Gesellschaftern verabschiedet werden, welche mindestens drei Viertel des Gesellschaftska-
pitals vertreten; die Änderung der Nationalität der Gesellschaft kann nur einstimmig beschlossen werden.

Art. 16. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar und endet am einunddreißigsten

Dezember eines jeden Jahres.

Art. 17. Finanzberichte. Jedes Jahr zum 31. Dezember werden die Bücher der Gesellschaft für das abgelaufene Ge-

schäftsjahr geschlossen und die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung vom Geschäftsführer oder, im Falle einer
Mehrheit von Geschäftsführern, vom Geschäftsführerrat, aufgestellt.

Jeder Gesellschafter kann am Gesellschaftssitz Einsicht in die Bilanz und in die Gewinn- und Verlustrechnung nehmen.

Art. 18. Gewinnverteilung - Rücklagen. Der Nettogewinn der Gesellschaft errechnet sich aus dem Bruttogewinn nach

Abzug aller Kosten und Abschreibungen. Aus dem Nettogewinn der Gesellschaft sind fünf Prozent (5%) in die Bildung
einer gesetzlichen Rücklage einzubringen, bis diese Rücklage betragsmäßig zehn Prozent (10%) des gezeichneten Gesell-
schaftskapitals erreicht. Die Gesellschafterversammlung entscheidet wie der restliche Jahresreingewinn verwendet wird.
Der Geschäftsführer oder, bei einer Mehrheit von Geschäftsführern die Geschäftsführer, kann bzw. können beschließen,
Zwischendividenden auszuzahlen.

Art. 19. Auflösung - Abwicklung. Nach Auflösung der Gesellschaft wird die Abwicklung durch einen oder mehrere

Liquidatoren, die Gesellschafter sein können, durchgeführt. Der Liquidator bzw. die Liquidatoren werden durch die Ge-
sellschafter unter Festlegung ihrer Befugnisse und Vergütungen ernannt.

Art. 20. Aufsicht und Kontrolle. Gemäß Artikel 200 des Gesetzes von 1915 muss die Gesellschaft einen Wirtschafts-

prüfer (commissaire aux comptes) ernennen, wenn sie mehr als 25 (fünfundzwanzig) Gesellschafter hat. Ein unabhängiger
Wirtschaftsprüfer (réviseur d'entreprises agréé) muss ernannt werden, wenn die Befreiung nach dem Artike 69(2) des
abgeänderten  Gesetzes  vom  19  Dezember  2002  über  das  Handels-  und  Gesellschaftsregister,  wie  abgeändert,  keine
Anwendung findet.

Art. 21. Verweis auf gesetzliche Bestimmungen. Alle Angelegenheiten, die nicht durch die vorliegende Satzung geregelt

werden, unterliegen dem Gesetz von 1915.

<i>Zeichnung und Einzahlung

Die Anteile wurden wie folgt gezeichnet:

Corestate HIGHSTREET II HoldCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 (fünfunddreizigtausend) Anteile

Alle Anteile wurden vollständig in bar eingezahlt, so dass die Summe von EUR 35.000,- (fünfunddreizigtausend Euro)

ab sofort der Gesellschaft zur Verfügung steht; ein entsprechender Nachweis wurde dem unterzeichneten Notar gegen-
über erbracht.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt heute und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft für diese Gründung entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich

auf ungefähr eintausendzweihundert Euro (EUR 1.200,-).

<i>Generalversammlung der Gesellschafter nach der Gründung

Im Anschluss an die Gründung der Gesellschaft hat der alleinige Gesellschafter, der das gesamte gezeichnete Gesell-

schaftskapital auf sich vereinigt, folgende Beschlüsse gefasst:

1. der Geschäftsführerrat hat 1 (ein) Mitglied. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft wird folgende Person

für eine unbestimmte Zeit ernannt:

11111

L

U X E M B O U R G

Herr Matthias Sprenker, geboren am 21. Februar 1954 in Mülheim an der Ruhr (D), mit Berufsanschrift in L-2163

Luxemburg, 35, avenue Monterey; und

2. der Sitz der Gesellschaft wird unter folgender Anschrift festgesetzt: L-2163 Luxemburg, 35, avenue Monterey.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Partei diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im Falle
einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Worüber die vorliegende Urkunde zum eingangs genannten Datum in Luxemburg erstellt wird.
Als Zeuge wovon wir, der unterzeichnete Notar, unsere Unterschrift und unser Siegel unter dem oben genannten

Datum unter diese Urkunde setzen.

Nach Vorlesen und Erklärung alles Vorstehenden haben der Bevollmächtigte der Erschienenen mit uns, dem unter-

zeichneten Notar, die vorliegende Urkunde unterschrieben.

Gezeichnet: P. CHANTRAIN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 18 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16446. Reçu soixante-quinze (75.-) euros

<i>Le Receveur

 (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209241/366.
(140233955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

HAB2 Prop Co. C S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-5326 Luxembourg, 17, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 175.214.

In the year two thousand and fourteen, on the eighteenth day of December.
Before Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, a special limited partnership (société en commandite spéciale)

organized as a specialised investment fund (fonds d'investissement spécialisé), incorporated and existing under the laws
of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of
Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 189.416, represented by
its manager ECE Real Estate Partners S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée), incor-
porated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter,
L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under
number B 157.549 and a share capital of one hundred twenty-five thousand euro (EUR 125,000.-),

here represented by José Maria Ortiz, Director, with professional address at 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern,

by virtue of a power of attorney dated 18 December 2014,

in its capacity as sole shareholder of HAB2 Prop Co. C S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité

limitée), incorporated and existing under the laws of Luxembourg, with registered office at 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500), registered
with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 175.214, incorporated on 8 February 2013 pursuant
to a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg (the Company).

The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to enact the following:
I. ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF is the sole shareholder (the Sole Shareholder) of the Company

and represents the entire share capital of the Company;

II. the Sole Shareholder takes the following resolution:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 3 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 3. Corporate object.
3.1. The purpose of the Company is the acquisition, directly or indirectly, of real estate property in Luxembourg or

abroad, in particular shopping centres, and the holding and managing of the assets required for the management of the
real estate property.

11112

L

U X E M B O U R G

3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation,
the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may also
give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to
guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other
company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial
sector without having obtained the required authorisation.”

<i>Second resolution

The Sole Shareholder, ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, resolves
a) to increase the share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250)

from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500,-) to thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 13,750)
by the issue of one thousand two hundred and fifty (1,250) shares with a par value of one euro (EUR 1,-) each,

b) to subscribe for one thousand two hundred and fifty (1,250) shares in registered form, with a par value of one euro

(EUR 1,-) each, and agrees to pay them in full by a contribution in cash in the amount of one thousand two hundred and
fifty euro (EUR 1,250) and to give evidence to the undersigned notary that the amount of one thousand two hundred
and fifty euro (EUR 1,250) is at the disposal of the Company,

c) to converse and allocate the thirteen thousand seven hundred and fifty (13,750) shares with a par value of one euro

each (EUR 1.-) each into (i) one thousand two hundred and fifty shares (1,250) of ordinary shares, (ii) one thousand two
hundred and fifty shares (1,250) of class A (the “Class A Shares”), (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
of class B (the “Class B Shares”), (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) of class C (the “Class C Shares”), (v)
one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class D (the “Class D Shares”), (vi) one thousand two hundred and
fifty (1,250) shares of class E (the “Class E Shares”), (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class F (the
“Class F Shares”), (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class G (the “Class G Shares”), (ix) one
thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class H (the “Class H Shares”), (x) one thousand two hundred and fifty
(1,250) shares of class I (the “Class I Shares”) and (xi) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class J (the
“Class J Shares”); each in registered form fully paid-up with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

and resolves to subsequently amend article 5 of the articles of association of the Company which shall henceforth read

as follows:

“ Art. 5. Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand seven hundred fifty euro (EUR 13,750.-), represented by

(i) one thousand two hundred and fifty (1,250) ordinary, (ii) one thousand two hundred and fifty shares of class A (the
“Class A Shares”), (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class B (the “Class B Shares”), (iv) one
thousand two hundred and fifty (1,250) of class C (the “Class C Shares”), (v) one thousand two hundred and fifty (1,250)
shares of class D (the “Class D Shares”), (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class E (the “Class E
Shares”), (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class F (the “Class F Shares”), (viii) one thousand two
hundred and fifty (1,250) shares of class G (the “Class G Shares”), (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares
of class H (the “Class H Shares”), (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class I (the “Class I Shares”)
and (xi) one thousand two hundred and fifty (1,250) shares of class J (the “Class J Shares”); each in registered form fully
paid-up with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 In addition to the issued capital, there may be set up a share premium account to which any share premium paid

on the ordinary shares of the Company in addition to its nominal value is transferred. The amount of the share premium
account may be used to provide for the payment of any ordinary shares which the Company may repurchase from its
shareholder(s), to offset any net realized losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or
to allocate funds to the legal reserve.

5.3. The subscribed share capital of the Company may be increased through the issuance of shares, or reduced, by a

resolution of the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution adopted in the manner required for
amendment of the Articles. In no case may the subscribed share capital be reduced to an amount lower than thirteen
thousand seven hundred fifty euro Euro (EUR 13,750.-). Notwithstanding the above, the share capital of the Company
may be reduced through the cancellation of a class of shares, in whole but not in part, consisting in the repurchase and
cancellation of all shares in issue in such class as may be determined from time-to-time by the board of managers and
approved at the General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, provided however that the Company
may not at any time repurchase and cancel the ordinary Shares. In the case of any repurchase and cancellation of a whole
class of shares, such repurchase and cancellation of shares shall be made in the following order: (i) Class J Shares; (ii)
Class I Shares; (iii) Class H Shares; (iv) Class G Shares; (v) Class F Shares; (vi) Class E Shares; (vii) Class D Shares; (viii)
Class C Shares; (ix) Class B Shares and (x) Class A Shares.

5.4. In the event of a reduction of share capital through the cancellation of a whole class of shares consisting in the

repurchase and cancellation of all shares in issue in such class (in the order provided for above), each such class of shares
entitles the holders thereof (pro rata to their holding in such class of shares) to such portion of the Total Cancellation
Amount with respect to the class of shares to be redeemed, and the holders of shares of the repurchased and cancelled

11113

L

U X E M B O U R G

shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant
class of shares.

5.5. The Company may repurchase its shares as provided herein only to the extent otherwise permitted by Law.
5.6. For the purpose of this article:
“Available Amount” means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) to the

extent shareholders would have been entitled to dividend distributions according to these Articles, increased by (i) any
freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium account up to the amount of losses
including carried forward losses) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve
reduction relating to the class of shares to be redeemed/cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward
losses), and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles, each
time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Whereby:
AA= Available Amount
NP= net profits (including carried forward profits)
P= any freely distributable reserves (including the share premium account up to the amount of L)
CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of shares to be cancelled
L= losses (including carried forward losses)
LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Law or of these Articles.
The Available Amount, as determined by using the formula described here above, can be increased by any surplus cash

or/and assets available to the Company at the time of the redemption, such surplus cash or/and assets being paid from
the share premium account up to the amount of the share premium at the time of the redemption.

“Cancellation Value Per Share” means the amount calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number

of shares in issue in the class of shares to be cancelled.

“Interim Accounts” means the interim accounts of the Company under Luxembourg GAAP as at the relevant Interim

Account Date.

“Interim Account Date” means the date no earlier than eight (8) days before the date of the cancellation of a class of

shares.

“Total Cancellation Amount” means the amount determined by the board of managers or as the case may be the sole

manager and approved at the General Meeting (or as the case may be the sole shareholder of the Company) or by way
of Shareholders Circular Resolution on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount shall
be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of shares unless
otherwise resolved at the General Meeting (or as the case may be by the sole shareholder of the Company) or by way
of Shareholders Circular Resolution in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that
the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 6. Shares.
6.1. The shares are and will remain in registered form (parts sociales nominatives). The shares are indivisible and the

Company recognises only one (1) owner per share.

6.2 The transfer of shares by reason of death to third parties must be approved by the shareholders representing

three-quarters of the rights owned by the survivors.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the

Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

6.3. A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
6.4. The Company may redeem its own shares, provided that the Company has sufficient distributable reserves for

that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.”

<i>Fourth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 7 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 7. Appointment and removal of managers.
7.1. The Company is jointly managed by two managers or more managers appointed by a resolution of the General

Meeting or by way of Shareholders Circular Resolution, which sets the term of their office. The managers need not be
shareholders.

11114

L

U X E M B O U R G

7.2. The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting or by

way of Shareholders Circular Resolution.”

<i>Fifth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 8 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

“ Art. 8. Board of managers. The Company will be managed by a board of managers (the Board). The Board shall be

composed of at least two (2) managers who will be A managers (hereafter each a Manager A) or B managers (hereafter
each a Manager B).

8.1. Powers of the board of managers
(i) All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of

the Board that has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.
(iii)  The  Board  shall  not  resolve  on  the  following  subject  matters  unless  with  (1)  the  approval  of  the  investment

committee of ECE Real Estate Partners S.à r.l. and such approval shall be documented in writing and (2) the unanimous
decision of all parties to any parallel investment agreement between ECE European Prime Shopping Centre II A, SCSp
SIF A, ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp and ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF C and,
as the case may be, further parties and such consent shall be documented in writing:

(a) any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from

the proportion of the Company's ownership) acquisition of shopping centres;

(b) any investment decision relating to the direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from

the proportion of the Company's ownership) disposal of shopping centres;

(c) any decision relating to direct or indirect (either by the Company or a subsidiary, independent from the proportion

of the Company's ownership) real estate financings; and

(d) any  decision  relating to  the  direct or indirect (either  by  the Company  or  a  subsidiary, independent  from the

proportion of the Company's ownership) enlargement of shopping centres, in particular the structural alteration of parts
or extensions of a building.

8.2. Procedure
(i) The Board meets upon the request of any manager, at the place indicated in the convening notice which, in principle,

is in Luxembourg.

(ii) Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance,

except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge

of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting.
Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously
adopted by the Board.

(iv) A manager may grant a power of attorney to another manager in order to be represented at any meeting of the

Board.

(v) The Board can validly deliberate and act only if (a) a majority of its members is present or represented, and (b) at

least one Manager A is present or represented at the meetings. Resolutions of the Board are validly taken by a simple
majority of the managers present or represented provided that at least one Manager A votes in favour of the decision(s)
to be adopted. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no
chairman has been appointed, by all the managers present or represented.

(vi) Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means

of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The
participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

(vii) Circular resolutions signed by all the managers (the Managers Circular Resolutions), are valid and binding as if

passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3. Representation
(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signatures of two managers, including at

least the signature of one Manager A.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have

been delegated.”

<i>Sixth resolution

The Sole Shareholder resolves to amend article 10 of the articles of association of the Company which shall henceforth

read as follows:

11115

L

U X E M B O U R G

“ Art. 10. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions.
10.1. Powers and voting rights
(i) Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders of the Company (the General

Meeting) or by way of circular resolutions (the Shareholders Circular Resolutions).

(ii) Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is

sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the share-
holders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last
signature.

(iii) Each share entitles to one (1) vote.
10.2. Notices, quorum, majority and voting procedures
(i) The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or

shareholders representing more than one-half of the share capital.

(ii) Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of

the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iii) General Meetings are held at such place and time specified in the notices.
(iv) If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the

agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

(v) A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order

to be represented at any General Meeting.

(vi) Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by

shareholders owning more than one-half of the share capital. if this majority is not reached at the first General Meeting
or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted
a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a
majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.

(vii) The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-

quarters of the share capital.

(viii) Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company

require the unanimous consent of the shareholders.”

10.3. Subject-Matters of Resolutions
The shareholders shall resolve on the subject-matters prescribed by the Law.”

<i>Seventh resolution

The Sole Shareholder resolves to redesignate the mandate of Mr José Maria Ortiz from manager to
manager A and to redesignate the mandate of Mr Ulrich Binninger from manager to manager B.
As a consequence, the Company will be managed by one Manger B and one Manager A, appointed for an undetermined

duration:

- Mr José Maria Ortiz, Director, born on January 3, 1970, in Madrid, Spain, with professional address at 17, rue Edmond

Reuter, L-5326 Contern, as Manager A,

- Mr Ulrich Binninger, Managing Director, born on August 30, 1966 in Trier, Germany, with professional address at

19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, as Manger B.

<i>Expenses

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a

result of the present deed, are estimated at approximately EUR 1,300.- (one thousand three hundred Euro).

WHEREOF the present deed was drawn up in Contern, on the day named at the beginning.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a German version; at the request of the same appearing party
and in case of divergences between the English and German texts, the English version shall prevail.

The document having been read to the person appearing, who is known to the notary by its surname, first name, civil

status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

Deutsche Uebersetzung des Vorstehenden Textes

Am achtzehnten Tag des Monats Dezember im Jahre zweitausendvierzehn,
ist vor dem unterzeichnenden Notar Edouard DELOSCH, mit Amtssitz in Diekirch, im Großherzogtum Luxemburg,

ERSCHIENEN:

Die ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, organisiert als spezialisierter Investmentfonds (fonds d'in-

vestissement spécialisé) in Form einer speziellen Kommanditgesellschaft (société en commandite spéciale), gegründet und

11116

L

U X E M B O U R G

bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Großherzogtum
Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handelsund Gesellschaftsregister unter Nummer B 189.416, vertreten durch
ihren Verwalter ECE Real Estate Partners S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité
limitée), gegründet und bestehend nach Luxemburger Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue Edmond Reuter, L-5326
Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen beim Luxemburger Handels-und Gesellschaftsregister unter Nummer
B 157.549 und ein Gesellschaftskapital von einhundertfünfundzwanzigtausend Euro (EUR125,000.-) hat,

in ihrer Eigenschaft als Alleingesellschafterin der HAB2 Prop Co. C S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung

(société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend nach luxemburgischen Recht, mit Gesellschaftssitz in 17, rue
Edmond Reuter in L-5326 Contern, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handelsund Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 175.214, gegründet am 8. Februar 2013 gemäß Urkunde von Maître Edouard Delosch,
Notar mit Amtssitz in Diekirch, Großherzogtum Luxemburg, (die Gesellschaft),

hier vertreten José Maria Ortiz, Geschäftsführer, geschäftsansässig in 17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Groß-

herzogtum Luxemburg, aufgrund der Vollmacht, welche am 18 Dezember 2014 erteilt wurde.

Besagte Vollmacht, welche von der erschienenen Partei und dem unterzeichnenden Notar unterzeichnet wurde, wird

der vorliegenden Urkunde beigefügt, um diese später bei der Registrierungsbehörde einzureichen.

Die erschienene Partei, vertreten wie oben dargestellt, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, folgendes zu beur-

kunden:

I. ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF ist Alleingesellschafterin der Gesellschaft (die Alleingesell-

schafterin) und vertritt das gesamte Gesellschaftskapital;

II. Die Alleingesellschafterin fasst folgende Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt Artikel 3 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, zu ändern, sodass dieser von

nun an wie folgt lautet:

„ Art. 3. Gesellschaftszweck.
3.1. Zweck der Gesellschaft ist der direkte oder indirekte Erwerb von Immobilien im Großherzogtum Luxemburg

oder im Ausland, insbesondere von Einkaufszentren, und der Erwerb und die Verwaltung von zur Bewirtschaftung der
Immobilien erforderlichen Gegenständen.

3.2. Die Gesellschaft kann Darlehen jeglicher Art aufnehmen, ausgenommen im Wege eines öffentlichen Angebots. Sie

kann, jedoch nur durch Privatplatzierungen, Schuldscheine, Anleihen sowie jegliche Art von Schuldtitel und Dividenden-
papiere ausgeben. Die Gesellschaft kann Geldmittel, einschließlich und uneingeschränkt die Erträge aus Kreditverbind-
lichkeiten, an ihre Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und andere Gesellschaft verleihen. Des Weiteren kann
die Gesellschaft in Bezug auf ihr gesamtes oder nur einen Teil ihres Vermögens Sicherheiten leisten, verpfänden, über-
tragen, belasten oder auf andere Weise Sicherheiten bestellen und gewähren, um ihren eigenen Verpflichtungen und
solchen anderer Gesellschaften nachzukommen und im Allgemeinen zu ihrem eigenen Vorteil und zum Vorteil jeder
anderen Gesellschaft oder Person. Um Unstimmigkeiten auszuschließen, ist die Gesellschaft nicht dazu befugt ohne die
erforderliche Genehmigung reglementierte Tätigkeiten in Bezug auf den Finanzsektor auszuüben.”

<i>Zweiter Beschluss

Die Alleingesellschafterin, ECE European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF, beschließt
a) das Stammkapital der Gesellschaft von zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um eintausendzweihundert-

fünfzig Euro (EUR 1.250) auf dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750) durch Ausgabe von eintausend-
zweihundertfünfzig (1.250) Anteilen mit einem Stückwert von je einem Euro (EUR 1.-) zu erhöhen,

b) eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Geschäftsanteile mit einem Nennwert von einem Euro (EUR 1.-) zu zeichnen

und den Betrag von eintausendzweihunderfünfzig Euro (EUR 1.250) vollständig in bar einzuzahlen und dem unterzeich-
neten Notar den Nachweis zu erbringen, dass der Betrag in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig (EUR 1.250) jetzt
der Gesellschaft zur Verfügung steht.

c) die dreizehntausendsiebenhundertfünfzig (13.750) Anteile mit einem Stückwert von je einem Euro (EUR 1.-) um-

zuwandeln  und  aufzuteilen in (i)  eintausend  zweihundertundfünfzig (1.250)  Stammanteile,  (ii)  eintausend zweihunder-
tundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse A (die “Klasse A Anteile”), (iii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile
der Klasse B (die “Klasse B Anteile”), (iv) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse C (die “Klasse C
Anteile”), (v) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (vi) eintausend
zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse E (die “Klasse E Anteile”), (vii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250)
Anteile der Klasse F (die “Klasse F Anteile”), (viii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G (die
“Klasse G Anteile”), (ix) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse H (die “Klasse H Anteile”), (x)
eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse I (die “Klasse I Anteile”) und (xi) eintausend zweihunder-
tundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse J (die “Klasse J Anteile”); jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile
mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Und beschließt daher, Artikel 5 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, sodass dieser von nun an wie folgt lautet:

11117

L

U X E M B O U R G

“ Art. 5. Kapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf dreizehntausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-), aufgeteilt in (i)

eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Stammanteile, (ii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse
A (die “Klasse A Anteile”), (iii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse B (die “Klasse B Anteile”),
(iv) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse C (die “Klasse C Anteile”), (v) eintausend zweihunder-
tundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse D (die “Klasse D Anteile”), (vi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile
der Klasse E (die “Klasse E Anteile”), (vii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse F (die “Klasse F
Anteile”), (viii) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse G (die “Klasse G Anteile”), (ix) eintausend
zweihundertundfünfzig  (1.250)  Anteile  der  Klasse  H  (die  “Klasse  H  Anteile”),  (x)  eintausend  zweihundertundfünfzig
(1.250) Anteile der Klasse I (die “Klasse I Anteile”) und (xi) eintausend zweihundertundfünfzig (1.250) Anteile der Klasse
J (die “Klasse J Anteile”); jede jeweils ausgegeben in voll liberierten Namensanteile mit einem Nominalwert von je einem
Euro (EUR 1).

5.2. Zusätzlich zum gezeichneten Gesellschaftskapital kann ein Rücklagenkonto für das Emmissionsagio eingerichtet

werden, auf welchem das auf die Stammanteile über deren Nominalwert eingezhalten Emissionsagio als Kapitalrücklage
verbucht werden kann. Der Betrag des Rücklagenkontos kann für Zahlungen der Gesellschaft an ihre(n) Gesellschafter
im Rahmen des Rückerwerbs von Stammanteilen, zum Ausgleich des realisierten Nettoverlusts, für Ausschüttungen an
den/die Gesellschafter in Form von Dividenden verwednet werden oder der gesetzlichen Kapitalrücklage zugeführt zu
werden.

5.3. Durch Beschluss der Generalversammlung der Gesellschafter, der in Übereinstimmung mit den für eine Satzungs-

änderung erforderlichen Bestimmungen zu fassen ist, kann das gezeichnete Gesellschaftskapital durch die Ausgabe von
Anteilen erhöht oder herabgesetzt werden. In keinem Fall darf das Gesellschaftskapital unter einen Betrag von dreizehn-
tausendsiebenhunderfünfzig Euro (EUR 13.750,-) fallen. Dessen ungeachtet kann das Gesellschaftskapital der Gesellschaft
verringert werden durch die Löschung einer gesamten Anteilsklasse (nicht jedoch eines Teils Anteilsklasse), welche durch
Rückerwerb und Annullierung aller in dieser Klasse ausgegebenen Anteilen erfolgt, wie es von Zeit zu Zeit durch den
Geschäftsführungsrat festgestellt und durch die Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesell-
schafter  bestätigt  wird;  der  Rückerwerb  und  die  Annullierung  von  Stammanteilen  durch  die  Gesellschaft  sind  ausge-
schlossen.  Sofern  der  Rückerwerb  und  die  Annullierung  einer  gesamten  Klasse  beabsichtigt  sind,  haben  diese  in  der
folgenden Reihenfolge zu erfolgen: (i) Klasse J Anteile; (ii) Klasse I Anteile; (iii) Klasse H Anteile; (iv) Klasse G Anteile; (v)
Klasse F Anteile; (vi) Klasse E Anteile; (vii) Klasse D Anteile; (viii) Klasse C Anteile; (ix) Klasse B Anteile und (x) Klasse
A Anteile.

5.4. Im Falle der Kapitalherabsetzung durch Löschung einer gesamten Anteilsklasse durch Rückerwerb und Annullie-

rung aller ausgegebenen Anteile in der betreffenden Klasse (gemäß obiger Reihenfolge) steht jedem Inhaber von Anteilen
dieser Anteilsklasse (pro rata gemäß der gehaltenen Anteile in der jeweiligen Anteilsklasse) ein anteiliger Anspruch aus
dem Gesamtannullierungsbetrag in Bezug auf die einzuziehende Anteilsklasse zu; jeder Inhaber von rückerworbenen oder
annullierten Anteilen erhält von der Gesellschaft einen Betrag, der dem Annullierungswert pro Anteil für jeden Anteil
der relevanten Anteilsklasse entspricht.

5.5. Die Gesellschaft kann den Rückerwerb von Anteilen gemäß den hier festgelegten Bedingungen nur im Rahmen

der Anforderungen des Gesetzes vornehmen.

5.6. Für Zwecke dieses Artikels:
“Verfügbarer Betrag” bedeutet den Gesamtbetrag des Nettogewinns der Gesellschaft (einschließlich vorgetragener

Gewinne) soweit Gesellschafter gemäß dieser Satzung zum Erhalt von Dividendenausschüttungen berechtigt gewesen
wären, erhöht um (i) alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zur
Höhe der Verluste einschließlich vorgetragener Verluste) und (ii) gegebenenfalls den Betrag der Kapitalherabsetzung und
der Verringerung der gesetzlichen Rücklagen im Hinblick auf die einzuziehenden/zu löschenden Anteilsklassen, jedoch
verringert um (i) alle Verluste (einschließlich vorgetragener Verluste), und (ii) aller Beträge, welche aufgrund des Gesetzes
oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden müssen, jedes Mal wie in den betreffenden Zwischenbilanzen dar-
gestellt (jedoch ohne doppelte Buchung) so dass:

AA = (NP + P+ CR) - (L + LR)
Wobei:
AA= Verfügbarer Betrag
NP= Nettogewinn (einschließlich vorgetragener Gewinne)
P= alle frei ausschüttbaren Reserven (einschließlich des Rücklagenkontos für das Emissionsagio bis zu einem Betrag

von L)

CR = der Betrag der Kapitalherabsetzung und der Herabsetzung der gesetzlichen Rücklage bezogen auf diejenige

Anteilsklasse, welche aufgelöst werden soll

L= Verluste (einschließlich vorgetragene Verluste)
LR = alle Beträge, welche aufgrund Anforderungen des Gesetzes oder dieser Satzung als Rücklage(n) gebildet werden

müssen.

11118

L

U X E M B O U R G

Der Verfügbare Betrag, basierend auf obiger Formel, kann um sämtliche der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Rück-

nahme zur Verfügung stehende überschüssige Liquidität und/oder Vermögenswerte, erhöht werden, wobei überschüssige
Liquidität und Vermögenswerte aus dem Rücklagenkonto des Emissionsagio bis zur Höhe des Betrags der an das Emis-
sionsagio gebundenen Kapitalrücklage zum Zeitpunkt der Rücknahme zu zahlen sind.

“Annullierungswert pro Anteil” bedeutet den durch Division des Gesamtannullierungsbetrages durch die ausgegebene

Anzahl von Anteilen in der von der Annullierung betroffenen Anteilsklasse errechneten Wert.

“Zwischenbilanzen” bedeuten die Zwischenbilanzen der Gesellschaft gemäß Luxemburger GAAP zum betreffenden

Zwischenbilanzzeitpunkt.

“Zwischenbilanzzeitpunkt” bedeutet das Datum frühestens acht (8) Tage vor dem Datum der Löschung einer Anteils-

klasse.

“Gesamtannullierungsbetrag” bedeutet der vom Geschäftsführungsrat oder gegebenenfalls dem Alleingeschäftsführer

festgelegten und von der Hauptversammlung (oder gegebenenfalls dem Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im
Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestätigten Betrag, basierend auf den relevanten Zwischenbilanzen.
Der Gesamtannullierungsbetrag muss niedriger oder gleich dem gesamten Verfügbaren Betrag zum Zeitpunkt der Lö-
schung  der  betreffenden  Anteilsklasse  sein,  es  sei  denn,  dass  dies  anderweitig  durch  die  Hauptversammlung  (oder
gegebenenfalls durch den Alleingesellschafter der Gesellschaft) oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter
gemäß den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung beschlossen worden ist, vorausgesetzt jedoch, dass der Gesamt-
annullierungsbetrag nie höher sein darf als der Verfügbare Betrag.”

<i>Dritter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, zu ändern, sodass dieser von

nun an wie folgt lautet:

„ Art. 6. Geschäftsanteile.
6.1. Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile (parts sociales nominatives). Die Geschäftsanteile sind unteilbar

und die Gesellschaft lässt nur einen (1) Eigentümer pro Geschäftsanteil zu.

6.2. Die Übertragung von Geschäftsanteilen aufgrund eines Todesfalles an Dritte bedarf der Zustimmung der anderen

Gesellschafter, welche drei Viertel der Rechte der Hinterbliebenen vertreten.

Eine Anteilsübertragung ist gegenüber der Gesellschaft oder Dritten nur wirksam, wenn eine solche gemäß Artikel

1690 des luxemburgischen Bürgerlichen Gesetzbuches gegenüber der Gesellschaft angezeigt oder von dieser anerkannt
wurde.

6.3. Am Sitz der Gesellschaft wird ein Gesellschafterregister geführt, welches auf Anfrage von jedem Gesellschafter

eingesehen werden kann.

6.4. Die Gesellschaft kann ihre eigenen Geschäftsanteile zurückkaufen, vorausgesetzt, die Gesellschaft verfügt über

ausreichend ausschüttbare Reserven oder falls der Rückkauf aufgrund einer Herabsenkung des Gesellschaftskapitals be-
ruht.”

<i>Vierter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 7 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, zu ändern, sodass dieser von

nun an wie folgt lautet:

„ Art. 7. Bestellung und Abberufung von Geschäftsführern.
7.1. Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich von zwei oder mehreren Geschäftsführern verwaltet. Diese werden durch

einen Beschluss der Hauptversammlung oder im Wege eines Umlaufbeschlusses der Gesellschafter bestellt, welcher auch
ihre Amtszeit festlegt. Die Geschäftsführer müssen keine Gesellschafter der Gesellschaft sein.

7.2. Die Geschäftsführer können zu jedem Zeitpunkt (mit oder ohne Grund) von der Hauptversammlung oder im

Wege eines Umlaufbeschlusses abberufen werden.”

<i>Fünfter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 8 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, zu ändern, sodass dieser von

nun an wie folgt lautet:

„ Art. 8. Geschäftsführungsrat. Die Gesellschaft wird von einem Geschäftsführungsrat (der Rat) verwaltet. Der Rat

soll aus mindestens zwei (2) Geschäftsführern bestehen, die entweder A Geschäftsführer (Geschäftsführer A) oder B
Geschäftsführer (Geschäftsführer B) sein sollen.

8.1. Befugnisse des Geschäftsführungsrates
(i) Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegende Satzung den Gesellschaftern

vorbehalten sind, fallen in den Zuständigkeitsbereich des Rates, welchem die Befugnis zusteht, jegliche Handlungen und
Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Gesellschaftszweck im Einklang stehen.

(ii) Besondere und eingeschränkte Vollmachten können für bestimmte Angelegenheiten an einen oder mehrere Hand-

lungsbevollmächtigte des Rates übertragen werden.

11119

L

U X E M B O U R G

(iii) In Bezug auf die folgenden Entscheidungen soll der Rat nur Beschlüsse fassen sofern (1) die Genehmigung des

Investment Komitees der ECE Real Estate Partners S.à r.l. vorliegt, und eine solche Genehmigung schriftlich festgehalten
wurde und (2) der einstimmigen Entscheidung aller Parteien einer jeden parallelen Investitionsvereinbarung zwischen der
ECE European Prime Shopping Centre II A, SCSp SIF, der ECE European Prime Shopping Centre II B, SCSp und der ECE
European Prime Shopping Centre II C, SCSp SIF und, gegebenenfalls, weiteren Parteien, und eine solche Zustimmung
schriftlich festgehalten worden ist:

(a) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich des direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) des Erwerbs von Einkaufszentren;

(b) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Veräußerung von Einkaufszentren;

(c) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Immobilien Finanzierung; und

(d) eine Investitionsentscheidung hinsichtlich der direkten oder indirekten (entweder durch die Gesellschaft oder eine

Tochtergesellschaft, unabhängig vom Anteil der Inhaberverhältnisse der Gesellschaft) Erweiterung von Einkaufszentren,
dass heißt insbesondere die bauliche Veränderungen durch neue Gebäudeteile und Anbauten, von Einkaufszentren.

8.2. Verfahren
(i) Auf Wunsch eines jeden Geschäftsführers findet eine Versammlung des Rates, an einem in der Ankündigung ge-

nannten Ort, grundsätzlich aber in Luxemburg, statt.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jeden Versammlung des Rates geht allen Geschäftsführern spätestens vierund-

zwanzig (24) Stunden vor der Versammlung zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in
der Ankündigung darzulegen ist.

(iii) Eine Ankündigung ist nicht erforderlich, wenn alle Mitglieder des Rates bei der Versammlung anwesend oder

vertreten sind und erklären, dass ihnen die Tagesordnung der Versammlung vollständig bekannt ist. Auf eine Ankündigung
kann ein Geschäftsführer zudem entweder vor oder nach der Sitzung freiwillig verzichten. Gesonderte schriftliche An-
kündigungen sind nicht erforderlich, wenn es sich um eine Versammlung handelt, welche örtlich und zeitlich im Voraus
in einem Terminplan angekündigt wurde, welcher durch den Rat verabschiedet wurde.

(iv) Ein Geschäftsführer kann einem anderen Geschäftsführer eine Vollmacht erteilen, um sich bei Versammlung des

Rates vertreten zu lassen.

(v) Der Rat ist nur tagungs- und beschlussfähig, wenn (a) die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend oder vertreten sind

und (b) wenigstens ein Geschäftsführer A bei der Versammlung anwesend oder vertreten ist. Die Beschlüsse des Rates
sind wirksam, wenn sie mit einer einfachen Mehrheit der von den anwesenden und vertretenen Geschäftsführern gefasst
werden,  wobei  mindestens  ein  Geschäftsführer  A  für  den  Beschluss  oder  die  Beschlüsse  gestimmt  haben  muss.  Die
Beschlüsse des Rates werden in Sitzungsprotokollen festgehalten, welche vom Vorsitzenden der Versammlung oder, wenn
kein Vorsitzender bestimmt wurde, von allen bei der Sitzung anwesenden und vertretenen Geschäftsführern unterzeich-
net werden müssen.

(vi) Jeder Geschäftsführer kann per Telefon- oder Videokonferenz oder durch jedes andere, vergleichbare Kommu-

nikationsmittel an einer Versammlung des Rates teilnehmen, welches es allen Teilnehmern der Versammlung ermöglicht,
einander zu identifizieren, zu hören und miteinander zu kommunizieren. Eine solche Teilnahme ist einer persönlichen
Teilnahme an einer ordnungsgemäß einberufenen und gehaltenen Versammlung gleichzusetzen.

(vii) Beschlüsse in Textform, welche von allen Geschäftsführern unterzeichnet sind und im Umlaufverfahren gefasst

worden sind (die Umlaufbeschlüsse der Geschäftsführer), sind genauso gültig und verbindlich wie ein Beschluss, der in
einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Versammlung des Rates gefasst wurde und tragen das Datum der zuletzt
hinzugefügten Unterschrift.

8.3. Vertretung
(i) Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinschaftliche Unterschrift von zwei

(2) Geschäftsführern gebunden, wobei stets mindestens ein Geschäftsführer A unterzeichnet haben muss.

(ii) Die Gesellschaft wird ebenfalls gegenüber Dritten durch die Unterzeichnung der mit gemäß Sinne von Artikel 8.1.

(ii) Spezialvollmachten ausgestatteten Personen gebunden.”

<i>Sechster Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 10 der Satzung der Gesellschaft zu ändern, zu ändern, sodass dieser von

nun an wie folgt lautet:

„ Art. 10. Hauptversammlung und Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter.
10.1. Vollmachten und Stimmrechte
(i) Beschlüsse der Gesellschafter werden in einer Hauptversammlung der Gesellschafter (die Hauptversammlung) oder

durch Beschlüsse im Umlaufverfahren (die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter) gefasst.

(ii) Werden Beschlüsse im Wege der Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter gefasst, so wird der Inhalt der Beschlüsse

gemäß den Bestimmungen der Satzung an alle Gesellschafter übersandt. Die von allen Gesellschaftern unterzeichneten

11120

L

U X E M B O U R G

Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter, welcher das Datum der zuletzt hinzugefügten Unterschrift trägt, ist genauso gültig
und verbindlich wie ein Beschluss, der in einer ordentlich einberufenen und abgehaltenen Hauptversammlung gefasst
wurde.

(iii) Je ein Geschäftsanteil gewährt eine (1) Stimme.
10.2. Ankündigung, Beschlussfähigkeit, Mehrheit der Stimmen und Wahlverfahren
(i) Auf Initiative eines Geschäftsführers oder der Gesellschafter, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals

vertreten, werden die Gesellschafter zur Hauptversammlung einberufen oder schriftlich zur Entscheidung gebeten.

(ii) Eine schriftliche Ankündigung einer jede Hauptversammlung geht allen Gesellschaftern spätestens acht (8) Tage im

Voraus zu, es sei denn es liegt ein Notfall vor, dessen Art und Umstand sodann in der Ankündigung dazulegen ist.

(iii) Die Hauptversammlungen finden an dem in der Ankündigung genannten Ort, zur in der Ankündigung genannten

Zeit statt; die Hauptversammlungen sollten grundsätzlich im Großherzogtum Luxemburg abgehalten werden.

(iv) Die Hauptversammlung kann ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden, wenn alle anwesenden oder ver-

tretenen Gesellschafter erklären, dass ihnen die Tagesordnung im Voraus bekannt gegeben wurde und sich selbst als
ordnungsgemäß einberufen betrachten.

(v) Ein Gesellschafter kann einer anderen Person, bei welcher es sich nicht um einen Gesellschafter handeln muss, eine

schriftliche Vollmacht erteilen, um von dieser bei der Hauptversammlung vertreten zu werden.

(vi) Die in den Hauptversammlungen oder in Form von Umlaufbeschlüssen der Gesellschafter zu fassenden Beschlüsse

werden von den Gesellschaftern getroffen, welche mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals vertreten. Wird eine
solche Mehrheit bei der ersten Hauptversammlung oder dem ersten Beschluss in Textform nicht erreicht, werden die
Gesellschafter per Einschreiben zu einer zweiten Hauptversammlung geladen oder erneut zur schriftlichen Entscheidung
gebeten und die Beschlüsse oder die Umlaufbeschlüsse der Gesellschafter werden sodann aufgrund der Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst, unbeschadet der Quote des vertretenen Gesellschaftskapitals.

(vii) Die Satzung kann mit Zustimmung der Mehrheit der Gesellschafter, welche drei Viertel des Gesellschaftskapitals

vertreten, abgeändert werden.

(viii) Jede Änderung der Nationalität der Gesellschaft und jede Erhöhung der Verpflichtungen eines Gesellschafters

gegenüber der Gesellschaft erfordert die einstimmige Zustimmung aller Gesellschafter.

10.3. Gegenstände von Beschlüssen
Die Gesellschafter sollen über die Gegenstände abstimmen welche per Gesetz vorgeschrieben sind.”

<i>Siebter Beschluss

Die Alleingesellschafterin beschließt das Mandat von Herrn José Maria Ortiz vom Geschäftsführer in einen Geschäfts-

führer A umzubestimmen und das Mandat von Herrn Ulrich Binninger vom Geschäftsführer in einen Geschäftsführer B
umzubestimmen. Als Konsequenz wird die Gesellschaft für einen unbestimmten Zeitraum von einem Geschäftsführer B
und einem Geschäftsführer A verwaltet:

1) Herr José Maria Ortiz, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 3. Januar 1970 in Madrid, Spanien, geschäftsansässig in

17, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, als Geschäftsführer A

2) Herr Ulrich Binninger, Verwaltungsratsmitglied, geboren am 30 August, 1966 in Trier, Deutschland, geschäftsansässig

in 19, rue des Lilas, L-8035 Strassen, als Geschäftsführer B

<i>Kosten

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu

tragen hat, belaufen sich auf ungefähr EUR 1.300,- (eintausenddreihundert Euro).

WORÜBER Urkunde erstellt in Contern am Datum, wie eingangs erwähnt.
Der unterzeichnete Notar, der der englischen Sprache mächtig ist, erklärt hiermit, dass auf Ersuchen der erschienenen

Parteien diese Urkunde in englischer Sprache verfasst und mit einer deutschen Übersetzung versehen ist und dass im
Falle einer Abweichung des englischen vom deutschen Text der englische Text maßgebend ist.

Nachdem die Urkunde der erschienenen Person, welche dem Notar mit Nachname, Vorname, Personenstand und

Adresse bekannt ist, vorgelesen wurde, hat die erschienene Person zusammen mit dem Notar die vorliegende Urkunde
unterschrieben.

Gezeichnet: J. M. ORTIZ, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 22 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16631. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Für gleichlautende Ausfertigung, ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Memorial C.

Diekirch, den 29. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014209229/541.
(140233504) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 décembre 2014.

11121

L

U X E M B O U R G

R.A.L. Management S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 370, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 193.202.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twenty-second of December.
Before us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg.

THERE APPEARED

1. Mr Gagik ADIBEKYAN, property developer, born on 23 January 1951 in Erevan (Armenia), residing at Boulevard

Dr Ernest Feltgen, N°28, L-1515 Luxembourg (Luxembourg).

2. Mrs Eleonora ADIBEKIAN, building project manager, born on 12 December 1980 in Erevan (Armenia), residing at

Boulevard Dr Ernest Feltgen, N°28, L-1515 Luxembourg (Luxembourg).

3. Mrs Lilit ADIBEKYAN, building project manager, born on 22 May 1985 in Erevan (Armenia), residing at Boulevard

Dr Ernest Feltgen, N°28, L-1515 Luxembourg (Luxembourg).

All here represented by Mrs Alexandra Fuentes, private employee, professionally residing in Luxembourg by virtue of

a proxy given under private seal in Luxembourg.

Which proxies, after having been signed “ne varietur” by the mandatory and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time.

Such appearing parties, represent as stated above, have requested the notary to inscribe as follows the articles of

association of a family asset management company (Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF in a shortened form)
which it forms:

“Title I. - Denomination, Registered office, Object, Duration

Art. 1. There is established by the shareholders a Société Anonyme governed by the laws of the Grand Duchy of

Luxembourg, especially the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies, as amended, and completed by the law

dated 11 

th

 May 2007 concerning the family asset management company (Société de Gestion de Patrimoine Familial, SPF

in a shortened form) and by the present articles of Incorporation.

The Company exists under the name of “R.A.L. MANAGEMENT S.A., SPF”.

Art. 2. The registered office of the company is established in Luxembourg.
The registered office may be transferred to any other place in the municipality by a decision of the board of directors.
If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might compromise with the normal activity

at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared
to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.

Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company. Such declaration of the transfer of the

registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the Company which is best
situated for this purpose under such circumstances.

Art. 3. The Company is established for an unlimited period of time.

Art. 4. The sole object of the Company is the acquisition, the holding, the management and the realization of financial

assets, within the meaning of the Law of 5 August 2005 on Financial Guarantee Contracts, as well as of cash monies and
assets of any nature held in a bank account, excluding any commercial activity.

Financial assets according to the Law of 5 August 2005 on Financial Guarantee Contracts consist in (a) any transferable

securities including, in particular, shares and other titles equivalent to shares, shares of undertakings for collective in-
vestment, bonds and debentures and any other form of proof of debt, certificates of deposit, notes, and bills of exchange;
(b) securities conferring the right to acquire shares, bonds and debentures and other stocks by way of subscription,
purchase or exchange; (c) forward financial instruments and securities conferring the right to a settlement in cash (except
payment instruments); including money market instrument; (d) any other title representing property rights, claims or
transferable securities; (e) any underlying instrument (be they related to indexes, raw materials, precious metals, foodstuff,
metals, commodities or other goods or risks); (f) any claim related to the items listed under (a) to (e) and any right
concerning these items or related to them, whether these instruments are materialized or dematerialized, transferable
by way of crediting on an account or by negotiation, bearer instruments or registered securities, endorsable or not, and
irrespective of the applicable law.

The Company may take any supervision measures, may carry out any transactions, which the Company may deem

useful to the accomplishment of its purposes but only under the condition that the Company does not involve itself in
the management of its shareholdings companies, within the meaning of the SPF Law.

The Company is submitted to the law of 11 May 2007 relative to the establishment of a family asset management

companies (law of 11 May 2007 relative to the establishment of a family asset management company ("SPF”).

11122

L

U X E M B O U R G

Title II. - Capital, Shares

Art. 5. The subscribed capital is set at thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-), divided into one thousand (1,000)

shares with a nominal value of thirty-two euros (EUR 32.-) par value.

An eligible investor within the meaning of this law is any person as follows:
a) an individual acting within the context of managing his/her private asset or
b) a asset management entity acting exclusively in the interests of the personal estate of one or several individuals, or
c) an intermediary acting on behalf of the investors referred to in a) or b) of this paragraph.
Each investor must declare his/her eligibility in writing addressed to the domiciliary agent or, failing this, to the directors

of the SPF.

The securities issued by an SPF may not be the object of a public issue nor may they be admitted to listing on a stock

exchange.

The capital of the Company may be increased or reduced by a decision of the general meeting of shareholders, voting

with the same quorum as for an amendment of the articles of incorporation.

Shares may be issued in registered or bearer form, at the shareholder's option.
The Company may, to the extent and under the terms permitted by law of 10 August 1915, purchase its own shares.

Title III. - Management

Art. 6. In case of plurality of shareholders, the Company must be managed by a Board of Directors consisting of at

least three members, who need not be shareholders.

The board of directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more

directors, who will be called managing directors.

It may also commit the management of all the affairs of the Company or of a special branch to one or more managers,

and give special powers for determined matters to one or more proxyholders, selected from its own members or not,
either shareholders or not.

In the case where the Company is incorporated by a sole shareholder or if at the occasion of a general meeting of

shareholders, it is established that the Company has only one shareholder left, the composition of the Board of Directors
may be limited to one member (the "Sole Director") until the next ordinary general meeting of the shareholders noticing
the existence of more than one shareholder. A legal entity may be a member of the Board of Directors or may be the
Sole Director of the Company. In such a case, its permanent representative shall be appointed or confirmed in compliance
with the Law.

The Directors or the Sole Director are appointed by the general meeting of shareholders for a period not exceeding

six (6) years and are re-eligible. They may be removed at any time by a resolution of the general meeting of shareholders.
They will remain in function until their successors have been appointed. In case a Director is elected without mention of
the term of his mandate, he is deemed to be elected for six years from the date of his election.

In the event of vacancy of a member of the Board of Directors because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors thus appointed may meet and elect, by majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general
meeting of shareholders which will be asked to ratify such election.

Art. 7. The board of directors will elect from among its members a chairman.
The board of directors convenes upon call by the chairman, as often as the interest of the Company so requires. It

must be convened each time two directors so request.

Art. 8. The board of directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition

in compliance with the corporate object.

All powers not expressly reserved by law or by the present articles of association to the general meeting of share-

holders  fall  within  the  competence  of  the  board  of  directors.  The  board  of  directors  may  pay  interim  dividends,  in
compliance with the legal requirements.

Any director having an interest in a transaction submitted for approval to the Board of Directors conflicting with that

of the company, shall advise the board thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the
meeting. He may not take part in these deliberations. At the next following general meeting, before any other resolution
is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the directors may have had an interest
conflicting with that of the company.

If there is only one shareholder, the minutes shall only mention the operations intervened between the Company and

its Sole Director having an interest conflicting with the one of the Company.

If there is only one Director, all such powers shall be reserved to the Sole Director.

Art. 9. Towards third parties, in all circumstances, the Company shall be, in case of a Sole Director, bound by the sole

signature of the Sole Director or, in case of plurality of directors, by the signature of one of two Directors together with
the Managing Director or by the single signature of the Managing Director or of any person to whom such signatory

11123

L

U X E M B O U R G

power shall be delegated by the Board of Directors or the Sole Director of the Company, but only within the limits of
such power.

Towards third parties, in all circumstances, the Company shall also be, in case if a managing director has been appointed

in order to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such
daily management and affairs, bound by the sole signature of the managing director, but only within the limits of such
power.

Art. 10. Any litigations involving the Company either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the

Company by the board of directors, represented by its chairman or by the director delegated for its purpose.

Art. 11. The company may have a sole shareholder at the time of its incorporation or when all of its shares come to

be held by a single person. The death or dissolution of the sole shareholder does not result in the dissolution of the
company.

If there is only one shareholder, the sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of Share-

holders and takes the decisions in writing.

In case of plurality of shareholders, the general meeting of Shareholders shall represent the entire body of Shareholders

of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the
Company.

Any general meeting shall be convened in compliance with the Law.
The general meeting shall be convened by means of the shareholders representing ten per cent (10 %) of the corporate

capital.

In case that all the shareholders are present or represented and if they state that they have been informed of the

agenda of the meeting, they may waive all convening requirements and formalities of publication.

A shareholder may be represented at a shareholders' meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not to be a shareholder and is therefore entitled to vote by proxy.

The shareholders are entitled to participate to the meeting by videoconference or by telecommunications means

allowing their identification, and are deemed to be present, for the quorum conditions and the majority. These means
must comply with technical features guaranteeing an effective participation to the meeting whereof the deliberations are
transmitted in a continuing way.

Unless  otherwise  provided  by  Law  or  by  the  Articles,  all  decisions  by  the  annual  or  ordinary  general  meeting  of

Shareholders shall be taken by simple majority of the votes, regardless of the proportion of the capital represented.

When the company has a sole shareholder, his decisions are written resolutions.
An extraordinary general meeting convened to amend any provisions of the Articles shall not validly deliberate unless

at least one half of the capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles. If the
first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles or
by the Law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous
meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both
meetings, resolutions, in order to be adopted, must be adopted by a two-third majority of the Shareholders present or
represented.

However, the nationality of the Company may be changed and the commitments of its Shareholders may be increased

only with the unanimous consent of all the Shareholders and in compliance with any other legal requirement.

Title IV. - Supervision

Art. 12. The Company is supervised by one or several statutory auditors, appointed by the general meeting of share-

holders which will fix their number and their remuneration, as well as the term of their office, which must not exceed
six (6) years.

Title V. - General meeting

Art. 13. The annual meeting will be held in the commune of the registered office at the place specified in the convening

notices on the second Tuesday of the month of June at 1.00 p.m.

If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day.

Title VI. - Accounting year, Allocation of profits

Art. 14. The accounting year of the Company shall begin on the first (1 

st

 ) of January and shall terminate on the thirty-

first (31 

st

 ) of December of each year.

Art. 15. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance

represents the net profits of the Company Of the net profits, five percent (5%) shall be appropriated for the legal reserve;
this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten percent (10%) of the capital of Company, but
it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been
touched.

11124

L

U X E M B O U R G

The balance is at the disposal of the general meeting.

Title VII. - Dissolution, Liquidation

Art. 16. The Company may be dissolved by a resolution of the general meeting of shareholders. The liquidation will

be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the general meeting of shareholders
which will specify their powers and fix their remunerations.

Title VIII. - General provisions

Art. 17.  As regards the matters which are not specified in the present articles, the parties refer and submit to the

provisions of the Luxembourg law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies and to the laws modifying it and the

law of the 11 May 2007 concerning the family asset management company, Société de Gestion de Patrimoine Familial
(SPF).”

<i>Transitory provisions

1) The first business year shall begin on the date of incorporation of the company and shall end on the 31 December

2014.

2) The first annual general meeting shall be held in 2015.

<i>Subscription and payment

The Articles having thus been established, the above-named party has subscribed for the one thousand (1.000) shares:

- Mr Gagjk ADIBEKYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980 shares

- Mrs Lilit ADIBEKYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 shares

- Mrs Eleonora ADIBEKIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 shares

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 shares

All these shares have been fully paid up so that the amount of thirty-two thousand euros (EUR 32,000.-) is forthwith

at the free disposal of the Company; as has been proved to the notary.

<i>Statement

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 26 as amended of the law of 10 August 1915

on commercial companies have been observed.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of its organization, is approximately one thousand five hundred euros
(EUR 1.500.-).

<i>Extraordinary general meeting

The above named person acting as sole shareholder of the Company, has immediately taken the following resolutions:
1. The Company's address is set at 370, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. The following persons have been appointed as Directors of the Company for a renewable period of six (6) years;

their mandates will terminate immediately after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020:

- Mr Gagjk ADIBEKYAN, property developer, born on 23 January 1951 in Erevan (Armenia), residing at 28, Boulevard

Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg;

- Mrs Eleonora ADIBEKIAN, building project manager, born on 12 December 1980 in Erevan (Armenia), residing at

28, Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg;

- Mrs Lilit ADIBEKYAN, building project manager, born on 22 may 1985 in Erevan (Armenia), residing at 28, Boulevard

Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

3. Mr Dominique FONTAINE, private employee, born on 19 November 1965 in Saint-Mard (Belgium), residing in 78,

Rue Castel, B-6700 Arlon (Belgium), has been appointed as Statutory Auditor; its mandate will terminate immediately
after the annual general meeting of shareholders to be held in 2020.

The undersigned notary, who knows the English language, states that on request of the appearing parties the present

deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French
text, the English version will be binding.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.
The document having been read to the representative of the person appearing, he signed together with the notary

the present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le dix-neuf décembre.

11125

L

U X E M B O U R G

Pardevant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU

1. Monsieur Gagik ADIBEKYAN, promoteur immobilier, né le 23 janvier 1951, à Erevan (Armenia) demeurant au 28,

Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

2. Madame Eleonora ADIBEKIAN, chef de projet immobilier, née à Erevan (Arménie), le 12 décembre 1980, et de-

meurant au 28, Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

3. Madame Lilit ADIBEKYAN, chef de projet immobilier, née à Erevan (Arménie), le 22 mai 1985 et demeurant au 28,

Boulevard Dr Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg.

Tous ici représentés par Madame Alexandra Fuentes, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg,

en vertu de procurations signées sous seing privé à Luxembourg,

Lesquels comparants, représentés tel qu'indiqué, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte constitutif d'une

Société Anonyme de gestion de Patrimoine Familiale qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

«Titre I 

er

 . Dénomination, Siège social, Objet, Durée

Art. 1 

er

 .  Il est formé par l'actionnaire unique une société anonyme (la «Société») régie par les lois du Grand-Duché

de Luxembourg, notamment par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et telles
que complétées par la loi du 11 mai 2007 relative à la création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF») et
par les présents statuts.

La Société existe sous la dénomination de «R.A.L. MANAGEMENT S.A., SPF».

Art. 2. Le siège de la société est établi à Luxembourg.
Il pourra être transféré dans tout autre lieu de la commune par simple décision du conseil d'administration.
Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique, de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anor-
males.

Une telle décision n'aura d'effet sur la nationalité de la société. La déclaration de transfert du siège sera faite et portée

à la connaissance des tiers par l'organe de la société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances
données.

Art. 3. La société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. L'objet unique de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la réalisation des actifs financiers, dans

le sens de la loi du 5 Août 2005 sur les contrats de garantie financière, ainsi que des fonds de trésorerie et des actifs de
toute nature détenus sur un compte en banque, à l'exclusion de toute activité commerciale.

Les actifs financiers en fonction de la loi du 5 Août 2005 sur les contrats de garantie financière consistant en (a) toutes

valeurs mobilières, y compris, en particulier, les actions et autres titres équivalents à des actions, les actions d'organismes
de placement collectif, les obligations et les titres obligataires et/ou tout autre document attestant de créance sous toutes
formes, les certificats de dépôt, billets à ordre et lettres de change; (b) les titres conférant le droit d'acquérir des actions,
des obligations et des titres obligataires et les autres titres par voie de souscription, d'achat ou d'échange; (c) les instru-
ments  financiers  à  terme  et  de  valeurs  mobilières  donnant  le  droit  à  un  règlement  en  espèces  (à  l'exception  des
instruments de paiement), y compris instruments du marché monétaire; (d) tout autre titre représentant des droits de
propriété, de créances ou de valeurs mobilières; (e) tout instrument sous-jacent (qu'ils soient liés à des indices, matières
premières, métaux précieux, produits alimentaires, métaux, matières premières ou autres biens ou risques); (f) toute
réclamation relative à des points énumérés aux points (a) à (e) et tout droit sur ces éléments ou qui leur sont liés, si ces
instruments sont matérialisés ou dématérialisés, transmissibles par voie de crédit sur un compte ou par voie de négo-
ciation, les instruments au porteur ou titres nominatifs, endossables ou non, et ce, quelle que soit la loi applicable.

La Société peut prendre toutes mesures de contrôle, peut effectuer toutes opérations, que la Société jugera utiles à

l'accomplissement de son objet, sous réserve que la Société ne s'immisce pas dans la gestion de ses sociétés de partici-
pations, au sens de la Loi sur les SPF.

Titre II. Capital, Actions

Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à trente-deux mille euros (EUR 32.000,-), divisé en mille (1.000) actions d'une

valeur nominale de trente-deux euros (EUR 32,-) chacune.

Les actions sont détenues par les investisseurs plus amplement définis ci-après.
Est considéré comme investisseur éligible au sens de la Loi:
a) une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
b) une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l'intérêt du patrimoine privé d'une ou de plusieurs personnes

physiques ou

c) un intermédiaire agissant pour le compte d'investisseurs visés sub a) ou b) du présent paragraphe.

11126

L

U X E M B O U R G

Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l'attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de

la SPF.

Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l'objet d'un placement public ou être admis à la cotation d'une bourse de

valeur.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme

en matière de modification des statuts.

Les actions de la société sont nominatives ou au porteur au choix des actionnaires.
La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,

telle que modifiée, racheter ses propres actions.

Titre III. Administration

Art. 6. En cas de pluralité d'actionnaires, la Société doit être administrée par un Conseil d'Administration composé de

trois membres au moins, actionnaires ou non.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui

prendront la dénomination d'administrateurs-délégués.

Il peut aussi confier la direction de l'ensemble ou de telle partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou

plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs,
choisis dans ou hors son sein, associés ou non.

Si la Société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est

constaté que la Société a seulement un actionnaire restant, le Conseil d'Administration peut être réduit à un Adminis-
trateur (L'«Administrateur Unique») jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires constatant l'existence de
plus d'un actionnaire. Une personne morale peut être membre du Conseil d'Administration ou peut être l'Administrateur
Unique de la Société. Dans un tel cas, son représentant permanent sera nommé ou confirmé en conformité avec la Loi.

Les Administrateurs ou l'Administrateur Unique sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour une

période n'excédant pas six ans et sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale des
actionnaires. Ils restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Les Administrateurs élus sans indi-
cation de la durée de leur mandat, seront réputés avoir été élus pour un terme de six ans.

En cas de vacance du poste d'un administrateur pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs

restants  nommés  de  la  sorte  peuvent  se  réunir  et  pourvoir  à  son  remplacement,  à  la  majorité  des  votes,  jusqu'à  la
prochaine assemblée générale des actionnaires portant ratification du remplacement effectué.

Art. 7. Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige.

Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Art. 8. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges de passer tous actes d'administration et de

disposition dans l'intérêt de la Société. Tous pouvoirs que la Loi ne réserve pas expressément à l'assemblée générale des
Actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Tout Administrateur qui a un intérêt opposé à celui de la Société, dans une opération soumise à l'approbation du

Conseil d'Administration, est tenu d'en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal
de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Lors de la prochaine assemblée générale, avant tout vote sur
d'autres résolutions, il est spécialement rendu compte des opérations dans lesquelles un des Administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'un Actionnaire Unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre

la Société et son Administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la Société.

En cas d'Administrateur Unique, tous ces pouvoirs seront réservés à cet Administrateur Unique.

Art. 9. Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur Unique, par la signature

unique de son Administrateur Unique ou, en cas de pluralité d'administrateurs, par les signatures conjointes d'un des
deux Administrateurs ensemble avec un l'Administrateur délégué ou par la signature unique l'Administrateur Délégué ou
de toute personne à qui le pouvoir de signature aura été délégué par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur
Unique de la Société, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Envers les tiers, en toutes circonstances, la Société sera engagée, en cas d'Administrateur-délégué nommé pour la

gestion et les opérations courantes de la Société et pour la représentation de la Société dans la gestion et les opérations
courantes, par la seule signature de l'Administrateur-délégué, mais seulement dans les limites de ce pouvoir.

Art. 10. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société par le conseil

d'administration, poursuites et diligences de son président ou d'un administrateur délégué à ces fins.

Art. 11. La Société peut avoir un actionnaire unique lors de sa constitution. Il en est de même lors de la réunion de

toutes ses actions en une seule main. Le décès ou la dissolution de l'actionnaire unique n'entraîne pas la dissolution de la
société.

11127

L

U X E M B O U R G

S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des

actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la Société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs à l'activité de la Société.

Toute assemblée générale sera convoquée conformément aux dispositions légales.
Elles doivent être convoquées sur la demande d'Actionnaires représentant aux moins dix pour cent du capital social.
Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir pris connaissance de l'agenda de

l'assemblée, ils pourront renoncer aux formalités préalables de convocation.

Un actionnaire peut être représenté à l'assemblée générale des actionnaires en nommant par écrit (ou par fax ou par

e-mail ou par tout moyen similaire) un mandataire qui ne doit pas être un actionnaire et est par conséquent autorisé à
voter par procuration.

Les actionnaires sont autorisés à participer à une assemblée générale des actionnaires par visioconférence ou par des

moyens de télécommunications permettant leur identification et sont considérés comme présent, pour les conditions de
quorum et de majorité. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation
effective à l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue.

Sauf dans les cas déterminés par la loi ou les Statuts, les décisions prises par l'assemblée ordinaire des actionnaires

sont adoptées à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représentée.

Lorsque la société a un actionnaire unique, ses décisions sont des résolutions écrites.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée aux fins de modifier une disposition des Statuts

ne pourra valablement délibérer que si au moins la moitié du capital est présente ou représentée et que l'ordre du jour
indique les modifications statutaires proposées. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une seconde assemblée
peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts ou par la loi. Cette convocation reproduit l'ordre du jour,
en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit
la proportion du capital représenté. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent être adoptées
par une majorité de deux tiers des Actionnaires présents ou représentés.

Cependant, la nationalité de la Société ne peut être changée et l'augmentation ou la réduction des engagements des

actionnaires ne peuvent être décidées qu'avec l'accord unanime des actionnaires et sous réserve du respect de toute
autre disposition légale.

Titre IV. Surveillance

Art. 12. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale, qui fixe leur

nombre et leur rémunération, ainsi que la durée de leur mandat, qui ne peut excéder six (6) années.

Titre V. Assemblée générale

Art. 13. L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans les convo-

cations, le second mardi du mois de Juin à 13 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable suivant.

Titre VI. Année sociale, Répartition des bénéfices

Art. 14. L'année sociale commence le premier (1 

er

 ) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque

année.

Art. 15. L'excédent favorable du bilan, défalcation faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice

net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale; ce
prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois
être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve
avait été entamé.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Titre VII. Dissolution, Liquidation

Art. 16. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale.
Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes

physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Titre VIII. Dispositions générales

Art. 17. La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et la loi du 11 mai 2007 relative à la

création d'une société de gestion de patrimoine familial («SPF»), trouveront leur application partout où il n'y est pas
dérogé par les présents statuts.»

11128

L

U X E M B O U R G

<i>Dispositions transitoires

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Souscription et libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, le comparant préqualifié déclare souscrire les mille (1.000) actions:

- M. Gagik ADIBEKYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

980 actions

- Mlle Lilit ADIBEKYAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 actions

- Mlle Eleonora ADIBEKIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 actions

TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 actions

Toutes les actions ont été intégralement libérées par des versements en numéraire de sorte que la somme trente-

deux mille euros (EUR 32.000,-) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au
notaire.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 nouveau de la loi du 10 août 1915 sur

les sociétés commerciales ont été accomplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille cinq cents euros (EUR
1.500,-).

<i>Assemblée générale extraordinaire

Le comparant préqualifié, représentant la totalité du capital souscrit et agissant en tant qu'actionnaire unique de la

société a pris les résolutions suivantes:

1. L'adresse de la Société est fixée au 370, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg.
2. Est appelé aux fonctions d'Administrateur pour une période maximale de six (6) ans, son mandat expirant lors de

l'assemblée générale annuelle des actionnaires de l'année 2020:

- Monsieur Gagik ADIBEKYAN, né à Erevan (Armenia), le 23 janvier 1951, et demeurant au 28, Boulevard Dr Ernest

Feltgen, L-1515 Luxembourg;

- Madame Eleonora ADIBEKIAN, née à Erevan (Arménie), le 12 décembre 1980, et demeurant au 28, Boulevard Dr

Ernest Feltgen, L-1515 Luxembourg;

- Madame Lilit ADIBEKYAN, né à Erevan (Arménie), le 22 mai 1985 et demeurant au 28, Boulevard Dr Ernest Feltgen,

L-1515 Luxembourg.

3. Est nommé commissaire aux comptes Monsieur Dominique FONTAINE, né le 19 novembre 1965, à Saint-Mard

(Belgique) et demeurant au 78, Rue Castel, B-6700 Arlon (Belgique), son mandat arrivera à échéance lors de l'Assemblée
Générale des Actionnaires qui se tiendra en 2020.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes com-

parantes les présents Statuts sont rédigés en anglais suivis d'une version française, à la requête des mêmes personnes et
en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, celui-ci a signé avec le notaire le présent

acte.

Signé: A. Fuentes et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 24 décembre 2014. LAC/2014/63265. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur (signée): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001100/428.
(150000069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

11129

L

U X E M B O U R G

Revod Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: CAD 15.560.122,00.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 192.744.

In the year two thousand and fourteen, on the sixteenth day of December.
Before Us Maître Jean-Paul MEYERS, notary residing in Rambrouch, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

The company Dover Corporation (Canada) Limited, a British Columbia corporation, having its registered office at

2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3E8, Canada and registered with the British Columbia
Corporate Registry under the number C0975227,

here represented by Maître Jil ROESER, lawyer, residing professionally in 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lu-

xembourg,

by virtue of a proxy given under private seal
The proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and by the undersigned notary will remain

attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Such appearing party, represented as mentioned above, has requested the undersigned notary to state that it declares

being the sole member (the “Sole Member”) of the company “Revod Luxembourg S.à r.l.”, having its registered office at
5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, not yet registered with the Luxembourg Trade and Companies' register
(the “Company”), incorporated by a deed of the undersigned notary on December 5, 2014, not yet published in the
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Such appearing party, represented as mentioned above, in its capacity of Sole Member of the Company requested the

undersigned notary to state its following resolutions:

<i>First resolution

The Sole Member resolved to increase the corporate capital of the Company by an amount of fifteen million five

hundred forty-one thousand six hundred twenty-two Canadian Dollars (CAD 15,541,622.-), so as to bring the corporate
capital from its present amount of eighteen thousand five hundred Canadian Dollars (CAD 18,500) represented by eigh-
teen thousand five hundred corporate units, with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each to the amount
of fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two Canadian Dollars (CAD 15,560,122.-) represented
by fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two (15,560,122) corporate units with a nominal value
of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.

<i>Second resolution

The  Sole  Member  resolved  to  issue  fifteen  million  five  hundred  forty-one  thousand  six  hundred  twenty-two

(15,541,622) new corporate units, having a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) and having the same rights
and obligations as the existing corporate units. The new corporate units will be issued with an aggregate share premium
of one hundred thirty nine million eight hundred seventy-four thousand six hundred fifteen Canadian Dollars (CAD
139,874,615.-).

<i>Subscription - Payment

There then appeared Maître Jil ROESER, previously named, acting in her capacity as duly appointed proxy of the Sole

Member by virtue of a the aforementioned power of attorney.

The proxy-holder representing the Sole Member Dover Corporation (Canada) Limited, a British Columbia corpora-

tion, having its registered office at 2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3E8, Canada and
registered with the British Columbia Corporate Registry under the number C0975227, declared to subscribe in the name
and on behalf the Sole Member for fifteen million five hundred forty-one thousand six hundred twenty-two (15,541,622)
corporate units, with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each together with an aggregate share premium
of  one  hundred  thirty-nine  million  eight  hundred  seventy-four  thousand  six  hundred  fifteen  Canadian  Dollars  (CAD
139,874,615.-) and to make payment of such new corporate units and the attached share premium in full by

(i) a contribution in kind of the member interests the Sole Member holds in CEP Liquidation, LLC (the “CEPL Member

Interests”), a Delaware limited liability company, with registered office at 2711 Centerville RD, Suite 400, DE 19808,
United States and registered with the register of Delaware under the number 2067182 (the “CEPL Contribution”),

(ii) a contribution in kind of the member interests the Sole Member holds in SE Liquidation, LLC (the “SEL Member

Interests”), a Delaware limited liability company, having its registered office at 2711 Centerville RD, Suite 400, DE 19808,
United States and registered with the register of Delaware under the number 3444562 (the “SEL Contribution”),

(iii) a contribution in kind of the member interests the Sole Member holds in Wilden Pump and Engineering, LLC (the

“Wilden Member Interests”), a Delaware limited liability company, with registered office at 2711 Centerville RD, Suite

11130

L

U X E M B O U R G

400, DE 19808, United States and registered with the register of Delaware under the number 2901449 (the “Wilden
Contribution”) (the CEPL Contribution, the SEL Contribution and the Wilden Contribution are hereinafter collectively
referred to as the “Contributions”).

It results from a valuation report issued by the Sole Member on December 11, 2014 that:
“Based on the verification carried out as described above, the value of the CEPL Member Interests may be set at least

at fifteen million eight hundred thirty-six seven hundred five Canadian Dollars (CAD 15,836,705.-).”

It results from a valuation report issued by the Sole Member on December 11, 2014 that:
“Based on the verification carried out as described above, the value of the SEL Member Interests may be set at least

at five million six hundred sixty-one thousand nine hundred thirty-five Canadian Dollars (CAD 5,661,935.-).”

It results from a valuation report issued by the Sole Member on December 11, 2014 that:
“Based on the verification carried out as described above, the value of the Wilden Member Interests may be set at

least at one hundred thirty-three million nine hundred seventeen thousand nine hundred fifty-seven (CAD 133,917,597.-).”

The said valuation reports, after having been signed “ne varietur” by the proxy-holder and by the undersigned notary,

will remain attached to the present deed to be filed together with it with the registration authorities.

Having acknowledged the above described Contributions, the Sole Member, represented as stated above, expressly

agreed with the description of the Contributions, with their valuation, with the effective transfer of the CEPL Member
Interests, SEL Member Interests and the Wilden Member Interests to the Company and confirmed the validity of the
subscription and payment of the corporate units issued and the attached share premium.

<i>Third resolution

The Sole Member resolved amending Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company to reflect

the above resolutions.

Consequently, Article 5 paragraph 1 of the articles of association of the Company is replaced by the following text:
“The corporate capital of the Company is set at fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-two

Canadian Dollars (CAD 15,560,122.-), represented by fifteen million five hundred sixty thousand one hundred twenty-
two (15,560,122) ordinary corporate units with a nominal value of one Canadian Dollar (CAD 1.-) each.”

<i>Declarations, costs, evaluation

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently

stated, are evaluated at approximately seven thousand euros.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version. On request of the same appearing party and
in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning of this document.
The document having been read to the proxy-holder, the said proxy-holder signed together with us, the notary, the

present original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le seize décembre.
Par-devant Maître Jean-Paul MEYERS, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

La société Dover Corporation (Canada) Limited, une société régie par les lois de la Colombie-Britannique, ayant son

siège  social  au  2200  HSBC Building,  885 West  Georgia Street,  Vancouver, BC V6C 3E8,  Canada,  inscrite au British
Columbia Corporate Registry sous le numéro C0975227,

ici représentée par Maître Jil ROESER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à 69, boulevard de la Pétrusse,

L-2320 Luxembourg,

en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.
La procuration, après avoir été signée «ne varietur» par la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée au présent procès-verbal, pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, a demandé au notaire instrumentant de noter

qu'elle déclare être l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société «Revod Luxembourg S.à r.l.», société à responsa-
bilité limitée, ayant son siège social à 5, avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg, non encore immatriculée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (la «Société») constituée suivant acte du notaire instrumentant
en date du 5 décembre 2014, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Ladite partie comparante, représentée de la manière décrite ci-dessus, en sa qualité d'Associé Unique de la Société, a

demandé au notaire instrumentant de noter ses résolutions comme suit:

11131

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L'Associé Unique a décidé d'augmenter le capital social de la Société par un montant de quinze millions cinq cent

quarante-et-un mille six cent vingt-deux Dollars Canadiens (CAD 15.541.622,-) pour l'amener de son montant actuel de
dix-huit mille cinq cents Dollars Canadiens (CAD 18.500,-) représenté par dix-huit mille cinq cents (18.500) parts sociales
d'une valeur d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune à un montant de quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-
deux Dollars Canadiens (CAD 15.560.122,-) représenté par quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux
(15.560.122) parts sociales d'une valeur d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune.

<i>Deuxième résolution

L'Associé Unique a décidé d'émettre quinze millions cinq cent quarante-et-un mille six cent vingt-deux (15.541.622)

nouvelles parts sociales d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) et ayant les mêmes droits et obligations
que les parts sociales existantes. Les nouvelles parts sociales seront émises avec une prime d'émission d'un montant total
de cent trente-neuf millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quinze Dollars Canadiens (CAD 139.874.615,-).

<i>Souscription - Paiement

A comparu ensuite Maître Jil ROESER, prénommée, agissant en tant que mandataire de l'Associé Unique, la société

Dover Corporation (Canada) Limited, une société régie par les lois de la Colombie-Britannique, ayant son siège social
au 2200 HSBC Building, 885 West Georgia Street, Vancouver, BC V6C 3E8, Canada, inscrite au British Columbia Cor-
porate Registry sous le numéro C0975227 en vertu de la procuration susmentionnée.

La partie comparante représentant l'Associé Unique, comme ci-avant décrite, a déclaré souscrire au nom et pour le

compte de l'Associé Unique à quinze millions cinq cent quarante-et-un mille six cent vingt-deux (15.541.622) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1,-) chacune avec une prime d'émission d'un montant total de cent
trente-neuf millions huit cent soixante-quatorze mille six cent quinze Dollars Canadiens (CAD 139.874.615,-) et de payer
intégralement ces parts sociales et la prime d'émission y attachée par

(i) un apport en nature des parts d'associés que l'Associé Unique détient dans CEP Liquidation, LLC (les «Parts d'As-

sociés CEPL»), une société à responsabilité limitée régie par les lois de Delaware, ayant son siège social à 2711 Centerville
RD, Suite 400, DE 19808, Etats-Unis, inscrite auprès du registre de Delaware sous le numéro 2067182 («Apport CEPL»)

(ii) un apport en nature des parts d'associés que l'Associé Unique détient dans SE Liquidation, LLC (les «Parts d'Associés

SEL»), une société à responsabilité limitée régie par les lois de Delaware ayant son siège social à 2711 Centerville RD,
Suite 400, DE 19808, États-Unis inscrite auprès du registre de Delaware sous le numéro 3444562 («Apport SEL»),

(iii) un apport en nature des parts d'associés que l'Associé Unique détient dans Wilden Pump and Engineering, LLC

(les «Parts d'Associés Wilden»), une société à responsabilité limitée régie par les lois de Delaware, ayant son siège social
au 2711 Centerville RD, Suite 400, DE 19808, États-Unis, inscrite au registre de Delaware sous le numéro 2901449
(«Apport Wilden»), (Apport CEPL, Apport SEL et Apport Wilden ensemble ci-après les «Apports»).

Il résulte d'un rapport d'évaluation émis par l'Associé Unique le 11 décembre 2014 que:
«Sur base des vérifications apportées selon la description ci-dessus, la valeur des Parts d'Associés CEPL est d'au moins

quinze millions huit cent trente-six mille sept cent cinq Dollars Canadiens (CAD 15.836.705,-).»

Il résulte d'un rapport d'évaluation émis par l'Associé Unique le 11 décembre 2014 que:
«Sur base des vérifications apportées selon la description ci-dessus, la valeur des Parts d'Associés SEL est d'au moins

cinq millions six cent soixante-et-un mille neuf cent trente-cinq Dollars Canadiens (CAD 5.661.935,-).»

Il résulte d'un rapport d'évaluation émis par l'Associé Unique le 11 décembre 2014 que:
«Sur base des vérifications apportées selon la description ci-dessus, la valeur des Parts d'Associés Wilden est d'au

moins  cent  trente-trois  millions  neuf  cent  dix-sept  mille  cinq  cent  quatre-vingt-dix-sept  Dollars  Canadiens  (CAD
133.917.597,-) Dollars Canadiens.»

Lesdits rapports d'évaluations, après avoir été signés «ne varietur» par la partie comparante et par le notaire soussigné,

resteront annexés au présent acte afin d'être enregistrés en même temps auprès des autorités compétentes.

Ayant reconnu les Apports en nature décrit ci-dessus, l'Associé Unique, représenté comme mentionné ci-avant, a

donné expressément son accord sur la description des Apports, leur évaluation, avec le transfert effectif des Parts d'As-
sociés CEPL, des Parts d'Associés SEL et des Parts d'Associés Wilden à la Société et a confirmé la validité de la souscription
et du paiement des parts sociales émises et de la prime d'émission y attachée.

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique a décidé de modifier l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société pour refléter les résolutions

ci-avant.

Par conséquent, l'article 5 paragraphe 1 des statuts de la Société est remplacé par le texte suivant:
«Le capital social de la Société est fixé à quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux Dollars Canadiens

(CAD 15.560.122,-) représenté par quinze millions cinq cent soixante mille cent vingt-deux (15.560.122) parts sociales
d'une valeur nominale d'un Dollar Canadien (CAD 1) chacune.»

11132

L

U X E M B O U R G

<i>Déclarations, frais, évaluation

Les frais, coûts, rémunérations et charges de quelque nature que ce soit incombant à la Société en raison du présent

acte, sont estimés approximativement à sept mille euros.

Le notaire instrumentant, qui comprend et parle l'anglais, déclare par la présente que, sur requête de la partie com-

parante susnommée, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française. A la requête de la même personne
comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Après lecture au mandataire, le mandataire a signé ensemble avec le notaire le présent acte.
Signé: Roeser, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 19 décembre 2014. Relation: RED/2014/2552. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 31 décembre 2014.

Référence de publication: 2015001103/180.
(140235824) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

RZ Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 8, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 78.726.

In the year two thousand and fourteen, on the seventeenth day of December.
Before Us Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg.

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of "RZ Holding S.A.", a société annonyme holding having its

registered office in L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, registered with the R.C.S Luxembourg number B78.726 and
incorporated by a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, notary residing in Sanem, dated October 30 

th

 , 2000, published

in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 359 of May 16 

th

 , 2001. The Articles of Association

have not been amended since.

The meeting is presided by Mr Karim VAN DEN ENDE, private employee, residing professionally in L-2449 Luxem-

bourg, 8, Boulevard Royal,

who appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKE, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg, 74,

Avenue Victor Hugo.

The meeting elects as scrutineer Mr Liridon ELSHANI, private employee, residing professionally in L-1750 Luxembourg,

74, Avenue Victor Hugo.

The office of the meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the notary to state:
I. That the shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an

attendance list signed “ne varietur” by the shareholders or their proxies, by the office of the meeting and the notary. The
said list as well as the proxies will be registered with this deed.

II. That it appears from the attendance list, that all of the shares are represented. The meeting is therefore regularly

constituted and can validly deliberate and decide on the aforecited agenda of the meeting, of which the shareholders have
been informed before the meeting.

III. That the agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda:

1) Deletion of the indication of the nominal value of the shares.
2) Conversion of the subscribed capital of the Company from five million six hundred thousands Icelandic Krona (ISK

5,600,000.-) into Euro according to the official exchange rate published two business days immediately preceding the
conversion.

3) Amendment of Article 5 of the articles of incorporation in order to reflect the above taken resolutions.
4) Miscellaneous.
After the foregoing was approved by the meeting, the meeting unanimously took the following resolutions:

<i>First resolution

The meeting decides to delete the par value of the shares.

11133

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

The meeting decides to convert the subscribed share capital of the Company from five million six hundred thousand

Icelandic Krona (ISK 5,600,000.-) into Euro according to the official exchange rate 1 ISK/0.0064 EUR applicable by XE.com
on December 15 

th

 2014, and sets the subscribed capital at thirty-five thousand eight hundred and forty Euro (EUR

35,840.-), represented by fifty-six thousand (56,000.-) shares without par value.

<i>Third resolution

Following the foregoing resolutions, Article 5 of the Articles of Incorporation is amended so as to read as follows:

“ Art. 5. The subscribed share capital is set at thirty-five thousand eight hundred and forty Euro (EUR 35,840.-),

represented by fifty-six thousand (56,000.-) shares without indication of a nominal value.

Each share is entitled to one vote in ordinary and extraordinary general meetings.”
Nothing else being on the agenda, the chairman closes the meeting.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on the request of the above ap-

pearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing
persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day mentioned at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary by their surnames,

names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us the notary the present original
deed.

Suit la traduction en langue française

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Par-devant Nous Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

S'est réunie

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «RZ Holding S.A.», avec siège social à

L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal, immatriculée avec le numéro R.C.S Luxembourg B78.726 et constituée suivant
acte reçu par le notaire Jean-Jospeh WAGNER, de résidence à Sanem en date du 30 octobre 2000, publié au Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 359 du 16 mai 2001. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Karim VAN DEN ENDE, employé privé, demeurant profes-

sionnellement à L-2449 Luxembourg, 8, Boulevard Royal,

qui désigne comme secrétaire Madame Marilyn KRECKE, employée privée, demeurant professionnellement à L-1750

Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Liridon ELSHANI, employé privé, demeurant professionnellement à

L-1750 Luxembourg, 74, Avenue Victor Hugo.

Le bureau ainsi constitué, Monsieur le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:
I. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence signée «ne varietur» par les actionnaires présents, les
mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire. Ladite liste
de présence, ainsi que les procurations des actionnaires représentés resteront annexées au présent acte pour être sou-
mises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction

des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et déclarant par
ailleurs, avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

III. Que la présente Assemblée Générale Extraordinaire a pour ordre du jour:

<i>Ordre du jour:

1. Suppression de la valeur nominale des actions;
2. Décision concernant la conversion du capital social actuel de la Société de cinq million six cent mille Couronnes

Islandaises (ISK 5.600.000.-) en Euros, conformément au taux de change officiel publié deux jours ouvrés précédant la
conversion;

4. Modification de l'article 5 des statuts afin de l'adapter à la décision précédemment prise;
5. Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, cette dernière, après délibération, a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de supprimer la valeur nominale des actions.

11134

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide de convertir le capital social souscrit de la Société de cinq million six cent mille Couronnes Islan-

daises (ISK 5.600.000.-) en Euros, au taux de change officiel publié au XE.com, soit 1 ISK/0,0064 EUR applicable au 15
décembre 2014, et fixe le capital souscrit à trente-cinq mille huit cent quarante euros (EUR 35.840,-), représenté par
cinquante-six milles (56,000) actions sans valeur nominale.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions prises ci-avant, l'article 5 des statuts est modifié et aura désormais la teneur suivante:

« Art. 5. Le capital social est fixé trente-cinq mille huit cent quarante euros (EUR 35.840,-), représenté par cinquante-

six milles (56,000) actions sans valeur nominale.

Chaque action donne droit à une voix dans les assemblée générales ordinaire et extraordinaires.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
Le notaire instrumentaire qui comprend et parle la langue anglaise, déclare que sur la demande des comparants le

présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Il est spécifié qu'en cas de divergences entre la
version anglaise et la version française, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels, états et demeures,

lesdits comparants ont signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: K. Van den Ende, M. Krecké, L. Elshani et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 23 décembre 2014. LAC/2014/62819. Reçu soixante-quinze euros (75.- €).

<i>Le Receveur (signé): Irène Thill.

POUR COPIE CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication au

Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Référence de publication: 2015001118/114.
(150000254) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Sheik Coast S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 41.313.

L'an deux mille quatorze, le seize décembre.
Par devant Maître Blanche MOUTRIER, Notaire de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché du Luxembourg).

S'est tenue

une Assemblée Générale Extraordinaire de «SHEIK COAST S.A.», une société anonyme de droit luxembourgeois

ayant son siège social à L-1114 Luxembourg 10, rue Nicolas Adames (Grand-Duché de Luxembourg) et inscrite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 41 313, constituée le 7 septembre 1992 par devant
Maître Marc Elter, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), acte publié au Mémorial C, Recueil
Spécial des Sociétés et Associations, numéro 585 de 1992, acte modifié pour la dernière fois sous seing privé le 28 juin
2002, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 1456 du 9 octobre 2002 («la Société»).

L'Assemblée Générale était présidée par Maître Charles Duro, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à 03,

rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président a désigné comme secrétaire Maître Lionel Bonifazzi. avocat à la Cour, demeurant professionnellement à

03, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale a choisi comme scrutateur Mlle Valeria Ercolini, juriste, demeurant professionnellement à 03,

rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).

Le président déclare et prie le notaire d'acter:
I. Qu'il résulte d'une liste de présence dressée et certifiée par les membres du bureau que l'intégralité du capital social

libéré et émis est dûment représentée à la présente Assemblée qui en conséquence est régulièrement constituée et peut
délibérer ainsi que décider valablement sur les points figurant à l'ordre du jour ci-après reproduit, tous les actionnaires
ayant accepté de se réunir sans convocation préalable.

II. Ladite liste de présence, portant les signatures des actionnaires tous présents ou représentés, restera annexée au

présent procès-verbal ensemble avec les procurations pour être soumise en même temps aux formalités de l'enregis-
trement.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

11135

L

U X E M B O U R G

<i>Ordre du jour

1. Dissolution avec effet immédiat et liquidation volontaire de la Société;
2. Nomination de ADLS s.à.r.l. aux fonctions de liquidateur de la Société;
3. Détermination des pouvoirs du Liquidateur et de la procédure de liquidation de la Société;
4. Divers.
Après avoir délibéré, l'Assemblée Générale a pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée Générale décide de dissoudre la Société avec effet immédiat et de la mettre en liquidation volontaire.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée Générale décide de nommer comme liquidateur de la Société ADSL s.à.r.l., une société à responsabilité

limitée de droit luxembourgeois ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 60, avenue de la Faïencerie (“le Liquidateur”).

<i>Troisième résolution

L'Assemblée Générale décide de conférer au Liquidateur les pouvoirs les plus larges pour effectuer sa mission, et, plus

spécialement ceux indiqués aux articles 144 jusque 148 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales ainsi que ses modifications.

L'Assemblée  Générale,  entre  autre,  décide  et  reconnaît  que  la  Société  sera  engagée  envers  les  tiers  par  la  seule

signature du Liquidateur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Dont procès-verbal, passé à Luxembourg, les jours, mois et an qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec Nous, notaire, la présente minute.
Signé: DURO, BONZIFFAZI, ERCOLINI, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24/12/2014. Relation: EAC/2014/18216. Reçu douze euros 12,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 02/01/2015.

Référence de publication: 2015001144/56.
(150000041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 2 janvier 2015.

Levhotel S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 31-33, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 66.224.

Le Bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014208203/10.
(140233137) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 décembre 2014.

Lostres S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 5, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 98.035.

Suite à la démission de la Fiduciaire Jean-Marc Faber &amp; Cie Sàrl de son poste de Commissaire aux Comptes en date

du 18/12/2014, avec effet au 01/01/2014, il y a lieu de rayer son inscription auprès du RCS.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
LOSTRES S.A.
Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014205928/15.
(140231140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

11136


Document Outline

BSO Network Solutions Luxembourg S.à.r.l.

Digital Services XXIX Top-Holding S.C.Sp.

HAB2 Prop Co. C S.à r.l.

Highstreet II PropCo II S.à.r.l.

Join Expérience S.A.

Levhotel S.A.

Lostres S.A.

Novaro Mediterranean S.A.

NRGenerating Luxembourg (No.1) S.à r.l.

NRGenerating Luxembourg (No.2) S.à r.l.

Nsearch S.A.

Nucco 1 S.à r.l.

Nucco 2 S.à r.l.

Nucco 3 S.A.

Nucco 4 S.A.

Obika Holdings S.A.

Octogone S.à r.l.

Odyssey Fund Sicav SIF

Oeko-Service Luxemburg (O.S.L.) S.A.

OPF Immo S.A.

Optique Quaring Bonnevoie S.à r.l.

Oriolan S.A.

Paris-les-Bains S.à r.l.

Partners Group Prime Yield, S.à r.l.

Patrimoine &amp; Conseils S.A.

Patron Caldew S.à r.l.

Patron Dieter II S. à r. l.

Patron Investments III S.à r.l.

PeaksideWert 2 S.à r.l.

Percival Properties

PetroSantander Luxembourg Holdings S.à r.l.

Photovoltaïque Mergen-Origer

Picton S.à r.l.

Porta Nova Participations SA

Pradera Holdco S.à r.l.

Prevprop Properties S.A.

R.A.L. Management S.A., SPF

Revod Luxembourg S.à r.l.

RZ Holding S.A.

Sheik Coast S.A.

THOMAS COOK succursale Luxembourg