logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 138

19 janvier 2015

SOMMAIRE

Anlogistyk Management S.à.r.l. . . . . . . . . . .

6591

CEP III Investment 17 S.à r.l. . . . . . . . . . . . .

6600

Daily Snack S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

DdC Consulting S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

De Keisecker S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Delta Concept Investissement S.A.  . . . . . .

6578

Delta Information Technologies S.A.  . . . .

6579

Devel+  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6579

Dexton Group S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Dexton ICT S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6578

Dexton Software S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6579

DH Holding (Luxembourg) S.à r.l.  . . . . . . .

6579

Diederich & Sinner S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . .

6580

Dienes International Beteiligungsgesell-

schaft mbH  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6580

Digital Services XVII S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6602

Disposable Solutions S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6580

DR Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6580

DR Invest S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Dudelounge S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Duisburg Holding (Luxembourg) S.A.  . . . .

6581

Eastern Domus Ventures  . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Edison Aviation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Edison Yachting S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Elie Saab Luxembourg S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

6583

Eschtari S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6622

Eurêka Solutions S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Euro'Pain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

European Direct Property IV S.A.  . . . . . . .

6579

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A. . . . .

6580

EuroProp (EMC VI) S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Exigo S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

Exploitation de carrières savonnières S.à

r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6583

Intaris - Salaires et Gestion  . . . . . . . . . . . . .

6624

International Campus Köln S.à r.l.  . . . . . . .

6621

Jenny Location S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6581

Kaola S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6621

Lex II Investments Holdings S.A.  . . . . . . . .

6584

Lex Investments Holdings S.A.  . . . . . . . . . .

6584

Oben der Kirch s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6602

Oben der Kirch s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6602

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A. . . .

6585

Organik Luxembourg S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

6584

Oropan International S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

6602

Oteo Investment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

6584

Parkwood (Cologne) S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

6584

Parthi SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6582

S.A. Grand Garage Olivier ORIGER  . . . . .

6599

TB Intermediate Holdings S.à r.l.  . . . . . . . .

6587

6577

L

U X E M B O U R G

Daily Snack S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2514 Luxembourg, 15, rue Jean-Pierre Sauvage.

R.C.S. Luxembourg B 166.945.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204077/9.
(140228797) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

De Keisecker S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6131 Junglinster, Centre Commercial Langwies.

R.C.S. Luxembourg B 45.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204085/10.
(140228722) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Delta Concept Investissement S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 71.979.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014204086/11.
(140227537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Dexton Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 18.600,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 155.547.

Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014204091/12.
(140228437) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Dexton ICT S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 146.951.

Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014204092/12.
(140228438) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6578

L

U X E M B O U R G

Delta Information Technologies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8245 Mamer, 9B, rue de la Libération.

R.C.S. Luxembourg B 110.023.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204087/10.
(140228168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Devel+, Société Anonyme.

Siège social: L-9964 Schmiede, 3, Op d'Schmett.

R.C.S. Luxembourg B 128.166.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Internationale SA

Référence de publication: 2014204090/10.
(140229080) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Dexton Software S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 143.890.

Le bilan de la société au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

<i>Pour la société
Un mandataire

Référence de publication: 2014204093/12.
(140228436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

DH Holding (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée holding unipersonnelle.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 125.067.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014204094/10.
(140228448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

EDP IV S.A., European Direct Property IV S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 44, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 129.794.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour European Direct Property IV S.A., en abrégé EDP IV S.A.
BNP Paribas Real Estate Investment Management Luxembourg S.A.
Signatures

Référence de publication: 2014204123/12.
(140229107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6579

L

U X E M B O U R G

Diederich &amp; Sinner S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3378 Livange, Zone Industrielle.

R.C.S. Luxembourg B 21.748.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204095/10.
(140228817) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3265 Bettembourg, 4, Op Fankenacker.

R.C.S. Luxembourg B 96.663.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204096/10.
(140228140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Disposable Solutions S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 56, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 168.629.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour DISPOSABLE SOLUTIONS S.à r.l.
United International Management S.A.

Référence de publication: 2014204099/11.
(140228115) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

DR Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.816.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204104/9.
(140228607) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 36, avenue Marie-Thérèse.

R.C.S. Luxembourg B 112.881.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014204165/14.
(140227695) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6580

L

U X E M B O U R G

DR Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 165.816.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204105/9.
(140228610) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

DdC Consulting S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2342 Luxembourg, 48-50, rue Raymond Poincaré.

R.C.S. Luxembourg B 121.215.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204067/10.
(140228714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Dudelounge S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3490 Dudelange, 4-6, rue Jean Jaurès.

R.C.S. Luxembourg B 122.984.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204107/10.
(140228723) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Duisburg Holding (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 122.244.

Les Comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Schuttrange, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014204108/10.
(140228112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Jenny Location S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8010 Strassen, 224, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 114.693.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2014.

<i>Pour JENNY LOCATIONS SARL
CONSTRUCTIONS CREA HAUS S.A.
224, route d'Arlon
L-8010 STRASSEN
Signature

Référence de publication: 2014204396/15.
(140228393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6581

L

U X E M B O U R G

Eastern Domus Ventures, Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, boulevard J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 169.861.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204110/9.
(140228180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Edison Aviation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.935.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204111/9.
(140228913) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Edison Yachting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 35A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 176.934.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204112/9.
(140228908) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Exigo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 11, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 132.099.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22/12/2014.

G.T. Experts Comptables Sàrl
Luxembourg

Référence de publication: 2014204175/12.
(140229106) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Parthi SA, Société Anonyme.

Siège social: L-8480 Eischen, 24, Cité Aischdall.

R.C.S. Luxembourg B 125.636.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Strassen, le 19 décembre 2014.

<i>Pour PARTHI S.A.
CONSTRUCTIONS CREA HAUS S.A.
224, route d'Arlon
L-8010 STRASSEN
Signature

Référence de publication: 2014204719/15.
(140228392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6582

L

U X E M B O U R G

Elie Saab Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 169.124.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014204115/10.
(140228252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Eurêka Solutions S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4053 Esch-sur-Alzette, 1, rue des Charbons.

R.C.S. Luxembourg B 172.272.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Eurêka Sàrl
Signature

Référence de publication: 2014204121/11.
(140228151) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

EuroProp (EMC VI) S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 127.186.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014204126/10.
(140227655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Exploitation de carrières savonnières S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7339 Steinsel, 40, rue des Vergers.

R.C.S. Luxembourg B 32.056.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Windhof, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014204128/10.
(140227651) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Euro'Pain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1880 Luxembourg, 30, rue Pierre Krier.

R.C.S. Luxembourg B 169.197.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire WBM
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014204160/13.
(140228570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6583

L

U X E M B O U R G

Lex Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 93.496.

Le bilan au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014204445/10.
(140227869) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Lex II Investments Holdings S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 39, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 98.289.

Le bilan au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014204446/10.
(140228032) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Organik Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1253 Luxembourg, 2A, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 95.145.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour ORGANIK LUXEMBOURG S.A.
Un mandataire

Référence de publication: 2014204666/11.
(140228274) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Parkwood (Cologne) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2212 Luxembourg, 6, place de Nancy.

R.C.S. Luxembourg B 125.027.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Signature

Référence de publication: 2014204679/11.
(140228501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Oteo Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 156.139.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Extrait sincère et conforme
OTEO INVESTMENT S.à r.l.
Signature

Référence de publication: 2014204669/12.
(140227384) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6584

L

U X E M B O U R G

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.639.

DISSOLUTION

In the year two thousand and fourteen, tenth of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, (Grand-Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1.- OCM Luxembourg POF IIIA S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 110.180,

2.- OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, registered

with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 116.601,

3.- OCM  Luxembourg OPPS  VI S.à  r.l.,  having its  registered office in L-2449 Luxembourg,  26A,  boulevard  Royal,

registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 121.877,

4.- OCM Luxembourg POF III S.à r.l., having its registered office in L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, regis-

tered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 109.801

all four here represented by Mr. Henri DA CRUZ, employee, residing professionally in Junglinster, by virtue of four

powers of attorney delivered to him under private seal.

Said powers of attorney, after having been signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the

officiating notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

Such appearing parties, represented as above stated, declare and request the notary to act the following:
1.- That the société anonyme incorporated and existing under the form of société anonyme and under the name of

“OCM  /  Nordenia  Luxembourg  GP  S.A.”,  having  its  registered  office  in  L-2449  Luxembourg,  26A,  boulevard  Royal,
registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register at section B, under the number 114.639, has been
incorporated on February 21, 2006 pursuant to a deed of Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notary, residing in
Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1023, page 49066 of May 26,
2006. The Articles of association of the Company (the Articles) have not been amended since its incorporation.

2.- That the share capital is set at thirty-one thousand Euro (EUR 31,000.-) consisting of twenty-four thousand eight

hundred (24,800) shares having a par value of one Euro twenty-five cents (EUR 1.25) each.

3.- That the appearing parties, represented as above stated, are the owner of all shares of the Company.
4.- That the appearing parties, represented as above stated, acting as shareholders of the Company, declares to proceed

with the dissolution of the Company.

5.- That the appearing parties, represented as above stated, appoint Headstart Management Services S.à r.l., a Luxem-

bourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 7, rue Robert
Stümper, L-2557 Luxembourg, and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 155.181 as liquidator of the Company, and in its capacity as liquidator of the Company shall have full powers to sign,
execute and deliver any acts and any documents, to make any declaration and to do anything necessary or useful so to
bring into effect the purposes of this deed.

6.- That the appearing parties, represented as above stated, declare that they irrevocably undertakes to settle any

presently known and unknown unpaid liability of the dissolved company.

7.- That the appearing parties, represented as above stated, declare that they take over all the assets of the Company,

and that they will assume any existing debt of the Company pursuant to section 6.

8.- That the appearing parties, represented as above stated, declare that the liquidation of the Company is closed and

that the share or bond certificates, the shareholders register as well as any register of the Company recording the issuance
of shares or of any other securities shall be cancelled.

9.- That full discharge is given to all the members of the board of directors and to the statutory auditor of the Company

for the exercise of their mandates as of the present date.

10.- That the books and documents of the Company will be kept for a period of five years at least in Luxembourg at

the former registered office of the Company in L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

<i>Costs

The amount of costs, expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the company and

charged to it by reason of the present deed is therefore estimated at nine hundred fifty Euros (EUR 950.-)

6585

L

U X E M B O U R G

<i>Statement

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing parties
and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by surname, Christian

name, civil status and residence, said proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le dix décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

A COMPARU:

1.- OCM Luxembourg POF IIIA S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 110.180,

2.- OCM Luxembourg EPOF S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite auprès

du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 116.601,

3.- OCM Luxembourg OPPS VI S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 121.877,

4.- OCM Luxembourg POF III S.à r.l., ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal, inscrite

auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro 109.801,

toutes les quatre ici représentées par Monsieur Henri DA CRUZ, employé, demeurant professionnellement à Jun-

glinster, en vertu de deux procurations sous seing privé lui délivrée.

Lesquelles procurations, après avoir été signées «ne varietur» par le notaire et le mandataire, resteront annexées au

présent acte avec lequel elles seront enregistrées.

Lesquelles parties comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, déclarent et requièrent le notaire instrumentant

d'acter ce qui suit:

1.- Que la société anonyme, «OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A.», ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,

26A, boulevard Royal, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg section B, sous le numéro
114.639, a été constituée le 21 février 2006 suivant un acte de Maître André-Jean-Joseph Schwachtgen, notaire de rési-
dence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1023, page 49066, du 26 mai
2006. Les statuts de la Société (les Statuts) n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

2.- Que le capital de la Société est fixé à EUR 31.000,- (trente-et-un mille Euros), divisé en vingt-quatre mille huit cents

(24.800) actions d'une valeur nominale de d'un euro et vingt-cinq centimes (EUR 1,25) chacune.

3.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, sont les seules propriétaires de toutes les actions

de la Société.

4.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, agissant comme associée, prononce la dissolution

anticipée de la Société.

5.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, désignent Headstart Management Services S.à r.l.,

une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7, rue Robert Stümper, L-2557
Luxembourg, et étant immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 155.181,
comme liquidateur de la Société, qui aura le pouvoir, en tant que liquidateur de la Société, d'établir, signer, exécuter et
délivrer tous actes et documents, de faire toute déclaration et de faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour mettre
en exécution les dispositions du présent acte.

6.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent de manière irrévocable reprendre tout

le passif présent et futur de la société dissoute.

7.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent qu'elles reprennent tout l'actif de la

Société et qu'elles s'engageront à régler tout le passif de la Société indiqué à la section 6.

8.- Que les parties comparantes, représentées comme dit ci-avant, déclarent que la liquidation de la Société est dès

lors clôturée et que les certificats d'actions ou d'obligations, le registre des actionnaires, ainsi que tout autre registre de
la Société relatif à l'émission d'actions ou de tous autres titres sera annulé.

9.- Que la décharge pleine et entière est donnée à tous les membres du conseil d'administration et au commissaire

aux comptes de la Société pour l'exécution de leurs mandats respectifs jusqu'à la date de ce jour.

10.- Que les livres et documents de la Société seront conservés pendant cinq ans au moins à Luxembourg à l'ancien

siège social de la Société à savoir à L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

6586

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société

à raison de cet acte, est dès lors évalué à neuf cent cinquante euros (EUR 950,-).

<i>Constatation

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de parties comparantes

le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête de cette même partie comparante et en
cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire par nom,

prénom usuel, état et demeure, le prédit mandataire a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/4968. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014204651/121.
(140228030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

TB Intermediate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: USD 5.020.000,00.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J. F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 190.946.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of November at 2:55 p.m. Central European Time.
Before Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

There appeared:

TB International Holdings I S.à r.l., a private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), organised

under the laws of Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855
Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.219 (the “Sole
Shareholder”),

hereby represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, with professional address at 101, rue Cents, L-1319 Luxem-

bourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed “ne varietur” by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the

undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:
I.- The appearing party is the sole shareholder of TB Intermediate Holdings S.à r.l., a private limited liability company

(“société à responsabilité limitée”) organized under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered
office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, incorporated by a deed enacted by Maître Edouard Delosch,
notary residing in Diekirch, on 9 October 2014, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations”
dated 18 November 2014 number 3.439, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number
B 190.946 (the “Company”).

II.-  The  2,000,000 (two million)  shares, with  a  nominal  value of USD  0.01 (one United  States  Dollar  Cent) each,

representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the
items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

III.- The agenda of the meeting is the following:

<i>Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Increase of the share capital of the Company by an amount of USD 5,000,000 (five million United States Dollars)

so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States Dollars) to USD 5,020,000 (five
million twenty thousand United States Dollars) by the issuance of 500,000,000 (five hundred million) new shares of the
Company with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) each, the whole to be fully paid up through
a contribution in kind;

3. Subscription and payment by the Sole Shareholder of the new shares by way of a contribution in kind;
4. New composition of the shareholding of the Company;
5. Subsequent amendment to the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company; and
6. Miscellaneous.

6587

L

U X E M B O U R G

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

<i>First resolution:

The Sole Shareholder resolves to waive its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder

acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers the meeting to be validly convened and therefore
agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation
has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine
carefully each document.

<i>Second resolution:

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of USD 5,000,000 (five

million United States Dollars), so as to raise it from its current amount of USD 20,000 (twenty thousand United States
Dollars) to USD 5,020,000 (five million twenty thousand United States Dollars) by the issuance of 500,000,000 (five
hundred million) new shares with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar Cent) each (the “New Shares”),
the whole to be fully paid by a contribution in kind made by the Sole Shareholder.

<i>Third resolution:

The Sole Shareholder further resolves to accept the subscription and the payment by the Sole Shareholder of the New

Shares through the contribution in kind as detailed below.

<i>Intervention - Subscription - Payment

Thereupon intervenes the Sole Shareholder, hereby represented by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy

given under private seal and declares to subscribe to the New Shares.

The New Shares have been fully paid-up by the Sole Shareholder through a contribution in kind as described below.

<i>Description of the contribution

The contribution made by the Sole Shareholder, in exchange for the issuance of the New Shares, is composed of all

the 2,000,000 (two million) ordinary shares and 2 (two) class B shares held by the Sole Shareholder in TB International
Holdings II S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated under the laws of
Luxembourg, having its registered office at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxem-
bourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 190.230 (the “Contribution”).

<i>Valuation

The net value of the Contribution amounts to USD 5,000,000 (five million United States Dollars).
Such valuation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value

dated November 25, 2014, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

<i>Evidence of the Contribution's existence

A proof of the existence of the Contribution has been given to the undersigned notary.

<i>Managers' intervention

Thereupon intervene:
a) Wolfgang Preiss, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, manager;

b)  Darin  Orr,  residing  professionally  at  1900  Colonel  Sanders  Lane,  Louisville,  Kentucky  40213,  United  States  of

America, manager; and

c) Michael McAuliffe, residing professionally at 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of

Luxembourg, manager;

all  represented  here  by  Mr.  Régis  Galiotto,  prenamed,  by  virtue  of  a  proxy  contained  in  the  above  statement  of

contribution value.

Acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the

Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation,
and confirm the validity of the subscription and payment.

<i>Fourth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, the shareholding of the Company is now composed as

follows:

- TB International Holdings I S.à r.l.: 502,000,000 (five hundred two million) shares.
The notary acts that the 502,000,000 (five hundred two million) shares, representing the entire share capital of the

Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

6588

L

U X E M B O U R G

<i>Fifth resolution:

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the Contribution having been fully carried out, it

is resolved to amend the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

“ Art. 8. The Company's share capital is set at USD 5,020,000 (five million twenty thousand United States Dollars),

represented by 502,000,000 (five hundred two million) shares with a nominal value of USD 0.01 (one United States Dollar
Cent) each.“

No other amendments shall be made to this article.

<i>Estimate of costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be

charged to it in connection with this deed, have been estimated at about six thousand Euro (EUR 6,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original

deed.

Traduction française du texte qui précède

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq novembre à 14h55, heure d'Europe centrale.
Par devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

TB International Holdings I S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-Duché de

Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée auprès du
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.219 (l'«Associé Unique»),

ici dûment représentée par Monsieur Régis Galiotto, clerc de notaire, avec adresse professionnelle sise au 101, rue

Cents, L-1319 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et

le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci auprès des autorités de
l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I. La partie comparante est l'associé unique de TB Intermediate Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée,

constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, Avenue John F. Kennedy,
L-1855 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, le 9
octobre 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations daté du 18 novembre 2014 numéro 3.439,
immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.946 (la «Société»).

II. Les 2.000.000 (deux millions) de parts sociales d'une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain)

chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valable-
ment se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été dûment préalablement
informé.

III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 5.000.000 USD (cinq millions de dollars américains)

afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt-mille dollars américains) à 5.020.000 USD (cinq millions
vingt mille dollars américains) par l'émission de 500.000.000 (cinq cent millions) nouvelles parts sociales d'une valeur
nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) chacune, le tout devant être entièrement libéré au moyen d'un apport
en nature;

3. Souscription et libération par l'Associé Unique des nouvelles parts sociales par voie d'apport en nature;
4. Nouvelle composition de l'actionnariat de la Société;
5. Modification subséquente du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société; et
6. Divers.
Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

6589

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution:

L'Associé Unique décide de renoncer à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'Associé Unique

reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en consé-
quence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble
de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre
un examen attentif de chaque document.

<i>Deuxième résolution:

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 5.000.000 USD (cinq millions de

dollars américain) afin de le porter de son montant actuel de 20.000 USD (vingt-mille dollars américains) à 5.020.000
USD (cinq millions vingt mille dollars américains) par l'émission de 500.000.000 (cinq cent millions) nouvelles parts sociales
d'une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar américain) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»), le tout devant
être entièrement libéré au moyen d'un apport en nature réalisé par l'Associé Unique.

<i>Troisième résolution:

L'Associé Unique décide ensuite d'accepter la souscription et la libération par l'Associé Unique des Nouvelles Parts

Sociales par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Intervention - Souscription - Paiement

Intervient ensuite l'Associé Unique, ici représenté par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration

donnée sous seing privé qui déclare souscrire les Nouvelles Parts Sociales.

Les Nouvelles Parts Sociales ont été entièrement souscrites par voie de l'apport en nature tel que décrit ci-après.

<i>Description de l'apport

L'apport réalisé par l'Associé Unique, en échange de l'émission des Nouvelles Parts Sociales est composé de l'ensemble

des 2.000.000 (deux millions) de parts sociales ordinaires et de 2 (deux) parts sociales de classe B détenues par l'Associé
Unique dans TB International Holdings II S.à r.l., une société à responsabilité limitée organisée selon les lois du Grand-
Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 46a, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg et immatriculée
auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 190.230 (l'«Apport»).

<i>Evaluation

La valeur nette de l'Apport s'élève à 5.000.000 USD (cinq millions de dollars américains).
Une telle évaluation a été approuvée par les gérants de la Société conformément à une déclaration sur la valeur de

l'apport en date du 25 novembre 2014, qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités
d'enregistrement.

<i>Preuve de l'existence de l'Apport

Preuve de l'existence de l'Apport a été donnée au notaire soussigné.

<i>Intervention des gérants

Interviennent ensuite:
a) Wolfgang Preiss, résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché

de Luxembourg, gérant;

b) Darin Orr, résidant professionnellement au 1900 Colonel Sanders Lane, Louisville, Kentucky 40213, Etats Unis

d'Amérique, gérant; et

c) Michael McAuliffe, résidant professionnellement au 46a, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché

du Luxembourg, gérant.

Tous représentés par Monsieur Régis Galiotto, prénommé, en vertu d'une procuration contenue dans la déclaration

sur la valeur de l'apport visée ci-dessus.

Reconnaissent avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement tenus en tant que

gérants de la Société en raison de l'Apport, acceptent expressément la description de cet Apport, avec son évaluation,
et confirment la validité de la souscription et du paiement.

<i>Quatrième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, l'actionnariat de la Société est désormais composé com-

me suit:

- TB International Holdings I S.à r.l.: 502.000.000 (cinq cent deux millions) de parts sociales.
Le notaire constate que les 502.000.000 (cinq cent deux millions) parts sociales représentant l'intégralité du capital

social de la Société sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement décider de la résolution à prendre ci-
dessous.

6590

L

U X E M B O U R G

<i>Cinquième résolution:

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport ayant été totalement réalisé, il est décidé de

modifier le premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

« Art. 8. Le capital social de la Société est fixé à 5.020.000 USD (cinq millions vingt mille dollars américains), représenté

par 502.000.000 (cinq cent deux millions) de parts sociales ayant une valeur nominale de 0,01 USD (un cent de dollar
américain) chacune.»

Aucune autre modification n'étant apportée à cet article.

<i>Estimation des coûts

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être

payés par elle en rapport avec cet acte, ont été estimés à environ six mille Euros (EUR 6.000,-).

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée,

le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction française. Sur demande de la même personne et en cas de
divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Dont Acte, fait et passé à Luxembourg, au jour indiqué en tête du présent document.
Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent

acte.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57485. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014204996/219.
(140227926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Anlogistyk Management S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 193.027.

STATUTES

In the year two thousand fourteen, on the twelfth day of December.
Before the undersigned Maître Carlo WERSANDT notary, residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

LINKSET ENTERPRISES LIMITED, a company incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered

office at 7D, Nikou Kranidioti Street, Tower 4, 3 

rd

 Floor, Flat/Office 302, 2411 Egkomi, Nicosia, Cyprus, and registered

with the Registrar of Companies of Cyprus under number HE 226090,

here represented by M. Harald CHARBON, employee, residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private

seal.

The said proxy, after having been signed “ne varietur” by the appearing party and the undersigned notary, will remain

annexed to the present deed for the purpose of registration.

Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the

articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name. There is formed a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name

“Anlogistyk  Management  S.à  r.l.”  (the  Company),  which  will  be  governed  by  the  present  articles  of  association  (the
Articles) as well as by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated August 10, 1915, on commercial companies,
as  amended  (the  Law  and  in  particular  by  the  law  of  18  September  1933  and  of  28  December  1992  on  ‘sociétés  à
responsabilité limitée' (the ‘Commercial Companies Law').

Art. 2. Registered office.
2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be

transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand

6591

L

U X E M B O U R G

Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single partner or the general meeting of partners adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces.  Such  temporary  measures  shall  have  no  effect  on  the  nationality  of  the  Company,  which,  notwithstanding  the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Object.
3.1 The Company may act as general partner (“associé gérant commandité”) of one or more Luxembourg partnership

(s) and, in that capacity, the Company may administer and manage such partnership(s) and their assets and decide on
their investment objectives, policies and restrictions and their course of conduct of management and business affairs.

3.2 The Company may carry out all transactions relating directly or indirectly to the taking of participating interests

in whatsoever form, in any enterprise in the form of a public limited liability company or of a private liability company, as
well as the administration, management, control and development of such participations.

3.3 The Company may carry out any commercial, industrial or financial operations, any transactions in respect of real

estate or moveable property, which the Company may deem useful to the accomplishment of its purposes.

3.4 In particular the Company may use its funds for the creation, management, development and the disposal of a

portfolio comprising all types of transferable securities or patents of whatever origin, take part in the creation, develop-
ment and control of all enterprises, acquire all securities and patents, either by way of contribution, subscription, purchase
or otherwise, option, as well as realize them by sale, transfer, exchange or otherwise.

3.5 The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies
and/or to any other company (including its partners). It may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or
otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings
and/or obligations and undertakings of any other company and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any
other company or person (including its partners).

3.6 The Company may also carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
3.7 The Company may also proceed with the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate,

whether furnished or not, and in general, carry out all real estate operations with the exception of those reserved to a
dealer in real estate and those concerning the placement and management of money. In general, the Company may carry
out any patrimonial, movable, immovable, commercial, industrial or financial activity as well as all transactions that aim to
promote and facilitate directly or indirectly the accomplishment and development of its purpose.

Art. 4. Duration.
4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.
4.2  The  Company  shall  not  be  dissolved  by  reason  of  the  death,  suspension  of  civil  rights,  incapacity,  insolvency,

bankruptcy or any similar event affecting one or several of the partners.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.
5.1 The Company's corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euros (12.500,-) represented by twelve

thousand five hundred (12.500) shares in registered form with a par value of one Euro (EUR 1,-) each, all subscribed and
fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single

partner or, as the case may be, by the general meeting of partners, adopted in the manner required for the amendment
of the Articles.

Art. 6. Shares.
6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion

to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint

co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among partners or, if there is no more than one partner, to third parties.
In case of plurality of partners, the transfer of shares to non-partners is subject to the prior approval of the general

meeting of partners representing at least three quarters of the share capital of the Company.

6592

L

U X E M B O U R G

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by,

the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, reference is being made to articles 189 and 190 of the Law.
6.4 A partners' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the

Law and may be examined by each partner who so requests.

6.5 The Company shall have power to redeem its own shares.
Such redemption shall be carried out by means of a resolution of an extraordinary general meeting of the shareholders

or of the sole shareholder (as the case may be), adopted under the conditions required for amendment of the Articles,
provided that such redemption has been proposed to each shareholder of the same class in the proportion of the capital
or of the class of shares concerned represented by their shares.

However, if the redemption price is in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may

only be decided to the extent that the excess purchase price may not exceed total profits made since the end of the last
financial year for which the annual accounts have been approved, plus any profits carried forward and sums drawn from
reserves available for this purpose, less losses carried forward and any sums to be placed to reserve pursuant to the
requirements of the Law or of Articles.

Such redeemed shares shall be cancelled by reduction of the share capital.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of managers.
7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single partner or the general

meeting of partners which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a
board of managers. The manager(s) need not to be partner(s).

7.2 The members of the board might be split in two categories, respectively denominated «Category A Managers»

and «Category B Managers».

7.3 The managers may be dismissed ad nutum.

Art. 8. Powers of the board of managers.
8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of partners fall within

the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers,
which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either partners or

not, by the manager, or if there are more than one manager, by any manager of the Company.

Art. 9. Procedure.
9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at

the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least 24 (twenty-four)

hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or

represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his

proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented

and, to the extent Category A Managers and Category B Managers were appointed, at least one Category A Manager
and one Category B Manager must be present or represented. Resolutions of the board of managers are validly taken by
the majority of the votes cast and, if the board of managers is composed of Category A Managers and Category B Managers
such resolutions must be approved by at least one Category A Manager and one Category B Manager. The resolutions
of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to
each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such
meeting.

9.7 Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by letter or facsimile.

6593

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Representation.
10.1 The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager and

by the joint signature of two managers in the case of a plurality of managers.

10.2 If the general meeting of partners decides to create two categories of managers (category A and category B), the

Company will only be bound by the joint signature of any A Manager together with any B Manager.

10.3 The Company shall further be bound by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory

power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

Art. 11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation

to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with
these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

IV. General meetings of partners

Art. 12 Powers and voting rights.
12.1 The single partner assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of partners.
12.2 Each partner has voting rights commensurate to its shareholding.
12.3 Each partner may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram,

telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of partners.

Art. 13 Form - Quorum - Majority.
13.1 If there are not more than twenty-five partners, the decisions of the partners may be taken by circular resolution,

the text of which shall be sent to all the partners in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
The partners shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the partners may appear on a single
document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

13.2 Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by partners owning more than half of the

share capital.

13.3 However, resolutions to alter the Articles or to dissolve and liquidate the Company may only be adopted by the

majority of the partners owning at least three quarters of the Company's share capital.

V. Annual accounts - Allocation of profits

Art. 14 Accounting Year.
14.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the thirty-first

December of each year.

14.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established

and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including
an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

14.3 Each partner may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

Art. 15 Allocation of Profits.
15.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation

and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated
to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

15.2 Notwithstanding the preceding provisions, the Board of Managers may decide to pay interim dividends to the

Shareholders before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are
available for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable,
realised profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but
decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the Law or
these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned shall be reim-
bursed by the Shareholders.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16 Dissolution - Liquidation.
16.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators,

who do not need to be partners, appointed by a resolution of the single partner or the general meeting of partners which
will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the partner(s) or by
Law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the
liabilities of the Company.

16.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be

paid to the partner or, in the case of a plurality of partners, the partners in proportion to the shares held by each partner
in the Company.

6594

L

U X E M B O U R G

VII. General provision

Art. 17. General provision. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2014[CH1].

<i>Subscription - Payment

Thereupon, LINKSET ENTERPRISES LIMITED, prenamed and represented as stated here-above, declares to have

subscribed to the whole share capital of the Company and to have fully paid up all twelve thousand five hundred (12.500)
shares by contribution in cash, so that the amount of twelve thousand five hundred Euros (EUR 12.500,-) is at the disposal
of the Company, as has been proved to the undersigned notary, who expressly acknowledges it.

<i>Estimate

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result

of its incorporation are estimated at approximately nine hundred euro (EUR 900.-).

<i>Resolutions of the sole partner

Immediately after the incorporation of the Company, the sole partner, representing the entirety of the subscribed

share capital has passed the following resolutions:

1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
- Mr. Eric LOGET, Manager, born on April 16 

th

 , 1964 in Savigny-sur-Orge (F), residing at 8, rue du Château, F-91590

D'Huisson Longueville;

- Mr. Harald CHARBON, born on July 11 

th

 , 1969 in Verviers (B), residing professionally at 412F, route d'Esch, L-2086

Luxembourg;

- Mr. Marc LIMPENS, born on February 17 

th

 , 1951 in Overijse (B), residing professionally at 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg.

2. The registered office of the Company is set at L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the

present deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le douze décembre.
Par-devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

LINKSET ENTERPRISES LIMITED, une société constituée et existant suivant les lois de Chypre, ayant son siège social

à 7D, Nikou Kranidioti Street, Tower 4, 3 

rd

 Floor, Flat/Office 302, 2411 Egkomi, Nicosia, Chypre, et enregistrée auprès

du Registrar of Companies de Chypre sous le numéro HE 226090,

ici représenté par M. Harald CHARBON, employé, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing

privé.

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le comparant et le notaire instrumentant, an-

nexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle comparante, ès-qualité qu'elle agit, a requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à respon-

sabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

I. Dénomination - Siège social - Objet social - Durée

Art. 1 

er

 . Dénomination.  Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination «Anlogistyk Management

S.à r.l.» (la Société), qui sera régie par les présents statuts (les Statuts) et par les lois du Luxembourg, en particulier par
la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi) et notamment par la loi du 18
septembre 1933 et du 28 décembre 1992 sur les sociétés à responsabilité limitée (la "Loi sur les Sociétés Commerciales").

Art. 2. Siège social.
2.1 Le siège social est établi à Luxembourg Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites

de la commune de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

6595

L

U X E M B O U R G

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique ou de
l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des

succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le
conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à
compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront
ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces
circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui restera
une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social.
3.1 La société agira en tant qu'associé gérant commandité d'une ou plusieurs société(s) en commandite au Luxembourg

et, à ce titre, la Société peut administrer et gérer ce(s) société(s) en commandite et leurs actifs et de décider de leurs
objectifs leurs politiques et leurs restrictions de placement, et leur ligne de conduite des affaires de gestion et commer-
ciales

3.2 La Société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations

sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise se présentant sous forme de société de capitaux ou de société de
personnes, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

3.3 La Société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, ainsi que tous transferts

de propriété immobiliers ou mobiliers.

3.4 Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, la mise en valeur et à la cession d'un portefeuille

se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de
toute entreprises, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute autre
manière, tous titres et brevet, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement.

3.5 La Société pourra emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder,

uniquement par voie de placement privé, à l'émission d'actions et obligations et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société pourra prêter des fonds, en ce compris, sans limitation, ceux résultant des emprunts et/ou
des émissions d'obligations ou de valeurs, à ses filiales, sociétés affiliées et/ou à toute autre société (ce y compris ses
associés). Elle peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs
ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs afin de garantir ses propres
obligations et engagements et/ou obligations et engagements de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur
et/ou en faveur de toute autre société ou personne (ce y compris ses associés).

3.6 La Société peut également réaliser son activité par l'intermédiaire de succursales au Luxembourg ou à l'étranger.
3.7 Elle pourra également procéder à l'acquisition, la gestion, l'exploitation, la vente ou la location de tous immeubles,

meublés, non meublés et généralement faire toutes opérations immobilières à l'exception de celles de marchands de biens
et le placement et la gestion de ses liquidités. En général, la Société pourra faire toutes opérations à caractère patrimonial,
mobilières, immobilières, commerciales, industrielles ou financières, ainsi que toutes transactions et opérations de nature
à promouvoir et à faciliter directement ou indirectement la réalisation de l'objet social ou son extension.

Art. 4. Durée.
4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.
4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite

ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. Capital - Parts sociales

Art. 5. Capital.
5.1 Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-), représenté par douze mille cinq cents

(12.500) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, toutes souscrites et
entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de

l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

Art. 6. Parts sociales.
6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le

nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis.

Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.
En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné

en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

6596

L

U X E M B O U R G

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou

acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, il est fait référence aux dispositions des articles 189 et 190 de la Loi.
6.4 Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra

être consulté par chaque associé.

6.5 La Société est autorisée à racheter ses propres parts sociales.
Un tel rachat sera décidé par une résolution de l'assemblée générale des associés ou de l'associé unique (le cas échéant),

par décisions prises selon les conditions requises pour la modification des Statuts, à condition qu'un tel rachat ait été
proposé à chaque associé de la même classe en proportion du capital social ou de la classe des parts sociales concernées
représentés par leurs parts sociales.

Néanmoins, si le prix de rachat excède la valeur nominale des parts sociales rachetées, le rachat ne pourra être décidé

que dans la mesure où le supplément du prix d'achat n'excède pas le total des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier
exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés et de toutes sommes issues
des réserves disponibles à cet effet, et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve confor-
mément aux exigences de la Loi ou des Statuts.

Les parts sociales rachetées seront annulées par réduction du capital social.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil de gérance.
7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne sont pas nécessairement des associés et qui seront

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixera la durée de leur mandat.
Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un Conseil de gérance.

7.2 Les membres du Conseil peuvent ou non être répartis en deux catégories, nommés respectivement «Gérants de

catégorie A» et «Gérants de catégorie B».

7.3 Les gérants sont révocables ad nutum.

Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance.
8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts

seront de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour
effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés

ou non, par tout gérant.

Art. 9. Procédure.
9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants

au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins 24 (vingt-quatre)

heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence
seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents

ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut
aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par
télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant

comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou

représentée et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants de catégorie B ont été nommés, que si au moins un Gérant
de catégorie A et un Gérant de catégorie B sont présents ou représentés. Les décisions du conseil de gérance sont prises
valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés et, si des Gérants de catégorie A et des Gérants
de catégorie B ont été nommés, ces résolutions ont été approuvées par au moins un Gérant de catégorie A et un gérant
de catégorie B. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou
représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout

autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent
s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la
réunion.

9.7 Les résolutions circulaires signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées

comme si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être
apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

6597

L

U X E M B O U R G

Art. 10. Représentation.
10.1 La Société sera engagée, en tout circonstance, vis-à-vis des tiers par la seule signature du gérant unique et, en cas

de pluralité de gérants, par la signature conjointe de deux gérants.

10.2 Dans l'éventualité où deux catégories de Gérants sont créées (Gérant de catégorie A et Gérant de catégorie B),

la Société sera obligatoirement engagée par la signature conjointe d'un Gérant de catégorie A et d'un Gérant de catégorie
B.

10.3 La Société sera aussi engagée par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de

signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

Art. 11 Responsabilités des gérants. Les gérants ne contractent à raison de leur fonction aucune obligation personnelle

relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont
pris en conformité avec les Statuts et les dispositions de la Loi.

IV. Assemblée Générale des associés

Art. 12. Pouvoirs et droits de vote.
12.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.
12.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.
12.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par

écrit, soit par lettre, télégramme, télex, téléfax ou courrier électronique une autre personne comme mandataire.

Art. 13. Forme - Quorum - Majorité.
13.1 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas vingt-cinq associés, les décisions des associés pourront être prises

par résolution circulaire dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex,
téléfax ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures
des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre
ou téléfax.

13.2 Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés

détenant plus de la moitié du capital social.

13.3 Toutefois, les résolutions prises pour la modification des Statuts ou pour la dissolution et la liquidation de la

Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la
Société.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices

Art. 14. Exercice social.
14.1 L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

14.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Sociétés sont arrêtés et le gérant ou, en cas de

pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de
la Société.

14.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

Art. 15. Affectation des bénéfices.
15.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements

et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera
affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

15.2 Nonobstant les dispositions précédentes, le Conseil de Gérance peut décider de payer des dividendes intérimaires

aux Associés avant la fin de l'exercice social sur la base d'un état de comptes montrant que des fonds suffisants sont
disponibles pour la distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut pas excéder, si applicable, les
bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmentés des bénéfices reportés et des réserves distribuables,
mais diminués des pertes reportées et des sommes allouées à la réserve établie selon la Loi ou selon ces Statuts et que
(ii) de telles sommes distribuées qui ne correspondent pas aux bénéfices effectivement réalisés seront remboursées par
les Associés.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 16. Dissolution - Liquidation.
16.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non,

nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémuné-
ration. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution du (ou des) gérant(s) ou par la Loi, les liquidateurs seront
investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

6598

L

U X E M B O U R G

16.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué

à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dé-
tenues par chacun d'eux dans la Société.

VII. Disposition générale

Art. 17. Loi applicable. Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est

fait référence à la Loi.

<i>Disposition transitoire

La première année sociale débutera à la date du présent acte et se terminera au 31 décembre 2014.

<i>Souscription - Libération

LINKSET ENTERPRISES LIMITED, représenté comme dit ci-dessus, déclare avoir souscrit à l'entièreté du capital social

de la Société et d'avoir entièrement libéré les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales par versement en espèces,
de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) est à la disposition de la Société, ce qui a été
prouvé au notaire instrumentant, qui le reconnaît expressément.

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ neuf cents euros (EUR 900,-).

<i>Décision de l'associé unique

Et aussitôt, l'associé unique, représentant l'intégralité du capital social a pris les résolutions suivantes:
1. Les personnes suivantes sont nommées comme gérants de la Société pour une durée indéterminée:
- Monsieur Eric LOGET, Dirigeant de sociétés, né le 16 avril 1964 à Savigny-sur-Orge (F), demeurant au 4, Allée de

l'Hermitage, F-91580 Etrechy;

- Monsieur Harald CHARBON, né le 11 juillet 1969 à Verviers (B), demeurant professionnellement au 412F, route

d'Esch, L-2086 Luxembourg;

- Monsieur Marc LIMPENS, né le 17 février 1951 à Overijse (B), demeurant professionnellement au 412F, route d'Esch,

L-2086 Luxembourg.

2. Le siège social de la Société est établi à L-2086 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte en

langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte
anglais fera foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, le comparant a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: H. CHARBON, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 16 décembre 2014. LAC/2014/60538. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff.

 (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée.

Luxembourg, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206643/447.
(140231507) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

S.A. Grand Garage Olivier ORIGER, Société Anonyme.

Siège social: L-3813 Schifflange, 55-57, rue Basse.

R.C.S. Luxembourg B 112.780.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Fiduciaire W B M
<i>Experts comptables et fiscaux
Signature

Référence de publication: 2014204821/13.
(140227528) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6599

L

U X E M B O U R G

CEP III Investment 17 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 1.811.105,00.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 161.144.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth day of December,
Before us Maître Jean-Paul Meyers, notary, residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

CEP III Investment 16 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,

with a share capital of GBP 1,011,105.-, having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number
B 161145 (the “Shareholder”),

hereby represented by Anne Mauske, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given on under private seal.
Which power of attorney, after being signed “ne varietur” by the representative of the appearing party and the un-

dersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Shareholder has requested the undersigned notary to record that the Shareholder is the sole shareholder of CEP

III Investment 17 S.à r.l., a société à responsabilité limitée governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with
a share capital of one million eight hundred eleven thousand one hundred and five British Pounds (GBP 1,811,105.-),
having its registered office at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorpo-
rated following a deed of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, dated
12 May 2011, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1845 of 11 August 2011 and
registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 161144 (the "Company"). The
articles of incorporation of the Company have been amended for the last time on 3 October 2011 pursuant to a deed
of Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial
C, Recueil des Sociétés et Association number 3067 of 14 December 2011.

The Shareholder, represented as above mentioned, having recognised to be duly and fully informed of the resolutions

to be taken on the basis of the following agenda:

<i>Agenda

1 To reduce the nominal value of the shares issued by the Company from one British Pound (GBP 1.-) per share to

one penny (GBP 0.01).

2 To amend article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the change of nominal value

of the shares.

3 Miscellaneous.
has requested the undersigned notary to record the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholder resolved to reduce the nominal value of the shares issued by the Company from one British Pound

(GBP 1.-) per share to one penny (GBP 0.01).

<i>Second resolution

The Shareholder resolved to amend article 6 of the articles of incorporation of the Company in order to reflect the

change of nominal value of the shares. Said article will from now on read as follows:

“ Art. 6. The share capital is fixed at one million eight hundred eleven thousand one hundred and five British Pounds

(GBP 1,811,105) represented by one hundred eighty-one million one hundred ten thousand five hundred (181,110,500)
shares with a nominal value of one penny (GBP 0.01) each.”

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same person and in case
of divergences between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Luxembourg by the undersigned notary, on the day referred to at the

beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the undersigned notary by his surname,

first name, civil status and residence, such person signed together with the undersigned notary, this original deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le douzième jour du mois de décembre,

6600

L

U X E M B O U R G

Par-devant nous Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence au 21, rue de Schwiedelbrouch, L-8806 Rambrouch,

Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU:

CEP III Investment 16 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant un capital social de GBP 1.011.105,-, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
B 161145 (l’«Associé»),

ici dûment représentée par Anne Mauske, demeurant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing

privé.

Ladite procuration, paraphée "ne varietur" par le représentant de la partie comparante et le notaire instrumentant,

demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l’enregistrement.

L’Associé a requis le notaire instrumentant d'acter que l’Associé est le seul et unique associé de CEP III Investment

17 S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant un capital social
d’un million huit cent onze mille cent cinq Livres Sterling (GBP 1.811.105,-), dont le siège social est au 2, avenue Charles
de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée en vertu d’un acte de Maître Francis Kesseler,
notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 12 mai 2011, publié au Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 1845 du 11 août 2011 et immatriculée au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161144 (la «Société»). Les statuts de la Société ont été modifiés pour
la dernière fois le 3 octobre 2011 par un acte de Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-
Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3067 en date du 14
décembre 2011.

L’Associé, représenté comme indiqué ci-avant, reconnaissant avoir été dûment et pleinement informé des décisions à

intervenir sur base de l’ordre du jour suivant:

<i>Ordre du jour

1 Réduction de la valeur nominale des parts sociales par la Société d’une livre sterling (GBP 1,-) par part sociale à un

penny (GBP 0,01).

2 Modification de l’article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la modification de la valeur nominale des parts

sociales.

3 Divers.
a requis le notaire soussigné d’acter les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L’Associé a décidé de réduire la valeur nominale des parts sociales émises par la Société d’une livre sterling (GBP 1,-)

par part sociale à un penny (GBP 0,01).

<i>Deuxième résolution

L’Associé a décidé de modifier l’article 6 des statuts de la Société pour refléter la modification de la valeur nominale

des parts sociales. Ledit article sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 6. Le capital social est fixé à un million huit cent onze mille cent cinq Livres Sterling (GBP 1.811.105,-), représenté

par cent quatre-vingt-un millions cent dix mille cinq cents (181.110.500) parts sociales d’une valeur nominale d’un penny
(GBP 0,01) chacune.»

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande du comparant

ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande du même comparant,
en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au comparant connu du notaire soussigné par ses nom, prénom

usuel, état et demeure, il a signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: Mauske, Jean-Paul Meyers.
Enregistré à Redange/Attert, le 17 décembre 2014. Relation: RED/2014/2493. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Kirsch.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d’enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la

publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Rambrouch, le 23 décembre 2014.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2014206793/107.
(140231310) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

6601

L

U X E M B O U R G

Oben der Kirch s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9640 Boulaide, 2, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 132.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204649/9.
(140228253) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Oben der Kirch s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9640 Boulaide, 2, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 132.399.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014204650/9.
(140228277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Oropan International S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1260 Luxembourg, 92, rue de Bonnevoie.

R.C.S. Luxembourg B 138.312.

Le bilan approuvé au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014204646/10.
(140228792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Digital Services XVII S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 13.750,00.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 186.480.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-first day of November,
Before us, Maître Henri Hellinckx, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B,
having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of one (1) common share of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 13 November 2014;

2. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the

laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of twelve thousand four hundred ninety-nine (12,499) common shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Berlin, Germany, on 14 November 2014;

3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands with its registered

office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under no.
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands (hereinafter the
“New Investor”), participating and voting only for purposes of agenda point 4 et seqq.

becoming the holder of one thousand two hundred and fifty (1,250) new created series A shares of the Company,

6602

L

U X E M B O U R G

here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy,

given in Schiphol, the Netherlands, on 12 November 2014;

The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1. and 2. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Digital Services XVII S.à r.l. (the “Com-

pany”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg,
having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 186.480 and
incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 April 2014, published in the Memorial C, Recueil des
Sociétés et Associations number 1691 dated 1 July 2014. The articles of association were not amended since.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the New
Investor participates and votes for purpose of agenda point 4 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company, namely the series A shares, so

that the Company will hence have two (2) series of shares, being the common shares (hereinafter “Common Shares”)
and the series A shares (hereinafter “Series A Shares”).

2. Acceptance of Netris B.V., aforementioned, as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company's share capital by an amount of one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250) so

as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500) up to thirteen thousand seven
hundred and fifty euro (EUR 13,750) by issuing one thousand two hundred and fifty (1,250) Series A Shares with a nominal
value of one euro (EUR 1) each.

4. Restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase as per the third

resolution as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of
the Company by the New Investor.

5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company,

namely the Series A Shares, so that the Company will hence have two (2) series of shares, being the Common Shares
and the Series A Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to accept Netris B.V., aforementioned, as new shareholder of the Com-

pany.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of one

thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250) so as to raise it from its current amount of twelve thousand five hundred
euro (EUR 12,500) up to thirteen thousand seven hundred and fifty euro (EUR 13,750) by issuing one thousand two
hundred and fifty (1,250) Series A Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

<i>Subscription

The one thousand two hundred and fifty (1,250) Series A Shares have been duly subscribed by Netris B.V., prenamed,

here represented as aforementioned.

<i>Payment

The one thousand two hundred and fifty (1,250) Series A Shares subscribed by Netris B.V., aforementioned, have been

entirely paid up through a contribution in cash in an amount of one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250).

The amount of one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250) is as now available to the Company as has been

proved to the undersigned notary.

The contribution in the amount of one thousand two hundred and fifty euro (EUR 1,250) is entirely allocated to the

share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association of

the Company in order to reflect the capital increase as per the third resolution as well as to reflect several amendments
to the articles of association following the entry into the capital of the Company by the New Investor.

6603

L

U X E M B O U R G

The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Digital Services

XVII S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company's share capital is set at thirteen thousand seven hundred and fifty Euros (EUR 13,750.00), represented

by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”), with a nominal value of

one Euro (EUR 1.00) each, and

5.1.2 one thousand two hundred fifty (1,250) series A shares (hereinafter “Series A Shares”) with a nominal value of

one Euro (EUR 1.00) each.

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association or by the Law.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

6604

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders.
7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by the shareholders at a majority of three quarters of the share capital (a “Super Majority”) and subject to the provisions
of any shareholders' agreement between the shareholders, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-
emption or tag-along rights or drag-along rights contained in any shareholders' agreement between the shareholders. To
the extent that such approval has been granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a transfer, assignment or any other disposal of shares by the shareholder Rocket Internet AG

("Rocket") and the shareholder Netris B.V. ("Eiffel", jointly with Rocket the "Investors" and each also an "Investor") to a
company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a sale, transfer, assignment or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is

directly or indirectly Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more
direct or indirect shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Con-
trolled” or “Controlling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company
as managing shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a
contractual voting pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and
policies of a person, whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective
Investor or one or more shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a transfer, assignment or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under a simplified

employee participation or (ii) to the Company and/or any Investor pursuant to a calloption under a vesting scheme;

7.4.4 in case of any transfer, assignment or any other disposal of shares within the framework of transformation

procedures pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the
Company, if the shareholders of the Company hold more than 50 % in any surviving legal entity after such transformation
procedure.

7.5 In the cases provided for in Article 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any transfer, assignment or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third

parties through the notification of the transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the transfer,
assignment or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Redemption of Shares.
8.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

8.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder's consent, if:
8.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

8.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

6605

L

U X E M B O U R G

8.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders' rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

8.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders' resolution is adopted (except in case of Article
8.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders'
resolution is required).

Art. 9. Compensation for Redemption.
9.1 Redemption is made against compensation.
9.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective date

is the date before the redemption resolution.

9.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
9.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

9.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable redemption compensation this is to determine by an

auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement is reached the expert
arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d'Arrondissement upon request of a shareholder or of the
Company. The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the
Company and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the
redemption price and the redemption price shall be reduced accordingly. The shareholder shall bear the remaining costs
in case the redemption price does not cover the costs allocated to the shareholder for the expert opinion.

Art. 10. Request of Assignment in lieu of Redemption.
10.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

10.2 This Article 10 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 9 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 11. Collective decisions of the shareholders.
11.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

11.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
11.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

11.4 The shareholders' resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

11.5 Unless a notarial record is made of shareholders' resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders' meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

11.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

6606

L

U X E M B O U R G

Art. 12. General meetings of shareholders.
12.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

12.2  The  shareholders'  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders' meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders' meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders'
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

12.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

12.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders' meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

12.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders' meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders' resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders'
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 13. Quorum and vote.
13.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
13.2 A shareholders' meeting only constitutes a quorum if at least 50% of the share capital is represented. Save for a

higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company's shareholders
are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share capital. If there is
no quorum, a new shareholders' meeting with the same agenda must be called without undue delay in compliance with
Article 12.2. This shareholders' meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital represented, if this
was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of the votes cast.

Art. 14. Change of nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

Art. 15. Amendments of articles of association.
15.1 Any amendment of these articles of association requires the approval of (i) a majority in number of shareholders

(ii) who also constitute a Super Majority, provided that at any time three (3) or more Investors have subscribed for shares
in the Company, it includes the affirmative vote of at least one Investor other than Rocket.

Art. 16. Shareholders' resolutions requiring specific majority.
16.1 Shareholders' Resolutions regarding the following subjects must be taken by (i) a majority in number of share-

holders (ii) who also constitute a Super Majority, provided that at any time three (3) or more Investors have subscribed
for shares in the Company, it includes the affirmative vote of at least one Investor other than Rocket:

16.1.1 disposition of all Company's assets or of a significant part of the Company's assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

16.1.2 resolution with respect to the merger, separation and transformation of the Company.
16.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority:
16.2.1  conclusion  of  intra-group  agreements  (Unternehmensverträge  within  the  meaning  of  sections  291  et  seqq.

German Stock Corporation Act (AktG));

16.2.2 conclusion of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal of shares) of

any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a participation
in the Company's profit or any payment that is dependent on the amount of the Company's profit; this does not include
agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a prospective
status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of business, e.g.
agreements between the Company and advertising partners;

16.2.3 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
16.2.4 acquisition of the Company's own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 8.2 and

transfers in accordance with Article 10.1 of these articles of association.

16.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

6607

L

U X E M B O U R G

D. Board of managers - Advisory board

Art. 17. Powers of the sole manager - Composition and powers of the board of managers.
17.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

17.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

17.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 18. Election, removal and term of office of managers.
18.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

18.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
18.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 19. Vacancy in the office of a manager.
19.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced manager  by the remaining  managers  until  the  next  meeting  of  shareholders which  shall resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 20. Convening meetings of the board of managers.
20.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

20.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 21. Management.
21.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

21.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

21.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

21.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event however the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

6608

L

U X E M B O U R G

21.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

21.8 The managers shall require the consent of the advisory board for the legal transactions and measures specified

below in accordance with Article 24.5, provided that at any time two (2) or more voting members have been appointed
to the Advisory Board in addition to the voting members nominated by Rocket, it includes the affirmative vote of at least
one voting member other than the voting members appointed by Rocket. No consent is required if such legal transactions
and measures have been precisely defined and have in advance been approved by an adopted budget with the consent of
the advisory board:

21.8.1 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in aggregate;

21.8.2 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

21.8.3 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
21.8.4 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

21.8.5 institution and termination of legal disputes, in particular, arbitration proceedings involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

21.8.6 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

21.8.7 transfer of industrial property rights or documented know-how by the Company to a third party, excluding,

however, such dispositions (i) in the ordinary course of business and (ii) between the Company and direct and indirect
subsidiaries of the Company;

21.8.8 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals. As such

shall be deemed to be direct or indirect shareholders of the Company, affiliated companies pursuant to sections 15 et
seqq. German Stock Corporation Act (AktG) as well as relatives pursuant to section 15 German Tax Code (AO) of direct
or indirect shareholders, as far as the latter - individually or jointly - hold, directly or indirectly, a majority interest. The
consent requirement pursuant to this Article 21.8.8 does not apply if the transaction belongs to the ordinary course of
business of the Company and is at arm's length;

21.8.9 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

outside the existing simplified employee participation agreed upon between the shareholders in any shareholders' agree-
ment, if any.

21.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders' meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the advisory board. The advisory board may give its consent also in
advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

21.10 The shareholders may by shareholders' resolution adopt rules of procedure for the managers.

Art. 22. Minutes of the meeting of the board of managers; Minutes of the decisions of the sole manager.
22.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any, or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers), such minutes
shall be signed by one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or
excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman,
if any, or by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of
managers (namely class A managers and class B managers), such copies or excerpts shall be signed by one (1) class A
manager and one (1) class B manager (including by way of representation).

22.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 23. Dealing with third parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

6609

L

U X E M B O U R G

Art. 24. Advisory board.
24.1 The Company shall have an advisory board. It shall consist of five (5) voting members. The shareholders may by

way of unanimous shareholders' consent increase or decrease the number of voting members of the advisory board.

24.2 The shareholders shall only set and/or amend rules of procedure for the advisory board by way of a unanimous

shareholders' consent.

24.3 The voting members of the advisory board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member's res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

24.3.1 four (4) voting members of the advisory board shall be nominated by Rocket in its sole discretion; and
24.3.2 one (1) voting member of the advisory board shall be nominated by Eiffel in its sole discretion.
24.4 The advisory board may have non-voting members of the advisory board as observers.
24.5 The advisory board shall have a chairman and a deputy chairman. A voting member nominated by Rocket shall

be the chairman of the advisory board. The rules of procedure of the advisory board may provide for further provisions
in particular on the self organization of the advisory board. The advisory board shall adopt resolutions with the simple
majority of votes cast. The advisory board shall hold meetings on a regular basis, at least once every calendar quarter.

24.6 The advisory board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 25. Auditor(s).
25.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

25.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

25.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
25.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

25.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 26. Financial year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 27. Annual accounts and allocation of profits.
27.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

27.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

27.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

27.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

27.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

27.6 Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they hold in the Company.

Art. 28. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.
28.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable and may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by
profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to
a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be distributed.

28.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

6610

L

U X E M B O U R G

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 30. Governing law.
30.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders' agreement which may be entered into from time to time between the shareholders and the Company, and
which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter contained in these articles conflicts with
the provisions of any shareholders' agreement, such shareholders' agreement shall prevail inter partes and to the extent
permitted by Luxembourg law.

30.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately EUR 2,500.-.

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am einundzwanzigsten November
Vor uns, dem unterzeichnenden Notar Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxem-

burg,

SIND ERSCHIENEN:

1. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber eines (1) Stammanteils der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 13.

November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
2. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht

mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  Berlin,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zwölftausendvierhundertneunundneunzig (12.499) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 14. November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

3.  Netris  B.V.,  eine  Gesellschaft  (Besloten  Vennootschap)  nach  dem  Recht  der  Niederlande,  mit  Sitz  in  Schiphol,

Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz
in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande, (der „Neue Investor“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der
Tagesordnung teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 12. November 2014, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1. und 2. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Digital Services XVII S.à r.l. (die

„Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), gegründet und bestehend

6611

L

U X E M B O U R G

unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Lu-
xemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter
der Nummer B 186.480, gegründet am 7. April 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden Notars, welche am 1.
Juli 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1691 veröffentlicht wurde. Die Satzung der
Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei der Neue Investor ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teil-
nahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) neuen Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und

zwar der Anteile der Serie A, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen
(die „Stammanteile“) und Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“).

2. Aufnahme von Netris B.V., vorbenannt, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von zwölftausendfünfhundert

Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) auf einen Betrag von dreizehn-
tausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750) durch die Ausgabe von eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen
der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapitalerhöhung gemäß des dritten Beschlusses, sowie weitere

Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch den Neuen Investor wiederzugeben.

5. Verschiedenes.
Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) neue Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft

zu schaffen, und zwar die Anteile der Serie A, sodass die Gesellschaft nunmehr zwei (2) Anteilsklassen hat, bestehend aus
Stammanteilen (die „Stammanteile“) und Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“).

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Netris B.V., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der Gesellschaft anzu-

nehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

zwölftausendfünfhundert Euro (EUR 12.500) um einen Betrag von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) auf
einen Betrag von dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750) durch die Ausgabe von eintausendzweihun-
dertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie A wurden ordnungsgemäß von Netris B.V., vorbenannt,

hier vertreten wie vorerwähnt, gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Netris B.V., vorbenannt, gezeichneten eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteile der Serie A wurden voll-

ständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250).

Die Summe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) steht der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung so wie

es dem amtierenen Notar nachgewiesen wurde.

Die Einlage in Höhe von eintausendzweihundertfünfzig Euro (EUR 1.250) wird vollständig dem Gesellschaftskapital

zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapital-

erhöhung gemäß des dritten Beschlusses, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch den Neuen
Investor wiederzugeben.

Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:

6612

L

U X E M B O U R G

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Digital Services XVII S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder
auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle
und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheine bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur vornehmen

sowie solche, welche das geistige Eigentum betreffen oder im Zusammenhang mit Grundeigentum stehen und die ihr zur
Erreichung dieser Zwecke im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art, förderlich
erscheinen.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch Beschluss der Gesellschafter, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt dreizehntausendsiebenhundertfünfzig Euro (EUR 13.750,00), be-

stehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile“) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1), und

5.1.2 eintausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A (die „Anteile der Serie A“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung oder

durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.
6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.

6613

L

U X E M B O U R G

6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz

oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar.
7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung von Gesellschaftern mit

einer Mehrheit von drei Vierteln des Gesellschaftskapitals (eine „Qualifizierte Mehrheit“) und vorbehaltlich der Bestim-
mungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbeson-
dere vorbehaltlich Vorkaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinba-
rungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde,
ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch den Gesellschafter

Rocket Internet AG („Rocket“) und den Gesellschafter Netris B.V. („Eiffel“, gemeinschaftlich mit Rocket die „Investoren“
und jeweils einzeln ein „Investor“) an eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff.
des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einem Verkauf, einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen durch

einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte
oder indirekte Gesellschafter des betreffenden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von
diesem Kontrolliert Wird, oder unter der gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder
„Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“ die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnen, durch (a)
die Leitung der Gesellschaft als geschäftsführender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das
Halten der Mehrheit der Stimmrechte durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt
oder indirekt die Leitung der Geschäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimm-
berechtigter Wertpapiere oder anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer
oder mehrere Gesellschafter dieses Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3  bei  einer  Übertragung,  einer  Abtretung  oder  einer  anderen  Veräußerung  von  Anteilen  (i)  an  einen  Dritten,

welcher Anteile unter einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen
beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im Zusammenhang mit einer Vesting-Regelung;

7.4.4 bei einer Übertragung, einer Abtretung oder einer anderen Veräußerung von Anteilen im Rahmen von Um-

wandlungsvorgängen  gemäß  des  Umwandlungsrechts  Luxemburgs,  insbesondere  (jedoch  nicht  beschränkt  auf)  eine
Verschmelzung der Gesellschaft, sofern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang
mehr als 50% an einer überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung, Abtretung oder andere Veräußerung von Anteilen wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten

gemäß Artikel 1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen
Veräußerung in Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur dann an neue Gesellschafter übertragen

werden, wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des
verstorbenen Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erfor-
derlich,  wenn  die  Anteile  an  Eltern,  Nachkommen  oder  den/die  überlebende/n  Ehepartner/in  oder  jeden  anderen
gesetzlichen Erben des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

Art. 8. Rückkauf von Anteilen.
8.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

8.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

6614

L

U X E M B O U R G

8.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

8.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

8.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

8.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 8.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 9. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
9.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
9.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

9.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
9.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

9.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d'Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit dem Rückkaufspreis verrechnet und der Rückkaufspreis dementsprechend herabgesetzt wird. Der Gesellschafter
hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern der Rückkaufspreis die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gut-
achten nicht deckt.

Art. 10. Abtretung anstelle von Rückkauf.
10.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

10.2 Der vorliegende Artikel 10 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 9 dieser Satzung vorgesehen, die Ausgleichs-

zahlung für die abzutretenden Anteile durch die die Anteile erwerbende Person geschuldet ist und dass die Gesellschaft
als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 11. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
11.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

übertragen wurden.

11.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
11.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form und übt sein
Stimmrecht schriftlich aus.

11.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-

6615

L

U X E M B O U R G

zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

11.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

11.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jeder Bezug auf die „Gesellschafter-
versammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezug auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang und soweit
anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter ausgeübt.

Art. 12. Gesellschafterversammlung.
12.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

12.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

12.3 Falls alle Gesellschafter in einer Versammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einberufungsformalitäten

verzichtet haben, kann die Gesellschafterversammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

12.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

12.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 13. Quorum und Abstimmung.
13.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
13.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens 50% des Gesellschaftskapitals ver-

treten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein höheres Mehrheits-
verhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von Gesellschaftern, die
mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals halten. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im Einklang mit Artikel 12.2
eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesellschafterversammlung ist
dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der die Versammlung einbe-
rufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst.

Art. 14. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 15. Änderung der Satzung.
15.1 Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen Mehrheit der Gesellschafter, (ii)

die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen, sofern diese, wenn drei (3) oder mehr Investoren zu einem Zeit-
punkt Anteile der Gesellschaft gezeichnet haben, die Ja-Stimme mindestens eines Investors beinhaltet, bei welchem es
sich nicht um Rocket handelt.

Art. 16. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
16.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern (i) eine zahlenmäßigen Mehrheit

der  Gesellschafter,  (ii)  die  gleichzeitig  eine  Qualifizierte  Mehrheit  darstellen,  sofern  diese,  wenn  drei  (3)  oder  mehr
Investoren  zu  einem  Zeitpunkt  Anteile  der  Gesellschaft  gezeichnet  haben,  die  Ja-Stimme  mindestens  eines  Investors
beinhaltet, bei welchem es sich nicht um Rocket handelt:

16.1.1 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

16.1.2 Beschluss bezüglich der Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
16.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit:
16.2.1 Abschluss von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG));

6616

L

U X E M B O U R G

16.2.2 Abschluss von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräußerung von An-

teilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere Vertragspartei
eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der Gesellschaft ab-
hängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich Verträge,
welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wurden, sowie
Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und Werbe-
partnern;

16.2.3 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
16.2.4 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 8.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 10.1 dieser Satzung.

16.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer - Beirat

Art. 17. Befugnisse des alleinigen Geschäftsführers - Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
17.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

17.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der Geschäftsführer“
als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

17.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 18. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
18.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

Amtszeit festlegt.

18.2 Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
18.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß im Protokoll der betreffenden Gesellschafterbeschlüsse festgehalten und die
Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 19. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
19.1 Scheidet ein Geschäftsführer durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Insolvenz, Rücktritt oder aus einem anderen Grund

aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen die ur-
sprüngliche Amtszeit nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesellschafterversammlung ausgefüllt werden,
welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die endgültige Ernennung entscheidet.

19.2  Für  den Fall,  dass  der alleinige Geschäftsführer  aus seinem Amt  ausscheidet, muss die  frei  gewordene  Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 20. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
20.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung eines beliebigen Geschäftsführers. Die Sitzungen

des Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

20.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgege-
ben haben, wobei eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des
Rates der Geschäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der
Geschäftsführer bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

20.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zugestimmt und diese unterzeichnet haben.

Art. 21. Geschäftsführung.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

6617

L

U X E M B O U R G

21.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer  geleitet.  In  dessen  Abwesenheit  kann  der  Rat  der  Geschäftsführer  ein  anderes  Mitglied  des  Rates  der
Geschäftsführer  durch  einen  Mehrheitsbeschluss  der  anwesenden  oder  vertretenen  Mitglieder  als  Vorsitzenden  pro
tempore ernennen.

21.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er ein anderen

Geschäftsführer schriftlich, per Faxschreiben, E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikationsmittel be-
vollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer kann einen
oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

21.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

21.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest die Mehrheit seiner

Mitglieder in der Sitzung anwesend oder vertreten ist.

21.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung jedoch unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der Mehrheit
der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsführers der
Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

21.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, EMail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer kann seine
Zustimmung getrennt erteilen, wobei die Gesamtheit aller schriftlichen Zustimmungen die Annahme des betreffenden
Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

21.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen im Einklang mit Artikel 24.5 sofern, wenn zwei (2) oder mehr stimmberechtigte Mitglieder des Beirats zu einem
Zeitpunkt zusätzlich zu den von Rocket ernannten stimmberechtigten Mitgliedern ernannt wurden, diese die Ja-Stimme
mindestens eines stimmberechtigten Mitglieds beinhaltet, bei welchem es sich nicht um die von Rocket ernannten stimm-
berechtigten Mitglieder handelt. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen
präzise definiert und im Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

21.8.1 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Gesamtbetrag von zwei-

hunderttausend Euro (EUR 200.000,00) überschreiten;

21.8.2 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.3 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungszusagen jeglicher Art;
21.8.4 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

21.8.5 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

21.8.6 Verwendung des Jahresergebnisses; Rücklagen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;

21.8.7 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder von dokumentiertem Know-how durch die Gesellschaft

an einen Dritten, jedoch unter Ausschluss von Verfügungen (i) im gewöhnlichen Geschäftsgang und (ii) zwischen der
Gesellschaft und direkten und indirekten Tochtergesellschaften der Gesellschaft;

21.8.8 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen.

Als solche werden angesehen direkte oder indirekte Gesellschafter der Gesellschaft, verbundene Gesellschaften gemäß
§§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG), sowie Angehörige direkter oder indirekter Gesellschafter gemäß Abschnitt
15 der deutschen Abgabenordnung (AO), sofern letztere -einzeln oder gemeinsam - direkt oder indirekt eine Mehr-
heitsbeteiligung halten. Die Zustimmung gemäß dieses Artikels 21.8.8 ist nicht erforderlich, wenn die Transaktion zum
gewöhnlichen Geschäftsgang der Gesellschaft gehört und marktüblichen Bedingungen unterliegt;

21.8.9 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Anteils- oder Aktienoptionen) außerhalb der bestehenden vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen
den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

21.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung

6618

L

U X E M B O U R G

des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

21.10 Die Gesellschafterkönnendurcheinen Gesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

Art. 22. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer - Protokoll der Entscheidungen des alleinigen Ge-

schäftsführers.

22.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhanden)
oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche
Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kate-
gorie B), werden solche Protokolle durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1) Geschäftsführer der
Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsver-
fahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer, falls
vorhanden, oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unter-
schiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer
der Kategorie B), werden solche Kopien oder Auszüge durch einen (1) Geschäftsführer der Kategorie A und einen (1)
Geschäftsführer der Kategorie B (oder deren Vertreter) unterzeichnet.

22.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien und Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 23. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  durch  (i)  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsame Unterschrift zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet; sofern
die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer
der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B), wird die Gesellschaft durch die gemeinsame Unterschrift min-
destens  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  A  und  eines  (1)  Geschäftsführers  der  Kategorie  B  (oder  deren
Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person(en), der/
denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflichtet.

Art. 24. Beirat.
24.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat. Dieser besteht aus fünf (5) stimmberechtigten Mitgliedern. Die Gesellschafter

können durch einstimmige Zustimmung die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder des Beirats erhöhen oder herab-
setzen.

24.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung festlegen

und/oder verändern.

24.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

24.3.1 vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von Rocket nach eigenem Ermessen ernannt; und 24.3.2

ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von Eiffel nach eigenem Ermessen ernannt.

24.4 Der Beirat kann nicht-stimmberechtigte Mitglieder als Beobachter haben.
24.5 Der Beirat hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden. Ein von Rocket ernanntes stimm-

berechtigtes  Mitglied  ist  der  Vorsitzende  des  Beirats.  Die  Geschäftsordnung  des  Beirats  hat  weitere  Bestimmungen,
insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Der Beirat fasst Beschlüsse mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal pro Kalenderquartal.

24.6 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 25. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
25.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

25.2 Ein Rechnungsprüfer kann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
25.3 Die Rechnungsprüfer haben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

25.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d'entreprise agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

6619

L

U X E M B O U R G

25.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 26. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 27. Jahresabschluss und Gewinne.
27.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

27.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

27.3  Durch  einen  Gesellschafter  erbrachte  Einlagen  in  Rücklagen  können  mit  Zustimmung  dieses  Gesellschafters

ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

27.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt

werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

27.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den ge-

setzlichen Vorschriften und den Bestimmungen dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesell-
schaft verwendet werden soll.

27.6 Ausschüttungen an die Gesellschafter erfolgen proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehalt-

enen Anteile.

Art. 28. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
28.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag soll gegebenenfalls verteilt werden und darf nicht die Summe der seit dem
Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebenenfalls erhöht durch vorgetragene Gewinne und
ausschüttbare Rücklagen, beziehungsweise vermindert durch vorgetragene Verluste oder Summen, die einer Rücklage
zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser Satzung nicht ausgeschüttert werden darf, übersteigen.

28.2 Das Agio, andere Kapitalreserven und andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen

des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 29. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird haben die Liquidatoren die weitestgehenden Rechte für die Verwertung der Vermögens-
werte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares Recht

Art. 30. Anwendbares Recht.
30.1 Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915 und

jeder Gesellschaftervereinbarung, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft eingehen und durch die bestimmte
Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Satzung mit den Bestimmungen einer
Gesellschaftervereinbarung in Widerspruch stehen, so ist die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit
nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

30.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr EUR 2.500,-geschätzt.

Worüber Urkunde, aufgenommen in Luxemburg am eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

6620

L

U X E M B O U R G

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Gezeichnet: P. SYLVESTRE und H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 1 

er

 décembre 2014. Relation: LAC/2014/56812. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG - Der Gesellschaft auf Begehr erteilt.

Luxemburg, den 17. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014204072/1029.
(140228464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Kaola S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 113.814.

Veuillez noter que l'associé Tarragona S.A. réside professionnellement au 15, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

<i>Pour Kaola Sà.r.l.
Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014204413/13.
(140227597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

International Campus Köln S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 191.627.

<i>Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 27 octobre 2014

1. Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l. a démissionné de son mandat de gérante unique.
2. M. Rolf ENGEL, investisseur, né à Augsburg (Allemagne), le 22 avril 1959, demeurant professionnellement à Bahn-

hofstrasse 37, 8001 Zürich (Suisse), a été nommé comme gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

3. M. Rüdiger KIMPEL, administrateur de sociétés, né à Wiesbaden (Allemagne), le 2 septembre 1960, demeurant

professionnellement au L-3328 Crauthem (Luxembourg), 10, rue de Weiler, a été nommé comme gérant de catégorie A
pour une durée indéterminée.

4. M. Patrick TANGNEY, avocat, né à New-York (Etats-Unis d'Amérique), le 25 juin 1969, demeurant professionnel-

lement à Dubai (Emirats Arabes Unis), EFT South Tower, DIFC, Suite 802-803, P.O. Box 506672, a été nommé comme
gérant de catégorie A pour une durée indéterminée.

5. M. Charbel ABOU-JAOUDE, ingénieur, né à Beirut (Liban), le 15 juillet 1962, demeurant professionnellement à

Dubai (Emirats Arabes Unis), EFT South Tower, DIFC, Suite 802803, P.O. Box 506672, a été nommé comme gérant de
catégorie A pour une durée indeterminée.

6. Mme Valérie PECHON, administrateur de sociétés, née à Caracas (Venezuela), le 10 Novembre 1975, demeurant

professionnellement à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 6 (Luxembourg), a été nommée comme gérante de
catégorie B pour une durée indéterminée.

7. M. Roeland Cornelis DE GRAAF, administrateur de sociétés, né à Hilversum (Pays-Bas), le 23 décembre 1985,

demeurant professionnellement à L-2453 Luxembourg, rue Eugène Ruppert 6, (Luxembourg), a été nommé comme gérant
de catégorie B pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 03 décembre 2014.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour International Campus Köln S.à r.l.
Un mandataire

Référence de publication: 2014204346/30.
(140228198) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

6621

L

U X E M B O U R G

Eschtari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock.

R.C.S. Luxembourg B 58.273.

L'an deux mille quatorze, le seizième jour de décembre.
Par-devant Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg.

Se réunit

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "ESCHTARI S.A.", une société anonyme régie

par le droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-9991 Weiswampach, 2, Am Hock, inscrite auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg à la section B sous le numéro 58.273, constituée suivant un acte reçu par
Maître Camille HELLINCKX, alors notaire de résidence à Luxembourg, suivant acte reçu le 4 février 1997, publié au
Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 296 du 13 juin 1997, et dont les statuts ont été modifiés en
dernier lieu suivant acte reçu par le notaire Edouard Delosch, alors notaire de résidence à Rambrouch, le 14 décembre
2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 337 du 8 février 2012, (la "Société").

L'assemblée est présidée par Madame Murielle DAVAL, Inspecteur d'assurances, demeurant à B-4590 Warzée, 8, Rue

Tige de Hody.

Le  président  désigne  comme  secrétaire  Madame  Anne-Françoise  MOUTSCHEN,  employée  privée,  demeurant  à

B-4141 Sprimont, 67, rue des Fawes.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN, employée privée, demeurant à B-4141

Sprimont, 67, rue des Fawes.

Le bureau ainsi constitué, le président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit:
I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de

présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-
annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Il ressort de la liste de présence que les 2.750 (deux mille sept cent cinquante) actions représentant l'intégralité du

capital social sont représentés à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider
valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour

1 Augmentation du capital social de la Société à concurrence de vingt-quatre mille huit cents euros (EUR 24.800,-)

pour le porter de son montant actuel de soixante-huit mille deux cents euros (EUR 68.200,-) à quatre-vingt-treize mille
euros (EUR 93.000,-);

2 Émission de mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR

24,80) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes;

3 Acceptation de la souscription de ces mille (1.000) nouvelles actions par Madame Murielle DAVAL, prénommée, et

acceptation de la libération intégrale de ces nouvelles actions par un apport en numéraire;

4 Modification de l'alinéa premier de l'article 3 des statuts de la Société, afin de refléter les résolutions à adopter suite

à cet ordre du jour;

5 Révocation de Madame Rachel PLOM comme commissaire aux comptes de la société et nomination de Madame

Nadine CARELLE au poste de commissaire aux comptes et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2017;

6  Renouvellement  des  mandats  pour  6  ans  de  Monsieur  Alain  CREFCOEUR,  de  Madame  Murielle  DAVAL  et  de

Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN en leur qualité d'administrateurs de la Société;

7 Divers.
Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée générale, après délibération, l'assemblée générale prend à l'una-

nimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale a décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence de vingt-quatre mille huit cents

euros (EUR 24.800,-) pour le porter de son montant actuel de soixante-huit mille deux cents euros (EUR 68.200,-) à
quatre-vingt-treize mille euros (EUR 93.000,-).

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale a décidé d'émettre mille (1.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de vingt-quatre euros

et quatre-vingt cents (EUR 24,80) chacune, ayant les mêmes droits et privilèges que les actions existantes.

6622

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Paiement

Ensuite a comparu Madame Murielle DAVAL, Inspecteur d'assurances, demeurant à demeurant à B-4590 Warzée, 8,

Rue Tige de Hody.

La comparante a déclaré souscrire les prédites mille (1.000) actions nouvelles et libérer intégralement chacune de ces

actions souscrites par un apport en numéraire.

Preuve de ce payement est donnée au notaire soussigné, de sorte que la somme de vingt-quatre mille huit cents euros

(EUR 24.800,-) se trouve à l'entière disposition de la Société.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale a décidé d'accepter ladite souscription et ledit paiement et d'émettre les nouvelles actions à

Madame Murielle DAVAL, prénommée.

L'assemblée générale a également constaté que tous les actionnaires existants de la Société ont décidé de renoncer à

leur droit préférentiel de souscription en ce qui concerne l'émission de ces actions nouvelles.

<i>Quatrième résolution

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions ci-dessus, l'assemblée générale a décidé de modifier

l'alinéa premier de l'article 3 des statuts de la Société.

Ledit alinéa sera dorénavant rédigé comme suit:

« Art. 3. La Société a un capital social de quatre-vingt-treize mille euros (EUR 93.000,-), représenté par trois mille sept

cent cinquante (3.750) actions avec une valeur nominale de vingt-quatre euros et quatre-vingt cents (EUR 24,80) par
action, toutes les actions étant entièrement libérées.»

<i>Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de révoquer Madame Rachel PLOM, demeurant à B-4800 Verviers,

124, Rue Simon Lobet comme commissaire aux comptes de la société et de lui donner pleine et entière décharge pour
sa mission jusqu'à ce jour et de nommer la Madame Nadine CARELLE, expert-comptable, née le 26 mai 1967 à Dudelange,
demeurant à L-4123 Esch-sur-Alzette, 4, rue du Fossé, au poste de commissaire aux comptes et ceci jusqu'à l'assemblée
générale qui se tiendra en l'an 2017.

<i>Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires a décidé de renouveler les mandats d'administrateurs de la Société pour une

nouvelle période de pour 6 ans, et ceci jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'an 2020, de:

- Monsieur Alain CREFCOEUR, né le 17 février 1961 à Namur (Belgique), administrateur, demeurant professionnel-

lement à L-1123 Luxembourg, 9a, Plateau Altmunster;

- Madame Murielle DAVAL, Inspecteur d'assurances, née le 18 octobre 1970 à Savigny-Sur-Orge (France), demeurant

à B-4590 Warzée, 8, rue Tige de Hody;

- Madame Anne-Françoise MOUTSCHEN, employée privée, née le 19 juillet 1969 à Verviers (Belgique), demeurant à

B-4141 Sprimont, 67, rue des Fawes.

<i>Estimation des frais

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société

ou qui sont mis à sa charge en raison de l'augmentation de son capital s'élève à environ mille deux cents cinquante euros
(EUR 1.250.-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Weiswampach, le jour, mois et an qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux membres du Bureau, connus du notaire soussigné par leur

nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Signé: M. DAVAL, A.-F. MOUTSCHEN, DELOSCH.
Enregistré à Diekirch, le 17 décembre 2014. Relation: DIE/2014/16309. Reçu soixante-quinze (75.-) euros.

<i>Le Receveur (signé): THOLL.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Diekirch, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014206891/102.
(140231372) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

6623

L

U X E M B O U R G

Intaris - Salaires et Gestion, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7373 Lorentzweiler, 93, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 145.750.

L'an deux mille quatorze, le seize décembre.
Par-devant nous, Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

A COMPARU:

La société anonyme de droit luxembourgeois «FIDACC», ayant son siège social à L-7373 Lorentzweiler, 93, route de

Luxembourg,  inscrite  auprès  du  Registre  de  Commerce  et  des  Sociétés  de  Luxembourg  sous  le  numéro  B.130.529,
constituée suivant acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire de résidence à Ettelbruck, en date du 27 juillet 2007,
publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2038 du 20 septembre 2007,

ici représentée par son administrateur unique, à savoir:
Monsieur Yves SCHARLE, comptable, demeurant professionnellement à L-7373 Lorentzweiler, 93, route de Luxem-

bourg, ayant pouvoir pour engager la prédite société en toutes circonstances par sa seule signature et nommé à cette
fonction suivant assemblée générale extraordinaire tenue lors de la constitution de ladite société.

Qu'elle déclare être l'associée unique de la société à responsabilité limitée «INTARIS - SALAIRES ET GESTION», ayant

son siège social à L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 145.750, constituée suivant acte reçu par Maître Henri HELLINCKX, notaire
de résidence à Luxembourg, en date du 1 

er

 avril 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro

925 du 4 mai 2009 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis la constitution,

Qu'elle s'est réunie en assemblée générale extraordinaire à laquelle elle s'entend par ailleurs dûment convoquée et a

pris les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'associée unique décide de transférer le siège de la société de L-7540 Rollingen/Mersch, 113, rue de Luxembourg à

L-7373 Lorentzweiler, 93, route de Luxembourg.

<i>Deuxième résolution

En conséquence de la décision qui précède, l'associée unique décide de modifier le premier alinéa de l'article 2 des

statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. Alinéa 1 

er

 .  Le siège social est établi dans la commune de Lorentzweiler.»

<i>Troisième résolution

L'associée unique décide de modifier l'article 13 des statuts en lui ajoutant une clause relative aux dividendes. L'article

13 aura dès lors la teneur suivante:

« Art. 13. A la fin de chaque exercice un bilan, un inventaire et un compte de profits et pertes seront établis. Le bénéfice

net après déduction des frais d'exploitation, des traitements ainsi que des montants jugés nécessaires à titre d'amortis-
sement et de réserves sera réparti comme suit:

a) cinq pour cent (5%) au moins pour la constitution de la réserve légale, dans la mesure des prescriptions légales;
b) le solde restant est à la disposition de l'assemblée générale des associés.
Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés proportionnellement au nombre de leurs parts, sans que

toutefois aucun des associés ne puisse être tenu ou responsable au-delà du montant de ses parts.

Des acomptes sur dividendes peuvent être distribués suivant les dispositions légales.»
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par nom, prénom,

qualité et demeure, ce dernier a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: V. ALEXANDRE, Y. SCHARLE, M. LECUIT.
Enregistré à Mersch, le 17 décembre 2014. Relation: MER/2014/2796. Reçu soixante quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): A. MULLER.

POUR COPIE CONFORME

Beringen, le 23 décembre 2014.

Référence de publication: 2014207049/52.
(140230769) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6624


Document Outline

Anlogistyk Management S.à.r.l.

CEP III Investment 17 S.à r.l.

Daily Snack S.à r.l.

DdC Consulting S.à r.l.

De Keisecker S.A.

Delta Concept Investissement S.A.

Delta Information Technologies S.A.

Devel+

Dexton Group S.à r.l.

Dexton ICT S.à r.l.

Dexton Software S.à r.l.

DH Holding (Luxembourg) S.à r.l.

Diederich &amp; Sinner S.à r.l.

Dienes International Beteiligungsgesellschaft mbH

Digital Services XVII S.à r.l.

Disposable Solutions S.à r.l.

DR Invest S.A.

DR Invest S.A.

Dudelounge S.à r.l.

Duisburg Holding (Luxembourg) S.A.

Eastern Domus Ventures

Edison Aviation S.A.

Edison Yachting S.A.

Elie Saab Luxembourg S.à r.l.

Eschtari S.A.

Eurêka Solutions S. à r.l.

Euro'Pain S.à r.l.

European Direct Property IV S.A.

Europe Fiduciaire (Luxembourg) S.A.

EuroProp (EMC VI) S.A.

Exigo S.A.

Exploitation de carrières savonnières S.à r.l.

Intaris - Salaires et Gestion

International Campus Köln S.à r.l.

Jenny Location S. à r.l.

Kaola S.à r.l.

Lex II Investments Holdings S.A.

Lex Investments Holdings S.A.

Oben der Kirch s.à r.l.

Oben der Kirch s.à r.l.

OCM / Nordenia Luxembourg GP S.A.

Organik Luxembourg S.A.

Oropan International S.à r.l.

Oteo Investment S.à r.l.

Parkwood (Cologne) S.à r.l.

Parthi SA

S.A. Grand Garage Olivier ORIGER

TB Intermediate Holdings S.à r.l.