logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 125

16 janvier 2015

SOMMAIRE

Gam Consult S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6000

Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5971

Holding Blanc Bleu 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

5979

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l.  . . . . . . . . .

5966

JPY Immo S.à.r.l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5985

KCTG Acquisition Holding 1 S.à.r.l. . . . . . .

5963

KED Holding 1 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5963

Maroti S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5954

MDC Commercial Finance (Luxembourg)

S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5955

Monségur PV Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

5954

Nova Participation S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5955

OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5956

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5956

Patron Sports Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . .

5960

Penelope Properties S.A.  . . . . . . . . . . . . . . .

5959

Phantom Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5956

Phantom S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5957

Phoenix Manufacturing and Trading A.G.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5957

Polma 1 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

Prime Credit 5 S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5954

PSPLUX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5961

QS PDI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5959

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5961

Queens International S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5960

Quinta da Murteira S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5959

RDH Investments International S.A.  . . . . .

5955

Regency Internationale S.A., SPF  . . . . . . . .

5955

Renewable Finance III  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5990

Rosiris Investment S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5957

RP II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5957

RP XIV S.àr.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5957

RP XVI S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

R Wealth Management SICAV SIF  . . . . . .

5960

Saw Grass S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

S.I.G. Kapital S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

Société de Boulangerie Artisanale au Le-

vain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5959

Star Capital Investments Europe S.à r.l.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5958

TEC S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5956

Telsi S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5961

Thunder Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . .

5962

Tracé s.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5965

5953

L

U X E M B O U R G

Monségur PV Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 156.527.

Par résolutions prises en date du 8 décembre 2014, l'associé unique a pris les décisions suivantes:
1. Nomination d'Emmanuel Mougeolle, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg,

au mandat de gérant, avec effet au 15 décembre 2014 et pour une durée indéterminée;

2. Acceptation de la démission de Géraldine Schmit, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882

Luxembourg de son mandat de gérant, avec effet au 15 décembre 2014;

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203430/15.
(140226497) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Maroti S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1259 Senningerberg, 13-15, Breedewues.

R.C.S. Luxembourg B 98.265.

<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société Maroti S.A. qui s'est tenue à Luxembourg en date

<i>du 3 décembre 2014.

L'assemblée a décidé:
De ne plus prolonger le mandat d'administrateur de Monsieur Christian Goecking, vu que son mandat est venu à

échéance.

De prolonger les mandats des administrateurs des Messieurs Lucien Zanella, Bénédict Fontanet et Gérard Scheiwen,

ainsi que le mandat du commissaire aux comptes, la société Premium Advisory Partners S.A. jusqu'à l'Assemblée Générale
qui se tiendra en 2015.

Senningerberg, le 18 décembre 2014.

<i>Pour la société
Mandataire

Référence de publication: 2014203438/18.
(140226611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Prime Credit 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: GBP 12.500,00.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 168.559.

En date du 9 décembre 2014, l'associé unique de la Société a pris les résolution suivantes:
de révoquer le mandat de;
PricewaterhouseCoopers, société anonyme, ayant son siège social au 400 routes d'esch, L-1014 Luxembourg, avec

effet immédiat,

de nommer en remplacement;
L'alliance Revision S.arl., société à responsabilité limitée ayant son siège social au 1, rue des Glacis, L-1628 Luxembourg,

en tant que réviseur d'entreprise de la Société avec effet immédiat pour une période se terminant à l'Assemblée Générale
Annuelle qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Prime Credit 5 S.àr.l.
Malcolm Wilson
<i>Administrateur

Référence de publication: 2014203509/21.
(140227079) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5954

L

U X E M B O U R G

MDC Commercial Finance (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.000.000,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 150.375.

EXTRAIT

En date du 20 July 2010, l'associé unique de la Société a changé sa dénomination sociale de «Treasury Holding Company

L.L.C» en «Mubadala Treasury Holding Company L.L.C».

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
<i>Le mandataire

Référence de publication: 2014203442/14.
(140226277) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Nova Participation S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 132.821.

<i>Extrait des résolutions prises lors de la réunion du Conseil d'Administration du 5 décembre 2014

- Il est pris acte de la démission de Madame Natalia VENTURINI de son mandat d'administrateur avec effet à ce jour.
- Monsieur Patrice Le Lann, né le 25 mai 1964 à Marseille (France), administrateur de société, demeurant au 16 Bd

Marshall Rokossovski, 107150 MOSCOU, RUSSIE est coopté en tant qu'administrateur en remplacement de Madame
Natalia VENTURINI, démissionnaire, avec effet à ce jour. Son mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale
Statutaire de l'an 2015.

- Conformément aux dispositions de l'article 64 (2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,

les Administrateurs élisent Monsieur Patrice LE LANN en tant que Président du Conseil d'Administration jusqu'au terme
de son mandat à savoir l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra en 2015.

Luxembourg, le 5 décembre 2014.

NOVA PARTICIPATION S.A.

Référence de publication: 2014203468/18.
(140226713) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

RDH Investments International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 169.618.

Le bilan et l'annexe au 31 décembre 2012 ont été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour la société
Un administrateur

Référence de publication: 2014203566/11.
(140226732) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Regency Internationale S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2320 Luxembourg, 21, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 32.659.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

REGENCY INTERNATIONALE S.A., SPF
Société Anonyme

Référence de publication: 2014203568/11.
(140227082) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5955

L

U X E M B O U R G

OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.637.

<i>Extrait de contrat de cession de parts sociales

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 9 décembre 2014, la part sociale d'une valeur nominale de

1,25 EUR de la Société a été transférée de OCM/Nordenia Luxembourg GP S.A. ayant son siège social au 26A Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg (RCSL B114.639) à OCM Luxembourg OPPS VI Sàrl dont le siège social a été transféré au
26A Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCSL B121877) suite à une résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 18 juillet 2011 (déposée au RCS le 05/08/2011 sous le numéro L110128853)

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203481/14.
(140227085) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 114.638.

<i>Extrait de contrat de cession de parts sociales

En vertu d'un contrat de cession de parts sociales daté du 9 décembre 2014, la part sociale d'une valeur nominale de

1,25 EUR de la Société a été transférée de OCM/Nordenia Luxembourg GP S.A. ayant son siège social au 26A Boulevard
Royal L-2449 Luxembourg (RCSL B114.639) à OCM Luxembourg EPOF Sàrl dont le siège social a été transféré au 26A
Boulevard Royal L-2449 Luxembourg (RCSL B121877) suite à une résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 30 juin 2011 (déposée au RCS le 25/07/2011 sous le numéro L110118995)

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203482/14.
(140227088) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Phantom Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 112.967.

Le Bilan et I"affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 Décembre 2014.

Phantom Holding S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager

Référence de publication: 2014203523/14.
(140226459) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

TEC S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 121.618.

Les comptes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TEC S.À.R.L.
DONATI Régis
<i>Gérant

Référence de publication: 2014203689/12.
(140227252) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5956

L

U X E M B O U R G

Phantom S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 110.843.

Le Bilan et l'affectation du résultat au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 15 Décembre 2014.

Phantom S.à r.l.
Manacor (Luxembourg) S.A.
<i>Manager

Référence de publication: 2014203524/14.
(140226462) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Phoenix Manufacturing and Trading A.G., Société Anonyme Unipersonnelle.

Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.

R.C.S. Luxembourg B 56.269.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203525/10.
(140227160) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Rosiris Investment S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 162.275.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203559/10.
(140226670) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

RP II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 123.737.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203575/10.
(140226882) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

RP XIV S.àr.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 128.224.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203576/10.
(140226997) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5957

L

U X E M B O U R G

Polma 1 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2661 Luxembourg, 40, rue de la Vallée.

R.C.S. Luxembourg B 115.941.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Pour copie conforme
<i>Pour la société
Maître Carlo WERSANDT
<i>Notaire

Référence de publication: 2014203533/14.
(140226608) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

RP XVI S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 131.572.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203577/10.
(140227024) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

S.I.G. Kapital S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 23, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 152.475.

Les comptes annuels au 31 mars 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203583/10.
(140226287) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Saw Grass S. à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 170.622.

Les comptes annuels du 01/01/2013 au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203587/10.
(140226612) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Star Capital Investments Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 130.559.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203607/10.
(140226886) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5958

L

U X E M B O U R G

Penelope Properties S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1309 Luxembourg, 79, rue Charles IV.

R.C.S. Luxembourg B 175.872.

<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires tenue le 4 novembre 2014:

- la démission de G.T. FIDUCIAIRES S.A., avec effet au 1 

er

 janvier 2014, en tant que Commissaire de la Société est

acceptée.

- la société LUX-AUDIT S.A., avec siège social à 57, avenue de la Faïencerie, L -1510 Luxembourg, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 25 797 est nommée en tant que Commissaire de la
Société avec effet immédiat pour un mandat d'une durée de quatre (4) années qui arrivera à échéance à l'issue de l'as-
semblée générale annuelle qui se tiendra en 2018.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 4 novembre 2014.

<i>Pour la Société
Un mandataire

Référence de publication: 2014203520/18.
(140226836) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Quinta da Murteira S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 146.483.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203546/9.
(140226864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

QS PDI, Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 179.216.

<i>Extrait du rapport du Conseil de Gérance du 28 novembre 2014

Le Conseil de Gérance a approuvé la démission de Monsieur Michel Abouchalache, demeurant professionnellement

au 243, Boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, de sa qualité de gérant de la Société, avec effet au 23 juillet 2014.

De plus, le Conseil de Gérance a également approuvé la nomination de Monsieur Johann, Guillaume Dumas, demeurant

professionnellement au 3, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, en tant que gérant de la Société, avec effet au 28 no-
vembre 2014.

Enfin, le Conseil de Gérance a approuvé la nomination de Monsieur Stanislas, Philippe, Hélion, Henri, Antoine, Marie

Poniatowski, demeurant au 104 El Majal - Annakhil Nord, La Palmeraie, 40000 Marrakech, Maroc, en tant que gérant de
la Société, avec effet au 28 novembre 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2014203547/18.
(140226326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 11, rue du Bassin.

R.C.S. Luxembourg B 20.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203599/9.
(140226745) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5959

L

U X E M B O U R G

Patron Sports Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 25.000,00.

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 147.439.

<i>Extrait des résolutions de l'associé unique de la Société du 18 décembre 2014

L'associé unique de la Société a pris les résolutions suivantes:
- Acceptation de la démission de M. Emmanuel Mougeolle de son poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

décembre 2014.

- Nomination de M. Steve van den Broek, directeur de sociétés, né à Anvers, Belgique, le 26 juillet 1970, résidant

professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, au poste de gérant de la société avec effet au 1 

er

 dé-

cembre 2014 pour une durée indéterminée.

Le Conseil de gérance de la Société se compose dorénavant comme suit:
- Mme Géraldine Schmit, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
- M. Steve van den Broek, gérant, résidant professionnellement au 6, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

La Société

Référence de publication: 2014203502/20.
(140227132) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Queens International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 106.334.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 04 décembre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, 6 

e

 Chambre, siégeant en

matière commerciale, après avoir entendu le Juge-commissaire en son rapport oral, le liquidateur et le Ministère Public
en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société sous mentionnée
et met les frais à charge du Trésor.

- La société anonyme QUEENS INTERNATIONAL S.A, avec siège social à L-6630 Wasserbillig, 40-42, Grand-Rue
N°RCS B 106334

Pour extrait conforme
Maître Céline CORBIAUX
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014203548/17.
(140226339) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

R Wealth Management SICAV SIF, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1748 Senningerberg, 6, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 173.853.

<i>Extrait des résolutions prises lors du conseil d'administration de R Wealth Management SICAV SIF (la «Société») qui s'est tenu en

<i>date du 17 novembre 2014:

1. Le Conseil d'administration a élu Monsieur Alexander MacPhee (demeurant professionnellement à New Court, St

Swithin's Lane, London EC4N8AL, Royaume-Uni) avec effet au 17 novembre 2014 à la fonction d'administrateur en
remplacement de Monsieur Marc Glesener. Monsieur Alexander MacPhee terminera le mandat de Monsieur Marc Gle-
sener. Son election sera définitive lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour le compte de R WEALTH MANAGEMENT SICAV SIF
Northern Trust Luxembourg Management Company S.A.

Référence de publication: 2014203549/17.
(140227023) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5960

L

U X E M B O U R G

PSPLUX, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 124, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 112.796.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de l'Associé Unique tenue le 9 décembre 2014

Il a été décidé:
de nommer Monsieur Dino Rambidis, né le 24 mai 1966, demeurant au 8 rue Théorêt, Kirkland, Quebec H9J 4A4, en

qualité de gérant de catégorie A, pour une durée indéterminée.

Le Conseil de Gérance se compose donc comme suit:

<i>Catégorie A:

Madame Martine Légaré, Madame Marie Falardeau, Monsieur Stéphane Jalbert et Monsieur Dino Rambidis

<i>Catégorie B:

Monsieur Marcel Krier, Monsieur Marcel Stephany, Madame Véronique Wauthier, Monsieur Pierre Hamel et Monsieur

Jean-Paul Gennari.

Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014203543/20.
(140227411) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A., Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme.

Capital social: GBP 81,00.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 167.584.

<i>Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires tenue en date du 18 décembre 2014

En date du 18 décembre 2014, les Actionnaires de la société Queensgate Carry Partner GP COOP S.A. ont décidé

comme suit:

- d'accepter la démission de Monsieur Alexander de Meyer, en tant qu'administrateur et commissaire aux comptes de

la Société avec effet au 11 novembre 2014;

- de nommer Madame Jueane Thiessen, née le 7 juin 1974 à Richmond, Canada, résidant professionnellement au 1-ère

étage, 22-23 Old Burlington Street W1S 2JJ Londres, Royaume-Uni, en tant qu'administrateur et commissaire aux comptes
de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 12 novembre 2014.

Le conseil d'Administration est désormais composé de:
- Monsieur Godfrey Abel;
- Monsieur Jaap Meijer;
- Madame Jueane Thiessen.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203545/22.
(140227087) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Telsi S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8030 Strassen, 163, rue du Kiem.

R.C.S. Luxembourg B 24.148.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour TELSI S.A.
HRT FIDALUX S.A.
<i>Agent Domiciliataire

Référence de publication: 2014203693/12.
(140226676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5961

L

U X E M B O U R G

Thunder Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

R.C.S. Luxembourg B 51.162.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

L'an deux mille quatorze, le premier décembre,
Par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg,

S’est tenue:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme, société de gestion de patrimoine familial

«THUNDER HOLDING S.A., SPF», ayant son siège social au 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 51.162, constituée suivant acte notarié en date
du 17 mai 1995, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 402 du 23 août 1995 (la Société).

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte reçu par le notaire soussigné en date

du 10 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 912 du 5 mai 2011.

La Société a été mise en liquidation suivant acte du notaire soussigné en date du 8 septembre 2014, publié au Mémorial

C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 3222 du 3 novembre 2014.

L'assemblée est ouverte à 9.00 heures sous la présidence de Madame Caroline Wolff, employée privée, 1, rue Joseph

Hackin, L-1746 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Madame Carole Sabinot, employée privée, 1, rue Joseph Hackin, L-1746 Luxembourg.
L'assemblée choisit comme scrutatrice Monsieur Roberto Manchiocchi, employé privé, 1, rue Joseph Hackin, L-1746

Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:
I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a été convoquée par des avis de convocation publiés au:
a) Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations:
- numéro 3306 du 8 novembre 2014,
- numéro 3426 du 18 novembre 2014,
b) Lëtzebuerger Journal:
- le 8 novembre 2014,
- le 18 novembre 2014,
II. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour:

<i>Ordre du jour

1) Acceptation du rapport du commissaire à la liquidation.
2) Décharge au liquidateur et au commissaire à la liquidation.
3) Clôture de la liquidation.
4) Indication de l’endroit où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans.
III. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre

d’actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les
actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau, restera annexée
au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l’enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes, les procurations des actionnaires représentés, après avoir été para-

phées ne varietur par les comparants.

IV. Qu'il résulte de la liste de présence que sur les dix mille (10.000) actions en circulation, quatre (4) actions sont

représentées à la présente assemblée.

V. Qu'en date du 11 novembre 2014 s’est tenue l’assemblée générale des actionnaires qui a nommé Fiduciaire Glacis

S.à r.l., ayant son siège social à 18a, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, en tant que commissaire à la liquidation.

VI. Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, sur les points portés à

l’ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l’unanimité des voix les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale prend connaissance du rapport du commissaire à la liquidation de la Société et décide de l’ac-

cepter.

Un exemplaire de ce rapport restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps.

5962

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution:

L'assemblée générale donne décharge pleine et entière au liquidateur Monsieur Pierre SCHILL et au commissaire à la

liquidation FIDUCIAIRE GLACIS S.à r.l..

Pour autant que de besoin, l’assemblée générale confirme que Monsieur Pierre SCHILL, en tant que liquidateur, reste

chargé des derniers décomptes et paiements à faire après la clôture de la liquidation.

<i>Troisième résolution:

L'assemblée générale prononce la clôture de la liquidation et constate que la société «THUNDER HOLDING S.A.,

SPF» a définitivement cessé d'exister.

<i>Quatrième résolution:

L'assemblée générale décide que les livres et documents sociaux de la Société seront conservés pendant la durée de

cinq ans à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, au siège social de la Société, date qu'en tête.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le

présent acte.

Signé: C. WOLFF, C. SABINOT, R. MANCIOCCHI et J. BADEN.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 3 décembre 2014. LAC / 2014 / 57356. Reçu soixante quinze euros € 75,-.

<i>Le Receveur (signé): THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014202086/74.
(140224904) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

KCTG Acquisition Holding 1 S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. KED Holding 1 S.à r.l.).

Capital social: USD 40.000,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 182.550.

In the year two thousand and fourteen, on the nineteenth of November.
Before Us, Maître Francis Kesseler, notary residing in Esch/Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

KCTG Holdings, LP, a limited partnership established and existing under the laws of the State of Delaware, United

States of America, with registered office at 1209 Orange Street, 19801 Wilmington, New Castle County, Delaware,
United States of America, and registered with the Secretary of State of the State of Delaware under number 3563378,

here represented by Marie Dupuis, employee, with professional address at 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-

Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on November 18, 2014.

The said proxy, signed ne varietur by the person appearing and the undersigned notary, will remain annexed to the

present deed to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, through its proxyholder, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing party is the sole shareholder of the private limited liability company established and existing under

Luxembourg laws under the name “KED Holding 1 S.à r.l.” (hereinafter, the Company), with registered office at 2-4, rue
Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Com-
panies Register under number B 182550, established pursuant to a deed of the undersigned notary, dated November 26,
2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 186 dated January 21, 2014 and
whose bylaws have not been amended since then.

II. The Company’s share capital is set at forty thousand United States Dollars (USD 40.000,00) represented by eight

hundred thousand (800.000) shares with a nominal value of five US Dollar cents (USD 0,05) each.

III. The sole shareholder takes the following resolutions:

<i>First resolution

The sole shareholder resolves to change the name of the Company from “KED Holding 1 S.à r.l.” to “KCTG Acquisition

Holding 1 S.à r.l.”

5963

L

U X E M B O U R G

<i>Second resolution

Further to the above resolution, article 4 of the Company’s articles of association is amended and shall henceforth

read as follows:

« Art. 4. The Company will have the name “KCTG Acquisition Holding 1 S.à r.l.”».

<i>Third resolution

The sole shareholder resolves to acknowledge the resignation of the following persons from their position as category

A managers of the Company, with immediate effect:

- Mr. Ross A. Goering, company manager, born on September 11, 1967 in Newport News, Virginia, United States of

America, with professional address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, United States of America; and

- Mr. David J. May, company manager, born on May 29, 1967 in Miami, Florida, United States of America, with pro-

fessional address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, United States of America.

<i>Fourth resolution

The sole shareholder resolves to grant them discharge for the exercise of their mandate until the effective date of

their resignation.

<i>Fifth resolution

The sole shareholder resolves to appoint the following persons as category A managers of the Company with imme-

diate effect and for an unlimited period of time:

- Mr. Mark A. Soucie, company director, born on July 16, 1964 in Nebraska, United States of America, with professional

address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, United States of America; and

- Ms. Jeanne R. Hernandez, treasurer, born on July 18, 1966 in Neodesha, Kansas, United States of America, with

professional address at 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, United States of America.

<i>Declaration

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing

person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person
and in case of divergence between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Senningerberg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the person appearing, who is known to the notary by her name,

civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present original deed.

Suit la traduction en langue française du texte qui précède.

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf novembre.
Par-devant Nous, Maître Francis Kesseler, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

KCTG  Holdings,  LP,  un  limited  partnership  constitué  et  existant  selon  les  lois  de  l’Etat  du  Delaware,  Etats-Unis

d’Amérique, ayant son siège social à 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle Country, 19801 Delaware, Etats-Unis
d’Amérique et enregistré auprès du Secrétaire d’Etat de l’Etat du Delaware sous le numéro 3563378,

ici représenté par Marie Dupuis, employée, ayant son adresse professionnelle au 1B Heienhaff, L-1736 Senningerberg,

Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d’une procuration donnée sous seing privé le 18 novembre 2014.

Laquelle procuration, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire du comparant et le notaire instrumentaire,

demeurera annexée aux présentes pour être enregistrée avec elles.

Lequel comparant, par son mandataire, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. Le comparant est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie et existante selon les lois du Luxem-

bourg sous la dénomination «KED Holding 1 S.à r.l.» (ci-après, la Société), ayant son siège social au 2-4, rue Eugène
Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des So-
ciétés de Luxembourg sous le numéro B 182550, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 26
novembre 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 186 en date du 21 janvier
2014, dont les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.

II. Le capital social de la Société est fixé à quarante mille Dollars Américains (USD 40.000,00) représenté par huit cent

mille (800.000) parts sociales d'une valeur nominale de cinq centimes de Dollar Américain (USD 0,05) chacune.

III. L’associé unique, représenté comme indiqué ci-dessus, prend les résolutions suivantes:

5964

L

U X E M B O U R G

<i>Première résolution

L’associé unique décide de changer la dénomination sociale de la Société de «KED Holding 1 S.à r.l.» en «KCTG

Acquisition Holding 1 S.à r.l.»

<i>Deuxième résolution

Suite à la résolution prise ci-dessus, l’article 4 des statuts de la Société est modifié pour avoir désormais la teneur

suivante:

« Art. 4. La Société a comme dénomination “KCTG Acquisition Holding 1 S.à r.l.”».

<i>Troisième résolution

L’associé unique décide de reconnaître la démission des personnes suivantes de leur poste de gérant de catégorie A

de la Société avec effet immédiat:

- M. Ross A. Goering, gérant de société, né le 11 septembre 1967 à Newport News, Virginie, Etats-Unis d’Amérique,

ayant son adresse professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d’Amérique; et

- M. David J. May, gérant de société, né le 29 mai 1967 à Miami, Floride, Etats-Unis d’Amérique, ayant son adresse

professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Quatrième résolution

L’associé unique décide de leur donner décharge pour l’exercice de leur mandat jusqu'à la date d’effet de leur démission.

<i>Cinquième résolution

L’associé unique décide de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de catégorie A de la Société avec

effet immédiat et pour une durée illimitée:

- M. Mark A. Soucie, administrateur de société, né le 16 juillet 1964 au Nebraska, Etats-Unis d’Amérique, ayant son

adresse professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d’Amérique; et

- Mme. Jeanne R. Hernandez, trésorière, née le 18 juillet 1966 à Neodesha, Kansas, Etats-Unis d’Amérique, ayant son

adresse professionnelle au 4111 E. 37 

th

 Street North, Wichita, 67220 Kansas, Etats-Unis d’Amérique.

<i>Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne com-

parante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même personne et en cas
de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, passé à Senningerberg, date qu'en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connue du notaire par son nom et prénom,

état et demeure, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Dupuis, Kesseler.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 21 novembre 2014. Relation: EAC/2014/15834. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.
Référence de publication: 2014204415/116.
(140228746) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Tracé s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8399 Windhof (Koerich), 4, rue d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 138.935.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Jean-Marie CESAR
<i>Gérant

Référence de publication: 2014203700/11.
(140226741) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5965

L

U X E M B O U R G

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 186.778.

In the year two thousand fourteen, on the eleventh day of December.
Before the undersigned, Maître Jean Seckler, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED

OPCIMMO, a professional open-ended real estate investment fund (société de placement à preponderance immobilière

à capital variable) established under the laws of France, having its registered office at 91-93 boulevard Pasteur, 75015
Paris, France, registered with the register of commerce and companies of Paris under number 533 506 234 (the "Sole
Shareholder"),

here represented by Mr Henri DA CRUZ, notary's clerk, with professional address in Junglinster, by virtue of a proxy

given on 9 December 2014.

The said proxy, signed “ne varietur” by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary, will remain

attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole shareholder of IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., a private limited liability company

(société à responsabilité limitée) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address
at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register
of Commerce and Companies ("RCS") under number B 186778 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned
notary, dated 16 April 2014, whose articles of incorporation (the "Articles") have beens published in the Mémorial C,
Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1800, page 86372, on 10 July 2014 (the "Company"). The
Articles of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 24
July 2014, published in the Mémorial number 2797, page 134253, on 8 October 2014.

The appearing party representing the whole share capital requires the notary to act the following resolutions taken in

accordance with the provisions of article 200-2 of the Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915, as
amended, pursuant to which a sole shareholder of a société à responsabilité limitée shall exercise the powers of the
general meeting of shareholders of the company and the decisions of the sole shareholder are recorded in minutes or
drawn up in writing:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to create new classes of shares in the share capital of the Company:
- the ordinary shares;
- the class A shares which are entitled to track the direct or indirect investment of the Company in Silizium Propco

S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C,
rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the RCS under number
B 186795; and

- the class B shares which are entitled to track the direct or indirect investment of the Company in RPTRE I S.à r.l., a

Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 46 A, Avenue
John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and being registered with the RCS under number
B 140024.

Only the class A shares and class B shares can be redeemed.

<i>Second resolution

The Sole Shareholder decides to increase the issued share capital of the Company by an amount of four hundred

twenty-five thousand seven hundred forty Euro (EUR 425,740.-), so as to bring it from its current amount of twenty-two
thousand nine hundred fifty Euro (EUR 22,950.-) to four hundred forty-eight thousand six hundred ninety Euro (EUR
448,690.-) by creating and issuing two hundred twenty thousand four hundred (220,400) new class A shares with a nominal
value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Class A Shares"), each of such New Class A Shares having such rights and
obligations as set forth in the Articles and being issued with a share premium of a total amount of one million nine hundred
eighty-three thousand six hundred Euro (EUR 1,983,600.-); and by creating and issuing two hundred five thousand three
hundred forty (205,340) new class B shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the "New Class B Shares"),
each of such New Class B Shares having such rights and obligations as set forth in the Articles and being issued with a
share premium of a total amount of one million eight hundred forty-eight thousand fifty-seven Euro (EUR 1,848,057.-).

<i>Subscription and payment

All the New Class A Shares are subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up by a contribution in cash of two

million two hundred four thousand Euro (EUR 2,204,000.-) out of which two hundred twenty thousand four hundred
Euro  (EUR  220,400.-)  are  allocated  to  the  share  capital  of  the  Company  and  one  million  nine  hundred  eighty-three
thousand six hundred Euro (EUR 1,983,600.-) are allocated to the share premium account.

5966

L

U X E M B O U R G

All the New Class B Shares are subscribed by the Sole Shareholder and fully paid up by a contribution in cash of two

million fifty-three thousand three hundred ninety-seven Euro (EUR 2,053,397.-) out of which two hundred five thousand
three hundred forty Euro (EUR 205,340.-) are allocated to the share capital of the Company and one million eight hundred
forty eight thousand fifty seven Euro (EUR 1,848,057.-) are allocated to the share premium account.

The proof of the existence and of the value of the contributions has been produced to the undersigned notary.

<i>Third resolution

Further to the previous resolutions, the Sole Shareholder resolves that the Company's share capital of four hundred

forty-eight thousand six hundred ninety Euro (EUR 448,690.-) will be represented as follows:

- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares held by the Sole Shareholder (the "Ordinary Shares");
- two hundred thirty thousand eight hundred fifty (230,850) class A shares held by the Sole Shareholder (the "Class A

Shares"); and

- two hundred five thousand three hundred forty (205,340) class B shares held by the Sole Shareholder (the "Class B

Shares");

each with a nominal value of one Euro (EUR 1.-).

<i>Fourth resolution

As a consequence of the above resolution, the Sole Shareholder decides to amend (i) article 5.1 of the Articles, (ii)

article 5.5 of the Articles and (iii) article 15 of the Articles, which shall now read as follows:

5.1. The issued share capital of the Company is four hundred forty-eight thousand six hundred ninety Euro (EUR

448,690.-) divided into:

- twelve thousand five hundred (12,500) ordinary shares (the "Ordinary Shares") with a nominal value of one Euro

(EUR 1.-) each;

- two hundred thirty thousand eight hundred fifty (230,850) class A shares (the "Class A Shares") which are entitled

to track the direct or indirect investment of the Company in Silizium Propco S.à r.l., a Luxembourg private limited liability
company (société à responsabilité limitée) having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, and
being registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 186795 (the "Class A
Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each; and,

- two hundred five thousand three hundred forty (205,340) class B shares (the "Class B Shares") which are entitled to

track the direct or indirect investment of the Company in RPTRE I S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company
(société à responsabilité limitée) having its registered office at 46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg and
being  registered  with  the Luxembourg  register  of commerce  and companies  under  number  B 140024 (the "Class  B
Investment") with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The Ordinary Shares, the Class A Shares and the Class B Shares are together referred to as the "Shares".
In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be

construed accordingly."

5.5. The share capital of the Company may be reduced through the repurchase and subsequent cancellation of all

the issued shares of one or more classes of shares (a "Share Redemption"). The Ordinary Shares cannot be redeemed.

Upon a Share Redemption becoming effective, the holders of the shares which are repurchased by the Company as

part of the Share Redemption (the "Redeemed Shares") will be paid the Redemption Price for each Redeemed Share.

In these Articles:
"Interim Accounts" are management accounts of the Company;
"Available Amount" equals: (W + X + Y) - Z where W, X, Y and Z are the following amounts taken from the Interim

Accounts without double counting:

"W" means the net profits of the Company including carried forward profits less any losses of the Company including

carried forward losses;

"X" means any freely distributable share premium and other freely distributable reserves of the Company other than

any premium included in Y and, for the avoidance of doubt, other than any share premium which only relates to shares
other than the Redeemed Shares;

"Y" means the amount paid up by way of par value and share premium on the Redeemed Shares;
"Z" means any sums to be placed into or retained in a non-distributable reserve pursuant to the requirements of law

or these Articles;

"Total Redemption Amount" is such amount as is determined by resolution of the Board of Managers and approved

by general meeting of the Shareholders, not exceeding the Available Amount;

"Redemption Price" equals the Total Redemption Amount divided by the total number of Redeemed Shares."

5967

L

U X E M B O U R G

15. Distributions on shares.
15.1 From the net profits of the Company determined in accordance with Luxembourg Law, five per cent shall be

deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the amount of the legal
reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

15.2 The Class A Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class A Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation to the Class A Investment (including
capital gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other
transfers of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management,
operation of the Class A Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to
dividend distribution)).

15.3 The Class B Shares are exclusively entitled to the assets related to the Class B Investment (including the balance

of all incomes, profits or other receipts paid or due in any other manner in relation the Class B Investment (including
capital gains, liquidation surplus and dividends distribution), minus the amount of the expenses, losses, taxes and other
transfers of funds incurred by the company and which can regularly and reasonably be attributed to the management,
operation of the Class B Investment (including fees, costs, corporate income tax on capital gain and expenses relating to
dividend distribution)).

15.4 All other distribution will be made to the holders of the Ordinary Shares.
15.5 The losses incurred by the Company in relation to one of its investments are subtracted from the amount attached

to the class of shares of such investment (whether profits, profits carried forward or the part representing the share
capital). If the losses exceed the amount attached to such class of shares, this excess will be borne by the other classes
of shares pro rata of their participation in the share capital. These provisions do not segregate the assets of the Company
into compartments enforceable in relation to third parties.

15.6 The Sole Manager or the Board of Managers as appropriate may decide to pay interim dividends to the Shareholder

(s) before the end of the financial year on the basis of a statement of accounts showing that sufficient funds are available
for distribution, it being understood that (i) the amount to be distributed may not exceed, where applicable, realised
profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased
by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established according to the 1915 Law or these
Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond to profits actually earned may be recovered
from the relevant Shareholder(s)."

<i>Costs and expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it

by reason of the present deed are assessed to three thousand Euro (EUR 3,000.-).

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in

English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will prevail.

Whereof, the present deed is drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder of the appearing party known to the notary by her name, first

name, civil status and residence, the proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français de ce qui précède:

L'an deux mille quatorze, le onze décembre.
Par-devant le soussigné Maître Jean SECKLER, notaire résidant à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

A COMPARU

OPCIMMO, une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable établie selon les lois de France,

ayant son siège social au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France, immatriculée auprès du registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le numéro 533 506 234 (l'"Associé Unique"),

ici représentée par Mr Henri DA CRUZ, clerc de notaire, demeurant professionnellement à Junglinster, en vertu d'une

procuration délivrée le 9 décembre 2014;

Ladite procuration signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera

attachée au présent acte pour être soumise avec lui aux autorités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante est l'associé unique de IMMO INVEST LUX HOLDCO S.à r.l., une société à responsabilité

limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365
Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
("RCS") sous le numéro B 186778, et constituée par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 16 avril 2014, dont
les statuts (les "Statuts") ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "Mémorial") numéro
1800, page 86372, en date du 10 juillet 2014 (la "Société"). Les Statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois
par un acte notarié du notaire soussigné, en date du 24 juillet 2014, publié au Mémorial numéro 2797, page 134253, en
date du 8 octobre 2014.

5968

L

U X E M B O U R G

La partie comparante, représentant l'ensemble du capital social requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes

prises conformément aux dispositions de l'article 200-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10
août 1915, telle que modifiée, selon lesquelles l'associé unique d'une société à responsabilité limitée exercera les pouvoirs
de l'assemblée générale des associés de la société et les décisions de l'associé unique seront documentées dans un procès
verbal ou rédigées par écrit:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide de créer de nouvelles catégories de parts représentant le capital social de la Société:
- les parts sociales ordinaires;
- les parts sociales de catégorie A qui financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans Silizium

Propco S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège
social au 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous
le numéro B 186795; et

- les parts sociales de catégorie B qui financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans RPTRE I

S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
46A, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le
numéro B 140024.

Seules les parts sociales de catégorie A et les parts sociales de catégorie B pourront être rachetées par la Société.

<i>Seconde résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quatre cent vingt-cinq mille sept

cent quarante euros (EUR 425.740,-), afin de le porter de son montant actuel de vingt-deux mille neuf cent cinquante
euros (EUR 22.950,-) à quatre cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 448.690,-) en créant et en
émettant deux cent vingt mille quatre cents (220.400) nouvelles parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale
d'un euro (EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales de
Catégorie A ayant les droits et obligations prévues par les Statuts et étant émises avec une prime d'émission d'une valeur
totale de un million neuf cent quatre-vingt-trois mille six cents euros (EUR 1.983.600,-); et en créant et en émettant deux
cent cinq mille trois cent quarante (205.340) nouvelles parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un euro
(EUR 1,-) chacune (les "Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales de Catégorie
B ayant les droits et obligations prévues par les Statuts et étant émises avec une prime d'émission d'une valeur totale de
un million huit cent quarante-huit mille cinquante-sept euros (EUR 1.848.057,-).

<i>Souscription et libération

Les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie A sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique par un apport

en numéraire de deux millions deux cent quatre mille euros (EUR 2.204.000,-) dont deux cent vingt mille quatre cents
euros (EUR 220.400,-) sont alloués au capital social de la Société et un million neuf cent quatre-vingt-trois mille six cents
euros (EUR 1.983.600) sont alloués au compte de primes d'émission.

Les Nouvelles Parts Sociales de Catégorie B sont souscrites et entièrement libérées par l'Associé Unique par un apport

en numéraire de deux millions cinquante-trois mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros (EUR 2.053.397,-) dont deux
cent cinq mille trois cent quarante euros (EUR 205.340,-) sont alloués au capital social de la Société et un million huit
cent quarante-huit mille cinquante-sept euros (EUR 1.848,057,-) sont alloués au compte de primes d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur des contributions ont été produites par devant le notaire instrumentant.

<i>Troisième résolution

Suite aux résolutions prises ci-dessus, l'Associé Unique décide que le capital social de la Société d'un montant de quatre

cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR 448.690,-) sera divisé comme suit:

- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") détenues par l'Associé;
- deux cent trente mille huit cent cinquante (230.850) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie

A"), détenues par l'Associé; et,

- deux cent cinq mille trois cent quarante (205.340) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"),

détenues par l'Associé,

chacune ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

<i>Quatrième résolution

En conséquence des résolutions ci-dessus, l'Associé Unique décide de modifier (i) l'article 5.1 des Statuts, (ii) l'article

5.5 des Statuts et (iii) l'article 15 des Statuts, qui se liront dorénavant comme suit:

5.1. Le capital social de la Société est fixé à quatre cent quarante-huit mille six cent quatre-vingt-dix euros (EUR

448.690,-) divisé en:

- douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ordinaires (les "Parts Sociales Ordinaires") ayant chacune une valeur

nominale d'un euro (EUR 1,-);

5969

L

U X E M B O U R G

- deux cent trente mille huit cent cinquante (230.850) parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie

A"): les Parts Sociales de Catégorie A financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans Silizium Propco
S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au
6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186795 (l' "Investissement de Catégorie A") ayant chacune une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-); et,

- deux cent cinq mille trois cent quarante (205.340) parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B"):

les Parts Sociales de Catégorie B financent des actifs spécifiques directs ou indirects de la Société dans RPTRE I S.à r.l.,
une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 46A,
Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Com-
merce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 140024 (l' "Investissement de Catégorie B") ayant chacune une
valeur nominale d'un euro (EUR 1,-).

Les Parts Sociales Ordinaires, Les Parts Sociales de Catégorie A et les Parts Sociales de Catégorie B sont ensemble

dénommées les "Parts Sociales".

Dans les présents Statuts, "Associés" signifie les détenteurs au moment pertinent des Parts Sociales et "Associé" doit

être interprété conformément."

5.5. Le capital social de la Société peut être réduit par le rachat et l'annulation de toutes les parts sociales d'une ou

de plusieurs catégories de Parts Sociales ("Rachat de Parts"). Les Parts Sociales Ordinaires ne peuvent pas être rachetées
par la Société.

Lorsque le Rachat de Parts sera effectif, les détenteurs des parts sociales rachetées par la Société dans le cadre du

Rachat de Parts (les "Parts Rachetées") auront droit au Prix de Rachat pour ces Parts Rachetées.

Dans ces Statuts:
Les "Comptes Intérimaires" sont les comptes préparés par le Conseil de Gérance de la Société.
Le "Montant Disponible" est égal à (W+X+Y)-Z où W, X, Y et Z sont équivalents aux montants suivants des Comptes

Intérimaires:

"W" signifie les profits nets de la Société y compris les profits reportés moins les pertes de la Société y compris les

pertes reportées.

"X" signifie la prime d'émission librement distribuable et autres réserves distribuables de la Société autres que celles

référées sous Y et, pour éviter tout doute, autres que la prime d'émission qui est relative aux Parts Rachetées.

"Y" signifie le montant payé par le biais de la valeur nominale et de la prime d'émission payée sur les Parts Rachetées.
"Z" signifie toutes les sommes placées dans des réserves non-distribuables en vertu de la loi ou de ces Statuts.
"Montant Total de Rachat" est le montant déterminé par une résolution du Conseil de Gérance et approuvée par

l'assemblée générale des Associés, qui ne dépasse pas le Montant Disponible.

"Prix de Rachat" est égal au Montant Total de Rachat divisé par le nombre total de Parts Rachetées.

15. Distributions sur les actions.
15.1 Du bénéfice net de la Société déterminé conformément au droit luxembourgeois, cinq pour cent seront déduits

et alloués à une réserve légale. Cette déduction cessera d'être obligatoire dès lors que ladite réserve légale atteint un
dixième du capital nominal de la Société.

15.2 Les Parts Sociales de Catégorie A donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie A

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société
en relation avec l'Investissement de Catégorie A (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui
peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Caté-
gorie A (y compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de
dividendes)).

15.3 Les Parts Sociales de Catégorie B donnent exclusivement droit aux actifs liés à l'Investissement de Catégorie B

(incluant le solde de tous les revenus, profits ou autres reçus payés ou dus de quelque manière que ce soit à la Société
en relation avec l'Investissement de Catégorie B (y compris les gains en capital, surplus à la liquidation et distribution de
dividendes), moins le montant des dépenses, pertes, impôts et autres transferts de fonds réalisés par la Société et qui
peuvent être régulièrement et raisonnablement attribués à la gestion et au fonctionnement de l'Investissement de Caté-
gorie B (y compris les honoraires, coûts, impôt sur les sociétés sur les gains et les dépenses relatives à la distribution de
dividendes)).

15.4 Toutes les autres distributions seront faites aux détenteurs de Parts Sociales Ordinaires.
15.5 Les pertes réalisées par la Société dans le cadre de l'un des investissements viennent d'abord en déduction des

sommes attachées à la catégorie de parts sociales (qu'il s'agisse de profits, profits reportés ou de la part représentant le
capital social) à laquelle cet investissement est rattaché. Si les pertes excèdent les sommes rattachées à la catégorie de
parts sociales en question, ces pertes excédentaires viendront greffer les autres catégories de parts au pro rata de leur

5970

L

U X E M B O U R G

participation dans le capital. Les présentes clauses ne créent pas une ségrégation des avoirs de la Société opposable aux
tiers.

15.6 Le Gérant Unique ou le Conseil de Gérance comme il convient le cas échéant peut décider de payer des dividendes

intérimaires à l'Associé/aux Associés avant la fin de l'exercice sur base d'un relevé de comptes indiquant que des fonds
suffisants sont disponibles pour une distribution, étant entendu que (i) le montant à distribuer ne peut dépasser, le cas
échéant, les bénéfices réalisés depuis la fin de l'exercice précédent, augmenté des bénéfices reportés et des réserves
distribuables, mais diminué par les pertes reportées et les montants à allouer à une réserve à établir d'après la Loi de
1915 ou les présents Statuts, et que (ii) toute somme distribuée qui ne correspond pas aux bénéfices effectivement réalisés
peut être récupérée auprès de l'Associé/des Associés concerné(s)."

<i>Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont

mis à sa charge en raison du présent acte, s'élèvent à environ trois mille Euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que le présent acte est rédigé

en langue anglaise, suivi d'une version française; à la requête de la partie comparante et en cas de divergences entre le
texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Fait et passé à Junglinster, à la date figurant en tête des présentes.
L'acte ayant été lu au mandataire de la partie comparante connu du notaire par son nom, prénom, statut civil et

résidence, le mandataire de la partie comparante a signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Henri DA CRUZ, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/4994. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014201699/302.
(140225883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1160 Luxembourg, 28, boulevard d'Avranches.

R.C.S. Luxembourg B 192.846.

STATUTES

In the year two thousand and fourteen, on the fourth day of the month of December;
Before the undersigned notary Carlo WERSANDT, residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg);

THERE APPEARED:

“Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”, a private limited liability company („Gesellschaft mit bes-

chränkter Haftung“)incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office
in L-1160  Luxembourg,  28,  Boulevard  d'Avranches,  registered with the  Luxembourg Trade  and Companies Registry
(„Handels- und Gesellschaftsregister“), section B, under number 117047,

here represented by Mrs. Christina MOURADIAN, employee, with professional address in L-1160 Luxembourg, 28,

Boulevard d'Avranches, by virtue of a proxy given under private seal; which proxy, after having been signed “ne varietur”
by the proxyholder and the officiating notary, will remain attached to the present deed in order to be recorded with it.

Such appearing party, represented as said before, requests the officiating notary to enact the articles of association of

a private limited liability company, („Gesellschaft mit beschränkter Haftung“), to establish as follows:

Chapter I. - Form, Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form - Corporate Name. There is formed a private limited liability company under the name “Goodman Arcadia

Logistics (Lux) S.à r.l.” which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the “Company”), and
in particular by the law of August 10 

th

 , 1915 on commercial companies as amended (hereafter the “Law”), as well as by

the present articles of incorporation (hereafter the “Articles”).

Art. 2. Registered Office. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City (Grand Duchy of

Luxembourg).

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraor-

dinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

However, the Sole Manager, or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company is authorised

to transfer the registered office of the Company within the City of Luxembourg.

Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent

the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily
transferred abroad until such time as the situation becomes normalised; such temporary measures will not have any effect

5971

L

U X E M B O U R G

on this  Company's  nationality,  which, notwithstanding  this temporary transfer  of the  registered office,  will remain  a
Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Sole Manager,
or in case of plurality of managers, the Board of Managers of the Company.

The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

Art. 3. Object. The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any

form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through par-
ticipation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way and namely to acquire
patents and licences, to manage and develop them. This includes direct or indirect investment in development or com-
mercial utilisation of property and real estate.

The Company may also enter into the following transactions:
- to borrow money in any form or to obtain any form of credit facility;
- to advance, lend or deposit money or give credit to its subsidiaries or companies in which it has a direct or indirect

interest, even not substantial, or any company being a direct or indirect shareholder of the Company or any company
belonging  to  the  same  group  as  the  Company  (hereafter  referred  to  as  the  “Connected  Companies”  and  each  as  a
“Connected Company”).

For purposes of this article, a company shall be deemed to be part of the same “group” as the Company if such other

company directly or indirectly owns, is in control of, is controlled by, or is under common control with, the Company,
in each case whether beneficially or as trustee, guardian or other fiduciary. A company shall be deemed to control another
company if the controlling company possesses, directly or indirectly, all or substantially all of the share capital of the
Company or has the power to direct or cause the direction of the management or policies of the other company, whether
through the ownership of voting securities, by contract or otherwise;

- to enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or

charge upon all or part of the undertaking, property assets (present or future) or by all or any of such methods, for any
assistance to the Connected Companies, within the limits of Luxembourg Law;

it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any

activity that would be considered as a banking activity.

The Company can perform all legal, commercial, technical and financial investments or operation and in general, all

transactions which are necessary to fulfil its object as well as all operations connected directly or indirectly to facilitating
the accomplishment of its object in all areas described above.

Art. 4. Duration. The Company is established for an unlimited duration.

Chapter II. - Capital, Shares

Art. 5. Share capital. The corporate capital is fixed at twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented

by twelve thousand five hundred (12,500) shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each.

The holders of the share(s) are referred to as the “Shareholders” and individually as a "Shareholder".
In addition to the corporate capital, there may be set up a premium account, into which any premium paid on any

share is transferred. The amount of said premium account is at the free disposal of the Shareholder(s).

All shares of the Company will have equal rights.
The Company can proceed to the repurchase of its own shares within the limits set by the Law.

Art. 6. Shares indivisibility. Towards the Company, the Company’s shares are indivisible, since only one owner is

admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

Art. 7. Transfer of Shares. In case of a single Shareholder, the Company’s Share held by the single Shareholder are

freely transferable.

In case of plurality of Shareholders, the share(s) held by each Shareholder may be transferred by application of the

requirements of articles 189 and 190 of the Law.

Chapter III. - Management

Art. 8. Management. The Company is managed by one or more manager(s) appointed by a resolution of the shareholder

(s). In case of one manager, she/he/it will be referred to as the “Sole Manager”. In case of plurality of managers, they will
constitute a board of managers (“conseil de gérance”) (hereafter referred to as the “Board of Managers”).

The managers need not to be shareholders. The managers may be removed at any time, with or without cause by a

resolution of the shareholder(s).

Art. 9. Powers of the sole manager or of the Board of Managers. In dealing with third parties, the Sole Manager or, in

case of plurality of managers, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all
circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company’s objects and provided
the terms of this article shall have been complied with.

5972

L

U X E M B O U R G

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of Shareholders fall within

the competence of the Sole Manager or in case of plurality of managers, of the Board of Managers.

Art. 10. Representation of the Company. Towards third parties, the Company shall be, in case of a Sole Manager,

bound by the sole signature of the Sole Manager or, in case of plurality of managers, by the joint signature of any two
managers or by the signature of any person to whom such power shall be delegated, in case of a Sole Manager, by the
Sole Manager or, in case of plurality of managers, by any two managers.

Art. 11. Delegation and Agent of the sole manager or of the Board of Managers. The Sole Manager or, in case of

plurality of managers, the Board of Managers may delegate its powers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

The Sole Manager or, in case of plurality of managers, the Board of Managers will determine any such agent’s respon-

sibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of its
agency.

Art. 12. Meeting of the Board of Managers. In case of plurality of managers, the meetings of the Board of Managers

are convened by any manager. The Board of Managers shall appoint a chairman.

The Board of Managers may validly debate and take decisions without prior notice if all the managers are present or

represented and have waived the convening requirements and formalities.

Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by telegram or telefax or

e-mail or letter another Manager as his proxy. A Manager may also appoint another Manager to represent him by phone
to be confirmed in writing at a later stage.

The Board of Managers can only validly debate and take decisions if a majority of its members is present or represented.

Decisions of the Board of Managers shall be adopted by a simple majority.

The use of video-conferencing equipment and conference call shall be allowed provided that each participating Manager

is  able  to  hear  and  to  be  heard  by  all  other  participating  managers  whether  or  not  using  this  technology,  and  each
participating Manager shall be deemed to be present and shall be authorised to vote by video or by telephone.

A written decision, signed by all the managers, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the

Board of Managers, which was duly convened and held. Such a decision can be documented in a single document or in
several separate documents having the same content signed by all the members of the Board of Managers.

The minutes of any meeting of the Board of Managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by two

managers.

Extracts shall be certified by any Manager or by any person nominated by any Manager or during a meeting of the

Board of Managers.

Chapter IV. - General meeting of shareholders

Art. 13. Powers of the general meeting of shareholder(s) - Votes. If there is only one Shareholder, that sole Shareholder

assumes all powers conferred to the general Shareholders’ meeting and takes the decisions in writing.

In case of a plurality of Shareholders, each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number

of Shares, which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. All Shares have equal
voting rights.

If all the shareholders are present or represented they can waive any convening formalities and the meeting can be

validly held without prior notice.

If there are more than twenty-five Shareholders, the Shareholders’ decisions have to be taken at meetings to be

convened in accordance with the applicable legal provisions.

If there are less than twenty-five Shareholders, each Shareholder may receive the text of the decisions to be taken

and cast its vote in writing.

A Shareholder may be represented at a Shareholders’ meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any

similar means) an attorney who need not be a Shareholder.

Collective decisions are only validly taken insofar as Shareholders owning more than half of the share capital adopt

them. However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority (in number) of the Shareholders
owning at least three-quarters of the Company’s Share capital, subject to any other provisions of the Law. Change of
nationality of the Company requires unanimity.

Chapter V. - Business year

Art. 14. Business year. The Company’s financial year starts on the 1 

st

 January and ends on the 31 

st

 December of each

year.

At the end of each financial year, the Company’s accounts are established by the Sole Manager or in case of plurality

of managers, by the Board of Managers and the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers
prepares an inventory including an indication of the value of the Company’s assets and liabilities.

Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company’s registered office.

5973

L

U X E M B O U R G

Art. 15. Distribution Right of Shares. From the net profits determined in accordance with the applicable legal provisions,

five per cent shall be deducted and allocated to a legal reserve fund. That deduction will cease to be mandatory when the
amount of the legal reserve fund reaches one tenth of the Company's nominal capital.

To the extent that funds are available at the level of the Company for distribution and to the extent permitted by law

and by these Articles, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers shall propose that cash
available for remittance be distributed.

The decision to distribute funds and the determination of the amount of such distribution will be taken by the Share-

holders in accordance with the provisions of Article 13.7 above.

Notwithstanding the preceding provisions, the Sole Manager or in case of plurality of managers, the Board of Managers

may decide to pay interim dividends to the shareholder(s) before the end of the financial year on the basis of a statement
of accounts showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that (i) the amount to be
distributed may not exceed, where applicable, realised profits since the end of the last financial year, increased by carried
forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve
to be established according to the Law or these Articles and that (ii) any such distributed sums which do not correspond
to profits actually earned shall be reimbursed by the shareholder(s).

Chapter VI. - Liquidation

Art. 16. Dissolution and Liquidation. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil

rights, insolvency or bankruptcy of the single Shareholder or of one of the Shareholders.

The liquidation of the Company shall be decided by the Shareholders’ meeting in accordance with the applicable legal

provisions.

The liquidation will be carried out by one or several liquidators, Shareholders or not, appointed by the Shareholders

who shall determine their powers and remuneration.

Chapter VII. - Applicable law

Art. 17. Applicable law. Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision

is made in these Articles.

<i>Transitory provisions

The first accounting year shall begin on the date of the incorporation of the Company and shall terminate on December

31, 2014.

<i>Subscription - Payment

All the shares of the Company have been subscribed by “Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR”,

previously named.

The shares have been fully paid up, so that the sum of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) is forthwith

at the free disposal of the Company, as has been proved to the notary.

<i>Costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately one thousand Euros.

<i>Decisions taken by the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the Company, the aforementioned appearing party, representing the whole of

the subscribed share capital, has adopted the following resolutions as sole shareholder:

1) Are appointed as Managers of the Company for an undetermined duration:
- Mr. Philippe VAN DER BEKEN, employee, born on 1 October 1975 in Aalst (Belgium), with professional address in

L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d’Avranches; and

- Mr. Dominique PRINCE, employee, born on 29 October 1978 in Malmedy (Belgium), with professional address in

L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d’Avranches.

Mr. Dominique PRINCE is appointed Chairman of the Board of Managers.
2) The Company shall have its registered office in L-1160 Luxembourg, 28, Boulevard d’Avranches (Grand Duchy of

Luxembourg).

<i>Statement

The undersigned notary, who understands and speaks English and German, states herewith that, on request of the

above appearing party, the present deed is worded in English followed by a German version; on request of the same
appearing party, and in case of discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day stated at the beginning.

5974

L

U X E M B O U R G

The deed having been read to the proxy-holder of appearing party, known to the notary by his first and last name,

civil status and residence, the said proxy-holder has signed with Us, the notary, the present deed.

Es folgt die deutsche Fassung des vorstehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am vierten Tag des Monats Dezember;
Vor dem unterzeichneten Notar Carlo WERSANDT, mit dem Amtssitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg);

IST ERSCHIENEN:

„Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR“, eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg

gegründete und bestehende Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d'Av-
ranches, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg, Sektion B, unter der Nummer 117047,

hier vertreten durch Frau Christina MOURADIAN, Angestellte, mit Berufsanschrift in L-1160 Luxemburg, 28, Boule-

vard d'Avranches, auf Grund einer ihr erteilten Vollmacht unter Privatschrift; welche Vollmacht von der Bevollmächtigten
und dem amtierenden Notar „ne varietur“ unterschrieben, bleibt der gegenwärtigen Urkunde beigebogen, um mit der-
selben einregistriert zu werden.

Welche erschienene Partei, vertreten wie hiervor erwähnt, den amtierenden Notar ersucht, die Statuten einer zu

gründenden Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beurkunden wie folgt:

Kapitel I. - Form, Name, Sitz, Gegenstand, Dauer

Art. 1. Form - Name der Gesellschaft. Es wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter dem Namen „Good-

man Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.“ errichtet, welche den Gesetzen, die für ein solches Unternehmen (im Folgenden die
„Gesellschaft“) gelten, und insbesondere dem Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geän-
derten Fassung (im Folgenden das „Gesetz“) sowie der vorliegenden Satzung (im Folgenden die „Satzung“) unterliegt.

Art. 2. Sitz der Gesellschaft. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Luxemburg-Stadt, (Großherzogtum Luxemburg).
Er kann durch Beschluss einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschafter in Übereinstimmung mit den

Bestimmungen für Satzungsänderungen an einen anderen Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.

Es kann jedoch der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat der Ge-

sellschaft den Gesellschaftssitz innerhalb von Luxemburg-Stadt verlegen.

Sollte eine militärische, politische, wirtschaftliche oder soziale Situation entstehen oder unmittelbar bevorstehen, wel-

che  den  gewöhnlichen  Geschäftsverlauf  der  Gesellschaft  an  ihrem  Sitz  beeinträchtigen  würde,  so  kann  der  Sitz  der
Gesellschaft zeitweilig und bis zur Normalisierung der Lage ins Ausland verlagert werden; diese provisorische Maßnahme
hat jedoch keine Auswirkung auf die Staatszugehörigkeit dieser Gesellschaft, die ungeachtet dieser zeitweiligen Verlegung
des Sitzes eine luxemburgische Gesellschaft bleibt. Der Beschluss hinsichtlich einer Verlegung des Gesellschaftssitzes ins
Ausland wird durch den Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch den Geschäftsführerrat
der Gesellschaft getroffen.

Die Gesellschaft kann Büros und Niederlassungen sowohl im Großherzogtum Luxemburg als auch im Ausland haben.

Art. 3. Gegenstand. Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und die Veräußerung von

Beteiligungen in jedweder Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wert-
papieren, Rechten und Vermögenswerten durch Beteiligung, Einlage, Festübernahme oder Kaufoption, Verhandlung oder
auf sonstige Weise und insbesondere der Erwerb von Patenten und Lizenzen und ihre Verwaltung und Entwicklung. Dies
beinhaltet ebenfalls die direkte oder indirekte Anlage in die Entwicklung oder wirtschaftliche Nutzung von Grundbesitz
und Immobilien.

Die Gesellschaft darf ebenfalls die folgenden Geschäfte ausführen:
- die Aufnahme von Darlehen oder Krediten in jedweder Form;
- die Leistung bzw. Vergabe von Vorschüssen, Darlehen, Einlagen oder Krediten an ihre Tochtergesellschaften oder

sonstige Gesellschaften, an denen sie eine direkte oder indirekte, auch unwesentliche, Beteiligung hält, oder an jedwedes
sonstige Unternehmen, das ein direkter oder indirekter Gesellschafter der Gesellschaft ist oder zur selben Gruppe wie
die Gesellschaft gehört (im Folgenden die „verbundenen Gesellschaften“ sowie einzeln eine „verbundene Gesellschaft“).

Für die Zwecke des vorliegenden Artikels gilt ein Unternehmen dann als Teil derselben „Gruppe” wie die Gesellschaft,

wenn es direkt oder indirekt das Eigentum an der Gesellschaft besitzt, sie kontrolliert oder von ihr oder gemeinsam mit
ihr kontrolliert wird, egal ob als wirtschaftlich Berechtigter oder als Verwalter, als Vormund oder als sonstiger Treuhän-
der. Ein Unternehmen gilt als beherrschendes Unternehmen, wenn es direkt oder indirekt das Eigentum am Stammkapital
der Gesellschaft vollständig oder wesentlich besitzt oder die Befugnis hat, die Geschäftsleitung oder Geschäftspolitik des
anderen Unternehmens zu führen oder maßgeblich zu beeinflussen, sei es durch das Eigentum stimmberechtigter Wert-
papiere, einen Vertrag oder auf sonstige Weise;

- die Stellung von Garantien, Bürgschaften oder sonstigen Sicherheiten, egal ob durch persönliche Verpflichtung oder

durch Hypothek oder durch Belastung des gesamten oder eines Teils des Unternehmens, der (aktuellen oder künftigen)
Vermögenswerte oder durch alle diese Methoden, zur Erfüllung aller Verträge oder Verpflichtungen der Gesellschaft oder

5975

L

U X E M B O U R G

verbundener Gesellschaften, sowie jedwede Hilfeleistung an die verbundenen Gesellschaften im Rahmen des luxembur-
gischen Gesetzes;

dabei gilt, dass die Gesellschaft keine Geschäfte ausführen darf, die dazu führen würden, dass sie in einem Bereich tätig

wäre, der als Bankaktivität zu betrachten wäre.

Die Gesellschaft kann alle rechtlichen, wirtschaftlichen, technischen und finanziellen Anlagen oder Geschäfte sowie

generell alle Transaktionen ausführen, die zur Erfüllung ihres Zweckes erforderlich sind, sowie alle Tätigkeiten, die direkt
oder indirekt mit der Erleichterung der Erzielung des Zweckes in allen oben beschriebenen Bereichen verbunden ist.

Art. 4. Dauer. Die Gesellschaft ist auf unbestimmte Zeit errichtet.

Kapitel II. - Kapital, Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital. Das Gesellschaftskapital beträgt zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) und ist in

zwölftausendfünfhundert (12.500) Anteile mit einem Nennwert von jeweils einem Euro (1,- EUR) aufgeteilt.

Die Inhaber der Anteile werden als „Gesellschafter” bezeichnet.
Zusätzlich zum Gesellschaftskapital kann ein Agiokonto eingerichtet werden, in welches der auf einen Anteil bezahlte

Ausgabeaufschlag eingestellt wird. Der Betrag auf dem genannten Agiokonto steht den Gesellschaftern zur freien Verfü-
gung.

Alle Anteile der Gesellschaft beinhalten die gleichen Rechte.
Die Gesellschaft darf die eigenen Anteile im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zurückkaufen.

Art. 6. Unteilbarkeit der Anteile. Gegenüber der Gesellschaft sind die Anteile der Gesellschaft unteilbar, da nur ein

Eigentümer pro Anteil zugelassen ist. Gemeinsame Miteigentümer müssen eine einzige Person zu ihrem Vertreter ge-
genüber der Gesellschaft bestimmen.

Art. 7. Übertragung von Anteilen. Im Falle eines alleinigen Gesellschafters ist der Gesellschaftsanteil, den der Allein-

gesellschafter hält, frei übertragbar.

Gibt es mehrere Gesellschafter, sind die Gesellschaftsanteile der einzelnen Gesellschafter gemäß den Bestimmungen

von Artikel 189 und 190 des Gesetzes übertragbar.

Kapitel III. - Management

Art. 8. Geschäftsführung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die durch Beschluss der Gesell-

schafter bestellt werden. Gibt es nur einen Geschäftsführer, so wird dieser als der „Alleingeschäftsführer“ bezeichnet.
Gibt es mehrere Geschäftsführer, bilden sie einen Geschäftsführerrat („conseil de gérance“) (im Folgenden der „Ge-
schäftsführerrat“).

Die Geschäftsführer brauchen keine Gesellschafter zu sein. Die Geschäftsführer können jederzeit mit oder ohne Grund

durch Gesellschafterbeschluss abgesetzt werden.

Art. 9. Befugnisse des Alleingeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats.  Gegenüber  Dritten  hat  der  Alleinge-

schäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat unbeschränkte Vollmacht, unter allen
Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und jegliche Tätigkeiten und Geschäfte durchzuführen und zu geneh-
migen, die mit dem Gegenstand der Gesellschaft in Einklang stehen, sofern die Bedingungen des vorliegenden Artikels
erfüllt sind.

Sämtliche Befugnisse, welche nicht ausdrücklich per Gesetz oder durch die vorliegenden Satzung der Gesellschafter-

versammlung  vorbehalten  sind,  fallen  in  den  Zuständigkeitsbereich  des  Alleingeschäftsführers  oder,  falls  es  mehrere
Geschäftsführer gibt, des Geschäftsführerrats.

Art. 10. Vertretung der Gesellschaft. Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft im Falle eines Alleingeschäftsführers

durch dessen alleinige Unterschrift oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, durch die gemeinsame Unterschrift zweier
Geschäftsführer oder durch die Unterschrift einer vom Alleingeschäftsführer bzw. den beiden Geschäftsführern hierzu
zu ermächtigenden Person verpflichtet.

Art. 11. Übertragung von Befugnissen und Vertretung des Alleingeschäftsführers oder des Geschäftsführerrats. Der

Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat kann für spezifische Aufgaben
einem oder mehreren Ad-hoc-Vertretern Vollmachten erteilen.

Der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat legt die Verantwort-

lichkeiten und ggf. die Entlohnung eines solchen Vertreters, die Dauer des Vertretungszeitraums und andere maßgebliche
Bedingungen dieser Vertretung fest.

Art. 12. Sitzung des Geschäftsführerrats. Gibt es mehrere Geschäftsführer, so werden die Sitzungen des Geschäfts-

führerrats durch einen (beliebigen) Geschäftsführer einberufen. Der Geschäftsführerrat bestimmt einen Vorsitzenden.

Wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und auf die Formen und Fristen der Einberufung verzichtet

haben, kann der Geschäftsführerrat ohne vorherige Einberufung wirksam tagen und Beschlüsse fassen.

5976

L

U X E M B O U R G

Jeder Geschäftsführer kann einen anderen Geschäftsführer schriftlich, durch Telegramm, Telefax, E-Mail oder Brief zu

seinem  Stellvertreter  auf  einer  Geschäftsführerratssitzung  bestimmen.  Ein  Geschäftsführer  kann  einen  anderen  Ge-
schäftsführer auch telefonisch zu seinem Stellvertreter bestimmen, wobei dies später schriftlich zu bestätigen ist.

Der Geschäftsführerrat kann nur dann wirksam tagen und Beschlüsse fassen, wenn eine Mehrheit seiner Mitglieder

anwesend oder vertreten ist. Beschlüsse des Geschäftsführerrats gelten mit einfacher Mehrheit als angenommen.

Geschäftsführerratssitzungen können per Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden, sofern jeder teilnehmen-

de Geschäftsführer alle anderen teilnehmenden Geschäftsführer hören und von ihnen gehört werden kann, unabhängig
davon, ob sie diese Technologie verwenden oder nicht, und dabei gilt jeder teilnehmende Geschäftsführer als anwesend
und ist berechtigt, per Video oder Telefon abzustimmen.

Ein schriftlicher Beschluss mit der Unterschrift aller Geschäftsführer ist ebenso zulässig und wirksam, als wäre er bei

einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Geschäftsführerratssitzung angenommen worden. Ein solcher Be-
schluss  kann  in  einem  einzigen  oder  in  mehreren  separaten  Dokumenten  desselben  Inhalts  mit  Unterschrift  aller
Geschäftsführerratsmitglieder dokumentiert werden.

Die Protokolle aller Sitzungen des Geschäftsführerrats sind vom Vorsitzenden oder in seiner Abwesenheit von zwei

Geschäftsführern zu unterzeichnen.

Auszüge sind von einem Geschäftsführer oder einer von einem Geschäftsführer oder während einer Geschäftsfüh-

rerratssitzung dazu bestimmten Person zu beglaubigen.

Kapitel IV. - Gesellschafterversammlung

Art. 13. Befugnisse der Gesellschafterversammlung - Stimmrecht. Gibt es nur einen Gesellschafter, so übt der Allein-

gesellschafter sämtliche Befugnisse der Gesellschafterversammlung aus und hält die Beschlüsse schriftlich fest.

Gibt es mehrere Gesellschafter, kann sich jeder Gesellschafter, unabhängig von der Anzahl der von ihm gehaltenen

Geschäftsanteile, an gemeinsamen Beschlüssen beteiligen. Das Stimmrecht der Gesellschafter steht dabei im Verhältnis
zu ihrem Anteilbestand. Alle Anteile beinhalten die gleichen Stimmrechte.

Sofern alle Gesellschafter anwesend oder vertreten sind, können sie unter Verzicht auf Formen und Fristen der Ein-

berufung ohne vorherige Einberufung wirksam tagen.

Gibt es mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter, sind die Gesellschafterbeschlüsse bei Gesellschafterversammlungen

zu fassen, die unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einzuberufen sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, kann jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse

erhalten und seine Stimme schriftlich abgeben.

Ein Gesellschafter kann sich auf einer Gesellschafterversammlung vertreten lassen, indem er schriftlich (oder per Fax

oder E-Mail oder auf ähnliche Weise) einen Bevollmächtigten bestimmt, der kein Gesellschafter zu sein braucht.

Gemeinsame Beschlüsse gelten nur als wirksam gefasst, wenn die Gesellschafter, die sie annehmen, mehr als der Hälfte

des Stammkapitals besitzen. Beschlüsse zur Änderung der Satzung können jedoch nur mit der (zahlenmäßigen) Mehrheit
der Gesellschafter verabschiedet werden, die über mindestens drei Viertel des Stammkapitals der Gesellschaft verfügen,
und gemäß allen sonstigen gesetzlichen Bestimmungen. Der Beschluss zur Änderung der Staatszugehörigkeit der Gesell-
schaft kann nur einstimmig gefasst werden.

Kapitel V. - Geschäftsjahr

Art. 14. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt jeweils am 1. Januar und endet am 31. Dezember

desselben Jahres.

Zum Ende des Geschäftsjahres erstellt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Ge-

schäftsführerrat den Jahresabschluss sowie ein Inventar mit Bewertung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft.

Jeder Gesellschafter kann am Sitz der Gesellschaft Einsicht in das oben genannte Inventar und die Bilanz nehmen.

Art. 15. Ausschüttungsrechte der Anteile. Von dem gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen ermittelten

Reingewinn werden fünf Prozent der gesetzlichen Rücklage zugewiesen. Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn
der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des Nennkapitals der Gesellschaft erreicht hat.

Soweit auf Gesellschaftsebene Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind und soweit nach Gesetz und Satzung zulässig,

schlägt der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer gibt, der Geschäftsführerrat vor, dass diese Be-
träge ausgeschüttet werden.

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung sowie die Festlegung der Höhe einer solchen erfolgt durch die Gesell-

schafter gemäß den oben in Artikel 13.7 ausgeführten Bestimmungen.

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen kann der Alleingeschäftsführer oder, falls es mehrere Geschäftsführer

gibt, der Geschäftsführerrat beschließen, an die Gesellschafter vor Ende des Geschäftsjahres auf der Grundlage eines
Rechenschaftsberichts, aus dem hervorgeht, dass genügend Mittel zur Ausschüttung verfügbar sind, Zwischendividenden
zu zahlen, wobei gilt, dass (i) der auszuschüttende Betrag ggf. die seit Ende des letzten Geschäftsjahres erzielten Gewinne,
zuzüglich der Gewinnvorträge und der ausschüttungsfähigen Rücklagen, jedoch abzüglich der Verlustvorträge und der
Beträge, die einer gemäß dem Gesetz bzw. der vorliegenden Satzung einzurichtenden Rücklage zuzuweisen sind, nicht

5977

L

U X E M B O U R G

übersteigen darf, und dass (ii) Ausschüttungen, die nicht den tatsächlich erzielten Gewinnen entsprechen, von den Ge-
sellschaftern zurückzuzahlen sind.

Kapitel VI. - Liquidation

Art. 16. Auflösung und Liquidation. Die Gesellschaft wird nicht aufgrund des Todes, des Verlusts der bürgerlichen

Rechte, der Insolvenz oder des Konkurses des Alleingesellschafters oder eines der Gesellschafter aufgelöst.

Die Liquidation der Gesellschaft ist von der Gesellschafterversammlung in Übereinstimmung mit den geltenden ge-

setzlichen Bestimmungen zu beschließen.

Die Liquidation wird von einem oder mehreren Liquidator(en) durchgeführt, Gesellschafter oder nicht, der/die von

den Gesellschaftern benannt wird/werden und dessen/deren Befugnisse und Entlohnung von den Gesellschaftern festlegt
werden.

Kapitel VII. - Anzuwendende Rechtsvorschriften

Art. 17. Geltendes Recht. In allen Angelegenheiten, für welche in der vorliegenden Satzung keine spezifischen Vor-

kehrungen getroffen wurden, wird auf die Bestimmungen des Gesetzes verwiesen.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit dem Datum der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2014.

<i>Zeichnung - Einzahlung

Alle Anteile der Gesellschaft wurden von der vorgenannten „Goodman Property Opportunities (Lux) S.à r.l., SICAR“

gezeichnet.

Die Anteile sind vollständig bezahlt, sodass die Summe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) ab sofort

zur freien Verfügung der Gesellschaft steht, wie dem Notar nachgewiesen wurde.

<i>Kosten

Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen, unter welcher Form auch immer, welche der

Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen und für die sie haftet, wird auf ungefähr tausend Euro abgeschätzt.

<i>Beschlussfassung der Alleinigen Gesellschafterin

Unverzüglich nach der Gründung der Gesellschaft, hat hiervor erwähnte Partei, welche das gesamte gezeichnete Ge-

sellschaftskapital vertritt, als Alleingesellschafterin folgende Beschlüsse gefasst:

1) Es werden für eine unbestimmte Dauer zu Geschäftsführern der Gesellschaft bestellt:
- Herr Philippe VAN DER BEKEN, Angestellter, geboren am 1. Oktober 1975 in Aalst (Belgien), mit Berufsanschrift

in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches; und

- Herr Dominique PRINCE, Angestellter, geboren am 29. Oktober 1978 in Malmédy (Belgien), mit Berufsanschrift in

L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches.

Herr Dominique PRINCE wird zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrats bestimmt.
2) Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1160 Luxemburg, 28, Boulevard d’Avranches (Großherzogtum Luxem-

burg).

<i>Erklärung

Der unterzeichnete Notar, der Englisch und Deutsch versteht und spricht, erklärt hiermit, dass, auf Wunsch der

erschienenen Partei, die vorliegende Urkunde in Englisch abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Fassung; auf Ersuchen
derselben erschienenen Partei, und im Falle von Divergenzen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, wird
die englische Fassung maßgeblich sein.

WORÜBER die vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg, an dem anfangs oben angegebenen Tag, erstellt wurde.
Und nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte der erschienenen Partei, dem instrumentierenden

Notar nach Vor- und Zunamen, Personenstand und Wohnort bekannt, hat dieselbe Bevollmächtigte mit Uns, dem Notar,
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Signé: C. MOURADIAN, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/58963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201632/407.
(140225950) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

5978

L

U X E M B O U R G

Holding Blanc Bleu 5 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.

R.C.S. Luxembourg B 190.285.

In the year two thousand and fourteen, on the twelfth of November.
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing at Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

Is held

an Extraordinary General Meeting of the shareholders of „Holding Blanc Bleu 5 S.à r.l.“, a société à responsabilité

limitée (limited liability company), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered
with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B 190.285, incorporated
pursuant to a deed of the undersigned notary, dated August 27 

th

 , 2014, not yet published with the Mémorial C, Recueil

des Sociétés et Associations.

The meeting is presided by Mrs Corinne PETIT, employee, residing professionally at 74, avenue Victor Hugo.
The chairman appoints as secretary Mrs Marilyn KRECKE, employee, with same professional address.
The meeting elects as scrutineer Mrs Corinne PETIT, prenamed.
The chairman declares the meeting open and requests the notary to act that:
I. The shareholders represented and the shares held by them are indicated on an attendance list (the „Shareholders“).

This list and the proxy signed “ne varietur” by the Chairman and the notary is being attached to the present notarial deed
in order to be filed with it.

II. The attendance list shows that out of 12,500,000 (twelve million five hundred thousand) shares of the Company, all

the 12,500,000 (twelve million five hundred thousand) shares, representing 100% of the total share capital of the Company,
are represented at the present extraordinary general meeting and that thus the general meeting has been duly constituted
and may validly decide on the items figuring on the agenda of which the Shareholders had been informed beforehand.

III. The Shareholders declare that they consider themselves as having been duly convoked and informed of the agenda

and that they waive the compliance with any convocation formalities, i.e. especially the convocation by registered letter.

IV. The Shareholders declare that the agenda of the general meeting is as follows:

<i>Agenda

1. Increase of the share capital by an amount of EUR 32,320 (thirty-two thousand three hundred twenty euro) to bring

it from its current amount of EUR 125,000 (one hundred twenty five thousand euro) up to an amount of EUR 157,320
(one hundred fifty-seven thousand three hundred twenty euro) through the creation of 323,200 (three hundred twenty-
three thousand two hundred) Class A ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred)
Class B ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class C ordinary shares, 323,200
(three hundred twenty-three thousand two hundred) Class D ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three
thousand two hundred) Class E ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class F
ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class G ordinary shares, 323,200 (three
hundred twenty-three thousand two hundred) Class H ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand
two hundred) Class I ordinary shares and 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class J ordinary
shares; all ordinary shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent euro) each,

2. Subsequent amendment of article 8 of the Articles of Incorporation.
3. Miscellaneous.
The chairman thereupon exposes the reasons that led the Board of Managers to present this agenda to the partners.
After discussion, the General Meeting adopts the following resolutions:

<i>First resolution

The Shareholders resolve to increase the share capital by an amount of EUR 32,320 (thirty-two thousand three hundred

twenty euro) to bring it from its current amount of EUR 125,000 (one hundred twenty-five thousand euro) up to an
amount of EUR 157,320 (one hundred fifty-seven thousand three hundred twenty euro) through the creation of 323,200
(three hundred twenty-three thousand two hundred) Class A ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three
thousand two hundred) Class B ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class C
ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class D ordinary shares, 323,200 (three
hundred twenty-three thousand two hundred) Class E ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand
two hundred) Class F ordinary shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class G ordinary
shares, 323,200 (three hundred twenty-three thousand two hundred) Class H ordinary shares, 323,200 (three hundred
twenty-three thousand two hundred) Class I ordinary shares and 323,200 (three hundred twenty-three thousand two
hundred) Class J ordinary shares; all ordinary shares having a nominal value of EUR 0,01 (one cent euro) each.

5979

L

U X E M B O U R G

<i>Renouncement, Subscription and payment

One of the actual three (3) Shareholders “Special Situations Venture Partners III, LP” expressively renounced to its

subscription right.

Therefore the newly issued shares have been subscribed as follows:
- 18 (eighteen) Class A ordinary shares, 18 (eighteen) Class B ordinary shares, 18 (eighteen) Class C ordinary shares,

18 (eighteen) Class D ordinary shares, 18 (eighteen) Class E ordinary shares, 18 (eighteen) Class F ordinary shares, 18
(eighteen) Class G ordinary shares, 18 (eighteen) Class H ordinary shares, 18 (eighteen) Class I ordinary shares and 18
(eighteen) Class J ordinary shares have been subscribed by Special Situations Venture Partners III Structured, LP, for an
aggregate subscription price of EUR 1.80 (one euro and eighty cents) and are entirely allocated to the share capital.

The shares so subscribed have been paid up by the above mentioned subscriber through a contribution in cash of EUR

1.80 (one euro and eighty cents) such contribution in cash is as of now at the disposal of the Company, as it has been
proved to the undersigned notary.

- 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class A ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine hundred

forty-five) Class B ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class C ordinary shares, 15,945
(fifteen thousand nine hundred forty-five) Class D ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class
E ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class F ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine
hundred forty-five) Class G ordinary shares, 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class H ordinary shares,
15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-five) Class I ordinary shares and 15,945 (fifteen thousand nine hundred forty-
five) Class J ordinary shares have been subscribed by Kieran Investment GmbH &amp; Co. KG, for an aggregate subscription
price of EUR 1,594.50 (one thousand five hundred ninety-four euro and fifty cents) and are entirely allocated to the share
capital.

The shares so subscribed have been paid up by the above mentioned subscriber through a contribution in cash of EUR

1,594.50 (one thousand five hundred ninety-four euro and fifty cents) such contribution in cash is as of now at the disposal
of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

- 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred nineteen) Class A ordinary shares, 230,119 (two hundred thirty

thousand one hundred nineteen) Class B ordinary shares, 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred nineteen)
Class C ordinary shares, 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred nineteen) Class D ordinary shares, 230,119
(two hundred thirty thousand one hundred nineteen) Class E ordinary shares, 230,119 (two hundred thirty thousand one
hundred nineteen) Class F ordinary shares, 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred nineteen) Class G ordinary
shares, 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred nineteen) Class H ordinary shares, 230,119 (two hundred
thirty thousand one hundred nineteen) Class I ordinary shares and 230,119 (two hundred thirty thousand one hundred
nineteen) Class J ordinary shares have been subscribed by Phileas Investment GmbH &amp; Co. KG, a company incorporated
under the laws of Germany, having its registered office at Südliche Münchner Straße 8, D-82031 Grünwald and registered
with the “Amtsgericht München” under number 98104,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal in

Germany on November 10 

th

 , 2014,

for an aggregate subscription price of EUR 23,011.90 (twenty-three thousand eleven euro and ninety cents) and are

entirely allocated to the share capital.

The shares so subscribed have been paid up by the above mentioned subscriber through a contribution in cash of EUR

23,011.90 (twenty-three thousand eleven euro and ninety cents) such contribution in cash is as of now at the disposal of
the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

- 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class A ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five

hundred fifty-nine) Class B ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class C ordinary shares,
38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class D ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred
fifty-nine) Class E ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class F ordinary shares, 38,559
(thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class G ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-
nine) Class H ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class I ordinary shares and 38,559
(thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class J ordinary shares have been subscribed by Bjurbom Invest AB (formerly
Fundamendet 2174 AB), a company incorporated under the laws of Sweden, having its registered office at Box 2046,
SE-640 02 Karlstad, Sweden and registered under number 556984-1371,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal in Sweden

on November 11 

th

 , 2014,

for an aggregate subscription price of EUR 3,855.90 (three thousand eight hundred fifty-five euro and ninety cents)

and are entirely allocated to the share capital.

The shares so subscribed have been paid up by the above mentioned subscriber through a contribution in cash of

3,855.90 (three thousand eight hundred fifty-five euro and ninety cents) such contribution in cash is as of now at the
disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

- 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class A ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five

hundred fifty-nine) Class B ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class C ordinary shares,

5980

L

U X E M B O U R G

38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class D ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred
fifty-nine) Class E ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class F ordinary shares, 38,559
(thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class G ordinary shares, 38,5+50+59 (thirty-eight thousand five hundred
fifty-nine) Class H ordinary shares, 38,559 (thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class I ordinary shares and 38,559
(thirty-eight thousand five hundred fifty-nine) Class J ordinary shares have been subscribed by Mr Lars ROSEN, born on
April 20 

th

 , 1965 in Sundsvall (Sweden), residing at Gränsgatan 2, SE-654 64 Karlstad, Sweden,

here represented by Mrs Corinne PETIT, prenamed, by virtue of a power of attorney given under private seal in

Sweden,

for an aggregate subscription price of EUR 3,855.90 (three thousand eight hundred fifty-five euro and ninety cents)

and are entirely allocated to the share capital.

Which proxies after having been initialled “ne varietur” by the proxy holder of the appearing party and the undersigned

notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The shares so subscribed have been paid up by the above mentioned subscriber through a contribution in cash of

3,855.90 (three thousand eight hundred fifty-five euro and ninety cents) such contribution in cash is as of now at the
disposal of the Company, as it has been proved to the undersigned notary.

After the capital increase the shares are allocated as follows:

SSVP III

Str

36.640%

SSVP III

37.662%

Kieran

6.169%

Phileas

14.627%

Bjurbom

Invest BA

2.451%

Lars

Rosen

2.451%

100.000%

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

5,764,180 5,925,000 970,450 2,301,190

385,590 385,590 15,732,000

<i>Second resolution

Further to the here-above resolutions, the Shareholders resolve to amend article 8 of the Articles, which shall hen-

ceforth read as follows:

'' Art 8. The Company's capital is set at EUR 157,320 (one hundred fifty-seven thousand three hundred twenty euro)

represented by 15,732,000 (fifteen million seven hundred thirty-two thousand) shares of EUR 0.01 (one cent euro) each,
divided into 1,573,200 (one million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class A Ordinary Shares, 1,573,200
(one million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class B Ordinary Shares, 1,573,200 (one million five
hundred seventy-three thousand two hundred) Class C Ordinary Shares, 1,573,200 (one million five hundred seventy-
three thousand two hundred) Class D Ordinary Shares, 1,573,200 (one million five hundred seventy-three thousand two
hundred) Class E Ordinary Shares, 1,573,200 (one million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class F
Ordinary Shares, 1,573,200 (one million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class G Ordinary Shares,
1,573,200 (one million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class H Ordinary Shares, 1,573,200 (one
million five hundred seventy-three thousand two hundred) Class I Ordinary Shares and 1,573,200 (one million five hundred
seventy-three thousand two hundred) Class J Ordinary Shares and, together with the Class A,B,C,D,E,F,G,H,I,J Ordinary
Shares referred to as the "Ordinary Shares" and, each having such rights and obligations as set out in these Articles. In
these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed
accordingly.”

<i>Estimate of costs

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the

Company incurs or for which it is liable by reason of the present, is approximately one thousand five hundred euro (EUR
1,500).

There being no further business, the meeting was thereupon adjourned.
The undersigned notary who understands and speaks English, hereby states that on request of the partners, the present

incorporation deed is worded in English, followed by a German version; on request of the same partners and in case of
discrepancies between the English and the German text, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

5981

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the persons appearing, they signed together with us, the notary, the present original

deed.

Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, den zwölften November.
Vor dem unterzeichneten Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Erschienen

zu einer außerordentlichen Generalversammlung die Gesellschafter der "Holding Blanc Bleu 5 S.à r.l", eine société à

responsabilité limitée (GmbH), mit Sitz in 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, eingetragen im Gesellschafts- und
Handelsregister Luxemburg (R.C.S. Luxembourg) unter der Nummer B 190.285, gegründet gemäß notarieller Urkunde
aufgenommen durch den unterzeichneten Notar, vom 27. August 2014, noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés
et Associations veröffentlicht.

Die Versammlung tagt unter dem Vorsitz von Frau Corinne PETIT, Angestellte, mit beruflicher Anschrift in 74, avenue

Victor Hugo, L-1750 Luxemburg.

Die Frau Vorsitzende bestellt zum Schriftführer Frau Marilyn KRECKE, Angestellte, mit derselben beruflichen Anschrift.
Die Versammlung wählt zum Stimmenzähler Frau Corinne PETIT, vorgenannt.
Die Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu

Protokoll genommen werden:

I. Die vertretenen Gesellschafter und die Anzahl der von ihnen gehaltenen Aktien auf einer Anwesenheitsliste ange-

geben sind (die „Gesellschafter"). Diese Liste und die von der Vertreterin und dem Notar „ne varietur“ unterschriebene
Vollmacht werden dieser Urkunde beigefügt, um mit ihr registriert zu werden.

II. Die Anwesenheitsliste zeigt, dass von 12.500.000 (zwölf Millionen fünfhunderttausend) Anteilen der Gesellschaft,

alle  12.500.000  (zwölf  Millionen  fünfhunderttausend)  Anteile,  welche  100%  des  Gesellschaftskapitals  der  Gesellschaft
repräsentieren, bei dieser außerordentlichen Hauptversammlung vertreten sind, so dass die Versammlung rechtsgültig
konstituiert wurde und verbindlich über alle Angelegenheiten der Tagesordnung entscheiden kann, über welche die Ge-
sellschafter im Voraus informiert wurden.

III. Die Gesellschafter erklären, dass sie sich als ordnungsgemäß einberufen und über die Tagesordnung informiert

betrachten und auf die Einhaltung sämtlicher Einberufungsverfahren, d.h. insbesondere auf die Einberufung durch einge-
schriebenen Brief, verzichten.

IV. Die Gesellschafter erklären, dass die Tagesordnung der Versammlung wie folgt lautet:

<i>Tagesordnung

1. Erhöhung des Gesellschaftskapitals um einen Betrag von EUR 32.320 (zweiunddreißigtausend dreihundertzwanzig

Euro) von seinem gegenwärtigen Betrag von EUR 125.000 (einhundertfünfundzwanzigtausend Euro) auf EUR 157.320
(einhundertsiebenundfünfzigtausend dreihundertzwanzig Euro) durch die Schaffung von 323.200 (dreihundert dreiund-
zwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse A, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Stammanteilen der Klasse B, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse C,
323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse D, 323.200 (dreihundert dreiund-
zwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse E, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Stammanteilen der Klasse F, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse G,
323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse H, 323.200 (dreihundert dreiund-
zwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse I und 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Stammanteilen der Klasse J, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein cent Euro);

2. Anschließende Abänderung des Artikels 8 der Gesellschaftssatzung.
3. Sonstiges.
Der Vorsitzende erklärt daraufhin die Gründe, welche die Geschäftsführung dazu bewegten der Generalversammlung

diese Tagesordnung zu unterbreiten.

Nach Diskussion fasst die Generalversammlung einstimmig folgenden Beschluss:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafter beschließen, das Gesellschaftskapital um den Betrag von EUR 32.320 (zweiunddreißig tausend drei-

hundertzwanzig Euro) zu erhöhen, um diesen von dem derzeitigen Betrag von EUR 125.000 (einhundertfünfundzwanzig-
tausend Euro) auf EUR 157.320 (einhundertsiebenundfünfzig tausend dreihundertzwanzig Euro) durch die Schaffung von
323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse A, 323.200 (dreihundert dreiund-
zwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse B, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Stammanteilen der Klasse C, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse D,
323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse E, 323.200 (dreihundert dreiund-
zwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse F, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert)
Stammanteilen der Klasse G, 323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse H,

5982

L

U X E M B O U R G

323.200 (dreihundert dreiundzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse I und 323.200 (dreihundert drei-
undzwanzigtausend zweihundert) Stammanteilen der Klasse J, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein cent Euro) zu
erhöhen.

<i>Verzicht, Zeichnung und Einzahlung

Einer der drei (3) aktuellen Gesellschafter “Special Situations Venture Partners III, LP” hat ausdrücklich auf sein Zeich-

nungsrecht verzichtet.

Demzufolge wurden die neu geschaffenen Anteile wie folgt gezeichnet:
- 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse A, 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse B, 18 (achtzehn) Stammanteile der

Klasse C, 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse D, 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse E, 18 (achtzehn) Stammanteile
der Klasse F, 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse G, 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse H, 18 (achtzehn) Stamm-
anteile der Klasse I und 18 (achtzehn) Stammanteile der Klasse J, sind von Special Situations Venture Partners III Structured,
LP gezeichnet worden, für einen Gesamtpreis von EUR 1,80 (ein Euro achtzig cents) und sind dem Gesellschaftskapital
zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen Anteile sind von dem genannten Zeichner vollständig in bar eingezahlt ge-
worden für einen Gesamtbetrag von EUR 1,80 (ein Euro achtzig cents) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung
steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

- 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse A, 15.945 (fünfzehn tausend neun-

hundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse B, 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile
der Klasse C, 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse D, 15.945 (fünfzehn tausend
neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse E, 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stamm-
anteile der Klasse F, 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse G, 15.945 (fünfzehn
tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse H, 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig)
Stammanteile der Klasse I und 15.945 (fünfzehn tausend neunhundert fünfundvierzig) Stammanteile der Klasse J sind von
Kieran Investment GmbH &amp; Co. KG gezeichnet worden, für einen Gesamtpreis von EUR 1.594,50 (eintausend fünfhundert
vierundneunzig Euro und fünfzig cents) und sind dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen
Anteile  sind  von  dem  genannten  Zeichner  vollständig  in  bar  eingezahlt  geworden  für  einen  Gesamtbetrag  von  EUR
1.594,50 (eintausend fünfhundert vierundneunzig Euro und fünfzig cents) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung
steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

- 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der Klasse A, 230.119 (zweihundertd-

reißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der Klasse B, 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertund-
neunzehn) Stammanteile der Klasse C, 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der
Klasse D, 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der Klasse E, 230.119 (zweihun-
dertdreißigtausend  einhundertundneunzehn)  Stammanteile  der  Klasse  F,  230.119  (zweihundertdreißigtausend  einhun-
dertundneunzehn) Stammanteile der Klasse G, 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stamman-
teile der Klasse H, 230.119 (zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der Klasse I, 230.119
(zweihundertdreißigtausend einhundertundneunzehn) Stammanteile der Klasse J sind von Phileas Investment GmbH &amp;
Co. KG, eine Gesellschaft gegründet unter der deutschen Gesetzgebung, mit Sitz in Südliche Münchner Straße 8, D-82031
Grünwald und eingetragen im Amtsgericht München unter der Nummer 98104,

hier  vertreten  durch  Frau  Corinne  PETIT,  vorbenannt,  aufgrund  einer  privatschriftlichen  Vollmacht  gegeben  in

Deutschland am 10. November 2014,

gezeichnet worden, für einen Gesamtpreis von EUR 23.011,90 (dreiundzwanzigtausend und elf Euro und neunzig cents)

und sind dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen Anteile sind von dem genannten Zeichner
vollständig in bar eingezahlt geworden für einen Gesamtbetrag von EUR 23.011,90 (dreiundzwanzigtausend und elf euro
und neunzig cents) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen
wurde.

- 38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse A, 38.559 (achtunddreißigtau-

send fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse B, 38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig)
Stammanteile  der  Klasse  C,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  D,
38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse E, 38.559 (achtunddreißigtausend
fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  F,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)
Stammanteile  der  Klasse  G,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  H,
38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse I und 38.559 (achtunddreißigtausend
fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse J, sind von Bjurbom Invest AB (vormals Fundamendet 2174 AB),
eine Gesellschaft gegründet unter der schwedischen Gesetzgebung, mit Sitz in Box 2046, SE-640 02 Karlstad, Schweden
und eingetragen unter der Nummer 556984-1371,

hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, vorbenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Schwe-

den am 11. November 2014,

gezeichnet worden, für einen Gesamtpreis von EUR 3.855,90 (dreitausend achthundert fünfundfünfzig Euro und neunzig

cents) und sind dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden. Die neu ausgegebenen Anteile sind von dem genannten
Zeichner vollständig in bar eingezahlt geworden für einen Gesamtbetrag von EUR 3.855,90 (dreitausend achthundert

5983

L

U X E M B O U R G

fünfundfünfzig Euro und neunzig cents) welcher der Gesellschaft ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem Notar
ausdrücklich nachgewiesen wurde.

- 38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse A, 38.559 (achtunddreißigtau-

send fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse B, 38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig)
Stammanteile  der  Klasse  C,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  D,
38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse E, 38.559 (achtunddreißigtausend
fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  F,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)
Stammanteile  der  Klasse  G,  38.559  (achtunddreißigtausend  fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  H,
38.559 (achtunddreißigtausend fünfhundert neunundfünfzig) Stammanteile der Klasse I und 38.559 (achtunddreißigtausend
fünfhundert  neunundfünfzig)  Stammanteile  der  Klasse  J,  sind  von  Herrn  Lars  ROSEN,  geboren  am  20.  April  1965  in
Sundsvall (Schweden), wohnhaft in Gränsgatan 2, SE-654 64 Karlstad, Schweden,

hier vertreten durch Frau Corinne PETIT, vorbenannt, aufgrund einer privatschriftlichen Vollmacht gegeben in Schwe-

den,

gezeichnet worden, für einen Gesamtpreis von EUR 3.855,90 (dreitausend achthundert fünfundfünfzig Euro und neunzig

cents) und sind dem Gesellschaftskapital zugeteilt geworden.

Welche Vollmachten die von den Erschienenen und der unterzeichnenden Notarin "ne varietur" unterzeichnet wurden,

bleiben dieser Urkunde beigefügt um sie, zusammen mit dieser bei der zuständigen Registerstelle einzureichen.

Die neu ausgegebenen Anteile sind von den genannten Zeichnern vollständig in bar eingezahlt worden für einen Ge-

samtbetrag von EUR 3.855,90 (dreitausend achthundert fünfundfünfzig Euro und neunzig cents) welcher der Gesellschaft
ab sofort zur Verfügung steht, wie dies dem Notar ausdrücklich nachgewiesen wurde.

Nach der Kapitalerhöhung werden die Anteile wie folgt gehalten:

SSVP III

Str

36.640%

SSVP III

37.662%

Kieran

6.169%

Phileas

14.627%

Bjurbom

Invest BA

2.451%

Lars

Rosen

2.451%

100.000%

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

J . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

576,418

592,500

97,045

230,119

38,559

38,559

1,573,200

5,764,180 5,925,000 970,450 2,301,190

385,590 385,590 15,732,000

<i>Zweiter Beschluss

Im Anschluss der oben genarmten Beschlüsse hinsichtlich des Gesellschaftskapitals beschließen die Gesellschafter,

Artikel 8 der Gesellschaftssatzung abzuändern, der nun wie folgt lauten soll:

Art. 8. Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf EUR 157.320 (einhundertsiebenundfünfzigtausend dreihundertzwanzig

Euro) und ist aufgeteilt auf 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der
Klasse A, 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse B, 1.573.200
(eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse C, 1.573.200 (eine Million fünf-
hundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse D, 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiund-
siebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse E, 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei
hundert) Stammanteile der Klasse F, 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stamman-
teile der Klasse G, 1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse H,
1.573.200 (eine Million fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse I, 1.573.200 (eine Million
fünfhundert dreiundsiebzigtausend zwei hundert) Stammanteile der Klasse J, mit einem Nennwert von je EUR 0,01 (ein
cent Euro), die Stammanteile der Klasse A, B, C, D, E, F, G, H, I und J werden als „Stammanteile" bezeichnet. Alle Anteile
haben die gleichen Rechte und Pflichten wie erklärt in dieser Gesellschaftssatzung. In dieser Gesellschaftssatzung bedeutet
die „Gesellschafter" die Inhaber der Anteile zu gegebener Zeit und „Gesellschafter" wird entsprechend ausgelegt."

<i>Kosten

Die Kosten, Ausgaben und Gebühren jeglicher Art, die der Gesellschaft entstehen oder ihr in Zusammenhang mit der

vorliegenden Urkunde in Rechnung gestellt werden, belaufen sich auf ungefähr eintausend fünfhundert Euro (1.500.- EUR).

Da es keine weiteren Tagesordnungspunkte zu besprechen gibt, wird die Versammlung geschlossen.

5984

L

U X E M B O U R G

Der unterzeichnete Notar, der Englisch spricht und versteht, bestätigt hiermit, dass auf Anfrage der oben erschienenen

Gesellschafter, dieser Akt auf Englisch verfasst wurde und von der deutschen Übersetzung gefolgt ist. Auf Anfrage der
gleichen Gesellschafter und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist die eng-
lische Fassung maßgebend.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Luxemburg, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Vorlesung und Erklärung alles Vorstehenden an die Erschienenen, haben die vorgenannten Komparenten zu-

sammen mit dem instrumentierenden Notar gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Versammlung für geschlossen.
Signé: C. Petit, M. Krecké et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 14 novembre 2014. Relation: LAC/2014/53611. Reçu soixante-quinze euros

Eur 75.-.

<i>Le Receveur

 (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d’inscription au Registre de

Commerce.

Luxembourg, le 26 novembre 2014.

Référence de publication: 2014201662/357.
(140225226) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

JPY Immo S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9942 Basbellain, 6, am Lehmeck.

R.C.S. Luxembourg B 192.973.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le dix-sept décembre.
Pardevant Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette.

S'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire de l'associé de la société privée à responsabilité limitée de droit belge dénommée

“JPY IMMO, en abrégé JPY», avec siège social à B-4654 Herve, 252, Sauvenière-Charneux, inscrite au Registre de Com-
merce de Liège sous le numéro 0553479228, dont le capital social s'élève actuellement à un million quatre cent quatre
mille euros (1.404.000.-EUR), divisé en quatorze mille quarante (14.040) parts sociales, sans désignation de valeur nomi-
nale.

La séance est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Nicolas de Caritat de Peruzzis, employé privé,

demeurant professionnellement au 56, rue Glesener L-1630 Luxembourg.

Monsieur le président désigne comme secrétaire et scrutateur Monsieur Nicolas Delattre, employé privé, demeurant

professionnellement au 56, rue Glesener L-1630 Luxembourg.

L'associé dûment représenté à la présente assemblée et le nombre de parts sociales possédées par lui ont été portées

sur une liste de présence, signée par le mandataire de l'associé, et à laquelle liste de présence, dressée par les membres
du bureau, les membres de l'assemblée déclarent se référer.

Ladite liste de présence ainsi que la procuration de l'associé représenté après avoir été signées ne varietur par les

membres du bureau et le notaire instrumentant, demeureront annexées au présent acte avec lequel elles seront enre-
gistrées.

Monsieur le président expose et l'assemblée constate:
Par une résolution valablement adoptée par l'associé, respectivement gérant de la Société en Belgique suite à une

assemblée générale extraordinaire tenue sous seing privé en date du 22 octobre 2014, déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de Liège le 30 octobre 2014, en voie de publication au Moniteur Belge, conformément aux dispositions des
statuts de la Société, la Société a décidé de transférer son siège social, son administration centrale et son siège de direction
effective de B-4654 Herve, 252, Sauvenière-Charneux, à L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck (ci-après le Luxembourg) avec
effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique. Toutes les
formalités requises par le droit belge afin de réaliser cette décision ont d'ores et déjà été accomplies; une copie de ladite
résolution restera annexée au présent acte.

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:
1.- Transfert du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la société de B-4654

Herve, 252, Sauvenière-Charneux, vers le Grand-Duché de Luxembourg, à L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck, avec effet
à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique.

5985

L

U X E M B O U R G

2.- Adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée sous la dénomination sociale «JPY

IMMO S.à r.l.», en abrégé JPY et acceptation de la nationalité luxembourgeoise découlant du transfert du siège social, de
l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société à Luxembourg;

3.- Constatation et approbation par l'associé respectivement gérant de la société du bilan d'ouverture de la Société

en date du 22 octobre 2014.

4.- Refonte globale et mise en conformité des statuts aux résolutions précédentes et adaptation à la législation lu-

xembourgeoise.

5.- Confirmation du maintien de la nomination pour une durée indéterminée au sein de la société de Monsieur Yvo

PIRENNE et de Monsieur Jean-Paul PIRENNE en tant que gérants de la société.

6.- Etablissement du siège social, de l'administration centrale et du siège de direction effective de la Société au L-9942

Basbellain, 6, Am Lehmeck, Grand-Duché de Luxembourg;

7.- Divers.
B) Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement, telle qu'elle est constituée, sur les objet portés à l'ordre du jour.

C) Que l'intégralité du capital social étant représentée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'associé

représenté se reconnaît dûment convoqué et déclare par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été
communiqué au préalable.

Ensuite l'assemblée aborde l'ordre du jour et, après en avoir délibéré, elle a pris à l'unanimité des voix les résolutions

suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée générale décide de transférer le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de

la Société de B-4654 Herve, 252, Sauvenière-Charneux, à L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck (Grand-Duché de Luxem-
bourg) avec effet à la date du présent acte, sans dissolution de la Société et avec continuation de sa personnalité juridique.
L'assemblée déclare en outre que toutes les formalités requises selon les lois et règlements applicables en Belgique afin
de donner effet à un tel transfert, ont été dûment remplies.

<i>Deuxième résolution

L'assemblée générale décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité sous le nom «JPY IMMO S.à

r.l.», en abrégé JPY accepte la nationalité luxembourgeoise et sera, à la date du présent acte, soumise aux lois et règlements
applicables au Luxembourg.

<i>Troisième résolution

L'assemblée générale constate et approuve le bilan d'ouverture de la Société daté du 22 octobre 2014, date à partir

de laquelle toutes les opérations sont effectuées pour le compte de la société «JPY IMMO S.à r.l.», en abrégé JPY régie
par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

<i>Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent et de les adapter

à la législation luxembourgeoise, et décident de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur
suivante:

“Chapitre I 

er

 . - Nom - Durée - Objet - Siège social

Art. 1 

er

 . Nom et Durée.  Il existe une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois sous la dénomination

«JPY IMMO S.à r.l.», en abrégé JPY (ci-après la "Société").

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 2. Objet. La société a pour objet, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, pour compte propre ou

pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-

location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins,
fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes
opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant
que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations
et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts;
souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements tech-
niques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes
opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

5986

L

U X E M B O U R G

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières

ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter
directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires,

entreprises associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à
favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses
produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel

que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans

tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution.
Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.
La gérance a compétence pour interpréter l'objet social.
Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le
développement.

Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi à Basbellain (commune de Troisvierges).
Il pourra être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution d'une assemblée générale

de son associé, ou en cas de pluralité d'associés, de ses associés.

La Société peut avoir d'autres bureaux et succursales (que ce soient des établissements permanents ou non) à la fois

au Luxembourg et à l'étranger.

Chapitre II. - Capital social

Art. 4. Capital. Le capital social de la Société est fixé à un million quatre cent quatre mille euros (1.404.000.-EUR),

divisé en quatorze mille quarante (14.040) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées.

Le capital social souscrit pourra être modifié à n'importe quel moment par décision de l'associé ou, selon le cas, pas

une décision de l'assemblée générale des associés délibérant selon le mode de délibération requis en cas de modification
des statuts.

Art. 5. Participation aux bénéfices. Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et bénéfices de la Société

en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

Art. 6. Transfert de parts. En cas d'associé unique, les parts sociales sont librement transmissibles à des non-associés.
En cas de pluralité d'associés, les parts sociales ne sont cessibles inter vivos à des tiers, non associés, que dans le respect

de l'approbation préalable par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Les
parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Les parts sociales ne peuvent être transmises mortis causa à des non associés que moyennant l'agrément des pro-

priétaires de parts sociales représentant les trois quarts des droits appartenant aux survivants.

Art. 7. Rachat de parts sociales. La Société pourra, sous réserve du respect des dispositions de la loi du 10 août 1915

sur les sociétés commerciales, telle qu'elle a été modifiée (la "Loi"), acquérir ses propres parts sociales.

L'acquisition et la disposition par la Société de ses propres parts sociales devront se faire par le biais d'une résolution

d'une et sous les conditions à fixer par une assemblée générale des associés.

Chapitre III. - Gérance - Réunion du conseil de gérance - représentation - signataires autorisés

Art. 8. Gérance. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants. En cas de pluralité de gérants, ils forment un

conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'a (ont) pas besoin d'être associé(s). Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée
générale des associés. L'assemblée générale des associés peut à tout moment révoquer ad nutum (sans devoir justifier
d'une raison) et remplacer le(s) gérant(s).

L'assemblée générale des associés décidera de la rémunération et des modalités de désignation de chacun des gérants.

Art. 9. Réunion du Conseil de gérance. Les réunions du conseil de gérance sont convoquées par tout membre du

conseil.

Les gérants seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil de gérance. Excepté les cas d'urgence qui seront

spécifiés dans la convocation ou avec l'accord préalable de tous les gérants, le délai de convocation sera d'au moins huit
jours.

La réunion sera valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants sont présents ou valablement repré-

sentés.

Les réunions sont tenues aux lieu, jour et heure spécifiés dans la convocation.

5987

L

U X E M B O U R G

Il peut être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant donné par lettre, télécopie, ou tout autre moyen

de télécommunication approprié. Aucune convocation spéciale n'est requise pour des réunions tenues à une date et à
un endroit prévus dans une planification de réunions préalablement adoptée par résolution du conseil de gérance.

Chaque gérant peut participer à une réunion en nommant comme son mandataire un autre gérant par lettre, télécopie,

ou tout autre moyen de télécommunication approprié.

Un gérant peut représenter plus d'un de ses collègues.
Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil par conférence téléphonique ou vidéo-

conférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant au conseil
de se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le(s) membre(s) concerné(s) sera/seront censés avoir participé en personne
à la réunion.

Le conseil de gérance ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou

représentée.

Les résolutions du conseil de gérance sont prises à la majorité absolue des voix exprimées.
En cas d'urgence, les résolutions signées par tous les gérants produiront les mêmes effets que les résolutions prises

lors d'une réunion du conseil de gérance dûment convoquée et tenue. De telles signatures peuvent apparaître sur un
document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent résulter de lettres, télécopies ou
télex.

Art. 10. Représentation - Signatures autorisées. Vis-à-vis des tiers, le(s) gérant(s) a/ont les pouvoirs les plus étendus

pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation
avec l'objet social de la Société, sous réserve des dispositions du présent article 10.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés

sont de la compétence du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance. En cas de
gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature
conjointe de deux membres du conseil de gérance. L'(es)associé(s) peut(vent) élire parmi les membres du conseil de
gérance un ou plusieurs gérant(s)-délégué(s) qui aura(ont) le pouvoir d'engager la Société par leur seule signature res-
pective, pourvu qu'il(s) agisse(nt) dans le cadre des compétences du conseil de gérance.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance peut sous-déléguer ses/leurs pouvoirs pour des

tâches particulières à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la responsabilité du/des mandataires

(s) et sa/leur rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation de son/leur mandat et toute autre
condition essentielle de son/leur mandat.

Art. 11. Responsabilité des gérants. Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent en raison de sa/leur position, aucune

responsabilité personnelle pour un engagement valablement pris par lui/eux au nom de la Société, aussi longtemps que
cet engagement est conforme aux statuts de la Société et aux dispositions applicables de la Loi.

Chapitre IV. - Secrétaire

Art. 12. Nomination d'un secrétaire. Un secrétaire peut être nommé suivant une résolution de l'associé unique (res-

pectivement de l'assemblée des associés) de la Société (le "Secrétaire").

Le Secrétaire, qui n'a pas besoin d'être un gérant, aura la responsabilité d'agir en tant que clerc des réunions du conseil

de gérance et, dans la mesure du possible, de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés) et de garder
les procès-verbaux et les minutes du conseil de gérance et de l'associé unique (respectivement de l'assemblée des associés)
et de toutes leurs transactions dans un livre tenu à cette fin. Il effectuera, si nécessaire, des fonctions similaires pour tous
les comités du conseil de gérance (s'il y en a). Il aura la possibilité de déléguer ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes
à condition qu'il conserve la responsabilité des tâches qu'il aura déléguées.

Le Secrétaire aura le pouvoir et l'autorité d'émettre des certificats et des extraits pour le compte de la Société qui

pourront être produits en justice, ou de manière générale, à l'égard de tous tiers et qui seront utilisés comme documents
officiels.

Chapitre V. - Assemblée générale des associés

Art. 13. Droit de vote des associés. Chaque associé peut prendre part aux assemblées générales des associés indé-

pendamment du nombre de parts qu'il détient.

Le droit de vote de chaque associé est proportionnel au nombre de parts qu'il détient.
Chaque associé peut désigner par procuration un représentant qui n'a pas besoin d'être associé pour le représenter

aux assemblées des associés.

Art. 14. Quorum - Majorité. Les résolutions aux assemblées des associés ne sont valablement prises que si elles sont

adoptées par une majorité d'associés possédant plus de la moitié du capital social.

5988

L

U X E M B O U R G

Cependant, les résolutions modifiant les statuts et celles tendant à la dissolution et la liquidation de la Société ne

peuvent être prises que par une majorité en nombre d'associés possédant au moins trois quarts du capital social de la
Société.

Les résolutions des associés peuvent, au lieu d'être prises lors d'une assemblée générale des associés, être prises par

écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de(s) résolution(s) à prendre devra être envoyé à
chaque associé, et chaque associé votera par écrit, les résolutions signées sur une ou plusieurs copies séparées produiront
les mêmes effets que les résolutions prises lors d'une assemblée générale des associés.

Chapitre VI. - Année sociale - Bilan - Répartition

Art. 15. Année sociale. L'année sociale commence le 1 

er

 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Art. 16. Comptes sociaux. Chaque année, les livres sont clos et le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil

de gérance prépare le bilan et le compte de pertes et profits.

Art. 17. Inspection des documents. Chaque associé peut prendre connaissance du bilan et du compte de pertes et

profits au siège social de la Société.

Art. 18. Distribution des bénéfices - Réserves. Un montant égal à cinq pour cent (5%) des bénéfices nets de la Société

est affecté à l'établissement de la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social
de la Société.

Le solde peut être distribué au(x) associé(s) en proportion des parts qu'il(s) détiennent dans la Société. L'assemblée

générale des associés a, sous réserve de la loi applicable, le pouvoir de rendre payable un ou plusieurs dividendes intér-
imaires.

Tout remboursement de primes d'émission au(x) associé(s) de la Société devra respecter les conditions applicables à

une réduction du capital social par remboursement au(x) associé(s).

Chapitre VII. - Dissolution - Liquidation

Art. 19. Dissolution. L'insolvabilité ou la faillite ou n'importe quelle autre procédure similaire d'un ou des associé(s)

n'entraînera pas la dissolution de la Société. Les associés doivent donner leur accord conformément aux dispositions de
l'article 15 paragraphe 2 des présents statuts à la dissolution et à la liquidation de la Société et fixer les modalités y relatives.

Art. 20. Liquidation. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par un ou plusieurs liquidateur(s),

associé(s) ou non, nommé(s) par le(s) associé(s) qui détermineront leurs pouvoirs et leur rémunération.

Chapitre VIII. - Vérification des comptes

Art. 21. Commissaires aux comptes - Réviseur d'entreprises. Conformément à l'article 200 de la Loi, la Société a

seulement besoin d'une vérification des comptes par un commissaire si elle a plus de 25 associés. Un réviseur d'entreprises
doit être nommé si l'exemption prévue par les articles 69 et 35 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés, à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, n'est pas applicable.

Chapitre IX. - Loi applicable

Art. 22. Référence aux dispositions légales. Pour tous les points non expressément prévus aux présents statuts, le ou

les associé(s) s'en réfèrent aux dispositions de la Loi.”

<i>Disposition transitoire

Suite au transfert du siège de la société de Belgique vers le Luxembourg: le premier exercice débute à la date de ce

jour, date à laquelle les opérations sont considérées avoir été effectuées pour le compte de la société "JPY IMMO, en
abrégé JPY ", et se termine le 31 décembre 2014.

La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2015.

<i>Constatation

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigés par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés

commerciales ont été accomplies.

<i>Septième résolution

L'assemblée générale décide que suite au transfert de siège social de Belgique vers le Luxembourg, les gérants de la

société continueront leurs fonctions pour une durée indéterminée, à savoir:

1) Monsieur Yvo PIRENNE, né à Lyon (France) le 25 février 1942, demeurant à L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck;
2) Monsieur Jean-Paul PIRENNE, né à Princeton (USA) le 15 décembre 1954, demeurant à L-9942 Basbellain, 6, Am

Lehmeck;

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle de chaque gérant.

5989

L

U X E M B O U R G

<i>Huitième résolution

L'assemblée générale décide d'établir le siège social, l'administration centrale et le siège de direction effective de la

Société au L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck.

<i>Neuvième résolution

L'assemblée générale constate que les associés de la société sont:
1) Monsieur Yvo PIRENNE, né à Lyon (France) le 25 février 1942, demeurant à L-9942 Basbellain, 6, Am Lehmeck,

détenant 7.020 parts sociales.

2) Monsieur Jean-Paul PIRENNE, né à Princeton (USA) le 15 décembre 1954, demeurant à L-9942 Basbellain, 6, Am

Lehmeck, détenant 7.020 parts sociales de la société.

<i>Frais

Les frais, dépenses, charges et rémunérations en relation avec les présentes sont tous à charge de la société et sont

estimés approximativement à € 2.700.-Plus rien d'autre ne se trouvant à l'ordre du jour, les comparants ont déclaré close
la présente assemblée.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ils ont tous signé le présent procès-verbal avec le notaire.

Signé: DE CARITAT DE PERUZZIS, DELATTRE, MOUTRIER.
Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 18/12/2014. Relation: EAC/2014/17527. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): SANTIONI.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 19/12/2014.

Référence de publication: 2014204398/270.
(140229475) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Renewable Finance III, Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 192.825.

STATUTEN

Im Jahre zweitausendvierzehn, am fünften Dezember.
Vor dem unterzeichneten Notar Pierre PROBST, mit dem Amtssitz in Ettelbrück, Großherzogtum Luxemburg

Ist erschienen:

Die SW Equities S.à r.l., société à responsabilité limitée, mit Gesellschaftssitz in 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg,

eingetragen im Handels und Gesellschaftsregister Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Num-
mer B 191847,

hier vertreten durch Dame Nadine Closter, beruflich ansässig in L-9087 ETTELBRUCK, Großherzogtum Luxemburg,

aufgrund einer Vollmacht gegeben unter Privatschrift am 2. Dezember 2014.

Die erteilte Vollmacht, ordnungsgemäß „ne varietur“ durch den Bevollmächtigen und den amtierenden Notar unter-

zeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigefügt, um mit derselben einregistriert zu werden.

Die Erschienene, handelnd wie angegeben, hat den unterzeichnenden Notar ersucht, die Gründung einer Aktienge-

sellschaft urkundlich festzustellen, die sie hiermit beschließt und deren Satzung wie folgt lautet:

SATZUNG

Kapitel I. - Name - Geschäftssitz - Geschäftszweck - Dauer

Art. 1. Die Gesellschaft ist als Aktiengesellschaft (société anonyme) nach luxemburgischem Recht mit dem Namen

„Renewable Finance III” errichtet (im Folgenden: die "Gesellschaft") und unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes über
Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in seiner jeweils geltenden Fassung (im Folgenden: das "Gesetz von 1915")
sowie den Bestimmungen der vorliegenden Satzung (im Folgenden: die "Satzung).

Art. 2.
(1) Der Geschäftssitz der Gesellschaft befindet sich in der Gemeinde Niederanven, Großherzogtum Luxemburg.
(2) Der Geschäftssitz der Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates (wie nachstehend in Artikel

11  definiert)  an  jeden  beliebigen  Ort  innerhalb  derselben  Gemeinde  verlegt  werden.  Im  Übrigen  gelten  die  für  eine
Änderung der Satzung geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

5990

L

U X E M B O U R G

(3) Sollte eine Situation entstehen oder als unmittelbar bevorstehend erscheinen, die eine normale Tätigkeit am Ge-

schäftssitz der Gesellschaft aus militärischen, politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Gründen verhindert,
darf der Geschäftssitz der Gesellschaft durch Beschluss des Verwaltungsrates vorübergehend ins Ausland verlegt werden
bis sich die Situation wieder normalisiert; solche zeitlich begrenzten Maßnahmen haben keinen Einfluss auf die Nationalität
der Gesellschaft, welche unabhängig von einer zeitlich begrenzten Verlegung des Geschäftssitzes der Gesellschaft eine
luxemburgische Gesellschaft bleibt.

(4) Die Gesellschaft kann durch einen Beschluss des Verwaltungsrates Büros und Zweigstellen sowohl im Großher-

zogtum Luxemburg als auch im Ausland errichten.

Art. 3.
(1) Der Geschäftszweck der Gesellschaft ist der Erwerb von Beteiligungen an Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen

Gesellschaften oder Unternehmen im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland in jedweder Form, sowie die Ver-
waltung, das Management, die Steuerung und die Entwicklung solcher.

(2) Die Gesellschaft kann insbesondere durch Zeichnung, Erwerb, Tausch oder in jeder möglichen anderen Weise

Aktien, Anteile und/oder andere Beteiligungen, Anleihen, Schuldscheine, Depotquittungen und/oder andere Schuldur-
kunden und im Allgemeinen alle Wertpapiere und/oder Finanzierungsinstrumente, die durch jedes öffentliche oder private
Unternehmen, herausgegeben werden, erwerben.

(3) Die Gesellschaft kann direkt oder indirekt in Immobilienanlagen investieren und den Erwerb und die Verwaltung

eines Portfolios von Patenten oder von anderen Rechten am geistigen Eigentum jeder Natur oder Ursprung tätigen.

(4) Die Gesellschaft kann in jeder möglichen Art und Weise borgen insbesondere kann sich die Gesellschaft durch die

Emission von Privatplatzierungen, Wertpapieren, Anleihen und Schuldscheinen und jede Art von Schuld- und/oder Divi-
dendenpapiere finanzieren. Die Gesellschaft kann Kapital ohne Beschränkung an seine Tochtergesellschaften, Filialen und
Agenturen, angeschlossene Firmen und/oder irgendwelche anderen Firmen oder Personen verleihen. Die Gesellschaft
kann (für alle oder nur Teile ihrer Aktiva) Garantien und Bürgschaften ausgeben, Sicherheiten abtreten oder Sicherheiten
erstellen um ihre eigenen Verpflichtungen und Unternehmungen, und/oder diejenigen Dritter, abzusichern. Sie kann dieses
zum eigenen Nutzen und/oder zum Nutzen Dritter (juristischer oder privater Personen) tun, solange jene Tätigkeiten
keine Tätigkeit ist, die den Verordnungen des Finanzsektors unterliegt.

(5) Die Gesellschaft kann an der Aufsetzung, an der Entwicklung, am Management und an der Steuerung von Gesell-

schaften  oder  Unternehmen  teilnehmen.  Die  Gesellschaft  darf  geschäftsführende  Tätigkeiten  im  Zusammenhang  mit
Handels-, Industrie-, Finanz- oder anderen Gesellschaften oder Unternehmen, im Großherzogtum Luxembourg oder im
Ausland, ausüben.

(6) Die Gesellschaft kann alle gewerblichen, technischen oder finanziellen Tätigkeiten durchführen, die direkt oder

indirekt mit allen oben beschriebenen Bereichen verbunden sind, um die Erfüllung ihres Zweckes zu fördern.

Art. 4. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

Kapitel II. - Gesellschaftskapital - Aktien

Art. 5.
(1) Das gezeichnete Gesellschaftskapital beträgt einunddreißigtausend Euro (EUR 31.000). Es ist in einunddreißigtau-

send (31.000) Aktien ohne Nennwert eingeteilt und in voller Höhe einbezahlt.

(2) Durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre oder des alleinigen Aktieninhabers, welcher in glei-

cher Weise wie für Satzungsänderungen erforderlich getroffen werden muss, kann das gezeichnete und genehmigte Kapital
der Gesellschaft erhöht oder reduziert werden.

Art. 6.
(1) Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Aktionäre haben.
(2) Die Gesellschaftsaktien sind Namensaktien.
(3) Ein Register der Namensaktien wird am Gesellschaftssitz geführt, wo es jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung

steht. Dieses Register enthält alle durch Artikel 39 des Gesetzes vorgeschriebenen Auskünfte. Der Nachweis des Eigen-
tums an den Namensaktien kann aufgrund der Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden. Das Register
steht jedem Aktionär zur Einsicht zur Verfügung. Abschriften des Registers können auf Ersuchen und auf Kosten eines
Aktionärs zur Verfügung gestellt werden

(4) Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Aktie an. Sollte das Eigentum an einer Aktie aufgeteilt sein, müssen

diejenigen, die ein Recht an dieser Aktie geltend machen, einen gemeinsamen Bevollmächtigten ernennen, der sie gege-
nüber der Gesellschaft vertritt.

Kapitel III. - Verwaltungsrat - Vertretungsbefugnis

Art. 7.
(1) Die Gesellschaft wird von einem Verwaltungsrat mit mindestens drei (3) Mitgliedern geführt (der „Verwaltungsrat“

und jedes Mitglied ein „Verwaltungsratsmitglied“), die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen.

5991

L

U X E M B O U R G

(2) Für den Fall, dass die Gesellschaft von nur einem Aktionär gegründet wurde oder in einer Hauptversammlung

festgestellt wird, dass alle von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien von einem Aktionär gehalten werden, kann die
Gesellschaft durch ein alleiniges Verwaltungsratsmitglied geführt werden bis zu der nächsten Hauptversammlung der
Aktionäre nachdem die Gesellschaft festgestellt hat, dass ihre Aktien von mehr als einem Aktionär gehalten werden.

(3) Die Mitglieder des Verwaltungsrates oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden von der Hauptversammlung

der Aktionäre oder dem alleinigen Aktionär gewählt; ihre Anzahl, Bezüge und die Dauer ihres Mandates werden von der
Hauptversammlung festgesetzt.

(4) Die Mitglieder des Verwaltungsrats oder das alleinige Verwaltungsratsmitglied werden für die Dauer eines Mandates

gewählt, welches sechs (6) Jahre nicht überschreiten darf und welches grundsätzlich mit der Bestellung eines Nachfolgers
endet.

(5) Die Hauptversammlung der Aktionäre kann zu jeder Zeit und ohne Angabe von Gründen ein Mitglied des Ver-

waltungsrates  abberufen.  Mitglieder  des  Verwaltungsrates  oder  das  alleinige  Verwaltungsratsmitglied  können  wieder
gewählt werden.

(6) Ist eine juristische Person als Verwaltungsratsmitglied bestimmt, muss sie einen ständigen Vertreter ernennen, der

diese Aufgabe im Namen und im Auftrag der juristischen Person ausführt. Diese juristische Person kann ihren Vertreter
nur abberufen, wenn sie gleichzeitig seinen Nachfolger ernennt.

(7) Wird die Position des Verwaltungsrates durch Tod, Rücktritt oder aus einem sonstigen Grund frei, so kann das

freigewordene Amt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vorläufig bis zur nächsten Hauptversammlung besetzt werden.

Art. 8.
(1) Alle Befugnisse, die weder von Gesetzes wegen noch durch diese Satzung ausdrücklich der Hauptversammlung der

Aktionäre vorbehalten sind, fallen in die Kompetenz des Verwaltungsrates. Der Verwaltungsrat hat Dritten gegenüber
grundsätzlich unbeschränkte Befugnis unter allen Umständen im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Verwal-
tungshandlungen,  Verfügungen  und  Maßnahmen  auszuführen  und  zu  genehmigen  die  dem  Zweck  der  Gesellschaft
entsprechen.

(2) Gegenüber Dritten wird die Gesellschaft rechtsgültig durch die gemeinsame Unterschrift von zwei Verwaltungs-

ratsmitgliedern oder durch die die Unterschrift des alleinigen Verwaltungsratsmitglieds verpflichtet.

(3) Die laufende Geschäftsführung der Gesellschaft sowie die diesbezügliche Vertretung Dritten gegenüber können

auf ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, leitende Angestellte, Geschäftsführer oder sonstige Vertretungs-
berechtigte, welche nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen, und welche gesamt- oder alleinzeichnungsberechtigt
sein können, übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und sonstigen Befugnisse werden durch Beschluss des
Verwaltungsrates geregelt.

(4) Ferner kann die Gesellschaft einzelne Aufgaben der Geschäftsführung durch privatschriftliche oder beglaubigte

Vollmacht übertragen.

Art. 9.
(1) Der Verwaltungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und hat die Möglichkeit, einen

stellvertretenden Vorsitzenden zu bestellen. Er kann außerdem einen Sekretär bestellen, welcher nicht Mitglied des Ver-
waltungsrates sein muss, und welcher für die Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrates und der Hauptversammlung
der Aktionäre, oder der Beschlüsse des alleinigen Aktionärs verantwortlich ist.

(2) Die Sitzungen des Verwaltungsrates werden am Sitz der Gesellschaft gehalten, soweit nicht anders im Einberu-

fungsschreiben mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird durch den Vorsitzenden oder zwei seiner Mitglieder, an dem in dem
Einberufungsschreiben bestimmten Ort einberufen.

(3) Außer in dringenden Fällen, wobei die Art und die Gründe dieser Dringlichkeit im Einberufungsschreiben angegeben

werden müssen, erhält jedes Mitglied des Verwaltungsrates wenigstens vierundzwanzig (24) Stunden vor dem vorgese-
henen Zeitpunkt der Sitzung ein schriftliches Einberufungsschreiben. Auf das Einberufungsschreiben kann schriftlich, durch
Fax, E-Mail, Telegramm oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel verzichtet werden. Für Sitzungen des Ver-
waltungsrates,  die  zu  einer  Zeit  und  an  einem  Ort  abgehalten  werden,  welche  von  einem  vorherigen  Beschluss  des
Verwaltungsrates festgesetzt wurden, ist ein spezielles Einberufungsschreiben nicht erforderlich.

(4) Sind alle Mitglieder des Verwaltungsrates in einer Sitzung anwesend oder vertreten oder im Falle schriftlicher

Beschlüsse, denen alle Verwaltungsratsmitglieder zustimmen und die von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterschrieben
werden, ist keine vorherige Einberufung erforderlich.

(5)  Jedes  Verwaltungsratsmitglied  kann  sich  in  der  Sitzung  des  Verwaltungs-rates  aufgrund  einer  schriftlich,  durch

Faxübertragung, E-Mail, Telegramm oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel erteilten Vollmacht durch ein
anderes Mitglied des Verwaltungsrates vertreten lassen. Ein Verwaltungsratsmitglied kann mehrere andere Verwaltungs-
ratsmitglieder vertreten.

(6) Jedes Verwaltungsratsmitglied kann durch Telefon- oder Videokonferenzschaltung oder durch ein vergleichbares

Kommunikationsmittel an einer Sitzung teilnehmen, vorausgesetzt, dass die Teilnehmer ständig einander hören können
und es eine effektive Teilnahme aller Teilnehmer an der Sitzung erlaubt. Die Teilnahme an einer Sitzung in dieser Weise
entspricht einer persönlichen Teilnahme.

5992

L

U X E M B O U R G

(7) Die Protokolle aller Sitzungen des Verwaltungsrates werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungs-

ratsmitgliedern unterzeichnet. Die Kopien oder Auszüge der Protokolle, die vor Gericht oder anderweitig vorgelegt
werden, werden vom Vorsitzenden oder von zwei (2) Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet.

(8) Der Verwaltungsrat ist nur beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend oder vertreten

ist. Gefasste Beschlüsse werden wirksam mit einfacher Mehrheit der auf der jeweiligen Sitzung anwesenden oder ver-
tretenen Mitglieder des Verwaltungsrates.

(9) Einstimmige Beschlüsse des Verwaltungsrates können auch per Umlaufbeschluss gefasst werden, wenn sie schriftlich

genehmigt und von allen Verwaltungsratsmitgliedern unterzeichnet werden. Diese Genehmigung darf in einem gemein-
samen Dokument oder in mehreren separaten Dokumenten erfolgen, welche per Fax, Email, Telegramm oder Telex
verschickt werden. Diese Beschlüsse haben dieselbe Gültigkeit wie Beschlüsse die auf Sitzungen des Verwaltungsrates
getroffen werden, welche körperlich abgehalten werden.

Kapitel IV. - Hauptversammlung der Aktionäre - Beschlüsse des alleinigen Aktionärs

Art. 10.
(1) Auf der rechtmäßig einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre werden alle Aktionäre vertreten. Sie hat die

weitest gehenden Befugnisse zur Anordnung, Ausführung oder Ratifizierung aller Handlungen im Hinblick auf die Geschäfte
der Gesellschaft.

(2) Im Fall eines alleinigen Aktionärs übt dieser die Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre aus und handelt

entsprechend. Von allen Beschlüsse des alleinigen Aktionärs wird schriftlicher Nachweis erbracht.

Art. 11.
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Verwaltungsrat einberufen.
(2) Sie kann auch auf Antrag von Aktionären, welche wenigstens zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals vertre-

ten, einberufen werden.

(3) Ferner dürfen Aktionäre, die wenigstens 10% des Gesellschaftskapitals halten, die Aufnahme eines oder mehrerer

Punkte auf die Tagesordnung der Hauptversammlung der Aktionäre verlangen. Dieser Antrag muss fünf (5) Tage vor dem
festgesetzten Termin für die Hauptversammlung am Gesellschaftssitz per Einschreiben gestellt werden.

Art. 12.
(1) Die ordentliche Hauptversammlung der Aktionäre findet nach den Bestimmungen des luxemburgischen Rechts

jährlich  am  Sitz  der  Gesellschaft  oder  an  einem  anderen,  in  der  Einladung  bestimmten  Ort  innerhalb  der  Gemeinde
Niederanven, Großherzogtum Luxemburg jeweils am dritten Mittwoch im Monat Juni um 10:30 Uhr, statt. Sollte dieser
Tag kein Bankarbeitstag sein, ist die Hauptversammlung zur gleichen Uhrzeit am nächstfolgenden Bankarbeitstag abzu-
halten. Der Verwaltungsrat kann im Interesse der Gesellschaft diese Hauptversammlung an einem anderen Tag abhalten,
dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Andere ordentliche Hauptversammlungen können an den in den Einberufungsschreiben bestimmten Zeitpunkten

und Orten einberufen werden.

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen können an den in den jeweiligen Einberufungsmitteilungen genannten Or-

ten und Zeiten abgehalten werden.

(4) Für Einberufungsschreiben und die Durchführung der Hauptversammlungen der Aktionäre der Gesellschaft gelten

die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Fristen und Anwesenheitsquoren, soweit diese Satzung keine anderweitigen
Bestimmungen enthält.

(5) Sind alle Aktionäre in einer Hauptversammlung anwesend oder vertreten und erklären sie, die Tagesordnung zu

kennen, so kann die Hauptversammlung ohne vorherige Einberufung abgehalten werden.

Art. 13.
(1) Jede Aktie gewährt eine Stimme. Jeder Aktionär kann sich auf der Hauptversammlung durch einen schriftlich, per

Faxübertragung, E-Mail, Telegramm oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel bevollmächtigten Dritten ver-
treten lassen.

(2) Aktionäre, die an der Hauptversammlung per Telefonkonferenz, Videokonferenzschaltung oder durch ein ver-

gleichbares Kommunikationsmittel teilnehmen, sofern diese Kommunikationsmittel ihre Identifizierung erlauben, gelten
als anwesend bei dieser Hauptversammlung für die Berechnung des Anwesenheitsquorums und der Mehrheiten. Das
verwendete Kommunikationsmittel muss gewährleisten, dass die teilnehmenden Personen einander verstehen können,
und eine ununterbrochene, effektive Teilnahme an der Hauptversammlung erlauben.

(3) Jeder Aktionär ist ermächtigt, mittels eines Stimmzettels, der per Post oder per Fax an den Gesellschaftssitz oder

an die im Einberufungsschreiben angegebene Adresse gesendet wird, an der Wahl teilzunehmen. Die Aktionäre dürfen
nur die von der Gesellschaft ausgegebene Stimmzettel verwenden, auf denen zumindest Ort, Datum und Zeitpunkt, die
Tagesordnung der Hauptversammlung, die zur Entscheidung der Hauptversammlung stehenden Anträge sowie für jeden
Antrag, drei Kästchen, die dem Aktionär, durch Ankreuzen des entsprechenden Kästchens erlauben, dem Antrag zuzus-
timmen, ihn abzulehnen oder sich zu enthalten, enthalten sind.

5993

L

U X E M B O U R G

(4) Stimmzettel, die nicht ausschließlich eine Ja- oder Neinstimme oder eine Enthaltung aufweisen, sind ungültig. Die

Gesellschaft berücksichtigt nur Stimmzettel, die vor dem Termin der entsprechenden Hauptversammlung eingegangen
sind.

(5) Beschlüsse der Hauptversammlung werden im Einklang mit den in Gesetz anwendbaren regeln betreffend Quorum

und Mehrheit gefasst.

Kapitel V. - Geschäftsjahr - Konten - Ertragsverwendung

Art. 14. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar (1.1.) und endet am einunddreißigsten Dezember

(31.12) des gleichen Jahres.

Art. 15.
(1) Es werden jährlich wenigstens fünf Prozent (5%) des möglichen Reingewinnes der Gesellschaft vorab der gesetzlich

vorgeschriebenen Reserve zugeführt bis diese Reserve zu einem Betrag von zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals
angestiegen ist.

(2) Die Generalversammlung oder der alleinige Aktionär beschließt auf Vorschlag des Verwaltungsrates über die Ver-

wendung der restlichen Betrages des Reingewinns.

(3) Der Verwaltungsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Vorschussdividenden ausschütten.

Art. 16.
(1)  Die  Gesellschaft  unterliegt  der  Überwachung  durch  einen  oder  mehrere  Rechnungsprüfer  (commissaire  aux

comptes), die nicht Aktionäre der Gesellschaft sein müssen. Die Funktion des Rechnungsprüfers wird abgeschafft und ein
oder mehrere unabhängige Rechnungsprüfer werden aus den Mitgliedern des Institut des réviseurs d'entreprises durch
die Hauptversammlung gewählt, die auch die Dauer ihres Amtes bestimmt, wenn auf die Gesellschaft die Voraussetzungen
des Artikels 35 für die in Artikel 36 des Gesetzes vom 19. Dezember 2002 über das Handels- und Gesellschaftsregister
und die Buchführung und Bilanzierung von Gesellschaften auf bestimmte Dauer zutreffen.

(2) Die Hauptversammlung ernennt Prüfer, bestimmt ihre Zahl und setzt ihre Vergütung und die Dauer ihres Mandates,

die sechs Jahre nicht überschreiten darf, fest. Die Rechnungsprüfer können mehrmals hintereinander ernannt werden.

Kapitel VI. - Auflösung und Liquidation

Art. 17. Wird die Gesellschaft durch Beschluss der Hauptversammlung aufgelöst, so wird die Liquidierung durch einen

oder mehrere Abwickler, welche natürliche oder juristische Personen sein können, durchgeführt.

Art. 18. Die Hauptversammlung ernennt diese Abwickler und setzt ihre Befugnisse und Vergütung fest.

Kapitel VII. - Anwendbares Recht

Art. 19. Für sämtliche Fragen, welche nicht durch diese Satzung geregelt sind, gelten die Bestimmungen des Gesetzes.

<i>Übergangsbestimmungen

Das erste Geschäftsjahr beginnt mit der Gründung der Gesellschaft und endet am 31. Dezember 2015.

<i>Zeichnung und Einzahlung der Aktien

Alle einunddreißigtausend Aktien (31.000) wurden von SW Equities S.à r.l. gezeichnet. Der Ausgabebetrag aller Aktien

wurde voll in bar eingezahlt, so dass der Gesellschaft ein Betrag in Höhe von einunddreißigtausend Euro (31.000 EUR)
von nun an zur Verfügung steht, was dem unterzeichnenden Notar nachgewiesen wurde

<i>Schätzung der Gründungskosten

Die der Gesellschaft aufgrund ihrer Gründung entstandenen Kosten, Gebühren, Honorare und Auslagen, welche der

Gesellschaft aus Anlass gegenwärtiger Gründung erwachsen, werden auf ungefähr 850 Euro geschätzt.

<i>Erklärung ders Unterzeichners

Der Gesellschafter erklärt hiermit, dass er der dinglich Begünstigte der Gesellschaft, die Gegenstand dieser Urkunde

ist, im Sinne des Gesetzes vom 12. November 2004 in der abgeänderten Fassung, und bescheinigt, dass die Mittel / Güter /
Rechte die das Kapital der Gesellschaft bilden nicht von irgendeiner Tätigkeit, die nach Artikel 506-1 des Strafgesetzbuches
oder Artikel 8-1 des Gesetzes vom 19. Februar 1973 betreffend den Handel von Arzneimitteln und die Bekämpfung der
Drogenabhängigkeit oder einer terroristische Handlung stammen im Sinne des Artikels 135-5 des Strafgesetzbuches (als
Finanzierung des Terrorismus definiert).

<i>Beschlussfassung durch den Alleinigen Aktionär

Die  Erschienene,  welche  das  gesamte  gezeichnete  Gesellschaftskapital  vertritt,  hat  unmittelbar  an  die  Gründung

anschließend folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Geschäftssitz befindet sich in 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.

5994

L

U X E M B O U R G

2. Auditeurs Associés, mit Sitz in L-1840 Luxembourg, 32, Boulevard Joseph II, R.C.S. Luxembourg B 93937, wird als

Rechnungsprüfer (commissaire aux comptes) bis zur Generalversammlung im Jahr 2015 bestellt.

3. Zu den Verwaltungsratsmitgliedern werden folgende Personen für die Dauer von sechs (6) Jahren ernannt:
a. Frau Desirée Eklund, geboren in Krefeld, Germany am 05.07.1969, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, 1736 Sennin-

gerberg, Großherzogtum Luxemburg;

b. Herr Jost Rodewald, geboren in Braunschweig am 30. Mai 1971, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, 1736 Senninger-

berg, Großherzogtum Luxemburg;

c. Frau Silvia Wagner, geboren in Solingen am 3. September 1964, beruflich ansässig in 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg,

Großherzogtum Luxemburg.

<i>Erklärung

Der unterzeichnende Notar bescheinigt, dass die Bedingungen von Artikel 26 des Gesetzes erfüllt sind.
Der unterzeichnete Notar versteht und spricht Englisch und erklärt, dass auf Wunsch des Komparenten gegenwärtige

Urkunde in Deutsch verfasst ist, gefolgt von einer englischen Fassung. Auf Ersuchen derselben Person und im Falle von
Divergenzen zwischen dem deutschen und dem englischen Text, ist die deutsche Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, Errichtet wurde in Ettelbrück, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung des Vorstehenden an die Erschienenen, dem Notar nach Namen, gebräuchlichem Vornamen, Stand

und Wohnort bekannt, haben dieselben gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.

Folgt die englische Fassung des vorstehenden Textes:

In the year two thousand and fourteen, on the fifth of Dezember
Before Maître Pierre PROBST, notary residing at Ettelbrück, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned;

There appeared:

SW Equities S.à r.l., a société à responsabilité limitée, having its registered office at 5, Heienhaff, 1736 Senningerberg,

filed at the Companies and Trade Register of Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg),
Section B, under the number B 191847,

here represented by Mrs Nadine Closter, residing in L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff, Grand-Duchy of Luxembourg,
by virtue of a power of attorney under private seal given on 2. December 2014.
Said power of attorney, having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the under-

signed notary, shall remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

This appearing party, represented as stated above, requests the undersigned notary to state as follows the articles of

association of a public limited liability company (société anonyme), which is hereby incorporated:

ARTICLES OF ASSOCIATION

Chapter I. - Name - Registered Office - Object - Duration

Art. 1. There is formed a public limited liability company (société anonyme) under the name “Renewable Finance

III” (the “Company”), which shall be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law of August 10, 1915,
on commercial companies, as amended from time to time (the “Company Law”), and by the present articles of association
(the “Articles”).

Art. 2.
(1) The registered office of the Company is established in the municipality of Niederanven, Grand Duchy of Luxem-

bourg.

(2) The registered office of the Company may be transferred within the boundaries of the municipality by resolution

of its Board of Directors (as defined in Article 11 of the Articles). In all other respects, the legal provisions relating to
the amendment of the Articles shall apply.

(3) Where the Board of Directors determines that extraordinary political or military developments or events have

occurred or are imminent as determined in the sole discretion of the Board of Directors and that these developments
or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communi-
cation between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the
complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality
of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg in-
corporated company.

(4) Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by

resolution of the Board of Directors.

Art. 3.
(1) The object of the Company is the acquisition of participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or

enterprises in any form whatsoever and the administration, management, control and development of such participations.

5995

L

U X E M B O U R G

(2) The Company may acquire by way of subscription, purchase, exchange or in any other manner any stock, shares

and/or other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit and/or other debt instruments and more
generally any securities and/or financial instruments issued by any public or private entity whatsoever.

(3) The Company may further make direct or indirect real estate investments and invest in the acquisition and man-

agement of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever.

(4) The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue, by way of private placement

only, notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including,
without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated
companies and/or any other companies or persons, and the Company may also give guarantees and pledge, transfer,
encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets in order to guarantee its own
obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company or person, and, generally, for its
own benefit and/or the benefit of any other company or person, in each case to the extent that such activities are not
regulated activities of the financial sector.

(5) The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.

The Company may carry out any activities in relation to the management of any commercial, industrial, financial or other
companies or enterprises, in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

(6) The Company may generally employ any techniques and methods relating to its investments for the purpose of

their efficient management, and may generally carry out any operations and transactions, which directly or indirectly favor
or relate to its object.

Art. 4. The Company is formed for an unlimited duration.

Chapter II. - Share capital - Shares

Art. 5.
(1) The Company's share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000) consisting of thirty-one thousand

(31,000) shares in registered form with no par value, all subscribed and fully paid-up.

(2) The share capital of the Company may be increased or by a resolution of the general meeting of shareholders of

the Company adopted in the manner required for amendments of the Articles.

Art. 6.
(1) The Company may have one or more shareholders.
(2) The shares are and shall remain in registered shares.
(3) With respect to the registered shares, a shareholder register shall be kept at the registered office of the Company

with a content as specified in Article 39 of the Company Law and may be examined by each shareholder upon request.
Entries in the shareholder register definitively determine the attribution of ownership in shares of the Company. At the
request and cost of a shareholder, the Company shall issue share certificates confirming its title thereof.

(4) Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is recognized per share. Joint

co-owners of shares must appoint a sole person as their representative towards the Company.

Chapter III. - Board of Directors - Representation

Art. 7.
(1) The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members (the”Board of

Directors”, each member the “Director), who need not be shareholders of the Company.

(2) As long as the Company has a single shareholder, the number of Directors may be limited to one Director having

the same powers as the Board of Directors.

(3) The general meeting of the shareholders or, as the case may be, the sole shareholder of the Company appoints

the Directors or the sole Director; the general meeting shall also determine their number, their remuneration and the
term of their office.

(4) The term of any individual Director's appointment may not exceed a period of six (6) years from the date of his

appointment, unless otherwise decided by the general meeting and until the appointment of a successor Director.

(5) The general meeting may remove or replace any Director at any time and without any duty to show cause. A

Director may be re-elected.

(6) If a legal entity is appointed as Director of the Company, this entity must designate a permanent representative

who shall represent such legal entity in its duties as Director of the Company. Should the permanent representative be
dismissed, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(7) In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining

Directors may appoint, by a majority vote, a Director to fill such vacancy until the next general meeting of the share-
holders.

5996

L

U X E M B O U R G

Art. 8.
(1) All powers not expressly reserved by the Company Law or the Articles to the general meeting of the shareholders)

fall within the competence of the Board of Directors, which shall have all powers to carry out and approve all acts and
operations consistent with the Company's object.

(2) The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) Directors

or, if only one Director has been appointed, by her/his/its sole signature.

(3) The board of directors is authorized to delegate the day-to-day management of the Company and the power to

represent the Company in respect thereto to one or more directors, officers, or other agents who may, but need not,
be shareholders, acting individually or jointly. If one or several directors have been empowered to represent the Company
with respect to the Company's day-to-day management, the board of directors must report to the annual general meeting
any salary, remuneration and/or other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

(4) The Board of Directors may delegate other special powers or proxies, or entrust limited permanent or temporary

functions to agents or committees of its choice.

Art. 9.
(1) The Board of Directors shall appoint from among its members a chairman who shall preside at the meetings of the

Board of Directors. It may also appoint a secretary, who need not be a Director, who shall be responsible for keeping
the minutes of the meetings of the Board of Directors and the minutes of the general meetings of the shareholders.

(2) The board of directors shall meet as often as the Company's interests so require upon call by the chairman or any

two (2) Directors, at the place indicated in the notice of meeting.

(3) Written notice of any meeting of the Board of Directors, regardless of whether delivered as an original or as a

copy by facsimile or by e-mail, shall be given to all Directors at least twenty-four (24) hours in advance of the date set
for such meeting, except in the case of an emergency meeting, in which case the nature of such circumstances shall be
set forth in the convening notice of the meeting of the Board of Directors. Separate written notice shall not be required
for meetings that are held at times and places designated in a schedule previously adopted by resolution of the board of
directors.

(4) No convening notice is required if all members of the Board of Directors are present or duly represented at the

meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda, of the meeting.

(5) Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing, in writing, regardless of whether

delivered as an original or as a copy by facsimile or by e-mail, another Director as his proxy. A Director may also appoint
another Director as his proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently in writing.

(6) Any Director may participate in any meeting of the Board of Directors by telephone or video conference call or

by any other similar means of communication that allows all the persons taking part in the meeting to identify, hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to in-person participation at
such meeting and a meeting held by way of such means of communication is deemed to be held at the registered office
of the Company.

(7) Resolutions of the Board of Directors shall be recorded in minutes signed by the chairman or any two (2) members

of the Board of Directors. Copies of extracts of the minutes of the Board of Directors or of the circular resolutions,
which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or any two (2) members of
the Board of Directors.

(8) The Board of Directors may validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented.

Resolutions of the Board of Directors are validly taken by a majority of the votes cast

(9) Circular resolutions signed by all the directors shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting

duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution
and may be evidenced by an original or by a copy delivered by facsimile or e-mail.

Chapter IV. - General meeting of shareholders - Resolutions of the sole shareholder

Art. 10.
(1) The general meeting of the shareholders properly constituted represents the entire body of shareholders of the

Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company
within the limits of the Company Law.

(2) To the extent that the Company has a sole shareholder, he shall assume all powers conferred by the Company

Law to the general meeting of the shareholders. Resolutions of the sole shareholder shall be recorded in writing.

Art. 11.
(1) The shareholders of the Company shall meet in general meetings upon the issuance of a convening notice by the

Board of Directors.

(2) One or more shareholders representing at least one tenth (1/10 

th

 ) of the subscribed capital may require the

convening of any general meeting.

5997

L

U X E M B O U R G

(3) One or more shareholders representing at least one tenth (1/10 

th

 ) of the subscribed capital may furthermore

require the entry of one or more items on the agenda of any general meeting in which instance the board of directors
may prepare a supplementary agenda; this request must be addressed to the Company by registered letter at least five
(5) days before the relevant general meeting.

Art. 12.
(1) The annual general meeting of the shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg

at the address of the Company's registered office or at such other place in the municipality of the registered office as
may be specified in the convening notice of general meeting, on the third Wednesday in June of each year at 10:30 a.m.
If such day is not a business day for banks in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the immediately
following business day.

(2) Any other general meeting of shareholders may be held at any other place and at any other time as may be specified

in the convening notice of general meeting.

(3) Extraordinary general meetings of shareholders may be held at any other place and at any other time as may be

specified in the convening notice of general meeting.

(4) For the convening of any general meeting of shareholders and the formalities necessary for admission thereto

reference is made to the provisions of the Company Law for all matters for which no specific provision is made in these
Articles.

(5) If all shareholders are present or represented and consider themselves as being duly convened and informed of

the agenda, the general meeting may take place without notice of the meeting.

Art. 13.
(1) Each share is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by the Company Law. A shareholder may act

at any general meeting of the shareholders by appointing another person (who need not be a shareholder) as his proxy
in writing, whether delivered in original or by facsimile or e-mail.

(2) Each shareholder may also participate at any general meeting of the shareholders by telephone or video conference

call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the general meeting to identify,
hear and speak to each other. The participation in a general meeting by any of these means is deemed equivalent to the
inperson participation by the shareholder at such general meeting.

(3) The shareholders are authorized to cast their vote by way of a ballot sheet provided by the Company. Ballot sheets

contain the date and place of the general meeting of the shareholders, its agenda, and the text of the proposed resolutions,
as well as for each proposed resolution, three boxes allowing the shareholders to vote in favor, against or abstain from
voting on each proposed resolution, together with a reference to the shares for which the shareholder exercises such
right. Shareholders must deliver their completed ballot sheets to the Company at its registered office by mail, facsimile
or e-mail.

(4) Ballot sheets indicating neither a vote (in favor or against the proposed resolutions) nor an abstention shall be void.

The Company will only accept ballot sheets received prior to the time of the general meeting as specified in the convening
notice.

(5) Resolutions of the general meeting of the shareholders are adopted in accordance with the provisions of the

Company Law.

Chapter V. - Financial Year - Annual Accounts - Allocation of profits

Art. 14. The Company's financial year shall begin on the first of January (1.1.) of each year and end on the thirty-first

of December (31.12.) of the same year.

Art. 15.
(1) From the annual net profits of the Company, five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve required by

the Company Law. Such allocation shall cease to be required as soon as the legal reserve amounts to ten percent (10%)
of the Company's share.

(2) The general meeting of the shareholders determines the allocation of any remaining annual net profits by ordinary

resolution.

(3) The Board of Directors may decide to pay interim dividends under the conditions and subject to the limitations of

the Company Law.

Art. 16.
(1) The financial operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors (commissaire(s)

aux comptes) or, to the extent required by Luxembourg law, by one or more external auditors (réviseur(s) d'entreprises).
The auditor(s) (who need not be shareholders and may be physical persons or legal entities) shall be appointed for a term
of not more than six (6) years and shall be eligible for reappointment.

(2) The general meeting of the shareholders appoints the auditor(s) by ordinary resolutions and determines their

number, their remuneration and the term of their office.

5998

L

U X E M B O U R G

Chapter VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 17. The company may be dissolved at any time by decision of the General Meeting, taking the decision according

to the procedures defined for the amendment of the statutes.

Art. 18. During the dissolution of the company, the General Meeting decides on the procedure for liquidation, appoints

one or more liquidators and determines their powers and emoluments.

Chapter VII. - General Provision

Art. 19. Reference is made to the provisions of the Company Law for all matters for which no specific provision is

made in these Articles.

<i>Transitory provision

The first fiscal year shall begin on the date of the incorporation and terminate 31 

st

 of December 2015.

<i>Payment of the shares

All thirty-one thousand (31,000) shares have been subscribed by the sole shareholder SW Equities S.à r.l., prenamed,

and totally paid up so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is from this day on at the free disposal
of the company and proof thereof has been given to the undersigned notary, who expressly attests thereto.

<i>Expenses

The amount of costs, expenses, salaries or charges, in whatever form it may be, incurred or charged to the company

as a result of its formation, is approximately valued at 850 Euros.

<i>Decisions of the sole shareholder

Immediately after the incorporation of the company, the aboved-named shareholder owner took the following reso-

lutions:

1. The registered office is established at L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.
2. To elect Auditeurs Associés, société anonyme, having its registered office at L-1840 Luxembourg, 32, Boulevard

Joseph II, R.C.S. Luxembourg B 93937, as financial controller (commissaire aux comptes) until the general meeting held
in 2015.

3. To appoint as Directors of the Board of Directors for a period of six (6) years:
a. Ms. Desirée Eklund, born in Krefeld, Germany, on the 5 July 1969, having his professional address at 5, Heienhaff,

1736 Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg;

b. Mr. Jost Rodewald, born in Braunschweig, on the 30 May 1971, having his professional address at 5, Heienhaff, 1736

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg;

c. Mr Silvia Wagner, born in Solingen, Germany, on the 3 September 1964, having his professional address at 1736

Senningerberg, Grand-Duchy of Luxembourg.

<i>Declaration

The undersigned notary certifies that the conditions of Article 26 of the Company Law have been satisfied.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing

party, the present deed is worded in German followed by a English translation; on the request of the same appearing
party and in case of divergence between the English and the German text, the German version will be prevailing.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Ettelbrück, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the appearing party, known to the notary, by his surname, Christian name, civil

status and residence, the said appearing party signed together with us, the notary, the present deed.

Signé: Nadine CLOSTER, Pierre PROBST.
Enregistré à Diekirch, Le 10 décembre 2014. Relation: DIE/2014/15986. Reçu soixante-quinze euros 75,00.-€.

<i>Le Receveur (signé): Tholl.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, der Gesellschaft auf Begehr und zum Zwecke der Veröffentlichung im

Memorial erteilt.

Ettelbruck, den 17. Dezember 2014.

Référence de publication: 2014201971/515.
(140225491) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

5999

L

U X E M B O U R G

Gam Consult S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8399 Windhof, 22, rue de l'Industrie.

R.C.S. Luxembourg B 87.819.

L'an deux mille quatorze, le premier décembre.
Par-devant Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage.

S'est réunie

l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "GAM CONSULT S.A." (numéro d’identité

2002 22 16 083), avec siège social à L-8077 Bertrange, 83A, rue de Luxembourg, inscrite au R.C.S.L. sous le numéro B
87.819, constituée suivant acte reçu par le notaire Jean SECKLER, de résidence à Junglinster, en date du 4 juin 2002, publié
au Mémorial C, numéro 1256 du 28 août 2002 et dont les statuts ont été modifiés suivant actes reçus par le prédit notaire
Jean SECKLER, en date du 12 juin 2002, publié au Mémorial C, numéro 1315 du 11 septembre 2002 et en date du 9
décembre 2004, publié au Mémorial C, numéro 303 du 6 avril 2005 et par le notaire instrumentant en date du 18 décembre
2012, publié au Mémorial C, numéro 421 du 20 février 2013 et en date du 7 juin 2013, publié au Mémorial C, numéro
2082 du 27 août 2013.

L'assemblée est présidée par Madame Michèle GRISARD, administrateur de société, demeurant professionnellement

à Steinfort.

La Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Albert DONDLINGER, employé privé, demeurant à Dahlem.
L'assemblée  désigne  comme  scrutateur  Monsieur  Jean-Marie  WEBER,  employé  privé,  demeurant  à  Aix-sur-Cloie/

Aubange (Belgique).

Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:
I.- L'ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
Transfert du siège social à L-8399 Windhof, 22, rue de l’Industrie, Bâtiment W22 et modification subséquente du 1

er

 alinéa de l’article 2 des statuts.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions

qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence signée par les actionnaires, les man-
dataires des actionnaires représentés, le bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte.

Les procurations des actionnaires représentés y resteront annexées de même.
III.- L'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée et tous les actionnaires présents

ou représentés déclarant avoir eu parfaite connaissance de l’ordre du jour avant l’assemblée, il a donc pu être fait abs-
traction des convocations d'usage.

IV.- La présente assemblée, représentant l’intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut valablement

délibérer sur l’ordre du jour.

Ensuite l’assemblée, après délibération, a pris à l’unanimité la résolution suivante:

<i>Résolution.

L'assemblée décide de transférer le siège social à L-8399 Windhof, 22, rue de l’Industrie, Bâtiment W22 et en consé-

quence de modifier le 1 

er

 alinéa de l’article 2 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«  Art. 2. alinéa 1 

er

 .  Le siège social est établi dans la commune de Koerich.»

<i>Frais

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge

en raison des présentes, sont estimés à environ mille euros (€ 1.000.-).

Plus rien n'étant à l’ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Bascharage en l’étude, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite à l’assemblée, les membres du bureau, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms usuels,

états et demeures, ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: GRISARD, DONDLINGER, J-M. WEBER, A. WEBER.
Enregistré à Capellen, le 11 décembre 2014. Relation: CAP/2014/4730. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur ff. (signé): ENTRINGER.

Pour expédition conforme, délivrée à la société sur demande.

Bascharage, le 22 décembre 2014.

Référence de publication: 2014204265/53.
(140227534) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

6000


Document Outline

Gam Consult S.A.

Goodman Arcadia Logistics (Lux) S.à r.l.

Holding Blanc Bleu 5 S.à r.l.

Immo Invest Lux Holdco S.à r.l.

JPY Immo S.à.r.l

KCTG Acquisition Holding 1 S.à.r.l.

KED Holding 1 S.à r.l.

Maroti S.A.

MDC Commercial Finance (Luxembourg) S.à r.l.

Monségur PV Holding S.à r.l.

Nova Participation S.A.

OCM Luxembourg Nordenia OPPS S.à r.l.

OCM Luxembourg Nordenia POF S.à r.l.

Patron Sports Holding S.à r.l.

Penelope Properties S.A.

Phantom Holding S.à r.l.

Phantom S.à r.l.

Phoenix Manufacturing and Trading A.G.

Polma 1 S.A.

Prime Credit 5 S.à r.l.

PSPLUX

QS PDI

Queensgate Carry Partner GP Coop S.A.

Queens International S.A.

Quinta da Murteira S.A.

RDH Investments International S.A.

Regency Internationale S.A., SPF

Renewable Finance III

Rosiris Investment S.A.

RP II S.à r.l.

RP XIV S.àr.l.

RP XVI S.à r.l.

R Wealth Management SICAV SIF

Saw Grass S. à r.l.

S.I.G. Kapital S.A.

Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l.

Star Capital Investments Europe S.à r.l.

TEC S.à r.l.

Telsi S.A.

Thunder Holding S.A., SPF

Tracé s.à r.l.