logo
 

This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.

Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.

Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.

L

U X E M B O U R G

MEMORIAL

Journal Officiel

du Grand-Duché de

Luxembourg

MEMORIAL

Amtsblatt

des Großherzogtums

Luxemburg

R E C U E I L   D E S   S O C I E T E S   E T   A S S O C I A T I O N S

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 110

15 janvier 2015

SOMMAIRE

Binsfeld Immobilière II S.à.r.l.  . . . . . . . . . . .

5272

CAH S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5243

Centre d'Expertise et de Diagnostic Auto-

mobiles Luxembourgeois S.A. . . . . . . . . . .

5234

Century S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5242

CHDA Liegenschaftsverwaltung S.à r.l.  . .

5234

Coffee & More S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5234

Field Conseil S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5268

Glencove S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5280

Graziel S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5268

Graziel S.à.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5268

Helpling Group Holding S.à r.l.  . . . . . . . . . .

5245

Ibralux Holdings 2 S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5242

Idea Legno S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5242

Immobilière N.Y. S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5235

Immo for life . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5235

Import East Solutions S.A.  . . . . . . . . . . . . . .

5242

Institut de Beauté LB S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

5241

ISM Conseil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5274

Itau Active Asset Allocation Funds  . . . . . .

5234

Jalador Holding S.A., SPF  . . . . . . . . . . . . . . .

5235

JAPI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5241

JEMA Beauté Sàrl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5241

Johnson Controls Eastern European Invest-

ment S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5235

Loria International S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5275

LSREF3 Eve Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . .

5276

Montrium Europe S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .

5279

Napoléon International S.A.  . . . . . . . . . . . .

5236

Naviglio Holdings S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . .

5236

Novalis S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5241

NT Human Services Investments S.A.  . . .

5242

Orkor Luxco 2 S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5236

OTMT Acquisition II S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . .

5235

RGI Co-Invest 1 S. à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . .

5240

Roermond S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5238

S & A Capital International S.A.  . . . . . . . . .

5237

Sacramento Resources S.A.  . . . . . . . . . . . . .

5238

Salon Joëlle S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5237

Samaya S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5239

Satisco S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5240

Sea Waves S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5234

Shanila Investments S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .

5240

Sinval S.A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5240

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.  . . . . .

5237

Société de Boulangerie Artisanale au Le-

vain S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5238

Société des Anciens Etablissements AU-

TOCARS EMILE FRISCH  . . . . . . . . . . . . . .

5238

Sommar S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5239

Stafford Sicav  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5236

Sunrise Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5280

Sylvie Becker S.à r.l.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5239

5233

L

U X E M B O U R G

Sea Waves S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.

R.C.S. Luxembourg B 98.540.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

FIDUO

Référence de publication: 2014202018/10.
(140225392) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Centre d'Expertise et de Diagnostic Automobiles Luxembourgeois S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-9227 Diekirch, 50, Esplanade.

R.C.S. Luxembourg B 98.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Diekirch, le 18 décembre 2014.

Signature.

Référence de publication: 2014203073/10.
(140226495) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

CHDA Liegenschaftsverwaltung S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 124.323.

Les  comptes  annuels  de  la  société  pour  l'exercice  clôturé  au  31  décembre  2013  ont  été  déposés  au  registre  de

commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203077/11.
(140226889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Itau Active Asset Allocation Funds, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement

Spécialisé.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 151.002.

Statuts coordonnes déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203270/11.
(140226597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Coffee & More S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-4361 Esch-sur-Alzette, 12, avenue du Rock'n'Roll.

R.C.S. Luxembourg B 167.838.

Le bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

ACA – Atelier Comptable & Administratif S.A.
Signature

Référence de publication: 2014203089/12.
(140227347) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5234

L

U X E M B O U R G

Immo for life, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5252 Sandweiler, 25A, rue Michel Rodange.

R.C.S. Luxembourg B 149.575.

Le bilan au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203264/10.
(140226992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Immobilière N.Y. S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 128.249.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203265/10.
(140226665) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Johnson Controls Eastern European Investment S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 180.646.

Statuts coordonnés, suite à l’assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de rési-

dence à Esch/Alzette, en date du 19 septembre 2014 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 20 octobre 2014.

Référence de publication: 2014203294/11.
(140227107) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Jalador Holding S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-2330 Luxembourg, 128, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 48.893.

Les comptes annuels, les comptes de Profits et Pertes ainsi que les Annexes de l'exercice clôturant au 30/06/2014 ont

été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>L'Organe de Gestion

Référence de publication: 2014203297/11.
(140226468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

OTMT Acquisition II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 164.879.

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale ordinaire de la société en date du 1 

er

 septembre 2014 que

la nomination de la société privée KPMG Audit S.à r.l. ayant son adresse professionnelle au 9, Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg, en tant que réviseur d'entreprises agréé pour l'année fiscale 2014 jusqu'à l'assemblée générale 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg, le 29 octobre 2014.

Référence de publication: 2014203490/12.
(140226493) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5235

L

U X E M B O U R G

Naviglio Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 236.900,00.

Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg B 129.599.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014203456/10.
(140226655) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Napoléon International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1343 Luxembourg, 9, Montée de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 33.360.

Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

NAPOLEON INTERNATIONAL S.A.

Référence de publication: 2014203459/10.
(140226811) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Stafford Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 176.560.

<i>Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Aktionärsversammlung vom 12. November 2014

Die Aktionärsversammlung hat beschlossen, das Mandat des zugelassenen Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises

agréé),  Ernst  &amp;  Young  S.A.,  mit  Sitz  in  7,  rue  Gabriel  Lippmann,  Parc  d'Activité  Syrdall  2,  L-5365  Munsbach.  (R.C.S.
Luxembourg B 47771) bis zur jährlichen ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2015 zu verlängern.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203606/12.
(140227284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Orkor Luxco 2 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.501,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 177.728.

<i>Extrait du procès-verbal du conseil de gérance de la Société en date du 10 décembre 2014

L'associé unique de la Société a décidé de prendre acte de la démission de Monsieur Wang Yong de son poste de

gérant de la Société avec effet au 10 décembre 2014.

L'associé unique de la Société a décidé de nommer Monsieur Chen Chenfang, résidant professionnellement au 37-39

boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, en tant que nouveau gérant de la Société, avec effet au 10 décembre
2014 et pour une durée indéterminée.

Dès lors le conseil de gérance de la Société est composé des personnes suivantes:
- Han Lu
- Chen Chenfang
- Liu Guangcai
Le conseil de gérance de la Société a décidé de transférer le siège social de la société au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

<i>Pour Orkor Luxco 2 S.à r.l.

Référence de publication: 2014203477/22.
(140226355) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5236

L

U X E M B O U R G

Skandinaviska Enskilda Banken S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2370 Howald, 4, rue Peternelchen.

R.C.S. Luxembourg B 10.831.

EXTRAIT

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 décembre 2014, Monsieur Christopher

Malmer avec adresse professionnelle à SE-106 40 Stockholm, 2, Sergels Torg, a été nommé administrateur avec effet au

er

 décembre 2014, date de début de mandat approuvée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Son

mandat expirera lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires à tenir en 2015.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203592/13.
(140226893) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

S &amp; A Capital International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 52.047.

Le siège social de la société anonyme, S &amp; A CAPITAL INTERNATIONAL S.A. dont le siège social était situé à L-1840

Luxembourg, 2a, Boulevard Joseph II, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro R.C.S. B 52.047, a été dénoncé par L'ETUDE DSM DI STEFANO MOYSE Avocats à la Cour avec effet au 18
décembre 2014.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

<i>Pour l'ETUDE DSM DI STEFANO MOYSE Avocats à la Cour
Un mandataire

Référence de publication: 2014203582/14.
(140226802) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Salon Joëlle S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2427 Luxembourg, 1, plateau du Rham.

R.C.S. Luxembourg B 187.149.

<i>Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du du 04 décembre 2014

<i>Première résolution

Le mandat de Madame HAUS Denise gérante technique prend fin; elle est remplacée, pour une durée indéterminée,

par Madame CARBONE Loredana, résidant 11, Rue de la Frontière - F-57540 Petite Rosselle.

<i>Deuxième résolution

Suite à une cession de parts sociales dûment approuvée par les associés et dûment signifiée à la société, le capital social

fixé à 12.500 EUR, représenté par 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, se repartit comme suit:

Monsieur BRAUN Léo
Vingt parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Madame BRAUN Joëlle
Soixante-quinze parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

Madame CARBONE Loredana
Cinq parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Total: cent parts sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 04 décembre 2014.

Salon Joëlle S.à r.l.
Fiduciaire des P.M.E.
Société anonyme
Signature

Référence de publication: 2014203585/27.
(140226814) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5237

L

U X E M B O U R G

Roermond S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 165.012.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203574/9.
(140227313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

SOBAL s.à r.l., Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5442 Roedt, 11, rue du Bassin.

R.C.S. Luxembourg B 20.662.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203598/9.
(140226744) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Sacramento Resources S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 32.180.

En date du 1 

er

 décembre 2014, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social de la Société du 13-15,

Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ce avec effet immédiat.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Signature
<i>Un mandataire

Référence de publication: 2014203610/13.
(140227370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Société des Anciens Etablissements AUTOCARS EMILE FRISCH, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1522 Luxembourg, 5, rue Jules Fischer.

R.C.S. Luxembourg B 9.311.

- FRISCH Joseph, retraité, né à Luxembourg le 16 mars 1942, demeurant à L-5884 Howald, 304 route de Thionville
associé de la Société à responsabilité limitée «Société des anciens établissements Autocars Emile Frisch» a pris acte

de la cession de parts intervenue avec effet au 2 décembre 2014 et déclare son accord quant à cette cession.

M. Joseph FRISCH, détenteur de 10 parts sociales cède 10 de ses parts à la valeur nominale de EUR 2,50 par part

sociale à:

- Monsieur Jean-Claude FRISCH, gérant, né à Luxembourg, le 8 juillet 1969, et demeurant à L-5240 Sandweiler, 12-14,

Rue Principale.

A la suite de cette cession, les 1.000 (mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de EUR 25.000 de

la Société à responsabilité limitée «Société des anciens établissements Autocars Emile Frisch» sont réparties comme suit:

- Emile FRISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 parts

- Guy FRISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

250 parts

- Jean-Claude FRISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

260 parts

- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 parts

Fait à Luxembourg, le 5 décembre 2014.

Jean-Claude FRISCH
<i>Gérant

Référence de publication: 2014203601/23.
(140226422) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5238

L

U X E M B O U R G

Sylvie Becker S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7213 Bereldange, 23, Am Becheler.

R.C.S. Luxembourg B 144.193.

EXTRAIT

Il résulte d'un procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire tenue en date du 11 décembre 2014 que:
- L'assemblée générale décide que Monsieur Alexandrino Alberto Luis, né le 7 juin 1964 à Sao Sebastiao (Portugal),

demeurant à L-7234 Helmsange. 2a, cité John F. Kennedy est nommé en tant que gérant administratif

- L'assemblée générale décide que Madame Becker Sylvie, née le 10 septembre 1971 à Luxembourg, demeurant à

L-7234 Helmsange, 2a, cité John F. Kennedy est nommé en tant que gérant technique

1. L'assemblée générale décide que la société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature unique

du gérant technique ou du gérant administratif jusqu'à un montant de 30.000 EUR. Pour tout montant dépassant 30.000
EUR la signature conjointe du gérant technique et du gérant administratif est requise

Pour extrait sincère et conforme

Référence de publication: 2014203609/17.
(140226985) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Samaya S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2561 Luxembourg, 43, rue de Strasbourg.

R.C.S. Luxembourg B 131.518.

<i>Extrait des résolutions prises par l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière Extraordinaire en date du 06 octobre 2014 au

<i>siège social de la société

1. La démission de la société I.C. Dom-Com S. à r.l, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro RC B133127, et dont le siège social se trouve à L-2562 Luxembourg, 2, Place de Strasbourg, de son poste
de Commissaire aux Comptes est acceptée.

2. Est appelé en remplacement à la fonction de Commissaire aux Comptes, la personne suivante:
Grant Thornton Lux Audit, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro RC

B183652, et dont le siège social se trouve à L-8308 Capellen, 89A, Pafebruch.

Son mandat prendra fin avec l'Assemblée Générale Annuelle de l'an 2019.

Pour extrait sincère et conforme
SAMAYA S.A.

Référence de publication: 2014203611/18.
(140227142) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Sommar S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 192.086.

Il résulte d'un contrat de transfert de parts sociales, signé en date du 12 décembre 2014, que l'associé unique, AIM

Services S.à r.l., a transféré la totalité des 12.500 parts sociales qu'il détenait dans la Société à:

- Hines Luxembourg Master Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée et régie selon les lois du

Grand Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro
B 184846, ayant son siège social à l'adresse suivante: 205, route d'Arlon L-1150 Luxembourg.

La totalité des 12.500 parts sociales de la Société sont désormais détenues par le nouvel associé unique, Hines Lu-

xembourg Master Holdings S.à r.l.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 décembre 2014.

Sommar Sà r.l.
Signature

Référence de publication: 2014203603/19.
(140226517) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5239

L

U X E M B O U R G

Satisco S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1220 Luxembourg, 194, rue de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 110.294.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait à Luxembourg.

Référence de publication: 2014203613/10.
(140226647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

RGI Co-Invest 1 S. à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-2346 Luxembourg, 20, rue de la Poste.

R.C.S. Luxembourg B 130.921.

Les comptes annuels abrégés au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203569/11.
(140226968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Shanila Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5367 Schuttrange, 64, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 172.612.

EXTRAIT

Il résulte d'un contrat de transfert de parts du 17 décembre 2014 que Pavel ROMANOVSKI demeurant au 15-4 Vtoroy

Truzhenikow Pereulok, Moscou, Russie a cédé 6,250 parts sociales qu'il détenait dans Shanila Investments S.à r.l. à David
SHOSTAK demeurant au 322 Vsevolozhysky Pereulok, Moscou, Russie.

Suite à ce transfert, David SHOSTAK détient les 12,500 parts sociales de la Société Shanila Investments S.à r.l
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait sincère et conforme
SHRM Financial Services (Luxembourg) S.A.
<i>Domiciliataire

Référence de publication: 2014203629/16.
(140227375) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Sinval S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 26.541.

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement rendu en date du 4 décembre 2014, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre,

siégeant  en  matière  commerciale,  après  avoir  entendu  le  Juge-Commissaire  en  son  rapport  oral,  le  liquidateur  et  le
Ministère Public en leurs conclusions, déclare closes pour insuffisance d'actif les opérations de liquidation de la société
susmentionnée, ordonne la publication du jugement par extrait au Mémorial et dit que les frais sont à prélever sur l'actif
réalisé, le solde étant à charge du Trésor.

Les livres et les documents sociaux seront déposés et conservés pendant 5 ans au moins au 14, rue du Bois, L-3980

Wickrange.

Pour extrait conforme
Me Isabelle PETRICIC-WELSCHEN
<i>Le liquidateur

Référence de publication: 2014203633/17.
(140226973) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5240

L

U X E M B O U R G

JAPI, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 130.511.

Le bilan et annexes au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203298/9.
(140226926) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

JEMA Beauté Sàrl, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1232 Howald, 90, rue Ernest Beres.

R.C.S. Luxembourg B 85.709.

Les comptes annuels au 18/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203303/9.
(140226724) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Institut de Beauté LB S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-4026 Esch-sur-Alzette, 173, rue de Belvaux.

R.C.S. Luxembourg B 144.791.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203284/9.
(140226645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Novalis S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6794 Grevenmacher, 12, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 143.116.

<i>Auszug aus dem Sitzungsprotokoll der Ordentlichen Generalversammlung vom 9. Mai 2014

Punkt 4 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen die Wiederwahl folgender Personen als Verwaltungsratsmitglieder:
- Herr Roland EBSEN, L-6745 Grevenmacher, 12, Kuschegässel, Verwaltungsratmitglied
- Frau Karla SCHNEIDER, D-54306 Kordel, 3, Auf dem Pfahl, Verwaltungsratmitglied
- Herr Michael SCHNEIDER, D-54306 Kordel, 3, Auf dem Pfahl, Verwaltungsratmitglied
Das Mandat der soeben ernannten Verwaltungsratmitglieder erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die

im Jahre 2020 stattfinden wird.

Punkt 5 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen die Wiederwahl folgender Person als delegiertes Verwaltungsratmitglied:
- Herr Michael SCHNEIDER, D-54306 Kordel, 3, Auf dem Pfahl, delegiertes Verwaltungsratmitglied
Das Mandat des soeben ernannten delegierten Verwaltungsratmitgliedes erlischt mit der ordentlichen Generalver-

sammlung die im Jahre 2020 stattfinden wird.

Punkt 6 der Tagesordnung:
Die Aktionäre beschließen die Wiederwahl der Gesellschaft ACCOUNT DATA EUROPE S.A., mit Sitz in L-6793

Grevenmacher, 77, route de Trèves zum Aufsichtskommissar.

Das Mandat des soeben ernannten Aufsichtskommissars erlischt mit der ordentlichen Generalversammlung die im

Jahre 2020 stattfinden wird.

Für gleichlautenden Auszug
<i>Der Vorsitzende der ordentlichen Generalversammlung

Référence de publication: 2014203469/27.
(140227243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

5241

L

U X E M B O U R G

Idea Legno S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7233 Bereldange, 53, Cité Grand-Duc Jean.

R.C.S. Luxembourg B 105.913.

Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203273/9.
(140226766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Ibralux Holdings 2 S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 152.763.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203272/9.
(140226579) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Import East Solutions S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2449 Luxembourg, 25A, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 94.763.

Le bilan au 31/12/2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2014203278/10.
(140226628) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

NT Human Services Investments S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 98.030.

EXTRAIT

1) En date du 1 

er

 décembre 2014, Monsieur Patrice Gallasin a démissionné de sa fonction d'administrateur de la

Société, NT Human Services Investments S.A.; et

2) En date du 1 

er

 juin 2012, Monsieur Olivier de Mets a démissionné de sa fonction de commissaire aux comptes de

la Société, NT Human Services Investments S.A.

Pour extrait conforme
Patrice Gallasin

Référence de publication: 2014203470/14.
(140227152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Century S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 165.948.

Les statuts coordonnés au 28 novembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxem-

bourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Marc Loesch
<i>Notaire

Référence de publication: 2014203975/12.
(140228484) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 décembre 2014.

5242

L

U X E M B O U R G

CAH S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 12, avenue de la Porte Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 192.848.

STATUTS

L'an deux mille quatorze, le huit décembre.
Par devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg.

ONT COMPARU

1. GAI S.àr.l., une Société à responsabilité limitée dûment établie selon les Lois du Grand Duché de Luxembourg, ayant

son siège social au 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg, sous la section B numéro 58.181,

ici dûment représentée par deux de ses gérants Monsieur Patrice BOUGON et Madame Marion HARTOG-GRAN-

BOULAN; et

2. Monsieur Romain PENINQUE, né le 12 décembre 1980 à Paris (France), demeurant au 20, rue Alphonse de Neuville,

F-75017 Paris,

ici représenté par Monsieur Frédéric TARON, demeurant professionnellement au 12, avenue de la Porte Neuve,

L-2227 Luxembourg, en vertu d’une procuration sous seing (désignés ensemble ci-après comme les «Comparants»).

Laquelle procuration restera, après avoir été signée «ne varietur» par le mandataire des comparants et le notaire

instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisé avec elles.

Lesquels comparants, ès-qualité qu'ils agissent, ont requis le notaire instrumentant de dresser acte d'une société à

responsabilité limitée dont elle a arrêté les statuts comme suit:

Art. 1 

er

 .  Entre les propriétaires des parts ci-après crées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, il est formé

par les présentes une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois en vigueur et notamment par celle du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée par la loi de 1993, ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. La société prend la dénomination de CAH S.à r.l..

Art. 3. Le siège social est fixé à la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il pourra être transféré

en tout autre lieu dans le Grand-Duché de Luxembourg, d’un commun accord entre les associés.

Art. 4. La société a pour objet toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de parti-

cipations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le
développement de ces participations, incluant le financement de participation, ainsi que l’activité de conseil en optimisation.

La société pourra procéder à la gestion de son propre patrimoine immobilier par l’achat, la location, la mise en valeur

et la vente de toutes propriétés et droits immobiliers.

Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d'un

portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au
contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat et de toute
autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d'échange ou autrement, faire mettre en
valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s'intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties.

Elle prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quelconques, qui

se rattachent à son objet ou qui le favorisent.

La société aura tous pouvoirs nécessaires à l’accomplissement ou au développement de son objet, dans le cadre de

toutes activités permises à une Société de Participations Financières.

La  société  pourra  effectuer toutes opérations  commerciales,  industrielles,  immobilières, mobilières et  financières,

pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles d'en faciliter l’ac-
complissement.

Art. 5. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 6. Le capital social est fixé à douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) divisé en douze mille cinq cents (12 500)

parts sociales de valeur nominale d’un euro (1.- EUR) chacune.

Art. 7. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Une cession de parts sociales entre vifs à un tiers non associé ne peut être effectuée que moyennant l’agrément donné

en assemblée générale des associés représentant plus de trois quarts du capital social.

Pour le reste, il est référé aux dispositions des articles 189 et 190 de la loi coordonnée sur les sociétés commerciales.

Art. 8. Le décès, l’interdiction, la faillite de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.

5243

L

U X E M B O U R G

Art. 9. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil

de gérance. Le(s) gérants ne sont pas obligatoirement associés. Le ou les gérants peuvent, même si ce n’est en aucun cas
une obligation, percevoir une rémunération, qui sera alors décidée au cas par cas pour chaque gérant par décision col-
lective des associés, prise à la majorité. Le(s) gérant(s) sont révocables ad nutum par simple décision des associés prise
à la majorité.

Par ailleurs, en cas de pluralité de gérants, les co-gérants devront agir en commun et conjointement pour l’accom-

plissement de leurs actes.

Dans les rapports avec les tiers, le(s) gérant(s) aura(ont) conjointement tous pouvoirs pour agir au nom de la Société

et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l’objet social et pourvu que les termes du présent
article aient été respectés. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l’assemblée générale des associés par la Loi
ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant et en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

Un gérant pourra délivrer à tout autre gérant, une procuration aux fins de le représenter à tout Conseil de gérance.
Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, peut subdéléguer une partie de ses pouvoirs pour

des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents ad hoc ou bien à un gérant.

Le gérant, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera les responsabilités et la rémunération

(s’il en est) de ces agents, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

Les décisions du Conseil, sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion, qui doit être

physiquement présent au Grand-Duché de Luxembourg, ou, si aucun président n’a été nommé, par tous les gérants
présents ou représentés.

Une décision prise par écrit, et notamment par résolution circulaire, approuvée et signée par tous les gérants, produira

effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du Conseil de gérance.

Chacun des gérants peut participer à toute réunion du Conseil de gérance par conférence téléphonique (conference-

call), vidéoconférence, messagerie électronique (e-mails) ou tout autre moyen de communication similaire permettant à
toutes les personnes prenant part à la réunion d’être en mesure de communiquer avec les autres participants. La parti-
cipation à une réunion, par ces moyens, est équivalente à une participation en personne à cette réunion.

Si les gérants sont temporairement dans l’impossibilité d’agir, la société pourra être gérée par l’associé unique ou en

cas de pluralité d’associés, par les associés agissant conjointement.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique, ou bien, en cas de pluralité de gérant, par signature conjointe

de tous les gérants. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui des
pouvoirs spéciaux ont été délégués par le Conseil de gérance.

Art. 10. Les décisions des associés sont prises en assemblée ou par consultation écrite à la diligence de la gérance.

Art. 11. L’année sociale commence le 1 

er

 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

Art. 12. Chaque année au dernier jour de décembre, il sera fait un inventaire de l’actif et du passif de la société, ainsi

qu’un bilan et un compte des pertes et des profits.

Art. 13. En cas de liquidation, chaque associé prélèvera avant tout partage le montant nominal de sa part dans le capital;

le surplus sera partagé au prorata des mises des associés. Si l’actif net ne permet pas le remboursement du capital social,
le partage se fera proportionnellement aux mises initiales.

Art. 14. Au cas où toutes les actions viendraient à être réunies entre les mains d’un seul des actionnaires, la loi sur la

société unipersonnelle s’appliquerait.

Art. 15. Pour tous les points qui ne sont pas réglementés par les statuts, les associés se soumettent à la législation en

vigueur.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2015.

<i>Souscription - Libération

Les Statuts de la Société ayant ainsi été arrêtés, les Comparants préqualifiés déclarent souscrire les douze mille cinq

cents (12.500) parts sociales comme suit:

Associés

Parts sociales :

1. GAI S.àr.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250 parts sociales

2. Monsieur Romain PENINQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.250 parts sociales

Total : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 parts sociales

Les douze mille cinq cents (12.500) parts sociales ont été libérées intégralement par des versements en numéraire de

sorte que la somme de douze mille cinq cents euros (12.500.- EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la
Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire par production d’un certificat émis par la banque.

5244

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Le comparant a évalué le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui

incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution à environ mille quatre cents euros (1.400.-
EUR).

<i>Décisions des associés

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés, représentant l’intégralité du capital social se sont réunis

en assemblée générale et ont pris, à l’unanimité, les décisions suivantes:

1) Le nombre de gérants est fixé à deux (2) et les personnes suivantes sont nommées en tant que gérants de la Société

pour une durée indéterminée:

a) Monsieur Romain PENINQUE, né le 12 décembre 1980 à Paris (France), demeurant au 20, rue Alphonse de Neuville,

F-75017 Paris; et

b) Monsieur Frédéric TARON, né le 13 octobre 1985 à Paris (France), demeurant professionnellement au 12, avenue

de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

2) Le siège social de la Société est établi au 12, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.
Signé: P. Bougon, F. M. Hartog-Granboulan Taron et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2014. LAC/2014/59271. Reçu soixante-quinze euros EUR 75,-

<i>Le Receveur ff. (signée): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, sur papier libre, aux fins de publication

au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201483/130.
(140226037) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Helpling Group Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 184.677.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-eighth day of november,
before us, Maître Marc Loesch, notary, residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

1. Rocket Internet AG (formerly Rocket Internet GmbH), a stock corporation (Aktiengesellschaft) existing under the

laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial register (Handelsregister) at
the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under no. HRB 159634 B, having its business
address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of ten thousand (10,000) common shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 25 November 2014;
2.  Bambino  53.  V  V  UG  (haftungsbeschränkt),  a  limited  liability  company  (Unternehmergesellschaft  (haftungsbes-

chränkt)) existing under the laws of Germany with its statutory seat in Berlin, Germany, registered with the commercial
register at the local court of Charlottenburg (Amtsgericht Charlottenburg), Germany, under number HRB 126893 B,
having its registered address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany,

being the holder of two thousand five hundred (2,500) common shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 25 November 2014;
3. Netris B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands with its registered

office in Schiphol, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register, under no.
60628022, having its business address at Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, the Netherlands,

being the holder of four hundred seventeen (417) series A1 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Schiphol, the Netherlands, on 25 November 2014;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce

5245

L

U X E M B O U R G

et des Sociétés) under number B 176.544, having its registered office at 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach,
Grand Duchy of Luxembourg, and having a share capital of forty-three thousand euros (EUR 43,000),

being the holder of one thousand two hundred fifty (1,250) series A1 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in London, England and Munsbach, Grand Duchy of Luxembourg, on 25

November 2014;

5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), a limited liability company (Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt))

existing under the laws of Germany with its statutory seat in Wehingen, Germany, registered with the commercial register
(Handelsregister) at the local court of Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart), Germany, under no. HRB 733673, having its
business address at Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen, Germany,

being the holder of forty-two (42) series A1 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Berlin, Germany, on 26 November 2014;
6. Kaltroco Limited, a company incorporated in Jersey with registered number 60595, having its business address at

Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,

being the holder of two thousand five hundred (2,500) series A2 shares of the Company,
here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Jersey, on 25 November 2014;
7. Phenomen Ventures LP, a company incorporated under the laws of the Cayman Islands, registration number OG -

66003, having its registered office at 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands, being the
holder of two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares of the Company,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Moscow, Russia on 26 November 2014;
8. Mangrove IV Investments S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated and existing under the laws of the

Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce
et des Sociétés) under number B 189.521, having its registered office at 20 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxem-
bourg, Grand Duchy of Luxembourg (hereinafter the “New Investor”), participating and voting only for purposes of
agenda point 4 et seqq.,

becoming the holder of three thousand three hundred thirty-four (3,334) new created series A4 shares of the Com-

pany,

here represented by Mr Philippe Sylvestre, maître en droit, professionally residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy under private seal given in Luxembourg, Grand duchy of Luxembourg on 26 November 2014.
The said proxies, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing parties and the notary will remain annexed

to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The parties 1., 2., 3., 4., 5., 6. and 7. (the “Existing Shareholders”) are all the shareholders of Helpling Group Holding

S.à r.l. (the “Company”), a société à responsabilité limitée incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy
of Luxembourg, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered
with the Luxembourg Trade and Companies’ Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 184.677
and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary on 7 February 2014, published in the Memorial C, Recueil
des Sociétés et Associations number 1074 dated 28 April 2014. The articles of association were amended for the last
time pursuant to a deed of the undersigned notary on 13 October 2014, not yet published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations.

The Existing Shareholders representing the entire share capital and having waived any notice requirement, the general

meeting of shareholders is regularly constituted and may validly deliberate on the following agenda whereby the New
Investor participates and votes for purpose of agenda point 4 et seqq. only:

<i>Agenda

1. Decision to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company, namely the series A4 shares,

so that the Company will hence have five (5) series of shares, being the common shares (hereinafter “Common Shares”),
the series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”), the series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”), the series
A3 shares (hereinafter the “Series A3 Shares”) and the series A4 shares (hereinafter the “Series A4 Shares”).

2. Acceptance of Mangrove IV Investments S.à r.l., aforementioned, as new shareholder of the Company.
3. Increase of the Company’s share capital by an amount of three thousand three hundred thirty-four euro (EUR 3,334)

so as to raise it from its current amount of eighteen thousand seven hundred ninety-three euro (EUR 18,793) up to
twenty-two thousand one hundred twenty-seven euro (EUR 22,127) by issuing three thousand three hundred thirty-four
(3,334) Series A4 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5246

L

U X E M B O U R G

4. Restatement of the articles of association of the Company in order to reflect the capital increase as per the third

resolution as well as to reflect several amendments to the articles of association following the entry into the capital of
the Company by the New Investor.

5. Miscellaneous.
Having duly considered each item of the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes the following

resolutions:

<i>First resolution

The general meeting of shareholders decides to create one (1) new series of shares in the share capital of the Company,

namely the Series A4 Shares, so that the Company will hence have five (5) series of shares, being the Common Shares,
the Series A1 Shares, the Series A2 Shares, the Series A3 Shares and the Series A4 Shares.

<i>Second resolution

The general meeting of shareholders decides to accept Mangrove IV Investments S.à r.l., aforementioned, as new

shareholder of the Company.

<i>Third resolution

The general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company by an amount of three

thousand three hundred thirty-four euro (EUR 3,334) so as to raise it from its current amount of eighteen thousand
seven hundred ninety-three euro (EUR 18,793) up to twenty-two thousand one hundred twenty-seven euro (EUR 22,127)
by issuing three thousand three hundred thirty-four (3,334) Series A4 Shares with a nominal value of one euro (EUR 1)
each.

<i>Subscription

The three thousand three hundred thirty-four (3,334) Series A4 Shares have been duly subscribed by Mangrove IV

Investments S.à r.l., aforementioned.

<i>Payment

The three thousand three hundred thirty-four (3,334) Series A4 Shares subscribed by Mangrove IV Investments S.à

r.l., aforementioned, represented as stated above, have been entirely paid up through a contribution in cash in an amount
of three thousand three hundred thirty-four euro (EUR 3,334).

The proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.
The contribution in the amount of three thousand three hundred thirty-four euro (EUR 3,334) is entirely allocated to

the share capital.

<i>Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to proceed to a complete restatement of the articles of association of

the Company in order to reflect the capital increase as per the third resolution as well as to reflect several amendments
to the articles of association following the entry into the capital of the Company by the New Investor.

The articles of association of the Company shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered Office

Art. 1. Name. There exists a private limited company (société à responsabilité limitée) under the name Helpling Group

Holding S.à r.l. (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.
2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign

companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and
development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it

holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the
Company.

2.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by

issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

2.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as

the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on
such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial
property rights.

5247

L

U X E M B O U R G

2.5 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities

which it considers useful for the accomplishment of these purposes, in view of its realisation by sale, exchange or other-
wise.

Art. 3. Duration.
3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.
3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered Office.
4.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg.
4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by decision of the board of managers. It

may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by resolution of the shareholders,
adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by resolution

of the board of managers.

4.4 In the event that the board of managers determines that extraordinary political, economic or social circumstances

or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its
registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these ex-
traordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwiths-
tanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. Share capital - Shares

Art. 5. Share Capital.
5.1 The Company’s share capital is set at twenty two thousand one hundred twenty-seven Euros (EUR 22,127.00),

represented by

5.1.1 twelve thousand five hundred (12,500) common shares (hereinafter “Common Shares”) each with a nominal

value of one EUR (EUR 1.00),

5.1.2 one thousand seven hundred nine (1,709) series A1 shares (hereinafter “Series A1 Shares”) each with a nominal

value of one EUR (EUR 1.00),

5.1.3 two thousand five hundred (2,500) series A2 shares (hereinafter “Series A2 Shares”) each with a nominal value

of one EUR (EUR 1.00),

5.1.4 two thousand eighty-four (2,084) series A3 shares (hereinafter “Series A3 Shares”) each with a nominal value of

one EUR (EUR 1.00) and

5.1.5 three thousand three hundred thirty-four (3,334) series A4 shares (hereinafter “Series A4 Shares”, jointly with

the Series A1 Shares, the Series A2 Shares and the Series A3 Shares the "Series A Shares"; the Series A Shares hereinafter
also referred to as “Preferred Shares”).

The rights and obligations attached to the shares shall be identical except to the extent otherwise provided by these

articles of association, any shareholders' agreement or by the Law.

5.2 The Company’s share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders

adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Each of the shareholders Rocket Internet AG (“Rocket”), Netris B.V. (“Eiffel”), JP Ventures UG (haftungsbes-

chränkt)  (“ES”),  Aismare  Lux  Holdings  S.à  r.l.  (“Aismare”),  Kaltroco  Limited  ("Kaltroco"),  Phenomen  Ventures  LP
(“Phenomen”) and/or Mangrove IV Investments S.à.r.l. (“Mangrove”, jointly with Rocket, ES, Eiffel, Aismare, Kaltroco and
Phenomen the “Investors” and each also an “Investor”) shall be entitled to subscribe for such amount of further shares
to be issued in the course of a capital increase implementing an investment offer of a third party (being neither a share-
holder nor a company affiliated to a shareholder within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG)) (a “Third Party Investor”) which has been approved with an Advisory Board Majority (as defined in Article
25.5 below) (such investment being a “Third Party Investment”) - irrespective whether made by the Third Party Investor
or one or more matching shareholders - required to maintain up to its percentage ownership in the Company prior to
such capital increase under the same terms and conditions on which the Third Party Investment is based on. The respective
Investor shall inform the Company by binding declaration within three (3) weeks whether it intends to exercise its right
pursuant to the foregoing sentence of this Article 5.3. This Article 5.3 shall apply mutatis mutandis in case any of the
Investors (or a company affiliated to an Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation
Act (AktG)) subscribe for further shares.

Art. 6. Shares.
6.1 The Company’s share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.
6.2 The shares of the Company are in registered form.
6.3 The Company may have one or several shareholders, with a maximum of forty (40) shareholders.

5248

L

U X E M B O U R G

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of

the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

6.5 The Company may accept contributions without issuing shares or other securities in consideration and may allocate

such contributions to one or more distributable reserves. Decisions as to the use of any such distributable reserves are
to be taken by the shareholder(s) or the manager(s) as the case may be, subject to the Law and these articles of association.

Art. 7. Register of Shares - Transfer of Shares.
7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection

by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Certificates of such registration
may be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall

appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend
the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable among shareholders, subject to the provisions of any shareholders’ agreement

between the shareholders of the Company, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-
along rights or drag-along rights contained in any shareholders’ agreement between the shareholders of the Company.

7.4 Inter vivos, the shares may only be transferred to new shareholders subject to the approval of such transfer given

by a majority vote of seventy five per cent (75%) of the votes of all shareholders of the Company (such majority being a
“Super Majority”) and subject to the provisions of any shareholders’ agreement between the shareholders of the Com-
pany, if any, in particular, any rights of first refusal, rights of pre-emption or tag-along rights or drag-along rights contained
in any shareholders’ agreement between the shareholders of the Company. To the extent that such approval has been
granted, an additional consent to the transfer of shares is not required:

7.4.1 in any case of a Transfer (as defined in Article 8.1 below) or any other disposal of shares by any Investor to a

company affiliated to such Investor within the meaning of sections 15 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG);

7.4.2 in case of a Transfer or any other disposal of shares by any Investor to a company (x) which is directly or indirectly

Controlling, Controlled by or under common Control with (i) this Investor or (ii) by one or more direct or indirect
shareholders of the respective Investor (each a “Controlled Company”), whereas “Control” or “Controlled” or “Con-
trolling” shall mean the direct or indirect domination of the company by way of (a) managing the company as managing
shareholder, (b) holding the majority of shares or (c) holding the majority of voting rights by means of a contractual voting
pool, or (d) the unilateral ability to cause, directly or indirectly, the direction of the management and policies of a person,
whether through the ownership of voting securities or otherwise, or (y) in which the respective Investor or one or more
shareholders of such Investor has a direct or indirect majority shareholding;

7.4.3 in case of a Transfer or any other disposal of shares (i) to a party acquiring shares under the simplified employee

participation agreed upon between the shareholders of the Company in a shareholders' agreement, if any or (ii) to the
Company and/or any Investor pursuant to a call-option under a vesting scheme implemented pursuant to such simplified
employee participation;

7.4.4 in case of any Transfer or any other disposal of shares within the framework of transformation procedures

pursuant to the transformation law of Luxembourg, in particular (but without limitation) a merger of the Company, if the
shareholders of the Company hold more than fifty per cent (50%) in any surviving legal entity after such transformation
procedure.

7.5 In the cases provided for in Articles 7.4.1 through 7.4.4 above, no duties to offer for sale apply, nor do any rights

of first refusal, rights of preemption or tag-along rights or drag-along rights in favour of other shareholders apply.

7.6 Any Transfer or any other disposal of shares shall become effective towards the Company and third parties through

the notification of the Transfer, assignment or any other disposal to, or upon the acceptance of the Transfer, assignment
or any other disposal by the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

7.7 In the event of death, the shares of the deceased shareholder may only be transferred to new shareholders subject

to the approval of such transfer given by a Super Majority (which, for these purposes, shall exclude the shares of the
deceased shareholder). Such approval is, however, not required in case the shares are transferred either to parents,
descendants or the surviving spouse or any other legal heir of the deceased shareholder.

Art. 8. Liquidation and Sale Preferences.
8.1 In case (i) of any Transfer of at least fifty per cent (50%) of all shares in the Company, or a swap or a take-over of

the Company in an economically comparable way in a single or more related transactions or in close time proximity to
one another, or (ii) Transfer of at least 50% of the Company’s Assets or business of the Company, in a single or more
related transactions or (iii) Transfer of a material part of the Company’s Intellectual Property Rights in a single or more
related transactions or (iv) of the liquidation or de facto liquidation of the Company (in particular following an asset deal)
or (v) of any sale or Transfer of shares in the Company either to third parties or other shareholders that would result
in either more than fifty per cent (50%) of the registered share capital or more than fifty per cent (50%) of the voting
rights being owned by the acquiring party/parties (change of control) as a result of one or more related acquisitions (each
of the events described in (i), (ii) and (iii) is hereinafter referred to as a “Liquidity Event”), the proceeds (“Exit Proceeds”)
- subject to Article 8.2 below - will be distributed in accordance with Article 8.3 to the shareholders pro rata to (i) in

5249

L

U X E M B O U R G

case of an asset Transfer, their shareholding in the registered share capital of the Company or (ii) in case of a share
Transfer, the number of shares sold in the Liquidity Event (as applicable).

“Transfer” means, with respect to any asset (including without limitation, shares and Intellectual Property Rights), any

transfer, assignment, sale, pledge, hypothecation, Encumbrance or other disposition of that asset or of any rights or
obligations associated with that asset, whether voluntary or involuntary, including an option to do any of the forgoing.

“Encumbrance”/“Encumbered” means any encumbrance whatsoever, including a mortgage, charge, debenture, pledge,

hypothecation, lien, security interest, title retention, option, right to acquire or purchase, restriction upon sale or transfer,
right of first refusal, right of pre-emption, third party right or interest, claims, trust arrangement, agreement to confer
security, other encumbrance or security interest of any kind or other type of preferential arrangement or any equity or
other restriction or limitation of any nature whatsoever (including, without limitation, a title transfer or retention ar-
rangement, any preliminary agreement or other arrangement to create any of the above) having similar effect.

8.2 On a preferred level (“Preferred Level”), each holder of Series A Shares shall receive an amount equal to its

respective total investment made to acquire its respective Series A Shares held by it (consisting of the nominal amount
of the Series A Shares acquired by that holder and any share premium and/or other capital contribution (account 115)
paid by the respective holder to the Company). If the Exit Proceeds do not suffice for the payments to be made on the
Preferred Level, the Exit Proceeds shall be allocated to each holder of Series A Shares pro rata to the amounts that would
have been allocated to that holder on the Preferred Level if the Exit Proceeds had been sufficient.

8.3 After the payments on the Preferred Level have been made, the remaining Exit Proceeds shall be allocated on a

common level (“Common Level”) to all selling shareholders pro rata to the respective shares disposed of in connection
with the Liquidity Event. Any amounts received by any shareholder on the Preferred Level shall reduce the amount to
be allocated to such shareholder on the Common Level; provided that no shareholder shall be obliged to repay any
amount received on the Preferred Level. Any Exit Proceeds remaining unallocated after allocation under this Article 8.3
shall also be allocated in accordance with this Article 8.3 by applying Article 8.3 repeatedly until all Exit Proceeds have
been allocated to the shareholders. Irrespective of whether or not the sale of shares is made in one or more transactions,
no shareholder shall receive for the sale of all of its shares (and repay any exceeding amount to the other shareholder)
an amount exceeding the higher of (i) its share in the total Exit Proceeds pro rata to the Shares sold or (ii) the amount
of its investment in the Company (payment of purchase price for shelf company, payment of share capital, including
premium, if any, and payments into account 115 of the standard chart of accountants “apport en capitaux propres non
rémunérés par des titres” under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg (additional amounts)) in respect of the
shares sold. If shares in the Company are sold in more than one transaction, no shareholder shall receive less proceeds
than it would have received if the shares in the Company were sold in one transaction.

8.4 The preferred allocation on the Preferred Level applies for the benefit of the respective shareholder so long as

the respective shareholder (including any sales prior to a Liquidity Event) has not yet received the full amount that is to
be allocated to such shareholder according to the Preferred Level.

Art. 9. Redemption of Shares.
9.1 The Company may redeem its own shares. The voting rights of any of its shares held by the Company are suspended,

for as long as they are held by the Company.

9.2 Shares of a shareholder may be redeemed without such shareholder’s consent, if:
9.2.1 insolvency proceedings are opened over the assets of the shareholder or the opening of insolvency proceedings

is rejected for lack of assets;

9.2.2 the share of a shareholder is seized or enforcement proceedings are otherwise initiated against such share and

such enforcement proceedings are not finally closed within two (2) months.

Upon receipt by such shareholder of the declaration of redemption sent by the board of managers, the shares shall

automatically be redeemed without any further action being required. The present articles together with the declaration
of redemption constitute together a valid instrument in writing for the purposes of article 190 of the Law and the Company
hereby acknowledges and accepts the transfer of the shares in such case and undertakes to register the transfer in its
share register and to proceed with the relevant filings required by law.

9.3 If the share is held by several persons, it is sufficient that the ground for redemption exists with respect to one

person; independently of this, several jointly entitled persons can only exercise the shareholders’ rights in a uniform way
through one jointly entitled person to be appointed for this purpose without undue delay after the joint entitlement
arises.

9.4 The board of managers may declare a redemption. The redemption declaration takes effect upon receipt of the

declaration by the shareholder concerned and if a respective shareholders’ resolution is adopted (except in case of Article
9.2 of these articles of association, in which no declaration by the shareholder concerned and no respective shareholders’
resolution is required).

Art. 10. Compensation for Redemption.
10.1 Redemption is made against compensation.

5250

L

U X E M B O U R G

10.2 The compensation consists of a total amount equal to the market value of the redeemed shares. The effective

date is the date before the redemption resolution.

10.3 The compensation for redemption shall be due and payable immediately upon redemption of the shares.
10.4 The withdrawing shareholder shall not be entitled to request the Company to provide security for outstanding

amounts including interest.

10.5 In the event of dispute regarding the amount of the payable compensation for redemption, such compensation is

to be determined by an auditor as expert arbitrator who shall jointly be appointed by the shareholders. If no agreement
is reached, the expert arbitrator shall be selected by the President of the Tribunal d’Arrondissement upon request of a
shareholder or of the Company.

The decision of the expert arbitrator shall be binding. The costs of the expert opinion shall be borne by the Company

and the requesting shareholder in equal parts, the part allocated to such shareholder shall be set off with the compensation
for  redemption  and  the  compensation  for  redemption  shall  be  reduced  accordingly.  The  shareholder  shall  bear  the
remaining costs in case the compensation for redemption does not cover the costs allocated to the shareholder for the
expert opinion.

Art. 11. Request of Assignment in lieu of Redemption.
11.1 The Company may decide that, in lieu of redemption, the shareholder concerned shall transfer the shares to a

person named by the Company (including another shareholder of the Company), including also partial redemption or
partial assignment of the shares to the Company or to a person named by the Company.

11.2 This Article 11 applies with the proviso that the compensation, as provided for in Article 10 of these articles of

association, for the shares to be assigned is owed by the person acquiring the shares and that the Company shall be liable
like a guarantor.

C. Decisions of the shareholders

Art. 12. Collective Decisions of the Shareholders.
12.1 The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by law and by these

articles of association.

12.2 Each shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns.
12.3 In case and as long as the Company has not more than twenty-five (25) shareholders, collective decisions otherwise

conferred on the general meeting of shareholders may be validly taken by means of written resolutions. In such case,
each shareholder shall receive the text of the resolutions or decisions to be taken expressly worded and shall cast his
vote in writing.

12.4 The shareholders’ resolutions are passed in meetings. Unless mandatory law prescribes another form, they can

also be passed outside meetings in writing (including e-mail or fax) or telephone voting if such procedure is requested by
a shareholder and no other shareholder declares its dissent with the procedure within two (2) weeks towards the board
of managers of the Company in written form. If no dissent is declared within the two (2) weeks pursuant to the foregoing
sentence, the votes of the shareholders which are not participating in the voting shall be deemed to be abstention from
voting. Written resolutions must be signed by each shareholder and the written record must be sent to each shareholder
without undue delay. Resolutions not passed in writing must be confirmed in writing. Such confirmation only has decla-
ratory significance.

12.5 Unless a notarial record is made of shareholders’ resolutions, a written record must be made of every resolution

passed at shareholders’ meetings (for purposes of proof, not as a precondition of validity) without undue delay, which
must state the date and form of the resolution passed, the content of the resolution and the votes cast. The written
record must be sent to each shareholder in writing without undue delay.

12.6 In the case of a sole shareholder, such shareholder shall exercise the powers granted to the general meeting of

shareholders under the provisions of section XII of the Law and by these articles of association. In such case, any reference
made herein to the “general meeting of shareholders” shall be construed as a reference to the sole shareholder, depending
on the context and as applicable, and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by
the sole shareholder.

Art. 13. General Meetings of Shareholders.
13.1 Meetings of shareholders may be held at the registered office of the Company or at such place and time as may

be specified in the respective convening notices of meeting.

13.2  The  shareholders’  meeting  is  called  by  registered  letter  (registered  personal  delivery,  registered  delivery  or

registered letter with confirmation of receipt) to each shareholder, stating the place, date, time and agenda, with a period
of notice of at least four (4) weeks for ordinary shareholders’ meetings and at least two (2) weeks for extraordinary
shareholders’ meetings. The period of notice begins to run on the day following postage. The day of the shareholders’
meeting is not counted in the calculation of the period of notice.

13.3 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived convening

requirements, the meeting may be held without prior notice.

5251

L

U X E M B O U R G

13.4 Each shareholder is entitled to be accompanied or represented at the shareholders’ meeting by another share-

holder authorised by a written power of attorney or by a lawyer, tax advisor or auditor under a professional duty of
confidentiality.

13.5 Unless a notarial record is made of the negotiations of the shareholders’ meeting, a written record must be made

concerning the course of the meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity), which must state the place
and date of the meeting, the participants, the items on the agenda, the main content of the negotiations and the share-
holders’ resolutions. The written record must be signed by all shareholders present or represented in the shareholders’
meeting (for purposes of proof, not as a precondition of validity). Each shareholder must be sent a copy of the written
record.

Art. 14. Quorum and Vote.
14.1 Each shareholder is entitled to as many votes as he holds shares.
14.2 A shareholders’ meeting only constitutes a quorum if at least fifty per cent (50%) of the share capital is represented.

Save for a higher majority provided in these articles of association or by Law, collective decisions of the Company’s
shareholders are only validly taken in so far as they are adopted by shareholders holding more than half of the share
capital. If there is no quorum, a new shareholders’ meeting with the same agenda must be called without undue delay in
compliance with Article 13.2. This shareholders’ meeting then shall constitute a quorum regardless of the share capital
represented, if this was pointed out in the notice calling the meeting and the decisions shall be taken at the majority of
the votes cast.

Art. 15. Change of Nationality. The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous

consent.

Art. 16. Amendments of Articles of Association. Any amendment of these articles of association requires the approval

of (i) a majority in number of shareholders (ii) who also constitute a Super Majority, provided that it includes the consent
of all of the Investors. Any amendment of these articles of association that materially or adversely affects the rights of
the holders of Series A Shares require the consent of all of the holders of those Series A Shares.

Art. 17. Shareholders’ Resolutions Requiring Specific Majority.
17.1 Shareholders’ resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and require the

consent of the Advisory Board:

17.1.1 conclusion, amendment and termination of intra-group affiliation agreements (Unternehmensverträge within

the meaning of sections 291 et seqq. German Stock Corporation Act (AktG));

17.1.2 conclusion or amendment of company participations (for the avoidance of doubt, other than by way of disposal

of shares) of any kind including silent partnerships and all agreements by which the other contractual party is granted a
participation in the Company’s profit or any payment that is dependent on the amount of the Company’s profit; this does
not include agreements with shareholders or employees of the Company, including agreements concluded in light of a
prospective status as shareholder or employee, as well as agreements with third parties within the ordinary course of
business, e.g. agreements between the Company and advertising partners.

17.2 Resolutions regarding the following subjects must be taken by a Super Majority and also require the consent of

all of the Investors:

17.2.1 material changes to the business object of the Company or any material modification of the fields of business

of the Company or the termination of existing and commencement of new fields of business;

17.2.2 exclusion of subscription rights in case of capital increases;
17.2.3 acquisition of the Company’s own shares, with the exception of acquisitions in accordance with Article 9.2 and

transfers in accordance with Article 11.1 of these articles of association;

17.2.4 disposition of all Company’s assets or of a significant part of the Company’s assets including the resolution with

respect to the liquidation of the Company;

17.2.5 merger, separation and transformation of the Company.
17.3. Whenever the capital of the company is divided into different classes of shares, the specific rights and obligations

attached to any class may be varied or abrogated with the unanimous consent in writing of the shareholders who hold
all the issued shares of that class.

D. Board of managers

Art. 18. Powers of the Sole Manager - Composition and Powers of the Board of Managers.
18.1 The Company shall be managed by one or several managers. If the Company has several managers, the managers

form a board of managers.

18.2 If the Company is managed by one manager, to the extent applicable and where the term “sole manager” is not

expressly mentioned in these articles of association, a reference to the “board of managers” used in these articles of
association is to be construed as a reference to the “sole manager”.

5252

L

U X E M B O U R G

18.3 The board of managers is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any

actions necessary or useful to fulfil the Company’s corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the
Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

Art. 19. Election, Removal and Term of Office of Managers.
19.1 The manager(s) shall be elected by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration

and term of office.

19.2 The managers shall be elected and may be removed from office at any time, with or without cause.
19.3 The general meeting of shareholders may decide to appoint managers of two (2) different classes, being class A

managers and class B managers. Any such classification of managers shall be duly recorded in the minutes of the relevant
shareholders resolutions and the managers be identified with respect to the class they belong.

Art. 20. Vacancy in the Office of a Manager.
20.1 In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or

otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of
the  replaced  manager by  the remaining managers  until  the next meeting  of shareholders  which  shall  resolve on the
permanent appointment, in compliance with the applicable legal provisions.

20.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company’s sole manager, such vacancy must be filled without undue

delay by the general meeting of shareholders.

Art. 21 Convening Meetings of the Board of Managers.
21.1 The board of managers shall meet upon call by any manager. The meetings of the board of managers shall be held

at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

21.2 Written notice of any meeting of the board of managers must be given to managers at least twenty-four (24)

hours in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the
reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each manager
in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such document being
sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined
in a prior resolution adopted by the board of managers which has been communicated to all managers.

21.3 No prior notice shall be required in case all managers are present or represented at a board meeting and waive

any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of
managers.

Art. 22. Management.
22.1 The board of managers may elect among its members a chairman. It may also choose a secretary, who does not

need to be a manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers.

22.2 The chairman, if any, shall chair all meetings of the board of managers. In his absence, the board of managers may

appoint another manager as chairman pro tempore by vote of the majority of managers present or represented at any
such meeting.

22.3 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing another manager as his proxy either

in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being
sufficient proof thereof. A manager may represent one or more but not all of the other managers.

22.4 Meetings of the board of managers may also be held by conference-call or video conference or by any other

means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis
and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means is equivalent to a
participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

22.5 The board of managers may deliberate or act validly only if at least a majority of the managers are present or

represented at a meeting of the board of managers.

22.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the managers present or represented at such meeting. The chairman,

if any, shall not have a casting vote. In the event, however, the general meeting of shareholders has appointed different
classes of managers (namely class A managers and class B managers) any resolutions of the board of managers may only
be validly taken if approved by the majority of managers including at least one class A and one class B manager (which
may be represented).

22.7 The board of managers may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in

writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each manager may express his consent
separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be
the date of the last signature.

22.8 The managers shall require the consent of the Advisory Board for the legal transactions and measures specified

below. No consent is required if such legal transactions and measures have been precisely defined and have in advance
been approved by an adopted budget with the consent of the Advisory Board:

22.8.1 approval of the annual plan including the budget plan for each following year;

5253

L

U X E M B O U R G

22.8.2 assumption of sureties, guarantees or similar liabilities in excess of an amount of two hundred thousand Euros

(EUR 200,000.00) in the individual case;

22.8.3 futures transactions concerning currencies, securities and exchange-traded goods and rights as well as other

transactions with derivative financial instruments;

22.8.4 granting, introduction and amendment of pension commitments of any kind;
22.8.5 conclusion, amendment or termination of Company collective agreements, works agreements (of substantial

importance) and of general guidelines regarding the Company pension scheme;

22.8.6 institution and termination of legal disputes, including arbitration proceedings, involving a judicial amount in

controversy of more than two hundred thousand Euros (EUR 200,000.00) in the individual case;

22.8.7 transactions of the Company and its investment companies with affiliated legal entities and individuals;
22.8.8 transfer of industrial property rights or documented knowhow by the Company to a third party outside the

ordinary course of business;

22.8.9 appropriation of the annual results; payments of profits to capital reserves or the carrying forward of such

profits to new accounts; increase or reduction of reserves as well as capital increase from company funds;

22.8.10 granting, setting up or amending any employee incentive scheme (including the grant of any share options)

other than the establishment of any simplified employee participation agreed upon between the shareholders of the
Company in a shareholders' agreement, if any.

22.9 If the consent is required as aforesaid for the acquisition, sale or encumbrance of objects, the consent is also

required for the contractual obligation relating thereto. The shareholders’ meeting may by resolution determine further
transactions and measures requiring the consent of the Advisory Board. The Advisory Board may give its consent also
in advance for certain groups and kinds of transactions and measures.

22.10 The shareholders may by shareholders’ resolution adopt rules of procedure for the managers.
22.11 The management shall ensure that, as far as legally possible, the regulations in this Article 22 apply in the same

manner to all related companies in which the Company holds a majority interest, directly or indirectly, at present or in
the future.

Art. 23. Minutes of the Meeting of the Board of Managers; Minutes of the Decisions of the Sole Manager.
23.1 The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman, if any or in his absence by

the chairman pro tempore, and the secretary (if any), or by any two (2) managers. In the event the general meeting of
shareholders has appointed different classes of managers (namely class A managers and class B managers) under the joint
signature of one (1) class A manager and one (1) class B manager (including by way of representation). Copies or excerpts
of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or
by any two (2) managers. In the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers
(namely class A managers and class B managers) under the joint signature of one (1) class A manager and one (1) class B
manager (including by way of representation).

23.2 Decisions of the sole manager shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole manager. Copies or

excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole manager.

Art. 24. Dealing with Third Parties. The Company shall be bound towards third parties in all circumstances (i) by the

signature of the sole manager, or, if the Company has several managers, by the joint signature of any two (2) managers;
in the event the general meeting of shareholders has appointed different classes of managers (namely class A manager
and class B manager), the Company will only be validly bound by the joint signature of at least one (1) class A manager
and one (1) class B manager (including by way of representation) or (ii) by the joint signatures or the sole signature of
any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of managers within the limits of such
delegation.

Art. 25. Advisory Board.
25.1 The Company has set up an advisory board (the “Advisory Board”). It consists of seven (7) voting members. The

shareholders may by way of unanimous shareholders’ consent increase or decrease the number of voting members of
the Advisory Board.

25.2 The shareholders’ shall only set and/or amend rules of procedure for the Advisory Board by way of unanimous

shareholders’ consent.

25.3 The voting members of the Advisory Board shall be nominated, withdrawn or replaced by each member’s res-

pective appointing shareholder by written notification towards the Company as follows:

25.3.1 four (4) voting members of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Rocket (“Rocket Mem-

bers”) in its sole discretion;

25.3.2 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Aismare (“Aismare Mem-

ber”) in its sole discretion;

25.3.3 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Phenomen (“Phenomen

Member”) in its sole discretion; and

5254

L

U X E M B O U R G

25.3.4 one (1) voting member of the Advisory Board shall be nominated by the shareholder Mangrove (“Mangrove

Member”) in its sole discretion.

25.4 Each Investor other than those entitled to appoint a voting member of the Advisory Board pursuant to Article

25.3 shall be entitled to appoint a non-voting member to the Advisory Board as an observer.

25.5 The Advisory Board shall have a chairman and a deputy chairman yet none of them shall have a casting vote and/

or any additional right and/or authority differing from the other members of the Advisory Board. One of the Rocket
Members shall be the chairman of the Advisory Board. The rules of procedure of the Advisory Board may provide for
further provisions in particular on the self-organization of the Advisory Board. Subject to any consents or approvals
otherwise required under these Articles and/or any shareholders’ agreement with respect to the Company, if any, the
Advisory Board shall adopt resolutions with the simple majority of votes cast, provided that it includes (i) the affirmative
vote of the Aismare Member, the Phenomen Member or the Mangrove Member (the „Advisory Board Majority“) or (ii)
for certain measures required under a shareholders’ agreement, the affirmative vote of two (2) of the Aismare Member
and/or the Phenomen Member and/or the Mangrove Member or any further member of the Advisory Board nominated
after the date hereof (the “Qualified Advisory Board Majority”). The Advisory Board shall hold meetings on a regular
basis, at least once every calendar quarter.

25.6 In addition to any consents or approvals otherwise required under these Articles and/or any shareholders’ agree-

ment with respect to the Company, if any, the Advisory Board has a consultative function and will not interfere in the
management of the Company.

25.7 The Advisory Board is not a supervisory board within the meaning of article 60bis-11 et seq. of the Law.

E. Audit and supervision

Art. 26. Auditor(s).
26.1 In case and as long as the Company has more than twenty-five (25) shareholders, the operations of the Company

shall be supervised by one or several internal auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint
the internal auditor(s) and shall determine their term of office.

26.2 An internal auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting

of shareholders.

26.3 The internal auditor has an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.
26.4 If the shareholders of the Company appoint one or more independent auditors (réviseur(s) d’entreprises agréé

(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies’ register and the
accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of internal auditor(s) is suppressed.

26.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with its

approval.

F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends

Art. 27. Financial Year. The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end

on the thirty-first of December of the same year.

Art. 28. Annual Accounts and Allocation of Profits.
28.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of managers draws up an inventory of

the Company’s assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

28.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve.

This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten
per cent (10%) of the share capital of the Company.

28.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the

contributing shareholder agrees with such allocation.

28.4 In case of a share capital reduction, the Company’s legal reserve may be reduced in proportion so that it does

not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

28.5 Upon recommendation of the board of managers, the general meeting of shareholders shall determine how the

remainder of the Company’s annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

28.6 Subject to Article 8, distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of shares they

hold in the Company.

Art. 29. Interim Dividends - Share Premium and Assimilated Premiums.
29.1 The board of managers may decide to pay interim dividends on the basis of interim financial statements prepared

by the board of managers showing that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed shall
be allocated where applicable - in accordance with the provisions of Article 8 - and may not exceed realized profits since
the end of the last financial year, increased by profits carried forward and distributable reserves, but decreased by losses
carried forward and sums to be allocated to a reserve which the Law or these articles of association do not allow to be
distributed.

5255

L

U X E M B O U R G

29.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the share-

holders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these articles of

association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting
of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless other-
wise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the
liabilities of the Company.

H. Final clause - Governing law

Art. 31. Governing Law.
31.1 All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law and any

shareholders’  agreement  with  respect  to  the  Company  which  may  be  entered  into  from  time  to  time  between  the
shareholders and the Company, and which may supplement certain provisions of these articles. Where any matter con-
tained in these articles conflicts with the provisions of any shareholders’ agreement with respect to the Company, such
shareholders’ agreement shall prevail inter partes and to the extent permitted by Luxembourg law.

31.2 These articles are worded in English followed by a German translation; in case of divergence between the English

and the German text, the English version shall prevail.”

<i>Costs and expenses

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are

estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).

Whereof, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this docu-

ment.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties,

the present deed is worded in English followed by a German translation; on the request of the same appearing parties
and in case of divergence between the English and the German text, the English version will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, known to the notary by name, first name

and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendvierzehn, am achtundzwanzigsten November,
vor uns, dem unterzeichnenden Notar Marc Loesch, mit Amtssitz in Bad-Mondorf, Großherzogtum Luxemburg:

SIND ERSCHIENEN:

1. Rocket Internet AG (vormals Rocket Internet GmbH), eine Aktiengesellschaft bestehend unter deutschem Recht

mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  Berlin,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts  Charlottenburg,
Deutschland, unter der Nummer HRB 159634 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zehntausend (10.000) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg, gemäß einer Vollmacht

vom 25. November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;

2. Bambino 53. V V UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter

deutschem Recht mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts
Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 126893 B, mit Sitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland,

Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Stammanteilen der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
3.  Netris  B.V.,  eine  Gesellschaft  (Besloten  Vennootschap)  nach  dem  Recht  der  Niederlande,  mit  Sitz  in  Schiphol,

Niederlande, eingetragen im Handelsregister des Dutch Trade Register unter der Nummer 60628022, mit Geschäftssitz
in Schiphol Boulevard 127, 1118BG Schiphol, Niederlande,

Inhaber von vierhundertsiebzehn (417) Anteilen der Serie A 1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. November 2014, ausgestellt in Schiphol, Niederlande;
4. Aismare Lux Holdings S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société a responsabilité limitée) gegründet

und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesell-
schaftsregister unter der Nummer B 176.544, mit Sitz in 6C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach, Großherzogtum
Luxemburg, mit einem Gesellschaftskapital von dreiundvierzigtausend Euro (EUR 43.000),

Inhaber von tausendzweihundertfünfzig (1.250) Anteilen der Serie A 1 der Gesellschaft,

5256

L

U X E M B O U R G

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. November 2014, ausgestellt in London, England und in Luxemburg,

Großherzogtum Luxemburg;

5. JP Ventures UG (haftungsbeschränkt), eine Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) bestehend unter deutsch-

em  Recht  mit  satzungsmäßigem  Sitz  in  Wehingen,  Deutschland,  eingetragen  im  Handelsregister  des  Amtsgerichts
Stuttgart, Deutschland, unter der Nummer HRB 733673, mit Geschäftssitz in Gosheimer Straße 48, 78564 Wehingen,
Deutschland,

Inhaber von zweiundvierzig (42) Anteilen der Serie A 1 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. November 2014, ausgestellt in Berlin, Deutschland;
6. Kaltroco Limited, eine Gesellschaft gegründet in Jersey, eingetragen unter der Nummer 60595, mit Geschäftssitz in

Floor One, Liberation Station, Esplanade, St Helier, Jersey, JE2 3AS,

Inhaber von zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A 2 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 25. November 2014, ausgestellt in Jersey;
7.Phenomen Ventures LP, eine Gesellschaft gegründet unter dem Recht der Kaimaninseln, Eintragungsnummer OG -

66003, mit Sitz in 89, Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Kaimaninseln,

Inhaber von zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A 3 der Gesellschaft,
hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. November 2014, ausgestellt in Moskau, Russland;
8.  Mangrove  IV  Investments  S.à  r.l.,  eine  Gesellschaft  mit  beschränkter  Haftung  (société  a  responsabilité  limitée),

gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und
Gesellschaftsregister unter der Nummer B 189.521, mit Sitz in 20, Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg, (nachfolgend der „Neue Gesellschafter“), ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung
teilnahme- und stimmberechtigt,

zukünftiger Inhaber von dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der neu geschaffenen Serie A 4 der

Gesellschaft,

hier vertreten durch Herrn Philippe Sylvestre, maître en droit, geschäftsansässig in Luxemburg,
gemäß einer privatschriftlichen Vollmacht vom 26. November 2014, ausgestellt in Luxemburg, Großherzogtum Lu-

xemburg.

Besagte Vollmachten, welche von dem Bevollmächtigten der erschienenen Parteien und dem Notar ne varietur para-

phiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Die Parteien 1., 2., 3., 4., 5., 6. und 7. (die „Bestehenden Gesellschafter“) sind alle Gesellschafter der Helpling Group

Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), ge-
gründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg,
Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et
des Sociétés) unter der Nummer B 184.677, gegründet am 7. Februar 2014 gemäß einer Urkunde des unterzeichnenden
Notars, welche am 28. April 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nummer 1074 veröffentlicht
wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt geändert am 13. Oktober 2014 gemäß einer Urkunde des unter-
zeichnenden Notars, welche noch nicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations veröffentlicht wurde.

Da die Bestehenden Gesellschafter das gesamte Gesellschaftskapital vertreten und auf jegliche Ladungsformalitäten

verzichtet haben, ist die Gesellschafterversammlung ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über die
folgende Tagesordnung verhandeln, wobei der Neue Investor ausschließlich für die Punkte 4 ff. der Tagesordnung teil-
nahme- und stimmberechtigt ist:

<i>Tagesordnung

1. Beschluss bezüglich der Schaffung einer (1) neuen Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft, und

zwar der Anteile der Serie A 4, sodass die Gesellschaft nunmehr fünf (5) Anteilsklassen hat, bestehend aus Stammanteilen
(die „Stammanteile“), Anteilen der Serie A 1 (die „Anteile der Serie A 1“), Anteilen der Serie A 2 (die „Anteile der Serie
A 2“), Anteilen der Serie A 3 (die „Anteile der Serie A 3“) und Anteilen der Serie A 4 (die „Anteile der Serie A 4“).

2. Aufnahme von Mangrove IV Investments S.à r.l., vorbenannt, als neuer Gesellschafter der Gesellschaft.
3. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von achtzehntausendsiebenhun-

dertdreiundneunzig Euro (EUR 18.793) um einen Betrag von dreitausenddreihundertvierunddreißig Euro (EUR 3.334) auf
einen Betrag von zweiundzwanzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 22.127) durch die Ausgabe von drei-
tausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A 4 mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

4. Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapitalerhöhung gemäß des dritten Beschlusses, sowie weitere

Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch den Neuen Investor wiederzugeben.

5. Verschiedenes.

5257

L

U X E M B O U R G

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Gesellschafterversammlung einstimmig die fol-

genden Beschlüsse:

<i>Erster Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, eine (1) neue Serie von Anteilen im Gesellschaftskapital der Gesellschaft

zu schaffen, und zwar die Anteile der Serie A4, sodass die Gesellschaft nunmehr fünf (5) Anteilsklassen hat, bestehend
aus Stammanteilen, die Anteile der Serie A1, die Anteile der Serie A2, die Anteile der Serie A3 und Anteilen der Serie A
4.

<i>Zweiter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, Mangrove IV Investments S.à r.l., vorbenannt, als neuen Gesellschafter der

Gesellschaft anzunehmen.

<i>Dritter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von

achtzehntausendsiebenhundertdreiundneunzig Euro (EUR 18.793) um einen Betrag von dreitausenddreihundertvierundd-
reißig Euro (EUR 3.334) auf einen Betrag von zweiundzwanzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 22.127)
durch die Ausgabe von dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteilen der Serie A 4 mit einem Nominalwert von
je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

<i>Zeichnung

Die dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteile der Serie A 4 wurden ordnungsgemäß von Mangrove IV

Investments S.à r.l., vorbenannt, vertreten wie vorgenannt, gezeichnet.

<i>Zahlung

Die von Mangrove IV Investments S.à r.l., vorbenannt, gezeichneten dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334)

Anteile der Serie A 4 wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in Höhe von dreitausenddreihundertvierundd-
reißig Euro (EUR 3.334).

Der Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde dem unterzeichnenden Notar

erbracht.

Die Einlage in Höhe von dreitausenddreihundertvierunddreißig Euro (EUR 3.334) wird vollständig dem Gesellschafts-

kapital zugeführt.

<i>Vierter Beschluss

Die Gesellschafterversammlung beschließt eine vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft, um die Kapital-

erhöhung gemäß des dritten Beschlusses, sowie weitere Änderungen der Satzung nach der Kapitaleinlage durch den Neuen
Investor wiederzugeben.

Die Satzung der Gesellschaft lautet nunmehr wie folgt:

„A. Name - Zweck Dauer - Sitz

Art. 1 Name. Es besteht eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) mit dem Namen

Helpling Group Holding S.à r.l. (die „Gesellschaft”), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über
Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.
2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Ge-

sellschaften, sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung
oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung,
Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder

Rechte jeglicher Art hält oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören Garantien geben,
Sicherheiten einräumen, Kredite gewähren oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann, außer im Wege eines öffentlichen Angebotes, in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere

durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und
Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.4 Der Zweck der Gesellschaft ist auch (i) der Erwerb durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die

Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten, (ii)
die Erteilung von Lizenzen bezüglich solchem geistigem Eigentum und solcher gewerblicher Schutzrechte, und (iii) das
Innehaben und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

5258

L

U X E M B O U R G

2.5 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller und finanzieller Natur, sowie

solche, welche geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke
förderlich erscheinen, im Hinblick auf deren Verwertung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art.

Art. 3. Dauer.
3.1 Die Gesellschaft wird für unbegrenzte Dauer gegründet.
3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung aufgelöst werden,

welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.
4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg.
4.2 Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Rates der Geschäftsführer

verlegt werden. Durch einen Gesellschafterbeschluss, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und
Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.3 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Rates der Geschäftsführer im

Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

4.4 Sollte der Rat der Geschäftsführer entscheiden, dass außergewöhnliche politische, wirtschaftliche oder soziale

Entwicklungen aufgetreten sind oder unmittelbar bevorstehen, welche die gewöhnlichen Aktivitäten der Gesellschaft an
ihrem  Gesellschaftssitz  beeinträchtigen  könnten,  so  kann  der  Gesellschaftssitz  bis  zur  endgültigen  Beendigung  dieser
außergewöhnlichen Umstände vorübergehend ins Ausland verlegt werden; solche vorübergehenden Maßnahmen haben
keine Auswirkungen auf die Nationalität der Gesellschaft, die trotz vorübergehender Verlegung des Gesellschaftssitzes
eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.

B. Gesellschaftskapital - Anteile

Art. 5. Gesellschaftskapital.
5.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft beträgt zweiundzwanzigtausendeinhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR

22.127,00), bestehend aus

5.1.1 zwölftausendfünfhundert (12.500) Stammanteilen (die „Stammanteile”) mit einem Nominalwert von je einem

Euro (EUR 1),

5.1.2 tausendsiebenhundertneun (1.709) Anteilen der Serie A1 (die „Anteile der Serie A1“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1),

5.1.3 zweitausendfünfhundert (2.500) Anteilen der Serie A2 (die „Anteile der Serie A2“) mit einem Nominalwert von

je einem Euro (EUR 1),

5.1.4 zweitausendvierundachtzig (2.084) Anteilen der Serie A3 (die „Anteile der Serie A3“) mit einem Nominalwert

von je einem Euro (EUR 1),

5.1.5 dreitausenddreihundertvierunddreißig (3.334) Anteile der Serie A4 (die „Anteile der Serie A4“, gemeinsam mit

den Anteilen der Serie A1, den Anteilen der Serie A2 und den Anteilen der Serie A3 die „Anteile der Serie A“; die Anteile
der Serie A im Folgenden auch die „Vorzugsanteile“).

Die mit den Anteilen verbundenen Rechte und Pflichten sind identisch, es sei denn, es wird in dieser Satzung, in einer

Gesellschaftervereinbarung oder durch das Gesetz von 1915 etwas Gegenteiliges bestimmt.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Gesellschafterversammlung, welcher in der für eine Sat-

zungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Jeder der Gesellschafter Rocket Internet AG („Rocket“), Netris B.V. („Eiffel“), JP Ventures UG (haftungsbeschränkt)

(„ES“), Aismare Lux Holdings S.à r.l. („Aismare“), Kaltroco Limited („Kaltroco“), Phenomen Ventures LP („Phenomen“),
und/oder Mangrove Investments S.à r.l. („Mangrove“, gemeinschaftlich mit Rocket, ES, Eiffel, Aismare, Kaltroco und Phe-
nomen die „Investoren“ und jeweils ein „Investor“) ist zur Zeichnung einer Anzahl weiterer bei einer Kapitalerhöhung
ausgegebener Anteile berechtigt, wodurch ein Investmentangebot eines Dritten umgesetzt wird (bei dem es sich weder
um einen Gesellschafter, noch um eine mit einem Gesellschafter verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des
deutschen Aktiengesetzes (AktG) (ein „Drittinvestor“) handelt), der mit einer Mehrheit des Beirats (wie in Artikel 25.5
definiert) zugestimmt wurde (wobei eine solche Investition als „Investition eines Dritten“ bezeichnet wird) -unabhängig
davon, ob diese vom Drittinvestor oder von einem oder mehreren vergleichbaren Gesellschaftern erfolgte - und die zur
Erhaltung der Beteiligungsquote an der Gesellschaft vor einer solchen Kapitalerhöhung erforderlich ist, und dies zu den-
selben  Bedingungen,  wie  bei  einer  Investition  eines  Dritten.  Der  jeweilige  Investor  hat  die  Gesellschaft  durch  eine
verbindliche Erklärung innerhalb von drei (3) Wochen darüber zu unterrichten, ob er sein Recht gemäß des vorstehenden
Satzes dieses Artikels 5.3 ausüben möchte. Dieser Artikel 5.3 ist für den Fall, dass einer der Investoren (oder eine mit
einem Investor im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) verbundene Gesellschaft) weitere Anteile
zeichnet, entsprechend anwendbar.

Art. 6. Anteile.
6.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Anteile mit jeweils dem gleichen Nominalwert aufgeteilt.

5259

L

U X E M B O U R G

6.2 Die Anteile der Gesellschaft sind Namensanteile.
6.3 Die Gesellschaft kann einen oder mehrere Gesellschafter haben, wobei deren Anzahl vierzig (40) nicht über-

schreiten darf.

6.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs oder die Insol-

venz oder ein vergleichbares, einen Gesellschafter betreffendes Ereignis, aufgelöst.

6.5 Die Gesellschaft kann Einlagen ohne Ausgabe von Anteilen oder anderen Sicherheiten als Gegenleistung annehmen

und diese einer oder mehreren ausschüttbaren Rücklagen zuführen. Entscheidungen bezüglich der Verwendung solcher
ausschüttbarer Rücklagen werden gegebenenfalls von dem(den) Gesellschafter(n) oder Geschäftsführer(n) unter Berück-
sichtigung des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung getroffen.

Art. 7. Anteilsregister - Übertragung von Anteilen.
7.1 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Anteilsregister geführt, welches von jedem Gesellschafter eingesehen werden

kann. Dieses Anteilsregister enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Auf Ersuchen und auf
Kosten des betreffenden Gesellschafters kann die Gesellschaft Zertifikate über die Eintragung ausgeben.

7.2 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Anteil an. Sofern ein Anteil von mehreren Personen gehalten

wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einem derartigen Anteil auszusetzen, bis eine Person als
Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.3 Die Anteile sind zwischen den Gesellschaftern frei übertragbar, vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaf-

tervereinbarungen zwischen den Gesellschaftern der Gesellschaft, sofern vorhanden, insbesondere vorbehaltlich Vor-
kaufsrechten, Bezugsrechten oder Mitverkaufsrechten- oder Pflichten aus Gesellschaftervereinbarungen zwischen den
Gesellschaftern der Gesellschaft übertragen werden.

7.4 Inter vivos dürfen die Anteile neuen Gesellschaftern nur vorbehaltlich der Zustimmung einer Mehrheit von fünf-

undsiebzig Prozent (75%) der Stimmen aller Gesellschafter der Gesellschaft (wobei eine solche Mehrheit als „Qualifizierte
Mehrheit“ bezeichnet wird) und vorbehaltlich der Bestimmungen von Gesellschaftervereinbarungen zwischen den Ge-
sellschaftern  der  Gesellschaft,  sofern  vorhanden,  insbesondere  vorbehaltlich  Vorkaufsrechten,  Bezugsrechten  oder
Mitverkaufsrechten-  oder  Pflichten  aus  Gesellschaftervereinbarungen  zwischen  den  Gesellschaftern  der  Gesellschaft
übertragen werden. Sofern eine solche Zustimmung erteilt wurde, ist eine weitere Einwilligung zur Übertragung von
Anteilen nicht erforderlich:

7.4.1 bei einer Übertragung (wie in Artikel 8.1 definiert) oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an

eine mit dem betreffenden Investor verbundene Gesellschaft im Sinne der §§ 15 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG);

7.4.2 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung durch einen Investor an eine Gesellschaft, (x) welche

direkt oder indirekt (i) diesen Investor oder (ii) einen oder mehrere direkte oder indirekte Gesellschafter des betreff-
enden Investors (jeweils eine „Kontrollierte Gesellschaft“) Kontrolliert, von diesem Kontrolliert Wird, oder unter der
gemeinsamen Kontrolle von diesem steht, wobei die Worte „Kontrolle“ oder „Kontrolliert Wird“ oder „Kontrolliert“
die direkte oder indirekte Beherrschung der Gesellschaft bezeichnet, durch (a) die Leitung der Gesellschaft als geschäfts-
führender Gesellschafter, (b) das Halten der Mehrheit der Anteile oder (c) das Halten der Mehrheit der Stimmrechte
durch eine vertragliche Stimmvereinbarung, oder (d) die einseitige Fähigkeit, direkt oder indirekt die Leitung der Ge-
schäftsführung und Handlungsweisen einer Person, entweder durch das Halten stimmberechtigter Wertpapiere oder
anderweitig, zu beeinflussen, oder (y) in welcher der betreffende Investor oder einer oder mehrere Gesellschafter dieses
Investors eine direkte oder indirekte Mehrheitsbeteiligung haben;

7.4.3 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung (i) an einen Dritten, welcher Anteile unter einer,

sofern von den Gesellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung beschlossen, vereinfachten Mitar-
beiterbeteiligung erwirbt, oder (ii) an die Gesellschaft und/oder einen beliebigen Investor gemäß einer Call-Option im
Zusammenhang  mit  einer  Vesting-Regelung,  die  gemäß  einer  solchen  vereinfachten  Mitarbeiterbeteiligung  eingeführt
wurde;

7.4.4 bei einer Übertragung oder jeglichen anderen Veräußerung im Rahmen von Umwandlungsvorgängen gemäß des

Umwandlungsrechts Luxemburgs, insbesondere (jedoch nicht beschränkt auf) eine Verschmelzung der Gesellschaft, so-
fern die Gesellschafter der Gesellschaft nach einem solchen Umwandlungsvorgang mehr als fünfzig Prozent (50%) an einer
überlebenden juristischen Person halten.

7.5 In den in Artikel 7.4.1 bis 7.4.4 vorgesehenen Fällen gelten weder Verpflichtungen zu Verkaufsangeboten, noch

Vorkaufsrechte, Bezugsrechte oder Mitverkaufsrechte- oder Pflichten zugunsten anderer Gesellschafter.

7.6 Eine Übertragung oder jegliche andere Veräußerung wird gegenüber der Gesellschaft und Dritten gemäß Artikel

1690 des Code Civil wirksam, nachdem die Gesellschaft von der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung in
Kenntnis gesetzt wurde oder der Übertragung, Abtretung oder anderen Veräußerung zugestimmt hat.

7.7 Im Todesfall dürfen die Anteile des verstorbenen Gesellschafters nur an neue Gesellschafter übertragen werden,

wenn einer solchen Übertragung mit einer Qualifizierten Mehrheit zugestimmt wird (wobei die Anteile des verstorbenen
Gesellschafters für diese Zwecke nicht berücksichtigt werden). Eine derartige Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn
die Anteile an Eltern, Nachkommen oder den/die überlebende/n Ehepartner/in oder jeden anderen gesetzlichen Erben
des verstorbenen Gesellschafters übertragen werden.

5260

L

U X E M B O U R G

Art. 8. Liquidations - und Verkaufspräferenzen.
8.1 Im Falle (i) einer Übertragung von mindestens fünfzig Prozent (50%) aller Anteile an der Gesellschaft oder eines

Tausches oder einer Übernahme der Gesellschaft in wirtschaftlich vergleichbarer Weise in einer oder mehreren ver-
bundenen  Transaktionen  oder  in  zeitlicher  Nähe  zueinander,  oder  (ii)  einer  Übertragung  von  mindestens  50%  des
Vermögens oder der Geschäfte der Gesellschaft in einer oder mehreren verbundenen Transaktionen oder (iii) einer
Übertragung eines wesentlichen Teils der Rechte des geistigen Eigentums der Gesellschaft in einer oder mehreren ver-
bundenen Transaktionen oder (iv) der Liquidation oder der de facto-Liquidation der Gesellschaft (insbesondere nach
einem Asset Deal) oder (v) eines Verkaufs oder einer Übertragung von Anteilen an der Gesellschaft entweder an Dritte
oder an andere Gesellschafter, was dazu führen würde, dass entweder mehr als fünfzig Prozent (50%) des eingetragenen
Gesellschaftskapitals oder mehr als fünfzig Prozent (50%) der Stimmrechte im Besitz der erwerbenden Partei bzw. Parteien
wären (change of control), als Ergebnis eines oder mehrerer verbundener Akquisitionen, (wobei jeder der unter (i), (ii)
und (iii) beschriebenen Fälle im Folgenden als „Liquiditätsereignis“ bezeichnet wird), werden die Erlöse („Exiterlöse“) -
vorbehaltlich des Artikels 8.2 - im Einklang mit Artikel 8.3 auf einer pro rata-Basis (i) entsprechend ihrer Beteiligung am
eingetragenen Gesellschaftskapital der Gesellschaft im Falle einer Vermögensübertragung, oder (ii) entsprechend der
Anzahl der im Liquiditätsereignis verkauften Anteile (soweit anwendbar) im Falle einer Anteilsübertragung an die Gesell-
schafter verteilt.

„Übertragung“ meint, im Hinblick auf Vermögenswerte (einschließlich, ohne Beschränkung, Anteile und Rechte des

geistigen Eigentums), eine Übertragung, eine Abtretung, einen Verkauf, eine Verpfändung (pledge), eine Beleihung (hy-
pothecation), eine Belastung oder andere Veräußerung dieses Vermögenswertes oder damit verbundener Rechte und
Pflichten, ob absichtlich oder unabsichtlich, einschließlich einer Option hinsichtlich jeder der vorgenannten Handlungen.

„Belastung“/“Belastet“ meint Belastungen jedweder Art, einschließlich Hypotheken, Belastungen (charge), Obligatio-

nen, Verpfändungen, Beleihungen, Pfandrechte, Sicherungsrechte, Eigentumsvorbehalte, Optionsrechte, Erwerbs- oder
Bezugsrechte, Verkaufs- oder Übertragungsbeschränkungen, Vorkaufsrechte, Bezugsrechte, Rechte oder Interessen eines
Dritten, Forderungen, Trust-Arrangements, Verträge bezüglich der Übertragung von Wertpapieren, anderer Belastungen
oder  anderer  Sicherungsrechte  jeder  Art  oder  anderer  Vorzugsvereinbarungen  oder  Eigenkapital  oder  anderer  Ein-
schränkungen  oder  Beschränkungen  jedweder  Art  (einschließlich,  ohne  Beschränkung,  Übertragungsabkommen  von
Titeln  oder  Vorbehaltsvereinbarungen,  Vorverträge  oder  andere  Vereinbarungen  bezüglich  einer  der  vorgenannten
Handlungen) mit ähnlicher Wirkung;

8.2 Auf einer Vorzugsebene („Vorzugsebene”) erhält jeder Inhaber von Anteilen der Serie A einen Betrag, welcher

dem Betrag seiner jeweiligen Gesamtinvestition entspricht, die er getätigt hat, um seine jeweiligen von ihm gehaltenen
Anteile der Serie A zu erwerben (bestehend aus dem Nominalbetrag der von diesem Inhaber erworbenen Anteile der
Serie A und dem Agio und/oder anderen Kapitaleinlage (Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans),
die von dem jeweiligen Inhaber an die Gesellschaft gezahlt wurden). Sind nicht ausreichend Exiterlöse für die Zahlungen
auf der Vorzugsebene vorhanden, so werden die Exiterlöse an jeden Inhaber der Anteile der Serie A auf einer pro- rata
Basis zu den Beträgen verteilt, die an diesen Inhaber auf der Vorzugsebene verteilt worden wären, wenn ausreichend
Exiterlöse vorhanden gewesen wären.

8.3 Nachdem die Zahlungen auf der Vorzugsebene geleistet wurden, werden die übrigen Exiterlöse auf einer gemein-

samen  Ebene  („Gemeinsame  Ebene“)  an  alle  verkaufenden  Gesellschafter  auf  einer  pro  rata-Basis  entsprechend  den
jeweiligen Anteilen, die im Zusammenhang mit dem Liquiditätsereignis veräußert wurden, verteilt. Sämtliche von einem
Gesellschafter auf der Vorzugsebene erhaltenen Beträge mindern den von diesem Gesellschafter zu erhaltenden Betrag
auf der Gemeinsamen Ebene; mit der Maßgabe, dass kein Gesellschafter zur Rückzahlung eines auf der Vorzugsebene
erhaltenen Betrags verpflichtet ist. Exiterlöse, welche nach der Verteilung gemäß dieses Artikels 8.3 nicht zugeteilt wur-
den, werden auch im Einklang mit diesem Artikel 8.3 durch die wiederholte Anwendung des Artikels 8.3 verteilt, bis alle
Exiterlöse an die Gesellschafter verteilt wurden. Unabhängig davon, ob der Verkauf von Anteilen in einer oder mehreren
Transaktionen erfolgt oder nicht, hat kein Gesellschafter für den Verkauf all seiner Anteile einen Betrag zu erhalten (und
übersteigende Beträge an die anderen Gesellschafter zurückzuzahlen), der höher ist, (i) als sein Anteil an der Gesamtheit
der Exiterlöse auf einer pro rata-Basis zu den verkauften Anteilen, oder (ii) als der Betrag seiner Investition in die Ge-
sellschaft  (Zahlung  des  Kaufpreises  für  eine  eventuelle  Vorratsgesellschaft,  Einzahlung  des  Gesellschaftskapitals,  ein-
schließlich ggf. des Agios, und Einzahlungen auf Konto 115 des Standardisierten Luxemburgischen Kontenplans „apport
en capitaux propres non rémunérés par des titres“ nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg (zusätzliche Be-
träge)) in Bezug auf die verkauften Anteile. Werden Anteile der Gesellschaft in mehr als einer Transaktion verkauft, so
hat kein  Gesellschafter  weniger Erlöse  zu  erhalten,  als  er  erhalten hätte,  wenn  die Anteile der  Gesellschaft  in  einer
Transaktion verkauft worden wären.

8.4 Die bevorzugte Zuteilung auf der Vorzugsebene gilt zugunsten des entsprechenden Investors solange, wie dieser

(einschließlich von Verkäufen vor einem Liquiditätsereignis) den vollständigen Betrag, der an diesen Gesellschafter gemäß
der Vorzugsebene zu verteilen ist, noch nicht erhalten hat.

Art. 9. Rückkauf von Anteilen.
9.1 Die Gesellschaft kann ihre eigenen Anteile zurückkaufen. Die Stimmrechte der von der Gesellschaft gehaltenen

Anteile werden so lange ausgesetzt, wie die Anteile von der Gesellschaft gehalten werden.

9.2 Anteile eines Gesellschafters können ohne Zustimmung eines solchen zurückgekauft werden, wenn:

5261

L

U X E M B O U R G

9.2.1 ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gesellschafters eröffnet wird oder die Eröffnung eines Insolvenz-

verfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

9.2.2 der Anteil des Gesellschafters gepfändet wurde oder Vollstreckungsverfahren anderweitig gegen diesen Anteil

eingeleitet wurden und diese Verfahren nicht innerhalb von zwei (2) Monaten vollständig eingestellt sind.

Mit Erhalt durch den Gesellschafter der vom Rat der Geschäftsführer gesendeten Rückkaufserklärung sind die Anteile

automatisch zurückgekauft, ohne dass es einer weiteren Handlung bedarf. Die vorliegende Satzung stellt gemeinsam mit
der Rückkaufserklärung ein gültiges Dokument im Sinne des Artikels 190 des Gesetzes von 1915 dar und die Gesellschaft
bestätigt hiermit die Kenntnisnahme der Übertragung der Anteile, akzeptiert diese und verpflichtet sich zur Eintragung
dieser Übertragung in ihrem Anteilsregister und zur entsprechenden gesetzlich geforderten Hinterlegung für diesen Fall.

9.3 Wird der Anteil von mehreren Personen gehalten, ist das Vorliegen eines Grundes zum Rückkauf in Bezug auf eine

Person ausreichend; unabhängig davon können mehrere gemeinschaftlich berechtigte Personen die Gesellschafterrechte
nur dann und einheitlich ausüben, wenn eine der gemeinschaftlich berechtigten Personen unverzüglich nach Eintritt der
gemeinschaftlichen Berechtigung zu diesem Zwecke ernannt wird.

9.4 Ein Rückkauf kann durch den Rat der Geschäftsführer erklärt werden. Die Rückkaufserklärung wird wirksam, sobald

der betreffende Gesellschafter die Erklärung erhält und ein entsprechender Gesellschafterbeschluss gefasst wird (außer
im Falle von Artikel 9.2 dieser Satzung, in welchem keine Erklärung des Gesellschafters und kein entsprechender Gesell-
schafterbeschluss erforderlich sind).

Art. 10. Ausgleichszahlung für den Rückkauf.
10.1 Der Rückkauf erfolgt gegen eine Ausgleichszahlung.
10.2 Die Ausgleichszahlung besteht aus einem Gesamtbetrag, welcher dem Marktwert der zurückgekauften Anteile

entspricht. Als Stichtag gilt der Tag vor dem Rückkaufsbeschluss.

10.3 Die Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist unmittelbar mit dem Rückkauf der Anteile fällig und zahlbar.
10.4 Der ausscheidende Gesellschafter ist nicht dazu befugt, von der Gesellschaft Sicherheiten für ausstehende Beträge

zuzüglich Zinsen zu verlangen.

10.5 Bei Streitigkeiten hinsichtlich des Betrags der zu zahlenden Ausgleichszahlung für den Rückkauf ist diese Aus-

gleichszahlung von einem Wirtschaftsprüfer in der Eigenschaft als Schiedsgutachter, der von den Gesellschaftern gemein-
schaftlich ernannt wird, festzulegen. Wird über die Ernennung des Schiedsgutachters keine Einigung erzielt, so wird dieser
auf Ersuchen eines Gesellschafters oder der Gesellschaft vom Vorsitzenden des Bezirksgerichts (Tribunal d’Arrondisse-
ment) bestimmt. Die Entscheidung des Schiedsgutachters ist bindend. Die Kosten für das Gutachten werden von der
Gesellschaft und dem betreffenden Gesellschafter zu gleichen Teilen getragen, wobei der vom Gesellschafter zu tragende
Teil mit der Ausgleichszahlung für den Rückkauf verrechnet und die Ausgleichszahlung für den Rückkauf dementsprechend
herabgesetzt wird. Der Gesellschafter hat die übrigen Kosten zu tragen, sofern die Ausgleichszahlung für den Rückkauf
die dem Gesellschafter zugewiesenen Kosten für das Gutachten nicht deckt.

Art. 11. Abtretung anstelle von Rückkauf.
11.1 Die Gesellschaft kann entscheiden, dass der betreffende Gesellschafter anstelle des Rückkaufs die Anteile an eine

von der Gesellschaft benannte Person (einschließlich eines anderen Gesellschafters) zu übertragen hat, auch im Falle eines
Teilrückkaufs oder einer Teilabtretung der Anteile an die Gesellschaft oder an eine von der Gesellschaft benannte Person.

11.2 Der vorliegende Artikel 11 gilt mit der Maßgabe, dass, wie in Artikel 10 dieser Satzung vorgesehen, die Aus-

gleichszahlung  für  die  abzutretenden  Anteile  durch  die  die  Anteile  erwerbende  Person  geschuldet  ist  und  dass  die
Gesellschaft als Garant haftet.

C. Entscheidungen der Gesellschafter

Art. 12. Gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter.
12.1 Die Gesellschafterversammlung ist mit allen Rechten ausgestattet, welche ihr durch das Gesetz und diese Satzung

ausdrücklich vorbehalten sind.

12.2 Jeder Gesellschafter darf unabhängig von der Anzahl seiner Anteile an gemeinsamen Entscheidungen teilnehmen.
12.3  Falls  und  solange  die  Gesellschaft  nicht  mehr  als  fünfundzwanzig  (25)  Gesellschafter  hat,  dürfen  gemeinsame

Entscheidungen, welche ansonsten der Gesellschafterversammlung vorbehalten wären, schriftlich gefasst werden. In die-
sem Fall erhält jeder Gesellschafter den Text der zu fassenden Beschlüsse oder Entscheidungen in ausformulierter Form
und übt sein Stimmrecht schriftlich aus.

12.4 Gesellschafterbeschlüsse werden in Versammlungen gefasst. Sofern nicht zwingende gesetzliche Vorschriften eine

andere Form vorschreiben, können sie auch außerhalb von Versammlungen in schriftlicher Form (einschließlich E-Mail
oder Fax) oder durch telefonische Abstimmung gefasst werden, sofern ein solches Verfahren von einem Gesellschafter
ersucht wird und kein anderer Gesellschafter innerhalb von zwei (2) Wochen in schriftlicher Form Widerspruch gegen
dieses Verfahren gegenüber dem Rat der Geschäftsführer der Gesellschaft einlegt. Wird innerhalb von zwei (2) Wochen
kein Widerspruch gemäß des vorstehenden Satzes eingelegt, so werden die Stimmen der nicht an der Abstimmung teil-
nehmenden Gesellschafter als Enthaltungen gewertet. Schriftliche Beschlüsse sind von jedem Gesellschafter zu unter-

5262

L

U X E M B O U R G

zeichnen und die Niederschrift ist jedem Gesellschafter unverzüglich zuzusenden. Beschlüsse, welche nicht in schriftlicher
Form gefasst werden, sind schriftlich zu bestätigen. Eine solche Bestätigung hat ausschließlich feststellende Bedeutung.

12.5 Von jedem Beschluss, der in Gesellschafterversammlungen gefasst wurde, ist unverzüglich eine Niederschrift

anzufertigen (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die Wirksamkeit), die das Datum und die Form des gefassten
Beschlusses, den Inhalt des Beschlusses und die abgegebenen Stimmen zu enthalten hat, es sei denn, die Gesellschafter-
beschlüsse wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift muss jedem Gesellschafter unverzüglich in schriftlicher Form
zugesendet werden.

12.6 Im Falle eines Alleingesellschafters übt dieser die Befugnisse der Gesellschafterversammlung nach den Vorschriften

des Abschnitts XII des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung aus. In diesem Fall ist jede Bezugnahme auf die „Gesell-
schafterversammlung“ in der vorliegenden Satzung als Bezugnahme auf den Alleingesellschafter, je nach Zusammenhang
und soweit anwendbar, zu verstehen und die Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden vom Alleingesellschafter
ausgeübt.

Art. 13. Gesellschafterversammlung.
13.1 Gesellschafterversammlungen finden am Sitz der Gesellschaft oder an einem Ort und zu einer Zeit statt, welche

in der entsprechenden Einladung genauer bestimmt werden.

13.2  Die  Gesellschafterversammlung  wird  mittels  Einschreiben  (Zustellung  zu  eigenen  Händen,  Einschreiben  oder

Einschreiben mit Rückschein) an jeden Gesellschafter einberufen und beinhaltet den Ort, das Datum, die Uhrzeit und die
Tagesordnung,  wobei  bei  ordentlichen  Gesellschafterversammlungen  eine  Ankündigungsfrist  von  mindestens  vier  (4)
Wochen und bei außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Ankündigungsfrist von mindestens zwei (2) Wo-
chen einzuhalten ist. Die Ankündigungsfrist beginnt am Tag nach dem Versand. Der Tag der Gesellschafterversammlung
wird bei der Berechnung der Ankündigungsfrist nicht berücksichtigt.

13.3 Falls alle Gesellschafter in einer Gesellschafterversammlung anwesend oder vertreten sind und auf Einladungs-

formalitäten verzichtet haben, kann die Versammlung auch ohne vorherige Ankündigung abgehalten werden.

13.4  Jeder  Gesellschafter  ist  dazu  berechtigt,  bei  der  Gesellschafterversammlung  von  einem  anderen  durch  eine

schriftliche Vollmacht dazu berechtigten Gesellschafter oder von einem Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer
unter der Berufsverschwiegenheitspflicht begleitet oder vertreten zu werden.

13.5 Eine Niederschrift hinsichtlich des Ablaufs der Versammlung ist (als Nachweis, nicht als Voraussetzung für die

Wirksamkeit) anzufertigen und hat den Ort und das Datum der Versammlung, die Teilnehmer, die Tagesordnungspunkte,
den Hauptinhalt der Verhandlungen und die Gesellschafterbeschlüsse zu beinhalten, es sei denn, die Verhandlungen der
Gesellschafterversammlung wurden notariell beurkundet. Die Niederschrift ist von allen bei der Gesellschafterversamm-
lung  anwesenden  oder  vertretenen  Gesellschaftern  zu  unterzeichnen  (als  Nachweis,  nicht  als  Voraussetzung  für  die
Wirksamkeit). Jedem Gesellschafter ist eine Kopie der Niederschrift zuzusenden.

Art. 14. Quorum und Abstimmung.
14.1 Jeder Gesellschafter hat so viele Stimmen, wie er Anteile hält.
14.2 Eine Gesellschafterversammlung ist nur dann beschlussfähig, wenn mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesell-

schaftskapitals vertreten sind. Vorbehaltlich anderer Regelungen dieser Satzung oder des Gesetzes von 1915, die ein
höheres Mehrheitsverhältnis vorsehen, bedürfen gemeinsame Entscheidungen der Gesellschafter der Zustimmung von
Gesellschaftern, die mehr als die Hälfte des Gesellschaftskapitals innehaben. Bei Beschlussunfähigkeit ist unverzüglich im
Einklang mit Artikel 13.2 eine neue Gesellschafterversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen. Diese Gesell-
schafterversammlung ist dann unabhängig von dem vertretenen Gesellschaftskapital beschlussfähig, sofern darauf in der
die Versammlung einberufenden Ladung hingewiesen wurde und Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen
Stimmen gefasst.

Art. 15. Änderung der Nationalität. Die Gesellschafter können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

Art. 16. Änderung der Satzung. Eine Änderung dieser Satzung erfordert die Zustimmung (i) einer zahlenmäßigen
Mehrheit der Gesellschafter, (ii) die gleichzeitig eine Qualifizierte Mehrheit darstellen, die die Zustimmung aller In-

vestoren  vorausgesetzt.  Änderungen  dieser  Satzung,  durch  welche  die  Rechte  der  Inhaber  der  Anteile  der  Serie  A
erheblich oder nachteilig beeinflusst werden, bedürfen der Zustimmung aller Inhaber dieser Anteile der Serie A.

Art. 17. Beschlüsse, die eine spezifische Mehrheit erfordern.
17.1 Gesellschafterbeschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte Mehrheit und

zudem die Zustimmung des Beirats:

17.1.1 abschluss, Änderung und Kündigung von Unternehmensverträgen (im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Akti-

engesetzes (AktG));

17.1.2 abschluss oder Änderung von Unternehmensbeteiligungen (um Zweifel auszuschließen, nicht durch die Veräu-

ßerung von Anteilen) jeglicher Art einschließlich stiller Beteiligungen und sämtlicher Verträge, durch welche die andere
Vertragspartei eine Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft erhält oder jede Zahlung, welche vom Gewinnbetrag der
Gesellschaft abhängig ist; dies umfasst nicht Verträge mit Gesellschaftern oder Angestellten der Gesellschaft, einschließlich
Verträge, welche im Hinblick auf einen voraussichtlichen Status als Gesellschafter oder Angestellter abgeschlossen wur-

5263

L

U X E M B O U R G

den, sowie Verträge mit Dritten innerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs, z.B. Verträge zwischen der Gesellschaft und
Werbepartnern.

17.2 Beschlüsse hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten erfordern eine Qualifizierte
Mehrheit und zudem die Zustimmung aller Investoren:
17.2.1 wesentliche Änderungen des Geschäftszwecks der Gesellschaft oder jegliche wesentliche Modifikation der Ge-

schäftsfelder der Gesellschaft oder die Aufgabe bestehender und die Aufnahme neuer Geschäftsfelder;

17.2.2 Ausschluss von Bezugsrechten im Falle von Kapitalerhöhungen;
17.2.3 Erwerb eigener Anteile der Gesellschaft, mit Ausnahme der Erwerbe gemäß Artikel 9.2 und Übertragungen

gemäß Artikel 11.1 dieser Satzung;

17.2.4 Veräußerung des gesamten Gesellschaftsvermögens oder eines beträchtlichen Anteils des Gesellschaftsvermö-

gens einschließlich des Beschlusses hinsichtlich der Liquidation der Gesellschaft;

17.2.5 Verschmelzung, Ausgliederung und Umwandlung der Gesellschaft.
17.3  Ist  das  Gesellschaftskapital  in  verschiedene  Anteilsklassen  unterteilt,  so  können  die  spezifischen  Rechte  und

Pflichten im Zusammenhang mit einer Anteilsklasse mit der einstimmigen und schriftlichen Zustimmung der Gesellschaf-
ter, die alle ausgegebenen Anteile dieser Anteilsklasse halten, verändert oder aufgehoben werden.

D. Rat der Geschäftsführer

Art. 18. Befugnisse des Alleinigen Geschäftsführers -Zusammensetzung und Befugnisse des Rates der Geschäftsführer.
18.1 Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Falls die Gesellschaft mehrere Ge-

schäftsführer hat, bilden diese einen Rat der Geschäftsführer.

18.2 Falls die Gesellschaft von einem einzelnen Geschäftsführer geleitet wird und soweit der Begriff „alleiniger Ge-

schäftsführer“ nicht ausdrücklich in dieser Satzung verwendet wird, ist jeder Verweis in dieser Satzung auf den „Rat der
Geschäftsführer“ als Verweis auf den „alleinigen Geschäftsführer“ auszulegen.

18.3 Der Rat der Geschäftsführer verfügt über die weitestgehenden Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln

und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme
der durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung der Gesellschafterversammlung vorbehaltenen Befugnisse.

Art. 19. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Geschäftsführern.
19.1 Der bzw. die Geschäftsführer werden durch die Gesellschafterversammlung ernannt, welche ihre Bezüge und

ihre Amtszeit festlegt.

19.2 Die Geschäftsführer können jederzeit und ohne Grund ernannt oder abberufen werden.
19.3 Die Gesellschafterversammlung kann die Ernennung von Geschäftsführern zwei (2) unterschiedlicher Kategorien

beschließen, nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der Kategorie B. Eine solche Klassifizierung
der Geschäftsführer muss ordnungsgemäß in der Niederschrift des betreffenden Gesellschafterbeschlusses festgehalten
und die Geschäftsführer der Kategorie, der sie angehören, zugeordnet werden.

Art. 20. Vakanz einer Geschäftsführerstelle.
20.1  Scheidet  ein  Geschäftsführer  durch  Tod,  Geschäftsunfähigkeit,  Insolvenz,  Rücktritt  oder  aus  einem  anderem

Grund aus seinem Amt aus, so kann die unbesetzte Stelle durch die übrigen Geschäftsführer vorübergehend für einen
die ursprüngliche Amtszeit des ersetzten Geschäftsführers nicht überschreitenden Zeitraum bis zur nächsten Gesell-
schafterversammlung ausgefüllt werden, welche im Einklang mit den anwendbaren gesetzlichen Vorschriften über die
endgültige Ernennung entscheidet.

20.2  Für  den Fall, dass der alleinige  Geschäftsführer aus  seinem Amt ausscheidet,  muss  die frei gewordene Stelle

unverzüglich durch die Gesellschafterversammlung neu besetzt werden.

Art. 21. Einladung zu Sitzungen des Rates der Geschäftsführer.
21.1 Der Rat der Geschäftsführer versammelt sich auf Einberufung durch einen Geschäftsführer. Die Sitzungen des

Rates der Geschäftsführer finden, soweit in der Einladung nichts anderes bestimmt ist, am Sitz der Gesellschaft statt.

21.2  Die  Geschäftsführer  werden  mindestens  vierundzwanzig  (24)  Stunden  vor  dem  für  die  Sitzung  anberaumten

Zeitpunkt zu jeder Sitzung des Rates der Geschäftsführer schriftlich geladen, außer in dringenden Fällen, wobei die Gründe
der Dringlichkeit in der Einladung zu bezeichnen sind. Eine solche Einladung kann unterbleiben, falls alle Geschäftsführer
per Post, Fax, EMail oder mittels eines vergleichbaren Kommunikationsmittels ihre Zustimmung abgegeben haben, wobei
eine Kopie eines solchen Dokuments ein hinreichender Nachweis ist. Eine Einladung zu Sitzungen des Rates der Ge-
schäftsführer ist nicht erforderlich, wenn Zeit und Ort in einem vorausgehenden Beschluss des Rates der Geschäftsführer
bestimmt worden sind, welcher allen Geschäftsführern übermittelt wurde.

21.3 Eine Einladung ist nicht erforderlich, wenn alle Geschäftsführer anwesend oder vertreten sind und diese alle

Einladungsvoraussetzungen abbedingen oder im Fall von schriftlichen Umlaufbeschlüssen, wenn alle Mitglieder des Rates
der Geschäftsführer diesen zustimmen und diese unterzeichnen.

5264

L

U X E M B O U R G

Art. 22. Geschäftsführung.
22.1 Der Rat der Geschäftsführer kann unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden auswählen. Der Rat der Ge-

schäftsführer kann auch einen Schriftführer ernennen, der nicht notwendigerweise selbst ein Geschäftsführer sein muss
und der für die Protokollführung der Sitzungen des Rates der Geschäftsführer verantwortlich ist.

22.2 Sitzungen des Rates der Geschäftsführer werden, falls vorhanden, durch den Vorsitzenden des Rates der Ge-

schäftsführer geleitet. In dessen Abwesenheit kann der Rat der Geschäftsführer einen anderen Geschäftsführer durch
einen Mehrheitsbeschluss der anwesenden oder vertretenen Mitglieder als Vorsitzenden pro tempore ernennen.

22.3 Jeder Geschäftsführer kann an einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer teilnehmen, indem er einen anderen

Geschäftsführer schriftlich oder durch Faxschreiben, per E-Mail oder durch ein anderes vergleichbares Kommunikati-
onsmittel bevollmächtigt, wobei eine Kopie der Bevollmächtigung als hinreichender Nachweis dient. Ein Geschäftsführer
kann einen oder mehrere, aber nicht alle anderen Geschäftsführer vertreten.

22.4 Eine Sitzung des Rates der Geschäftsführer kann auch mittels Telefonkonferenz, Videokonferenz oder durch ein

anderes Kommunikationsmittel abgehalten werden, welches es allen Teilnehmern ermöglicht, einander durchgängig zu
hören und tatsächlich an der Sitzung teilzunehmen. Eine Teilnahme an einer Sitzung durch solche Kommunikationsmittel
ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an einer solchen Sitzung und die Sitzung gilt als am Sitz der Ge-
sellschaft abgehalten.

22.5 Der Rat der Geschäftsführer kann nur dann wirksam handeln und abstimmen, wenn zumindest eine Mehrheit der

Geschäftsführer in einer Sitzung anwesend oder vertreten ist.

22.6 Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der an der Sitzung des Rates der Geschäftsführer

teilnehmenden oder vertretenen Geschäftsführer gefasst. Der Vorsitzende des Rates der Geschäftsführer, falls vorhanden,
hat im Falle von Stimmgleichheit nicht die entscheidende Stimme. Sofern die Gesellschafterversammlung allerdings un-
terschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), werden Beschlüsse des Rates der Geschäftsführer nur dann wirksam gefasst, wenn sie von der
Mehrheit der Geschäftsführer einschließlich mindestens eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines Geschäftsfüh-
rers der Kategorie B (oder deren Vertreter) gefasst werden.

22.7 Der Rat der Geschäftsführer kann einstimmig Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung,

per Faxschreiben, oder per E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen. Jeder Geschäftsführer
kann  seine  Zustimmung  getrennt  erteilen,  wobei  die  Gesamtheit  aller  schriftlichen  Zustimmungen  die  Annahme  des
betreffenden Beschlusses nachweist. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Be-
schlusses.

22.8 Die Geschäftsführer benötigen die Zustimmung des Beirats für die unten genannten Rechtsgeschäfte und Maß-

nahmen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, sofern solche Rechtsgeschäfte und Maßnahmen präzise definiert und im
Voraus von einem bewilligten Haushaltsplan mit der Zustimmung des Beirats genehmigt wurden:

22.8.1 Genehmigung des Jahresplans, einschließlich des Haushaltsplans für jedes folgende Jahr;
22.8.2 Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder ähnlichen Verpflichtungen, die einen Betrag von zweihundert-

tausend Euro (EUR 200.000,00) übersteigen;

22.8.3 Termingeschäfte über Devisen, Sicherheiten und börsengehandelte Waren und Rechte, sowie weitere Trans-

aktionen mit derivaten Finanzinstrumenten;

22.8.4 Gewährung, Einführung und Änderung von Versorgungsverpflichtungen jeglicher Art;
22.8.5 Abschluss, Änderung oder Kündigung von Unternehmenstarifverträgen, Betriebsvereinbarungen (von erhebli-

cher Bedeutung) und allgemeiner Richtlinien hinsichtlich der betrieblichen Altersvorsorge der Gesellschaft;

22.8.6 Einleitung oder Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere Schiedsgerichtverfahren mit einem Streit-

wert von über zweihunderttausend Euro (EUR 200.000,00) im Einzelfall;

22.8.7 Transaktionen der Gesellschaft und ihrer Investoren mit verbundenen juristischen und natürlichen Personen;
22.8.8 Übertragung von Rechten des geistigen Eigentums oder dokumentiertem Wissen durch die Gesellschaft an einen

Dritten, die außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsbetriebs liegt;

22.8.9 Verwendung des Jahresergebnisses; Zahlungen von Gewinnen in Kapitalreserven oder der Gewinnvortrag sol-

cher Gewinne auf neue Rechnung; Erhöhung oder Herabsetzung von Reserven, sowie Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-
mitteln;

22.8.10 Gewährung, Schaffung oder Änderung eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms (einschließlich der Gewährung

jeglicher Aktienoptionen) mit Ausnahme der Schaffung einer vereinfachten Mitarbeiterbeteiligung, die zwischen den Ge-
sellschaftern der Gesellschaft in einer Gesellschaftervereinbarung, sofern vorhanden, vereinbart wurde.

22.9 Ist die Zustimmung zum Erwerb, zum Verkauf oder zur Belastung von Objekten wie oben beschrieben erforder-

lich, so ist die Zustimmung ebenfalls für die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen erforderlich. Die Gesell-
schafterversammlung kann durch einen Beschluss weitere Transaktionen und Maßnahmen bestimmen, die die Zustimmung
des Beirats erfordern. Der Beirat kann seine Zustimmung für bestimmte Gruppen und Arten von Transaktionen und
Maßnahmen auch im Voraus erteilen.

5265

L

U X E M B O U R G

22.10 Die Gesellschafter können durcheinenGesellschafterbeschluss eine Geschäftsordnung für die Geschäftsführer

beschließen.

22.11 Die Geschäftsführung hat sicherzustellen, dass die Bestimmungen dieses Artikels 22, soweit gesetzlich möglich,

auf die gleiche Weise auf sämtliche verbundenen Gesellschaften angewendet werden, in welchen die Gesellschaft direkt
oder indirekt gegenwärtig oder künftig eine Mehrheitsbeteiligung hält.

Art. 23. Protokoll von Sitzungen des Rates der Geschäftsführer; Protokoll der Entscheidungen des Alleinigen Ge-

schäftsführers.

23.1 Das Protokoll einer Sitzung des Rates der Geschäftsführer wird vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,

falls vorhanden oder, im Falle seiner Abwesenheit, vom Vorsitzenden pro tempore und dem Schriftführer (falls vorhan-
den), oder von zwei (2) beliebigen Geschäftsführern unterzeichnet. Sofern die Gesellschafterversammlung unterschied-
liche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäftsführer der
Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Ge-
schäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter). Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichts-
verfahren oder auf sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom Vorsitzenden des Rates der Geschäftsführer,
falls  vorhanden,  oder  von  zwei  (2)  beliebigen  Geschäftsführern  unterzeichnet.  Sofern  die  Gesellschafterversammlung
unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäftsführer der Kategorie A und Geschäfts-
führer der Kategorie B), bedarf es der gemeinsamen Unterschrift eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines
(1) Geschäftsführers der Kategorie B (oder deren Vertreter).

23.2 Die Entscheidungen des alleinigen Geschäftsführers werden in ein Protokoll aufgenommen, welches vom alleinigen

Geschäftsführer unterzeichnet wird. Kopien oder Auszüge solcher Protokolle, die in einem Gerichtsverfahren oder auf
sonstige Weise vorgelegt werden können, werden vom alleinigen Geschäftsführer unterzeichnet.

Art. 24. Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber Dritten. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Um-

ständen  (i)  durch  die  Unterschrift  des  alleinigen  Geschäftsführers  oder,  für  den  Fall,  dass  die  Gesellschaft  mehrere
Geschäftsführer hat, durch die gemeinsamen Unterschriften zwei (2) beliebiger Geschäftsführer wirksam verpflichtet;
sofern die Gesellschafterversammlung unterschiedliche Kategorien von Geschäftsführern ernannt hat (nämlich Geschäfts-
führer  der  Kategorie  A  und  Geschäftsführer  der  Kategorie  B),  wird  die  Gesellschaft  nur  durch  die  gemeinsamen
Unterschriften mindestens eines (1) Geschäftsführers der Kategorie A und eines (1) Geschäftsführers der Kategorie B
(oder deren Vertreter), oder (ii) durch die gemeinsamen Unterschriften oder die alleinige Unterschrift jedweder Person
(en), der/denen eine Unterschriftsbefugnis durch den Rat der Geschäftsführer übertragen worden ist, wirksam verpflich-
tet.

Art. 25. Beirat.
25.1 Die Gesellschaft hat einen Beirat gebildet (der „Beirat“). Dieser besteht aus sieben (7) stimmberechtigten Mit-

gliedern. Die Gesellschafter können durch einstimmige Zustimmung der Gesellschafter die Anzahl der stimmberechtigten
Mitglieder des Beirats erhöhen oder herabsetzen.

25.2 Die Gesellschafter können die Geschäftsordnung für den Beirat nur durch einstimmige Zustimmung der Gesell-

schafter festlegen und/oder verändern.

25.3 Die stimmberechtigten Mitglieder des Beirats werden von dem ernennenden Gesellschafter jedes entsprechenden

Mitglieds durch schriftliche Mitteilung an die Gesellschaft wie folgt ernannt, abberufen oder ersetzt:

25.3.1 vier (4) stimmberechtigte Mitglieder des Beirats werden von dem Gesellschafter Rocket nach eigenem Ermessen

ernannt (die „Rocket-Mitglieder“);

25.3.2 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Aismare nach eigenem Ermessen

ernannt (das „Aismare-Mitglied“);

25.3.3 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter Phenomen nach eigenem Ermessen

ernannt (das „Phenomen-Mitglied“); und 25.3.4 ein (1) stimmberechtigtes Mitglied des Beirats wird von dem Gesellschafter
Mangrove nach eigenem Ermessen ernannt (das „Mangrove-Mitglied“).

25.4 Jeder Investor, der nicht zur Ernennung eines stimmberechtigten Mitglieds des Beirats gemäß Artikel 25.3 be-

rechtigt ist, darf ein nichtstimmberechtigtes Mitglied des Beirats als Beobachter ernennen.

25.5  Der  Beirat  hat  einen  Vorsitzenden  und  einen  stellvertretenden  Vorsitzenden,  wobei  keiner  von  beiden  eine

entscheidende Stimme und/oder zusätzliche Rechte und/oder Befugnisse hat, die sich von denen der anderen Mitglieder
des Beirats unterscheiden. Eines der Rocket-Mitglieder ist der Vorsitzende des Beirats. Die Geschäftsordnung des Beirats
hat weitere Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der Selbstorganisation des Beirats, zu enthalten. Vorbehaltlich an-
derer  Zustimmungs-  oder  Genehmigungserfordernisse  gemäß  dieser  Satzung  und/oder  Gesellschaftervereinbarungen
bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, fasst der Beirat Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men, sofern (i) die Ja-Stimme des Aismare-Mitglieds, des Phenomen-Mitglieds oder des Mangrove-Mitglieds in dieser
Mehrheit (die „Mehrheit des Beirats“) eingeschlossen ist oder (ii) für bestimmte Maßnahmen, die sich aus einer Gesell-
schaftervereinbarung ergeben, zwei (2) Ja-Stimmen von dem Aismare-Mitglied und/oder dem Phenomen-Miglied und/oder
dem Mangrove-Mitglied oder jedem anderen Mitglied des Beirats, das ab dem Datum dieser Satzung ernannt wird, ein-

5266

L

U X E M B O U R G

geschlossen sind (die „Qualifizierte Mehrheit des Beirats“). Der Beirat hält regelmäßig Sitzungen ab, mindestens einmal
pro Kalenderquartal.

25.6 Vorbehaltlich anderer Zustimmungs- oder Genehmigungserfordernisse gemäß dieser Satzung und/oder Gesell-

schaftervereinbarungen bezüglich der Gesellschaft, sofern vorhanden, hat der Beirat eine beratende Funktion und wird
nicht in die Geschäftsführung der Gesellschaft eingreifen.

25.7 Der Beirat ist kein Aufsichtsrat im Sinne des Artikels 60bis-11 ff. des Gesetzes von 1915.

E. Aufsicht und Prüfung der Gesellschaft

Art. 26. Rechnungsprüfer/Wirtschaftsprüfer.
26.1 Falls und solange die Gesellschaft mehr als fünfundzwanzig (25) Gesellschafter hat, werden die Geschäfte der

Gesellschaft durch einen oder mehrere Rechnungsprüfer beaufsichtigt (commissaire(s)). Die Gesellschafterversammlung
ernennt die Rechnungsprüfer und legt ihre Amtszeit fest.

26.2 Ein Rechnungsprüferkann jederzeit und ohne Grund von der Gesellschafterversammlung abberufen werden.
26.3 Die Rechnungsprüferhaben ein unbeschränktes Recht der permanenten Überprüfung und Kontrolle aller Ge-

schäfte der Gesellschaft.

26.4 Wenn die Gesellschafter im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 69 des Gesetzes vom 19. Dezember

2002  betreffend  das  Handelsregister  und  die  Buchhaltung  und  den  Jahresabschluss  von  Unternehmen,  in  der  jeweils
gültigen Fassung, einen oder mehrere unabhängige Wirtschaftsprüfer (réviseurs d’entreprises agréé(s)) ernennen, entfällt
die Funktion des Rechnungsprüfers.

26.5 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer darf nur aus berechtigtem Grund oder mit seiner Zustimmung durch die

Gesellschafterversammlung abberufen werden.

F. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnverwendung - Abschlagsdividenden

Art. 27. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am

einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 28. Jahresabschluss und Gewinne.
28.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Rat der Geschäftsführer erstellt im

Einklang mit den gesetzlichen Anforderungen ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und
Verlustrechnung.

28.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage

der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser
Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals beträgt.

28.3 Durch einen GesellschaftererbrachteEinlageninRücklagen können mit Zustimmung dieses Gesellschafters ebenfalls

der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden.

28.4 Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage der Gesellschaft verhältnis-

mäßig herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

28.5 Auf Vorschlag des Rates der Geschäftsführer bestimmt die Gesellschafterversammlung im Einklang mit den Be-

stimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft
verwendet werden soll.

28.6 Vorbehaltlich des Artikels 8 erfolgen Ausschüttungen an die Gesellschafter proportional zur Anzahl der von ihnen

an der Gesellschaft gehaltenen Anteile.

Art. 29. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.
29.1 Der Rat der Geschäftsführer kann Abschlagsdividenden auf Grundlage von Zwischenabschlüssen zahlen, welche

vom Rat der Geschäftsführer vorbereitet wurden und belegen, dass ausreichende Mittel für eine Abschlagsdividende zur
Verfügung stehen. Der ausschüttbare Betrag wird gegebenenfalls - im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 8 -
verteilt und darf nicht die Summe der seit dem Ende des vergangenen Geschäftsjahres angefallenen Gewinne, gegebe-
nenfalls  erhöht  durch  vorgetragene  Gewinne  und  ausschüttbare  Rücklagen,  beziehungsweise  vermindert  durch
vorgetragene Verluste und Summen, die einer Rücklage zugeführt werden, welche nach dem Gesetz von 1915 oder dieser
Satzung nicht ausgeschüttet werden darf, übersteigen.

29.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können im Einklang mit den Bestimmun-

gen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung frei an die Gesellschafter ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 30. Liquidation. Im Falle der Auflösung der Gesellschaft im Einklang mit Artikel 3.2 dieser Satzung wird die Liqui-

dation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Gesellschafterversammlung ernannt werden,
die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit
nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermö-
genswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

5267

L

U X E M B O U R G

H. Schlussbestimmungen - Anwendbares recht

Art. 31. Anwendbares Recht.
31.1 Sämtliche in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten unterliegen den Bestimmungen des Gesetzes von

1915 und jeder Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft, die die Gesellschafter mitunter mit der Gesellschaft
eingehen und durch die bestimmte Bestimmungen dieser Satzung ergänzt werden könnten. Sollte ein Artikel dieser Sat-
zung mit den Bestimmungen einer Gesellschaftervereinbarung bezüglich der Gesellschaft in Widerspruch stehen, so ist
die Gesellschaftervereinbarung zwischen den Parteien, soweit nach luxemburgischem Recht zulässig, maßgebend.

31.2 Diese Satzung wurde auf Englisch verfasst, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; im Falle von Abweichungen

zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.“

<i>Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft zu tragen sind, werden auf

ungefähr zweitausend Euro (EUR 2.000) geschätzt.

Worüber Urkunde, Aufgenommen in Luxemburg, zum eingangs erwähnten Datum.
Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende

Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung;
auf Verlangen besagter erschienener Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen
Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die  vorstehende  Urkunde  ist  dem  Bevollmächtigten  der  erschienenen  Parteien,  welcher  dem  Notar  mit  Namen,

Vornamen und Wohnsitz bekannt ist, verlesen und vom Notar gemeinsam mit diesem Bevollmächtigten unterzeichnet
worden.

Signé: P. Sylvestre, M. Loesch.
Enregistré à Remich, le 1 

er

 décembre 2014. REM/2014/2614. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201658/1291.
(140225318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Field Conseil S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4702 Pétange, 24, rue Robert Krieps.

R.C.S. Luxembourg B 123.914.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014203202/9.
(140226494) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Graziel S.à.r.l., Société à responsabilité limitée,

(anc. Graziel S.A.).

Siège social: L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 56.352.

L'an deux mille quatorze, le quatrième jour du mois de décembre;
Pardevant Nous Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

soussigné;

Se réunie

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, (l'“Assemblée”), de la société anonyme constituée et existant

sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg “GRAZIEL S.A.”, établie et ayant son siège social à L-2449 Luxembourg,
25B, boulevard Royal, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro
56352, (la “Société”), constituée suivant acte reçu par le notaire de résidence Luxembourg Maître Emile SCHLESSER, le

er

 octobre 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 627 du 4 décembre 1996,

et dont les statuts, (les “Statuts”) ont été modifiés suivant une résolution prise par l'assemblée générale extraordinaire

tenue prise sous seing privé en date du 20 décembre 2001, contenant notamment la conversion de la devise du capital
social en euros, l'extrait afférent ayant été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 601 du
18 avril 2002.

5268

L

U X E M B O U R G

L'Assemblée est présidée par Madame Anna KOLESNIKOVA-SCHMITT, juriste, demeurant professionnellement à

L-2499 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

La Présidente désigne comme secrétaire et l'Assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Patrick MEUNIER, conseil

économique, demeurant professionnellement à L-2449 Luxembourg, 25B, boulevard Royal.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, la Présidente expose et prie le notaire instrumentaire d'acter ce

qui suit:

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant:

<i>Ordre du jour:

1. Changement de la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en société à res-

ponsabilité limitée (S.à r.l.);

2. Changement du nom de la Société en “Graziel S.à r.l.”;
3. Acceptation de la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes, avec décharge;
4. Nomination d'un ou plusieurs gérants de la Société et détermination de la durée de son (ses) mandat(s) et pouvoir

de signature;

5. Divers.
B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont

portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux
représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des associés représentés, signées “ne varietur” par les membres du bureau de l'Assemblée

et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisée avec lui.

D) Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée et que les actionnaires, présents ou représentés,

déclarent avoir été dûment notifiés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour préalablement à cette Assemblée et
renoncer aux formalités de convocation d'usage, aucune autre convocation n'était nécessaire.

E) Que la présente Assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer

valablement sur les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Assemblée décide de changer la forme juridique de la Société, pour la transformer de société anonyme (S.A.) en

société à responsabilité limitée (S.à r.l.) et de procéder à une refonte complète des Statuts, afin de les adapter à la nouvelle
forme de la Société, sans modification de ses éléments essentiels, comme l'objet social.

Cette modification n'aura aucun impact sur la continuité de la personnalité juridique de la Société.
Le capital social et les réserves demeureront intacts ainsi que tous les éléments de l'actif et du passif, les amortisse-

ments, les plus-values et les moins-values.

La société à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.
Par conséquent, mille (1.000) actions actuelles sont remplacées par mille (1.000) parts sociales avec une valeur nominale

de trente Euros et quatre-vingt-dix-huit soixante-sept Cents (30,9867 EUR).

Chaque associé recevra une “parts sociales S.à r.l.” en échange d'une “action S.A.”.
Dans le cadre de la transformation de la forme juridique, il est justifié au notaire instrumentant par un bilan établi au

4 décembre 2014 et par une déclaration émises par le conseil d'administration de la Société le 4 décembre 2014, que
l'actif net de la Société n'est pas inférieur au capital social minimum applicable pour une société à responsabilité limitée,
soit un montant de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR).

Lesdits bilan et déclaration, après avoir été signés “ne varietur” par les membres du bureau et le notaire instrumentant,

resteront annexés au présent acte pour être enregistrés avec celui-ci.

<i>Deuxième résolution

L'Assemblée décide:
- de changer le nom de la Société en “Graziel S.à r.l.”;
- d'accepter la démission des administrateurs et du commissaire aux comptes et de leur donner décharge pleine et

entière pour l'exercice de leurs mandats jusqu'à ce jour; et

- de procéder à une refonte totale des Statuts afin de refléter les résolutions prises ci-avant et pour les adapter à la

nouvelle forme juridique de la Société, leur donnant la teneur suivante:

Art. 1 

er

 .  Il existe une société à responsabilité limitée sous la dénomination de “Graziel S.à r.l.”, (la “Société”), régie

par les présents statuts (les “Statuts”) ainsi que par les lois respectives et plus particulièrement par la loi modifiée du 10
août 1915 sur les sociétés commerciales (la “Loi”).

5269

L

U X E M B O U R G

Art. 2. La Société a pour objet la prise d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres entreprises luxem-

bourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

Elle peut notamment acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des

valeurs mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La Société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou

pouvant les compléter.

La Société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle participe ou auxquelles elle s'intéresse direc-

tement ou indirectement tous concours, prêts, avances ou garanties.

La Société pourra faire, en outre, toutes opérations commerciales, industrielles et financières, tant mobilières qu'im-

mobilières qui peuvent lui paraître utiles dans l'accomplissement de son objet.

Art. 3. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg). L'adresse du siège

social peut-être déplacée à l'intérieur de la commune par simple décision de la gérance.

Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une simple décision des associés

délibérant comme en matière de modification des statuts.

Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité

normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège
social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète des circonstances anormales. Une
telle décision n'aura aucun effet sur la nationalité de la Société. La déclaration de transfert de siège sera faite et portée à
la connaissance des tiers par l'organe de la Société qui se trouvera le mieux placé à cet effet dans les circonstances données.

Par simple décision de la gérance, la Société pourra établir des bureaux, filiales, succursales, agences ou sièges admi-

nistratifs aussi bien dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

Art. 4. La durée de la Société est illimitée.

Art. 5. Le capital social est fixé à trente mille cent quatre-vingt-six Euros et soixante-neuf Cents (EUR 30.986,69),

représenté par mille (1.000) parts sociales d'une valeur nominale de trente Euros et quatre-vingt-dix-huit soixante-sept
Cents (30,9867 EUR) chacune.

Lorsque, et aussi longtemps qu'un associé réunit toutes les parts sociales entre ses seules mains, les articles 200-1 et

200-2, entre autres, de la Loi sont d'application, c'est-à-dire chaque décision de l'associé unique ainsi que chaque contrat
entre celui-ci et la Société doivent être établis par écrit et les clauses concernant les assemblées générales des associés
ne sont pas applicables.

La Société peut acquérir ses propres parts à condition qu'elles soient annulées et le capital réduit proportionnellement.

Art. 6. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune

d'elles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la Société a le droit de suspendre l'exercice des droits afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard, propriétaire de la part sociale. Il en sera de
même en cas de conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier-gagiste.

Toutefois, les droits de vote attachés aux parts sociales grevées d'usufruit sont exercés par le seul usufruitier.

Art. 7. Les cessions de parts entre vifs à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.

Les cessions de parts à cause de mort à des associés et à des non-associés sont subordonnées à l'agrément donné en

assemblée générale des associés représentant les trois quarts au moins du capital social appartenant aux survivants.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont transmises à des héritiers réservataires, soit au conjoint survivant.
En cas de refus d'agrément dans l'une ou l'autre des hypothèses, les associés restants possèdent un droit de préemption

proportionnel à leur participation dans le capital social restant.

Le droit de préemption non exercé par un ou plusieurs associés échoit proportionnellement aux autres associés. Il

doit être exercé dans un délai de trois mois après le refus d'agrément. Le non-exercice du droit de préemption entraîne
de plein droit agrément de la proposition de cession initiale.

Art. 8. Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des associés ne mettent pas fin à la Société. En cas de

décès d'un associé, la Société sera continuée entre les associés survivants et les héritiers légaux.

Art. 9. Les créanciers, ayants droit ou héritiers des associés ne pourront pour quelque motif que ce soit, apposer des

scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux.

Art. 10. La Société est gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non. Les pouvoirs d'un gérant

seront déterminés par l'assemblée générale lors de sa nomination. Le mandat de gérant lui est confié jusqu'à révocation
ad nutum par l'assemblée des associés délibérant à la majorité des voix.

5270

L

U X E M B O U R G

Le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les affaires de la Société et pour représenter la

Société judiciairement et extrajudiciairement.

Le ou les gérants peuvent nommer des fondés de pouvoir de la Société, qui peuvent engager la Société par leurs

signatures individuelles, mais seulement dans les limites à déterminer dans la procuration.

Art. 11. Tout gérant ne contracte à raison de sa fonction, aucune obligation personnelle, quant aux engagements

régulièrement pris par lui au nom de la Société; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

Art. 12. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés

représentant plus de la moitié du capital social.

Toutefois, les décisions ayant pour objet une modification des Statuts ne pourront être prises qu'à la majorité des

associés représentant les trois quarts du capital social.

Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment dans les conditions suivantes:
- des comptes intérimaires sont par le(s) gérant(s),
- ces comptes doivent montrer un profit suffisant, bénéfices reportés inclus,
- la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par une assemblée générale extraordinaire des associés.

Art. 13. L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Art. 14. Chaque année, au 31 décembre, la gérance établira les comptes annuels et les soumettra aux associés.

Art. 15. Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication des comptes annuels pendant les quinze

jours qui précéderont son approbation.

Art. 16. L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais généraux, charges sociales,

amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net seront prélevés et affectés à la réserve légale. Ces prélèvements

et affectations cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve aura atteint un dixième du capital social, mais devront être
repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve se
trouve entamé. Le solde est à la libre disposition des associés.

Art. 17. En cas de dissolution de la Société pour quelque raison que ce soit, la liquidation sera faite par la gérance ou

par toute personne désignée par les associés.

La liquidation de la Société terminée, les avoirs de la Société seront attribués aux associés en proportion des parts

sociales qu'ils détiennent.

Des pertes éventuelles sont réparties de la même façon, sans qu'un associé puisse cependant être obligé de faire des

paiements dépassant ses apports.

Art. 18. Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales en

vigueur.

<i>Troisième résolution

L'Assemblée décide de fixer le nombre des gérants à un (1) et de nommer, pour une durée indéterminée, Monsieur

Fernando ACEDO-RICO HENNING, directeur de sociétés, né à Madrid (Espagne), le 27 septembre 1958, résidant à
E-28034 Madrid, Marbella 66, IZ, 6° A, (Espagne), comme gérant de la Société.

L'Assemblée décide de fixer le pouvoir de signature des gérants comme suit:
“La Société est valablement engagée en toutes circonstances et sans restrictions par la signature du gérant”.
Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, la Présidente

a ensuite clôturé l'Assemblée.

<i>Frais

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la

Société, ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quinze euros.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.
Après lecture du présent acte aux comparants, connus du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits

comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: A. KOLESNIKOVA-SCHMITT, P. MEUNIER, C. WERSANDT.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/58957. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

<i>Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

5271

L

U X E M B O U R G

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201651/179.
(140225703) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Binsfeld Immobilière II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3860 Schifflange, 15, rue de Noertzange.

R.C.S. Luxembourg B 192.855.

STATUTS

L'AN DEUX MIL QUATORZE. LE VINGT-CINQ NOVEMBRE.
Par-devant Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Madame Marie-Thérèse OLINGER, retraitée, veuve de Monsieur Armand BINSFELD, demeurant à L-3860 Schifflange,

15, rue de Noertzange,

ici représentée par Monsieur Yves BINSFELD, gérant de sociétés, demeurant à L-3860 Schifflange, 19, rue de Noer-

tzange,

spécialement mandaté à cet effet par procuration sous seing privé lui délivrée.
La prédite procuration, signée "ne varietur" par le mandataire de la comparante et le notaire instrumentant, restera

annexée aux présentes avec lesquelles elle sera soumise à la formalité de l’enregistrement.

Laquelle comparante, représentée comme dit-ci-avant, a prié le notaire instrumentant d’arrêter ainsi qu'il suit les statuts

d'une société à responsabilité limitée à constituer.

Art. 1 

er

 .  Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois qui sera régie

par les lois en vigueur et notamment par celles du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, du 18 septembre 1933
sur les sociétés à responsabilité limitée et leurs lois modificatives en particulier celle du 28 décembre 1992 relative à la
société à responsabilité limitée unipersonnelle, ainsi que par les présents statuts.

A tout moment, l’associé peut s'adjoindre un ou plusieurs coassociés et, de même, les futurs associés peuvent prendre

les mesures appropriées tendant à rétablir le caractère unipersonnel de la Société.

La société prend la dénomination de «BINSFELD IMMOBILIÈRE II S.à r.l.».

Art. 2. Le siège social est établi dans la commune de Schifflange. Il pourra être transféré en tout autre endroit du

Grand-Duché de Luxembourg par simple décision des associés ou de l’associé unique à prendre conformément aux
dispositions de l’article 9 (2) des statuts.

Art. 3. La société a pour objet social, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, pour compte propre ou

pour compte de tiers:

- toutes opérations généralement quelconques pratiquées par les "immobilières" comprenant notamment, l’exploita-

tion d'une agence immobilière, les opérations portants sur l’acquisition des biens meubles ou immeubles, la promotion
foncière ou immobilière, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, la construction, l’échange, la vente, la
location de tous immeubles privés, commerciaux ou industriels, l’aménagement, la viabilisation ou le lotissement tous
terrains, camps ou emplacements fonciers tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l’étranger, l’énonciation ci-dessus
étant énonciative et non limitative.

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’exécution de toutes prestations se rapportant à la

profession de comptable. Elle pourra également effectuer le contrôle contractuel des comptes, donner des conseils en
matière fiscale et en matière économique, organiser et tenir les comptabilités et analyser, par les procédés de la technique
comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises sous leurs différents aspects économiques, juridiques et
financiers. L’objet est également étendu à la formation et au recrutement dans le domaine de la comptabilité et la gestion.

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’exécution de toutes activités de conseil et d'assistance

dans le domaine économique au sens le plus large.

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’exécution de toutes activités d’agence d’assurance et

de conseil en assurances. Elle peut effectuer toutes opérations d’assurances par l’intermédiaire de personnes physiques
dûment agréées.

- toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l’exécution des opérations de courtage au sens large,

en matière de prêts hypothécaires et à la consommation.

D’une façon générale, la Société pourra effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobi-

lières et financières, pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités ci-dessus décrites ou susceptibles
d’en faciliter l’accomplissement.

La Société pourra s’intéresser, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, dans toutes sociétés ou entre-

prises se rattachant à son objet ou de nature à le favoriser et à le développer.

5272

L

U X E M B O U R G

La Société pourra faire l’acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens,

directement ou indirectement, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises et
étrangères, (ii) l’acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière et l’aliénation par vente, échange ou de
toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs mobilières ou instruments financiers de toutes
espèces, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l’administration, le déve-
loppement et la gestion de son portefeuille (composé notamment des actifs tels que ceux définis aux points (i) et (ii) ci-
dessus).

Art. 4. La société est constituée pour une durée indéterminée.

Art. 5. Le capital social est fixé à 12.500,- euros (douze mille cinq cents euros) représenté par 100 (cent) parts sociales

de 125,- euros (cent vingt-cinq euros) chacune.

Les parts sociales ont été souscrites et entièrement libérées comme suit:

Madame Marie-Thérèse OLINGER, prénommée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales
Total: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 parts sociales

Art. 6. Les parts sociales ne peuvent être cédées à un non-associé qu’avec le consentement des coassociés. Elles ne

peuvent être cédées à non-associé pour cause de mort, que moyennement l’agrément de tous les associés survivants.

Art. 7. Le décès, l’interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés ne mettent pas fin à la société.
Les créanciers, ayants-droit ou héritiers ne pourront, pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les

biens et documents de la société, ni s'immiscer d’aucune manière dans les actes de son administration. Pour faire valoir
leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans le dernier bilan et inventaire de la société.

Art. 8. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tous moments

par l’assemblée générale qui en fixe les pouvoirs et rémunérations.

Les gérants peuvent voter par lettre, télégramme, télex, téléfax ou tout autre support écrit.
Le ou les gérant(s) sont nommés pour une durée indéterminée et ils sont investis dans la représentation de la Société

vis-à-vis des tiers des pouvoirs les plus étendus.

La Société sera engagée par la signature du gérant unique si elle est administrée par un seul gérant, et dans le cas d'un

conseil de gérance, par la signature conjointe de deux gérants.

Des pouvoirs spéciaux et limités pourront être délégués à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, associés ou non, pour

des affaires déterminées par le(s) gérant(s).

Art. 9. L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés par les dispositions de la section XII

de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés à responsabilité limitée.

Il s'ensuit que toutes décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises par l’associé unique.
En cas de pluralité d'associés, les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants seront prises en assemblée.

Art. 10. L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

Art. 11. Chaque année le trente et un décembre les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire

comprenant l’indication des valeurs actives et passives de la société.

Les produits de la société, constatés dans l’inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et

charges constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la continuation d’un fonds de réserve jusqu’à ce que celui-

ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

le solde est à la libre disposition de l’associé unique ou selon le cas, de l’assemblée des associés.

Art. 12. Pour tout ce qui n’est pas prévu dans les présents statuts, le ou les associés se réfèrent et se soumettent aux

dispositions légales régissant la matière et notamment aux lois du 10 août 1915, du 18 septembre 1933 et du 28 décembre
1992.

<i>Disposition transitoire

Le premier exercice social commence le jour de la constitution de la société et se termine le 31 décembre 2015.

<i>Souscription et paiement

Les 100 (cent) parts sociales de 125,- euros (cent vingt-cinq euros) chacune ont été entièrement souscrites par l’associé

unique, Madame Marie-Thérèse OLINGER, prénommée.

Toutes les parts sociales ont été intégralement libérées par des versements en espèces de sorte que la somme de

12.500,- euros (douze mille cinq cents euros) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société, preuve en ayant
été donnée au notaire instrumentant.

5273

L

U X E M B O U R G

<i>Constatation

Le notaire instrumentaire a constaté que les conditions prévues par l’article 183 des lois sur les sociétés (loi du 18

septembre 1933) se trouvent remplies.

<i>Frais

Les parties ont évalué les frais incombant à la société du chef de sa constitution à environ EUR 1.000,-.

<i>Résolutions de l’associé unique

L’associé unique prénommé, représenté comme dit ci-avant, représentant l’intégralité du capital social, a pris les ré-

solutions suivantes:

<i>Première résolution

Est appelé aux fonctions de gérant unique:
Monsieur Yves BINSFELD, gérant de sociétés, né le 12 janvier 1964 à Esch-sur-Alzette, demeurant à L-3860 Schifflange,

19, rue de Noertzange,

avec les pouvoirs définis à l’article 11 des statuts.
Il pourra nommer des agents, fixer leurs pouvoirs et attributions et les révoquer.
Le mandat du gérant unique est établi pour une durée indéterminée.

<i>Deuxième résolution

Le siège social de la société est fixé au 15, Rue de Noertzange, L-3860 Schifflange.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la comparante, connu du notaire par noms, prénoms,

états et demeures, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Y. BINSFELD, C. DELVAUX.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 02 décembre 2014. Relation: LAC/2014/57080. Reçu soixante-quinze euros

75,00 €.

<i>Le Receveur (signé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxem-

bourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014201441/133.
(140226238) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

ISM Conseil, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre.

R.C.S. Luxembourg B 150.447.

L'an deux mille quatorze, le onze décembre.
Pardevant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1.- Monsieur Patrick GALAMPOIX, salarié, né à Sarcelles (France), le 14 décembre 1963, demeurant à L-7243 Berel-

dange, 23, rue du 10 Octobre, et

2.- Madame Nathalie GALAMPOIX, née FIORITI, gérante de sociétés, née à Thionville (F), le 11 septembre 1965,

demeurant à L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre.

Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée "ISM Conseil", avec siège social à L-2157 Luxembourg, 3, rue 1900, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, sous le numéro 150.447, a été constituée suivant
acte reçu par le notaire instrumentant en date du 7 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et
Associations, numéro 241 du 4 février 2010. Les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant
en date du 12 octobre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2937 du 4 décembre
2012

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés actuels de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée

générale extraordinaire et ont pris à l’unanimité, sur ordre du jour conforme, les résolutions suivantes:

<i>Première résolution

L'assemblée décide de transférer l’adresse du siège social vers L-7243 Bereldange, 23, rue du 10 Octobre.

5274

L

U X E M B O U R G

<i>Deuxième résolution

L'assemblée décide en conséquence de ce qui précède de modifier le premier alinéa de l’article 4 des statuts pour lui

donner la teneur suivante:

«  Art. 4. (1 

er

 alinéa).  Le siège social est établi dans la Commune de Walferdange, (Grand-Duché de Luxembourg).»

<i>Frais

Tous les frais et honoraires des présentes, évalués à la somme de huit cent cinquante euros, sont à charge de la société,

et les associés s'y engagent personnellement.

DONT ACTE, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et

demeure, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: Patrick GALAMPOIX, Nathalie GALAMPOIX, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/4986. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

<i>Le Receveur

 (signé): G. SCHLINK.

Référence de publication: 2014201731/38.
(140225424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Loria International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1720 Luxembourg, 6, rue Heinrich Heine.

R.C.S. Luxembourg B 139.323.

DISSOLUTION

L'an deux mille quatorze, le neuf décembre.
Par-devant Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg),

A comparu:

Monsieur André MIRJOL, demeurant à F-75011 Paris, 4, Square Saint Irenée,
représenté par M. Laurent Barnich, salarié, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxem-

bourg),

en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle, après avoir été signée ne varietur par le mandataire et le notaire

soussigné, sera annexée au présente acte à des fins d'enregistrement.

Lequel comparant, représenté comme décrit ci-dessus, a requis le notaire instrumentant d'acter que:
I. la société Loria International SA, une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg,

ayant son siège social à L-1720 Luxembourg, 6, rue Heine, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro B 139323, a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Elvinger, notaire de
résidence à Luxembourg, en date du 5 juin 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro
1632 du 3 juillet 2008 et dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution;

II. le capital social de la Société a été fixé à trente et un mille euros (31.000,-EUR) représenté par mille (1.000) actions

sans valeur nominale, chacune entièrement libérées;

III. le comparant est l'actionnaire unique de la Société;
IV. le comparant a décidé de dissoudre la Société, avec effet immédiat, étant donné que la Société a cessé toute activité;
V. le comparant, étant l'unique actionnaire de la Société et agissant comme liquidateur de la Société et au vu du bilan

de la Société au 26 novembre 2014 déclare:

- que tous les actifs ont été réalisés;
- que, sous réserve de ce qui suit, tous les passifs connus de la Société vis-à-vis des tiers ont été entièrement réglés;
- qu'il déclare irrévocablement assumer et payer au nom et pour le compte de la Société tous éventuels autres passifs

actuellement inconnus de la Société et dès lors impayés à cette date;

VI. la liquidation de la Société est dès lors à considérer comme clôturée;
VII. décharge pleine et entière est accordée aux administrateurs et au commissaire aux comptes de la Société pour

l'exercice de son mandat;

VIII. les livres et documents de la Société seront conservés pendant une durée de cinq ans à L-1720 Luxembourg, 6,

rue Heine.

Toutefois, aucune confusion de patrimoine entre la société dissoute et l'avoir social de, ou remboursement à, l'ac-

tionnaire unique ne pourra se faire avant le délai de trente jours (article 69 (2) de la loi sur les sociétés commerciales) à
compter de la publication du présent acte et sous réserve qu'aucun créancier de la Société présentement dissoute et
liquidée n'aura exigé la constitution de sûretés.

5275

L

U X E M B O U R G

<i>Frais

Les dépenses, frais, rémunérations et charges de toutes espèces qui incombent à la Société en raison du présent acte,

sont évalués approximativement à mille euros (1.000,- EUR).

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Lecture du présent acte faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, connu du notaire instrumentant

par ses noms, prénoms usuels, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Barnich, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/58255. Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €).

<i>Le Receveur

 (signé): Irène Thill.

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201771/53.
(140225940) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 2.145.750,00.

Siège social: L-8070 Bertrange, 33, rue du Puits Romain.

R.C.S. Luxembourg B 188.002.

In the year two thousand and fourteen, on the eighth day of December,
Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under

the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 155,489,243.- and registered with
the Luxembourg Register of Commerce and Companies (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) (the
“RCS”) under number B 191119 (the “Sole Shareholder”)

hereby represented by Mrs. Valérie Fagnant, employee, professionally residing in Bertrange, by virtue of a power of

attorney, given in Bertrange, on 8 December 2014.

Said proxy, after having been signed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned

notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, represented as aforementioned, declared being the Sole Shareholder of the private limited liability

company (société à responsabilité limitée) LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., registered with the RCS under number B 188002,
with a share capital of EUR 1,762,125.-, having its registered office at Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits
Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and incorporated under the initial name of LSREF3 Lux Invest-
ments VI S.à r.l. pursuant to a deed of the undersigned notary dated 6 June 2014 published in the Mémorial C, Recueil
des Sociétés et Associations (the “Mémorial”) dated 4 July 2014 number 1729, which articles of incorporation have been
amended for the last time on 7 November 2014 by a deed of the undersigned notary, not yet published in the Mémorial
(the “Company”).

The appearing party, through its proxyholder, declared and requested the undersigned notary to state that:
1. The entire issued share capital represented by 14,097 (fourteen thousand ninety-seven) shares is held by the Sole

Shareholder.

2. The Sole Shareholder is represented by proxy so that all shares in issue in the Company are represented at this

extraordinary decision of the Sole Shareholder so that the decisions can be validly taken on all the items of the below
agenda.

3. The agenda of the meeting is as follows:
a) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 383,625.- (three hundred eighty-three thousand

six hundred twenty-five euro) in order to increase the current capital from its current amount of EUR 1,762,125.-, (one
million seven hundred sixty-two thousand one hundred twenty-five euro) to an amount of EUR 2,145,750.- (two million
one hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro) by the creation and issue of 3,069 (three thousand sixty-nine)
new ordinary shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each (the “New Shares”);
subscription and payment of the New Shares by the Shareholder by a contribution in cash for a total amount of EUR
383,668.73 (three hundred eighty-three thousand six hundred sixty-eight euro and seventy-three cents) which shall be
allocated (a) to the share capital of the Company for an amount of EUR 383,625.- (three hundred eighty-three thousand

5276

L

U X E M B O U R G

six hundred twenty-five euro), and (b) to the share premium account for an amount of EUR 43,73 (forty-three euro and
seventy-three cents).

b) As a consequence, amendment of the first paragraph of article 6 of the Company's articles of association as follows

to reflect the share capital increase proposed above:

“  Art. 6. Subscribed capital.  The  Company's  subscribed  share  capital  is  fixed  at  EUR  2,145,750.-(two  million  one

hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro), represented by 17,166 (seventeen thousand one hundred sixty-
six) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”; and

c) Amendment of the share register of the Company in order to reflect the changes proposed above with power and

authority to any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder, to proceed, under his/her sole
signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share register of the Company and
(ii) to the performance of any formalities in connection therewith.

The Sole Shareholder, represented as stated above, then, asked the undersigned notary to record its resolutions as

follows:

<i>First resolution

The Sole Shareholder resolves to increase the share capital of the Company by an amount of EUR 383,625.- (three

hundred eighty-three thousand six hundred twenty-five euro) so as to raise it from its current amount of EUR 1,762,125.-,
(one million seven hundred sixty-two thousand one hundred twenty-five euro) to an amount of EUR 2,145,750.- (two
million one hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro) by the creation and issue of 3,069 (three thousand
sixty-nine) New Shares, having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each, in consideration of a
contribution in cash by the Sole Shareholder for a total amount of EUR 383,668.73 (three hundred eighty-three thousand
six hundred sixty-eight euro and seventy-three cents) allocated as follows.

<i>Subscription - Payment

The Sole Shareholder, represented as stated above, declared to subscribe for 3,069 (three thousand sixty-nine) New

Shares with a nominal value of one hundred twenty-five euro (EUR 125.-) per share and to make payment in full for such
New Shares by a contribution in cash for a total amount of EUR 383,668.73 (three hundred eighty-three thousand six
hundred sixty-eight euro and seventy-three cents) which is allocated (a) to the share capital of the Company for an amount
of EUR 383,625.- (three hundred eighty-three thousand six hundred twenty-five euro), and (b) to the share premium
account for an amount of EUR 43,73 (forty-three euro and seventy-three cents).

All the 3,069 (three thousand sixty-nine) New Shares issued are therefore fully subscribed and paid up in cash by the

Sole Shareholder so that the amount of EUR 383,668.73 (three hundred eighty-three thousand six hundred sixty-eight
euro and seventy-three cents) is at the free disposal of the Company as it has been proved to the undersigned notary
who expressly bears witness to it.

As a consequence of the above-resolved share capital increase, the Sole Shareholder now holds 17,166 (seventeen

thousand one hundred sixty-six) ordinary shares of the Company.

<i>Second resolution

As a consequence of the first resolution, the Sole Shareholder resolves to amend the first paragraph of article 6 of the

Company's articles of association, which English version shall be henceforth reworded as follows:

“ Art. 6. Subscribed capital. The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 2,145,750.- (two million one

hundred forty-five thousand seven hundred fifty euro) represented by 17,166 (seventeen thousand one hundred sixty-
six) ordinary shares having a nominal value of EUR 125.- (one hundred twenty-five euro) each.”

<i>Third resolution

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the change resolved

above and hereby empower and authorise any manager of the Company and/or any employee of the Sole Shareholder,
to proceed, under his/her sole signature, on behalf of the Company (i) to the registration of the New Shares in the share
register of the Company and (ii) to any formalities in connection therewith.

<i>Expenses

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are

estimated at two thousand two hundred euro (EUR 2,200.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith, that on request of the proxyholder of

the above appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the
same proxyholder and in case of divergences between the English and French texts, the English version shall be prevailing.

Whereof, the present notarial deed is drawn up in Luxembourg, at the office of the undersigned notary, on the day

named at the beginning of this document.

5277

L

U X E M B O U R G

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder appearing signed,

together with the notary the present original deed.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille quatorze, le huit décembre,
Par-devant Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU:

LSREF3 Dutch Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social

à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, ayant un
capital social de EUR 155.489.243,- et immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (le
«RCS») sous le numéro B 191119,

ici représentée par Mme Valérie Fagnant, employée, en vertu d'une procuration donnée à Bertrange, le 8 décembre

2014.

Ladite procuration, après signature ne varietur par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire,

restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel qu'indiqué ci-avant, a déclaré être l'Associé Unique de la société à responsabilité

limitée LSREF3 Eve Holdings S.à r.l., immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 188002, avec un capital social de EUR
1.762.125,-, ayant son siège social à l'Atrium Business Park-Vitrum, 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand
Duché de Luxembourg, et constituée sous le nom initial de LSREF3 Lux Investments VI S.à r.l. selon un acte du notaire
instrumentaire en date du 6 juin 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») du 4
juillet 2014, numéro 1729, lesquels statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 7 novembre 2014 par un acte
du notaire instrumentaire, non encore publié au Mémorial (la «Société»).

La partie comparante, par son mandataire, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:
1. La totalité du capital social, représentée par 14.097 (quatorze mille quatre-vingt-dix-sept) parts sociales, est détenu

par l'Associé Unique.

2. L'Associé Unique est représenté en vertu d'une procuration de sorte que toutes les parts sociales émises par la

Société sont représentées à cette décision extraordinaire de l'Associé Unique et toutes les décisions peuvent être vala-
blement prises sur tous les points de l'ordre du jour ci-après.

3. L'ordre du jour est le suivant:
a) Augmentation du capital social de la Société par un montant de EUR 383.625,- (trois cent quatre-vingt-trois mille

six cent vingt-cinq euros) afin d'augmenter le capital social de son montant actuel de EUR 1.762.125,- (un million sept
cent soixante-deux mille cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 2.145.750,- (deux millions cent quarante-cinq mille
sept cent cinquante euros) par voie de création et d'émission de 3.069 (trois mille soixante-neuf) nouvelles parts sociales
ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune (les «Nouvelles Parts Sociales»);
souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'Associé par un apport en numéraire pour un montant total
de EUR 383.668,73 (trois cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-huit euros et soixante-treize cents) qui sera alloué
(a) au capital social de la Société pour un montant de EUR 383.625,- (trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-
cinq euros), et (b) au compte de prime d'émission pour un montant de EUR 43,73 (quarante-trois euros et soixante-
treize cents);

b) En conséquence, modification du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société comme suit afin de

refléter l'augmentation de capital proposée ci-dessus:

« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social est fixé à EUR 2.145.750,- (deux millions cent quarante-cinq mille sept

cent cinquante euros) représenté par 17.166 (dix-sept mille cent soixante-six) parts sociales ordinaires d'une valeur
nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»;

c) Modification du registre de parts sociales de la Société de façon à refléter les changements proposés ci-dessus avec

pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société et/ou à tout employé de l'Associé Unique, afin d'effectuer, par sa
seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription des Nouvelles Parts Sociales dans le registre de parts sociales
de la Société et (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire de prendre acte des réso-

lutions suivantes:

<i>Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de EUR 383.625,- (trois cent quatre-

vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros) afin de le porter de son montant actuel de EUR 1.762.125,- (un million sept
cent soixante-deux mille cent vingt-cinq euros) à un montant de EUR 2.145.750,- (deux millions cent quarante-cinq mille
sept cent cinquante) par la création et l'émission de 3.069 (trois mille soixante-neuf) Nouvelles Parts Sociales, ayant une
valeur nominale de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune, en contrepartie d'un apport en numéraire de l'Associé
Unique d'un montant total de EUR 383.668,73 (trois cent quatre-vingt-trois mille six cent soixante-huit euros et soixante-
treize cents).

5278

L

U X E M B O U R G

<i>Souscription - Paiement

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-avant, a déclaré souscrire 3.069 (trois mille soixante-neuf) Nouvelles

Parts Sociales d'une valeur nominale de cent vingt-cinq euro (EUR 125,-) par part sociale et libérer intégralement ces
Nouvelles Parts Sociales souscrites par un apport en numéraire pour un montant total de EUR 383.668,73 (trois cent
quatre-vingt-trois mille six cent soixante-huit euros et soixante-treize cents) qui est alloué (a) au capital social de la Société
pour un montant de EUR 383.625,- (trois cent quatre-vingt-trois mille six cent vingt-cinq euros), et (b) au compte de
prime d'émission pour un montant de EUR 43,73 (quarante-trois euros et soixante-treize cents).

L'ensemble des 3.069 (trois mille soixante-neuf) Nouvelles Parts Sociales émises sont donc intégralement souscrites

et libérées en numéraire par l'Associé Unique, de sorte que la somme de EUR 383.668,73 (trois cent quatre-vingt-trois
mille six cent soixante-huit euros et soixante-treize cents) est à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il a été prouvé
au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

Suite à l'augmentation de capital décidée ci-dessus, l'Associé détient maintenant 17.166 (dix-sept mille cent soixante-

six) parts sociales ordinaires de la Société.

<i>Seconde résolution

Suite à la première résolution, l'Associé Unique décide de modifier le premier paragraphe de l'article 6 des statuts de

la Société, dont la version française aura désormais la teneur suivante:

« Art. 6. Capital Social Souscrit. Le capital social est fixé à EUR 2.145.750,- (deux millions cent quarante-cinq mille sept

cent cinquante) représenté par 17.166 (dix-sept mille cent soixante-six) parts sociales ordinaires d'une valeur nominale
de EUR 125,- (cent vingt-cinq euros) chacune.»

<i>Troisième résolution

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements effectués

ci-dessus et mandate et autorise par la présente tout gérant de la Société et/ou tout employé de l'Associé Unique, afin
d'effectuer, par sa seule signature, pour le compte de la Société, (i) l'inscription de l'émission des Nouvelles Parts Sociales
dans le registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) la réalisation de toute formalité en relation avec ce point.

<i>Frais

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués

approximativement à deux mille deux cents euros (EUR 2.200.-).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande du mandataire de la

partie comparante ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande
du même mandataire et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, au bureau du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.
Après lecture du document faite au mandataire de la partie comparante, ledit mandataire comparant et le notaire ont

signé le présent acte original.

Signé: V. Fagnant et M. Schaeffer.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2014. LAC/2014/59025. Reçu soixante-quinze euros (75.- €)

<i>Le Receveur ff. (signé): Carole Frising.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de publication au Mémorial,

Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201802/192.
(140225406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Montrium Europe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 12.500,00.

Siège social: L-5820 Fentange, 2A, rue Adolphe Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 175.062.

L’an deux mille quatorze, le huit décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

MONTRIUM S.A. ayant son siège social au 24, rue Saint Mathieu, L-2138 Luxembourg, RCS Luxembourg B 167434,
ici représentée par Madame Marta COTAS, employée privée, demeurant professionnellement à L-2138 Luxembourg,

24, rue St. Mathieu,

5279

L

U X E M B O U R G

En vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le mandataire de la partie comparante et le

notaire instrumentant, annexée aux présentes pour être formalisée avec elles.

Laquelle partie comparante a requis le notaire instrumentant d’acter ce qui suit:
- Que la société à responsabilité limitée MONTRIUM EUROPE S.à r.l., ayant son siège social à L-4362 Esch/Alzette,

9, avenue des Hauts Fourneaux, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant de résidence à Luxembourg,
en date du 30 janvier 2013, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 786 du 3 avril 2013.

- Que la partie comparante est le seul et unique associé actuel de ladite société et qu’elle a pris la résolution suivante:

<i>Résolution unique

L’associé unique décide de transférer le siège social de la société au 2A, rue Adolphe Diderich L-5820 Fentange de

sorte que le premier alinéa de l’article 5 des statuts aura désormais la teneur suivante:

«Le siège social est établi à Fentange.»
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états

et demeures, les comparants ont tous signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: M. COTAS et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59162. Reçu soixante-quinze euros (75.-

EUR).

<i>Le Receveur

 (signé): I. THILL.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Référence de publication: 2014201857/36.
(140225616) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 décembre 2014.

Sunrise Holding S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1463 Luxembourg, 29, rue du Fort Elisabeth.

R.C.S. Luxembourg B 112.381.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg.

Référence de publication: 2014203258/10.
(140226580) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Glencove S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 218.350,00.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.055.

<i>Extrait des résolutions prises par le Conseil de Gérance en date du 3 décembre 2014

En date du 3 décembre 2014, le conseil de gérance a décidé de transférer le siège social de la société du 13-15, avenue

de la Liberté, L-1931 Luxembourg, au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg et ceci avec effet immédiat.

De plus, il est porté à la connaissance des tiers que l'adresse professionnelle de Mr. Richard Brekelmans, Mrs Elizabeth

Timmer et Intertrust Management (Luxembourg) S.à r.l., gérants de la société a changé et est désormais le 6, rue Eugène
Ruppert L-2453 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 décembre 2014.

Signature
<i>Mandataire

Référence de publication: 2014203223/18.
(140226342) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.

Editeur:

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

5280


Document Outline

Binsfeld Immobilière II S.à.r.l.

CAH S.à r.l.

Centre d'Expertise et de Diagnostic Automobiles Luxembourgeois S.A.

Century S.à r.l.

CHDA Liegenschaftsverwaltung S.à r.l.

Coffee &amp; More S.A.

Field Conseil S.à r.l.

Glencove S.à r.l.

Graziel S.A.

Graziel S.à.r.l.

Helpling Group Holding S.à r.l.

Ibralux Holdings 2 S.A.

Idea Legno S.à r.l.

Immobilière N.Y. S.A.

Immo for life

Import East Solutions S.A.

Institut de Beauté LB S.à r.l.

ISM Conseil

Itau Active Asset Allocation Funds

Jalador Holding S.A., SPF

JAPI

JEMA Beauté Sàrl

Johnson Controls Eastern European Investment S.à r.l.

Loria International S.A.

LSREF3 Eve Holdings S.à r.l.

Montrium Europe S.à r.l.

Napoléon International S.A.

Naviglio Holdings S.à r.l.

Novalis S.A.

NT Human Services Investments S.A.

Orkor Luxco 2 S.à r.l.

OTMT Acquisition II S.à r.l.

RGI Co-Invest 1 S. à r.l.

Roermond S.A.

S &amp; A Capital International S.A.

Sacramento Resources S.A.

Salon Joëlle S.à r.l.

Samaya S.A.

Satisco S.A.

Sea Waves S.A.

Shanila Investments S.à r.l.

Sinval S.A.

Skandinaviska Enskilda Banken S.A.

Société de Boulangerie Artisanale au Levain S.à r.l.

Société des Anciens Etablissements AUTOCARS EMILE FRISCH

Sommar S.à r.l.

Stafford Sicav

Sunrise Holding S.A.

Sylvie Becker S.à r.l.