This site no longer hosts any data. The file you are looking for is probably available on the official Legilux website by clicking on this link.
Ce site n'héberge plus aucune donnée. Le fichier que vous cherchez est probablement accessible sur le site officiel Legilux en cliquant sur ce lien.
Diese Seite nicht mehr Gastgeber keine Daten. Die Datei, die Sie suchen ist wahrscheinlich auf der offiziellen Legilux Website, indem Sie auf diesen link verfügbar.
L
U X E M B O U R G
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
R E C U E I L D E S S O C I E T E S E T A S S O C I A T I O N S
Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.
C — N° 92
13 janvier 2015
SOMMAIRE
Bielefeld Neumarkt III S.à.r.l . . . . . . . . . . . .
4388
Bielefeld Neumarkt II S.à.r.l. . . . . . . . . . . . .
4381
Bielefeld Neumarkt IV S.à.r.l. . . . . . . . . . . .
4398
Cabinet d'experts Romain FISCH S.A. . . .
4370
Carmeuse Holding S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
C.B.C. Immo S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
CB S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
Centurion European German Property 2 S.
à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
Certes Capital SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
CGARD S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4374
ChloroPhil SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
C+ Investments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l. . . . .
4395
Clervaux Invest Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
C.L.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Codic Luxembourg S.A. . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
Cofimin S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
COMETAL-Constructions Métalliques
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
COMETAL-Constructions Métalliques
S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
COM-Invest Management Distriland
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
Com-Invest Management Rubens S.C.A.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
Com-Invest Management S.à r.l. . . . . . . . . .
4376
Com-Invest Management Wallmark
S.C.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
Co-Operation HJ S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
Crest Capital S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4375
Deloitte Audit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4376
Deloitte General Services . . . . . . . . . . . . . . .
4377
Deloitte Tax & Consulting . . . . . . . . . . . . . .
4378
Dora Couture S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4378
D.R.C. S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4373
E-Carat SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4379
Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l. . . .
4379
Elinar Group S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4380
EPM Services Sà.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4405
Euro-Fina S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4378
EuroHoldings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4380
European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4379
Fair TopCo S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4370
Fourteen Madder S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . .
4371
GCA Europe S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4380
Gerona Holdings S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . .
4377
G Pioneer Holdco I S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . .
4414
I.E.C.I.L. S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4380
Joal S.à r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4416
Leap International Sàrl . . . . . . . . . . . . . . . . .
4372
4369
L
U X E M B O U R G
C.L.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-9999 Wemperhardt, 4A, Op der Hardt.
R.C.S. Luxembourg B 175.643.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200818/10.
(140224617) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
C+ Investments, Société Anonyme.
Siège social: L-2540 Luxembourg, 15, rue Edward Steichen.
R.C.S. Luxembourg B 92.342.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200819/10.
(140224725) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
CABEFI, Cabinet d'experts Romain FISCH S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-6951 Olingen, 29A, rue de Flaxweiler.
R.C.S. Luxembourg B 150.249.
Les comptes annuels au 31/12/2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200820/9.
(140224641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Fair TopCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.600,00.
Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 161.808.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession sous seing privé intervenu en date du 12 Décembre 2014, que:
la société Fair Partners S.à r.l. S.C.A., Société en Commandite par Actions, immatriculée au registre de commerce et
des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 135.513, dont le siège social est situé au 121, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg,
a cédé la totalité des parts sociales de la société Fair Topco S.à r.l. aux sociétés suivantes:
- C-VIII FAIR INVESTOR, LLC, «a Limited Liability Company», immatriculée sous le numéro 4473338 dont le siège
social est situé au 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808: 6,225 parts sociales.
- Cz2 Fair S.à r.l., Société à Responsabilité Limitée immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxem-
bourg sous le numéro B 134.774, dont le siège social est situé au 121, avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg: 6,225
parts sociales.
- MEP FOUNDER PARTNER II LP, «a Limited Partnership», immatriculée au registre de commerce et des sociétés de
Guernsey, sous le numéro 1017, dont le siège social est situé au Canada Court, Upland Road St Peter Port, Guernsey,
Channel Island BGU-GY1 3BQ: 150 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la Société
i>Najat MOKHNACHE
Référence de publication: 2014200911/25.
(140224971) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4370
L
U X E M B O U R G
Centurion European German Property 2 S. à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1140 Luxembourg, 45-47, route d'Arlon.
R.C.S. Luxembourg B 118.290.
<i>Dépôt rectificatif du bilan qui a été déposé le 04.12.2014 avec comme numéro de référence de dépôt L140215376i>
Les comptes annuels au 31.12.2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200824/10.
(140225182) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Certes Capital SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 169.582.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014i>
<i>(l' «Assemblée»)i>
L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au
14 décembre 2014.
L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15
décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2018:
- Caroline Kinyua née le 22 Février 1978 à Nairobi, Kenya, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
À Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014200825/19.
(140225005) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
ChloroPhil SA, Société Anonyme.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 167.735.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200826/10.
(140224884) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Fourteen Madder S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 190.543.
En vertu d'un contrat de cession daté du 23 octobre 2014, Alter Domus Luxembourg S.à r.l. a cédé l'intégralité des
parts sociales qu'il détenait dans la Société à OpCapita Consumer Opportunities Fund, L.P., une société en commandite
régie par les lois de Guernesey, ayant son siège social à Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernesey, GY1
3BQ, immatriculée sous le numéro 2037.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour Fourteen Madder S.à r.l.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014200913/15.
(140225030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4371
L
U X E M B O U R G
Co-Operation HJ S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 79.115.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 30 novembre 2014.
Natacha Hainaux.
Référence de publication: 2014200828/10.
(140225119) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Leap International Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.394,68.
Siège social: L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie.
R.C.S. Luxembourg B 61.456.
L’an deux mille quatorze, le deux décembre.
Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.
S'est réunie
l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée LEAP INTERNATIONAL, S.à
r.l., ayant son siège social à L-1510 Luxembourg, 57, avenue de la Faïencerie, constituée suivant acte de Maître Jean Seckler,
notaire de résidence à Junglinster, en date du 25 septembre 1997, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations
C numéro 73 du 4 février 1998, dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date
du 23 octobre 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 2819 du 5 décembre 2007.
L’assemblée se compose de son unique associé, à savoir:
Madame Martine Anne Marguerite Françoise Marie de Stoop, demeurant à Quinta da Vela, Murcafem, 2825-836 Tra-
faria, Portugal,
Ici représentée par Madame Annick Braquet, demeurant professionnellement à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,
En vertu d’une procuration sous seing privé.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée “ne varietur” par le comparant et le notaire instrumentant, annexée
aux présentes pour être formalisée avec elles.
Ceci exposé, le comparant prémentionné a requis le notaire instrumentant de documenter ainsi qu'il suit les résolutions
suivantes:
<i>Première résolutioni>
L’associé unique décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour.
<i>Deuxième résolutioni>
L’associé unique décide de nommer comme liquidateur, Monsieur Rui Maria DE STOOP CAMÕES TEIXEIRA GUER-
RA, né le 21 février 1963 à Lisbonne (Portugal), demeurant à F-78290 Croissy-sur-Seine, 17, chemin des Présidannes.
Le liquidateur a les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 144 à 148bis des lois coordonnées sur les sociétés
commerciales. Il peut accomplir les actes prévus à l’article 145 sans devoir recourir à l’autorisation de l’assemblée générale
dans les cas où elle est requise.
Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.
Il peut, sous sa responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs mandataires
telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture, le mandataire de la partie comparante a signé avec le notaire instrumentant le présent acte.
Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.
Enregistré à Luxembourg A.C., le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59146. Reçu douze euros (12.- EUR).
<i>Le Receveuri> (signé): I. THILL.
- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200318/44.
(140224456) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 décembre 2014.
4372
L
U X E M B O U R G
CB S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 217, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 105.266.
Le Bilan au 31 décembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signature.
Référence de publication: 2014200841/10.
(140224593) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Carmeuse Holding S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1651 Luxembourg, 9, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 114.218.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration de la société CARMEUSE HOLDING S.A. qui s'est tenue en datei>
<i>du 25 novembre 2014i>
Il a été décidé ce qui suit:
Conformément à l'article 42 nouveau de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales tel
qu'adopté par la loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur, le Conseil d'Administration
décide de désigner en qualité de dépositaire agréé, Maître Véronique Wauthier de l'Etude Tabery & Wauthier, 10 rue
Pierre d'Aspelt, L-1142 Luxembourg, ou son successeur dans la profession.
Les actions de Carmeuse Holding S.A. non réclamées en échange des actions de la société absorbée du chef de la
fusion-absorption approuvée lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 11 septembre 2007 (Mémorial C Recueil
des Sociétés et Associations N° 2008 du 18 septembre 2007) subiront le même traitement. Les actions au porteur
Carmeuse Holding S.A. seront immobilisées auprès du dépositaire au nom de l'actionnaire présentant les titres de la
société absorbée à l'échange, ou convertis au nominatif.
Extrait certifié conforme
Signatures
<i>Mandatairei>
Référence de publication: 2014200839/22.
(140224576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
D.R.C. S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-9991 Weiswampach, 2, am Hock.
R.C.S. Luxembourg B 83.889.
<i>Extrait du Procès-verbal de l'assemblée générale du 2 décembre 2014i>
- L'Assemblée renouvelle le mandat des Administrateurs suivants:
* la société LP INVEST SA, représentée par M. Philippe Moortgat, demeurant professionnellement au 58, Breendonk-
dorp à B-2870 Puurs
* la société LEMA SA, représentée par M. Michel Moortgat, demeurant professionnellement au 58, Breendonkdorp à
B-2870 Puurs
* la société Risk & Reinsurance Solutions SA en abrégé 2RS, représentée par Mr Gérard Dardenne tous deux demeurant
professionnellement au 23 Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg,
Leur mandat est prolongé jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en décembre 2015 pour
statuer sur les comptes de l'exercice se clôturant le 30 juin 2015.
- L'Assemblée renouvelle le mandat de VPC Luxembourg (B 172513) en tant que réviseur d'entreprises de la société
pour une période de un an qui viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de décembre 2015 qui statuera
sur les comptes de l'exercice se clôturant le 30 juin 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
<i>Pour la sociétéi>
Référence de publication: 2014200865/22.
(140225122) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4373
L
U X E M B O U R G
C.B.C. Immo S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4959 Bascharage, 9, Zone Artisanale Zaemer.
R.C.S. Luxembourg B 148.226.
<i>Extrait de résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014i>
<i>Première résolution.i>
L'Assemblée Générale constate que le mandat des administrateurs, de l'administrateur-délégué et du commissaire aux
comptes est venu à échéance.
<i>Deuxième résolution.i>
L'Assemblée décide de nommer comme nouveaux administrateurs de la société:
- Monsieur Daniel SANTARINI, directeur de société, demeurant à L-4879 LAMADELAINE 79 rue de la Montagne,
administrateur-délégué
- Monsieur Germain JUNG, ingénieur-technicien, demeurant à L-3265 BETTEMBOURG 10 op Fankenacker
- Monsieur Jean-Paul JACOBY, ingénieur-technicien, demeurant à L-4397 PONTPIERRE 19 am Bockeisfeld.
leur mandat expirant à l'issue de l'Assemblée Générale ordinaire en 2019.
L'Assemblée décide de nommer commissaire aux comptes, la Société Luxembourgeoise de Révision Sàrl, société à
responsabilité limitée, avec siège social à L-1220 Luxembourg, 246 rue de Beggen, son mandat expirant à l'Assemblée
Générale ordinaire en 2019.
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
SANTARINI Daniel / JUNG Germain / JACOBY Jean-Paul.
Référence de publication: 2014200843/23.
(140224820) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
CGARD S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.
R.C.S. Luxembourg B 183.073.
I. Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 12 décembre 2014, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
- Nomination de Sandra Legrand, avec adresse professionnelle au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, au
mandat d’administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors de l’assemblée
générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui se tiendra en
2020;
- Nomination de Joan Sophie Kiener-Wegmann, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile Reuter, L- 2420
Luxembourg au mandat d’administrateur de catégorie B, avec effet immédiat et pour une période venant à échéance lors
de l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et
qui se tiendra en 2020;
- Acceptation de la démission d’Anke Jager, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-
Findel de son mandat d’administrateur de catégorie B, avec effet immédiat;
- Acceptation de la démission de James Bermingham, avec adresse professionnelle au 7, rue Lou Hemmer, L-1748
Luxembourg-Findel de son mandat d’administrateur de catégorie B, avec effet immédiat;
II. Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue en date du 16 décembre 2014, les actionnaires ont pris les décisions
suivantes:
- Nomination de Jennifer Ferrand, avec adresse professionnelle au 24, avenue Emile Reuter, L- 2420 Luxembourg au
mandat d’administrateur de catégorie A, avec effet au 12 décembre 2014 et pour une période venant à échéance lors de
l’assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’exercice social se clôturant au 31 décembre 2019 et qui
se tiendra en 2020;
- Acceptation de la démission de Kathryn O’Sullivan, avec adresse au 92, route de Remich, L-5330 Moutfort de son
mandat d’administrateur de catégorie A, avec effet au 12 décembre 2014;
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200847/31.
(140224650) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4374
L
U X E M B O U R G
Clervaux Invest Sàrl, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 17.656.900,00.
Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 143.801.
<i>Extrait des résolutions du conseil de gérance du 5 décembre 2014i>
Le conseil de gérance accepte la démission de Monsieur Alain ROCH, gérant de catégorie A.
Les gérants restants cooptent Monsieur James Bradley UNSWORTH, gérant, demeurant professionnellement 483,
Herengracht NL - 1017 BT Amsterdam qui a déclaré accepter le mandat de gérant de catégorie A.
Monsieur James Bradley UNSWORTH terminera le mandat de gérant de catégorie A, qui viendra à échéance lors de
l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes annuels au 31 décembre 2014.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200848/16.
(140225168) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Codic Luxembourg S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2324 Luxembourg, 4, avenue Jean-Pierre Pescatore.
R.C.S. Luxembourg B 58.352.
Les comptes annuels arrêtés au 30/04/2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200852/9.
(140225305) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Cofimin S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 90.803.
Le Conseil d'Administration prend note du changement d'adresse de Madame Mireille GEHLEN, qui désormais de-
meure au 2, rue Stade J.-F. Kennedy, L-3502 Dudelange.
Pour extrait conforme
Référence de publication: 2014200853/10.
(140224914) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Crest Capital S.A., Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-8041 Strassen, 65, rue des Romains.
R.C.S. Luxembourg B 144.025.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014i>
<i>(l' «Assemblée»)i>
L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au
14 décembre 2014.
L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15
décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:
- Daniel le Delnoije née le 14 Février 1974, à Sittard, Pays-Bas, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince
Henri, L-1724 Luxembourg.
À Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Pour extrait conforme
La Société
Signatures
Référence de publication: 2014200864/19.
(140225002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4375
L
U X E M B O U R G
COM-Invest Management Distriland S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 141.243.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200857/10.
(140224726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Com-Invest Management Rubens S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 115.061.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200858/10.
(140224710) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Com-Invest Management S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 113.108.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200859/10.
(140224606) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
COMETAL-Constructions Métalliques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 72.212.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200861/10.
(140225126) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 67.895.
Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire, tenue le 25 novembre 2014, que:
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise agréé, H.R.T. Révision S.A., RCS B 51238,
dont le siège social est établi à L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer
sur les comptes arrêtés au 31 mai 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200867/14.
(140225010) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4376
L
U X E M B O U R G
Com-Invest Management Wallmark S.C.A., Société en Commandite par Actions.
Siège social: L-1650 Luxembourg, 6, avenue Guillaume.
R.C.S. Luxembourg B 113.130.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200860/10.
(140224738) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
COMETAL-Constructions Métalliques S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-4570 Niedercorn, rue Pierre Gansen.
R.C.S. Luxembourg B 72.212.
Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Signature.
Référence de publication: 2014200862/10.
(140225127) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Deloitte General Services, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 40.400,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.179.
Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire, tenue le 25 novembre 2014, que:
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise agréé, H.R.T. Révision S.A., RCS B 51238,
dont le siège social est établi à L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer
sur les comptes arrêtés au 31 mai 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200868/14.
(140225011) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Gerona Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 162.387.
EXTRAIT
Il résulte d'une décision prise par l'associé unique de la Société en date du 28 novembre 2014 que:
- La démission de Monsieur Philip Godley de ses fonctions de gérant de catégorie B de la Société a été acceptée avec
effet au 28 novembre 2014.
- Madame Alexandra Fantuz, née le 25 septembre 1974 à Hayange, demeurant professionnellement au 51, avenue John
F. Kennedy, L-1855, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, a été nommée aux fonctions de gérante de catégorie
B de la Société en remplacement de Monsieur Philip Godley démissionnaire, à compter du 28 novembre 201 4 pour une
durée indéterminée.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014200939/20.
(140225050) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4377
L
U X E M B O U R G
Deloitte Tax & Consulting, Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 35.000,00.
Siège social: L-2220 Luxembourg, 560, rue de Neudorf.
R.C.S. Luxembourg B 165.178.
Il résulte de l'Assemblée générale ordinaire, tenue le 25 novembre 2014, que:
1. L'assemblée décide de renouveler le mandat du réviseur d'entreprise agréé, H.R.T. Révision S.A., RCS B 51238,
dont le siège social est établi à L-8030 Strassen, 163 rue du Kiem, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire devant statuer
sur les comptes arrêtés au 31 mai 2015.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200869/14.
(140225009) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Dora Couture S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-4130 Esch-sur-Alzette, 47, avenue de la Gare.
R.C.S. Luxembourg B 150.171.
EXTRAIT
Il résulte d'un contrat de cession de parts sociales du 15 décembre 2014 entre Dora MORELLI épouse ANASTASI,
née le 23 septembre 1954 à Thil (France), demeurant à F-54190 Villerupt, 62, rue Emile Zola et Sandro ANASTASI, né
le 6 janvier 1947 à Gualdo Tadino (Italie), demeurant à F-54190 Villerupt, 62, rue Emile Zola et Ana Paula VIEIRA MA-
RINHO DA SILVA, née le 17 janvier 1973 à Lisbonne (Portugal), demeurant à L-4348 Esch-sur-Alzette, 32, rue Léon
Weirich et Mario Fernando MARTINS MARINHO DA SILVA, né le 17 février 1973 à Lisbonne (Portugal), demeurant à
L-4348 Esch-sur-Alzette, 32, rue Léon Weirich, que Madame Dora MORELLI épouse ANASTASI a cédée 24 parts sociales
de la Société à Madame Ana Paula VIEIRA MARINHO DA SILVA et que Monsieur Sandro ANASTASI a cédée 76 parts
sociales de la Société à Monsieur Mario Fernando MARTINS MARINHO DA SILVA avec effet immédiat en présence de
Dora Couture S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant approuvée la prédite cession.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Référence de publication: 2014200877/19.
(140224871) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Euro-Fina S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.
R.C.S. Luxembourg B 20.882.
<i>Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants et de la décision du conseil d'administration en date du 8i>
<i>décembre 2014i>
1. M. Julien NAZEYROLLAS, administrateur de sociétés, né à Nancy (France), le 19 décembre 1978, demeurant pro-
fessionnellement à L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert, a été coopté comme administrateur de la société en
remplacement de Mme Katia CAMBON, administrateur de catégorie B et présidente du conseil d'administration démis-
sionnaire, dont il achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de
2019.
Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.
2. M. Julien NAZEYROLLAS a été élu comme président du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée
générale ordinaire de 2019.
Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
<i>Pour EURO-FINA S.A.
Un mandatairei>
Référence de publication: 2014200907/21.
(140225162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4378
L
U X E M B O U R G
E-Carat SA, Société Anonyme de Titrisation.
Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.
R.C.S. Luxembourg B 147.332.
<i>Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 12 décembre 2014i>
<i>(l' «Assemblée»)i>
L'Assemblée accepte la démission de Martijn Sinninghe Damsté en tant qu'administrateur de la Société avec effet au
14 décembre 2014.
L'Assemblée décide de nommer la personne suivante en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet 15
décembre 2014 et ce jusqu'à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2016:
- Caroline Kinyua née le 22 Février 1978 à Nairobi, Kenya, avec adresse professionnelle au 9B, Boulevard Prince Henri,
L-1724 Luxembourg.
À Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Pour extrait conforme
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014200882/19.
(140225004) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 25.004,00.
Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.
R.C.S. Luxembourg B 157.161.
Suite aux résolutions de l'associé unique de la Société en date du 16 décembre 2014 la décision suivante a été prise:
1. Election du nouveau Gérant A pour une durée indéterminée à compter du 17 décembre 2014:
Hamish M. Walker, né le 9 octobre 1984 à Sydney, Australie, avec adresse professionnelle au Building 4, Chiswick
Park, 566 Chiswick High Road, Londres, W4 5YE, Royaume-Unis.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l.
Patrick Leonardus Cornelis van Denzen
<i>Gérant de classe Bi>
Référence de publication: 2014200884/16.
(140224857) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1855 Luxembourg, 51, avenue J. F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 190.283.
EXTRAIT
Suite au contrat de cession du 1
er
décembre 2014 entre l'associé unique de la Société, European Real Estate Debt
S.àr.l., en tant que cédant, et European Real Estate Senior Debt 1 L.P., un limited partnership immatriculé en Angleterre
(Royaume-Uni) auprès du Companies House sous le numéro LP16296, ayant son siège social au 94 Solaris Avenue, Camana
Bay, PO Box 1348, KY1-1108, Iles Caïmanes, en tant que cessionnaire, le cédant a cédé la totalité de ses parts sociales
au cessionnaire de sorte que European Real Estate Senior Debt 1 L.P. détienne, à compter du 1
er
décembre 2014,
l'intégralité du capital social de la Société représenté par 12.500 parts sociales.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Pour extrait sincère et conforme
Sanne Group (Luxembourg) S.A.
Référence de publication: 2014200890/19.
(140224599) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4379
L
U X E M B O U R G
Elinar Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 10.970.000,00.
Siège social: L-1882 Luxembourg, 5, rue Guillaume Kroll.
R.C.S. Luxembourg B 163.046.
En date du 12 novembre 2014, l'associé CONSEL LIMITED avec siège social au 232, des Vœux Road Central, 11/Fka
Wah Bank Centre, Hong Kong, a cédé la totalité de ses 105.934 parts sociales de classe A à ELINAR HOLDING COM-
PANY, avec siège social au ow.1, Merchant Aleshin sq. Ateptsevo village, 143322 Naro-Fominsk District, Moscou, Russie
qui les acquiert.
En conséquence, l'associé unique de la société est Elinar Holding Company, précité, avec 105.934 parts sociales de
classe A et 10.864.066 parts sociales de classe B
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 9 décembre 2014.
Référence de publication: 2014200886/16.
(140224578) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
EuroHoldings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: EUR 12.500,00.
Siège social: L-1371 Luxembourg, 7, Val Sainte Croix.
R.C.S. Luxembourg B 189.130.
L'adresse correcte de M. Michael Ellis, Gérant avec pouvoir de signature A de la société EuroHoldings S.à r.l. ayant
son siège social au 7, Val Ste-Croix, L-1371 Luxembourg, est Route de Divonne 29, CH-1260 Nyon (Suisse).
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 16 décembre 2014.
Signatures
<i>L'agent domiciliatairei>
Référence de publication: 2014200891/14.
(140224919) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
I.E.C.I.L. S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1627 Luxembourg, 7, rue Giselbert.
R.C.S. Luxembourg B 18.821.
Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Pour ordre
EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.
Boîte Postale 1307
L-1013 Luxembourg
Référence de publication: 2014200983/14.
(140225112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
GCA Europe S.A., Société Anonyme.
Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 123.788.
Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
FIDUO
Référence de publication: 2014200947/10.
(140224843) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
4380
L
U X E M B O U R G
Bielefeld Neumarkt II S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.880.
STATUTES
In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bielefeld Neumarkt Holding S.a r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, on December 17
th
,
2014, by a deed drawn up by the officiating notary, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch
in process of being filed at Companies and Trade Register of Luxembourg, (“Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg”)
Here represented by Mr. Max MAYER, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of
a proxy delivered to him.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and deve-
lopment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a
financial participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Neumarkt II S.ar.l..
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
4381
L
U X E M B O U R G
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager
and one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution
of the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members
or not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
4382
L
U X E M B O U R G
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the
sole manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for trans-
actions up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred
thousand euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid
law of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual
contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers
in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be,
distributed to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall
refer to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing Bielefeld Neumarkt Holding S.a r.l., prenamed and represented as stated here-above, de-
clared to have subscribed to the whole share capital of the Company.
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.
4383
L
U X E M B O U R G
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Isaac SCHAPIRA, director, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens,
London NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
b) Mr Patrice GALLASIN, director, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address
at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
c) Mr Andrew PETTIT, director, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
d) Mr Nicholas WEST, director, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Deutsche Übersetzung des vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend vierzehn, am siebzehnten Dezember.
Vor uns, dem amtierenden Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Bielefeld Neumarkt Holding S.a r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet am 17. Dezember 2014, auf
Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in L-1470
Luxemburg, 70, route d'Esch, welche dabei ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragen zu werden,
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxemburg, aufgrund einer ihm
ausgestellten Vollmacht.
Besagte Vollacht soll nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.
Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art,
in Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft
kann zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland
tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und
4384
L
U X E M B O U R G
Entwicklung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Neumarkt II S.ar.l..
4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann
durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde
verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebe-
nenfalls der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet wer-
den. Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten
der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Per-
sonen im Ausland, kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände
nicht mehr gegeben sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft,
welche auch bei zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst
Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden
Anteile vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäfts-
jahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten
oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss
sich die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kate-
gorie B zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbe-
schluss abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine
Gesellschafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
4385
L
U X E M B O U R G
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zu-
sammen mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten
an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle Ge-
schäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Ge-
schäftsführerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu
hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommuni-
kationsmitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführer-
versammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen
Ausfertigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Tele-
tex, Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haf-
tung in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche
Verpflichtung im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind
und die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
4386
L
U X E M B O U R G
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufge-
stellt.
Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüt-
tet. Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflösung
16. Auflösung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den
oder die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse
übertragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienene Bielefeld Neumarkt Holding S.a r.l., vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile
der Gesellschaft gezeichnet zu haben.
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft
der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.450,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Isaac SCHAPIRA, Direktor, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft
Gardens, London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Herr Patrice GALLASIN, Direktor, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäfts-
ansässig 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
c) Herr Andrew PETTIT, Direktor, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäfts-
ansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
4387
L
U X E M B O U R G
d) Herr Nicholas WEST, Direktor, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig
105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d‘Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5104. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014202999/397.
(140226619) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
Bielefeld Neumarkt III S.à.r.l, Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.881.
STATUTES
In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, on December 17
th
,
2014, by a deed drawn up by the officiating notary, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch
in process of being filed at Companies and Trade Register of Luxembourg, (“Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg”)
Here represented by Mr. Max MAYER, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of
a proxy delivered to him.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and deve-
lopment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a
financial participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Neumarkt III S.àr.l..
4388
L
U X E M B O U R G
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager
and one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution
of the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members
or not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
4389
L
U X E M B O U R G
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the
sole manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for trans-
actions up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred
thousand euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid
law of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual
contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
4390
L
U X E M B O U R G
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers
in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be,
distributed to the members proportionally to the shares they hold.
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall
refer to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, de-
clared to have subscribed to the whole share capital of the Company.
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Isaac SCHAPIRA, director, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens,
London NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
b) Mr Patrice GALLASIN, director, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address
at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
c) Mr Andrew PETTIT, director, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
d) Mr Nicholas WEST, director, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend vierzehn, am siebzehnten Dezember.
Vor uns, dem amtierenden Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet am 17. Dezember 2014, auf
Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in L-1470
Luxemburg, 70, route d'Esch, welche dabei ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragen zu werden,
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxemburg, aufgrund einer ihm
ausgestellten Vollmacht.
Besagte Vollacht soll nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.
4391
L
U X E M B O U R G
Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art,
in Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft
kann zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland
tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und
Entwicklung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Neumarkt III S.àr.l..
4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann
durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde
verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebe-
nenfalls der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet wer-
den. Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten
der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Per-
sonen im Ausland, kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände
nicht mehr gegeben sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft,
welche auch bei zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst
Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
4392
L
U X E M B O U R G
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden
Anteile vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäfts-
jahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten
oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss
sich die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kate-
gorie B zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbe-
schluss abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine
Gesellschafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zu-
sammen mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten
an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle Ge-
schäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Ge-
schäftsführerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu
hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommuni-
kationsmitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführer-
versammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen
Ausfertigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Tele-
tex, Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
4393
L
U X E M B O U R G
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haf-
tung in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche
Verpflichtung im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind
und die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufge-
stellt.
Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüt-
tet. Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflösung
16. Auflösung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den
oder die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse
übertragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienene Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile
der Gesellschaft gezeichnet zu haben.
4394
L
U X E M B O U R G
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft
der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.450,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Isaac SCHAPIRA, Direktor, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft
Gardens, London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Herr Patrice GALLASIN, Direktor, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäfts-
ansässig 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
c) Herr Andrew PETTIT, Direktor, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäfts-
ansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
d) Herr Nicholas WEST, Direktor, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig
105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d‘Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5105. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014203000/397.
(140226638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Enseigne commerciale: C-K-A-N Beauty.
Siège social: L-4431 Belvaux, 72, rue des Champs.
R.C.S. Luxembourg B 178.341.
Handelsbezeichnungen: C-K-A-N Beauty
C-K-A-N Services,
C-K-A-N Events,
The Studio by C-K-A-N Beauty,
LuxBeautyConcept
Im Jahre zweitausendvierzehn, den elften Tag im Monat Dezember.
Vor dem unterzeichnenden Notar Paul BETTINGEN, mit dem Amtssitze zu Niederanven.
Sind erschienen:
1.- Herr Dr. Alfred NEHRING, Jurist und Bankkaufmann, geboren in Insterburg (Deutschland) am 27. Juni 1933,
wohnhaft in Fährblick 10, in D-24790 Schacht-Audorf (Schleswig-Holstein),
2.- seine Ehefrau, Frau Karin NEHRING, geborene Struckmann, Geschäftsführungsassistentin, geboren in Schneeren
(Deutschland) am 14. August 1945, wohnhaft in Fährblick 10, D-24790 Schacht-Audorf, und
3.- Herr Claus Nehring, Kaufmann, geboren am 23. Juni 1963, in Göttingen (Deutschland), wohnhaft in L-4431 Belvaux,
72 rue des Champs.
4395
L
U X E M B O U R G
Welche Erschienenen den instrumentierenden Notar ersuchen, Folgendes zu beurkunden:
Die Erschienenen, vorbenannt unter 1° und 2°, sind die alleinige Gesellschafter der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l., mit Sitz in L-4431 Belvaux, 72 rue des Champs, eingetragen im Handels-
register zu Luxemburg unter Sektion B und der Nummer 178341, gegründet gemäss Urkunde, aufgenommen durch den
unterzeichnenden Notar am 25. Juni 2013, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 1982 vom 16. August 2013, (die
„Gesellschaft“).
In ihrer Eigenschaft als alleinige Gesellschafter erklären die vorgenannten Erschienenen dem instrumentierenden Notar,
sich zu einer ausserordentlichen Generalversammlung zusammenzufinden mit folgender Tagesordnung:
<i>Tagesordnungi>
1.- Annahme der Handelsbezeichnungen C-K-A-N Beauty, C-K-AN Services, C-K-A-N Events, The Studio by C-K-A-
N Beauty, und LuxBeautyConcept, und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der Satzung der Gesellschaft.
2.- Abänderung der Anzahl und des Nominalwertes der Anteile der Gesellschaft damit das Gesellschaftskapital nun-
mehr in vierundachtzig (84) Anteile eingeteilt ist mit einem Nominalwert von eintausend Euro (EUR 1.000,-) pro Anteil
3.- Erhöhung des Gesellschaftskapitals um sechsundfünfzigtausend Euro (EUR 56.000,-), um es von seinem jetzigen
Stand von vierundachtzigtausend Euro (EUR 84.000,-) auf einhundertvierzigtausend Euro (EUR 140.000,-) zu bringen, dies
durch die Schaffung von sechsundfünfzig (56) neue Anteile mit einem Nennwert von je eintausend Euro (EUR 1.000,-)
welche die gleichen Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Anteile. Die sechsundfünfzig (56) neuen Anteilen
werden von Herrn Claus Nehring, vorbenannt unter 3°, gezeichnet, so dass nach Kapitalerhöhung die Anteile gehalten
werden wie folgt:
- Herr Dr. Alfred NEHRING, vorbenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
- seine Ehefrau, Frau Karin NEHRING, vorbenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
- Herr Claus Nehring, vorbenannt, sechsundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
TOTAL: EINHUNDERTVIERZIG ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
4.- Abänderung von Artikel 6 der Satzung der Gesellschaft.
5.- Abänderung des Gesellschaftszwecks und dementsprechend Abänderung von Artikel 3 wie folgt:
Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf den Gebieten des Marketings in
allen Medienbereichen (Marketing-Service), das Management und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art, speziell
von Werbeveranstaltungen und Produktpräsentationen (Event-Service), Dienstleistungen und Beratungen für Firmen
(Firmen-Service) und der Handel mit Kosmetikartikeln, Parfums und damit zusammenhängenden Waren sowie der Betrieb
von Kosmetik-Studios (Beauty Services).
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.
6.- Abänderung von Artikel 11, Absatz 3 wie folgt:
Art. 11. (Absatz 3). Im Todesfall eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit dessen Erben fortgesetzt, wenn diese
bereits Gesellschafter sind oder von den verbliebenen Gesellschaftern aus diesem Anlass als neue Gesellschafter aufge-
nommen werden. Sind oder werden die Erben nicht Gesellschafter, fallen dessen Geschäftsanteile an die verbleibenden
Gesellschafter im Verhältnis ihrer bisherigen Kapitalanteile und sind zum Buchwert an die Erben auszuzahlen.
7.- Ernennung von Herrn Claus Nehring als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.
8.- Verschiedenes.
Gemäss der Tagesordnung haben die Erschienenen, vertreten wie vorerwähnt, einstimmig folgende Beschlüsse gefasst.
<i>Erster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Handelsbezeichnungen C-K-A-N Beauty, C-K-A-N Services, C-K-A-N Events, The
Studio by C-K-A-N Beauty, und LuxBeautyConcept, anzunehmen und dementsprechend Abänderung von Artikel 1 der
Stazung der Gesellschaft wie folgt:
Art. 1. Die vorbenannten Erschienenen errichten hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung unter der Be-
zeichnung "C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l." und können unter den Handelsbezeichnungen C-K-A-N Beauty, C-K-
A-N Services, C-K-A-N Events, The Studio by C-K-A-N Beauty, und LuxBeautyConcept, tätig werden.
<i>Zweiter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen die Zahl und das Nominalwert der Anteile der Gesellschaft abzuändern damit das
Gesellschaftskapital nunmehr in vierundachtzig (84) Anteile eingeteilt ist mit einem Nominalwert von eintausend Euro
(EUR 1.000,-) pro Anteil
4396
L
U X E M B O U R G
<i>Dritter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftskapitals um sechsundfünfzigtausend Euro (EUR 56.000,-) zu erhöhen,
um es von seinem jetzigen Stand von vierundachtzigtausend Euro (EUR 84.000,-) auf einhundertvierzigtausend Euro (EUR
140.000,-) zu bringen, dies durch die Schaffung von sechsundfünfzig (56) neue Anteile mit einem Nennwert von je ein-
tausend Euro (EUR 1.000,-) welche die gleichen Rechte und Vorteile geniessen wie die bestehenden Anteile. Die
sechsundfünfzig (56) neue Anteile werden von Herrn Claus Nehring, vorbenannt unter 3°, gezeichnet, so dass nach
Kapitalerhöhung die Anteile gehalten werden wie folgt:
- Herr Dr. Alfred NEHRING, vorbenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
- seine Ehefrau, Frau Karin NEHRING, vorbenannt, zweiundvierzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
- Herr Claus Nehring, vorbenannt, sechsundfünfzig Anteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
TOTAL: EINHUNDERTVIERZIG ANTEILE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Die gesamten sechsundfünfzig (56) Anteile wurden voll in barem Gelde eingezahlt, sodass ab heute der Gesellschaft
die zusätzliche Summe von sechsundfünfzigtausend Euro (EUR 56.000,-) zur Verfügung steht, so wie dies dem unter-
zeichneten Notar nachgewiesen wurde.
<i>Vierter Beschlussi>
Infolge vorangehender Kapitalerhöhung beschliessen die Gesellschafter den Artikel 6 der Statuten wie folgt abzuändern:
„ Art. 6. Das Gesellschaftskapital beträgt EINHUNDERTVIERZIGTAUSEND Euro (EUR 140.000,-) und ist eingeteilt
in EINHUNDERTVIERZIG (140) Geschäftsanteile zu je eintausend Euro (EUR 1.000,-).
Das Gesellschaftskapital kann unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Großherzogtums Luxemburg auf
Beschluss der Gesellschafterversammlung erhöht oder ermäßigt werden.“
<i>Fünfter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen das Gesellschaftszweck abzuändern und dementsprechend Abänderung von Artikel 3
wie folgt:
„ Art. 3. Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen aller Art auf den Gebieten des Marketings in
allen Medienbereichen (Marketing-Service), das Management und die Durchführung von Veranstaltungen aller Art, speziell
von Werbeveranstaltungen und Produktpräsentationen (Event-Service), Dienstleistungen und Beratungen für Firmen
(Firmen-Service) und der Handel mit Kosmetikartikeln, Parfums und damit zusammenhängenden Waren sowie der Betrieb
von Kosmetik-Studios (Beauty Services).
Die Gesellschaft kann jede andere Tätigkeit welche mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Verbindung
steht oder welche diesen fördern kann im In- und Ausland, ausüben.“
<i>Sechster Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Artikel 11, Absatz 3 abzuändern wie folgt:
Art. 11. (Absatz 3). „Im Todesfall eines Gesellschafters wird die Gesellschaft mit dessen Erben fortgesetzt, wenn diese
bereits Gesellschafter sind oder von den verbliebenen Gesellschaftern aus diesem Anlass als neue Gesellschafter aufge-
nommen werden. Sind oder werden die Erben nicht Gesellschafter, fallen dessen Geschäftsanteile an die verbleibenden
Gesellschafter im Verhältnis ihrer bisherigen Kapitalanteile und sind zum Buchwert an die Erben auszuzahlen.“
<i>Siebter Beschlussi>
Die Gesellschafter beschliessen Herrn Claus Nehring, vorbenannt, als Geschäftsführer der Gesellschaft für eine un-
bestimmte Dauer zu ernennen.
Die Gesellschaft wird durch die alleinige Unterschrift eines Geschäftsführers verpflichtet.
<i>Erklärungi>
Der Notar hat die Erschienenen darauf aufmerksam gemacht, dass eine Handelsermächtigung, in Bezug auf den Ge-
sellschaftszweck, ausgestellt durch die luxemburgischen Behörden, vor jeder kommerziellen Tätigkeit erforderlich ist,
was die Erschienenen ausdrücklich anerkennen.
<i>Kosteni>
Die Kosten welche der Gesellschaft wegen der gegenwärtigen Urkunde obliegen, werden auf eintausend fünfhundert
Euro (EUR 1.500,-) abgeschätzt.
<i>Bevollmächtigungi>
Die Erschienenen, handelnd in gemeinsamem Interesse, erteilen hiermit einem jeden Angestellten des unterzeichneten
Notars Spezialvollmacht, in ihrem Namen jegliche etwaige Berichtigungsurkunde gegenwärtiger Urkunde aufzunehmen.
Worüber Urkunde, Aufgenommen zu Senningerberg, Datum wie eingangs erwähnt.
4397
L
U X E M B O U R G
Und nach Vorlesung alles Vorstehendem an den Bevollmächtigten der Erschienenen, hat derselbe mit Uns Notar
gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Alfred Nehring, Karin Nehring, Claus Nehring, Paul Bettingen.
Enregistré à Luxembourg, A.C., le 12 décembre 2014. LAC / 2014/ 59795. Reçu 75.-€.
<i>Le Receveuri>
(signé): Irène Thill.
- Für gleichlautende Kopie - Ausgestellt zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.
Senningerberg, den 17. Dezember 2014.
Référence de publication: 2014203045/132.
(140227414) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
Bielefeld Neumarkt IV S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 192.883.
STATUTES
In the year two thousand four, on the seventeenth day of December.
Before Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, on December 17
th
,
2014, by a deed drawn up by the officiating notary, having its registered office at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch
in process of being filed at Companies and Trade Register of Luxembourg, (“Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg”)
Here represented by Mr. Max MAYER, with professional address in Junglinster, 3, route de Luxembourg, by virtue of
a proxy delivered to him.
The said proxy, after having been signed ne varietur by the appearing party and the undersigned notary, will remain
annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing party, represented as stated here-above, has requested the undersigned notary, to state as follows the
articles of association of a private limited liability company (société à responsabilité limitée), which is hereby incorporated:
Title I. Form - Object - Name - Registered office - Duration
1. Form. There is hereby formed a «société à responsabilité limitée» which will be governed by actual laws, especially
the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies such as amended.
2. Object. The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and
foreign companies, or other business entities, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well
as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and
the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in
partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The object of the Company is also the acquisition, management, development, sale and rental of any real estate, whether
furnished or not, and in general, all real estate operations, with the exception of those reserved to a dealer in real estate,
and those concerning the placement and management of money. The Company can also perform in Luxembourg as well
as abroad, in whatsoever form, any industrial, commercial, financial, personal or real estate property transactions which
are directly in connection with the creation, management and financing, in whatsoever form, of any undertakings and
companies whose object is the performance of any activities in whatsoever form, as well as the management and deve-
lopment, permanently or temporarily, of the portfolio created for this purpose. The Company shall be considered as a
financial participations company according to the applicable provisions.
The Company may take participating interests by any means in any business, undertakings or companies having the
same, analogous or connected object or which may favour its development or the extension of its operations.
3. Name. The private limited liable Company is incorporated under the name of Bielefeld Neumarkt IV S.àr.l..
4. Registered office.
4.1. The registered office of the Company is established in Luxembourg-City, Grand Duchy of Luxembourg. It may be
transferred within the boundaries of the municipality by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the
board of managers of the Company. The registered office may further be transferred to any other place in the Grand
Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the single member or the general meeting of members adopted in the
manner required for the amendment of the Articles.
4.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad
by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single
4398
L
U X E M B O U R G
manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or
events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities
of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the
registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstan-
ces. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the
temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.
5. Duration.
5.1. The Company is constituted for an undetermined period.
5.2. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency,
bankruptcy or any similar event affecting one or several of the members.
Title II. Capital - Shares
6. Capital.
6.1. The Company's capital is set at twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-), represented by one hundred
(100) shares of a par value of one hundred and twenty-five euro (EUR 125.-) each, all fully subscribed and entirely paid
up.
6.2. Each share confers the right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the
number of shares in existence.
6.3. The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the
single member or, as the case may be, by the general meeting of members, adopted in the manner required for the
amendment of the Articles.
7. Shares.
7.1. Shares may be freely transferred by a sole member to a living person or persons including by way of inheritance
or in the case of liquidation of a husband and wife's joint estate.
7.2. If there is more than one member, the shares are freely transferable among members. In the same way they are
transferable to non-members but only with the prior approval of the members representing at least three quarters of
the capital. In the same way the shares shall be transferable to non-members in the event of death only with the prior
approval of the owners of shares representing at least three quarters of the rights owned by the survivors.
7.3. In the case of a transfer in accordance with the provisions of Article 189 of the law dated 10 August 1915 on
commercial companies, the value of a share is based on average balance sheet of the last three financial years and, in case
the Company counts less than three financial years, it is established on basis of the balance sheet of the last financial year
or of those of the last two financial years.
Title III. Management
8. Board of managers and powers of the board of managers.
8.1. The Company is managed by a sole manager or a board of managers composed of at least one class A manager
and one class B manager.
8.2. The manager(s) are appointed, and may be removed at any time ad nutum (without any reason), by a resolution
of the member(s) whom shall set the term of their office. The manager(s) need not be member(s).
8.3. All powers not expressly reserved, by the Law or the present Articles, to the members fall within the competence
of the sole manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have
all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.
8.4. Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, whether members
or not, by the sole manager or, as the case may be, any class A manager jointly with any class B manager.
9. Procedures.
9.1. The board of managers shall meet as often as the Company's interests so require or upon call of any manager at
the place indicated in the convening notice.
9.2. Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24)
hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such cir-
cumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.
9.3. No such convening notice is required if all members of the board of managers of the Company are present or
represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda
of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or
e-mail, of each member of the board of managers of the Company. Separate written notice shall not be required for
meetings that are held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of
managers of the Company.
4399
L
U X E M B O U R G
9.4. Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing, whether in original, by
telefax, e-mail, telegram or telex, another manager as his proxy. A manager may also appoint another manager as his
proxy by phone, such appointment to be confirmed in writing subsequently.
9.5. No resolutions of the board of managers will be valid or effective without votes in favour of the relevant resolution
from at least one (1) class A manager and at least one (1) class B manager. The resolutions of the board of managers will
be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.
9.6. Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or
by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, and hear and
speak to, each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at
such meeting.
9.7. Circular resolutions signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a
meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical
resolution and may be evidenced by an original or by telegram, telex, facsimile or e-mail.
10. Representation. The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the sole signature of the
sole manager, or (ii) the joint signatures of any one class A manager and any one class B manager, save for administrative
matters, where the Company is bound towards third parties by the single signature of any manager but only for trans-
actions up to an amount of twenty thousand euros (EUR 20,000) on a per transaction basis and an amount of one hundred
thousand euros (EUR 100,000) on an annual aggregate basis, or (iii) by the single or joint signature(s) of any person(s) to
whom such signatory power has been validly delegated in accordance with Article 8.4.
11. Liability of the managers. The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any
commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these
Articles as well as the applicable provisions of the Law.
Title IV. Decisions of the sole member - Collective decisions of the members
12. Powers and voting rights.
12.1. The sole member exercises the powers devolved to a meeting of members by the dispositions of the foresaid
law of August 10
th
, 1915.
12.2. As a consequence thereof all decisions which exceed the powers of the manager(s) are taken by the sole member.
12.3. In the case of more than one member the decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by
the meeting.
Title V. Financial year - Balance sheet - Distributions
13. Financial year. The accounting year of the Company shall begin on the first of January of each year and end on the
thirty-first December of each year.
14. Balance sheet. Each year, on the thirty-first day of December, there will be drawn up a record of the assets and
liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.
The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and
provisions represents the net profit of the Company.
15. Distributions. Every year five percent (5%) of the net annual profit of the Company shall be transferred to the
Company's legal reserve until such time as the legal reserve amounts to one tenth of the issued capital. If at any time and
for any reason whatsoever the legal reserve falls below one tenth of the issued capital the five percent (5%) annual
contribution shall be resumed until such one tenth proportion is restored.
The excess is attributed to the sole member or distributed among the members if there is more than one. However,
the sole member or, as the case may be, a meeting of members may decide, at the majority vote determined by the
relevant laws, that the profit, after deduction of any reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary
reserve.
Title VI. Dissolution
16. Dissolution.
16.1. The Company is not automatically dissolved by the death, the bankruptcy, the interdiction or the financial failure
of a member.
16.2. In the event of the dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by the manager or managers
in office or failing them by one or more liquidators appointed by the sole member or by a general meeting of members.
The liquidator or liquidators shall be vested with the broadest powers in the realization of the assets and the payment
of debts.
16.3. The assets after deduction of the liabilities shall be attributed to the sole member or, as the case may be,
distributed to the members proportionally to the shares they hold.
4400
L
U X E M B O U R G
Title VII. General provisions
17. General provisions. For all matters not provided for in the present Articles of Incorporation, the members shall
refer to the law of August 10
th
, 1915 on commercial companies as amended.
<i>Subscription and Paymenti>
Thereupon, the appearing Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., prenamed and represented as stated here-above, de-
clared to have subscribed to the whole share capital of the Company.
The subscribed share capital of the Company has been fully paid up by contribution in cash, so that the amount of
twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500) is at the disposal of the Company, as has been proved to the undersigned
notary, who expressly acknowledges it.
<i>Transitory provisioni>
The first accounting year shall begin on the date of this deed and shall end on 31 December 2015.
<i>Estimate of costsi>
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be
charged to it in connection with its incorporation, have been estimated at about EUR 1,450.-.
<i>Resolutions of the sole memberi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole member, representing the entirety of the subscribed
share capital has passed the following resolutions:
1. The following persons are appointed as managers of the Company for an indefinite period:
a) Mr Isaac SCHAPIRA, director, born on 16 December 1952 in Jerusalem, Israel and residing at 2 Danescroft Gardens,
London NW4 2ND, United Kingdom, as class A manager;
b) Mr Patrice GALLASIN, director, born on 9 December 1970 in Villers-Semeuse, France and with professional address
at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, as class A manager;
c) Mr Andrew PETTIT, director, born on 7 March 1968 in Cleethorpes, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager; and
d) Mr Nicholas WEST, director, born on 17 May 1972 in Aylesbury, United Kingdom and with professional address
at 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, United Kingdom, as class B manager.
2. The registered office of the Company is set at L-1470 Luxembourg, 70, route d'Esch.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
party, the present deed is worded in English followed by a German version and in case of divergences between the English
and the German text, the English version will prevail.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the person appearing, said person appearing signed together with the notary the
present deed.
Deutsche Übersetzung des Vorhergehenden Textes:
Im Jahre zweitausend vierzehn, am siebzehnten Dezember.
Vor uns, dem amtierenden Notar Jean SECKLER, mit Amtswohnsitz in Junglinster, Grossherzogtum Luxemburg.
Ist erschienen:
Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet am 17. Dezember 2014, auf
Grund einer Urkunde aufgenommen durch den amtierenden Notar, nach dem Recht von Luxemburg mit Sitz in L-1470
Luxemburg, 70, route d'Esch, welche dabei ist beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg („Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg“) eingetragen zu werden,
hier vertreten durch Herrn Max MAYER, geschäftsansässig in Junglinster, 3, route de Luxemburg, aufgrund einer ihm
ausgestellten Vollmacht.
Besagte Vollacht soll nach ne varietur Unterzeichnung durch den Bevollmächtigten und den unterzeichneten Notar
gegenwärtiger Urkunde als Anlage zu Registrierungszwecken beigefügt wird.
Die Erschienene, vertreten wie eingangs erwähnt, ersucht den amtierenden Notar die Satzung einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung zu beurkunden, welche hiermit gegründet wird:
4401
L
U X E M B O U R G
Titel I. Rechtsform - Zweck - Benennung - Sitz - Dauer
1. Rechtsform. Es wird hiermit eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet,
die durch das abgeänderte Gesetz vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in der jeweils gültigen Fassung
geregelt wird.
2. Zweck. Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an Unternehmen und Gesellschaften jedweder Art,
in Luxemburg oder im Ausland, sowie dem Besitz, der Verwaltung, Entwicklung und Leitung ihres Portfolios. Die Gesell-
schaft kann Pfandbriefe, Obligationen, Schuldverschreibungen, Wertpapiere und Anleihen durch Zeichnung, Ankauf oder
in sonstiger Art und Weise erwerben und durch Verkauf, Tausch oder in sonstiger Weise veräußern. Die Gesellschaft
kann zudem Anteile an Gesellschaften halten und ihre Geschäfte über Niederlassungen in Luxemburg oder im Ausland
tätigen.
Zweck der Gesellschaft ist außerdem der Erwerb, die Verwaltung, die Erschließung, der Verkauf und die Vermietung
von jeglichen Immobilien, sei es möbliert oder unmöbliert, und im Allgemeinen alle Operationen, die Immobilien betreffen,
mit Ausnahme derjenigen, die einem Immobilienhändler vorbehalten sind und die Platzierung von Geld und die Vermö-
gensverwaltung betreffen. Die Gesellschaft kann zudem, in welcher Form auch immer, sowohl in Luxemburg als auch im
Ausland, sämtliche Industrie-, Handels-, Finanz-, Immobiliar- oder Mobiliargeschäfte tätigen, die, ganz gleich auf welche
Art, direkt oder indirekt mit der Gründung, Verwaltung und Finanzierung von Unternehmen und Gesellschaften in Ver-
bindung stehen, deren Zweck Aktivitäten jedweder Art als auch die dauerhafte oder zeitweilige Verwaltung und
Entwicklung des eigens zu diesem Zweck geschaffenen Portfolios sein können. Die Gesellschaft wird gemäß den gesetz-
lichen Bestimmungen als Société de Participations Financières (Finanzbeteiligungsgesellschaft) gegründet.
Die Gesellschaft kann sich durch beliebige Mittel an anderen Unternehmen, Gesellschaften oder Geschäften beteiligen,
die einen identischen, ähnlichen oder verwandten Zweck haben oder ihren Gesellschaftszweck fördern oder ihm nützlich
sind.
3. Name. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gegründet unter dem Namen Bielefeld Neumarkt IV S.àr.l..
4. Sitz.
4.1. Der Sitz der Gesellschaft ist in Luxemburg-Stadt des Großherzogtums Luxemburg. Der Gesellschaftssitz kann
durch Beschluss des alleinigen Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer innerhalb der gleichen Gemeinde
verlegt werden. Der Gesellschaftssitz kann des Weiteren durch Beschluss des alleinigen Gesellschafters oder gegebe-
nenfalls der Gesellschafter entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen an jeden anderen
Ort im Großherzogtum Luxemburg verlegt werden.
4.2. Niederlassungen und Tochtergesellschaften sowie Büros der Gesellschaft können durch Beschluss des alleinigen
Geschäftsführers oder gegebenenfalls der Geschäftsführer sowohl im Großherzogtum als auch im Ausland eröffnet wer-
den. Sofern nach Ansicht des alleinigen Geschäftsführers oder der Geschäftsführer außerordentliche politische oder
militärische Entwicklungen oder Umstände eingetreten sind oder einzutreten drohen, welche die normalen Aktivitäten
der Gesellschaft an ihrem Gesellschaftssitz beeinträchtigen können oder die Kommunikation zwischen diesem und Per-
sonen im Ausland, kann der Gesellschaftssitz zeitweise ins Ausland verlegt werden, bis die beeinträchtigenden Umstände
nicht mehr gegeben sind. Solche zeitweiligen Maßnahmen haben keine Auswirkung auf die Nationalität der Gesellschaft,
welche auch bei zeitweiliger Sitzverlegung ins Ausland eine luxemburgische Gesellschaft bleibt.
5. Dauer. Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.
5.2. Die Gesellschaft wird nicht durch den Tod, die Aberkennung der bürgerlichen Rechte, den Verlust der Geschäfts-
fähigkeit, die Insolvenz eines Gesellschafters oder mehrerer Gesellschafter oder ähnlicher Ereignisse aufgelöst
Titel II. Stammkapital - Gesellschaftsanteile
6. Stammkapital.
6.1. Das Kapital der Gesellschaft ist festgesetzt auf zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR), eingeteilt in einhun-
dert (100) Anteile mit einem Nennwert von je einhundertfünfundzwanzig Euro (125,- EUR), alle vollständig gezeichnet
und eingezahlt.
6.2. Jeder Anteil berechtigt im direkten Verhältnis zur Anzahl der existierenden Anteile zur Beteiligung am Vermögen
und an den Gewinnen der Gesellschaft.
6.3. Das Kapital der Gesellschaft kann von Zeit zu Zeit durch den Beschluss des alleiniges Gesellschafters oder gege-
benenfalls der Gesellschafterversammlung entsprechend den in der Gesellschaftssatzung festgelegten Bestimmungen
erhöht oder verringert werden.
7. Gesellschaftsanteile.
7.1. Jedwede Anteilsübertragung unter Lebenden durch den alleinigen Gesellschafter sowie die Übertragung von An-
teilen durch Erbschaft oder durch Auflösung einer Gütergemeinschaft zwischen Eheleuten ist frei.
7.2. Bei mehreren Gesellschaftern sind die Anteile unter Gesellschaftern frei übertragbar. Anteilsübertragungen an
Nichtgesellschafter sind nur mit vorheriger Zustimmung von Gesellschaftern möglich, die wenigstens drei Viertel des
Gesellschaftskapitals vertreten. Auf die gleiche Weise können im Todesfall die Anteile an Nichtgesellschafter nur mit
4402
L
U X E M B O U R G
Zustimmung der Anteilsbesitzer übertragen werden, die mindestens drei Viertel der den Überlebenden gehörenden
Anteile vertreten.
7.3. Bei einer Anteilsübertragung gemäß den Bestimmungen des Artikel 189 des Gesetzes vom 10. August 1915 über
die Handelsgesellschaften wird der Wert eines Anteils auf der Basis der Durchschnittsbilanz der letzten drei Geschäfts-
jahre berechnet und, falls die Gesellschaft noch keine drei Geschäftsjahre zählt, wird er auf der Basis der Bilanz des letzten
oder der beiden letzten Geschäftsjahre berechnet.
Titel III. Geschäftsführung
8. Geschäftsführung und Befugnisse.
8.1. Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer geleitet. Bei mehreren Geschäftsführern muss
sich die Geschäftsführung aus wenigstens einem Geschäftsführer der Kategorie A und einem Geschäftsführer der Kate-
gorie B zusammensetzen.
8.2. Der oder gegebenenfalls die Geschäftsführer können bestellt und zu jeder Zeit ad nutum per Gesellschafterbe-
schluss abberufen werden. Der oder die Gesellschafter legen den Bestellungszeitraum der Geschäftsführer fest, die keine
Gesellschafter sein müssen.
8.3. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich kraft Gesetzes oder vorliegender Artikel den Gesellschaftern vorbehalten
sind, fallen in den Kompetenzbereich des oder gegebenenfalls der Geschäftsführer, die mit allen Vollmachten ausgestattet
sind, um jegliche Handlungen und Tätigkeiten auszuführen und zu genehmigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft im
Einklang stehen.
8.4. Der Geschäftsführer oder - bei mehreren Geschäftsführern - jeder Geschäftsführer der Kategorie A kann zu-
sammen mit jedem Geschäftsführer der Kategorie B besondere oder begrenzte Befugnisse für bestimmte Angelegenheiten
an einen oder mehrere Bevollmächtigte übertragen, die nicht Gesellschafter sein müssen.
9. Form, Beschlussfähigkeit und Mehrheit.
9.1. Die Geschäftsführerversammlung tritt sooft zusammen, wie es erforderlich ist, oder bei Einberufung durch einzelne
Geschäftsführer, an einem Ort, der in der Einberufungsmitteilung angegeben ist.
9.2. Einberufungsmitteilungen für Geschäftsführerversammlungen müssen allen Geschäftsführern wenigstens vierund-
zwanzig (24) Stunden vor der jeweiligen Geschäftsführerversammlung schriftlich zugehen. In dringenden Fällen können
sie kurzfristiger einberufen werden, wobei die Umstände der Dringlichkeit in der Einberufungsmitteilung für die Ge-
schäftsführerversammlung dargelegt werden müssen.
9.3. Eine schriftliche Einberufungsmitteilung ist nicht erforderlich, wenn auf der Geschäftsführerversammlung alle Ge-
schäftsführer anwesend oder ordnungsgemäß vertreten sind, und wenn sie erklären, ordnungsgemäß informiert worden
zu sein und eine vollständige Kenntnis der Tagesordnung zu haben. Jeder Geschäftsführer der Gesellschaft kann auf die
Einberufungsmitteilung verzichten und seine Zustimmung schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Teletex,
Telefax oder E-Mail geben. Gesonderte schriftliche Einberufungsmitteilungen sind nicht erforderlich, wenn der jeweilige
Einberufungstermin und -ort in einem Zeitplan erfasst und zuvor per Geschäftsführerbeschluss angenommen wurde.
9.4. Jeder Geschäftsführer kann jeden anderen Geschäftsführer schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm,
Teletex, Telefax oder E-Mail als seinen Bevollmächtigten bestellen. Ein Geschäftsführer kann auch telefonisch durch einen
anderen Geschäftsführer zum Bevollmächtigten bestellt werden, wobei eine solche Bestellung anschließend schriftlich
bestätigt werden muss.
9.5. Geschäftsführerbeschlüsse sind weder gültig noch wirksam, wenn nicht wenigstens ein (1) Geschäftsführer der
Kategorie A und wenigstens ein (1) Geschäftsführer der Kategorie B ihre Stimmen zugunsten des betreffenden Beschlusses
abgegeben haben. Die Geschäftsführerbeschlüsse werden in einem Protokoll festgehalten und von allen auf der Ge-
schäftsführerversammlung anwesenden oder vertretenen Geschäftsführer unterzeichnet.
9.6. Jeder Geschäftsführer kann an jeder Geschäftsführerversammlung mittels Telefon- oder Videokonferenz oder
ähnlichen Kommunikationsmitteln teilnehmen, die es allen Teilnehmern erlauben, sich gegenseitig zu identifizieren, zu
hören und miteinander zu sprechen. Die Teilnahme an einer Geschäftsführerversammlung mit ebensolchen Kommuni-
kationsmitteln wird wie die persönliche Teilnahme des jeweiligen Geschäftsführers an einer Geschäftsführerversammlung
bewertet.
9.7. Zirkularbeschlüsse, die durch alle Geschäftsführer unterzeichnet wurden, sind in gleichem Maße rechtsverbindlich
und gültig wie Geschäftsführerbeschlüsse, die auf einer ordnungsmäßig einberufenen und gehaltenen Geschäftsführer-
versammlung gefasst wurden. Dabei können die Unterschriften auf einem einzigen Dokument oder auf mehrfachen
Ausfertigungen eines identischen Beschlusses erscheinen und schriftlich per Originalschreiben, mittels Telegramm, Tele-
tex, Telefax oder E-Mail nachgewiesen werden.
10. Vertretung. Die Gesellschaft wird in allen Gelegenheiten gegenüber Dritten durch die (i) Unterschrift des alleinigen
Geschäftsführers oder (ii) die gemeinschaftliche Unterschrift jeweils eines Geschäftsführers der Kategorie A und eines
Geschäftsführers der Kategorie B rechtskräftig verpflichtet. In Bezug auf administrative Angelegenheiten hingegen wird
die Gesellschaft gegenüber Dritten entweder durch die alleinige Unterschrift eines jeden Geschäftsführers rechtkräftig
verpflichtet, und zwar für Transaktionen bis zu einem Betrag in Höhe von zwanzigtausend Euro (EUR 20.000) je Ge-
schäftsvorgang und einem Betrag in Höhe von einhunderttausend (EUR 100.000) pro Jahr, oder (iii) durch die alleinige
4403
L
U X E M B O U R G
oder die gemeinschaftliche Unterschrift der Person oder der Personen, welchen eine Vertretungsvollmacht gemäß Artikel
8.4 rechtswirksam übertragen wurde.
11. Haftung der Geschäftsführer. Die Geschäftsführer übernehmen im Rahmen ihres Mandats keine persönliche Haf-
tung in Bezug auf von ihnen im Namen der Gesellschaft rechtmäßig eingegangene Verpflichtungen, sofern solche
Verpflichtung im Einklang sowohl mit dieser Satzung als auch mit den anzuwendenen gesetzlichen Bestimmungen steht.
Titel IV. Entscheidungen des alleinigen Gesellschafters - Gemeinsame Entscheidungen mehrerer Gesell-
schafter
12. Befugnisse und Stimmrechte.
12.1 Der alleinige Gesellschafter übt die Vollmachten aus, welche der Gesellschafterversammlung vorbehalten sind
und die im Einklang mit dem vorbenannten Gesetz vom 10. August 1915 stehen.
12.2 Demzufolge werden alle Entscheidungen vom alleinigen Gesellschafter getroffen, die die Befugnisse des oder der
Geschäftsführer überschreiten.
12.3 Bei mehreren Gesellschaftern werden die Entscheidungen durch die Gesellschafterversammlung getroffen, wenn
diese die Befugnisse des oder der Geschäftsführer überschreiten.
Titel V. Geschäftsjahr - Bilanz - Gewinnverteilung
13. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten
Dezember desselben Jahres.
14. Bilanz. Am Ende eines jeden Geschäftsjahres wird per einunddreißigsten Dezember durch die Geschäftsführung
eine Bilanz, welche das Inventar der Aktiva und Passiva zusammenfasst, sowie eine Gewinn- und Verlustrechnung aufge-
stellt.
Der Saldo dieser Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nach Abzug der Kosten, Aufwendungen, Abschreibungen
und Rückstellungen dem Nettogewinn der Gesellschaft.
15. Gewinnverteilung. Von diesem Nettogewinn der Gesellschaft werden jährlich fünf Prozent (5%) der gesetzlichen
Rücklage der Gesellschaft zugeführt, solange bis die gesetzliche Rücklage ein Zehntel des Kapitals beträgt. Sollte zu einem
gegebenen Zeitpunkt und aus irgendeinem Grunde, die gesetzliche Rücklage unter ein Zehntel des Gesellschaftskapitals
fallen, so muss die jährliche Zuführung von fünf Prozent wieder aufgenommen werden, bis die gesetzliche Rücklage wieder
ein Zehntel des Kapitals beträgt.
Der verbleibende Gewinn wird an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüt-
tet. Jedoch kann der alleinige Gesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafterversammlung durch Mehrheitsbeschluss
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auch entscheiden, dass der verbleibende Gewinn, nach Abzug jeglicher Rücklagen,
auf das folgende Jahr vorgetragen wird oder einer außerordentlichen Rücklage zugeführt wird.
Titel VI. Auflösung
16. Auflösung.
16.1. Die Gesellschaft wird nicht automatisch durch den Tod, die Insolvenz, die gerichtliche Entmündigung oder den
Bankrott eines Gesellschafters aufgelöst.
16.2. Sollte die Gesellschaft aufgelöst werden, so wird diese Auflösung vom alleinigen Geschäftsführer oder gegebe-
nenfalls von den Geschäftsführern im Amt oder, sofern dies nicht möglich ist, von einem oder mehreren Insolvenzver-
waltern durchgeführt, die vom alleinigen Gesellschafter oder der Gesellschafterversammlung ernannt wurden. An den
oder die Insolvenzverwalter werden zur Abwicklung der Vermögenswerte und Schulden die ausgedehntesten Befugnisse
übertragen.
16.3. Die Vermögenswerte werden nach Abzug aller Schulden an den alleinigen Gesellschafter oder gegebenenfalls an
die Gesellschafter im Verhältnis ihrer Anteile ausgeschüttet.
Titel VII. Allgemeine Bestimmungen
17. Allgemeine Bestimmungen. Überall dort, wo vorliegende Satzung einzelne Fälle nicht ausdrücklich regelt, finden
die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in seiner jeweils
gültigen Fassung Anwendung.
<i>Zeichnung und Einzahlungi>
Die Erschienene Bielefeld Neumarkt Holding S.à r.l., vorgenannt und vertreten wie oben angegeben, erklärt alle Anteile
der Gesellschaft gezeichnet zu haben.
Das gezeichnete Stammkapital der Gesellschaft wurde vollständig in bar eingezahlt, so dass ab heute der Gesellschaft
der Betrag in Höhe von zwölftausendfünfhundert Euro (12.500,- EUR) zur Verfügung steht, wie dies dem unterzeichneten
Notar nachgewiesen wurde, der dies ausdrücklich bestätigt.
4404
L
U X E M B O U R G
<i>Übergangsbestimmungi>
Das erste Geschäftsjahr beginnt am Tag der Gründung und endet am 31. Dezember 2015.
<i>Kosteni>
Der Gesamtbetrag der Kosten, Ausgaben, Vergütungen und Auslagen unter welcher Form auch immer, welche im
Zusammenhang mit der Gesellschaftsgründung entstehen, beläuft sich auf ungefähr 1.450,- EUR.
<i>Beschlüssei>
Sofort nach Gründung der Gesellschaft fasst die alleinige Gesellschafterin, welche das gesamte Stammkapital der Ge-
sellschaft vertritt, folgende Beschlüsse:
1. Es werden zum Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit ernannt:
a) Herr Isaac SCHAPIRA, Direktor, geboren am 16. Dezember 1952 in Jerusalem, Israel und wohnhaft 2 Danescroft
Gardens, London NW4 2ND, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie A;
b) Herr Patrice GALLASIN, Direktor, geboren am 9. Dezember 1970 in Villers-Semeuse, Frankreich und geschäfts-
ansässig 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Geschäftsführer der Kategorie A;
c) Herr Andrew PETTIT, Direktor, geboren am 7. März 1968 in Cleethorpes, Vereinigtes Königreich und geschäfts-
ansässig 105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B; und
d) Herr Nicholas WEST, Direktor, geboren am 17. Mai 1972 in Aylesbury, Vereinigtes Königreich und geschäftsansässig
105 Wigmore Street, London, W1U 1QY, Vereinigtes Königreich, Geschäftsführer der Kategorie B.
2. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in L-1470 Luxemburg, 70, route d‘Esch.
<i>Erklärungi>
Der unterzeichnete Notar, welcher der englischen Sprache kundig und mächtig ist, erklärt hiermit, dass die vorliegende
Urkunde auf Wunsch der Erschienenen auf Englisch abgefasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung, und dass
im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung die englische Fassung maßgebend ist.
Worüber Urkunde, aufgenommen in Junglinster, am Datum wie eingangs erwähnt.
Nach Verlesung der Urkunde durch den Notar haben der Bevollmächtigte der Erschienenen zusammen mit uns, dem
unterzeichneten Notar, gegenwärtige Urkunde unterschrieben.
Gezeichnet: Max MAYER, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 18 décembre 2014. Relation GRE/2014/5119. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri> (signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014203001/397.
(140226653) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
EPM Services Sà.r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-1528 Luxembourg, 1, boulevard de la foire.
R.C.S. Luxembourg B 192.861.
STATUTES
In the year two thousand fourteen, on the eleventh day of December,
Before the undersigned Maître Jean SECKLER, notary residing in Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.
There appeared:
Round Hill Capital S.à r.l. a company duly incorporated and validly existing under the laws of Luxembourg, having its
registered office at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated by a deed
of the undersigned notary dated 27 November 2013, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register
under number B 182465, duly represented by Mr. Kemal AKYEL, manager, residing professionally in Luxembourg, pur-
suant to a proxy given under private seal.
The said proxy signed ne varietur by the proxy holder and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed
to be filed with the registration authorities.
The appearing party, acting in the capacity of which it acts, has requested the undersigned notary to draw up the
following articles of association of a société à responsabilité limitée (private limited liability company) it wished to incor-
porate:
Title I. Form - Name - Registered office - Purpose - Duration
Art. 1. Form. There is hereby formed a société à responsabilité limitée (private limited liability company) (the “Com-
pany”), governed by the laws pertaining to such an entity, especially the law of August 10, 1915 concerning commercial
companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association (the “Articles”).
4405
L
U X E M B O U R G
Art. 2. Name. The Company's name is “EPM Services S.à r.l.”.
Art. 3. Registered Office. The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg.
It may be transferred to any other place within the city of Luxembourg by a decision of the Board of Managers (as
defined below), in accordance with these Articles.
It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the sole
shareholder or, in case of plurality of shareholders by a resolution of the general meeting of shareholders representing
at least seventy five (75%) percent taken by a vote of the majority of the share capital of the Company.
The Company may establish branches or other offices both in Luxembourg or abroad.
Art. 4. Purpose. The object of the Company is the acquisition, holding, management and disposal of participations and
any interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, enterprises or
investments, the acquisition and/or investment in by way of purchase, subscription, or in any other manner as well as the
transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures and any other securities or financial instruments or
assets of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio.
The Company may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise
and may invest in any way and in any type of assets. It may further invest in the acquisition and management of a portfolio
of patents or other intellectual property rights of any nature or origin whatsoever. The Company may also hold interests
in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.
The Company may borrow in any form except by way of public offer. It may issue by way of private placement only,
notes, bonds and debentures and any kind of debt and/or equity securities. The Company may lend funds including the
proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries, affiliated companies or to any other
company. It may also give guarantees and grant securities in favour of third parties to secure its obligations or the
obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company. The Company may further pledge, transfer,
encumber or otherwise create security over all or over some of its assets.
The Company may generally employ any techniques and instruments relating to or with respect to any of its investments
for the purposes of efficient management, including without limitation techniques and instruments designed to protect
the Company against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.
In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other
activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accom-
plishment and development of the foregoing.
The Company may also provide assistance in any form including but not limited to administrative, technical, consulting
and operational support and assistance, acquisition and financing advisory services, asset strategy management services,
property management services to the Company's direct or indirect subsidiaries. The Company may also provide the same
kind of assistance to minority shareholdings or undertakings of the Company or to third parties, provided that doing so
falls within the Company's best interest and does not trigger any business license or any financial license requirements.
Art. 5. Duration. The Company is formed for an unlimited duration.
Title II. Share capital - Shares
Art. 6. Share Capital. The share capital of the Company is set at EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros),
divided into 12,500 (twelve thousand five hundred) shares with a nominal value of EUR 1 (one euro) each fully subscribed
and paid-up.
The share capital of the Company may be increased or reduced from time to time by a resolution of the sole share-
holder or, in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders
representing at least seventy five (75%) percent of the share capital of the Company.
Art. 7. Shares. Towards the Company, the shares are indivisible and the Company will recognize only one owner per
share.
Each share is entitled to an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to such sha-
reholder's ownership of shares.
The shares are freely transferable among shareholders.
When the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to non-shareholders.
In case of plurality of shareholders, the transfer of shares (inter vivos) to non-shareholders is subject to the prior
approval of the shareholders, representing, at least seventy five (75%) percent of the share capital of the Company given
in a general meeting.
The transfer of shares to non-shareholders, by reason of death, must be approved by a resolution taken by a vote of
the majority of the shareholders representing at least seventy five (75%) percent of the share capital of the Company
given in a general meeting.
4406
L
U X E M B O U R G
Shares shall be transferred by instrument in writing in accordance with the Law. The transfer of shares is only binding
upon the Company or non-shareholders following a notification to, or acceptance by the Company in accordance with
article 1690 of the Luxembourg Civil Code.
The Company shall be able to redeem its own shares, in the framework of a decrease of its subscribed capital by
cancellation of the redeemed shares, under the following terms and conditions: (i) the redemption price shall be set by
reference to the nominal value of each redeemed share, or if higher within the total amount of any distributable sums in
accordance with the entitlement of the redeemed shares as provided for by the Articles. When the redemption price is
in excess of the nominal value of the shares to be redeemed, the redemption may only be decided to the extent that
sufficient distributable sums are available as regards the excess purchase price; (ii) the redemption shall be carried out by
a resolution of the sole shareholder, or in case of plurality of shareholders, by a resolution taken by a vote of the majority
of the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital of the Company; (iii) the redee-
med shares shall be cancelled following the decrease of the share capital of the Company.
Title III. Management
Art. 8. Appointment of the managers. The Company is managed by a board of managers (the “Board of Managers”)
composed of at least one or more class A manager(s) and one or more class B manager(s), which need not be shareholders
of the Company, and which shall be appointed by resolution of the sole shareholder, or, in case of plurality of shareholders,
by a resolution taken by vote of the majority of the shareholders representing more than fifty percent (50%) of the share
capital of the Company. The remuneration, if any, of the managers shall be determined in the same manner.
A manager may be removed, with or without cause, at any time and replaced by a resolution of the sole shareholder
or, in case of plurality of shareholders, by a resolution of the shareholders representing more than fifty (50%) percent of
the share capital of the Company.
Art. 9. Powers of the managers. All powers not expressly reserved by the Law or these Articles to the sole shareholder
or, in case of plurality of shareholders, to the general meeting of shareholders, fall within the competence of the Board
of Managers.
The Company shall be bound, towards third parties, by the joint signatures of a class A manager and a class B manager
in all matters. The Board of Managers may delegate its powers for specific and limited tasks to one or several ad hoc
agents, who need not be shareholder(s) or manager(s) of the Company. The Board of Managers, will determine the
powers and remuneration (if any) of the agent, and the duration of its representation as well as any other relevant
condition.
Art. 10. Board of managers. The Board of Managers may choose among its members a chairman and a vice-chairman.
It may also choose a secretary who need not be a manager or a shareholder of the Company and who shall be
responsible for keeping the minutes of the board meetings.
The Board of Managers shall meet when convened by any one manager. Notice stating the business to be discussed,
the time and the place, shall be given to all managers at least 24 hours in advance of the time set for such meeting, except
as a matter of emergency, in which case the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the
notice. None notice shall be required when waived by the consent of each manager, or when all the managers are present
or represented.
Any manager may act at any meeting by appointing in writing or by any other appropriate telecommunication means
another manager as his proxy. A manager may represent more than one manager.
Any and all managers may participate to a meeting by phone, videoconference, or any appropriate telecommunication
means allowing all managers participating in the meeting to hear each other at the same time. Such participation is deemed
equivalent to a participation in person.
A meeting of managers is duly constituted if at the commencement of the meeting there are present in person or by
alternate not less than one-half (1/2) of the total number of managers, except when the Board of Managers is composed
of less than three (3) managers, in which case the quorum shall be of all the managers.
Decisions of the Board of Managers are validly taken by a resolution approved at a duly constituted meeting of managers
of the Company by the affirmative vote of not less than one half (1/2) of the managers present or represented who voted
and did not abstain.
Written resolutions approved and signed by all the managers shall have the same effect as resolutions passed at a
meeting of the board. Such resolutions may be signed in counterparts, each of which shall be an original and all of which,
taken together, shall constitute the same instrument.
Deliberations of the Board of Managers shall be recorded in minutes signed by the chairman or by two (2) managers.
Copies or extracts of such minutes shall be signed by the chairman or by two (2) managers.
Art. 11. Liability of the managers. No manager assumes any personal liability in relation with any commitment validly
made by him in the name of the Company in accordance with these Articles, by reason of his function as a manager of
the Company.
4407
L
U X E M B O U R G
Title IV. Shareholders' meetings
Art. 12. Sole shareholder. A sole shareholder assumes all the powers devolved to the general meeting of shareholders
in accordance with the Law.
Except the current operations concluded under normal conditions, contracts concluded between the sole shareholder
and the Company have to be recorded on minutes or drawn-up in writing.
Art. 13. General meetings. In case of plurality of shareholders, the general meeting of the shareholders represents all
the shareholders of the Company. All the shareholders shall be bound with those resolutions.
General meetings of shareholders may be convened by the Board of Managers failing which by shareholders repre-
senting more than fifty (50) percent of the share capital of the Company.
Written notices convening a general meeting and setting forth the agenda shall be sent to each shareholder at least
24 hours before the meeting, specifying the time and place of the meeting, except in case of emergency, in which case
the nature and the circumstances of the emergency shall be mentioned in the notice convening a general meeting. None
notice shall be required when waived by the consent of each shareholder, or when all the shareholders are present or
represented and if they all state that they have been duly informed of the agenda of the meeting.
Any shareholder may be represented and act at any general meeting by appointing in written another person to act
as such shareholder's proxy, which person needs not to be a shareholder of the Company.
Resolutions of the general meetings of shareholders are validly taken when adopted by the affirmative vote representing
more than fifty (50%) percent of the share capital of the Company. If the quorum is not reached at a first meeting, the
shareholders shall be convened by registered letter to a second meeting.
Resolutions will be validly taken at this second meeting by a majority of votes cast, regardless of the portion of share
capital represented.
The holding of shareholders meetings is not compulsory as long as the number of shareholders does not exceed
twenty-five (25). In the absence of meetings, shareholders resolutions are validly taken in writing, at the same majority
vote cast as the ones provided for general meetings, provided that each shareholder receive in writing by any suitable
communication means the whole text of each resolution to be approved prior to his written vote.
However, resolutions to amend the Articles shall only be adopted by a resolution taken by a vote of the majority of
the shareholders, representing at least seventy-five percent (75%) of the share capital.
Each shareholder shall participate to a general meeting of shareholders by phone, videoconference, or any appropriate
telecommunication means allowing his designation and allowing all shareholders participating in the meeting to hear each
other without discontinuity and allowing them to participate fully in the meeting. Such participation is deemed equivalent
to a participation in person.
In case the Company has more than twenty-five (25) shareholders, a general meeting shall be held annually in Luxem-
bourg at the registered office of the Company on the first Wednesday of the month of June or on the following day if
such day is a public holiday.
Title V. Financial year - Annual accounts - Profits supervision
Art. 14. Financial Year. The financial year of the Company starts on 1
st
January of each year and ends on 31
st
December
of the same year.
Art. 15. Annual accounts. Each year, at the end of the financial year, the Board of Managers shall draw up a balance
sheet and the profits and losses account, to which an inventory will be annexed, in accordance with the Law, all together
with the annual accounts are submitted to the sole shareholder or in case of plurality of shareholders to the general
meeting of shareholders.
Art. 16. Profits. The credit balance of the profits and losses account, after deduction of the expenses, costs, amorti-
zations, charges and provisions, such as approved by the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, by the
general meeting of shareholders, represents the net profit of the Company.
Each year, five (5%) percent of the net profit shall be allocated to the legal reserve account of the Company. This
allocation ceases to be compulsory when the legal reserve amounts to one tenth of the share capital, but must be resumed
at any time when it has been broken into.
The remaining profit shall be allocated by resolution of the sole shareholders or, in case of plurality of shareholders,
by resolution of the shareholders representing more than fifty (50%) percent of the share capital, resolving to distribute
it proportionally to the shares they hold, to carry it forward, or to transfer it to a distributable reserve.
Art. 17. Interim dividends. Notwithstanding the above provision, the Board of Managers may decide to pay interim
dividends before the end of the current financial year, on the basis of a statement of accounts prepared by the Board of
Managers.
This statement of account must show that sufficient funds are available for distribution. The amount to be distributed
may not exceed realized profits since the end of the last financial year, increased by carried forward profits and distri-
4408
L
U X E M B O U R G
butable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve established in accordance
with the Law or the Articles.
Art. 18. Supervision. Where the number of shareholders exceeds twenty-five (25), the supervision of the Company
shall be entrusted to one or more statutory auditors (commissaire(s) aux comptes) who need not to be shareholder,
and will serve for a term ending on the date of the annual general meeting of shareholders following his/their appointment.
However his/their appointment can be renewed by the general meeting of shareholders.
The review of the accounts shall be entrusted to one or more independent approved statutory auditors (réviseur(s)-
agréé(s)) appointed by a resolution of the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders may
however appoint an independent auditor at any time.
Title VI. Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution. The dissolution of the Company shall be resolved by a resolution of the sole shareholder or, in
case of plurality of the shareholders, by a resolution of the general meeting of shareholders by a resolution taken by a
vote of the majority of the shareholders, representing at least seventy five (75%) percent of the share capital of the
Company. The Company shall not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of any
shareholder.
Art. 20. Liquidation. The liquidation of the Company will be carried out by one or more liquidators appointed by the
sole shareholder or in case of plurality of shareholders by a resolution taken by a vote of the majority of the shareholders,
representing at least seventy five (75%) percent of the share capital of the Company. This resolution shall determine his/
their powers and remuneration. At the time of closing of the liquidation, the assets of the Company will be allocated to
the sole shareholder or, in case of plurality of shareholders, to the shareholders, proportionally to the shares they hold.
<i>Temporary provisioni>
Notwithstanding the provisions of article 14 above, the first financial year of the Company starts today and will end
on December 31
st
, 2015.
<i>Subscription and paymenti>
All the 12,500 (twelve thousand five hundred) shares, representing the entire share capital of the Company have been
fully subscribed and paid-up by Round Hill Capital S.à r.l., prenamed.
The amount of EUR 12,500 (twelve thousand five hundred euros) is now at the disposal of the Company, proof of
which has been duly given to the notary by producing a blocked funds certificate issued by the bank ING Luxembourg,
on December 9
th
, 2014.
<i>Costsi>
The amount of the costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company to
it in connection with its incorporation, have been estimated at about one thousand one hundred Euro (EUR 1,100.-).
<i>Resolutions of the sole shareholderi>
Immediately after the incorporation of the Company, the sole shareholder representing the entirety of the subscribed
share capital of the Company passed the following resolutions:
1) The number of members of the Board of Managers is fixed at two (2);
2) The following persons are appointed as members of the Board of Managers of the Company for an undetermined
duration:
i. Mr. Paul BASHIR, born on 2 September 1975, in Shotley Bridge, United Kingdom, with professional address at 250
Kings Road, London SW3 5UE, United Kingdom, as class A manager; and
ii. Mr. Kemal AKYEL, born on 2 June 1977, in Beringen, Belgium, with professional address at 1, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, as class B manager;
3) The registered office of the Company is established at 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duchy
of Luxembourg.
<i>Declarationi>
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing
parties, the present deed is worded in English followed by a French version and in case of divergences between the English
and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read to the proxyholder, such proxyholder signed together with the notary the present
deed.
4409
L
U X E M B O U R G
Suit la version française du texte qui précède:
L'an deux mille quatorze, le onzième jour du mois de décembre,
Par devant Maître Jean SECKLER, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,
A comparu:
Round Hill Capital S.à r.l., une société de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 1, Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée par acte du notaire instrumentant et enregistrée auprès
du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 182465 dûment représentée par Monsieur
Kemal AKYEL, gérant, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing
privé.
La procuration signée ne varietur par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour
être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
Ladite partie comparante, agissant ès qualité, a requis le notaire instrumentant de dresser les statuts d'une société à
responsabilité limitée qui est ainsi constituée:
Titre I
er
. Forme - Dénomination - Siège social - Objet - Durée
Art. 1
er
. Forme. Il est formé par les présentes une société à responsabilité limitée (la «Société»), régie par le droit
applicable à ce type de sociétés et plus particulièrement par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales,
telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents Statuts (les «Statuts»).
Art. 2. Dénomination. La dénomination de la Société est «EPM Services S.à r.l.».
Art. 3. Siège social. Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Il peut être transféré en tout autre lieu de la commune de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance (tel que
défini ci-dessous), conformément aux présents Statuts.
Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par résolution de l'associé unique, ou en cas
de pluralité d'associés, par une résolution de l'assemblée générale des associés, prise par la majorité des associés repré-
sentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.
La Société pourra établir des succursales ou bureaux dans le Grand-Duché du Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger.
Art. 4. Objet. L'objet de la Société est l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations et d'in-
térêts, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toutes autres entités,
entreprises ou investissements, l'acquisition et/ou l'investissement par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen,
de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, de bons, d'obligations, de créances et toutes
sûretés, avoirs ou instruments financiers de quelque nature que ce soit, et la détention, l'administration, le développement
et la gestion de son portefeuille.
La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise
et peut investir de quelque manière que ce soit et dans tous types d'avoirs. Elle peut en outre investir dans l'acquisition
et la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que
ce soit. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'in-
termédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères.
La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, unique-
ment par voie de placement privé, à l'émission d'obligations, bons, certificats et d'autres titres représentatifs d'emprunts
et/ou de créances. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant de tous emprunts et/ou des émissions
d'obligations, à ses filiales, sociétés affiliées et à toute autre société. Elle peut également consentir des garanties ou des
sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales, sociétés affiliées ou
de toute autre société. La Société peut, en outre, nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer,
de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.
La Société peut généralement employer toutes techniques et tous instruments en relation avec un quelconque de ses
investissements dans le but d'une gestion efficace, y compris sans limitation des techniques et des instruments destinés à
protéger la Société contre les risques de crédit, de taux de change, taux d'intérêt et tout autre risque.
D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager
dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'ac-
complissement et le développement de ce qui précède.
La Société peut aussi accorder toute forme d'assistance incluant mais non limité à l'octroi de support et d'assistance
administratif, technique, de conseil et opérationnel, prestation de services de conseil en acquisition et financement, ser-
vices de gestion d'actifs, services de gestion des biens immobiliers aux filiales directes ou indirectes de la Société. La
Société peut également accorder le même type d'assistance aux associés minoritaires de la Société ou aux sociétés qui
font partie du même groupe de sociétés que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social
et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.
Art. 5. Durée. La Société est constituée pour une durée indéterminée.
4410
L
U X E M B O U R G
Titre II. Capital social - Parts sociales
Art. 6. Capital social. Le capital social de la Société est fixé à EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros), divisé en
12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune entièrement souscrite
et libérée.
Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité
d'associés, par une résolution de l'assemblée générale des associés, prise par la majorité des associes représentant au
moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.
Art. 7. Parts sociales. Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne connaît qu'un seul propriétaire
par part sociale.
Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé dispose de droits de vote proportionnels
aux parts sociales qu'il détient.
Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles à l'égard des tiers.
Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales entre vifs à des tiers est soumise à l'accord préalable
des associés donnée en assemblée générale représentant, au moins, soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.
La cession de parts sociales à un tiers par suite du décès d'un associé doit être approuvée par résolution de l'assemblée
générale prise par la majorité des associés représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social.
La cession de parts sociales est constatée par écrit conformément à la Loi et ne pourra être opposable à la Société et
aux tiers qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690
du code civil luxembourgeois.
La Société pourra procéder au rachat de ses propres parts sociales, dans le cadre d'une réduction de son capital
souscrit, par annulation des parts rachetées et conformément aux modalités et conditions suivantes: (i) le prix de rachat
sera fixé par référence à la valeur nominale de chacune des parts sociales rachetées, ou au montant total de toutes les
sommes distribuables et en conformité avec les droits conférés aux parts sociales rachetées tel que prévu par les Statuts.
Lorsque le prix de rachat est supérieur à la valeur nominale des parts sociales à racheter, le rachat ne pourra être décidé
que dans la mesure où des sommes distribuables suffisantes sont disponibles pour couvrir l'excédent de prix; (ii) le rachat
sera décidé par une résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution de l'assemblée
générale des associés, prise par la majorité des associes représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital
social; (iii) les parts sociales rachetées seront annulées immédiatement après la réduction du capital social.
Titre III. Gérance
Art. 8. Nomination des gérants. La Société est gérée par un conseil de gérance (le «Conseil de Gérance») comprenant
au moins un ou plusieurs gérants(s) de catégorie A et un ou plusieurs gérant(s) de catégorie B qui n'ont pas à être associés
de la Société et qui sont nommés par résolutions de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution
de l'assemblée générale des associés, prise par la majorité des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%)
du capital social. La rémunération, le cas échéant, du ou des gérant(s) est déterminée de la même manière que pour leur
nomination.
Un gérant peut être révoqué, avec ou sans juste motif, à tout moment, et être remplacé par résolution de l'associé
unique, ou en cas de pluralité d'associés, par une résolution de l'assemblée générale des associés, prise par la majorité
des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.
Art. 9. Pouvoirs des gérants. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à l'associé unique,
ou en cas de pluralité d'associés, à l'assemblée générale des associés, seront de la compétence du Conseil de Gérance.
La Société est engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe d'un gérant de catégorie
A et d'un gérant de catégorie B.
Le Conseil de Gérance peut déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques et limitées à un ou plusieurs agents ad
hoc, qui n'ont pas à être associé(s) ou gérant(s) de la Société. Le Conseil de Gérance déterminera les pouvoirs et rému-
nérations (s'il y a lieu) des agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres modalités ou conditions de leur mandat.
Art. 10. Conseil de gérance. Le Conseil de Gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président.
Le Conseil de Gérance pourra également choisir un secrétaire qui n'a pas à être un gérant ou associé de la Société et
qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance.
Le Conseil de Gérance se réunira sur convocation d'un gérant. La convocation détaillant les points à l'ordre du jour,
l'heure et le lieu de la réunion, sera donnée à l'ensemble des gérants au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf
en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à
la réunion. Aucune convocation ne sera requise dès lors que chacun des gérants y a renoncée ou lorsque tous les gérants
sont présents ou représentés.
Chaque gérant peut prendre part aux réunions du Conseil de Gérance en désignant par écrit ou par tout autre moyen
de communication adéquat un autre gérant pour le représenter.
4411
L
U X E M B O U R G
Un gérant peut représenter plus d'un gérant.
Tout gérant peut participer à une réunion du Conseil de Gérance par téléphone, visioconférence ou par tout autre
moyen de communication approprié permettant à l'ensemble des gérants participant à la réunion de s'entendre les uns
les autres au même moment. Une telle participation sera réputée équivalente à une participation physique.
Une réunion du Conseil de Gérance est dûment tenue, si au commencement de celle-ci, la moitié du nombre total de
gérants de la Société est présente en personne ou représentée, sauf lorsque le Conseil de Gérance est composée de
moins de trois (3) gérants auquel cas, le quorum sera de tous les gérants.
Les décisions du Conseil de Gérance sont prises valablement par une résolution approuvée lors d'une réunion du
Conseil de Gérance de la Société dûment réunie, par vote d'au moins la moitié (1/2) des gérants présents ou représentés
qui ont voté et ne se sont pas abstenus.
Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les gérants auront le même effet que les résolutions prises lors
d'une réunion du Conseil de Gérance. Les résolutions pourront être signées sur des exemplaires séparés, chacun d'eux
étant un original et tous ensembles constituant un seul et même acte.
Les délibérations du Conseil de Gérance seront consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par
deux gérants. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux seront signés par le président ou par deux gérants.
Art. 11. Responsabilité des gérants. Aucun gérant n'assume de responsabilité personnelle quant aux engagements
régulièrement pris par lui au nom de la Société dans le cadre de ses fonctions de gérant de la Société et conformément
aux Statuts.
Titre IV. Assemblée générale des associés
Art. 12. Associé unique. En présence d'un associé unique, l'associé unique assume tous les pouvoirs dévolus à l'as-
semblée générale des associés conformément à la Loi.
Hormis les opérations courantes conclues à des conditions normales, les contrats conclus entre l'associé unique et la
Société doivent faire l'objet de procès-verbaux ou être établis par écrit.
Art. 13. Assemblées générales. En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale des associés de la Société représente
l'ensemble des associés de la Société. Ses résolutions lient tous les associés de la Société.
Les assemblées générales d'associés peuvent être convoquées par le Conseil de Gérance à défaut, par les associés
représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social.
Les convocations écrites à une Assemblée Générale indiquant l'ordre du jour doivent être envoyées à chaque associé
au moins vingt-quatre (24) heures avant l'assemblée en indiquant l'heure et le lieu de la réunion, sauf en cas d'urgence,
auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence seront mentionnées dans la convocation à l'assemblée générale.
Aucune convocation ne sera requise dès lors que chacun des associés y a renoncée ou lorsque tous les associés sont
présents ou représentés et s'ils déclarent connaître l'ordre du jour.
Tout associé peut se faire représenter et agir à toute assemblée générale en nommant comme mandataire et par écrit
un tiers qui n'a pas à être associé de la Société.
Les résolutions de l'assemblée générale des associés sont valablement adoptées par vote des associés représentant
plus de cinquante pour cent (50%) du capital social. Si le quorum n'est pas atteint lors d'une première assemblée, les
associés seront convoqués par lettre recommandée à une seconde assemblée.
Lors de cette seconde assemblée, les résolutions sont valablement adoptées à la majorité des votes émis, quel que
soit la portion du capital représenté.
Si le nombre d'associés de la Société est inférieur ou égal à vingt-cinq (25), les résolutions des associés sont adoptées
par voie de circulaires écrites, à la même majorité des votes exprimés que pour une Assemblée Générale, et pour autant
que chaque associé ait reçu, par tout moyen de communication approprié, l'intégralité du texte de chaque résolution
soumise à approbation, préalablement à son vote écrit.
Les résolutions décidant de modifier les Statuts ne peuvent cependant être adoptées que par une résolution prise à
la majorité des associés et représentant au moins soixante-quinze pourcent (75%) du capital social.
Tout associé peut prendre part à une assemblée générale des associés par conférence téléphonique, visioconférence
ou par tout autre moyen de communication permettant son identification et permettant que toutes les personnes par-
ticipant à l'assemblée s'entendent mutuellement sans discontinuité et puissent participer pleinement à l'assemblée. Cet
associé est censé être présent pour le calcul du quorum de la majorité.
Si la Société compte plus de 25 associés, l'assemble générale annuelle des associés devra être tenue annuellement à
Luxembourg au siège social de la Société le premier mercredi du mois de juin ou le lendemain si ce jour est férié.
Titre V. Exercice social - Comptes sociaux - Profits - Révision
Art. 14. Exercice social. L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine
le trente-et-un décembre de la même année.
4412
L
U X E M B O U R G
Art. 15. Comptes annuels. Tous les ans, à la clôture de l'exercice social, le Conseil de Gérance dresse un bilan et un
compte de pertes et profits auxquels un inventaire est annexé, conformément à la Loi, l'ensemble, avec les comptes
annuels, est alors soumis à l'associé unique ou en cas de pluralité d'associés à l'assemblée générale des associés.
Art. 16. Bénéfices. Le solde positif du compte de pertes et profits, après la déduction des dépenses, coûts, amortis-
sements, charges et provisions, tel qu'approuvé par l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associé, par l'Assemblée
Générale des associés, représente le bénéfice net de la Société.
Chaque année, cinq pour cent (5%) du bénéfice net est affecté à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être
obligatoire lorsque la réserve légale atteint un dixième (10%) du capital social, mais doit être reprise à tout moment
jusqu'à entière reconstitution.
Le bénéfice restant est affecté, par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité des associés, par résolution
des associés représentant plus de cinquante pour cent (50%) du capital social, décidant de sa distribution aux associés,
proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent, de son report à nouveau, ou de son allocation à une réserve
distribuable.
Art. 17. Dividendes intérimaires. Nonobstant ce qui précède, le Conseil de Gérance peut décider de verser des
dividendes intérimaires avant la clôture de l'exercice social en cours sur la base d'un état comptable établi par le Conseil
de Gérance.
Cet état comptable doit faire ressortir que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution de tels dividendes.
Les fonds à distribuer ne peuvent excéder le montant des bénéfices réalisés depuis le dernier exercice social, augmenté
des bénéfices reportés et des réserves distribuables, mais diminué des pertes reportées et des sommes à affecter à une
réserve constituée conformément à la Loi ou aux Statuts.
Art. 18. Surveillance. Lorsque le nombre des associés excède vingt-cinq (25), la surveillance de la Société est confiée
à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, associé(s) ou non, qui exerceront leur mandat jusqu'à la date de l'assemblée
générale annuelle des associes qui suit leur nomination. Cependant leur mandat peut être renouvelé par l'assemblée
générale des associés.
La Société confiera la révision de ses comptes à un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) désigné(s) par
résolution de l'assemblée générale des associés. L'assemblée générale des associés pourra cependant nommer un réviseur
d'entreprise agréé à tout moment.
Titre VI. Dissolution - Liquidation
Art. 19. Dissolution. La dissolution de la Société sera décidée par l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés,
par l'Assemblée Générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la majorité des associés, représentant
au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. La Société ne sera pas dissoute par la mort, la suspension des
droits civils, la déconfiture ou la faillite d'un associé.
Art. 20. Liquidation. La liquidation de la Société est menée par un ou plusieurs liquidateurs désignés par l'associé unique,
ou en cas de pluralité d'associés, par l'assemblée générale des associés par une résolution prise par un vote positif de la
majorité des associés, représentant au moins soixante-quinze pour cent (75%) du capital social. Cette résolution déter-
minera leurs pouvoirs et rémunération. Au moment de la clôture de la liquidation, les actifs de la Société seront à l'associé
unique ou, en cas de pluralité d'associés, aux associés, proportionnellement au nombre de parts qu'ils détiennent.
<i>Disposition temporairei>
Nonobstant les dispositions de l'article 14 mentionné au-dessus, le 1
er
exercice de la Société débute ce jour et
s'achèvera le 31 décembre 2015.
<i>Souscription et paiementi>
La totalité des 12.500 (douze mille cinq cents) parts sociales représentant l'intégralité du capital social a été entièrement
souscrite et libérée (en numéraire) par Round Hill Capital S.à r.l., susnommée.
Le montant de EUR 12.500 (douze mille cinq cents euros) est donc à la disposition de la Société ainsi qu'il en a été
justifié au notaire instrumentant par la production d'un certificat de blocage des fonds émis par la banque ING Luxem-
bourg, le 9 décembre 2014.
<i>Fraisi>
Le montant des frais, dépenses, coûts ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société en raison
de sa constitution, sont approximativement évalués à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).
<i>Résolutions de l'associé uniquei>
Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique, représentant la totalité du capital social souscrit
de la Société, a pris les résolutions suivantes:
1) Le nombre de membres au Conseil de Gérance est fixé à deux (2).
2) Les personnes suivantes sont nommées membres du Conseil de Gérance de la Société pour une durée indéterminée:
4413
L
U X E M B O U R G
i. Monsieur Paul BASHIR, né le 2 septembre 1975, à Shotley Bridge, Royaume-Uni, demeurant professionnellement à
250 Kings Road, London SW3 5UE, en tant que gérant de catégorie A; et
ii. Monsieur Kemal AKYEL, né le 2 juin 1977, à Beringen, Belgique, demeurant professionnellement à 1, Boulevard de
la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que gérant de catégorie B;
3) Le siège social de la Société est établi au 1, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des parties comparantes, le présent
acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte
français, le texte anglais fera foi.
Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.
Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire, ledit mandataire a signé le présent acte avec le notaire.
Signé: Kemal AKYEL, Jean SECKLER.
Enregistré à Grevenmacher, le 15 décembre 2014. Relation GRE/2014/4987. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.
<i>Le Receveuri>
(signé): G. SCHLINK.
Référence de publication: 2014203171/475.
(140226354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
G Pioneer Holdco I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Capital social: USD 20.000,00.
Siège social: L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves.
R.C.S. Luxembourg B 180.772.
In the year two thousand and fourteen, on the tenth day of December.
Before Us, Maître Léonie GRETHEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
THERE APPEARED:
Garrison Pioneer Class A L.P., a Cayman Islands Exempted Limited Partnership, having its registered office at Ugland
House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands (the Sole Shareholder),
here represented by Mrs Monique Drauth, employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given
under private seal on 1
st
December 2014.
The said proxy, signed ne varietur by the proxyholder of the person appearing and the undersigned notary, will remain
attached to the present deed to be filed with the registration authorities.
Such appearing person, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to state that:
I. The appearing person is the sole shareholder of the private limited liability company (société à responsabilité limitée)
established and existing in the Grand-Duchy of Luxembourg under the name “G Pioneer Holdco I S.à r.l.” (hereinafter,
the Company), with registered office at L-2633 Senningerberg, 6D, route de Trèves, Grand-Duchy of Luxembourg, re-
gistered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 180772, established pursuant to a deed
of the undersigned notary dated September 30, 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations
number 2956 dated November 22, 2013 and which bylaws have not been amended since then.
II. The Company’s share capital is set at twenty thousand US Dollars (USD 20,000.-) represented by two million
(2,000,000) shares with a nominal value of one US Dollar cent (USD 0.01) each.
III. The agenda of the meeting is the following:
1. Anticipated dissolution of the Company and opening of its liquidation.
2. Appointment of Garrison Pioneer Class A L.P., prenamed, as liquidator of the Company, and fixation of his powers
and responsibilities as provided by articles 144 to 148 bis of the Luxembourg companies’ law.
3. Discharge to the managers for the exercise of their mandate until the date of this meeting.
IV. The Sole Shareholders takes the following resolutions:
<i>First resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to dissolve anticipatively the Company and to put the Company into liquidation.
<i>Second resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to appoint Garrison Pioneer Class A L.P., prenamed, as liquidator of the Company.
The Sole Shareholder resolves that the liquidator shall have the most extended powers as provided by articles 144 to
148bis of the Luxembourg companies’ law. It may carry out all acts provided by article 145 without previous general
meeting of shareholders’ authorization except if required by law.
4414
L
U X E M B O U R G
All powers are granted to the liquidator to represent the Company for all operations being a matter of liquidation
purpose to realize the assets, to discharge all liabilities and to distribute the net assets of the Company to the shareholders,
in kind or in cash.
The said person may in particular, without the following enumeration being limitative, sell, exchange and alienate all
either movable or immovable properties and all related rights, and alienate the said property or properties if the case
arises, grant release with waiver of all chattels, charges, mortgages and actions for rescission, of all registrations, entries,
garnishments and attachments, absolve the registrar of mortgages from automatic registration, accord all priorities of
mortgages and of charges, concede priorities of registration, make all payments even if they are not ordinary administrative
payments, remit all debts, compound and compromise on all matters of interest to the Company, extend all jurisdictions,
and renounce remedies at law or acquired rights of prescription.
<i>Third resolutioni>
The Sole Shareholder resolves to give full discharge to the members of the board of managers of the Company for
the execution of their mandate until the date of the present meeting unless the liquidation reveals faults in the execution
of their duties.
There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.
<i>Costsi>
The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the
above resolutions are estimated at two thousand Euro (EUR 2,000.-).
<i>Declarationi>
The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxy holder of
the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version. On request of the same
proxyholder and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.
WHEREOF, the present deed was drawn up in Luxembourg, on the date first written above.
The document having been read to the proxy holder of the appearing person, who is known to the notary by her full
name, civil status and residence, she signed together with Us, the notary, the present deed.
Suit la traduction française du texte qui précède:
L’an deux mille quatorze, le dix décembre.
Par-devant Nous, Maître Léonie GRETHEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.
A COMPARU:
Garrison Pioneer Class A L.P., une société à responsabilité limitée de droit des Iles Cayman, ayant son siège social au
Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Iles Cayman, (l’Associé Unique),
ici représentée par Mme Monique Drauth, salariée, demeurant professionnellement à Luxembourg, en vertu d’une
procuration donnée sous seing privé le 1
er
décembre 2014.
Laquelle procuration restera, après avoir été signée ne varietur par la mandataire de la personne comparante et le
notaire instrumentaire, annexée aux présentes pour être enregistrée avec elle.
Laquelle comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d’acter que:
I. La personne comparante est l’associé unique de la société à responsabilité limitée établie au Grand-Duché de Lu-
xembourg sous la dénomination «G Pioneer Holdco I S.à r.l.» (ci-après la Société), ayant son siège social à L-2633
Senningerberg, 6D, route de Trèves, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et
des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 180772, constituée par acte du notaire soussigné en date du 30 septembre
2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2956 en date du 22 novembre 2013, et dont
les statuts n’ont pas été modifiés depuis lors.
II. Le capital social de la Société est fixé à vingt mille US Dollars (USD 20.000,-) représenté par deux millions (2.000.000)
de parts sociales d’une valeur nominale d’un cent US Dollars (USD 0,01) chacune.
III. L’ordre du jour de l’assemblée est le suivant:
1. Dissolution anticipée de la Société et mise en liquidation volontaire.
2. Nomination de Garrison Pioneer Class A L.P., pré qualifiée, en tant que liquidateur de la Société et fixation de ses
pouvoirs et responsabilités tels que prévus par les articles 144 à 148 bis de la loi Luxembourgeoise sur les sociétés
commerciales.
3. Décharge aux membres du conseil de gérance de la Société pour l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de cette
assemblée.
V. L’Associé Unique a pris les résolutions suivantes:
4415
L
U X E M B O U R G
<i>Première résolutioni>
L’Associé Unique décide de procéder à la dissolution anticipée de la Société et à sa mise en liquidation volontaire.
<i>Deuxième résolutioni>
L’Associé Unique décide de nommer Garrison Pioneer Class A L.P., pré qualifiée, en tant que liquidateur de la Société.
L’Associé Unique décide que le liquidateur aura les pouvoirs les plus étendus tels que prévus par les articles 144 à
148bis de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales. Il peut accomplir tous les actes prévus à l’article 145 sans
recourir à l’autorisation de l’assemblée générale des associés toutes les fois où celle-ci est requise.
Tout pouvoir est conféré au liquidateur de représenter la Société pour toutes opérations pouvant relever des besoins
de la liquidation, afin de réaliser l’actif, d'apurer le passif et de distribuer les avoirs nets de la Société aux associés, en
nature ou en numéraire.
Il peut, en particulier, et sans que l’énumération qui va suivre soit limitative, vendre, échanger et aliéner tous biens
tant meubles qu’immeubles et tous droits y relatifs, le cas échéant donner mainlevée avec renonciation à tous droits réels,
privilèges, hypothèques et actions résolutoires, de toutes inscriptions, transcriptions, mentions, saisies et oppositions;
dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office; accorder toutes priorités d'hypothèques et
de privilèges; céder tous rangs d'inscription; faire tous paiements, même s'ils n'étaient pas des paiements ordinaires
d'administration; remettre toutes dettes; transiger et compromettre sur tous intérêts sociaux; proroger toutes juridic-
tions; renoncer aux voies de recours ou à des prescriptions acquises.
<i>Troisième résolutioni>
L’Associé Unique décide de donner décharge pleine et entière aux membres du conseil de gérance de la Société pour
l’exercice de leur mandat jusqu’à la date de cette assemblée, sauf si la liquidation fait apparaître des fautes dans l’exécution
des tâches qui leur incombaient.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée.
<i>Fraisi>
Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge
à raison des présentes, sont évalués à la somme de deux mille Euro (EUR 2.000,-).
<i>Déclarationi>
Le notaire soussigné qui comprend et parle l’anglais, constate par les présentes qu’à la requête de la mandataire de la
personne comparante, le présent acte est rédigé en anglais suivi d’une version française. A la requête de la même man-
dataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.
DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu’en tête des présentes.
Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la personne comparante, connue du notaire par son nom et
prénom, état et demeure, elle a signé avec Nous notaire, le présent acte.
Signé: Drauth, GRETHEN.
Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 10 décembre 2014. Relation: LAC/2014/59270. Reçu douze euros (12,00 €).
<i>Le Receveuri> (signé): Irène Thill.
Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au Mémorial C.
Luxembourg, le 18 décembre 2014.
Référence de publication: 2014203218/128.
(140227141) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 19 décembre 2014.
Joal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.
Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.
R.C.S. Luxembourg B 125.598.
<i>Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue en date du 16 décembre 2014i>
Il résulte de l'assemblée générale extraordinaire de la société tenue en date du 16 décembre 2014 que:
- Madame Miriam Wilson, né le 17 décembre 1961 à Dublin, (Irlande), demeurant au 82, Val Saint Croix à L-1370
Luxembourg, est le nouveau nom de famille du gérant et associé unique de la société (anciennement Madame Miriam
Mascherin).
Son mandat continue pour une durée illimitée.
Référence de publication: 2014201015/13.
(140225022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 décembre 2014.
Editeur:
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
4416
Bielefeld Neumarkt III S.à.r.l
Bielefeld Neumarkt II S.à.r.l.
Bielefeld Neumarkt IV S.à.r.l.
Cabinet d'experts Romain FISCH S.A.
Carmeuse Holding S.A.
C.B.C. Immo S.A.
CB S.A.
Centurion European German Property 2 S. à r.l.
Certes Capital SA
CGARD S.A.
ChloroPhil SA
C+ Investments
C-K-A-N Marketing & Services S.à r.l.
Clervaux Invest Sàrl
C.L.L. S.à r.l.
Codic Luxembourg S.A.
Cofimin S.A.
COMETAL-Constructions Métalliques S.A.
COMETAL-Constructions Métalliques S.A.
COM-Invest Management Distriland S.C.A.
Com-Invest Management Rubens S.C.A.
Com-Invest Management S.à r.l.
Com-Invest Management Wallmark S.C.A.
Co-Operation HJ S.A.
Crest Capital S.A.
Deloitte Audit
Deloitte General Services
Deloitte Tax & Consulting
Dora Couture S.à r.l.
D.R.C. S.A.
E-Carat SA
Egmont Holdings Luxembourg S.à r.l.
Elinar Group S.à r.l.
EPM Services Sà.r.l.
Euro-Fina S.A.
EuroHoldings S.à r.l.
European Real Estate Senior Debt 1 S.à r.l.
Fair TopCo S.à r.l.
Fourteen Madder S.à r.l.
GCA Europe S.A.
Gerona Holdings S.à r.l.
G Pioneer Holdco I S.à r.l.
I.E.C.I.L. S.à r.l.
Joal S.à r.l.
Leap International Sàrl